Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 7 avril 1951, samedi 7 (no 14)
[" ïome 83, N° 14 1095 Vol.83.No.14 \t\t \t\t_ \t\t Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette de Québec (PUBUÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED «Y THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 7 avril 1051 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion tst suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc.sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday; April 7th, 1951 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, (Hta-claue, Ministère des Postes, Ottawa.Canada.wa, as second class mailable matter.0270 1096 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome S3, Nb U délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition (pie l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de ictarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volontés: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 I*cs chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième a celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie 3ue la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.29088 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thurs day, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.290S8\u20141-52 Lettres patentes A.C.Automobiles Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du treize février 1951.constituant en corporation: Armand Poupart, avocat et Conseil en Loi du Roi, J.-Clovis Dagenais, avocat, tous deux de la cité de Montréal, et Jeanne Senay, sténographe, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles et Opérer des garages, sons le nom «le \"A.('.Automobiles Limitée ', avec un capital de $40,000 «li-visé en 400 actions de $100 chacune.I/c siège social de la compagnie sera à Montréal.district judiciaire «le M«>ntn>al.Daté «lu bureau du Procureur général le treize février 1951.L*Assistant-procureur général, 29803-o L.DÊSELETS.Letters Patent \u2022 A.C.Automobiles Limitée Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of February, 1051, incorporating: Armand Poupart, advocate and King's Counsel, J.Clovis Dagenais.advocate, both of the city of Montreal, and Jeanne Senay, stenographer, of Verdun, all of the ju«li-cial district of Montreal.f«ir the following purposes: To deal in motor vehicles and operate garages, umler the name of \"A.C.Automobiles Limitée\", with a capital stock of $10,000 divided into 400 shares of $100 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth «lav of February, 1951.L.DÉSILETS, 29S03 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7th, 1951, Vol.83, No.U 1097 Air-Photo Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six février 1951, constituant en corporation: Richard Crépeau, Guy Crépcau, avocats, Laurent Dumont, notaire, Madeleine Legendre, sténographe, et Dame Veuve Corinne P.Sirois, sténographe, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Faire un service de photographie aérienne, d'arpentage aérien et tout autre service technique aérien, sous le nom de \"Air-Photo Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six février 1951.L'Assistant-procureur général, 29S03-o L.DÉSILETS.Air-Photo Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of February, 1951, incorporating: Richard Crépeau, Guy Crépeau, advocates, Laurent Dumont, notary, Madeleine Legendre, stenographer, and Dame Widow Corinne P.Sirois, stenographer, all of Sherbrooke,judicial district of St.Francis, for the following purposes: To provide a service of aerial photography, aerial survey and any other technical air service, under the name of \"Air-Photo Inc.\", with a capital stock of $10,000 divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth dav of February,, 1951.L.DESILETS, 29803 Deputy Attorney General.Albert G.Martin Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze février 1951, constituant en corporation: Albert Martin, maître-plombier, Dame Lucette Guérin Martin, comptable, épouse contractuelle-ment séparée de biens de Albert Martin et Paul Guérin.livreur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires respectivement comme manufacturiers, plombiers, constructeurs, entrepreneurs et agents généraux pour travaux de plomberie et d'électricité, sous le nom de \"Albert G.Martin Limitée\", avec un capital de 825,000 divisé en 250 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville I^e-moyne, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatorze février 1951.L'Assist ant-procureur général.29803-o L.DESILETS.Albert G.Martin Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1951, incorporating: Albert Martin, master-plumber.Dame Lucette Guérin-Martin, accountant, wife separate as to property by marriage contract of Albert Martin, and Paul Guérin, delivery-man, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business respectively as manufacturers, plumbers, builders, contractors and general agents, for plumbing and electrical works, under the name of \"Albert G.Martin Limitée\", with a capital stock of $25,000 divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at the town of Lemoyne, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803 Deputy Attorney General.Alfred Lcgault & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois février 1951.constituant en corporation: Alfred Lcgault, administrateur.André Lcgault, courtier d'assurances, et Raymond Lcgault.employé civil, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Sujet aux dispositions de la Loi des assurances de Québec, exercer le commerce de courtiers en assurance et agir comme agents d'assurance, sous le nom de \"Alfred Lcgault & Fils Inc.\".avec un capital «le $20,000 divisé en 1.000 actions de $20 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général le vingt-trois février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803-o L.DÉSILETS.Alfred Legault & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of February, 1951, incorporating: Alfred Legault, manager, André Ii des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf février 1951.constituant en corporation: Bernard-Camille Blanchard, marchand.Maurice Saint-Louis, et René Sénécal, compta-tables, tous «les cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes d'objets en bois, en métal ou autres matériaux; d'appareils de radio, «le phonographe, et de tous mobiliers «le maison, sous le nom de \"B.C.Blanchard Limitée\"\u2014\"B.C.Blanchard Limited.\", avec un capital «le 810,000 divisé en 400 actions «le 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général le dix-neuf février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803-o L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-fourth day of February, 1951, incorporating: Charles Levy, manufacturer.June Kirlin, and Sylvia Robinovich, secretaries, spinsters, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate coin-panv, under the name of \"Asconia Apartments Ltd,\", with a capital stock of 840,000 divided into 300 preferred shares having a par value of S100 each, and 100 common shares having a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fourth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29S03-o Deputy Attorney General.Association des Taverniers de la Cité de Shawinigan Falls et du District Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing ration mav hold is to be limited, is $10.000.The head office of the corporation will be at Saint-Bruno, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of February.1951.L.DESILETS, 29803 Deputy Attorney General.Laiterie de Chicoutimi Ltée Laiterie de Chicoutimi Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la !>een issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of QucImv, l>eariug date-the twenty- du vingt-trois février 1951, constituant en corpo- third day of February, 1951, incorporating: 1104 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 83, N° IL ration: Frank Grimard, rentier, Bertrand Gri-mard et Laurent Grimard, commerçants, tous de Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Faire le commerce du lait et de tous autres produits laitiers et de tous les produits qui peuvent être obtenus du lait et sous-produits, sous le nom de \"Laiterie de Chicoutimi Ltée\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803-o L.DÉSILETS.La Ligue de Hockey du Nord Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en tlate du quatorze février 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Eddy Fortier, gérant, de Mont-Rolland, Maurice St-Louis, gérant, de Sainte-Agathe-des-Monts, tous deux du district judiciaire de Terre-bonne, et Odilon Ouellette, industriel, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir, maintenir et diriger un ou plusieurs clubs, de hockey, sous le nom de \"La Ligue de Hockey du Nord Inc.\".Lesdits biens immobiliers ou les revenus en provenant que peut acquérir et posséder la corporation sont limités à 825,000.Le siège social de la corporation est situé au village de Mont-Rolland, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général le quatorze février 1951.L'Assistant-procu reu r général, 29803-o L.DÉSILETS.Le Comité d'Entretien des Chemins d'hiver de St-Joseph et de St-Athanase, de Kamouraska, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt février 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Michel Ouellet, industriel, Joseph Pelletier, menuisier tous deux de Saint-Joseph, et Jos Ouellet, garde-forestier, de Saint-Athanase, tous du district judiciaire de Kamouska, pour les objets suivants: Ouvrir la voie publique depuis la route numéro 51 jusqu'à la route numéro 2-A en passant par St-Athanase et St-Joseph de Kamouraska, sous le nom de \"Le Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de St-Joseph et de St-Athanase, de Kamouraska, Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $30,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Athanase, djstrict judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau «lu Procureur général le vingt-février 1951.L'Assistant-procureur général.29803-o L.DÉSILETS.Frank Grimard, annuitant, Bertrand Grimard and Laurent Grimard, traders, all of Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in milk and in all kinds of other dairy products, and in any products capable of being derived therefrom, under the name of \"Laiterie de Chicoutimi Ltée\", with a capital stock of 840,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third dav of February, 1951.L.DÉSILETS, 29S03 Deputy Attorney General.La Ligue de Hockey du Nord Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth clay of February, 1951, to incorporate into a corporation without share capital: Eddy Fortier, manager, of Mont-Rolland, Maurice St-Louis, manager, of Sainte-Agathe-des-Monts, both of the judicial district of Terrebonne, and Odilon Ouellette, industrialist, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To establish, maintain and direct one or several hockey clubs, under the name of \"La Ligue de Hockey du Nord Inc\".The said immovable property or the revenue derived therefrom which the corporation may acquire and hold shall be limited to $25,000.The head office of the corporation will be in the village of Mont-Rolland, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1951.L.DÉSILETS.29803 Deputy Attorney General.Le Comité d'Entretien des Chemins d'hiver de St-Joseph et de St-Athanase, de Kamouraska, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of February, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Michel Ouellet, industrialiste, Joseph Pelletier, joiner, both of Saint-Joseph, and Jos Ouellet, forest ranger, of Saint-Athanase, all of the judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To open the public road from Highway No.51 to Highway No.2-A passing through St-Athanasc and St-Joseph de Kamouraska, under the name of \"Le Comité d'Entretien des Chemins d'Hiver de St-Joseph et de St-Athanase, de Kamouraska, Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation mav hold is to be limited, is 830,000.The head office of the corporation will be at Saint-Athanase, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of Februarv, 1951.L.DESILETS, 29803 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7th, 1.951, Vol.83, No.11 1105 Le Comité* des Chemins d'Hiver D'Aston-Jonction Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-six février 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Joseph Arel, cultivateur, Léo-Paul Therrien, boucher, et Bruno Morin, voyageur de commerce, tous de Saint-Raphaël d'Aston, district judiciaire de Ni-colet, pour les objets suivants: L'entretien des chemins d'hiver dans le comté de Nicolet et d'Arthabaska, sous le nom de \"Le Comité des Chemins d'Hiver D'Aston-Jonction\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de S 15,000.Le siège social de la corporation sera à Aston-Jonction, district judiciaire de Xicolet.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six février 1951.L'Assistant-procureur général, 29S03-o L.DÉSILETS.Les Immeubles Union Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettrres patentes, en date du seize février 1951, constituant en corporation: Jean-R.Lcgault, Gérard Laverdière, agents, des cité et district judiciaire de Montréal, et Jacques Langlois, agent, de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Acquérir, bâtir, posséder, développer ou autrement faire le commerce et disposer des lots, terrains, sites, immeubles et propriétés réelles ou de tout intérêt en iceùx, sous le nom de \"Les Immeubles Union Ltée\", avec un capital de $10,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général le seize février 1951.L'Assistant-procureur général.29803-o L.DÉSILETS.London Felt Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél)ec.il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec, des lettres patentes en date du seize février 1951, constituant en corporation: David (.(Kidman, Jack Lighstone, avocats et Imelda Langlois, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de feutre, bourre, laine brute, coton, soie, toile, lin chanvre, fils mercerisés, fils, cordes et denfelles, sous le nom de \"London Felt Mfg, Co.Inc.\", avec un capital de $200,000 divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 1,500 actions rivilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1951.L'Assistant-procureur général.29S03 L.DÉSILETS.Le Comité des Chemins d'Hiver D'Aston-Jonction Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-sixth day of February, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Joseph Arel, farmer, Léo-Paul Therrien, butcher, and Bruno Morin, commercial traveller, all of Saint-Raphaël d'Aston, judicial district of Nicolct, for the following purposes: The maintenance of winter roads in the counties of Nicolet and of Arthabaska, under the name of \"Le Comité des Chemins d'Hiver d'Aston-Jonction\".The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $15,000.The head office of the corporation will be at Aston-Jonction, judicial district of Nicolet.» Dated at the office of the Attorney General, this twentv-sixth dav of February, 1951.L.DESILETS, 29803 Deputy Attorney General.Les Immeubles Union Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1951, incorporating: Jean R.Legault, Gérard Laverdière, agents, of the city ami judicial district of Montreal, and Jacques Langlois, agent, of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes: To acquire, build, own, develop or otherwise deal in and deal with lots, lands, sites, immovables and real estate, or any interest therein, under the name of \"Les Immeubles Union Ltée\", with a capital stock of $10,000, divided into 100 shares of S100 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated nit the office of the Attorney General, this sixteenth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803 Deputy Attorney General.London Felt Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1951, incorporating: David Goodman, Jack Lightstone, .advocates, and Imelda Langlois.secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturer and dealers in felt, flock, raw wool, cotton, silk, linen, flax, hemp, threads, yarns, ropes and lace, under the name of \"London Felt Mfg, Co.Inc.\", with a capital stock of $200,000.divided into 500 common shares of the par value of $100.each, and 1,500 preferred shares of the par value of $100.each.The head office of the Company will l>e at Montreal.Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803-o Deputy Attorney General. 1106 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 83, N° U Luke's Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et un février 1951, constituant en corporation: Louis Fitch, Cit., Gertrude Wasscr-man, avocats et Rose Markis, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements, bottes et chaussures, marchandises sèches, menus objets, quincaillerie et articles semblables, sous le nom de \"Luke's Inc.\", avec un capital de S40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803 L.DÉSILETS.Luke's Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec bearing date the twenty-first day of February, 1951, incorporating: Louis Fitch, K.C., Gertrude Wasserman, advocates, and Rose Markis, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal with clothing, boots and shoes, dry goods, small wares, hardwares, hardware and similar articles, under the name of \"Luke's Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will.be at Rouyn, in the Judicial District of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General this twentv-first day of February, 1951.L.DESILETS, 29803-o Deputy Attorney General.Maison Maxime Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur île la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze février 1951, constituant en corporation: Lily Pearl, marchande, épouse séparée de biens de Max Pearl, Sylvia Rabinovich, secrétaire, fille majeure, et Max Pearl, marchand, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: » Faire le négoce ou le commerce de vêtements de toute description, chaussures, marchandises sèches et quincaillerie, sous le nom de \"Maison Maxime Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.'Daté du bureau du Procureur général, le quatorze février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803 L.DÉSILETS.New Manoir Limited (Le Nouveau Manoir Limitée) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du 14 février 1951, constituant en corporation:.Frédéric Lapierre, marchand, Eva Lapierre Yvonne Lapierre, célibataires et Dame Rose-Ange Lapierre Couture, épouse séparée de biens de René Couture, journalier, tous de la cité et district judiciaire de Montréal pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtellerie, sous le nom de \"New Manoir Limited (Le Nouveau Manoir Limitée)\", avec un capital de $99.000 divisé en 990 actions de $100 dollars chacune.Le siège social de la compagnie sera à 75 rue Frontenac, Berthierville, district judiciaire de Joliettc.Daté du bureau du Procureur général, le 14 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803 L.DÉSILETS.Maison Maxime Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1951, incorporating: Lily Pearl, merchant, wife separate as to property of Max Pearl, Sylvia Rabinovich, secretary, spinster, and Max Pearl, merchant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To deal in or with wearing apparel of every description, shoes, dry goods and hardware, under the name of \"Maison Maxime Inc.\", with a capital stock of $10,000.divided into 300 preferred shares having a par value of $100.each, and 100 common shares having a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Granby.in the Judicial District of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29S03-o Deputy Attorney General.New Manoir Limited (Le Nouveau Manoir L imitée) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued b\\\\the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1951, incorporating: Frédéric Lapierre, merchant, Eva Lapierre, Yvonne Lapierre, spinsters, and Dame Kose-Ange Lapierre Couture, wife separate as to property of René Couture, journeyman, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of hotel keeper, under the name of \"New Manoir Limited (Le Nouveau Manoir Limitée)\", with a capital stock of $99,000.divided into 990 shares of $100.each.The head office of the Company will be at 75 Frontenac Street, Berthierville, Judicial District of Juliette.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7th, 1051, Vol.S3, No.U 1107 Planet Heating Industries Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf février 1951, constituant en corporation: James Conrad, comptable, demeurant à Greenfield Park, Loyola Schmidt, entrepreneur, demeurant à Dorion, et Henri Lcfort, vendeur, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, acheter, vendre tous appareils, matériaux et marchandises se rapportant à l'industrie du chauffage et de la plomberie, sous le nom de \"Planet Heating Industries Limited\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2439, rue Notre-Dame Est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803-o L.DÉSILETS.Pollack's Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du 19 février 1951, constituant en corporation: Isidore C.Pollack, avocat, Samuel L.Pollack, docteur et Roger Létourneau, avocat, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Pollack's Ltd.\" avec un capital de $30,000 divisé en 300 actions de $1C0 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le 19 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803 L.DÉSILETS.Procure Générale de Musique (Ltée) Avis est donné qu'en vertu de la première pi rtie de la Loi des compagnies de Québec, il a été r.cccrdé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du «\\unze février 1951, constituant en corporation: Raymond Cossctte, notaire, Anne-Marie La-jeunesse, secrétaire, tous deux de Québec, et Gilles Dcmers, étudiant en droit de Sillcry, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de musique et des instruments de musique de toute nature, sous le nom de \"Procure Générale de Musique (Ltée), avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $50 chacune et en 600 actions privilégiées de $50.chacune.Ix; siège social de la compagnie sera à Quél)ec.district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quinze février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803-o L.DÉSILETS.Raphaël Ruflb Demolition Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Planet Heating Industries Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of February, 1951, incorporating: James Conrad, accountant, residing at Greenfield Park, Loyola Schmidt, contractor, residing at Dorion, and Henri Lefort, salesman, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, purchase, sell any apparatus, materials and merchandise, connected with the heating and plumbing industries, under the name of \"Planet Heating Industries Limited\", with a capital stock of $50,000, divided into 500 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 2439 Notre-Dame Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of Februarv, 1951.L.DÉSILETS, 29803 Deputy Attorney General.Pollack's Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of February, 1951, incorporating: Isidore C.Pollack, lawyer, Samuel L.Pollack, doctor, and Roger Létourneau, lawyer, all of the City and Judicial District of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Pollack's Ltd\", with a capital stock of $30,000 divided into 300 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Quebec, Judicial District of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this nineteenth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803-o Deputy Attorney General.Procure Générale de Musique (Ltée) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February.1951, incorporating: Raymond Cossette, notary, Anne Marie Lajeunesse, secretary, both of Quebec, and Gilles Deniers, law student, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in music and musical instruments of all kinds, under the name of \"Procure Générale de Musique (Ltée)\", with a capita Jstock.of $40,000 divided into 200 common shares of $50 each and into 600 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803 Deputy Attorney General.Raphael Ruflb Demolition Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 1108 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 83, N° U province de Québec des lettres patentes, en date du seize février 1951, constituant en corporation: Raphaël Ruffo, démolisseur, Dame Annette Gohier, épouse séparée de biens dudit Raphaël Ruffo, Fernand Robitaille, contracteur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fournisseurs de matériaux de construction, et exercer l'industrie de la construction sous toutes ses formes.sous le nom de \"Raphaël Ruffo Démolition Limitée\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5497, Côte Saint-Luc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803-o L.DÉSILETS.Regis Trading Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt février 1951, constituant en corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Arthur Daniel Ruby, comptable agréé et Mi hired Brown, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de produits fabriqués, en tout ou en partie de cuir, caoutchouc,\"métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre, produits chimiques, et des produits de la terre, de la mer et de la forêt, sous le nom de \"Regis Trading Corporation\", avec un capital de $5,000 divisé en 50 actions de $100 chacune.' Le siège social de la compagnie sera à Montréal, dialrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt février 1951.L'Assistant-procu reu r général, 29803 L.DÉSILETS.René Binette Limitée René Binette Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze février 1951, constituant en corporation: René Binette, marchand, Mme Marie Hacala, ménagère, épouse de René Binette et Clément Perreault, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal.]>our les objets suivants: Conformément à la Loi des électriciens et des installations électriques (S.R.Q.1941, ch.172): exercer le commerce comme électriciens, manufacturiers et poseurs d'installations électriques, sous le nom de \"René Binette Limitée\"\u2014\"René Binette Limited\", avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4840 rue St-Denis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803 L.DÉSILETS.Roland Électrique Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent have Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of February, 1951, incorporating: Raphaël Ruffo, demolisher, Dame Annette Gohier, wife separate as to property of said Raphaël Ruffo, Fernand Robitaille, contractor, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of suppliers of building requisites, and to carry on the construction business in all lines of same, under the name of \"Raphaël Ruffo Démolition Limitée\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 5497 Côte Saint-Luc, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803 Deputy Attorney General.Regis Trading Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of February, 1951, incorporating: Milton Lowen Klein, advocate, Arthur Daniel Ruby, chartered accountant, and Mildred Brown, secretary, all of the city and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, made in whole or in part, of leather, rubber metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles glass, chemical products, land, sea and forest products, under the name of \"Regis Trading Corporation\", with a capital stock of $5,000.divided into 50 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803-o Deputy Attorney General.René Binette Limitée René Binette Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of February, 1951, incorporating: René Binette, merchant.Mrs.Marie Hacala, housekeeper, wife of René Binette, and Clément Perreault, accountant, all of the City of Judicial District of Montreal, for the following purposes: Subject to the Electricians and Electrical Installations Act (R.S.Q., 1941, Ch.172): to carry on the business of electricians, manufacturers and installers of electrical construction, under the name of \"Rene Binette Limitée\"\u2014 \"René Binette Limited\", with a capital stock of $40,000.divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the Company will be at 4840 St.Denis St.Montreal, Judicial District, of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fifteenth dav of Februarv, 1951.L.DÉSILETS, 29803-o Deputy Attorney General.Roland Électrique Inc. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7th, 1051, Vol.S3, No.IL 1109 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze février 1951, constituant en corporation: Antoine Gobeil, Jean Rivard, avocats', et Denise Villeneuve, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants \\M Sujet à la Loi des Electriciens et installations électriques (S.R.Q.1951, chap.172) exercer le commerce d'accessoires et appareils électriques; exercer le commerce d'entrepreneur électriciens, sous le nom de \"Roland Électrique Inc.\", ¦ Le capital-actions de la compagnie est divisé en 200 actions sans valeur au pair ou nominale et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $2,000.Le siège social tic la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté\"du bureau du Procureur général, le (piatorze février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803-o L.DÉSILETS.S.Lotansky Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du 14 février, 1951, constituant en corporation: Isidore Popligcr, avocat et conseil en loi du roi, Lawrence Popligcr, avocat, Samuel Litwin, agent d'assurance, et Samuel Lotansky, marchand, tous de la cité et district judiciaire de Montréal, poulies objets suivants: Exercer le commerce de boucherie, sous le nom de S.Lotansky Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le 14 février 1951.L'Assistant -procureur général, 29803 L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1951, incorporating: Antoine Gobeil, Jean Rivard, advocates, and Denise Villeneuve, secretary, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: Subject to the Electricians and Electrical Installations Act, (R.S.Q.1941, chap.172) to deal in electrical accessories and apparatus; to carry on business as electrical contractors, under the name of \"Roland Électrique Inc.\" The capital stock of the company will be divided into 200 shares without par or nominal value, and the amount of capital stock with which the company will begin its operations is 82,000.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of Februarv, 1951.L.DESILETS, 29803 Deputy Attorney General.S.Lotansky Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1951, incorporating: Isidore Popligcr, advocate ami King's Counsel, Lawrence Popliger, advocate, Samuel Litwin, insurance agent, and Samuel Lotansky, merchant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a butcher, under the name of \"S.Lotansky Ltd.\", with a capital stock of S40.000.divided 'into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of Februarv.1951.L.DÉSILETS, 29803-o Deputy Attorney General.St.Ann Realty Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu tic la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec des lettres patentes, en date du douze février 1951, constituant en corporation : John Gérald Coote, avocat, Hartley Lynch Joseph Aubin, \"manager\", et Lucile Gignac, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie d'immeubles et de placement, sous le nom de \"St.Ann Realty Co.Ltd.\", avec un capital de SI0,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le douze février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803-o L.DÉSILETS.St.Ann Realty Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of February, 1951, incorporating: John Gerald Coote, advocate, Hartley Lynch Joseph Aubin, manager, and Lucille Gignac, stenographer, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of St.Ann Realty Co.Ltd.\", with a capital stock of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of Februarv, 1951.L.DÉSILETS, 29S03 Deputy Attorney General.Tomeo & Colavccchio Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date Tomco & Colavecchio Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth 1110 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 83, N° IL du dix-neuf février 1951, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Anne Zif-kin, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal V» et Cyril E.Schwisberg, avocat d'Outre-mont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce commme manufacturiers et marchands de toutes sortes de fourrures et vêtements et accessoires en fourrures, sous le nom de \"Tomeo & Colavecchio Inc.\", avec un capital de §30,000 divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur ati pair de $100 chacune et 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 7463 St-Denis, cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803 L.DÉSILETS.Town Frocks Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du 10 février 1951, enostituant en corporation: Samuel Menakcr, manufacturer, Nathaniel Leonard Rappaport, avocat, et James Topping, surintendant, tous de la cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et faire le négoce de vêtements et habillements de toute sorte et description, sous le nom de \"Town Frocks Inc.\", avec un capital de $100,000 divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100.chacune, et 850 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le 10 février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803 L.DÉSILETS.Valcourt Print Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze février 1951, constituant4 en corporation: Joseph-Aimé Archambault, médecin-vétérinaire,- Dame Yvonne Drainville, garagiste, veuve de feu Georges Rodrigue, Yvon Brodeur, industriel, Romain Paquette, contracteur-élec-tricien, et Oréus Racicot, manufacturier, tous domiciliés à Valcourt, district judiciaire de Bedford, 'pour les objets suivants: Exercer le négoce d'imprimeurs et teinturiers d'étoffes, tissus, draps, ainsi que de tous autres produits textiles, de quelque nature qu'ils soient, sous le nom de \"Valcourt Print Limited\", avec un capital de $25,000 divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Valcourt, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le qua-quatorze février 1951.L'Assistant-procureur général, 29803-o L.DÉSILETS.day of February, 1951, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Anne Zifkin, secretary, both of the City of Montreal, and Cyril E.Schwisberg, advocate, of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers of, and dealers in all kinds of furs and fur garments and accessories, under the name of \"Tomeo & Colavecchio Inc.\", with a capital stock of $30,000.divided into 200 common shares of the par value of $100.each, and 100 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the Company will be at 7463 St.Denis St., City of Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this nineteenth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803-o Deputy Attorney General.Town Frocks Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of February, 1951, incorporating: Samuel Menaker, manufacturer, Nathaniel Leonard Rappaport, advocate, and James Topping, superintendent, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in garments and clothing of every description, under the name of \"Town Frocks Inc.\", with a capital stock of $100,000.divided into 150 common shares of a par value of $100.each, and 850 preferred shares of a par value of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office or the Attorney General, this tenth dav of February, 1951.L.DÉSILETS.29803-o Deputy Attorney General.Valcourt Print Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of February, 1951, incorporating: Joseph Aimé Archambault, veterinary surgeon, Dame Yvonne Drainville, garage-keeper, widow of the late Georges Rodrigue, Yvon Brodeur, industrialist, Romain Paquette, electrical contractor, and Oréus Racicot, manufacturer, all domiciled at Valcourt, judicial district of Bedford, for the following purposes: To carry on business as printers and dyers of materials, fabrics, cloths, and also of any other textile products, of whatever nature they may be, under the name of \"Valcourt Print Limited\", with a capital stock of $25,000, divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Valcourt, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of February, 1951.L.DÉSILETS, 29803 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7th, 1951, Vol 83, No.1L 1111 * Foyer de Charité Avis est donné qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la Loi des éveques catholiques romains, (14 George VI, chapitre 76), il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mars 1951, constituant en corporation le \"Foyer de Charité\".Le siège social de ladite corporation est situé dans la municipalité de Point-aux-Trembles, dans le district de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le\" 3 avril 1951.Le Sous-secrétaire\" de la province, 29824-o JEAN BRUCHÊSI.Foyer de Charité Notice is given that under the provisions of section 20 of the Roman Catholic Bishops Act, (14 George VI, chapter 76) letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of March, 1951, incorporating the \"Foyer de Charité\".The head office of the said corporation is situate in the municipality of Pointe-aux-Trem-bles, in the district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, Aprils, 1951.JEAN BRUCHÊSI, 29824 Under Secretary of the Province.Actions en séparation de biens Actions for separation as to property Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure, N° 297919.Dame Thérèse Bourque, ménagère, épouse commune en biens de Paul Lcmaire, entrepreneur général, de Ville Lasalle, district de Montréal, demanderesse, vs Ledit Paul Lcmaire, de Ville Lasalle, dit district de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 29ème jour de mars 1951.Montréal, le 31 mars 1951.Les Procureurs de la demanderesse, RODIER & RODIER, avocats, suite 911, Edifice Aldred, 507 Place d'Armes, 29805-o Montréal.Canada, Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure, N° 294 854.Dame Marie Anna Jobin, épouse commune en biens de Ovila Marcotte journalier, résidant au N° 8325 de la rue St-Dominique, dans les Cité et District de Montréal, demanderesse, vs Ovila Marcotte, époux commun en biens de Marie-Anna Jobin, journalier résidant au N° 8325 de la rue St-Dominique, dans les Cité et District de Montréal, défendant.Avis est donné par les présentes, qu'une action en séparation de biens a été instituée par la demanderesse contre le défendeur.Montréal, le 27 mars 1951.Le Procureur de la demanderesse.29806-o PHILIPPE AUBE.Canada, Province de Québec.District de Terrebonne, Cour Supérieure.N° 20.608.Dame Georgette Normand, de la ville de Lachute, comté d'Argenteuil, district de Terrelwnne, épouse commune en biens «le Jean Lomcr Sauvé des mêmes lieux et district, promoteur, demanderesse, vs Jean Lomcr Sauvé, de la dite ville de Lachute, comté d'Argenteuil, district de Terrebonne, défendeur.Un action en séparation «le biens a été instituée en cette cause, le cinquième jour du mois de mars, mil neuf cent cinquante et un.St-Jérômc, le 30 mars.1951.Les Procureurs «le la demanderesse, 29807-o LEGAULT & LEGAULT.Province «le Québec, District «le Montréal.Cour Supérieure, N° 29S13S.Dame Dora Chazen, demanderesse vs Jack Rahinovitch.de-feneur.Une action eu séparation «le biens a été intentée dans cette cause contre le défendeur en date du 4 avril 1951.Le Procureur «le la «leman«ler«^-e.29839 R.L.BERCOVTTCH.Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.297919.Dame Thérèse Bourque, housekeeper, wife common as to property of Paid Lemaire, general contractor, of Ville Lasalle, district of Montreal, plaintiff, vs The said Paul Lemaire, of Ville Lasalle, said district of Montreal, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this case on March 29, 1951.Montreal, March 31, 1951.RODIER & RODIER, advocates, suite 911, Aldred Bldg., 507 Place d'Armes, Montreal.29805 Attorneys for Plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.294 854.Dame Marie Anna Jobiu, wife common as to property of Ovila Marcotte, journeyman, domiciled at No.8325 St.Dominique Street in the City ami District of Montreal, plaintiff, vs Ovila Marcotte, journeyman, domiciled at No.8325 St.Dominique Street, in the City and District of Montreal, defendant.Notice is hereby given that an Action in separation as to property has been taken by the plaintiff against the defendant in the present case.Montreal, the 27th.of March 1951.PHILLIPE AUBÉ.29806-o Attorney for the Plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of Terrebonne.Superior Court, No.20,608.Dame Georgette Normand, of the town of Lachute, county of Argentcuil, district of Terrebonne, wife common as to property of Jean Lomer Sauvé, of the same place ami district, promoteur plaintiff; vs Jean Lomer Sauvé, of said town of Lachute, county of Argentcuil, district of Terrebonne, defendant.An action for separation as to property was instituted in this case on the fifth day of the month of March nineteen humlrcd and fifty-one.St.Jérôme, March 30.1951.LEGAULT & LEGAULT, 29807 Attorneys for the plaintiff.Province of Quebec.District of Montreal.Superior Court, No.208138.Dame Dora Chazen.plaintiff, vs Jack Rabinovitch, defend-and.An action in separation as to property has been instituted in this case against the defendant on the 4th day «>f April, l !>;>!.R.L.BERCOVITCH.29S30-o Attorney f«>r plaintiff. 1112 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 83, N° Il ARRÊTE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 287 Québec, le 22 mars 1951.Présent: Le Liteutcnant-Gouverncur-cn-Conseil.Concernant des modifications aux règlements pris en exécution de la Loi des mécaniciens en tuyauterie.Attendu que pour fins de sécurité publique, il a été reconnu nécessaire de contrôler le compétence des entrepreneurs et des compagnons poseurs brûleurs à l'huile; Attendu que l'accroissement du nombre des licences émises et du champ d'application de la loi rend nécessaire l'émission de licences distinctes pour chaque catégorie d'entrepreneur et «l'ouvrier: Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'Honorable Ministre du Travail: Que soient approuvées les modifications aux règlements pris en exécution de la loi des mécaniciens en tuyauterie (chapitre 173 des statuts refondus de Québec 19-11) édictés par l'arrêté ministériel numéro 1117 du 10 mai 1934 modifiés par les arrêtés ministériels numéros 2757 du 23 décembre 1938 et 097 du 14 juin 19Ô0, dont copie est annexée à la proposition susdite.A.MORISSET, 29840-o Greffier du Conseil Exécutif.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 2S7 Quebec, March 22, 1951 Present: The Lieutenant Governor in Council.Concerning amendments of the regulations enacted under the Pipe Mechanics Act.Whereas, for purposes of public safety, it has been deemed advisable to supervise the competency of contractors and journeymen doing the installation of oil burners; Whereas the increase in number of the licenses issued and the wider scope of the Act have made it necessary to issue distinct licenses for each category of contractors and workers; Ii is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour, That the amendments to the regulations enacted under the Pipe Mechanics Act (chapter 173 of the Revised Statutes of Quebec, 1941) by Order in Council number 1117 of May 16, 1934, amended by Orders 2757 of December 23, 1938, and 697 of June 14, 1950, copy of which is annexed to the above-mentioned recommendation, be approved.A.MORISSET, 29840-o Clerk of the Executive Council.Modifications aux règlements pris en exécution de la \\aà des mécaniciens en tuyauterie.1.Les articles 2a et 2b édictés par l'arrêté ministériel numéro 097 du 14 juin 1950, lequel modifiait l'arrêté ministériel numéro 1117 du 0 mai 1934 sont radiés et remplacés par les suivants: 2a.Les entrepreneurs poseurs «le brûleurs à l'huile pour le chauffage central doivent obtenir la licence E A tel que mentionné à l'article 2 des présents règlements.Cette licence est octroyée comme une sous-classification de système de chauffage.2b.Les ouvriers poseurs de brûleurs à l'huile doivent obtenir la licence C A tel que mentionné à l'article 2 des présents règlements.L'apprentissage est d'une année plus un stage d'une autre année à titre de compagnon junior.Après avoir subi avec succès les examens requis, l'ouvrier obtient la licence C A.2.Les articles 3, 5 et 6 édictés par l'arrêté ministériel numéro 2757 du 23 décembre 193S lequel modifiait l'arrêté ministériel numéro 1117 du G mai 1934 sont radiés et remplacés par les suivants: 3.L'honoraire d'une licence d'entrepreneur, pour chaque métier ou chaque sous-classification de métier, est de 815.00.L'honoraire d'une licence de compagnon C A, C A junior, C B, C B junior ou C C, pour chaque métier ou chaque sous-classification de métier, est de SI .00.L'honoraire d'une licence d'apprenti, pour chaque métier ou chaque sous-classification de métier, est de $0.25.5.L'honoraire pour le renouvellement d'une licence d'entrepreneur, de compagnon ou «l'appren ti est le même que celui exigé pour l'émission.amendments to the regulations enacted under the Pipe Mechanics Act.1.Article 2a and 2b.enacted by Order in Council number 097 of June 14, 1950, which amen ded Order in Council number 1117 of May 0.1934, are deleted and the following substituted therefor: 2a.Contractors doing the installation of oil burners for central heating shall obtain license E A as mentioned in article 2 hereof.This license is granted as a heating system sub-classification.2b.Workers doing the installation of oil burners shall obtain license C A as mentioned in article 2 hereof.Apprenticeship shall consist of one year plus another period of one year as junior journeyman.Once he has passed the required examinations, the worker obtains license C A.2.Article 3, 5 and 6, enacted by Order in Council number 2757 of December 23, 1938, which amended Order in Council number 1117 of May 0.1934, are deleted and the following substituted therefor: 3.Thé contractor's license fee.for each trade or trade sub-classification, is 815.00 The fee for the following journeymen's licenses: C A, C A junior, C B, C B junior or C C.for each trade or trade sub-classification, is SI 00.The apprentice's license fee, for each trade or trade sub-classification, is SO.25.5.The fee for#the renewal of a contractor's, journeyman's or apprentice's license is the same as that established for the original issue.Arrêtés en Conseil Orders in Council QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7th, 1951, Vol 83, No.1L 1113 6.Lc bureau des examinateurs émet une autre licence de compagnon ou d'apprenti pour remplacer une licence perdue, volée ou détruite, sur présentation des preuves nécessaires.Dans un tel cas l'honoraire est lc même que celui chargé régulièrement.29846-0 ARRÊTE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 253 Québec, le 22 mars 1951.Présent : Lc Licutcnaht-Gouvcrncur-cn-Conscil.Concernant l'enregistrement des véhicules automobiles.Attendu que le Lieutenant-gouverneur en conseil a autorisé, en vertu de l'article 68 de la Ix>i des véchicules automobiles (chapitre 142, S.R.Q.1941) de faire des règlements concernant l'enregistrement des véhicules automobiles; Il est ordonné en conséquence, sur la proposition de l'honorable Trésorier de la province:\u2014 Que la partie de l'arrêté en conseil numéro 205, du 28 février 1951, qui prolongeait la validité de l'enregistrement «les véhicules automobiles et des permis de conduire, soit modifiée en substituant les mots \"30 avril\" au mots \"31 mars\".Extrait.A.MORISSET.29829-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 319 Québec, le 28 mars 1951.Présent: Le Lieutenant-gouverneur-en-Conscil Section \"A\" Concernant des modifications au décret relatif aux Métiers de l'Imprimerie dans l'Ile de Montréal et un rayon de 100 milles de ses limites.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de l'Imprimerie dans l'Ile de Montréal et un rayon de 100 milles de ses limites, rendue obligatoire par lc décret numéro 3088 du 7 août 1946, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements: Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 10 février 1951; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 3088, soit modifié comme suit : 1° Le paragraphe \"d\" de l'article III est radié et remplacé par le suivant: TJX._ d) Lc mot \"aide\" désigne un salarié inexpérimenté du sexe masculin effectuant «les travaux manuels ne nécessitant aucune forina- 6.The Board of Examiners issues another journeyman's or apprentice's license to replace a license which was lost, stolen or destroyed upon production of necessary evidence.In such cases, the fee is the same as the one regularly charged.29846-0 ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 253 Quebec, March 22, 1951.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the registration of motor vehicles.Whereas the Lieutenant-Governor in Council is authorized under section 68 of the Motor Vehicles Ad (Chapter 142.R.S.Q.1941), to make regulation of motor vehicles; It is therefore ordered, upon the recommendation of the Honourable the Treasurer of the Province: That the part of Order in Council number 205, of February 28, 1951, extending the validity of the registration of motor vehicles and driver's permit, be now amended by replacing the words \"March 31st\" by the words \"April 30th\".Extract.A.MORISSET, 29S29-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 319 Quebec, March 28, 1951.Present: The Lieutenant-Governor in Council Part \"A\" CONCERNING amendments of the decree relating to the printing trades in the Island of Montreal and a radius of 100 miles from its limits.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec.1941, Chapter 163 and amendments), the contracting parties to the Collective Lal>our Agreement Relating to the Printing Trades in the Island of Montreal and a radius of 100 miles from its limits rendered obligatory by decree number 30SS of August 7, 1946, have submitted to the Minister of Labour, a request to amend the said decree and its amendments: Whereas the said request has l>ecn published in the Quebec Official Gazette, issue of February 10.1951; Whereas the objections set forth have l>een considered in pursuance of the Act; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, numtar 30S8, l>c amen-ed as follows: 1.Subsection d) of Section III is deleted and replaced by the following: \"III.cen pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Dawes Realty Company\", incorporated by letters patent dated the 3rd dav of August, 1923. 1122 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 88, N° IL Avis est de plus donné qu'à compter «lu deux avril 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 3 avril 1951.L'Assistant-procureur général, 29823 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus dc Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon dc la charte de la compagnie 'Gaucher & Fils Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 janvier 1950.Avis est de plus donné qu'à compter du 2 avril 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 3 avril 1951.L'Assistant-procureur général, 29823-o L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Quélwc, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Gauthier & Qucnnevillc, Limitée', constituée en corporation par lettres patentes en date du 21 novembre 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du 2 avril 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 3 avril 1951.L'Assistant-procureur général, 29823-0 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 20, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte «le la compagnie \"Jack Krefting Limited!', constituée en corporation par lettres patentes en date du 3 février 1950.Avis est de plus donné qu'à compter «lu deux avril 1951, ladite compagnie a été «lissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 3 avril 1951.L'Assistant-procureur général, 29823 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 20, chapitre 270, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Lennox Investment Co.Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 juin 1934.Avis est de plus donné qu'à compter du deux avril 1951, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau «lu Procureur général, ce 3 avril 1951.L'Assistant-procureur général.29823 L.DÉSILETS.Notice is also given that from and after the second day of April, 1951, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 3rd day of April, 1951.L.DÉSILETS, 29S23-o Deputy Attorney General Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 270, section 20, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Gaucher & Fils Limitée\", incorporated by letters patent dated the tenth day of January, 1950.Notice is also given that from and after the second 0 .décembre 1901 décembre 1962 .décembre 1963 .décembre 1964 .décembre 1905 .1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 975,000 \u2014 16 ans Capital .82.000.00 .2.000.00 .2,000.00 .2,000.00 .2.000.00 .2.000.00 .3.000.00 .3.000.00 .5.000.00 .5.000.00 .9.000.00 .9.000.00 .9.000.00 .9,000.00 .11.000.00 Table of Redemption \u2014 Year December 1st, 1951 .December 1st, 1952 .December 1st, 1953 .December 1st, 1954 .December 1st, 1955 .December 1st, 1956 .December 1st, 1957 .December 1st, 1958 .December 1st, 1959 .December 1st, 1960 .December 1st, 1961 .December 1st, 1962 .December 1st, 1963 .December 1st, 1964 .December 1st, 1965 .$75,000 \u2014 15 years Capital .$2,000.00 .2,000.00 .2,000.00 .2,000.00 .2,000.00 .2,000.00 .3,000.00 .3.000.00 .5,000.00 .5.000.00 .9.000.00 .9,000.00 .9,000.00 .9,000.00 .11,000.00 Le capital et les intérêts sont payables à la Capital and interest are payable at the bank banque dont le nom est mentionné dans la pro- mentioned in the loan procedure, at Montreal, cédure d'emprunt, à Montréal, Québec ou à Quebec or at Belœil.Belœil. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7th, 1951, Vol.88, No.14 1141 Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue le lundi 23 avril 1951, à 8 heures p.m., à l'Hôtel de Ville, rue Laurier^ Belœil.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Belœil, (Comté de Verchères), ce 4 avril 1951.Le Sécrétaire-trésorier, P.-R.CHGQUETTE, Hôtel de Ville, rue Laurier, 29841-0 Belœil.(Comté de Verchères).P.Q.The said bonds may be redeemed by antici pation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date, under the authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday the 23rd of April, 1951, at eight o'clock in the evening, at the Town Hall, Laurier Street, Belœil.The council docs not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Bclœil (County of Verchères), this 4th day of April, 1951.P.-R.CHOQUETTE, Secretary -Trcasu rer, Town Hall, Laurier Street, 29841 Belœil (County Verchères) P.Q.Province de Québec Village St-Joseph (Comté de St-Hyacinthe) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Roméo Forbes, secrétaire-trésorier, 53, rue Centrale, Village St-Joseph, Clé St-Hyacinthe, jusqu'à 8 heures p.m., mardi lc 24 avril 1951, pour l'achat de $75,000 d'obligations du village St-Joseph, comté de St-Hyacinthe, datées du 1er avril 1951 et remboursables par séries des 1er avril 1952 au 1er avril 1966 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3%% pur année payable semi-annucllcment les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut avrier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Province of Quebec Village of St-Joseph (County of St-Hyacinthe) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Roméo Forbes, secretary-treasurer, 53 Centrale street, Village of St-Joseph, county of St-Hyacinthe, up to eight o'clock in the evening, Tuesday, the 24th day of April, 1951, for the purchase of $75,000 of bonds of the Village of St-Joseph, county of St-Hyacinthe, dated the 1st of April, 1951, and redeemable serially from the 1st of April, 1952 to the 1st of April, 1966, inclusively, with interest at a rate not exceeding 3%% per annum, payable semi-annually the 1st of April and 1st of October of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $75,000 \u2014 15 ans Table of Redemption \u2014 875,000 \u2014 15 years Année Capital 1er avril 1952 .S 1,500.00 1er avril 1953 .1,500.00 1er avril 1954 .1.500.00 1er avril 1955 .1,500.00 1er avril 1956 .1,500.00 1er avril 1957 .* 1,500.00 1er avril 1958 .1,500.00 1er avril 1959 .2.000.00 1er avril 1960 .2.000.00 1er avril 1961.2.000.00 1er avril 1962 .2.000.00 1er avril 1963 .2.000.00 1er avril 1964 .2.000.00 1er avril 1965 .2.000.00 1er avril 1966 .50,500.00 Year Capital 1st April 1952.$ 1,500.00 1st April 1953.1,500.00 1st April 1954.1,500.00 1st April 1955.1,500.00 1st April 1956.1,500.00 1st April 1957.1,500.00 1st April 1958.1,500.00 1st April 1959.2,000.00 1st April 1960 .2,000.00 1st April 1961.2,000.00 1st April 1962.2,000.00 1st April 1963 .2,000.00 1st April 1964 .2,000.00 1st April 1965 .2.000.00 1st April 1966 .50,500.00 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure «l'emprunt à Montréal, à Québec ou au village St-Joseph, comté dc St-Hyacinthe.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or in the Village of St-Joseph, county of St-Hyacinthe.The said bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date, under authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941 ; however, 1142 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome S3, N° H cependant, si tel rachat est partiel, il afi'ectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue le mardi 24 avril 1951, à 8 heures p.m., dans le sous-basse-ment de l'Ecole du Sacré-Cœur, rue St-Pierre, Village St-Joseph, comté dc St-Hyacinthe.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Joseph (Comté de St-Hyacinthe).ce 4 avril 1951.Lc Secrétaire-! résorier, ROMÉO FORBES, 53, rue Centrale, Village St-Joseph, 29843-0 (Cté-St-Hyacinthe), Que.Province de Québec Commission scolaire de la villi-; de Ste-Thérèse (Comté de Terrebonne) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Antonio Forget, secrétaire-trésorier, 78, rue Blainville-Ouest, Ste-Thérèse, Cté Terrebonne, jusqu'à 8 heures p.m., mercredi le 25 avril 1951, pour l'achat de 855,000 d'obligations de la commission scolaire de la ville de Ste-Thérèse, datées du 1er mai 1951 et remboursables par séries du 1er mai 1952 au 1er mai 1971 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3l£% par année payable scmi-annucllemcnt les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014*6ô,000\u201420 ans Année Capital 1er mai 1952.xSO.500.00 1er mai 1953.x 7,000.00 1er mai 1954.x 7,000.00 1er mai 1955.x 7,500.00 1er mai 1950.1.500.00 1er mai 1957.1,500.00 1er mai 1958.1,500.00 1er mai 1959.1,500.00 1er mai 1960.1,500.00 1er mai 1961.1,500.00 - 1er mai 1902.1,500.00 1er mai 1963.1,500.00 1er mai 1964.1,500.00 1er mai 1965.1,500.00 1er mai 1966 .2,000.00 1er mai 1967.2,000.00 1er mai 1968 .2,000.00 1er mai 1969 .2,000.00 1er mai 1970 .2,000.00 1er mai 1971.2,000.00 Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $25,-266.00, accordé par le Secrétaire de la province et payable en quatre versements de $6,316.50 chacun, de 1952 à 1955 inclusivement, seront reçu et appliqués au service de cet emprunt.if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, the 24th day of April, 1951, at eight o'clock in the evening, in the basement of the Sacré-Cœur school, (École du Sacré-Cœur) St-Pierre street, Village of St-Joseph, county of St-Hyacinthe.% The council docs not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.St-Joseph (County of St-Hycainthe), this 4th dav of April, 1951.ROMÉO FORBES, Secretary-Treasurer, 53, Centrale street, Village of St-Joseph, 29843 (County of St-Hyacinthe).Que.Province of Quebec School Commission of the Town of Ste-Thérèse (County of Terrebonne) Public notice is'hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Antonio Forget, Sccietary-trcasurer, 7.S Blainville street West, Ste-Thérèse, county of Terrebonne, up to eight o'clock in the evening, Wednesday, the 25th day of April, 1951, for the purchase of $55,000 ôf bonds of the School Commission of the Town of Ste-Thérèse, dated the 1st of May, 1951, and redeemable serially from the 1st of May, 1952.to the 1st of May, 1971, inclusively, with interest at a rate not exceeding 3j.-> per annum, payable semi-annually the 1st of May and 1st of November of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of recemption is as follows: Table of Redemption\u2014$55,000\u2014JO years Year Capital May 1st, 1952.x$6.500.00 May 1st, 1953.x 7,000.00 May 1st, 1954.x 7,000.00 May 1st.1955.x 7,500.00 May 1st, 1956.1,500.00 Mav 1st, 1957.1,500.00 May 1st, 1958.1,500.00 May 1st, 1959.1,500.00 May 1st.1900.1,500.00 May 1st, 1961.1,500.00 May 1st.1962.1.500.00 May 1st, 1963.1,500.00 May 1st, 1964.1,500.00 Mav 1st.1965.1,500.00 May 1st, 1966 .2.000.00 Mav 1st, 1967 .2,000.00 May 1st, 1968 .2,000.00 May 1st, 1969.2,000.00 Mav 1st, 1970.2,000.00 May 1st, 1971.2.000.00 The letters x indicate the years during which annual payments of a total amount of $25,266.00 granted by the Provincial Secretary and payable in four instalments of $6,310.50 each, from 1952 to 1955 inclusively, will be received and applied to the use of this loan. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7th, 1961, Vol.83, No.U 1143 Le capital et les intérêts sont payables à lu bunque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, a Québec ou à Ste-Thérèse, comté de Terrebonne.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées pur anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel ruchat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix olfert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance de lu commission scolaire qui sera tenue mercredi le 25 avril 1951, à 8 heures p.m., à l'Académie Ste-Thérèse, à Ville Ste-Thérèse, comté de Terrebonne.lies commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni lu plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Thérèse (Comté de Terrebonne), ce 4 avril 1951.Lc Secrétaire-trésorier, ANTONIO FORGET, 78, rue Blainvillc-Oucst, Ste-Thérèse, (('té Terrebonne), 29842-o Québec.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at Ste-Thérèse, county of Terrebonne.The said bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date, under the authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Québec, 1941; however, if such redemption by partial, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompagnied by an accepted cheque equal to 1% of the amount of the loan and must specify whether the price offered includes or docs not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commission, to be held on Wednesday, the 25th day of April, 1951, at eight o'clock in the evening, at the Ste-Thérèse Academy (Académie Ste-Théièse), in the Town of Ste-Thérèse, county of Terrebonne.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Ste-Thérèse, (County of Terrebonne), this 4th .lay of April, 1951.ANTONIO FORGET, \u2022 Secietary-Treasurer, 78, Blainville street West, Ste-Thérèse, (Cty of Terrebonne)', 29842 Quebec.Province de Québec Commission scolaire DE StE-ThERÈSE DE L'Enfant-Jesus (Cowansville) (Comte de Missisquoi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Roger Lussier, secrétaire-trésorier, CP.400, Cowansville, comté de Missisquoi jusqu'à 8 heures p.m., lundi le 23 avril 1951, pour l'achat de $375,000 d'obligations «le la commission scolaire «le Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus (Cowansville), «latées du 1er décembre 1950 et remboursables par séries du 1er «lécembre 1951 au 1er «lécembre 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux n'excédant pas 3%% par annt'c payuble scmi-annucl-lement les 1er juin et 1er «lécembre «le chaque année.Les taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014$375,000\u201420 ans Année Capital 1er décembre 1951.x$22.500.00 1er décembre 1952.x 23,000.00 1er décembre 1953.x 24,000.00 1er décembre 1954.x 25.000 00 1er décembre 1955.x 26.000.00 1er décembre 1956.x 26,500.00 1er «lécembre 1957.x 27.500 00 1er décembre 1958.x 28,500.00 1er décembre 1959.x 29,500 00 1er décembre 1960.x 30,500.00 1er décembre 1961.9,500.00 1er «lécembre 1962.10,000.00 1er décembre 1963.10,500.00 1er décembre 1964.10,500 00 1er «lécembre 1965.11.000 00 1er décembre 1966.11,500.00 1er décembre 1967.11,500.00 1er décembre 1968.12.000.00 1 er décembre 1969.12,500.00 1er décembre 1970.13.000.00 Province of Quebec School Commission of Ste-Thf.rese de L'Enfant-Jésus (('owansville) (County of Missisquoi) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bomls\" will be received by the undersigned, Roger Lussier, secretary-treasurer, P.O.Box 400, Cowansville, county of Missisquoi, up to eight o'clock in the evening, Monday, the 23r«l «hiy of April, 1951, for the purchase of $375.000 «>f bonds of the School Commission of Ste-Thérèse «le l'Enfant-.h'vsiis (Cowansville), dated the 1st of December, 1050, ami redeemable serially from the 1st of December, 1951, to the 1st «if December, 1970, inclusively, with interest at a rate not exceeding 3/i% per annum, payable semi-annually the 1st of June ami 1st of December of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vury uccording to maturities.The table of reccmption is as follows: Table of rcdemption \u2014 9375,000 \u2014 20 years Year\t\tCapital\t December 1st, 1951 .\t.x\t$22.500\t00 DeccimVr 1st.1952.\t.X\t23,000\t00 December 1st.1058.\t.x\t24,000\t00 December 1st.1954 .\t.x\t25.000\t00 December 1st, 1955 .\t.x\t26,000\t00 December 1st.1956.\t.x\t26.500\t00 DccciuIht 1st.1957 .\t.x\t27,500\t00 December 1st, 195S .\t.x\t28.500\t00 December 1st.1959.\t.x\t29.5(H)\t(X) December 1st, 1900 .\t.x\t30,500\t00 December 1st.1961 .\t\t9.500\t00 Decemb r 1st.1962 .\t\t10.000\t00 December 1st.1963 .\t\t10.500\t00 \t\t10,500\t00 December 1st, 1965 .\t\t11,000\t00 D«-cember 1st.19(56 .\t\t11,500\t00 DecemlMT 1st, 1967 .\t\t11.500\t00 December 1st.196S\t\t12.000\t00 DecemlKT 1st, 1969\t\t12.500\t00 December 1st, 1970.\t\t13,000\t00 1144 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 83, N° IL Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $220,-997.40, accordé par le Secrétaire de la province et payable en dix versements de $22,099.74 chacun, de 1951 à 19(50 inclusivement, seront reçu et appliqués au service de cet emprunt.Lc capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou a Cowansville.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance dc la commission scolaire qui sera tenue lundi le 23 avril 1951 à 8 heures p.m.à l'école St-Léon, Boulevard Davignon, Cowansville.Les commissaires d'école se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Cowansville (Comté de Missisquoi), ce 5 avril.1951.Le Secrétaire-trésorier, ROGER LUSSIER, CP.400, Cowansville, (Cté de Missisquoi), 29854-0 Québec.The letters \"X\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $220.997.40 granted by the Provincial Secretary and payable in ten instalments of $22.099.74 each, from 1951 to 19(50 inclusively, will be received and applied to the use of this loan.Capital ami interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, Quebec or at Cowansville.The said bonds may be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date, under authority of chapter 212 of the Revised Statutes of Quebec, 1941; however, if such redemption be partial, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.' Each tender must be accompanied by an accepted cheque equal to 1% of the amount of the loan and must specify whether the price offered includes or does not include accrued interest on the bonds to time of their delivery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commission, to be held on Monday, the 23rd day of April, 1951.at eight o'clock in the evening, at the St-Léon School, Boulevard Davignou, Cowansville.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest nor any of the tenders.Cowansville (County of Missisquoi), this 5th day of April.1951.ROGER LUSSIER.Secretary-Treasurer.P.O.Box 400, Cowansville (Countv of Missisquoi), 29854 Que.Ventes par licitations Province de Québec, District de Saint-Hyacinthe, N° 6781, Cour Supérieure.Mlle Honorine Dumaine, demanderesse; vs Clovis Dumuine, défendeur, et Mlle Eva Dumaine, mise-en-cause.AVIS Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant ù Saint-Hyacinthe, dans le district de Saint-Hyacinthe, le 13ème jour de mars 1951, dans une cause dans laquelle Mlle Honorine Dumaine, de Saint-Hugues de Bagot, district de Saint-Hyacinthe, est demanderesse, ordonnant la licitation de certains immeubles désignés comme suit, savoir: \"Une ferme située en la paroisse de Saint-Hugues, désignée comme étant le lot numéro trois cent un (n° 301) uu cadastre officiel de cette paroisse, mesurant trois arpents dc largeur sur trente arpents de profondeur, le tout plus ou moins, à distraire, cependant dudit lot.les emplacements appartenant à Polydore Bazinet, Mine W.Melancon, la corporation du village Saint-Hugues et Paul Laporte, ou leurs représentants.\" L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur lc VINGT-SIXiÈME jour d'AVRl L 1951.Cour tenante, dans la salle «l'audience du Palais de Justice de Saint-Hyacinthe, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier «les clutrges déposé au gieffe du protonotaire «le ladite Cour; et que toute opposition à fin d'annuler, à fin «le charge ou a fin «le distraire à ladite licitation, devra être déposée au greffe «lu proto- Sales by Licitations Province of Quebec, District of Saint-Hyacinthe, No.67S1, Superior Court.Miss Honorine Dumaine, plaintiff; vs Clovis Dumuine, defendant; and Miss Evu Dumuine, ini.se-en-cau.se.NOTICE Notice is given that in virtue of a judgment of Superior Court, sitting at Saint-Hyacmthe, in the «listrict oscr lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent avis, ils seront forclos «lu «lroit de le faire.Un dépôt de $5,000.00 «levra être fait entre les mains de l'officier chargé de la vente, par tout offrant et enchérisseur avant son offre ou enchère.Montréal, 20 mars 1951.Les Avocats «lu demandeur, 29751-12-2-o Trudeau, Beaulieu & Ethier.charges or to withdraw from the said licitation must be filed in the office of the Prothonotary of the said Court, at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication ami all opposition to payment must be filed within six days after the adjudication, ami failing the parties to file such oppositions within the delays herein prescribed, they shall be foreclosed from so doing.Saint-Hyacinthe, this 19th of March, 1951.PH.POTHIER, 29731-12-2 Attorney for the plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.239-912.NOTICE OF LICITATION* Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court, sitting at Montreal, for the «listrict of Montreal, rendered on the 16th day of October 1950.by Honourable Justice Joseph Jean, in a case wherein Albert amont, clerk, is plaintiff and Ernestine Aumont, Marie-Anne Aumont.Alphonse Aumont, tavern keeper, Charles-Ed.Aumont, clerk ami René Aumont, civil employee, arc defendants, all of the city and district of Montreal, the licitation of the following immovables was ordered, to wit: an emplacement, in the city of Montreal, fionting on Ontario Street, East, measuring thirty feet in width on the said street, by eighty four feet in depth on Jeanne d'Arc Street forming an area of two thousand and five hun«lrc«l and twenty square feet, English measure and more or less, the said emplacement being composed of: the lot of land known and designated as number three hundred and three of the official subdivision of the original lot number fourteen (14-303) on the official plan and in the book of reference for the incorporated bvillage of Hoehelaga; the said lot of laud being bounded: on the north by the number (11-301), on the southwest by the number (14-302), on the southeast by the number (14-301), and on the northwest by the number (14-312).With the buildings thereon erected bearing the civic numbers 4021.4023, 4025 Ontario Street East.The above described immovables will be sold by auction ami adjudged to the highest ami last bidder, WEDNESDAY on the TWENTY-FIFTH day of APRIL, 1951.at HALF PAST TEN o'clock in the forenoon (daylight Saving Time, if in force in Montreal, otherwise at stan-dard time.) in the Court Room No.31 of the Court House, at Montreal, or in any other Court Room to which the interested parties may l>e referre«l.the whole subject to the charges, clauses and comlitions mentioned in the list of charges file«l in the office of the Prothonotary of the sai«l Couit; and any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation must be filed in the office of the Prothonotary at least twelve days l>efore the day fixe«l as aforesaid f«>r the sale and adjudication ami any opposition for payment must be filed within six days following the adjudication; ami.failing the interested parties to file the said oppositions within the delays hereby limited, they shall be forecloses from so doing.A deposit, of $5.000.00 by each and every bidder to l>e made to the officer in charge of the sale, before his bid or offer.\\ Montreal.March 20th.1951.Trudeau, Beaumeu & Ethier, 29751-12-2-o Attorneys for plaintiff. 1146 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 83, N° 14 Ventes pour taxes Sales for Taxes Province de Québec \u2014 Comté de Châteauguay Province of Quebec\u2014County of Chateauguay Ville de Châteauguay Town of Châteauguay Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la ville de Châteauguay, que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique au bureau du Conseil, à l'hôtel de ville de la susdite Municipalité, MARDI le PREMIER jour de MAI 1951, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales, scolaires et intérêts, mentionnées dans l'état ci-dessous et les frais qui seront subsé-quemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.Public notice is hereby given by the undersigned, secretary-treasurer of the Town of Chateauguay, that the properties hereinafter described, will be sold by public auction at the office of the Council at the Town Hall of the aforesaid Municipality TUESDAY, on the FIRST day of the month of MAY 1951, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy to the payment of municipal and school taxes with interest mentioned in the hereunder statement, and the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes-interest and costs be paid before the sale.Propriétaires Proprietors\tCadastre\tSubdivisions\tTaxes dues Taxes due Poirier, Eugène, adresse inconnues\u2014address unknown.Lussier, Suce.\u2014Est.-Louis, bâtisses seulement\u2014Buildings\t275.\t53.\t9.77 18.22 98.44 \t49.\t1, 32 à-to 36.41 à-to 44, 49 à-to 52.59 à-to 64, 70 à-to 73.78 à-to81.\t De la partie N.E.du lot 49.des subdivisions 5.28, 31, 58, ainsi que la moitiée N.E.de (a subdivision 84, aussi cette partie N.E.non subdivisée du dit lot 49.Avec les b&tisscs dessus construites.Jack, Suce\u2014Est.Wm.A.Of the N.E.part of lot 49.subdivisions 5, 28.31, 58.of one half of the N.E.of 84, and also the N.E.part not subdivided of said lot 49.With buildings thereon erected.3.\t1 à-to 127.12.\t P.13.\t1 à- to 75.P.14.\t1 à-to 42.P.15.\t1 à-to 27.P.15.\t32 à-to 56.Avec les bâtisses dessus construites.With buildings thereon erected.Sauvé, René.1.Un terrain faisant partie du lot 275 subdivision P.46, borné on front, par la rue Jeanne d'Arc, en arrière Par le lot 278, vers l'est par la partie du lot 46 et vers ouest par le lot 47, mesurant 16 pieds 2/3 par la profondeur.2.Un terrain faisant partie du lot 275, subdivision P.47, borné en front par la rue Jeanne d'Arc, en arrière par le lot 278, vers l'est par le lot 46, et vers l'ouest par le résidu du lot 47, mesurant 41 pieds 2/3 par la profondeur.Avec les bâtisses dessus construites.Bertrand, Euclide.Un terrain faisant partie du lot 13 subdivision P.78 et P.79, borné en front par la rue Latour, vers l'ouest par partie du lot 79, vers le nord par P.80 et vers l'est par le résidu des dits lots 78 et 79, mesurant 50 pieds de largeur par 100 pieds de profondeur, avec les bâtisses dessus construites.Tucker, Edith M.épouse de\u2014 J.E.Lanktree.1.Un terrain faisant partie du lot 278 subdivision 273.Avec bâtisses.2.Un terrain faisant partie du lot 278 subdivision P.268, borné en front par la rue Crépin.vers le sud par le lot 269, d'un côté par les lots 272 et 273 et de l'autre côté par le résidu du dit lot 268, mesurant 20 pieds de largeur, par 90 pieds de profondeur.Avec bâtisses dessus construites.128.39 69.05 1.A piece of land forming part of lot 275 subdivision P.46, bounded on the front by Joanne d'Arc St, at the Back by lot 278, on the east side by part of lot 46, and on the west side by lot 47, measuring 16 feet 2/3 by the depth of said lot.2.A piece of land forming part of lot 275 subdivision P.47, bounded on the front by Jeanne d'Arc 8t.et the back by lot 278, on the ea9t side by lot 46, and on the west side by the residue of lot 47, measuring 41 feet 2/3 by the depth of said lot.With buildings thereon erected.I 54.60 A piece of land forming part of lot 13 subdivision P.78 and P.79, bounded on the front by Latour St., on the west side by part of lot 79, on the north sido by P.80, and on the east sido by the residue of said lots 78 and 79, measuring 50 foot wide by 100 feet doop.with buildings thereon erected.\u2022 \u2022 I-\u2022.I.I 202.12 1.A piece of land forming part of lot 278 subdivision 273.With buildings.2.A piece of land forming part of lot 278 subdivision P.268, bounded on the front by Crépin St, on the south side by lot 269, on one side by lots 272, and 273 and on the other sido by the residue of said lot 268, measuring 20 feet wide by 90 feet deep.With buildings thereon erected.Les immeubles ci-dessus décrits sont tous des plans et livres de renvoi officiels de la Paroisse St-Joachim de Châteauguay, et situés dans la ville de Châteauguay.Donné sous mon seing, en la ville de Châteauguay, ce 2 avril 1951.Le Secrétaire-trésorier, 29814-14-2-0 RENÉ LUSSIER.The above immovables are all upon the official plan and in the book of reference of the Parish of St-Joachim of Chateauguay, and situated in the Town of Chateauguay.Given under my hand, in the Town of Chateauguay this 2nd day of April 1951.RENÉ LUSSIER, 29814-14-2-o Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7th, 1951, Vol 88, No.U 1147 Province de Québec Province of Quebec Municipalité du comté de Rivière-du-Loup Municipality of the County of Rivière du- Loup Aux contribuables de la susdite municipalité To the Tax-payers of the aforesaid municipality Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Paul-E.Roy, Secrétaire-trésorier de la susdite Municipalité du comté de Rivière-du-Loup, que JEUDI, le QUATORZIÈME jour de JUIN mil neuf cent cinquante-un, à DIX heures de l'avant-midi, au chef-lieu du Comté, à l'Hôtcl-de-Ville de Rivièrc-du-Loup, seront vendus à l'enchère publique les immeubles ci-après désignés pour non paiement des taxes municipales, scolaires, frais et charges «lus sur chacun dc ces immeubles, à moins que lesdits taxes, frais et charges ne soient plus tôt payés et acquittés' avec les frais encourus avant la vente, savoir: Public notice is hereby given by the undersigned Paul-E.Roy, secretary-treasurer, of the aforesaid municipality of the county of Rivière-du-Loup, that on THURSDAY, the FOURTEENTH day of JUNE, nineteen hundred and fifty-one, at TEN o'clock in the forenoon, at the Chief Place of the county, at the Town-Hall of Rivière-du-Loup, there shall be sold by public auction the immovables hereinafter designated, for the non-payment of municipal, school taxes, costs and charges due on each of these immovables, unless said taxes, costs and charges be paid and acquitted, with costs incurred before the sale, to wit: Municipalité de Raudot (Ste-Rita) Municipality of Raudot (Ste-Rita) Nom du propriétaire Names of Owner\tOccupation Occupation\tAdresse Address\tNo des lots No.of lots\tRang Range\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal \tIndustriel-Industrialist\tSt-Médard, Rimouski.\tP.40 & P.41.\tI.\t$15.20\t$03.10\t$ 9.21\t$87.51 \t\t\t\t\t\t\t\t Donné ù St-Arsène, ce quatrième jour d'avril Given at St-Arsène, this fourth day of April, mil neuf cent cinquantc-un.nineteen hundred and fifty-one.Le Secrétaire-trésorier PAUL-E.ROY, du Conseil municipal Secretary-Treasurer du Comté de Rivière-du-Loup, of the Municipal Council 29838-14-2-o PAUL-E.ROY.29838-14-2 of the County of Rivière-du-Loup.Province de Québec Municipalité scolaire protestante de Val d'Or Aux contribuables de la susdite municipalité avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, que la Commission Municipale de Québec, par arrêté en date du 27 mars, 1951, a ordonne au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 dc la Loi de la Commission Municipale de Quéliec (R.S.Q.1941.chap.207) de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la Municipalité scolaire protestante de Val d'Or avec intérêts et frais, et qu'en conséquence lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Val d'Or.JEUDI le (10) DIXIÈME jour de MAI, 1951.à ONZE heures du matin, heure normale de l'est.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes devenues exigibles le ou avant le 1 octobre, 1950, auront été payées avant le moment de la vente.La vente des immeubles décrits dans la première section du présent avis sera faite sujette au droit de retrait, mais suivant les dispositions de l'article 74 de la Loi de la Commission Municipale de Québec.Immeubles sujets au droit de retrait: Province of Quebec Protestant School Municipality of Val d'Or To the ratepayers of the aforesaid Municipality public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the aforesaid Municipality, that the Quebec Municipal Commission by an order dated March 27th, 1951, has directed the undersigned in conformity with the provisions of Article 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q.1941, Chapter 207) to sell the immovables hereinafter described to satisfy the payment of the arrears of taxes due to the Protestant School Municipality of Val d'Or, with interest and cots, and consequently said immovables will be sold by Public Auction in the Council Chamber of the Town Hall of the Town of Val d'Or, on THURSDAY, the (10th) TENTH day of MAY, 1951, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Eastern Standard Time.However, there shall be excluded from the sale those immovables on which the taxes that became exigible on or before October 1st, 1959, shall have been paid before the actual sale.The sale of the immovables described in the first section of the present notice will be subject to the right of redemption, according to the provisions of Art.74 of the Québec Municipal Commission Act.Immovables subject to the right of redemption : 1148 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 88, N° 14 \t\t\tRang \tCad.\tSubdiv.\t\u2014 \t\t\tRange \t76.\t14 .,\t Borné au sud par lu deuxième Ave; à l'ouest par lc Bounded on the North by a common lane; South lot 14-77; au nord par la ruelle; i\\ l'est par lot 14-75.by Second Ave; West by lot 14-77; East by lot 14-75.Surporficie 5,500 pieds carrés et bâtisse.Lot with building thereon containing 5,500 sq.feet.2.\u2014 Mrs.C.E.Gillis McDougal.I 237.| 34.| Borné au nord par l'Ave Centrale; i\\ l'ouest par le Bounded on the North by Central Ave; West by lot 34-230; au sud par la ruelle; it l'est par lot 34-238.lot 34-236; South by a common lone; East by lot Surperficie 5,500 pieds carrés.34-238.Lot only containing 5,500 sq.feet.3.\u2014 Mrs.C.E.Gillis McDougul.I 238.J 34.I Borné au nord par 1'Ave Centrale; à l'ouest par le lot Bounded on the North by Central Ave; West by 34-237; au sud par la ruelle; â l'est par le lot 34-239.lot 34-237; South by a common lane; East by lot Surporficie 5,500 pieds carrés.34-239.Lot only containing 5,500 sq.feet.La vente des immeubles décrites ci-dessus est sujette The sale of the above immoveables are subject to aux conditions des baux emphytéotiques pouvant the conditions of the emphyteutic leases, which may affecter lesdits immeubles.Le prix d'adjudication affect the said immovables.The purchase price will de chacun de ces immeubles sera payable immédiate- be payable immediately by cash or accepted cheque, ment comptant ou par chèque visé.Donné à Val d'Or ce cinquième jour d'avril (liven at Val d'Or this fifth day of April, one mil neuf cent cinquante et un.thousand nine hundred fifty one.Le Secrétaire-Trésorier, JEAN H.AUBURN, 29834-14-2-0 JKAN II.AUBURN.29834-14-2-o Secretary-Treasurer.VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC est par le résent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.GASPÊ Fieri Fada» de Bonis et de Terris En la Cour de Magistrat Province de Québec., A W.PATTERSON District de Gaspé, \\ du village de Gaspé, Percé, à savoir: < comté de Gaspé, P.Q.N° 7646.(demandeur vs CYRIL v MAHER, CLINTON MA HER et LEONARD MAHER, faisant affaires autrefois sous lc nom non-enregistré «le Maher Bros, à L'Anse à Brillant, comté de Gaspé.province dc Québec, et domiciliés actuellement en les cité et district de Montréal, 1*.Q., défendeurs.Tous leurs droits indivises, intérêt et titre légal des propriétés immobilières suivantes, à savoir: a) Un certain morceau ou parcelle dc terre situé à L'Anse à Brillant, comté dc Gaspé, province de Québec, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton «le Douglas comme une partie du lot numéro sept (7) dans le premier rang Bois Brûlé, dans ledit canton de Douglas, étant borné au non! par les eaux de l'entrée de la Baie «le Gaspé.au sud par la ligne separative «lu rang arrière, à l'est par la propriété occupée par Dame Michael White et à l'ouest par la propriété occupée par Martin White, avec toutes les bâtisses dessus érigées, circonstances et dé- pendances.6) Un certain morceau ou parcelle de terre situé à l'Anse à Biillant, comté de Gaspé, province de Québec, connu et désigné aux plan «\u2022t livre «le renvoi officiels du canton dé Douglas comme étant le |ot numéro huit-C (S-C) «lans le premier rang Bois Bridé «ludit canton «le Douglas, étant borné au n«>r«l par les eaux «le l'entrée SHERIFF'S SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seize»!, and will be sold at the respective time and place mentioned below.GASPÊ Fieri Facias de Bonis et de Terris In the Magistrates Court Province of Quebec, , A W.PATTERSON of District of Gaspé, i the village of Gaspé, Percé, to wit: < County of Gaspé, P.Q.No.7646.J Plaintiff: Vs CYRIL MA-^ HER.CLINTON MAKER ami LEONARD MAHER formerly doing business under the unregistered name of Maher Bros, at L'Anse a Brillant, County of Gaspé, Province of Quebec, and presently residing at the City ami District of Montreal, P.Q.Defendants.All their undivided rights, interest and title at law in the following immoveable properties to with: a) A certain piece or parcel of land situate at L'Anse a Brillant.County of Gaspé, Province of Quebec, known ami designated on the Official Plan and in the Book of Reference of the Township of Douglas as part of lot number seven (7) in the first Range Bois-Brulé in the said Township of Douglas, being bounded on the North by the waters to the entrance of the Bay of Gaspé.on the South by the rear range Division Line, on the East by the property occupied by Michael White, and on the Weft by the property occupied by Martin White, with all buildings thereon erected circumstances and dependencies.b) A certain piece or parcel of land situate at L'Anse a Brillant County of Gaspé, Province of Quebec, known and designated on the Official Plan and in the Book of Reference of the Township of Douglas as lot number eight-C (8-C) in the first Range Bois-Brulé.of the said Township of Douglas, being bounded on the North by the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, April 7tiï, 1951, Vol S3, No.1J, 1149 de la Baie de Gaspé, au sud par la ligne separative du rang arrière, à l'est par la propriété occupée par Dame Michael White et à l'ouest par la propriété occupée par Martin White, avec toutes les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de Douglastown, comté de Gaspé, MARDI le HUITIÈME jour de MAI 1951, à DIX heures et TRENTE du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, M.J.FURLONG.Percé, 39 mars 1951.29825-14-2 [Première insertion: 7 avril 1951] Fieri Facias de Bonis et dc Terris En la Cour Supérieure Province de Québec, (THE GIRARD TRAD-District de Gaspé, ) * ING COMPANY LI-Percé, à savoir: ) MITED de Belle Anse, N° 3215 (comté de Gaspé, P.Q., de- manderesse vs CYRIL MAHER, dc l'Anse à Brillant, comté dc Gaspé, P.Q., domicilié actuellement à 5868, 7ième avenue, Rosemont, Montréal, défendeur.Tous ses droit indivises, intérêt et titre légal des propriétés immobilières suivantes, à savoir: a) Un certain morceau ou parcelle de terre situé à l'Anse à Brillant, comté de Gaspé, province de Québec, connu et désigné afix plan et livre de renvoi officiels du canton dc Douglas comme étant une partie du lot numéro sept (7) dans le premier rang Bois Brûlé, dans ledit canton de Douglas, étant borné au nord par les eaux de l'entrée de la Baie de Gaspé, au sud par la ligne separative du rang, arrière à l'est par la propriété occupée par Dame Michael White et à l'ouest par la propriété occupée par Martin White, avec toutes les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.b) Vn certain morceau ou parcelle de terre situé à l'Anse à Brillant, comté de Gaspé, province de Québec, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Douglas comme étant le lot numéro huit-C (8-C) dans le premier rang Bois Brûlé dudit canton de Douglas, étant borné au nord par les eaux de l'entrée de la Baie de Gaspé, au sud par la ligne arrière de séparation du rang, à l'est par la propriété occupée par Dame Michael White et à l'ouest par la propriété occupé par Martin White, avec toutes les bâtisses dessus érigées, Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de Douglastown, comté de Gaspé, MARDI le HUITIÈME jour de MAI 1951 à DIX heures du matin.L Shérif, Bureau du Shérif.M.J.FURLONG.Percé, 30 mars 1951.29824-14-2 [Première insertion: 7 avril 1951] waters to the entrance of the Bay of Gaspé.on the South by the rear Range Division Line, on the East by the property occupied by Dame Michael White and on the West by the property occupied by Martin, White with all buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of the parish of Douglastown County of Gaspé, on TUESDAY the EIGHTH day of MAY 1951 at TEN-THIRTY o'clock in the forenoon.M.J.FURLONG, Sheriffs Office, Sheriff.Percé, March 30th 1951.29825-14-2-o [First insertion: April 7, 1951] Fieri Facias de Bonis et de Terris In the Superior Court Province of Quebec, (\"TW^ GIRARD TRAD-District of Gaspé, ) * isq COMPANY LI-Pcrcé to wit; ) MITED, of Belle Anse, No.3215 (County of Gaspé, P.Q.plaintiff; vs CYRIL MAHER of L'Anse a Brillant, County of Gaspé, P.Q.and presently residing at 58G8, 7th Avenue, Rosemont, Montreal, defendant.All his undivided rights, interest and tigle at law in the following immoveable properties to wit: a) A certain piece or parcel of land situate at l'Anse a Brillant, County of (Jaspé, Province of Quebec, known and designated on the Official Plan and in the Book of Reference of the Township of Douglas as part of lot number seven (7) in the First Range, Bois Brûlé, in the said Township of Douglas, being bounded on the North by the waters to the enterance of the Bay of Gaspé on the South by the rear Range Division Line, on the East by the property occupied by Dame Michael White and on the West by the property occupied by Martin White, with all buildings thereon erected, circumstances and dependencies.b) A certain piece or parcel of land situate at l'Anse a Brillant County of Gaspé, Province of Quebec, known ami designated on the Official plan in the Book of Reference of the Township of Douglas as lot number eight-C (8-C) in the first Range, Bois Brûlé of the said Township of Douglas being bounded on the North by the Waters to the entrance of the Bay of Gaspé, on the South by the Rear Range Division Line, on the East by the property occupied by Dame Michael White and on the West by the property occupied by Martin White, with all building's thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of the parish of Douglastown, county of Gaspé, on TUESDAY the EIGHTH day MAY 1951 at TEN o'clock in the forenoon.M.J.FURLONG, Sheriff's Office.Sheriff.Percé, March 3Gth 1951.29826-14-2-o [First insertion: April 7, 1951] PONTIAC Cour de Magistrat\u2014District de Pontiac Canada, ( p EORGE MacGOWAN Province de Québec, ) marchand de bes-Pontiac.j tiaux, de l'endroit appelé N° 529G ' Havelock, comté de Peter- borough, province «l'Ontario, demandeur, vs GILBERT DUNN, de l'endroit appelé Centre Deniers, district de Pontiac, défendeur.PAUL MARTINEAU, avocat, Campbell's Bay, P.Q., mis-en-cause.PONTIAC Magistrate's Court\u2014District of Pontiac Canada, ( p EORGE MacGOWAN Province of Quebec, ) cattle dealer, of the Pontiac, \\ place called Havelock, in No.5296 { the county of Peterborough, in the Province of Ontario, plaintiff, vs~ GILBERT DUNN, of the place called Denies ('entre, in the District of Pontiac, defendant.PAUL MARTINEAU, Advocate, Campbells Bay, P.Q., distractingfor costs. 1150 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 7 avril 1951, Tome 88, N° U 'Le lot N° quatorze (14) du rang N° IV des plan et livre de renvoi officiels du canton dc ï'Ilc-aux-AlIumcttes, district de Pontiac, avec ensemble tous les membres et appartenances y appartenant.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Pontiac.à 'Campbell's Bay, MARDI, le DIX-SEPTIEME jour d'AVRIL 1951.à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif.DOMINIC SLOAN.Campbell's Bay, P.Q., 12 mars 1951, 29089-11-2 [Premiere insertion: 17 mars 1951] QUÉBEC Fieri Facias Cour de Magistrat Québec, à savoir: j ALFRED SÉVIGNY ca-N° 134870 l 4* mionneur, domicilié en la cité de Québec; contre NORBERT ROUSSEAU, domicilié à St-Apollinaire, P.Q.à savoir: Le lot N° 78 (soixante-dix-huit) du cadastre officiel pour la paroisse de St-Apollinaire, comté de lotbinière, et le lot No.490 (quatre cent quatre-vingt-dix) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Croix, comté de Lotbinière, étant une terre contenant deux arpents de front sur quarante arpents de profondeur, plus ou ou moins, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.A distrai-res des dits lots la partie vendue au chemin de fer et celle vendue au Ministère de la Voirie, suivant leurs titres, ainsi que le garage.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale dc St-Apollinaire, comté de Lotbinière, le ONZIÈME jour de MAI prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, AIMÉ DION.Québec, 5 avril 1951.29837-14-2-o [Première insertion: 7 avril 1951].[Seconde insertion: 21 avril 1951.] Lot No.fourteen (14) of Range No.IV, of the Official Plan and Book of Reference of the Township of Allumettes Island, in the District of Pontiac, together with all members and appurtenances thereto belonging.To be sold at the Registrar's Office for the County of Pontiac, in Campbell's Bay, on TUESDAY the SEVENTEENTH day of APRIL, 1951, at TEN of the clock in the forenoon.DOMINIC SLOAN, Sheriff's Office, Sheriff.Campbell's Bay, P.Q., March 12th, 1951.29089-1 l-2-o [First insertion: March 17, 1951] QU1DEC Fieri Facias Magistrate's Court Quebec, to wit: i A LFRED SÉVIGNY, car-No.134870 1
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.