Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 8 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1975-03-08, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" AVIS JURIDIQUES PARTIE 1 JURIDICAL NOTICES 107e ANNÉE 8 MARS 1975 NO 10 t GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC \t\t\t\t 71\t\t\t¦\u20141\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.8 mars 1975, 107' année, n' 10 2007 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS OfV- S V, 4t* l 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazelle officielle du Québec.2.La Gazelle officielle du Québec est composée île deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 paraît le samed i matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.PART 1 NOTICE TO READERS I.Address all communications to the Québec Gfficial Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.S.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mardi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas.l'ultime délai expire à midi, le lundi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazelle (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Tuesday noon; if Tuesday is a holiday, the deadline is Monday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Quibec Official Publisher 2008 QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: 81 chacun.Feuilles volantes: 83 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1) : du 1er janvier au 31 décembre, $20: du 1er avril au 31 décembre, 815 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec.25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation : 85 per 100 words.Single copies: 81 each.Slips: 83 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, 815 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings.Québec.October 25.1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Editeur officiel du Québec.Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7.P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Quebec Official Gazette, please call : Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash ¦\u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n° 10 2009 AVIS JURIDIQUES\t\tJURIDICAL NOTICES\t\t Compagnies \u2014 Loi des\t\t\tCompanies\tAct Administrateurs (Article 84)\t\tDirectors (Section 84)\t\t Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont modifié le nombre de leurs administrateurs tel qu'indiqué ci-après.\t\tNotice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have changed the number of their directors as indicated hereinafter.\t\t Nom de la compagnie Name of company\t\tDate de constitution Dale of incorporation\tNombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Nouveau nombre Previous number New number\t ALPHA GOLD MINES INC.LES MINES D'OR ALPHA INC.1356-3598\tOS\t05 74\t3\t6 ROBERT L.BRAMHILL & ASSOCIATES INC.ROBERT L.BRAMHILL & ASSOCIES INC.1356-9595\t29\t05 74\t3\t4 CALEB BRETT (CANADA) LIMITEE.CALEB BRETT (CANADA) LIMITED 1848-66\t28\t04 66\t6\t4 CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'ETUDES EN MANAGEMENT - CIREM (QUEBEC) INC.730452\t01\t02 73\t5\t20 2933-45\t17\t04 45\t3\t4 LAITERIE CITE LIMITEE 1166-0422\t12\t09 41\t6\t7 LES MINES D'OR FERVAT INC.1354-6296\t11\t03 74\t3\t6 FONDATION DES DIPLOMES H.E.C.1369-1563\t30\t07 74\t7\te 1115-7930\t27\t08 65\t4\t3 ENTREPRISES J.J.INC.1216-4380\t30\t06 71\t6\t3 INDUSTRIES J.L.INC.1137-9534\t31\t08 59\t6\t3 LIDO JEWELLERS COMPANY.1109-1485\t29\t01 40\t4\t6 716645\t29\t10 71\t6\t3 VILLA NOTRE-DAME DES ANGES INC.HOP: 4486-68\t06\t06 69\t3\t5 Le directeur du service des compagnies, 60183-o Pierre Desjardins.\t\t60183-o\tPierre Desjardins, Director of the Companies Service.\t 2010 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Siege social (Article 84) Head office (Section 84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont changé leur siège social tel qu'indiqué ci-après.Notice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have changed their head office as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Ancienne adresse Previous address Siège social Head office Nouvelle adresse New address 04 66 1112, rue Leblanc, Montréal-Nord.9124, boulevard Saint-Laurent, Montréal.1660, Place Gaudet.Trois-Rivières.01 63 Montréal.03 62 07 57 ALIMENTS NATURELS A LA SOURCE DE 16 02 72 Québec.SANTE INC.1223-8374 COMPACTEURS D.& L.INC.18 05 71 Montréal.and its English version D.& L.COMPACTORS INC.1211-2181 LA COMPAGNIE B.A.C.LTEE.01 B.A.C.COMPANY LTD.1228-U996 ELECTRODESIGN LTD.13 09 60 1108-1452 FRANCHISE & PROMOTION MONTREAL 19 03 74 INC.1354-9944 ROGER GAGNE LIMITEE.23 359-63 GIROVAL INC.02 1107-5868 HARCOURT MANUFACTURING & SALES 31 COMPANY 12085-67 IZENBERG ENTERPRISES LTD.28 LES ENTREPRISES IZENBERG LTEE 724815 MARCHE D'ALIMENTATION A.P.A.LTEE.03 09 74 1358-9502 PRODUITS FORESTIERS KAMOREX INC.03 10 72 KAMOREX FOREST PRODUCTS INC.725513 SHERMOUNT HOLDINGS CORPORATION.12 09 69 4227-69 LA SOCIETE BELLE-VUE LTEE.01 04 64 1158-7565 TESSIER - DUCHAINE ET ASSOCIES INC.07 05 71 2404-71 TRACY INDUSTRIAL SERVICES INC.29 12 61 SERVICES INDUSTRIELS TRACY INC.1130-9382 TRANS-VIL INC.03 11 69 Québec.6362-69 1200, rue Demontigny, Montréal.302, rue Lindsay, Drummond ville.08 72 4854.Côte-des-Neiges, Montréal.Pierreville.Saint-Joseph-de-Kamouraska.1367, avenue Greene, Westmount.Sillery.714, Moreau, Sainte-Foy.51, chemin St-Ours, Sorel.1208, rue Commerciale, Saint- Romuald-d'Etchemin.9015, rue Daillon, Saint-Léonard.197, rue Larocque, Bromptonville.840, rue I.allow:.LaSalle.3726, chemin Côte-Ste-Catherine, suite 17, Montréal.8185, rue Guyenne, Saint-Leonard.364, rue SUJean.Longueuil.220, Grande-Allée est, Québec.151, chemin Trottier, Piedmont.Route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac.1011, rue Marquette, Montréal.2075, rue Université, Montréal.3350,rue de la Pérade, Sainte-Foy.1490, rue Beaulieu, suite 905, Sillery.708, Route Marie-Victorin, Tracy.360, rue de Navarre, Charlesbourg.60183-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.60183-o Pierre Desjardinb, Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S mars 1975, 107- année, n° 10 2011 Lettres patentes (1™ partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and cooperatives donne avis, qu'en vertu de la première partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LES ACCOMMODATIONS WAN MORIN INC.1300-2586 ALUMINIUM BUSQUE INC.et sa version anglaise BUSQUE ALUMINIUM INC.1361-2361 AMENAGEMENTS LAC-DROLET INC.1361-2882 LES AMENAGEMENTS MAGSTONE INC.and its English version MAGSTONE DEVELOPMENT INC.1370-7526 VICTOR ANCTIL INC.1361-1637 ANGERS & GOLDSTEIN INC.1360-8500 ANTIQUITES TOI & MOI INC.1370-9902 ARTISANAT DES CINQ CONTINENTS INC.1361-3187 LES ATTACHES DE REMORQUES UNIVERSELLES G.T.J.L.INC.et sa version anglaise UNIVERSAL TRAILER HITCHES G.T.J.L.INC.1370-4515 AUBERGE PAUGAN INC.et sa version anglaise PAUGAN INN INC.1360-0879 AUTO SAPHIR INC.et sa version anglaise SAPHIRE AUTO INC.1361-3641 AUTOMOBILES A.LACHANCE INC.et sa version anglaise A.LACHANCE AUTOMOBILES INC.1361-2460 AUTOMOBILE DENIS ST-ONGE INC.1361-1447 AUX HABITS LIMOILOU INC.1361-3328 AVIATION LES ILES LTEE 1361-2106 C.BLAIS & FILS INC.1370-9589 363, Ross, Rimouski.39, rue Michener, Saint>Joseph 67, rue Principale, Lac-Drolet.253, chemin Westcroft, Beaconsfield.2163, boulevard Laurier, Sillery.8470, avenue Mountain Sights, Montréal.965, rue Notre-Dame, Lavaltrie.Beloeil.1750, rue Jacques-Lemaistre, Montréal.Low.5717, rue Alphonse, Brossard.529.boulevard Kennedy, Saint-Louis-de-Pintendre.Rue Saint-Isidore, (Côte-nord), Saint-Isidore.1102, 1ère Avenue, Québec.LES BOIS CARILLON INC.1360-0671 2786, Chenal-du-Moine, Sainte-Anne-de-Sorel.1141, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice .441, 5e Rue, Laval-des-Rapides, Laval 13 11 74 15 01 75 17 01 76 17 12 74 09 01 76 16 12 74 16 01 75 21 01 76 20 11 74 04 11 74 22 01 75 15 01 76 09 01 75 20 01 75 10 01 75 13 01 75 04 11 74 2012 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Nom/ Name HONORE BOISVERT.COURTIER EN IMMEUBLE, INC.1370-9399 MAURICE BOULANGER INC.1359-7869 BOUTIQUE FREED INC.et sa version anglaise FREED'S SHOP INC.1370-1933 BOUTIQUE LE CHARME NU INC.1361-2890 BOUTIQUE LE COUSSIN INC.1359-9139 BOUTIQUE OMINI INC.and its English version OMINI BOUTIQUE INC.1371-0413 BOUTIQUE PICOLO INC.1361-1017 LE CABARET DU CHENAL INC.1360-6801 CABLODISTRIBUTION DE L'EST INC.1361-3930 CAFE CLEOPATRE INC.and its English version CLEOPATRA CAFE INC.1370-8581 L.E.CANTIN (1975) INC.1361-5208 CANTINE AUTOROUTE TRENTE INC.1361-2304 LA CANTINE F.BOILY & FILS INC.1360-9615 LES CARROSSIERS VIA INC.et sa version anglaise VIA BODY-BUILDERS INC.1359-7760 CENTRALINQUE INC.1357-7218 CENTRE DE LA CAMERA COTE-NORD INC.1360-3519 CENTRE COMMERCIAL PERRON LTEE.and its English version PERRON COMMERCIAL CENTRE LTD.1370-5512 CENTRE DU COUPON CHIBOUGAMAU INC.1361-5018 LE CENTRE D'ORIENTATION ET DE RECHERCHE ACOUSTIQUE C.O.R.A.INC.1361-4896 CENTRE DE PLONGEE NEPTEAU INC.1370-9597 CENTRE DE SKI AU CHALET SUISSE INC.1360-9078 Incorporation Siège social / Head Office Date Laval.13 01 75 2690, Arthur-Bouret, Giffard.30 12 74 5260, chemin de la Reine-Marie, 15 01 75 Montréal.Place Saint-Laurent, Rimouski.17 01 75 Montréal.24 10 74 8172-C, boulevard Champlain, 20 01 76 LaSalle.372, 1ère Avenue, Saint-Georges.30 12 74 2306, Chenal-du-Moine, Sainte- 09 12 74 Anne-de-Sorel.Rimouaki.23 01 75 1230, boulevard Saint-Laurent, 30 12 74 Montréal.1, Place Ville-Marie, suite 1536, 30 01 75 Montréal.L'Ange-Gardien.14 01 76 Thetford Mines.23 12 74 10,000, rue Park Way, Anjou.18 10 74 Montréal.10 07 74 Sept-Ilea.19 11 74 1010, rue Sainte-Catherine ouest, 02 12 74 Montréal.468, 3e Rue, Chibougamau.29 01 76 131, 18e Rue est, Québec.29 01 76 1060, rue Langevin, Sherbrooke.13 01 75 346, rue Principale, La Sarre, Abitibi .18 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n° 10 2013 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date CHARIOTS ELEVATEURS HERCULE (QUEBEC) LIMITEE.and its English version HERCULES LIFT TRUCKS (QUEBEC) LIMITED 1370-9084 CLINIQUE BEIGER & BEIGER INC.and its English versoin BEIGER & BEIGER CLINIC INC.1361-1546 CLINIQUE DE MEDECINE GENERALE ET D'OBSTETRIQUE D'ALMA INC.1361-2320 CLINIQUE VETERINAIRE BELANGER, BOUTIN & ASSOCIES INC.1361-8913 COFFRAGES INDUSTRIELS RAYVAL LTEE.et sa version anglaise RAYVAL INDUSTRIAL FORMS LTD.1371-0967 LA COMPAGNIE DE FILMS K.F.INC.1361-6818 LA COMPAGNIE GAETAN GLADU INCORPOREE.1370-6932 LA COMPAGNIE DE PLACEMENT J.M.R.THOMSON LTEE and its English version THE J.M.R.THOMSON HOLDING COMPANY LTD.1370-9886 LA COMPAGNIE ROBERT GRANGER INC.and its English version ROBERT GRANGER ci CO.INC.1370-8250 1010, rue Ste-Catherine ouest, suite 08 01 75 921, Montréal.7335, rue Sherbrooke ouest, Montréal.08 01 75 665, rue de la Gare, Aima.14 01 75 Plessisville.24 01 75 4480, Pouget, Saint-Léonard.24 01 75 273, Carré St-Louis, Montréal.11 02 75 10391, rue Péloquin, Montréal.13 12 74 Montréal.16 01 75 1190, avenue Ducharme, Outremont.23 12 74 CONFECTION J.R.INC.1361-3310 CONSTRUCTION BERNARDINE INC.and its English version BERNARDINE CONSTRUCTION INC.1371-0066 LES CONSTRUCTIONS JEAN KLAUDE LTEE.1360-8237 CONSTRUCTIONS MONT ROUGE INC.et sa version anglaise MONT ROUGE CONSTRUCTIONS INC.1370-9464 6136, rue Bellevue, Rock Forest 4569, chemin du Lac, Dollard-des-Ormeaux.5005, Poitiers, Auteuil, Laval.Boucherville.20 01 75 17 01 75 13 12 74 13 01 75 CONSTRUCTION O.C.A.LTEE 1371-2310 CONSTRUCTION RENEX INC.1358-6326 LES CONSTRUCTIONS TURRIS INC.et sa version anglaise TURRIS CONSTRUCTION INC.1361-4581 LES CONSULTANTS S.L.S.INC.et sa version anglaise S.L.S.CONSULTANTS INC.1370-8599 COPEXIM INC.1370-8730 Montréal.04 02 75 Laval.14 08 74 Montréal.27 01 75 3778, CÔte-des-Neiges, Montréal.30 12 74 1432, rue de la Montagne, Montréal.27 01 75 2014 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date COPIGRAPH INC.1370-7625 CORPORATION AMENAGEMENTS HABLANK.and its English version HABLANK DEVELOPMENT CORPORATION 1360-5928 CORPORATION D'AMENAGEMENT LES PAYS D'EN HAUT and its English version HIGH WILDERNESS DEVELOPMENT CORP.1361-4441 COUVREURS VAL ROYAL LTEE.and its English version VAL ROYAL ROOFERS LTD.1360-9508 CREATIONS G.O.LTEE.and its English version G.O.CREATIONS LTD.1360-9342 FRANÇOIS DANDURAND INC.1361-6016 DEPANNEUR TERRASSE INC.1361-5158 DEVELOPPEMENT TECHNIQUE AVANT-GARDE.et sa version anglaise AVANT-GARDE TECHNICAL DEVELOPMENT INC.1370-8904 DILIDAM INC.1361-1561 DISTRIBUTIONS FLASHBEC INC.et sa version anglaise FLASHBEC DISTRIBUTIONS INC.1361-3146 DOMAINE LACSOL, INC.1360-5381 RAYNALD DUMAS INC.1361-1983 ELECTRICITE D'AUTOMOBILE HARRICANA INC.et sa version anglaise HARRICANA AUTO ELECTRIC INC.1361-4789 ENTREPOTS LAPALME INC.et sa version anglaise LAPALME WAREHOUSING INC.1371-2344 ENTREPOT DE TAPIS LOMY.INC.1360-9367 LES ENTREPRISES B.BOUDREAU INC.1360-4319 LES ENTREPRISES BOGUY INC.1359-5301 LES ENTREPRISES CLAUVAIN INC.1370-7146 LES ENTREPRISES D.L.R.INC.1361-0894 Montréal Montréal 18 12 74 04 12 74 14, rue Calumet, Place Bonaventure, 27 01 75 Montiéal.5081, boulevard Saint-Martin, Chomedey, Laval.Montréal 23 12 74 19 12 74 316, rue St-Joseph, Saint-Grégoire- 04 02 75 le-Grand.235, Rivière sud, Saint-Eustache.30 01 75 8500, 4e Avenue, Anjou.06 01 75 Place St-Laurent, Rimouski.05 02 76 4, rue Notre-Dame est, suite 801, 06 02 75 Montréal.5207, rue Victoria, app.5, Montréal.20 11 74 Sorel.13 01 75 Amos.28 01 75 1435, Island, Montréal.04 02 75 90-B, rue Richelieu.Saint-Jean.19 12 74 Havre Saint-Pierre.26 11 74 1, rue Bernard est, Montréal.04 10 74 1683, rue Massenet, Chomedey, Laval.13 12 74 186, rang 2, Saint-David-de- 06 01 75 Falardeau. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n\" 10 2015 Nom / Name LES ENTREPRISES D'ELECTRICITE ALTEM LTEE.and its English version ALTEM ELECTRICAL ENTERPRISES LTD.1360-1992 ENTREPRISES D'ELECTRICITE MIRABEL LTEE.et sa version anglaise MIRABEL ELECTRICAL ENTERPRISES LTD.1370-9167 ENTREPRISES D'ELECTRONIQUE E.A.INC.1360-8021 LES ENTREPRISES FORESTIERES ETCHEMIN LTEE.1360-8229 LES ENTREPRISES GASTON GLEETON INC.1360-7106 LES ENTREPRISES DE GESTION PAJEP INC.1371-0108 LES ENTREPRISES GLANAUD INC.1361-4847 LES ENTREPRISES J.D.GODBOUT INC.1361-1686 LES ENTREPRISES JEAN-PAUL MARTINEAU INC- 1361-4219 ENTREPRISES LE CANARI MOBILE LTEE.1360-7593 LES ENTREPRISES LOUIS-O.TREMBLAY INC.1371-0132 ENTREPRISES M.BOULET INC.1370-9647 LES ENTREPRISES MARC DRAPEAU INC.1360-4889 LES ENTREPRISES MICHEL BLOUIN INC.1360-3337 LES ENTREPRISES MIRADIX LTEE.1370-5637 LES ENTREPRISES PAQUETTE ET MENARD INC.1361-2858 LES ENTREPRISES PAU-ROB INC.1360-5761 LES ENTREPRISES QUADRIFIDE LTEE.1360-5787 LES ENTREPRISES S.C.E.M.INC.1360-9425 LES ENTREPRISES WAYNE COOTE INC.and its English version WAYNE COOTE ENTERPRISES INC.1361-1496 ENTREPRISES YAMERIC INC.1371-2435 EPICERIE MARCEL BOUCHARD INC.1361-4425 EPICERIE PIERRETTE GOYETTE INC.1360-9706 Incorporation Siège social ; Head Office Date 1231,,Sainte-Catherineo ouest, suite 13 12 74 221, Montréal.Mirabel.09 01 75 Cap-aux-Meules.06 12 74 370, 2e Avenue, Lac-Etchemin.13 12 74 612, 5e Rue, Murdochville.10 12 74 31, rue Saint-Jacques, Montréal.17 01 75 77-79, rue Wellington, Hull.28 01 75 i >l I \\ I HI k MOTOR SALES LTÉE 670.Nolre-Dame Galineau lQué.1 Rôle M-6559 M-5O537ID-O01 DE CHANTAL.I.l II.LAl ME SR.206.rue Ste-Anne Stc-Anne-de-Bellevue (Que.) Rôle M-6560 M-5053O8-D-O0I NORMAN GAMACHE INC 152, rue de L'Eglise Laeolle (Que.) Rôle M-6561 M-505308-D-002 NORMAN GAMACHE INC.152.rue de L'Eglise Laeolle (Oué.l Rôle M-6562 M 505768-D-001 LA VOIE, CLAUDE 9265.Oclave-Pellelier Monlréal (Oué.) Rôle M-6563 M-5053I2-D-OOI JORG.PAUL 147.Nolre-Dame Nominingue (Oué.l Rôle M-6564 M-5053I8-D-OOI ABRAHAM.ARNOLD R.R.no 3 Buckingham (Oué.) Rôle M-6565 M-5O53O9-D-0OI Nouvelle demande: La partie requérante demande à la CTO un permis de propriétaire pour effectuer par véhicule-taxi, du transport dans la région de Bro-mont.06-3830-VT.comprenant Bromont.Taux applicables de Montréal aux Maritimes: 1.Augmentations dans les taux de classe de 6 à 91* sur les taux de base P & 0 (Cueillette et livraison).2.Augmentations dans les taux d'exception de 4 à 61 sur les taux de base P & D.(Cueillette el livraison) 3.Augmentations dans les taux compétitifs d'espèces au piggyback.Conformément à la décision MS-1280-TF dans la cause no R.S.0874-16023-V-Sl-TF.La requérante, propnéiaire d'un camion im-matriculé au Ouébec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des transports du Québec un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 7.New application: The applicant requests from the OTC an owner's permit lo effect iranspon by taxicab in ihe region of Bromoni.06-3830-VT.comprising Bromoni.Rales from Montreal to Maritime destination: 1.Increases in class rates of 6 to 9% on a P & D basis.2.Increases in exception commodity rales of 4 to 60} on a P & D basis.3.Increases in piggyback commodity competitive rales.According to (he decision MS-1280-TF in the application No.R.S 0874-16023-V-S-1-TF The applicant, owner of a truck regisiered in the Province ol Québec since April 14.1972.requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.7.Le requérant, propriétaire d un camion immatriculé au Québec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des tiansports du Québec un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 10.The applicant, owner of a truck registered in the Province ot Québec since April 14.1972.requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Artisan class, for Region No.10.La requérante, propriétaire d'un camion immatriculé au Québec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des transports du Ouébec un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 6.La requérante, propriétaire c'un camion immatriculé au Québec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des transports du Québec un permis de camionnage en vrac, calégorie Entrepreneur, pour la région no 6.Le requérant, piopriélairc d'un camion immatricule au Québec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des transports du Ouébec un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 10.Le requérant, propriétaire d'un camion immatriculé au Québec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des tiansports du Québec un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 7.Le requérant, propriétaire d'un camion immatriculé au Québec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des transports du Ouébec un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 7.Le requérant, propriétaire d'un camion immatriculé au Ouébec depuis le 14 avril 1972.The applicant, owner of a truck regisiered in the Province of Québec since April 14.1972.requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.6.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec since April 14.1972.requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.6.The applicant, owner of a truck registered in Ihe Province of Québec since April 14.1972.requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Artisan class, for Region No.10.The applicant, owner of a truck regisiered in the Province of Québec since April 14.1972.requests from the Québec Transpon Commission a bulk trucking permit.Contractor class, lor Region No.7.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec since April 14.1972.requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Artisan class, for Region No.7.The applicant, owner of a truck regisiered in the Province of Québec since April 14.1972. 20S6 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 7975, Vol.107.No.10 STANLEY, LAWSON R.R.no i Ouyon (Ponliac) (Oué.) Rôle M-6566 M-5O5309-D-0O2 STANLEY, LAWSON R.R.no I Ouyon (Ponliac) (Que.) Rôle M-6567 M-5053I4-D-00I DE ANGELIS, ANTONIO 7903, rue Si-Dominique Monlréal (Oué.) Rôle M-6568 M-5053I9-D-001 ROSS CONSTRUCTION INC.CP.396 Sennelerre (Oué.) Rôle M-6569 M-5O5O52-D-O0I DESCOTEAUX.MARCEL 240.Si-Picrre-de-Sorel Sorel (Que.) demande à la Commission des transports du Ouébec un permis de camionnage en vrac, calégoric Enlrcprcneur.pour la région no 7.Le requérant, propriétaire d'un camion immatriculé au Ouébec depuis le 14 avril 1972, demande à la Commission des transports du Ouébec un permis de camionnage en vrac, catégorie Enlrcprcneur.pour la région no 7.Le requérant, propriétaire d'Un camion immatriculé au Ouébec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des transports du Ouébec un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région no 10.La requérante, propriétaire d'un camion immatriculé au Ouébec depuis le 14 avril 1972.demande à la Commission des Iranspons du Ouébec un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 8.Le requérant, qui possède une attestation M-5O5O52-D-0OI.demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région no 6.requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.7.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Ouébec since April 14.1972, requests from the Quebec Transport Commission a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.7.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec since April 14.1972.requests from Ihe Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Artisan Class, for Region No.10.The applicant, owner of a truck registered in the Province of Québec since April 14.1972.requests from the Québec Transport Commission a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.8.The applicant, who holds certificalc M-5O5O52-D-0O1.requests a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.6.Rôle M-6570 M-502734-D-00I DEGUIRE, ARTHUR 630.rue Beaulne Stc-Agaihe-Sud (Que.) el / and M-500396-D-00I LEDUC, ONIAS 1272.rue Rochon St-Jovite (Oué.) Rôle M -6571 M-502061-D-00I RAGUSA, GAETANO 6217.rue De Beauvais St-Léonard (Oué.) et / and M-502087-D-O0I POMPA, NICOLA 8520.rue Viau, app.30 St-Léonard (Que.) Rôle M-6572 M-500426-D-00I ROBITAILLE.FRANÇOIS 587.rue Montcalm Repenligny (Que.) el /and M-505891-D-0OI LEVESQUE.JACQUES 2014.rue Des Carrières Montreal (Que.) Demande de transfert: Le requérant-cédant demande à la Commission de transférer à: Leduc.Onias 1272.rue Rochon St-Jovite (Oué.) l'atiestation ou le permis no M-502734-D-001 qu'il détienl pour effectuer du camionnage en vrac dans la région no 6.catégorie Artisan.Demande de transfert: Le requéranl-cédanl demande à la Commission de transférer à: Pompa.Nicola 8520.rue Viau.app.30 St-Léonard (Oué.) l'attestation ou le permis no M-502061-D-OOI qu'il détienl pour effecluer du camionnage en vrac dans la région no 10.catégorie Entrepreneur.Demande de transfert: Le requéranl-cédanl demande à la Commission de Iransférer à: Levesque, Jacques 2014.rue Des Carrières Monlréal (Oué.) l'atiestation ou le permis no M-500426-D-OOI qu'il détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région no 10.catégorie Entrepreneur.Applicalion for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer lo: Leduc.Onias 1272 Rochon Street Saint-Joviie.P.O.his permit or certificate No.M-502734-D-001, which he holds, to effect bulk trucking in Region No.6.Artisan class.Applicalion for Iransfer: The applicant-transferror requests the Commission lo transfer to: Pompa.Nicola 8520 Viau Streel.Apt.30 Saint-Léonard.P.O.his permil or certificate No.M-5O2O61-D-001.which he holds, to effect bulk trucking in Region No.10.Contractor class.Applicalion for transfer: The applicant-transferror requests Ihe Commission to iransfer to: Levesque.Jacques 2014 Des Carrières Streel Montreal.P.O.his permit or certificate No.M-500426-D-001.which he holds, to effect bulk trucking in Region No.10, Contractor class. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 197$, 107' mwfe, n' 10 2087 Rôle M-6573 M-500494-D-OOI LAROCHELLE.YVON 501 esi.3e Rue La Sarre (Oué.) el / and M-5O0666-D-O0I LACROIX, DENIS Roquemaure (Abilibi-Ouesl) (Oué.) Rôle M-3II3 I5720-V-D-I CHRÉTIEN, GÉRARD Sle-Ursule (Maskinongé) (Oué.) el / and BÉLAND.NORMAND 910.rang Sl-Charles Sl-Léon-le-Grand (Maskinongé) (Oué.) Rôle Q-3114 5315-V-D-l RHEAULT & FILS ENRG.(Armand Rhcaull) 142.rue Si-Jean-Bapiisic CP.324.Victoriaville (Oué i el / and RHEAULT & FILS I.TÉE 142, rue St-Jean-Baptiste Victoriaville (Oué.) Demande de transfert: Le requérant-cédant demande à la Commission de transférer à: Lacroix.Denis Roquemaure (Abitibi-Oucst) (Oué.) l'attestation ou le permis no M 500494-D-00I qu'il détienl pour effecluer du camionnage en vrac dans la région no 8.catégorie Artisan.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Lacroix.Denis Roquemaure Abnibi-West.P.O.his permil or certificate No M-500494-D-001.which he holds, to effect bulk trucking in Region No.8.Artisan class.Demande de transfert: Gérard Chrétien demande que son permis de transport no 15720-V soit transféré à: Béland.Normand 910.rang Sl-Charles Sl-Léon-le-Grand (Maskinongé) (Oué.) lequel se lil comme suit: Transpon général - longue distance - route restreinte - irrégulier - Irrégulièrement de Sic-Ursule à Montréal, pour le transport de viandes el d'animaux vivants, el retour avec marchandises diverses destinées à Ste-Ursule.Demande de transfen: Rheauit & Fils Enrg.(Armand Rheault) demande que son permis de transpon no 5315-V soit transféré à: Rheault & Fils Liée 142.rue St-Jean-Baptiste Victoriaville (Oué ) lequel se lit comme suit: A) Marchandises générales: a-l) Transpon général - service local -a-l) Victoriaville el lous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville.a-2) Transpon général - longue dislance - rayon - a-2) De Victoriaville à lous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles des limites de ladite ville, et retour.B) Transpon de ménages et ameublements usagés tel que défini à l'anicle 51 de l'Ordonnance générale sur le camionnage avec des véhicules spécialement agencés à cet effet: 6-1) Transpon restreint - service local - territoire - 6-1) À Victoriaville el de lous points à un autre dans un rayon de cinquante (50) milles des limites de la ville de Victoriaville.6-2) Transpon restreint - longue dislance -rayon - 6-2) De Victoriaville el de lous points dans un rayon de cinquante (50) milles de la ville de Victoriaville.à tous les points situés dans un layon de cent cinquante ( 150) milles des limites de ladite ville de Victoriaville.et retour.6-3) Transpon restreint - longue distance -territoire - 6-3) De tout point à tout autre dans les limites de la province de Ouébec pourvu que la distance entre ces deux points soit de plus de cent ( 100) milles.Applicalion for Iransfer: Gérard Chrétien requests that his transpon permit No.15720-V be transferred lo: Béland.Normand 910 St-Charles Range Saint-Léon-le-Grand.(Maskinongé) P.O.which reads as follows: General trucking - long dislance -restricted toute - irregular - Irregularly from Sainte-Ursule to Montreal, for the transpon of meals and livestock, and return wilh goods destined lo Sainte-Ursule.Application for transfer: Rheault & Fils Enrg.(Armand Rheault) requests that his transport permil No 5315-V be transferred to: Rheault & Fils Liée 142 Sl-Jean-Bapiisie Street Victoriaville P.Q.which reads as follows: (A) General merchandise: («-l) General trucking - local service -(a-l) Victoriaville and all points located within a dislance not exceeding five (5) miles from the limits of said City.(a-2) General trucking - long dislance - radius ¦ (a-2) From Victoriaville to all points located within a radius of thirty (30) miles from the limits of the said Cily.and return.(B) Transportation of household goods: (6-1) Restricted trucking - local service -territory - (6-1) At Victoriaville and lo/and between all points situated within a radius of fifty (50) miles from the limils of the Cily of Victoriaville.(6-2) Restricted trucking - long distance -radius - (6-2) From Victoriaville and all points situated within a radius of fitly (50) miles from the limits of the Cily of Victoriaville to all points situated within a radius of one hundred and fifty (150) miles from the limits of said City of Victoriaville.and rclum.(6-3) Restricted trucking - long distance -territory - (6-3) Between all points situated in the Province of Québec provided the distance between the said two points is in excess of one hundred (1001 miles. ¦_'flss QUÉBEC OFFICIAI.OA/.ETTE.March 8, 7975.Vol.107.-Y.W 6-4) Transport reslrcinl - longue distance -rouie restreinte - 6-4) De toutes les localités situées dans la province de Uuébec à la froniière du Nouveau-Brunswick, et retour (via toutes les routes et lous les ports d'entrée): origine eu destination: les localités des provinces du Nouveau-Brunswick.Nouvelle-Ecosse.Ile du Prince-Edouard et Tcr-reneuve.6-5) Transport restreint - longue distance -route restreinte \u2022 b-5) De toutes les localités situées dans la province de Ouébec à la frontière de l'Ontario, et retour (via toutes les roules cl tous les ports d'entrée): origine ou destination: les localités des provinces d'Ontario.Manitoba.Saskatchewan.Albena.Colombie Britannique, les territoires du Nord-Ouest et du Yukon.6-6) Transpon reslrcinl - longue distance -route restreinte - 6-6) De toutes les localités situées dans la province de Ouébec à la frontière des Étals-l ins.el reloui (via nulles les roules el lous les pons d'entrée): origine ou destination: localités des Étals-Unis.6-7) Tianspon restreint - longue distance -route restreinte - in transit - 6-7) En transit, d'une fron:ière à loute autre frontière de la province de Ouébec; origine ou destination: entre les provinces du Canada autres que Ouébec el entre lesdites provinces et les Étals-Unis et les territoires du Nord-Ouest el du Yukon.Droits additionnels: 1.Le détenteur de ce permis a le droit d'agir à litre de courtier en transpon aux fins d'accepter les commandes pour le transpnn de ménages el ameublements usagés el de transferer lesdites commandes à être exécutées suivant les connaissements ou autres documenis de la United Van Lines Canada Ltd.et United Van Lines Inc.pourvu que te détenteur continue à être responsable auprès du client même si le transpon est effectué par un autre camionneur détenteur d'un permis de la Commission.2.Le détenteur aura tous les privilèges accordés par l'anicle 13-C de l'Ordonnance générale sur le camionnage d'agir à titre de counicr en transport, si les conditions mentionnées dans ledil article 13-C sont observées.Restrictions re / transport de ménages el ameublements usagés: 1.Les clauses 6-4 et 6-5 de ce permis seront opérées conjointement avec les cenificals de permis à être émis par les provinces du Canada qui sont mentionnées el serom inopérantes tant qu'une copie d'un tel permis n'aura pas été déposée à la Commission.2.Le service effectué en vertu de la clause 6-6 du permis est subordonné à l'aulorisalion émise par Ylntersiute Commerce Commission à United Van Lines Inc.sous k no 67234 sub.I cl pour laquelle le détenleur agit à litre d'agent transponeur.3.La clause 6-7 de ce permit doit êlre opérée conjointement avec les certificats ou les permis émis par les autoirlés ayanl juridiction dans les provinces autres que Ouébec cl les États-Unis d'où les marchandises proviennent cl où elles sont destinées.(6-4) Restricted trucking - long distance -restricted route - (6-4) From all localities situated in the Province of Québec to the New Brunswick-Québec border, and return (via irregular routes and all pons of entry); destination or origin: localities of New Brunswick.Nova Scotia.Prince Edward Island and New Foundland.(/»-5) Restricted trucking - long distance -restricted route - (6-5) From all localities situated in the Province of Québec lo the Ontario-Ouébec border, and return (via irregular routes and all pons of cntty); destination or origin: localities of Ontario.Manitoba.Saskatchewan.Albena.British Columbia.North West Terntorics and Yukon.(6-6) Restricted trucking - long distance -restricted route - (6-6) From all localities in the Province of Québec lo the United Stales-Ouébcc border, and return (via irregular roules and all ports of enlry): destination or origin: all localities of ihe United Stales.(6-7) Restricted trucking - long distance -restricted route - in transii - (6-7) In transit, from one border of the Province to another border of the Province: destina-lion or origin: between provinces of Canada others than Ouébec.and between said provinces and the United Stales and the North West and Yukon Territories.Additional rights: 1.The holder hereof has the right to act as a transportation broker for the purpose of accepting orders from customers covering the transportation of household goods and to transfer said orders to be moved on shipping bills or documents of United Van Lines Canada Ltd.and United Van Lines Inc.provided the permit holder continues lo be responsible to the cus-lomei although the actual service may be given by anothet carrier holding a permit from this Commission.2.The holder shall have the general authority conferred by article 13-C of the General Order on Trucking lo act as a transportaiion broker if Ihe conditions set out in the said article 13-C are observed.Restrictions re / transportation of household goods: 1.Clauses 6-4 and 6-5 of this permit shall he utilized only with a permit, certificate or other right issued by the competent authority of prov-inves above mentioned, copy of which must he tiled with the Commission.2.Clause 6-6 of this permit shall be utilized only in conjunction with permit of the Interstate Commerce Commission.No.67234 Sub.I issued lo United Van Lines Inc.for which the holder is a hauling agent.3.Clause 6-7 of this permit shall be utilized only with a permit, certificate or olhcr righl issued by the competent authority of provinces above mentioned and of the United States. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 7975, 707' année, n° 10 2089 Rôle 0-3115 1271-V-D-l 1271-V FRENETTE, LAURÉAT (décédé / deceased| Dame Anna Deschènes-Frenelte 771, rue Si-Bernard Ouébec 8 (Oué.) el / and 22890-V ROY, CHARLES-HENRI 3185.des Grives Orsainville (Oué.) Rôle 0-3116 246-N-D-l TRAVERSE LONGUEUIL INC.174.Mane-Viciorin Longueuil (Oué.) el / and EXCURSIONS MARITIMES MISS MONTREAL INC.711.rue Le Caron Longueuil (Oué.) 4.Le détenleur du permis ne devra pas transférer son bureau d'affaires de la ville de Victoriaville sans en avoir obtenu l'approbation écrite préalable de la Commission et re devra pas, directement ou indirectement, ouvrir un bureau d'affaires dans quelque localité que ce soit de la province de Ouébec.autre que la ville de Victoriaville.sans en avoir obtenu l'approbation préalable de la Commissiom.5.Les connaissements doivent être émis conformément aux lois de la province de Ouébec.6.Ce permis sera sujet à révision par la Commission advenant que le détenteur abandonne son affiliation à titre d'agent transporteur pour United Van Lines (Canada) Ltd.et United Van Lines Inc.Les actions de Rheault & Fils Ltée sont distribuées comme suit: Aciions ordinaires Armand Rheault.président 2.998 Mme Gisèle B.Rheault.secrétaire i Mme Gisèle R.Carrier, vice-présidente 1 1.Demande de transmission par décès en faveur de: Dame Anna Deschènes-Frenette 771.rue St-Bernard Québec (Oué.) du permis no 1271-V que détenait de son vivant M.Lauréat Frenelte.lequel permis se lit comme suie Transport général - service local -Ouébec et environs.Restriclion: Le droit de transporter de la marchandise dans les véhicules suivants est exclus: camions blindés, fardiers.camions-citernes, véhicules agencés pour déménagements spéciaux et véhicules servant au transport de véhicules automobiles.2.Demande de transfert du permis no 1271-V en faveur de: Roy.Charles-Henri (22890-V) 3185.des Grives Orsainville (Que.) délenteur du permis no 22890-V se lisant comme suit: Transport restreint - service local - contrat -Québec et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville, pour la livraison de meubles neufs et d'appareils électriques, pour le compte de Jean Croteau Enrg.Transfert de permis: Le requérant-vendeur demande à la Commission des transpons du Québec la permission de céder son permis no 246-N.selon l'anicle 36 de la Loi des transpons.à: «Excursions Maritimes Miss Montreal Inc.» le permis se lit comme suit: Service 1: Transpon de passagers par traversiez entre Longucuil et le port de l'Ile de la Ronde à Terre des Hommes.4.The permit holder shall not transfer his office from the City of Victoriaville without prior written authority from this Commission and shall not directly or indirectly operate an office without prior permission of this Commission at any locality in the Province of Québec other than the City of Victoriaville.5.Bills of lading shall be issued in accordance with the laws of the Province of Québec 6.This permit is subject lo revision by the Commission and will be revised immediately if the operator ceases to be a hauling agent of United Van Lines (Canada) Lid.and United Van Lines Inc.The shares of Rheault & Fils Liée are allotted as follows: Common shares Armand Rheault.president 2.998 Mrs.Gisèle B.Rheault.secretary i Mrs.Gisèle R.Carrier.vice-president I I.Transmission owing to death: Dame Anna Deschènes-Frenette 771 Saint-Bernard Street Québec.P.Q.requests that permit No.1271-V.which was held by her husband.Mr.Lauréat Frenetic deceased, be transferred in her favour, namely: General transpon - local service - Ouébec and environs.Restriction: This permit docs not authorize (he transport by armoured vehicles.Ooals.lank trucks, special moving vans and special motor vehicle transporters.2.Application for transferring permit No.1271-V in favour of: Roy.Charles-Henri (22890-Vi 3185.des Grives Orsainville.P.O.who holds permit No.22890-V.namely: Restricted trucking - local service - contract -Québec and any point situated within a distance of five (5) miles from ihe limits of said City, for the delivery of new furniture and of electric appliances, on behalf of Jean Croteau Enrg.Request for transfer: The applicant-vendor requests lo the Ouébec Transport Commission authorization lo transfer permit No.246-N according to article 36 of Transport Act, lo: \"Excuisions Maritimes Miss Montreal Inc.\" permit reads as follows: Service I : Transpon of passengers by feny-boats between Longueuil and pon of lie de la Ronde at Terre des Hommes. 2090 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8.7.975, Vol.107.Ko.10 Rôle 0-3117 I0542-V-D-I LABRECQUE.PAUL-ÉMILE 408.Chrislophe-Colomb Ouest Ouébec (Oué.l et / and EXPRESS A & F BAILLARGEON QUÉBEC INC./ A & F BAILLARGEON EXPRESS QUÉBEC INC.2.Chauveau.2e étage Ouébec (Oué.) Rôle 0-3129 O-201232-D-2 CAYER.ADRIEN 130.Bostonais La Tuque (Que.) O-202I63 RIBERDY, MICHEL 718.Roy La Tuque (Oué.) Rôle Q-3130 O-200367-D-7 ÉMOND.LORENZO 5.rue Dollard-Rivière-du-Loup (Oué.) Q-202165 VIEL.MARC-ANDRÉ Notrc-Dame-du-Portage Rivière-du-Loup (Que.) Service 2: Excursions touristiques sur le Fleuve St-Laurent départ de la rue McGill.Montréal, pour se rendre jusqu'à la Marina sur l'Ile de la Ronde et retour, ainsi que pour les excursions entre Lachine et Repenligny.Demande de transfert: Le requérant qui détient le pernis numéro 10542-V se lisant comme suit: Transpon général - service local -Ste-Foy el tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites dudil endroit; Transport général - longue distance - rayon -De Ste-Foy à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles dudit endroit, et retour, demande à la Commission des transports du Québec l'autorisaiion de céder le système de iransport qu'il exploite en venu dudit permis à A & F Baillargcon Express Québec Inc., 2.Chauveau.2e élage.Québec, requérante conjointe.Les actions de Express A & F Baillargcon Ouébec Inc./ A & F Baillargeon Express Québec Inc.se répartissent comme suit: A & F Baillargeon Express Inc.: Guy-Bernard Baillargeon.prés, / pres.: Claude Collard.vice-prés.' vice-pres.: Louise Baillargeon.sec.-très./Treas.-secr.: Demande de transfert: Cayer.Adrien, demande à la Commission de transférer à: Riberdy.Michel 718.Roy La Tuque (Que.) le permis no Q-201232-D-2 pour effectuer du transpon par véhicule-taxi dans l'agglomération A-50.La Tuque.Demande de transfert: Emond.Lorenzo, demande à la Commission de transférer à: Viel.Marc-André Notre-Dame-du-Portage Rivière-du-Loup (Que.) le permis no Q-200367-D-7 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération A-13.Rivicre-du-Loup.Service 2: Sightseeing tours on \"Fleuve St-Laurent starting McGill Street Montreal going lo Ihe Marina on the Ile de la Ronde and return, and the same for tours between Lachine and Repentigny.Application for transfer: The applicant which holds permil number 10542-V reading as follows: General transport - local service -Saintc-Foy and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said City: General transport - long distance - radius -From Sainte-Foy lo all points located within a radius of 30 miles from said City, and return, requests the Ouébec Transport Commission the authorization to transfer the transportation service, thai he operates by virtue of said permit, to A & F Baillargeon Express Québec Inc.2 Chauveau.2nd floor.Québec, joint applicant.Shares of Express A & F Baillargeon Québec Inc./ A & F Baillargeon Express Québec Inc.are distributed as follows: Actions ordinaires Actions privilégiées Common shares 997 1 I I Preferred shares 200 Application for transfer: Cayer.Adrien, requests the Commission to iransfer to: Riberdv.Michel 718, Roy-La Tuque (Que.) permil No.O-20I232-D-2 to effect\" Iransport by taxicab in Conglomeration A-50, La Tuque.Application for Iransfer: Emond.Lorenzo, requests the Commission to transfer to: Viel.Marc-André Notre-Dame-du-Portage Rivière-du-Loup (Que.) permil No.Q-200367-D-7 to effeel (ranspon by taxicab in Conglomeration A-13.Rivière-du-Loup.Rôle 0-3131 O-500388-D-001 RAYMOND LEMAY Principale.St-Édouard (Lotbinière) (Oué.) el / and O-504856-D-00I RICHARD LEMAY St-Édouard (Lolbinière) (Que.) Demande de transfert: Raymond Lemay demande à la Commission de transférer à: Richard Lemay St-Édouard (Lolbinière) (Que.) le permis ou l'attestation Q-5C0388-D-001 qu'il délient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région no 3.catégorie Artisan.Application for transfer: Raymond Lemay requests ihe Commission to transfer to: Richard Lemay Saint-Edouard (Lolbinière) (Que.) permit or certificate O-500388-D-00I.which he holds, toeffect bulk trucking, in Region No.3.Artisan class. GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, H mars J!)7.r,, 107' année, n° 10 2091 Rôle 0-3132 O-501595-D-00I ARTHUR MATHIEU 271.Sl-Édouard Normandin (Roberval) (Oué.) el / and Q-504834-D-00I GÉRALD GOULET 271.Si-Êdouard Normandin (Roberval) (Oué.) Rôle M-6645 30OO4-D-73-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASSOC 555 Dixon Road Rexdale.Ontario Au Ouébec: In Ouébec: 1434 ouest.Ste-Catherine.suite 404 Monlréal (Oué.) Rôle 6646 40013-D-6-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASSOC.555 Dixon Road Rexdale.Ontario Au Ouébec: In Ouébec: 1434 ouest.Ste-Catherine.suite 404 Montréal (Oué.) Rôle 6647 30004-D-72-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASSOC.555 Dixon Road Rexdale.Ontario Au Québec: In Québec: 1434 ouest.Ste-Catherine.suite 404 Montréal (Que.) H3G IR4 Demande de transfert: Arthur Mathieu demande à la Commission de transférer à: Gérard Goulet 271.St-Édouard Normandin (Roberval) (Que.) le permis ou l'attestation Q-50I595-D-00I qu'il détienl pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région no 2, catégorie Artisan.Application for transfer: Arthur Mathieu requests the Commission to transfer to: Gérard Goulet 271 Saint-Edouard Normandin (Roberval) (Que.) permil or certificate O-501595-D-00I.which he holds, to effect bulk trucking, in Region No.2.Artisan class.En vertu de l'article 2.58.1 des regies de pratique de la Commission des transports du Ouébec.On demande une augmentation de 7.5% applicable aux taux (mais non aux frais accessoires s'y rattachant) du tarif concurrentiel entre le Ouébec el l'Ontario, no 71-D.B.T.O.no 2926.Cette augmentation doit entrer en vigueur le 1er mai 1975.en vertu des disposions contenues à la partie 2H, article 2.58.1 des règles de pratique de la Commission des transpons.On demande de toute urgence que publicalion immédiate de cet avis soit faite dans la Gazelle officielle du Québec, en raison du délai de 21 jours qui iniervieni après la première publication.En vertu de l'article 2.58.1 des règles de pratique de la Commission des transports du Ouébec.On demande une augmentaiion de 7.5% applicable aux taux (mais non aux frais accessoires s'y rattachant) du tarif s'appliquant à l'équipement spécial, entre le Ouébec et l'Onlario.no 210.B.T.O.3275.Celte augmentaiion doit entrer en vigueur le 1er avril 1975.en venu des dispositions contenues à la partie 2H.article 2.58.1 des règles de pratique de la Commission des transports.On demande de toute urgence que publicalion immédiate de cet avis soit faite dans la Gazelle officielle du Québec, en raison du délai de 21 jours qui intervient après la première publicalion.En venu de l'article 2.58.1 des règles de pratique de la Commission des transports du Québec.On demande une augmentaiion de 7.5% applicable aux taux (mais non aux frais accessoires s'y rattachant) des tarifs indiqués ci-dessous.Celte augmentaiion doit entrer en vigueur le 1er avril 1975.en venu des dispositions contenues à la panie 2H de l'article 2.58.1 des règles de pratique de la Commission des transports.On demande de toute urgence que publicalion immédiate de eel avis sou faite dans la Gazelle officielle du Québec, en raison du délai de 21 jours qui intervient après la première publication.Québec-Ontario tarif de classe no 10-E.B.T.O.no 1500 Ouébec-Ontario tarif d'espèces no 15-K.B.T.O.no 2805 Tarif applicable au fer el à l'acier, no 32-G.B.T.O.no 2909 Pursuanl to section 2.58 1 of the Québec Transpon Commission Rules of Practice.Request increase of 7.5% in rates (but not accessorial charges) in Québec-Ontario Compel in ve Tariff No.71-D.T.B Q.No.2926.effective May 1.1975.under procedures in 2H.section 2.58.1 of Transport Commission Rules of Practice.Urgent request is made for immediate publication in the Québec Official Gazelle due to the 21-day waiting period after first gazetting.Pursuant to section 2.58.1 of the Québec Transpon Commission Rules of Practice.Request increase of 7.5% in rates (bui not accessorial chargesl in Québec-Ontario Specialized Equipment Tariff No.210.T.B.Q 3275.effective April 1.1975.under procedures in 2H.section 2.58.1 of Transport Commission Rules of Practice.Urgent request is made for immediate publication in the Québec Official Gazelle due to the 21-day waning period after first gazetting.Pursuant to section 2.58.1 of the Québec Transport Commission Rules of Practice.Request increase of 7.5% in rates and minimum charges (but not accessorial charges) in the tariffs named below, effective April 1.1975.under procedures in 2H.section 2.58.1 of Transport Commission Rules of Practice.Urgent request is made for immediate publicalion in the Québec Official Gazelle due lo the 21-day wailing period after first gazetling.Québec-Ontario class tariff No.10-E.T.B.Q.No.1500 Ouébec-Ontario commodity tariff No.15-K.T.B.Q.No.2805 Iron and steel tariff No.32-G.T.B.Q.No.2909 2092 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.March 8, J97Ô.Vol.107.No.10 Rôle M-6713 14234-V-D-l BERGEVIN, GILLES Hôtel St-Louis St-Louis-de-Gonzague (Que.Rôle M-6749 30003-D-64-TF BUREAU DES TARIFS DU QUÉBEC INC.1259 rue Berri.suite 460 Montréal (Que.) Tarif applicable au papier.no40-G.B.T.Q.no 2910 Tarif d'importation et d'exportation no 45-M.B.T.O.no 1808 Tarif d'importation et d'exportation, no 74-A.B.T.O- no 3372.applicable aux conteneurs.Transfert de permis: Le requérant-vendeur: Gilles Bergevin Hôtel St-Louis Sl-Louis-de-Gonzague (Que.) s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir l'approbation de celte dernière sur le transfert de son permis no 14234-V en faveur de: la requérante-acquéreur: Vallevficld Dock & Terminal Co.Ltd.CP.123 Valleyfield (Que.) Le tout conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi des transports.Teneur du permis no 14234-V: Classe: Transport général - service local -Service: St-Louis-de-Gonzague et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite municipalité.Distribution des actions de la compagnie acquéreur: Actions ordinaires Milton, Douglas, président 21 Chodos.Tcd.vice-président 3 Milton.Nicole 2 St-Onge.Jacques, secrétaire-trés.3 Demande de fixation de taux: Demande permanente: Pour la publication au tarif 120 de notre supplément d'urgence no 1265 Ce supplément a été approuvé pour six (6) \"lois par la Commission des transports du Ouébec par décision MS-I24I-TF.cause MRS-0730, dossier 30003-S-1 l-TF.B.T.O.contrôle X-165.Division des revenus au tarif 120: Augmentation des taux proportionnels ou la portion du camionneur du Québec en rapport avec les dernières augmentations accordées aux taux directs publiés au tarif 120 » Inler-Provin-cial»: 20% sur les taux de classe 100.85.70 et 55.9% sur les taux de classe 45.$1.00 sur les minimums.Tarif 100-C: Nouveaux membres: Jim Lynn Transport Inc.Roy Transport.Gevry Transport Inc.Supplément intérim no 2038: Brazeau Transport Inc.Augmenter les frais publiés à la note 2.de la clause ss de 12%.Augmenter les taux au mille de l'annexe «,A» de la clause ss de 12%.Supplément intérim no 1887: Michel Transport Inc.Paper tariff No.40-G.T.B.Q.No.2910 Export and import tariff No.45-M.T.B.Q.No.1808 Import and Export container tariff No.74-A.T.B O.No.3372.Transfer of permil: The applicant-vendor: Gilles Bergevin Hôtel Saint-Louis Saint-Louis-de-Gonzague.P.O.requests from the Québec Transport Commission approval of the iransfer of his permil No.14234-V in behalf of: the applicant-purchaser: Valleyfield Dock & Terminal Co.Ltd.P.O.Box 123 Valleyfield.P.O.The whole in conformity with [he provisions of section 36 of the Transport Act.Terms of permit No.14234-V: Class: General trucking - local service -Service: Saint-Louis-de-Gonzague and any point located within a distance of five miles (51 from the limns of said Municipality.Distribution of shares of the purchasing company: Common shares Milton.Douglas.President 21 Chodos.Tcd.Vice-president 3 Milton.Nicole 2 St-Onge.Jacques.Secr.-ireas.3 Application for fixation of rates: Permanent request: To publish our emergency supplement No.1265 to tariff 120.This supplement has been approved by the Québec Transport Commission by decision MS-1241-TF.case MRS-0730.file 30003-S- 1 l-TF.B.T.O.control X-165.Division of revenus lo tariff 120: Increase of proportional rates or the portion of the Ouébec carrier in accordance with the latest increases granted to through rates published in tariff 120 \"Inter-Provincial\": 20% on class rales 100.85.70 and 55.9\"7< on class 45 rates.S 1.00 on Ihe minimum.Tariff 100-C: New members: Jim Lynn Transporl Inc.Roy Transport.Gevry Transporl Inc.Interim supplement No.2038: Bra/eau Transport Inc.Increase Ihe charges published in ihe note 2 of clause ss by 12%.Increase the mileage rales on annex \"A\" of clause ss by 12%.Interim supplemenl No.1887: Michel Transport Inc. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.S murs 1975, JOT année.n° 10 2093 Augmenter les frais publiés à la note 2 des clauses ss, uu, vv de 12%.Augmenter les taux au mille de l'annexe «A», des clauses ss.uu.m de 12%.Supplément intérim no 2031: Chalut Transport Inc.Augmenter les frais publiés à la note 2 des clauses e,k.1 de 12%.Augmenter les taux au mille de l'annexe «A», des clauses c.k.I de 12%.Supplément intérim no 2032: St-Jérôme Express Liée.Augmenter les frais publiés à la note 2 des clauses r.d de 12%.Augmenter les taux au mille de l'annexe .: La Commission donne avis qu'elle enlend décider des affaires suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les quinze jours francs de la date de la présente publicalion.Rôle 0-3127 23I59-V-P-1 BENOIT CROTEAU LTÉE 85, rue Notre-Dame Drummondville (Oué.) Aux fins de révoquer la décision QCR-352 autorisant la délivrance du permis no 23159-V détenu par Benoil Croleau Ltée et ce.à la demande de ce dernier.I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission: The Commission gives notice of its intention to settle the following proceedings in conformity wilh the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of fifteen clear days following the dale of this publication.For the purpose of revoking decision OCR-352 authorizing the issue of permit No.23159-V held by Benoil Croteau and this, at the latler's request.60184-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n° 10 2097 V \u2014 Avis de décisions rendues : La Commission donne avis de la nature des décisions suivan tes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement No 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered : The Commission gives notice of the nature ol the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation No.2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transporl Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.DECISIONS DE LA COMMISSION » PROPRIO MOTU » / DECISIONS \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION No\tDate\tRequérants Applicants\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions MPT-8222\t14-02-75\tM-201471-D-1 MAURICE LEMAY\t9296\t14-12-74\tM-4173\t La Commission déclare amendées les parties de la décision MPT-956 en date du 19 juin 1974 où il est indiqué « la municipalité de Ste-Thérèse (06-6309-C) » c'est-à-dire au premier paragraphe de ladite décision et au troisième paragraphe des conclusions de ladite décision afin qu'elles se lisent comme suit: « la région de Ste-Thérèse Ouest (06-6312-VT) » MPT-8223 14-02-75 M-201472-D-1 WALTER LE FRANÇOIS La Commission déclare amendées les parties de la décision MPT-957 en date du 19 juin 1974 où il est indiqué « la mu-niciplité de Ste-Thérèse (06-6309-C) » c'est-ù-oiie fill ric-mier paragraphe de ladite décision et au troisième paragraphe des conclusions de ladite décision de manière à ce qu'elles se lisent comme suit: « la région de Ste-Thérèse Ouest (06-6312-VT) » MPT-8224 18-02-75 M-205118-P-1 ANDRE VIENS La Commission donne acte au requérant de son désistement et annule, à toutes fins que de droit, le permis M-205118 détenu par André Viens.MPT-8225 18-02-75 M-204146-P-1 REJEAN BELANGER La Commission corrige la décision MPT-4535 pour qu'elle se lise: l'agglomération A-5, Montréal.MCR-1604-TF 18-02-75 30004-P-l-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N.La Commission déclare corrigée la décision MCR-129-TF en date du 10 juillet 1973 de façon à ce que la date d'expiration mentionnée dans ladite décision soit: 31 mars 1974 relativement aux dossiers 974-TE, 973-TF, 825-TF et 415-TF qui représentaient les contrats a taux convenus nos 29-B, T.B.Q.3789- 28, T.B.Q.3610 et 7-F, T.B.Q.37?0 ren.ecli-cetnent.MCR-1605 18-02-75 5415-V-1M HERVEJENNE La Commission: 1.annule, à toutes fins que de droit, les conclusions de la décision MCR-1271, en date du 23 octobre 1974 à l'exception, toutefois, des paragraphes concernant la disposition du cautionnement et du paiement des droits exigihles; 2.annule, à toutes fins que de droit, les clauses c, d et c du permis no 5415-V, détenu par Hervé Venne; The Commission declares amended parts of the decision number MPT-956, dates June 19, 1974, where \"The Municipality of Sainte-Thérèse (06-6309-C)\" is mentioned, that is, in the first paragraph of said decision and in the third paragraph of the conclusions of said decision in order to read as follows: \"The Region of Sainte-Thérèse West (06-6312-YT)\" 9296 14-12 7-1 M-4174 The Commission declares amended parts of decision number MPT-957, dated June 19, 1974.where \"The Municipality of Sainte-Thérèse (06-6309-C)\" is mentioned, that is.in the first paragraph of said decision and in the third paragraph of the conclusions of said decision in order to read as follows : \"The Region of Sainte-Thérèse West (06-G312-VT)' 7895 19-10-74 M-340S The Commission acknowledges the applicant's withdrawal and cancels, for all legal purposes, permit No.M-205118 held by André Viens.7897 19-10-74 M-3524 The Commission corrects decision MPT-4535, to read as follows: Conglomeration A-5, Montreal.179 11-01-75 M-4797 The Commission declares that decision MCR-129-TF, dated July 10, 1973 is corrected in order that the date of expiry mentioned in said decision he: March 31, 1974 with regard to files 974-TF, 973-TF, S25-TF and 415-TF.representing the agreed charge contracts Nus.20-B.T.B.Q.37S9-28.T.B.Q.3010 and 7-1'.T.B.Q.37S0 respectively.9499 21-12-74 M-4335 The Commission: 1.cancels, for all legal purposes, conclusions of decisions MCR-1271.dated October 23.1974.with the exception however of paragraphs concerning the disposal of the deposit and payment of the exigible fees; 2.cancels, for all legal purposes, clauses c, (/ and r, of permit No.5415-V, held by Hervé Venne; 209S QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE, Marri, S, J975.Vol.307, So.10 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\tApplicant*\tpage\tdate\tCase\tDécisions 3.autorise le transfert des clauses a et b du permis de Hervé Venne, no 5415-V.:'i Laurent Yenne, 647.rue Notre-Dame.St-I'aul-l'Emite.comté He L'Assomption, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi des transports; 4.autorise Laurent Yenne.047.rue Notre-Dame, St-Paul-l'Erniite, comté L'Assomption (Que.), a donner, à l'avenir, le service suivant; Classe: a) Transport général - service local -Service: a) St-Paul-l'Ermite et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites dudit endroit : Classe: b) Transport général - longue distance - rayon -Service : 6) De St-Paul-l'Ermite a tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites dudit endroit, et retour.5.décrite que les taux applicables seront ceux déposés au dossier.MCS-1027 14-02-75 3.authorizes the transfer of clauses a and b of permit No.5415-V, held hy Hervé Yenne, to Laurent Yenne.647 Notre-Dame Street, Saint-l'aul-l'Ernitte.County of L'Assomption, in conformity with the provisions of section 39 of the Transport Act; 4.authorizes Laurent Venne, 647 Notre-Dame Street.Saint-Paul-l'Ermite, County of L'Assomption, P.Q.to provide, in the future, the following service: Class : (a) General trucking - local service -Service: (a) Saint-Paul-l'Ermite and all points located within a radius of 5 miles from the limits of said locality; Class: (b) General trucking - long distance - radius -Service : (b) From Saint-Paul-l'Ermite to all points located within a radius of 30 miles from the limits of said locality, and return.5.Orders that the applicable rates shall be those filed in the record.22499-V-D-2-P-1 LES TRANSPORTS DE LA BAIE D'HUDSON INC.La commission: 1.déctere amendée la décision MCR-1262, MCS-782.en date du 22 octobre 1974; 2.annule, à toutes fins que de droit, les termes « et/ou isothermes « que l'on retrouve dans la clause de droit additionnel dans le dispositif de ladite décision.9295 14-12-74 M-424S MCS-1028 14-02-75 2873-V-P-l LAMOTHE QUEBEC INC.La commission: 1.déclare amendée la décision MCR-1261, MCS-78I, en date du 22 octobre 1974; 2.annule, à toutes fins que de droit, les termes « et/ou isothermes » que l'on retrouve dans la clause de droit additionnel dans le dispositif de ladite décision.The Commission: 1.declares amended decision MCR-1262, MCS-782, dated October 22.1974; 2.cancels, for all legal purposes, the terms \"et / ou isothermes\" appearing in the clause of additional right in the conclusion of said decision.9295 14-12-74 M-4250 The Commission: 1.declares amended decision MCR-1261, MCS-781, dated October 22, 1974; 2.cancels, for all legal purposes, the terms \"et / ou isothermes\" appearing in the clause of additional right in the conclusion of said decision.MCS-1029 14-02-75 4724-V-D-l-P-l MAGNY TRANSPORT INC.La commission: 1.déclare amendée la décision MCR-1267.MCS-786.en date du 22 octobre 1974; 2.annule, à toutes fins que de droit, les termes c et/ou isothermes » que l'on retrouve dans la clause de droit additionnel dans le dispositif de ladite décision.9290 14-12-74 M-4274 MCS-1030 14-02-75 14838-V-D-2-P-1 PHILIPPE ROY TRANSPORT La commission: 1.annule, îi toutes fins que de droit, le troisième paragraphe de la page 3, de la décision MCS-801, en date du 4 novembre 1974; 2.autorise Philippe Roy Transport Inc.à ajouter a son permis le service suivant : Classe: Transport restreint - longue distance \u2014 rayon - contrat -Service : De Sherbrooke à tous les endroits situés dans un rayon de 500 milles de ladite localité, et retour, pour le transport par camions munis d'un treuil, de briques, pierres usinées, blocs de ciment et des palettes servant à la manipulation desdits matériaux pour le compte de o Les Produits de Ciment Windsor Inc.* Restriction: 1.En donnant le service sus-mentionné.la détentrice ne sera pas autorisée à desservir les villes de Québec et Montmorency, ainsi que le rayon de 5 milles desdites municipalités.The Commission : 1.declares amended decision MCR-12G7, MCS-786, dated October 22.1974; 2.cancels, for all legal purposes, the terms \"et/ou isothermes\" appearing in the clause of additional right in the conclusion of said decision.9296 14-12-74 M-4172 INC.The Commission: 1.cancels, for all legal purposes, the third paragraph of page 3 of decision MCS-801, dated November 4, 1974; 2.authorizes Philippe Roy Transport Inc.to add the following service to its permit: Class: Restricted trucking - long distance - radius - contract -Service : From Sherbrooke to all the points located within a radius of 500 miles from said locality, and return, for the transport by truck equipped with a winch, of bricks, hewn stone, concrete blocks and pallets used for the handling of said materials on behulf of Les Produits de Ciment Windsor Inc.\".Restriction; 1.When providing the abovementioned service, the holder shall not be authorized to serve Québec Citv and the Town of Montmorency, neither the 5 miles radius from said municipal- GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, H mars 197Ô, JOT aimée.>i° 10 2099 \t\t\tC\t.O.Q.\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\tApplicants\tpage\tdate\tCase\tDécisions 2.Les produits de même nature manufacturée par la compagnie Domtar et la compagnie St-Laurent Ltée seront exclus du service autorisé par la clause ci-dessus.2.The same kind of products manufactured by Domtar Company and St-Laurent Ltée shall be excluded from the service authorized by the abovementioned clause.MCS-1031 14-02-73 8505-V-D-2-P-S CENTRAL TRICK LINES LTD La commission: 1.déclare amendée la décision MCR-1264, MCS-783, en date du 22 octobre 1974: 2.annule, à toutes fins que de droit, les termes « et/ou isothermes » que l'on retrouve dans la clause de droit additionnel dans le dispositif de ladite décision.9295 14-12-74 M-4247 The Commission : 1.declares amended decision MCR-1204, MCS-783, dated October 22, 1974; 2.cancels, for all legal purposes, the terms \"et /ou isothermes\" appearing in the clause of additional right in the conclusion of said decision.ML-546 18-02-75 802-D Y-P-l VILLENEUVE RENT-A-CAR La Commission : 1.annule, à toutes fins que de droit, le permis no 802-DY détenu par: Villeneuve Rent-A-Car Villeneuve location d'automobiles (Marcel Villeneuve, opérant sous le rem de:) 2.Clot le dossier.179 11-01-75 M-4740 The Commission: 1.cancels, for all legal purposes, permit No.802-DY' held by: Villeneuve Rent-A-Car Villeneuve location d'automobiles (Marcel Villeneuve operating under the name of:) 2.Closes the file.ML-547 18-02-75 993-DYV-D-l-P-l LOCATION MAJOR Requérante-venderesse Applicant-vendor 8072 26-10-74 M-3575 La Commission: 1.annule, à toutes fins que de droit, la décision MI.-381 en date du 5 août 1974 à l'exception toutefois de l'item décrétant la remise de dépôt de $50.2.décrète la remise de la somme de $32 (reçu no 4S726) déposée par le procureur des requérants pour le paiement des droits.The Commission : 1.cancels, for all legal purposes, decision ML-381 dated August 5, 1974, except however the item ordering the reimbursement of the $50 deposit.2.Orders the reimbursement of the sum of $32 (receipt No.48726) deposited by the applicants' attorney for the payment of fees.QCR-958-TF 26-02-75 3002-P-l-TK L'ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUEBEC INC.La Commission corrige les pages 1 et 2 de la décision QCR-890-TF comme suit: « L'Association du Camionnage du Québec Inc.» et -2%.payable scmi-annuelle-ment les 15 octobre et 15 avril de chaque année.Létaux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 avril 1975.not be considered.Adjudication shall be made according to law.The maturity of April 15, 1985.in the amount of $136.500 includes a balance of $117.000 renewable for an additional 30-year period.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicateel in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Municipality of Notre-Dame agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 15.1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The saiel bonds will be issued pursuant to the following bvlaws: 49 \u2014 $95.000 \u2014 loan renewal; 69 \u2014 $44.000 \u2014 roads; 70 \u2014 $52.200 \u2014 roads: 71 \u2014 $30.000 \u2014 roads; 72 \u2014 $7,800 \u2014 waterworks, sewers; 73 \u2014 $35.000 \u2014 waterworks, sewers.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council to be held on Wednesday.March 26, 1975, at 8:00 o'clock p.m.in the Church Basement, Riendeau Boulevarel.Notre-Dame.County of Laprairie.P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Notre-Dame (County of Laprairie), Februarv 26.1975.Miss Lucille Gagnon\".Secretary-Treasu rer.Municipal Office.855 Domville Street.Notre-Dame.County of Laprairie.P.Q.Telephone: 676-1954, code 514.60201 City of Sainte-Foy Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Me Noël Perron, City Clerk, at the City Hal], 1000 De l'Église Foad.Sainte-Foy.P.Q.until 8:00 o'clock p.m.on Monday, March 24.1975.for the purchase of a bond issue of $4,000.000 for the City of Sainte-Foy, dated April 15.1975 and redeemable serially from April 15, 1976 to April 15, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9.! ¦>%, payable semiannually on October 15th and April 15th of each year.The rate of interest may be the dame for the whole issue; however, should more than one rate be usedv the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 15, 1975. 211ÎS QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Tableau d'amortissement \u2014 S4.000.000 \u2014 20 ans Date Capital 15 04 197G.8 70,000 15 04 1977.77.000 15 04 1978.84,000 15 04 1979.93.000 15 04 1980.103.000 15 04 1981 .112.000 15 04 1982.124.000 15 04 1983.136,000 15 04 1984.150.000 15 04 19S5.165.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 8425,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 avril 1995.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8425,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation uu pair le 15 avril de chaque année pourle montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Sainte-Foy s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement numéro 1870 \u2014 84,000.000 \u2014 emprunt pour payer le coût des travaux décrétés par différents règlements.Redemption table \u2014 S4.000.000 \u2014 20 years Date Capital 15 04 1986.5181.000 15 04 1987 .199,000 5 04 9S8 .219,000 5 ni 9S9 .241,000 15 04 990 :.266.000 15 04 1991.292,000 15 04 1992.321,000 15 04 1993.353,000 15 04 1994.389.000 15 04 1995.425,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than 8425,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of April 15, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amcAint greater than 8425,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption tabic appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Sainte-Foy agrees not to bring out new-bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 15, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.Said bonds will be issued pursuant to bylaw number 1870 \u2014 $4,000.000 \u2014 loan covering the cost of the works ordered by various bylaws. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1976, 107- année, n\" 10 2119 Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8.00 heures du soir, lundi, le 24 mars 1974, Hôtel de ville, 1000 route de l'Église, Sainte-Foy, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sainte-Foy, ce 4 mars 1975.Le greffier.Me Noël Perron.Hôtel de ville, 1000 route de l'Église, Sainte-Foy, P.Q.Téléphone: 657-4411, 657-4172, code 418.60261-o Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Monday, March 24,1975, at 8:00 o'clock p.m., at the City Hall, 1000 De l'Église Road, Sainte-Foy, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Sainte-Foy, March 4, 1975.Me Noel Perron, City Clerk.City Hall, 1000 De l'Église Road, Sainte-Foy, P.Q.Telephone: 657-4411, 657-4127, code 418.60261 La commission scolaire Seigneurie Siège social: Papineauville, Papineau, Que.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Raymond Lépine, directeur général, jusqu'à 4.30 heures de l'après-midi.Centre administratif, 188, rue Sainte-Jeanne-d'Arc, C.P.280 Papineauville, (Papineau) Que.et par après jusqu'à 8.00 heures du soir, Salle Communautaire de l'Aile « D », du Centre d'Accueil de la Petite Nation de Saint-André-Avellin, (Papineau), Que., mercredi, le 26 mars 1975, pour l'achat de $240,000 d'obligations pour la commission scolaire Seigneurie, datées du 15 avril 1975 et remboursables en série du 15 avril 1976 au 15 avril 1985 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9J^%, payable semi-annuellement les 15 octobre et 15 avril de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 avril 1975.The Seigneurie School Board Head Office: Papineauville, Papineau, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Raymond Lépine, Director-General, until 4:30 o'clock p.m., at the Administration Centre, 188 Sainte-Jeanne-d'Arc Street, Post Office Box 280, Papineauville, (Papineau), P.Q., and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at the 'Salle Communautaire de l'Aile \"D\" du Centre d'Accueil de la Petite Nation de Saint-André-Avellin\", (Papineau), P.Q., on Wednesday, March 26, 1975, for the purchase of a bond issue of $240,000 for the Seigneurie School Board, dated April 15, 1975 and redeemable serially from April 15, 1976 to April 15, 1985 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9}^%, payable semiannually on October 15th and April 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 15, 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $240,000 \u2014 10 ans Date Capital 15 04 1976.$16,000 15 04 1977.16,000 15 04 1978.18,000 15 04 1979.20,000 15 04 1980.23,000 La commission scolaire Seigneurie, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par, lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.Redemption table \u2014 $240,000 \u2014 10 years Date Capital 15 04 1981.$25,000 15 04 1982.27,000 15 04 1983.28.000 15 04 1984.32,000 15 04 1985.35,000 The Seigneurie School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to depsit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required. 2120 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire Seigneurie s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 avril 1975, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 30-1-75 \u2014 $135,000 \u2014 dépenses d'immobilisations; 30-1-75 \u2014 $105,000 \u2014 dépenses d'immobilisations.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 26 mars 1975, à 8.00 heures du soir.Salle Communautaire de l'Aile « D » du Centre d'Accueil de la Petite Nation de Saint-André-Avellin, comté de Papineau, Que.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Papineauville, ce 3 mars 1975.Le directeur général, Raymond Lépine.Centre Administratif, 188, rue Sainte-Jeanne-d'Arc, CP.280, Papineau\\iIIe (Papineau) Que.Téléphone: 427-6258, code 819.60262-o Cité de Giffard Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription » Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jacques Simoneau, greffier.Hôtel de ville, 3095, Chemin Royal, Giffard, Québec 5, Que., jusqu'à 7.30 heures du soir, lundi, le 24 mars 1975, pour l'achat de $735,500 d'obligations de la cité de Giffard.datées du 15 avril 1975 et remboursables en série du 15 avril 1976 au 15 avril 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9}^%, payable semi-annuellement les 15 octobre et 15 avril de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'Intérêt sera calculé à compter du 15 avril 1975.It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.\u2022» Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Seigneurie School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 15, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: 30-1-75 \u2014 $135,000 \u2014 capital expenditure; 30-1-75 \u2014 $105,000 \u2014 capital expenditure.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Wednesday, March 26, 1975, at 8:00 o'clock p.m., at the 'Salle Communautaire de l'Aile \"D\" du Centre d'Accueil de la Petite Nation de Saint-André-Avellin\", County of Papineau, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Papineauville, March 3, 1975.Raymond Lépine, Director-General.Administration Centre, 188 Sainte-Jeanne-d'Arc Street, Post Office Box 280, Papineauville (Papineau), P.Q.Telephone: 427-6258, code 819.60262 City of Giffard Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Jacques Simoneau, City Clerk, at the City Hall, 3095 Chemin Royal, Giffard, Québec 5, Que., until 7:30 o'clock p.m., on Monday 24, 1975, for the purchase of a bond issue of $735,500 for the City of Giffard, dated April 15, 1975 and redeemable serially from April 15.1976 to April 15, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than payable semiannually on October 15th and April 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 15, 1975. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1976, 107\u2022 année, n° 10 2121 Tableau d'amortissement \u2014 $735,500 \u2014 20 ans Date Capital 15 04 1976.$ 12,500 15 04 1977.14,000 15 04 1978.15,000 15 04 1979.16,000 15 04 1980.17,000 15 04 1981.32,000 15 04 1982.33,000 15 04 1983 .37,000 15 04 1984.38,000 15 04 1985.41,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $52,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 avril 1995.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $52,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Giffard s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 215 \u2014 $65,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 532 \u2014 $41,000 \u2014 renouvellement d'em- Redemption table \u2014 $736,600 \u2014 SO years Date Capital 15 04 1986.$ 45,000 15 04 1987.49,000 15 04 1988.52,000 15 04 1989 .57,000 15 04 1990.52,000 15 04 1991.38,000 15 04 1992.42,000 15 04 1993 .45,000 15 04 1994.48,000 15 04 1995.52,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $52,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of April 15, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $52,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Giffard agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 15, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 215 \u2014 $65,500 \u2014 loan renewal; 532 \u2014 $41,000 \u2014 loan renewal; 542 \u2014 $19,500 \u2014 loan rene- 2122 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 prunt; 542 \u2014 $19,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 555 \u2014 $29,000 \u2014 renouvellement d'emprunt: 556 \u2014 $3,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 667 \u2014 $552,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 700 \u2014 $25,000 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 7.30 heures du soir, lundi, le 24 mars 1975, Hôtel de ville, 3095, Chemin Royal, Giffard, Québec 5, Que.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Giffard.ce 25 février 1975.Le greffier, Jacques Simoneau.Hôtel de ville, 3095, Chemin Royal, Giffard, Québec 5, Que.Téléphone: 667-8120, code 418.60198-o wal; 555 \u2014 $29,000 \u2014 loan renewal; 556 \u2014$3,500 \u2014 loan renewal; 667 - $552,000 - waterworks, sewers and roads; 700 \u2014 $25,000 \u2014 refinancing costs.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 7:30 o'clock p.m.on Monday, March 24, 1975, at the City Hall, 3095 Chemin Royal, Giffard, Québec 5, Que.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Giffard, February 25, 1975.Jacques Simoneau, Cily Clerk.City Hall, 3095 Chemin Royal, Giffard, Québec 5, Que.Telephone: 667-8120, code 418.60198 Proclamation Proclamation HUGUES LAPOINTE Canada, Province de Québec.[L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que, sous l'autorité de l'article 2 de la Loi des titres de propriété dans certains districts électoraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 321), le ministre des terres et forêts a fait dresser des plan et livre de renvoi révisés, dans le district électoral de Bonaventure, pour le cadastre d'une partie du canton de Maria à l'endroit des lots 44 et 45e à 52 et 53d inclusivement, 78 et 79 du premier rang, partie est de leurs subdivisions respectives, le tout situé dans la division d'enregistrement de Bonaventure No 2; Attendu que, conformément aux articles 2 et 3 de ladite Loi, le ministre des terres et forêts a fait déposer: 1.le 6 décembre 1974, aux archives du ministère des terres et forêts, à Québec, ces plan et livre de renvoi ; 2.le 10 décembre 1974, au bureau de la division d'enregistrement de Bonaventure No 2, à Carleton, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi ; 3.le 6 décembre 1974, au bureau désigné par lui, à savoir celui du secret' ire-trésorier de la corporation municipale du canton de Maria, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite Loi.HUGUES LAPOINTE Canada Province of Québec [L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, under the provisions of section 2 of Certain Electoral Districts Land Titles Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 321), the Minister of Lands and Forests has caused to be drawn up a revised plan and book of reference in the Electoral District of Bonaventure for the cadastre of a part of the Township of Maria, with regard to lots 44 and 45e to 52 and 53d inclusive, and 78 and 79, in the First Range, East Part, and their respective subdivisions, the whole located in the Second Registration Division of Bonaventure; Whereas, in conformity with sections 2 and 3 of said Act, the Minister of Lands and Forests has caused to be deposited: 1.on December 6,1974 in the Archives of the Department Lands and Forests, in Québec, this plan and book of reference; 2.on December 10, 1974 in the Office of the Second Registration Division of Bonaventure, in Carleton, a certified copy of said plan and book of reference; 3.on December 6, 1974 in the office designated by him, namely that of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the Township of Maria, a certified copy of said plan and book of reference; Whereas it is now expedient to issue the proclamation provided for in section 4 of said Act. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n° 10 2123 À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 420-75, du 29 janvier 1975, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi des titres de propriété dans certains districts électoraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 321), qu'il y a lieu: a) de fixer à la date de la deuxième et dernière publication consécutive de cette preelamation dans la Gazelle officielle du Québec, l'entrée en vigueur des plan et livre de renvoi revisés, dans le district électoral de Bonaventure, pour le cadastre d'une partie du canton de Maria à l'endroit des lots 44 et 45e à 52 et 53d inclusivement, 78 et 79 du premier rang, partie est et de leurs subdivisions respectives, le tout situé dans la division d'enregistrement de Bonaventure No 2; b) d'indiquer que ces plan et livre de renvoi revisés sont déposés aux archives du ministère des terres et forêts, à Québec, et, qu'en outre, le ministre des terres et forêts a fait déposer une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi revisés au bureau de la division d'enregistrement de Bonaventure No 2, à Carleton, ainsi qu'au bureau désigné par lui, à savoir celui du secrétaire-trésorier de la corporation municipale du canton de Maria; c) d'informer le public que, pendant les huit (8) mois qui suivront la deuxième et dernière publication de cette proclamation dans la Gazelle officielle du Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement lesdits plan et livre de renvoi revisés; d) de porter notification qu'à l'expiration de ce délai le ministre des terres et forêts délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l'immeuble avec ou sans titre, même s'il n'est qu'administrateur ou simple exploitant, à moins d'opposition écrite d'un intéressé; e) d'ordonner que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire susdit pour lequel un plan et un livre de renvoi revisés ont été déposés soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil; /) d'informer aussi le public que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 420-75, dated January 29, 1975, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and in conformity with sections 2, 3, 4 and 5 of the Certain Electoral Districts Lands Titles Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 321), that it is expedient: (a) To fix the date of the second and final consecutive publication of this proclamation in the Québec Official Gazelle as the date of the coming into force of the revised plan and book of reference, in the Electoral District of Bonaventure, for the cadastre of a part of the Township of Maria, with regard to lots 44 and 45e to 52 and 53d inclusive and 78 and 79, in the First Range, East Part, and their respective subdivisions, the whole located in the Second Registration Division of Bonaventure; (b) To state that the said revised plan and book of reference have been deposited in the Archives of the Department of Lands and Forests, in Québec, and that moreover, the Minister of Lands and Forests has caused a certified copy of said revised plan and book of reference to be deposited in the Second Registration Division of Bonaventure, in Carleton, as well as in an office designated by him, namely that of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the Township of Maria; (c) To inform the public that during the eight months following upon the second and final publication of this proclamation in the Québec Official Gazelle, any interested party may consult, without charge, the said revised plan and book of reference; (d) To give notice that when such time limit expires, the Ministerof Lands and Forests will issue a certificate of ownership to any occupant of the immoveable, with or without title, even though he be only an administrator or an operator of such immoveable, unless an interested party objects in writing; (e) To order that any real right affecting a lot comprised in the aforesaid territory for which a revised plan and book of reference have been deposited be renewed, within the same period, in the manner prescribed by articles 2172 and 2172a of the Civil Code; (/) Also to inform the public that, failing such renewal, the real rights preserved by the first registration shall have no effect as regards other creditors or subsequent purchasers whose rights are duly registered.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec. 2124 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1976, Vol.107, No.10 Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-neuvième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante-quinze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-troisième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Libro: 502 René Lange vin.Folio: 64 60136-9-2-o Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-ninth dav of January in the year of Our Lord, one thousand nine hundred seventy-five and m the twenty-third year of Our Reign.By command, Libro: 502 Folio: 64 René Langevin, Assistant Deputy Attorney General.60136-9-2 Assurances Insurance LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-JULffiN-DE-WOLFESTOWN, COMTE DE WOLFE Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « LA COMPAGNES D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-JULIEN-DE-WOLFESTOWN, COMTE DE WOLFE » a cessé de faire affaires dans le Québec le 31 décembre 1974; Attendu que le président et le secrétaire-trésorier de ladite compagnie ont produit au Service des assurances, 31 décembre 1974, une déclaration assermentée à l'effet que la compagnie n'a plus d'assurance en vigueur, qu'elle a payé toutes ses dettes et distribué son surplus; En conséquence, avis est par les présentes donné que les permis et certificat d'enregistrement de « LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-JULIEN-DE-WOLFESTOWN, COMTE DE WOLFE » sont annulés à compter du 31 décembre 1974.Donné au bureau du Service des assurances.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 31 décembre 1974.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le surintendant des assurances, 60128-9-2-o Roger-A.Camaraire.LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-JULIEN-DE-WOLFESTOWN, COMTE DE WOLFE Notice of Cancellation of Licence and Certificate of Registration Whereas \"LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-JULDSN DE WOLFESTOWN, COMTE DE WOLFE\" has ceased to do business in Québec as from the 31st of December 1974; Whereas the president and the secretary-treasurer of the said company have filed, on the 31st of December 1974, with the Insurance Branch, a sworn declaration to the effect that the company had no more insurance in force, discharged all its debts and distributed its surplus; Therefore, notice is hereby given that the licence and certificate of registration of \"LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-JULIEN-DE-WOLFESTOWN, COMTE DE WOLFE\" are cancelled as from the 31st of December 1974.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 31st of December 1974.For Ihe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 60128-9-2-o Superintendent of Insurance.BUFFALO INSURANCE COMPANY A vis de changement de raison sociale Avis est donné par les présentes, que « BUFFALO INSURANCE COMPANY », constituée en corporation sous l'empire des lois de l'état de New York, Etats-Unis d'Amérique, et enregistrée au Service des assurances du Québec sous le numéro 542, a changé son nom en celui de \u2022 UNION AMERICA REINSURANCE COMPANY ».Fait à I/3s Angeles, Californie, États-Unis d'Amérique, le 2 janvier 1975.Le secrétaire, 60127-9-2-o John P.Jeffreys.BUFFALO INSURANCE COMPANY Notice of change of name Notice is hereby given that \"BUFFALO INSURANCE COMPANY\", incorporated under the laws of the State of New York, United States of America, and registered with the Québec Insurance Branch under number 542, has changed its name to: \"UNIONAME-RICA REINSURANCE COMPANY\".Dated at Los Angeles, California, United States of America, this 2nd of January 1975.John P.Jeffreys, 60127-9-2-o Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S mars 1975, 107' aimée, »° 10 2125 LONDON & EDINBURGH GENERAL INSURANCE COMPANY OF CANADA .lui* d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que « LONDON & EDINBURGH GENERAL INSURANCE COMPANY OF CANADA .enregistrée sous le numéro 768, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 2268 qui l'autorise à compter du 10 janvier 1975, à effectuer dans la province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Automobile; Aviation; Biens; Grêle; Responsabilité.Le siège social de la compagnie est situé dans la suite numéro 1880 de l'édifice Sun Life, à Montréal.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 10 janvier 1975.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province.Le surintendant des assurances.60238-10-2-o Rogek-A.Camaraire.L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES THE CANADIAN UNION INSURANCE COMPANY Règlement numéro 14-A Le règlement numéro 13-A est abrogé, le nombre des administrateurs de la compagnie est porté de quinze (15) qu'il était auparavant, à douze (12).de telle sorte que l'article 1 de la section III du règlement numéro 1-A se lira dorénavant comme suit: « Le conseil d'administration de la compagnie est composé de 12 administrateurs comprenant les « administrateurs des actionnaires » et les « administrateurs des membres », s'il y a lieu.» Fait à Québec, le 21 mars 1974.Le secrétaire.60239-o Georges-H.Larouche.Assemblée nationale Canada Province de JEAN Tl'RGEON Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A nos très aimés et fidèles conseillers les membres de l'Assemblée nationale du Québec.Salut.Proclamation Attendu que, pour diverses considérations, il est à propos de convoquer la Législature de la province de Québec pour l'expédition des affaires.Xous vous con- LONDON & EDINBURGH GENERAL INSURANCE COMPANY OF CANADA Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"LONDON & EDINBURGH GENERAL INSURANCE COMPANY OF CANADA\", registered under number 76S, has obtained the license and certificate of registry number 2268, authorizing it.as from the 10th of January 1975.to undertake in the Province contracts of insurance in the following classes: Aircraft; Automobile; Hail; Liability; Property.The head office of the company is situated in suite 1880, Sun Life Building.Montreal.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 10th of January 1975.For the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camahaire.60238-10-2-o Superintendent of Insurance.L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES THE CANADIAN UNION INSURANCE COMPANY By-law number 14-A By-law number 13-A is repealed, the number of Directors of the Company is changed from fifteen (15) as heretofore, to twelve (12), so that section 1 of division III of By-law number 1-A wi 11 henceforth read as follows: \"The Board of Directors of the Company is managed by 12 Directors inclusing \"shareholders directors\" and \"members directors\", if necessary.\" Dated at Québec, this 21st of March 1974.Georges-H.Larouche, 60239-o Secretary.National Assembly Canada.Province of JEAN TURGEON Québec.[L.S.J ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the I'nited Kingdom.Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To our Beloved and Faithful Councillors, the members of the National Assembly of Québec, Greeting.Proclamation Whereas, for various considerations, it is expedient to summon the Legislature of the Province of Québec for the dispatch of business, We hereby convene you 2126 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8.1975, Vol.107, No.10 voquons par les présentes pour le dix-huitième jour de mars prochain et.en conséquence, vous mandons et ordonnons de vous assembler à cette date, au palais législatif, en la ville de Québec, pour y expédier les affaires de la province et y examiner, discuter et décider les questions qui vous seront soumises.En foi de quoi.Nous avons fait rendre nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de la province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Juge Jean TurgeoN, administrateur du gouvernement de ladite Province.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec, le sixième jour de mars, l'an de grâce mil neuf cent soixante-quinze et de Notre règne le vingt-quatrième.Par ordre.Le secrétaire de la chancellerie à Québec.60185-10-2-o René Blondin.Concernant les projets de loi privés qui seront présentés pendant la prochaine session.Conformément aux règles de pratique adoptées par l'Assemblée nationale le 21 décembre 1972 et dont un exemplaire peut être obtenu en s'adressant au soussigné : Les projets de loi privés doivent être déposés au secrétariat des commissions avant le jour de l'ouverture de la session.Les documents dont il est fait mention dans le projet doivent être déposés avec celui-ci.Québec, le 6 mars 1975.Le secrétaire des commissions, 60185-10-2-o Jacques Pou mot.Arrêté en conseil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 586-75 Québec, le 12 février 1975.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un changement pour les protestants seulement, aux limites de la municipalité scolaire de Cowansville.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'éducation: Que les limites de la municipalité scolaire de Cowansville soient changées, pour protestants au sens de l'article 49 de la Loi de l'instruction publique, en détachant le territoire comprenant en référence au cadastre officiel des paroisses de Saint-Miohel-de-Rougemont et de Saint-Jean-Baptiste, dans le comté de Rouville et de la paroisse de Saint-Damase.dans le comté de Saint-Hyacinthe: for the heighteenth day of March next and, accordingly, command and order you to meet on such date at the Parliament Buildings, in the city of Québec, for the dispatch of the business of the Province and to examine, discuss and decide the questions to be submitted to you.In testimony whereof.We have caused these Our letters to be made patent and the Great Seal of our Province of Québec to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable Justice Jean Turceon, Administrator of the Government of the said Province.Given at Our Government House, in Québec, on the sixth day of March, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventy-five, in the twenty-fourth year of Our Reign.By command, René Blondin, 60185-10-2-o Clerk of the Crown in Chancery, at Québec.Concerning private bills which shall be introduced during the next session.In accordance with the rules of procedure adopted by the National Assembly on December 21st 1972, a copy of which may be obtained from the undersigned: Private bills shall be filed with the Secretariat of Committees before the day of the opening of the session.The documents mentioned in the bill must be filed with it.Québec, March 6th 1975.Jacques Pouliot, 60185-10-2-o Secretary of Committees.Order in Council Order in Council Executive Council Chamber Number 586-75 Québec, February 12, 1975.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an alteration, for Protestants only, of the boundaries of the School Municipality of Cowansville.It is ordered upon the recommendation of the Minister of Education: That the boundaries of the School Municipality of Cowansville be altered, for Protestants only, within the meaning of section 49 of the Education Act.by detaching therefrom the territory comprising, with reference to the official cadastre for the Parishes of Saint-Miehel-de-Rougeraont and Saint-Jean-Baptisle, in the County of Rouville.and the Parish of Saint-Damase.in the County of Saint-Hyacinthe: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n° 10 2127 1° Les rangs suivants: Pointe de la Montagne; Petit rang Caroline, rangs des Dix terres, vingt de Corbin, dix de Corbin et rang de la Caroline; 2° Les parties de rangs suivants: a) Les lots 478 et 480 à 542 inclusivement du rang Double, côté ouest; 6) Les lots 540 à 597 inclusivement du rang Double, côté est; c) Les lots 481 à 508 inclusivement du rang du Cordon; d) Le lot 292 du rang Corbin; e) Les lots 462 à 474 inclusivement du rang les Soixante, et ce, conformément aux articles 46 et 49 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Le greffier du Conseil exécutif, 60217-o Julien Chouinard.1.The following Ranges: Pointe de la Montagne; Petit rang Caroline, Ranges des Dix terres, vingt de Corbin, dix de Corbin and Range de la Caroline; 2.Parts of the following Ranges: (a) Lots 478 and 480 to 542 inclusive in Double Range, west side; (6) Lots 540 to 597 inclusive in Double Range, east side; (c) Lots 481 to 508 inclusive in Range du Cordon; (d) Lot 292 in Range Corbin; (e) Lots 462 to 474 inclusive in Range les Soixante, the foregoing, in conformity with sections 46 and 49 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.Julien Chouinard, 60217 Clerk of the Executive Council.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PAUL-APOTRE (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que « LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PAUL-APOTRE » a été dissoute le 14 février 1975 et ce, en vertu de la Loi des caisses d'épargne et de crédit et de la Loi de la liquidation des compagnies.Québec, le 21 février 1975.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 60240-o Albert Jessop.CAISSE D'ECONOMIE STE-JUSTINE (Loi des caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a approuvé la requête des caisses d'épargne et de crédit «LA CAISSE D'ECONOMIE COORSH \u2014 COORSH CREDIT UNION » et « LA CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYÉS DE L'HOPITAL STE-JUSTINE », datée du 12 novembre 1974, demandant la confirmation de l'acte d'accord prévoyant la fusion de ces deux caisses.Le nom de la caisse résultant de cette fusion est: « CAISSE D'ÉCONOMIE STE-JUSTINE ».Le siège social de cette caisse est situé à Montréal dans le district électoral de Outremont.Le groupe dans lequel la caisse pourra recruter ses membres sera: les personnes travaillant sur les lieux de l'Hôpital Ste-Justine de Montréal et de ses dépendances, les employés de la compagnie S.Coorsh & Sons Ltd.ainsi que les employés de H.Chenoy & Co.Ltd.Cette caisse sera affiliée à la Fédération des Caisses d'Économie du Québec.Québec, le 21 février 1975.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 60241-o Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PAUL-APOTRE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that \"LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PAUL-APOTRE\" was dissolved on February 14, 1975, pursuant to the Savings and Credit Unions Act and to the Winding-Up Act.Québec, February 21, 1975.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60240 Companies and Cooperatives.CAISSE D'ECONOMIE STE-JUSTINE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the request of \"LA CAISSE D'ÉCONOMIE COORSH-\u2014COORSH CREDIT UNION\" and \"LA CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE L'HOPITAL STE-JUSTINE\", dated November 12, 1974, for confirmation of the deed of agreement providing for the amalgamation of these two Unions.The name of the Union resulting from this amalgamation is: \"CAISSE D'ECONOMIE STE-JUSTINE\".The head ofBce of this Union is located in Montreal, in the Electoral District of Outremonl.The group from among which the Union may recruit its members shall be: the persons working on the premises of Ste-Justine Hospital, in Montreal, and its dependencies, the employees of S.Coorsh & Sons Ltd.and the employees of H.Chenoy & Co.Ltd.This Union will be affiliated to the Fédération des Caisses d'Économie du Québec.Québec, February 21, 1975.Ai.hurt Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60241 Companies and Cooperatives. ¦2 [2s QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Ventes pour taxes Sales for taxes Ville de Châteauguay Town of Châteauguay Avis public est par les présentes donné par le sous- Public notice is hereby given by the undersigned, signé, Claude Hurtubise, c.a., trésorier et assistant- Claude Hurtubise, c.a., Treasurer and Assistant-Clerk greffier de la ville de Châteauguay, comté de Château- of the Town of Châteauguay, County of Châteauguay, guay, que les immeubles ci-dessous désignés seront that the hereinafter described immoveables will be vendus à l'enchère publique au gymnase du départe- sold by public auction at the gymnasium of the police ment de la police, 25, boul.St-Francis, dans ladite ville, department, 25 Saint-Francis Blvd., in the said Town, JEUDI le VINGT-SEPTIÈME jour de MARS 1975, on THURSDAY, the TWENTY-SEVENTH day of à DEUX heures de l'après-midi, pour satisfaire au MARCH, 1975, at TWO o'clock in the afternoon, to paiement des taxes municipales et scolaires ainsi que satisfy the payement of municipal and school taxes des intérêts courus et des frais, à moins que ces taxes, with accrued interest and costs incurrred thereon, intérêts et frais ne soient payés avant la vente: unless said taxes, interest and costs be paid before the sale: Noms des propriétaires Numéros de cadastre Names of property owners Cadastral numbers Riverdrive Gardens Inc.254 P.659 Palese Inv.Ltd.254 660.Palese Inv.Ltd.254 666 667.Palese Inv Ltd.254 663 664 665.Normand Raymond.253 315 /264 651 Riverdrive Housing & Land Corp.264 P.130 Riverdrive Gardens Inc.253 P 305 Henri Renaud.253 92____.Jean-Pierre Viau.257 140 Jean Bergevin.257 P.181 P.'182 Total Louis-Philippe Brosseau.279 146.?189.33 Léon-G.Lemire.279 P.150.1,632.99 Norman-A.Hubbard.279 9.218.78 Norman-A.Hubbard.279 9 .691.12 J.-L.Tustin & J.-M.Côté.279 40.628.81 J.-L.Tustin & J.-M.Côté.279 41.112.64 Riverdrive Realty Inc.279 116 .402.08 Raoul Villeneuve.P.279 .289.39 Normand Desbiens.P.282 282-1 282-P.1.2,077!84 Normand Desbiens.P.281.710.29 Normand Desbiens.P.281.463.87 Normand Desbiens.P.281.644 32 René Chapleau.290 P.3 .328 99 René Chapleau.P.293.1,088 '.28 René Chapleau.P.293.281 43 J.-L.Tustin & J.-M.Côté.279 75 76 .478 15 J.-L.Tustin & J.-M.Côté.278 P.60 P.61.91069 Josaphat Demers.278 P.23 68 69 70 .607.94 Gilbert Meunier.278 455 .432 91 Roger Simard.278 438.1,058!95 Roger Benoit.274 P.6-1 5-2 P.10-7 10-8 P.15-3 15-4 16-2.613.02 Inconnu-Unknown.274 P.18./.164 19 Y von Gauthier.274 33 35.2,508 34 Guy Normandeau.263 298-1 298-2.1 423 66 Palese Inv.Ltd.254 635-5-2/ 254 635-6-1/ _ 254 635-7-1.1 134 14 Pierre Hutchison.254 635-2.fioo 7n Paul Hébert et al.257 P.77 P.78.no 94 Mrs.Lillian Mallette.257 112.184.36 Mrs.Lillian Mallette.257 111.220 14 Armand Duhamel.257 114.Marcel Ledoux.257 161.1,065.50 505.86 Marcel Ledoux.257 152.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.['.'.[['.'.'.'.'.'.'.'.605^86 Marcel Ledoux.257 153.505;!!; Marcel Ledoux.257 154.W> ' Rfi Palese Inv.Ltd.P.267 Riverdrive Gardens Inc.253 318.Riverdrive Gardens Inc.253 317 Palese Inv.Ltd.253 316 269.43 386.15 386.16 laicoe niv.uia.203 316.336 64 Laurent Serres.254 658 P.659.!.625 ! 80 228.97 442.90 297.36 985.47 1,291.08 169.31 238.95 441.93 263.08 268.02 gazette officielle du québec, 8 mars 1975, 107' année, n° 10 2129 Noms des propriétaires Numéros de cadastre Total Names of property owners Cadastral numbers Valerie Construction Enrg.Les Projets Bellevue Ltée- Andon Realties Inc.Palese Inv.Ltd.Jose Meneses.Jose Meneses.Jose Meneses.Jose Meneses.Riverdrive Gardens Inc.Gérard Daoust.Carmine Principe.Riverdrive Gardens Inc.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Riverdrive Gardens Inc.Riverdrive Gardens Inc.Andon Realties Inc.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Mme Claude Vallée.Mme Claude Vallée.Paul Théoret.Claude Boucher.Valérie Construction Enrg.Mme Georges Gouger.Zoltan Kasko.Zoltan Kasko.Mrs.Grace Lafleur.Andon Realties Inc.Riverdrive Gardens Inc.Andon Realties Inc.Riverdrive Gardens Inc.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Andon Realties Inc.Mme Georges Gouger.Mme Georges Gouger.Mme M.Beniusis.Mme M.Beniusis.L.-Philippe Poirier.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Riverdrive Gardens Inc.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Riverdrive Gardens Inc.Palese Inv.Ltd.F.A.Maria.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Andon Realties Inc.Andon Realties Inc.Andon Realties Inc.Andon Realties Inc.Andon Realties Inc.Andon Realties Inc.254 648.254 368.254 411.264 412.254 413.254 414.254 415.254 416.263 182.254 141.254 545.254 P.527.254 520.254 518 / 257 234 254 516.254 515.254 514.264 513.254 509.254 508.254 507.254 506.254 505.254 504.254 503.254 502.254 501.254 492.254 491.254 490.254 489.254 58.254 P.57.254 52.253 29.253 36.254 640.254 642.254 643.257 46 47.253 82.253 P.83.253 81.253 P.80.254 635-31.254 635-30.254 635-29.254 635-28.254 635-27.254 635-26.254 427-.254 426.254 405.254 404.254 403.254 306.254 305.254 302 P.303.254 181.264 187.254 P.188.254 190.254 191.253 154.254 206.254 211.254 210.254 209.263 161.253 162.253 163.263 164.253 165.263 166.2,510.96 118.90 150.22 150.22 74.96 74.96 74.96 74.96 158.96 1,917.27 126.64 77.88 150.22 161.02 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 160.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 1,064.46 616.48 524.88 299.35 490.63 612.40 1.136.16 1,384.20 1,375.57 182.78 77.88 182.71 101.41 158.96 80.23 80.26 80.26 168.96 158.96 158.96 168.96 158.96 135.94 118.35 132.81 92.20 219.40 158.96 158.96 77.88 168.96 158.96 182.78 136.89 196.29 147.64 147.64 158.96 158.96 158.96 168.96 168.96 168.96 2130 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Noms des propriétaires Names of property owners Numéros de cadastre Cadastral numbers Andon Realties Inc.Riverdrive Gardens Inc.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Andon Realties Inc.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Pnlcso Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Robert Decoste.Robert Decoste.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.253 167.253 181.253 272.253 273.253 274.253 275.253 276.253 277.253 278.253 279.253 280.253 281.253 282.253 270.253 269.253 268.253 267.253 266 / 254 467.254 468.254 469.254 470.254 471.254 472.254 473.254 474.254 475.254 476.254 477.254 478.254 479.254 480.254 481.254 482.254 483.253 260.253 261.253 262.,____ 253 263.253 264.253 265 /254 463.254 464.254 465.254 457.254 448.254 447.253 248.253 249.263 250.253 251.253 252.253 253 /254 453.254 454.254 455.254 456.253 259.253 258.263 257.253 256.253 255.253 254 / 254 462.254 461.264 460.253 237.253 238.253 239.253 240.253 241 /264 446.254 444.264 443.254 442.254 441.254 440.253 246.Total I 158.96 158.96 171.81 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 171.81 171.81 171.81 171.81 171.81 182.31 203.96 203.96 160.76 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 160.22 150.22 ISO.22 150.22 160.74 127.58 107.92 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 160.22 138.67 171.80 226.27 182.78 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 160.22 150.22 150.22 150.22 150.22 150.22 160.22 150.22 160.22 150.22 160.22 150.22 150.22 150.22 150.22 160.22 160.22 236.72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n\" 10 2131 Noms des propriétaires Names of property owners Numéros do cadastre Cadastral numbers Total Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.F .A.Maria.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Pidese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Paleae Inv.Ltd.A.C.Doa Santos.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Pal-se Inv.Ltd.J.Rodrigues 4 A.Ferreira Bokor Holding (Ont.) Ltd.Bokor Holding (Ont.) Ltd.Bokor Holding (Ont.) Ltd Bokor Holding (Ont.) Ltd Bokor Holding (Ont.) Ltd Palese Inv.Ltd.Riverdrive Gardens Inc.J.Rodrigues 4 A.Ferreira.J.Rodrigues 4 A.Ferreira.J.Rodrigues 4 A.Ferreira Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Sylvio Varin.Sylvio Varin.René Cornen.Riverdrive Gardens Inc.Palese Inv.Ltd.Riverdrive Gardens Inc.Riverdrive Gardens Inc.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.J.-Marcel Cadorette.Palese Inv.Ltd.Andon Realties Inc.Riverdrive Gardens Inc- Palese Inv.Ltd.Mme Georges Gouger.Mme Georges Gouger.253 253 253 253 254 251 2 54 254 254 2.54 2.54 254 254 254 254 254 254 2.54 254 2.54 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 251 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 245.244.243.242 / 254 452.451.450.449.212.243.242.241.240.239.238.237.236.232.231.230.229.228.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.295.286.285.284.283.282.274.P.271.309.310.311.397.396.395.394.393.392.554.P.553.P.553.552.550.549.578.569 / 257 229.522 / 257 232.686.153.683.693.694.676 P.120.679.678.147.146.P.165.164.I 150.22 150.22 160.22 150.22 150.22 150.22 150.22 249.74 170.58 169.09 193.78 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 168.96 147.64 147.64 190.38 218.24 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 158.96 369.03 185.08 185.08 185.08 185.08 158.96 143 65 89.25 218.60 147.28 158.96 150.38 150.38 150.38 150.38 150.38 150.38 159.21 77.90 78.13 159.01 96.01 95.61 91.81 215.73 281.22 233.70 233.70 161.30 150.22 160.22 207.45 94.12 95.90 216.61 177.40 327.67 164.00 2132 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8.1975, Vol.107, No.10 Noms des propriétaire» Names of property owners Numéros de cadastre Cadastral numbers Total Palese Inv.Ltd.Carmine Principe.Riverdrive Gardens Inc.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Bokor Holding (Ont.) Ltd.Emilio Ciciola.Emilio Ciciola.Sylbio Varin.Sylvio Varin.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.J.Meneses.J.Meneses.1.Meneses.Palese Inv.Ltd.J.Meneses.Wilfred Breau.Robert Jack.Mme Jacqueline Proteau.Favreau, Hébert A al.Notaire McGowan.Daniel Fettu.Bruno Favreau 4 Leopold Hébert.Bruno Favreau 4 Leopold Hébert.Bruno Favreau 4 Leopold Hébert.Roland Bourque.Guy Goulet.Henri Rochefort.Fernand Leclerc.F.-X.I.at our.Mme L.-M.Siroia-Grimard.Angelo Gicas.*.Jean-Guy Benoit.Zéphirin Bouchard.Robert 4 Mary Jack.Robert 4 Mary Jack.Gilles Gendron.Braja Kinshore Swain 4 at.Braja Kinshore Swain 4 ai.La Curatelle Publique.C.-A.Michaud.C.-A.Michaud.Miss Audrey L.Fitzpatrick.Kurt Heinzinger.Kurt Heinz in ger.Kurt Heinzinger.Kurt Heinzinger.Kurt Heinzinger.Kevin Duffey.Arthur Richard Keech.Deckelbaum Const.Corp.4 Hy Deckelbaum.Gilles Desgroseilliers.Jean Rock.Dame Marie-Reine Briére Meloche.Dame Marie-Reine Briére Meloche.Duong Nhu Hoa.Duong Nhu Hoa.L.Pasquariello.L.Pasquariello.Beauchamp 4 Chevrefils Inc.Eduardo Reposo.Eduardo Reposo.Beauchamp 4 Chevrefils Inc.Mlle Marguerite Moran.Deckelbaum Construction Corp.4 Hy Deckelbaum Ltd.Deckelbaum Construction Corp.4 Hy Deckelbaum Ltd.Mrs.Ian Garden.Eugène Beauchamp.Marcel Goupil.Edward Zelinski.Victor Wodon.Hercules Dev.Corp.254 162.254 116.253 P.138.254 608.254 607.254 606.254 593.254 592.257 218.257 217.254 610 / 257 92.254 611.254 621.254 622.254 623.254 628 / 257 104.254 624.6 P.179 P.180 P.181 P.3 / P.13/P.14/P.15 P.3.1 P.513.1 513-20 513-21 513-24 .1 513-22 513-23.1 P.513.P.513.P.513.P.513.513-16 513-50.25A-1 34-1 P.34 P.513 P.503 P.504.422-7 422-8 495.14 36 / 15 22.15 24.5 189 190 P.191.3 120 121.P.15.P.13 / P.14 / P.15.20 P.371-4.49 456.49 466.50 310 311-2.49 445 / 50 282.49 436.62 214.49 387.49 394.49 395.49 402.49 403.49 90.55 39.P.55.66 408 / 57 676.P.55.67 P.462 P.463.67 P.462 P.463.56 391 413.55 392.56 509.55 510.P.57.P.56 P.P.56 P.P.57 .50 361.55 412 / 53 377 / 52 348 / P.62 .P.52.50 346.67 185.57 P.210 211.44 101 102 103 104.20 97 98.44 435.67.67.226.44 124.98 66.38 62.50 160.22 190.63 54.90 88.46 148.18 97.36 158.54 158.54 110.71 94.68 105.55 201.26 90.28 953.16 1,310.86 311.83 2.128.78 1.901.50 383.68 1,099.17 902.79 1,151.20 778.10 298.12 190.36 576.16 1,071.31 81.94 471.30 757.23 2.198.35 1,613.88 593.17 1,173.27 273.30 273.30 1,008.13 1.894.84 2,428.68 991.40 801.19 1,266.83 731.74 1,108.22 1,119.64 1,358.77 496.71 1,705.94 387.12 1,032.45 946.68 948.87 961.27 1,979.26 568.60 943.18 2,530.29 222.78 222.78 2,436.16 1,130.26 6,688.01 1,697.62 1.590.64 1,808.59 716.78 1.161.94 941.26 485.06 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n° 10 2133 Noms des propriétaires Numéros de cadastre Total Names of property owners Cadastral numbers Miss D.Jeanney.17 H.F.Gropler.44 James Sharkey.44 Carlyle Gilmour.43 G.-E.Lagarde.17 G.-E.Lagarde.17 J.S.Scott.17 B.A.Smith.17 Carlyle Gilmour.43 Carlyle Gilmour.20 Mrs.' Annie Boulter.47 Paul Bouchard.47 Antoine Lancelot.47 Antoine Lancelot.47 J.-Herbert Oliver.44 Harry Beauvais.17 Harry Beauvais.17 Harry Beauvais.17 E.R.Richardson.17 Daniel Minogue.17 W.G.Hull.17 Blueridge Inv.Inc.P.Adélard Laberge.47 Miss D.Jeanney.17 Nicola Piazza.P.Nicola Piazza.P.Nicola Piazza.P.Nicola Piazza.P.Nicola Piazza.P.Nicola Piazza.P.Nicola Piazza.P.88A 89A.t 611.28 96 97.185.49 386 387 388.1,845.54 63A 64A 65A.1,987.75 254 255 256 257 258 269.1,991.44 299.158.08 408.315.10 409 410 .964.22 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 .3,283.90 123 124 125 126 127 .2.420.84 P.8.542.89 50 P.61.1.121 68 98 .783.30 99.783.30 213 214.815.25 304 305 306 .301.10 301 302 303 .354.24 453 454 455 456 457 458 .638.05 473 474 475 476.577.82 291 292 293 294.1,062.65 285 286 287 288.1,533.02 44.1,056 80 P.6.404.65 99A 100 A 101A 102A.1,231.70 44 .833.36 44.1,166.56 44.1,040.90 43/P.44.845.24 43.1,040.90 43.1,166.65 43.833.00 Prenez avis que la liste ci-haut contient une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles à être vendus, conformément à une autorisation à cet effet émise par la Commission municipale de Québec en date du 20 novembre 1974.Prenez avis, de plus, que dans le cas où les immeubles ci-haut mentionnés contiennent des bâtisses ou dépendances dessus construites, la vente de ces immeubles pour taxes aura lieu avec l'ensemble des bâtisses et dépendances dessus construites.Donné à Châteauguay, ce 20e jour de février 1975.Le trésorier el assistant-greffier, 60142-9-2-o Claude Hurtubise, c.a.Notice is also given that the hereinabove statement countains an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables to be sold, according to an authorization to that effect given by the Québec Municipal Commission dated November 20th, 1974.Notice is also given that in the case the immoveables hereinabove mentioned have buildings thereon erected, the sale of these immoveables for non-payment of taxes shall include the buildings thereon erected.Given at Châteauguay, this 20th day of February, 1975.Claude Hurtubise, c.a., 60142-9-2-o Treasurer and assistant-clerk.Ville de Boucherville Avis public est par la présente donné que le conseil municipal de la ville de Boucherville, par une résolution en date du 18 février 1975, a ordonné au soussigné, conformément à la Loi des cités et villes, de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes municipales, générales ou spéciales, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle du conseil de l'Hôtel de ville de Boucherville, 500, rue Rivière-Aux-Pins, le HUITIÈME jour du mois d'AVRIL 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Toutefois, seront exclus de la vente, les immeubles sur lesquels lesdites taxes pour l'année 1974 et des années antérieures, intérêts et frais, auront été payés avant le moment de la vente.Town of Boucherville Public notice is hereby given that the Town Council of the Town of Boucherville, by a resolution dated February 18th, 1975, has ordered the undersigned, pursuant to the Cities and Towns Act, to sell the immoveable properties hereinafter described for non-payment of municipal, general or special taxes, with interest and costs, and that consequently the said immoveable properties shall be sold by public auction in the Council Room of the Town Hall of Boucherville, 500 Rivière-Aux-Pins Street, on the EIGHTH day of APRIL, 1975, at TEN o'clock, in the forenoon.However, there shall be excluded from the sale, those immoveable properties on which the said taxes for the year 1974, and previous years, interest and costs have been paid prior to the sale. 2134 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujet au droit de retrait d'un an.Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y a lieu, sujet à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les affecter.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement, en monnaie légale ou par chèque visé.The immoveable properties hereinafter described will be sold subject to the one year right or redemption.They shall be sold with buildings erected thereon, circumstances and dependencies if any, subject to all any servitudes both active and passive, apparent or unapparcnt which may affect them.The purchase price of said immoveable shall be payable immediately, in legal currency or by certified cheque.Cadastre de la paroisse Ste-Famille-de-Boucherville \u2014 Cadaster of the Parish Sainte-Famille of Boucherville Rôle Nom du propriétaire Description de l'immeuble Roll Name of the proprietor Description of immoveable 1-51-1085 Gosselin, Gilles.1-51-1036 Vernon Homes Inc.Une partie du lot P-12 bornée comme suit: au nord-est par une partie du lot No 11 ; au sud-est par le chemin de fer du Canadien National; au sud-ouest par une partie du lot No 13, et au nord-ouest par la rue de Kingston, le tout représentant une superficie approximative de 17.621 arpents carrés.1-51-998 Lemay, Viateur.Une partie du lot P-14 bornée comme suit: au nord-est, par une partie du lot No 14-1 ; au sud-est par une partie du lot No 14-26; au sud-ouest, par une partie du lot No.14-65 et au nord-ouest, par le boulevard Marie-Victorin.le tout représentant une superficie approximative de 168,154 pieds carrés.11-3 .P-12 A part of lot P-12 bounded as follows: at northeast by a part of lot No.11; at southeast by Canadian National Railway; at southwest by a part of lot No.13 and at northwest by the Kingston Street, representing approximately 17.521 square arpents.P-14 A part of lot P-14 bounded as follows: at northeast, by a part of lot No.14-1; at southeast, by a part of lot No.14-26; at southwest, by a part of lot No.14-65 and at northwest, by Marie-Victorin Boulevard, representing approximately 158,154 square feet.1-51-1002 Parent, Jean-Paul.1-57-1033 Johnson, Robert.1-51-976 Ouellet, Gilles.1-12-19 Morin, Claude.1-55-967 Pauld, Roger.1-52-79 Directeur des Terres destinées aux anciens combattants 1-27-934 Compagnie de Construction Colas.1-27-938 Compagnie de Construction Colas.1-27-942 Compagnie de Construction Colas.1-20-85 Johnston, Robert.Une partie du lot P-18-143 bornée comme suit: au nord-est par la rue de Mézy; au sud-est par une partie du lot P-18-144; au sud-ouest par le lot 18-91 et au nord-ouest par une partie du lot 18-142, le tout représentant une superficie approximative de 2,655 pieds carrés.Une partie du lot P-18-144 bornée comme suit: au nord-est par la rue de Mézy; au sud-est par une partie du lot 18-144-1 ; au sud-ouest par une partie du lot 18-90 et du lot 18-91 et au nord-ouest par une partie du lot P-18-143, le tout représentant une superficie approximative de 3,600 pieds carrés.14-1 .14-32 .17-44, 17-415 .17-81 .17-97, 17-98-1 .17-171 .17-380, 17-381 .17-382, 17-383 .17-384, 17-385 .P-18-143, P-18-144 A part of lot P-18-143 bounded as follows: at northeast by de Mézy Street; at southeast by a part of lot P-18-144; at southwest by the lot 18-91 and at northwest by a part of lot 18-142, representing approximately 2,656 square feet.A part of lot P-18-144 bounded as follows: at northeast by de Mézy Street; at southeast by a part of lot 18-144-1 ; at southwest by a part of lot 18-90 and of lot 18-91 and at northwest by a part of lot P-18-143, representing approximately 3,600 square feet.1-34-885 Cotran, Camille.1-43-879 Boisvert, Serge.1-34-879 Bauerle, Holger.1-16-849 Labarre, André.1-15-880 Belmont, Roger-Pierre.1-63-848 Reiter, Michelle, épouse de Pierre Lamoureux.1-17-796 Les immeubles Boucherville Inc.1-67-815 Jourdain, Viateur.1-28-15 Desjardins, Rollande Mme.1-63-793 Lahaye, Bernard.Une partie du lot P-22-66 bornée comme suit: au nord-est par une partie du lot 22-65; au sud-est par la rue Pierre-Viger; au sud-ouest par une partie du lot P-22-67 et au nord-ouest, par une partie du lot 22-60.Une partie du lot P-22-67 bornée comme suit: au nord-est par le lot P-22-66; au sud-est par la rue Pierre-Viger; au sud-ouest par le lot 22-67-1 et au nord-oueBt par le lot 22-60, les deux parties représentant une superficie approximative de 7,600 pieds carrés.18-297, 19-224 .18-299, 19-225 .18-301 .19-81 .19-170 .20-100, 21-39 .21-213 .21-262 .22-33 .P-22-66, P-22-67 A part of lot P-22-66 bounded as follows: at northeast by a part of lot 22-65; at southeast by Pierre-Viger Street; at southwest by a part of lot P-22-67 and at northwest, by a part of lot 22-60.A part of lot P-22-67 bounded ae follows: at northeast by the lot P-22-66; at southeast by Pierre-Viger Street ; at southwest by the lot 22-67-1 and at northwest by the lot 22-60, the two parts representing approximately 7,600 square feet. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n\" 10 2135 Rôle Roll Nom du propriétaire Name of the proprietor Description de l'immeuble Description of immoveable 1-28-71 Beaupré, Lise Tremblay.22-91 1-27-770 Senécal, Claudette.22-258 1-27-768 Senécal, Claudette.22-259 1-51-782 Pauld, Roger.22-322 2-32-160 Lamarre, Gisèle Mme P-23-100, 24-12,24-13 Une partie du lot P-23-100 bornée comme suit: au nord, par A part of lot P-23-100 hounded as follows: at north by de le chemin de Montbrun; à l'est, par une partie du lot 23-196: au Mont brun Road; at east, by a part of lot 23-196, at south by sud, par une partie du lot 24-13 et à l'ouest, par une partie du a part of lot 24-13 and at west, by a part of lot No.24, repre-lot No 24, le tout représentant une superficie approximative de senting approximately 2,531 square feet.2,531 pieds carrés.2-32-130 Charest, Lucien Mme et Prud'Homme Jean, Claude.Guy, André, Lise, P-25-1 Pierre.Une partie du lot No P-25-1 bornée comme suit: au nord-est A part of lot No.P-25-1 bounded as follows: at northeast by par une partie du lot No 24-1; au sud-est par une partie du a part of lot No.24-1; at southeast by a part of lot 25-2; at lot 25-2; au sud-ouest par la rue Charles-Aubertin et au nord- southwest by Charles-Aubertin Street and at northwest by ouest par le chemin de Montbrun, le tout représentant une de Montbrun Road, representing approximately 1,143 square superficie approximative de 1,143 pieds carrés.feet.2-12-160 Lambert, Guy.25-29,26-62 2-11-705 La Construction Boucherville Ltée.P-28 Une partie du lot P-28 bornée comme suit: au nord-est par A part of lot P-28 bounded as follows: at northeast by a part une partie du lot 28-165: au sud-est par la rue Abbés-Primeau; of lot 28-165: at southeast by Abbés-Primeau Street; at south-au sud-ouest par une partie du lot No 2S et au nord-ouest par west bv a part of lot No.28 and at northwest by another part une autre partie du lot No 28, le tout représentant approxima- of lot No.28.representing approximately 2,500 square feet, tivement 2.500 pieds carrés.2-51-694 Tardif, Maurice.28-58.28-59 2-31-699 Morin, Armand.28-140 2-38-22 Boisclair, Jean-Paul.29-11 2-18-126 Venne, Maurice.30-92,30-93 2-63-596 Cyr, Real.31-183 2-47-597 Blanchet, Claude.31-212 2-47-585 Legault, Richard.31-216,32-270 2-69-540 Fabrique Chapelty Holy Cross.P-32 Une partie du lot P-32 bornée comme suit: au nord-est par A part of lot P-32 bounded as follows: at northeast by une autre partie dudit lot No 32; au sud-est et au sud-ouest another part of said lot No.32: at southeast and at southwest par d'autres parties dudit lot No 32 et au nord-ouest par une by other parts of 6aid lot No.32 and at northwest by a part of partie du lot No 32-55 (rue Rivière-Aux-Pins*, le tout repré- lot No.32-55 (Rivière-Aux-Pins Street), representing approx-sentant une superficie approximative de 57,673 pieds carrés.imately 57,673 square feet.2-19-478 Boucher, Viateur.32-24 2-82-829 Boucher, Justin.32-191 2-69-538 Fabrique Chapelty Holy Cross.P-33 Une pirtie du lot P-33 bornée comme suit: au nord-est par A part of lot P-33 bounded as follows: at northeast by a part une p; rtie du lot No 32; au sud-est par une autre partie du lot of lot No.32; at southeast by another part of lot No.32.at No 32; au sud-ouest par une autre paitie du loi No 32 et southwest by another rart of lot No.32 and at northwest by au nord-ouest par une autre partie dudit lot No 33 (me pro- another part of said lot No.33 (projected street), representing jetée), le tout représentant une superficie approximative de approximately 11,296 square feet.11,296 pieds carrés.3-27-450 Les Entreprises Victor Inc.P-35 Une partie du lot P-35 bornée comme suit: au nord-est parle A part of lot P-35 bounded as follows: at northeast by boulevard Montarville: au sud-est par la voie d'accès de la Montarville Boulevard; at southeast by Highway number 3; route 3: au sud-ouest parles lots 36-108.36-113.36-66, 36-82.at southwest by the lots 36-108, 36-113, 36-66, 36-82, 36-84, 36-84 et P-36-99 et au nord-ouest par le lot 35-75, représentant and P-36-99 and at northwest by the lot 35-75.representing une superficie approximative de 6.12 arpents carrés.approximately 6.12 square arpents.3-51-439 Déguise, Georges Mme.35-8, 35-9 3-55-454 Les Entreprises Victor Inc.35-27-2 3-55-453 Les Entreprises Victor Inc.P-35-32 Une partie du lot P-35-32 bornée comme suit: au nord-est, A part of lot P-35-32 bounded as follows: at northeast, by par le boulevard Montarville; au sud-est par le lot 35-32-2; Montarville Boulevard; at southeast by the lot 35-32-2; at au sud-ouest par la rue Darontal et au nord-ouest par le lot southwest by Darontal Street and at northwest by the lot 35-32-1, représentant une superficie approximative de 60,957 35-32-1, representing approximately 60,957 square feet, pieds carrés.3-54-850 Lea Entreprises Victor Inc.35-33.35-34, 35-35 3-55-475 Gagnon, Germain-Pierre.35-39 3-55-469 Page, Jean-Paul.35-42 3-55-461 Les Entreprises Victor Inc.35-45 2130 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March S, 1975, Vol.107, No.10 Rôle Roll Nom du propriétaire Name of the proprietor Description de l'immeuble Description of immoveable 3-54-844 Bibeau, Jean-Guy.35-50,333-6 3-21-437 Les Entreprises Victor Inc.35-64, 70-4 3-22-67 Francoeur, Léa Dame.36-57 3-69-396 Fabrique Chapelty Holy Cross.36-90 3-75-409 Trans Québec Realties Ltd.36-114 3-75-407 Trans Québec Realties Ltd.36-115 3-75-405 Trans Québec Realties Ltd.36-116 3-75-387 Braun, Guy.36-122, 37-37 3-44-784 Dansereau, Dollard.36-147 3-75-398 Dansereau, Dollard.36-149 3-44-786 Dansereau, Dollard.36-160 3-21-426 Bervl Construction Inc.36-193-3,36-194-1.3-21-424 Beryl Construction Inc.36-194-2 3-27-350 Dobois Realties Inc.P-38 Une partie du lot 38 bornée comme suit: au nord-est par les A part of lot 38 bounded as follows: at northeast by the lots lots 37-25 à 37-29-1 inclusivement et par une partie du lot 37-25 at 37-29-1 inclusively and by a part of lot P-37; at south-P-37 ; au sud-est par la Route No 3; au sud-ouest par une partie east by Highway number 3; at southwest by a part of lot No.du lot No 311 et au nord-ouest parle boulevard Fort-St-Louis.311 and at northwest by Fort-St-Louis Boulevard, representing représentant une superficie approximative de 6.2 arpents carrés.approximately 6.2 square arpents.3-46-796 Dobois Realties Inc.38-28 3-46-800 Dobois Realties Inc.38-29 3-46-804 Dobois Realties Inc.38-30 3-46-806 Dobois Realties Inc.38-31 3-46-810 Dobois Realties Inc.38-32 3-92-109 Dobois Realties Inc.38-33 3-92-113 Dobois Realties Inc.38-34 3-92-115 Dobois Realties Inc.38-35 3-90-814 Thibault Flavius Nelson.38-40 3-90-816 Desbiens, Alain.38-41 3_90_852 Le Sablier Inc.38-54-2.38-55 3-90-771 Jardins St-Lambert Inc.38-74 3-90-773 Jardins St>Lambert Inc.38-75 3-90-777 Jardins St-Lambert Inc.38-76 3-90-779 Jardins St-Lambert Inc.38-77 3-78-107 Houde, Fleurette Hébert.P-39-107, P-39-108 Une partie du lot P-39-107 bornée comme suit: au nord-est A part of lot P-39-107 bounded as follows: at northeast by par les lots P-39-105 et 39-104; au sud-est par le lot 39-132; the lots P-39-105 and 39-104; at southeast by the lot 39-132; sud-ouest par la rue Mgr-Taché et au nord-ouest par le at southwest bv Mgr-Taché Street and at northwest by the lot P-39-108.lot P-39-108.L'ne partie du lot P-39-108 bornée comme suit: au nord-est A part of lot P-39-108 bounded as follows: at northeast by par les lots 39-104 et 39-103; au sud-est par le lot P-39-107; au the lots 39-104 and 39-103; at southeast by the lot P-39-107; sud-ouest par la rue Mgr-Taché et au nord-ouest par le lot at southwest by Mgr-Taché Street and at northwest by the 39-109.les deux parties représentant une superficie approxima- lot 39-109, the two parts representing approximately 8,181 tivede8.181 pieds carrés.square feet.3-34-191 Cattoor, Robert.39-184 3-34-188 Dufour, Roger.39-242 3-18-6 Martineau, Gérard.P-41-12-2,41-16 Une partie du lot P-41-12-2 bornée comme suit: au nord-est A part of lot P-41-12-2 bounded as follows: at northeast by par le lot 41-12-1 ; au sud-est par le lot No 41-11-2; au sud-ouest the lot 41-12-1; at southeast by the lot No.41-11-2; at south-par le lot 41-17 et le lot 41-16 et au nord-ouest par une partie west by the lot 41-17 and the lot 41-16 and at northwest by a des lots 41-13-4 et 41-13-1, représentant une superficie approxi- part of lots 41-13-4 and 41-13-1, representing approximately mative de 7,150 pieds carrés.7,150 square ffeet.3-39-224 Miloslav, Slezak Mme.43-158 3-25-230 Dubé, Marcel.43-223, 60-66 3-51-124 Ouimet, Jacques.P-46-27 Une partie du lot P-46-27 bornée comme suit: au nord-est par A part of lot P-46-27 bounded as follows: at northeast by the le lot 46-67; au sud-est par le lot P-46-34; au sud-ouest lot 46-67; at southeast by the lot P-46-34; at southwest by par la rue Frechette et au nord-ouest par le boulevard Marie- Frechette Street and at northwest by Marie-Victorin Bou-Victorin, le tout représentant une superficie approximative de levard, representing approximately 15,754 square feet.15,754 pieds carrés.3-26-43 I.aporte, Pierre.46-57 3-51-126 Lavergne, Armand R.46-67 3-115-110 Agri-Tech Inc.48-8 3-134-1035 Laperrifre.Ronald.67-34 3-81-224 Pariseault, Pierre.58-155,58-156,61-118,61-119 3-81-332 Carignan.Armand.66-33-1-3.65-34-1-1 3-40-1020 Dupuis, Alain-Roch.65-70 3-40-1016 Danis, Marcel.66-71. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1975, 107' année, n° 10 2137 Rôle Roll Nom du propriétaire Name of the proprietor Description de l'immeuble Description of immoveable 3-38-362 Léger, Jean-Bertin.65-111 3-38-356 Les Habitations des Vieux Moulins Inc.66-113-1,65-114-4 66-168-2 3-84-233 Senécal.Honoré.66-37.3-81-342 Les Entreprises Sogecor Inc.66-77-1 3-81-344 Les Entreprises Sogecor Inc.66-78-1 3-110-342 Les Entreprises Sogecor Inc.66-159,67-152 3-110-367 Les Habitations des Vieux Moulins Inc.66-203.67-191 3-110-363 Les Entreprises Sogecor Inc.66-205,67-182 3-110-337 Sogecor Inc.66-213,67-172 3-84-221 Seigneurie Builders Inc.67-13 3-16-204 Knowles, Ezra.67-32, 3-81-369 Biais, Maurice.67-88-1 3-38-329 Lajeunesse, André.67-105 3-61-188 Champagne.Germain.67-131 3-110-330 Les Habitations des Vieux Moulins Inc.67-148 3-110-335 Sogecor Inc.67-155 3-155-355 Les Entreprises Sogecor Inc.67-163 3-155-361 Les Entreprises Sogecor Inc.67-165 3-70-392 Mancheron.Jacques.68-28 3-70-292 Tremblay.Jeanne.68-98-2,68-97-1,69-137, 69-136-1 3-70-381 Edmond, Michel.68-166,68-167 3-68-335 Barrette, Gérard.68-226,68-227,71-98,71-99 3-20-208 Rivard Vandal, Louiselle.69-33 3-70-258 Sogecor Inc.69-132-3,69-150 3-68-336 Cossette, Guy-Paul et Michaud.Mme Pierre.71-74, 71-75 2-71-665 Parent, Jean-Paul.P-77-6 Une partie du lot P-77-6 bornée comme suit : au nord-est par A part of lot P-77-6 bounded as follows: at northeast by the le lot 77-5; au sud-est par le chemin du lac; au sud-ouest par lot 77-5; at southeast by \"chemin du lac\"; at southwest by the les lots Nos 77-7-2 et 77-7-1 et au nord-ouest par le lot lots Nos.77-7-2 and 77-7-1 and at northwest by the lot No.No 26-69, représentant une superficie approximative de 14,593 26-69, representing approximately 14.593 square feet, pieds carrés.1-83-1118 Papadopoulos, Elie.88-83 1-68-755 Papadopoulos, Elie.88-145 1-71-1450 Blagden, Bernice Elizabeth Mme.P-102 Une partie du lot P-102 bornée comme suit: au nord par le A part of lot P-102 bounded as follows: at north by Général-chemin Général-Vanier; au nord-est par une partie du lot Vanier Road; at northeast by a part of lot No.102; at south-No 102; au sud-est par une autre partie du lot No 102 et au east by another part of lot No.102 and at southwest by sud-ouest par une autre partie du lot No 102, le tout représen- another part of lot No.102, representing approximately tant une superficie approximative de 53,400 pieds carrés.53.400 square feet.2-81-671 Montico Limited.P-119 Une partie du lot P-119 bornée comme suit: au nord-est, par A part of lot P-119 bounded as follows: at northeast by the le lot 118; au sud-est, par le boulevard Mortagne; au sud-ouest lot 118; at southeast, by Mortagne Boulevard; at southwest par le lot 121 et au nord-ouest par les lots 77 et 78.A distraire by the lot 121 and at northwest by the lots 77 and 78.To be un emplacement situé sur le lot P-119, de 7.500 pieds carrés, deducted one emplacement situated on lot P-119, of 7,500 appartenant à Mme Fernand Laprise.Cette partie de lot square feet, belonging to Mrs.Fernand Laprise.This part of P-119 représente une superficie approximative de 28.9 arpents lot P-l 19 represents approximately 28.9 square arpents, carrés.3-116-1189 Vatzakis, Theodorus.127-38 3-116-1191 Vatzakis, Theodorus.127-39 3-116-1195 Koulis, George.127-40 3-114-1221 Marcopoulos, John et Marcopoulos Dimitra Mme.127-88 3-114-1211 Thersidis, Elias.127-91 3-114-1209 Viastikopoulos, Kostas et Dame Evdokia Thersidis.127-92 3-114-1209 Viastikopoulos, Kostas et Dame Evdokia Thersidis.127-93 3-114-1201 Karkavanedes, James.127-94 3-116-1275 Hinla Corporation.127-122 3-116-1277 Hinla Corporation.127-123.3-116-1296 Gonidis, Xenophon Mme.129-1378 3-116-1292 Papadopoulos, Panagiotis.129-1380 3-156-1289 Les Industries Wedco Ltée.137-11, 138-6, 138-8, 139-5.139-7 3-77-10 Meklyn Inv.Ltd.P-142 Une partie du lot P-142 bornée comme suit: au nord-est par A part of lot P-142 bounded as follows: at northeast by a une partie du lot 143; au sud-est par les limites de la ville de part of lot 143; at southeast by the limits of the Town of Boucherville et de St-Hubert; au sud-ouest par les limites de la Boucherville and St-Hubert; at southwest by the limits of the ville de Boucherville, Longueuil et St-Hubert; et au nord- Town of Boucherville, Longueuil and St-Hubert and at north-ouest par la rue De Touraine, le tout représentant une su- west by De Touraine Street, representing approximately 62.43 perficie approximative de 62.43 arpents carrés.square arpents. 2138 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Rôle Roll Nom du propriétaire Name of Ihe proprietor Description de l'immeuble Description of immoveable 3-77-264 Western Dev.Ltd.Interbank.P-151, P-153 Une partie du lot P-151 bornée comme suit: ft l'est par une A part of lot P-151 hounded as follows: at east by a part of partie du lot 153; au nord par une partie du lot 129 et au sud- lot 153: at north by a part of lot 129 and at southwest Dy ouest par la route Trans-Canadienne, le tout représentant une Trans-Canada Highway, representing 2^,ouu square leei.superficie totale de 22,500 pieds carrés.Une partie du lot P-153 bornée comme suit: à l'est par une A part of lot P-153 bounded as follows: at east by a P*rtOf partie du lot 154; au nord par une partie du lot 129; a l'ouest lot 154; at north by a part of lot 129; at west by a part oi lot par une partie du lot 151 et au sud-ouest par la route Trans- 151 and at southwest by Trans-Canada Highway, representing Canadienne, le tout représentant une superficie approximative approximately 96,000 square feet, de 96,000 pieds carrés.1-77-1201 Racicot, Paul-Emile Succession.P-182, P-183 (Bâtisses seulement).(Buildings only).1-84-1263 Gantcheft, Georges.190-5, 190-7 190-8 1-84-1387 Sutton Yvonne.190-83 190-84 1-84-1260 Gantcheff, Georges.190-89.190^.190-91.190-92.190-94.190-95, 190-96 1-84-1386 Smith, Marie Lorna.190-166.190-167, 190-168, 190-169 1-79-861 Mesicslmre.P-194 Une partie du lot P-194 bornée comme suit: au nord-est par A part of lot P-194 bounded as follows: at northeast by a une partie du lot No 266; au sud-est par le chemin public part of lot No.266; at southeast by public road De Lorraine; de Lorraine; au sud-ouest par une autre partie du lot 194 et au at southwest by another part of lot 194 and at northwest by nord-ouest par une autre partie du lot 194, le tout représentant another part of lot 194, representing approximately 30.387 une superficie approximative de 30,387 pieds carrés.square feet.1-79-855 Juhos Laszlo Mme.P-194 Une partie du lot P-194 bornée comme suit: au nord-est par A part of lot P-194 bounded as follows: at northeast by une autre partie du lot 194; en front au sud-est parle chemin another part of lot 194: in fiont ut southeast by public road public de Lorraine; au sud-ouest par le chemin de Montbrun De Lorraine; at southwest by De Montbrun Road and at et au nord-ouest par une autre partie du lot 194, le tout repré- northwest by another part of lot 194, representing approxi-sentant une superficie approximative de 13,260 pieds carrés.mately 13,260 square feet, 2-77-645 Gothic Developments Inc.P-204 Une partie du lot P-204 bornée comme suit : il l'est par une A part of lot P-204 bounded as follows: at east by a part of partie du lot 202; ft l'ouest par une partie du lot 295; au sud lot 202; at west by a part of lot 205; at south by De Touraine par la rue de Touraine et au nord-ouest par une partie du lot Street and at northwest by a part of lot 160, representing 160, le tout représentant une superficie approximative de approximately 11 square arpents, 11 arpents carrés.2-79-680 Mendelson, Sara, Kaufman, Sam, Wohl, Morris, Polansky Jack & Hyman P-268 Une partie du lot P-258 bornée comme suit: au nord-est par A part of lot P-258 bounded as follows: at northeast by the le lot P-267; au sud-est par les limites de la ville de Boucher- lot P-267: at southeast by the limits of the Town of Boucherville et de St-Bruno; au sud-ouest par le lot P-265 et au nord- ville and St-Bruno; at southwest by the lot P-265 and atnorth-ouest par la rue de Lorraine.A soustraire l'emprise de la route west by De Lorraine Street.To bè deducted the right of way Trans-Canadienne et !a voie de ceinture numéro 30 et la partie ofTrans-Canada Highway.Highway number 30 and De Lor-expropriée pour l'élargissement delà rue de Lorraine (6e Rang).raine Street (6th Range), representing approximately 34.13 le tout représentant une superficie approximative de 34.13 square arpents, arpents carrés.2-79-700 Mendelson, Sara, Kaufman, Sam, Wohl, Morris, Polansky, Jack & Hyman P-259 Une partie du lot P-259 bornée comme suit: à l'est par une A part of lot P-259 bounded as follows: at east by a part of partie du lot 260; a l'ouest par une partie du lot 258; au sud lot 260; at west by a part of lot 268; at south by the limits par les limites de la ville de Boucherville et de St-Bruno et au of the Town of Boucherville and St-Bruno and at northwest by nord-ouest par la rue de Lorraine.A soustraire l'emprise de la De Lorraine Street.To be deducted the right of way of Trans-route Trans-Canadienne et la voie de ceinture numéro 30.la Canada Highway, Highway number 30, and De Lorraine partie expropriée pour l'élargissement de la rue de Lorraine Street, representing approximately 95.8 square arpents.(6e rang), le tout représentant une superficie approximative de 95.8 arpents carrés.1-79-880 Kettanch, Charles.P-266 Une partie du lot P-266 bornée comme suit : au nord-est par A part of lot P-266 bounded as follows: at northeast by a part une partie du lot 267; au sud-est par le chemin de Lorraine; of lot 267; at southeast by De Lorraine Road; at southwest by au sud-ouest par une partie du lot 265 et au nord-ouest par a part of lot 265 and at northwest by a part of lot 192.une partie du lot 192.Une autre partie du lot P-266 bornée comme suit: au nord- Another part of lot P-266 hounded as follows: at northeat est par une partie du lot 267; au sud-est par le chemin de by a part of lot 267; at southeast by De Lorraine Road- at Lorraine; au sud-ouest par l'autoroute No 30 et par une partie southwest by Highway number 30 and by a part of lot No.265 du lot No 2G5 et au nord-ouest par le chemin de Lorraine, les and at northwest by De Lorraine Road, the two parts répre- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n° 10 2139 Rôle Roll Nom du propriétaire Name of the proprietor Description de l'immeuble Description of immoveable deux parties représentant une superficie approximative de senting approximately 97.48 square arpents.97.48 arpents carrés.3-51-360 Corbeil Maurice Mme.331 Cadastre du village incorporé de Boucherville \u2014 Cadaster of the Village Incorporated of Boucherville 2-51-600 Jodoin Charles Succession.Une partie du lot P-27 bornée comme suit: au nord-est par une partie des lots 1-3 à 1-22 inc'usivement; au sud-est par une partie des lots P-27, 27-1.28-1, 28-2; au sud-ouest par une partie des lots 28-2.P-28, 28-3.27-2 et au nord-ouest par le chemin Marie-Victorin et par une partie des lots Nos 27-2.27-25 et 27-26, le tout représentant une superficie approximative de 8.83 arpents carrés.2-18-6 Brochu, Carmen Mme.Une partie du lot P-64 bornée comme suit : au nord par la rue De La Perrière: à l'est par une autre partie du lot No 64; au sud par une partie du lot No 63 et à l'ouest par une autre partie du lot No 63.le tout représentant une superficie approximative de 2,270 pieds carrés.2-18-40 Chef.Gérard.Une partie du lot P-83 bornée comme suit : au nord par la rue De La Perrière; à l'est par la rue St-Sacrement; au sud par une partie du lot No 84-1 et a l'ouest par une partie du lot No 83.le tout représentant une superficie approximative de 5,442 pieds carrés.2-45-580 Chef, Gérard.Une partie du lot P-84 bornée comme suit: au nord-est par une partie du lot No 83; au sud-est par une partie du lot No 84-1 ; au sud-ouest par une partie du lot No 85 et au nord-ouest par la rue Ste-Marguerite.le tout représentant une superficie approximative de 5,318 pieds carrés.2-39-561 Chef.Gérard.2-20-43 Descheneaux, Yvon.Une partie du lot P-93 bornée comme suit: au sud par la rue De Grosbois; à l'ouest, par une partie du lot No 94; au nord par une partie du lot No 93 et à l'est par une partie des lots Nos 93-2 et 93-1, le tout représentant une superficie approximative de 3,086 pieds carrés.2-51-536 Tardif Cie Limitée.2-51-510 Moseley Douglas Arthur.Une partie du lot P-143 bornée comme suit: au nord-est par la rue Pierre-Boucher; au sud-est par une partie du lot 145; au sud-ouest par une partie des lots 146 et 144 et au nord-ouest par la rue Marie-Victorin.le tout représentant une superficie approximative de 25,619 pieds carrés.P-27 A part of lot P-27 bounded as follows: at northeast by a part of lots 1-3 at 1-22 inclusively; at southeast by a part of lots P-27.27-1, 28-1, 28-2; at southwest by a part of lots 28-2.P-28, 2S-3, 27-2 and at northwest by Marie-Victorin Road and by a part of lots Nos.27-2, 27-25 and 27-26, representing approximately 8.83 square arpents.P-64 A part of lot P-64 bounded as follows: at north by De La Perrière Street; at east by another part of lot No.64; at south by a part of lot No.63 and at west by another part of lot No.63, representing approximately 2,270 square feet.P-83 A part of lot P-83 bounded as follows: at north by De La Perrière Street; at east by St-Sacrement Street; at south by a part of lot No.84-1 and at west by a part of lot No.83, representing approximately 5,442 square feet.P-84 A part of lot P-84 bounded as follows: at northeast by a part of lot No.83; at southeast by a part of lot No.84-1 ; at southwest by a part of lot No.85 and at northwest by Ste-Marguerite Street, representing approximately 5,318 square feet.84-1 .P-93 A part of lot P-93 bounded as follows: at south by De Grosbois Street; at west by a part of lot No.94; at north by a part of lot No.93 and at east by a part of lots Nos.93-2 and 93-1, representing approximately 3,086 square feet.105-1 .P-143 A part of lot P-143 bounded as follows: at northeast by Pierre-Boucher Street; at southeast by a part of lot 145; at southwest by a part of lots 146 and 144 and at northwest by Marie-Victorin Street, representing approximately 25.619 square feet.Donné à Boucherville, ce 20e jour de février 1975.Le greffier.60105-9-2-o EfoÈNF.McClish.Municipalité du comté de Huntingdon Avis public est par les présentes donné que le soussigné, Ross W.Antaya, secrétaire-trésorier de la municipalité du comté de Huntingdon, que les lots de terre, emplacements ou autres édifices énumérés ci-dessous seront vendus à l'enchère publique, JEUDI, le HUI- Given at Boucherville, this 20th day of February, 1975.Euc.ène McClish.60105-9-2-o City Clerk.Municipality of the County of Huntingdon Public notice is hereby given by the undersigned Ross W.Antaya, Secretary-Treasurer, of the aforesaid Municipality, that the lands and buildings listed hereunder will be sold for arrears of municipal, school and other taxes due thereon together with costs, at a 2140 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 TIÈME jour du mois de MAI 1975.à DIX heures de l'avant-midi à l'édifice du comté, ville de Huntingdon, tant pour les taxes municipales, scolaires et autres redevances à moins que ces diverses sommes et les frais encourus ne soient payés avant le jour de la vente.public sale of lands for arrears of taxes, at the County building.Town of Huntingdon, on THURSDAY, the EIGHTH day of the month of MAY 1975, at TEN o'clock in the forenoon, unless the said taxes and costs incurred are paid to me before the day of sale.Municipalité de la paroisse de St-Anicet \u2014 Municipality of the Parish of Saint-Amcet Noms .Vt m es Lots Nos Rang Range Taxes mun.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total Knox, Hartley.\t.P.609.\t\t?\t123.81\tS\t123.81 Elias, Maurice.\t.319.\t\t\t585.62\t\t585.62 Russell.Leon.\t.'.882.\t\t\t96.24\t\t96.24 Campbell, Kelly.\t.P.848.\t\t\t37.85\t\t37.85 \t.690-68.\t\t\t157.26\t\t157.26 \tMunicipalité du canton ae Dundee\t\u2014 Municipality of the\tTownship of Dundee\t\t\t 0.Gorman, Paul.\t.P.1.,\t.B.F.R.\t.$ 3.92 $\t16.77\tt\t19.69 Cartier, Charles.\t.P.8.\t.5.\t2.27\t43.73\t\t46.00 \t\t\t\t\t\t \tMunicipalité du canton de Franklin -\t\u2014 Municipality of the\tTownship of Franklin\t\t\t Moïse, Hermas.\t.P.26.\t\tt\t18.71\tt\t18.71 \t\t\t\t\t\t Municipalité du canton de Godmanchester\t\t\u2014 Municipality of the\tTownship of Godmam\trhester\t\t Bergeron, Gilles.\t.P.401.\t\tt 10.22 t 27.00\t161 13\ts\t171.35 Vaillancourt, Wilbrod.\t.P.280.\t\t\t424.98\t\t461.98 \t\t\t\t\t\t Municipalité du canton de Hinchinbrooke ¦\t\t\u2014 Municipality of the\tTownship of Hinchinbrooke\t\t\t Beerworth, Herman.315.1.Thoukanas, Athanasies.335.1.Travers, B.P.34A.Kruyk, Simon.P.19B.Latulippe, Clément.19B.Hovorka, Vilebald.24A.Biais, Jacques.P.9B.Provost.Albert.18D.Thurston, Maurice.3C.Russell, David.8.Quinn, Fred.31A.Asworth, Gladys.31A-B-C.Gagnon, Pierre.31B.Murray, Georges.31B.Ruel, Raymond.P.32B-P.32C.Travisée.William.28F.Thurston, Maurice.3E.Dagenais, Jacques.31B.114\t17 8\t114.17 28\t.14\t28.14 19\tSO\t19.80 7!)\t.17\t79.17 19\tso\t19.80 497\t12\t497.42 29\t68\t29.68 19\t.80\t19.80 79.\t17\t79.17 49\t,49\t49.49 19\t80\t19.80 168\t.34\t188.24 19\t.80\t19.80 69\t27\t69.27 40\tID\t49.49 118\t.74\t118.74 29\t,68\t29.68 19\t80\t19,80 \tMunicipalité du canton de Havelock \u2014 Municipality of the\tTownship of Havelock\t\t \t.P.174D.4.\t\t62.89 S\t81.74 81,56 80.33 26.77 \t.P.162B-P.162C.4.\t81 55\t\t \t.P.35C.\t\t80.33 26.77\t Tremblay, Lucie.\t.P.89D.\t\t\t \t\t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, \u201e° 10 2141 Municipalité du canton de Hemmingford \u2014 Municipality a/ the Township of Hemmingford \t\t\tTaxes\tTaxes\t Noms\t\tRang\tmun.\tscol.\t \tLots Nos\t\t\t\tTotal Names\t\tRange\tM unie, taxes\tSchool taxes\t Stairholmes Farms Inc.C.B Scribers block ?509.22 $2,091.19 S 2.600.41 Stairholmes Farms Inc.6D.1 CL.Stairholmes Farms Inc.7C.1 CL.Stairholmes Farms Inc.8C.1 CL.Stairholmes Farms Inc.9A.1 CL.Leemhuis, Feico Mme.1A.2CL.Leemhuis, Feico Mme.IB.2 CL.Leemhuis.Feico Mme.1C.2 CL .20 .40 .40 .40 2.16 11.66 75.17 .20 .40 .40 .40 2.16 11.60 75.17 Municipalité de la paroisse de Ste-Barbe \u2014 Municipality of the Parish of Sainte-Barbe Gagné, Madelaine.48P.Baros, Stéphane.51P.Bougie.Jean-Louis.52P.112.94 s 112.94 17.66 17.66 229.43 229.43 Municipalité du canton de Elgin \u2014 Municipality of the Township of Elgin Ménard, Louis.P.7.Tardif, Pierre.P.14.Gallant, François.P-14.Guerer, Félix.P.14-P.15.Narbonne.René.P.12-P.13.Ducharme, Mme Monique.P.18-P.19.Grenier.M.P-14.Gallant.G.P.13.R2vsh.$ R2vsh.R2vsh.R2vsh.R2vsh.R2vsh.R2vsh.R2vsh.7.10 $\t12.20 $\t19.30 7.10\t12.20\t19.30 7.10\t12.20\t19.30 7.10\t12.20\t19.30 7.10\t12.20\t19.30 7.10\t12.20\t19.30 14.20\t24.41\t38.61 21.30\t36.61\t57 91 L'énumération abrégée des numéros de cadastre a été autorisée par la Commission municipale du Québec, le 18 octobre 1967.Donné à Huntingdon, ce 20e jour de février 1975.60181-9-2-o Le secrétaire-trésorier, Ross W.Antaya.The abreviated enumeration of the cadastral numbers has been authorized by the Municipal Commission on the 18th October.1967.Given at Huntingdon, this 20th day of February, 1975.Ross W.Antaya.60181-9-2-o Secretary-Treasurer.Municipalité du comté de Pontiac Avis public est par le présent donné par le soussigné, C.Robillard, secrétaire-trésorier de la municipalité du comté de Pontiac, que les terrains ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique, à l'édifice du comté, Campbells' Bay.Québec.JEUDI, le HUITIEME jour de MAI, 1975, à DIX heures de l'avant-midi, pour les cotisations et frais dus aux municipalités ci-après mentionnées, à moins que lesdites taxes et frais encourus ne soient payés avant le jour fixé pour la vente.Municipality of the County of Pontiac Public notice is hereby given by C.Robillard, Secretary-Treasurer of the Municipality of the County of Pontiac, that the lands hereinafter mentioned will be sold by public auction, at the Countv Building Campbell's Bay, Québec, on THURSDAY, the EIGHTH day of MAY, 1975.at TEX o'clock in the forenoon, for the assessments and costs due the municipalities hereinafter described, unless they be paid to me with costs incurred, before the day fixed for the sale. 2142 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol 107, No.JO Municipalité du canton d'Allumette Island \u2014 Municipality of the Township of Allumette Island Commission scolaire de Por.tiac \u2014 Pontiac School Board Nom sur rôle Name on roll\tSuperficie Area\tLots nos\tRang Range\tTaxes mun.Man.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal Cameau, Harry.\tBât.seul.Bldgs only.\tSur / On P.39.P.40 & P.41A.\t6 .\t8 S4.68 30.45\t8 191.29 237.90\tS 54.27 68.30\tS 300.24 326.65 St.Cyr, Zephirim.\t\t\t4.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité d'Allumette Island East \u2014 Municipalily of Allumette Island East Commission scolaire protestante de Pontiac \u2014 Ponliac Protestant School Board Neuman, Mrs.Geneva.22.05 S 114.73 8 34.62 Municipalité du canton de Bristol \u2014 Municipality of the Township of Bristol Polk, Est.Roland.Polk.Est.Roland.Polk, Est.Roland.Polk, Est.Roland.Polk, Est.Roland.Polk.Est.Roland.Chapman, Mrs.D.W.Joyce, Mr.& Mrs.Howard Joyce, Mr.& Mrs.Howard Muret.Mrs.Lilias.Stahan, Mrs.Janet.Rue / Street.Rue / Street.Rue / Street .Rue / Street.Rue / Street.Rue / Street.Chalet et lot Cot.and lot.Chalet et lot Cot.and lot.Chalet et lot Cot.and lot.9A-43.9A-44.9A-45 .9A-46.9A-25.9A-26.P.3B.12-151 .12-152.11-6.9-106.1.1.1.1.1.1.12 1.1.I.1.$ 33.14\tS 99\t91\t8 33\t95\t8 167.00 8.28\t24\t96\t15\t98\t49.22 26.92\t81\t17\t29\t46\t137.55 8.28\t24\t95\t15\t98\t49.21 7.14\t12\t49\t13\t53\t33.16 7.14\t12\t49\t13\t53\t33.16 11.27\t14\t91\t14\t71\t40.89 17.84\t47\t50\t21\t76\t87.10 208.61\t348\t51\t110\t28\t667.40 141.98\t112\t94\t55\t89\t310.81 143.63\t37\t59\t32\t62\t213.84 Municipalité du village de Bryson \u2014 Municipality of the Village of Bryson Pigeon, Léo.\t6,510 pi.ca.sq.ft.\t365-3\t\t8 200.94\t8 177.80\t8 78.17\t8 456.91 \t\t\t\t\t\t\t Municipalité du canton de Grand Calumet Island \u2014 Municipality of the Township of Grand Calumet Island Cieszkowski, Marion Cieszkowski, Marion CieszkowskL Marion Lachance, Rita.Lachance, Rita.LaSalle, Joseph.Miroslaw, Salazka.Nelson, Vernon.Nelson, Vernon.Nelson, Vernon.Nelson, Vernon.Nelson, Vernon Nelson, Vernon.Nelson, Vernon.Nelson, Vernon.Nelson.Vernon.Nelson, Vernon.Sicard.Yvon.38 a.25 a.25 a.10 a.120 a.10.890 pi.ca.sq.ft.70 a.67 a.66 a.100 a.100 a.50 a.100 a.100 a.100 a.75 a.85 a.la.26 30 84 21 22 8.33 25 26 22 23 30 31 32 33 34 23 M N 8 8.N N 4.9.N N 8.8.8.8.8.8.8.9.3.28.63\t\t8 15.15\t8 43.78 18.87\t\t13.40\t32.27 18.87\t\t13.40\t32.27 3.99\t$ 5.36\t10.68\t20.03 27.69\t57.25\t25.29\t110.23 108.65\t321.53\t87.43\t517.61 60.57\t\t21.90\t82.47 17.46\t35.04\t19.45\t71.95 9.49\t17.76\t14.90\t42.15 22.85\t46.75\t22.53\t92.13 22.85\t46.74\t22.53\t92.12 17.67\t35.53\t19.58\t72.78 22.85\t46.75\t22.53\t92.13 22.85\t46.74\t22.53\t92.12 22.85\t46.73\t22.62\t92.10 18.33\t36.95\t19.95\t75.23 21.13\t42.99\t21.54\t85.66 78.15\t159.29\t52.74\t290.18 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n\" 10 2143 Commission scolaire protestante de Pontiac \u2014 Ponliac Prctcstanl School Board Nom sur rôle Name on roll\tSuperficie Area\tLots nos\tRang Range\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal Strzemieczny, Alexander.\t\t27.\tN.\t\tS 32.55\tS 15.86\tS 48.41 Municipalité du village de Campbell's Bay \u2014 Municipality of the Village of Campbell's Bay Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Beard\t\t\t\t\t\t\t McCoshen, Austin.Browning, Mrs.Sarah.\t4,600 pi.ca.sq.ft.\t109 & 121____ 4.\t\t8 305.65 5.30\t8 245.43\t8109.19 10.95\tS 660.27 16.25 Municipalité du canton de Chichester \u2014 Municipality of the Township of Chichester\t\t\t\t\t\t\t \tBat.seul.Bldgs only.\tP.25.P.20.\t4.\t8 27.67 72.51\t8 101.25 329.86\t8 33.21 82.43\t8 162.13 484.80 \t\t\t1.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Commission scolaire protestante de Pontiac \u2014 Pontiac Protestant School Board\t\t\t\t\t\t\t \t\t6.\t3.\t\t100.07 100.62\t28.01 28.11\t128.08 128.73 \t\t5.\t6.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité du village de Chapeau \u2014 Municipality of the Village of Chapeau Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontine School Board\t\t\t\t\t\t\t Dupuis, Jean-Guy.\t\tP.54.\t\t\tS 127.24\tS 32.90\tS 160.14 Municipalité du canton de Dorion \u2014 Municipality of the Township of Dorion\t\t\t\t\t\t\t \t0.72 a.\t7.\tB.\t8 69.65 19.35\tS 24.43 5.09\t$ 26.93 14.40\t8 121.01 38.84 \t0.67 a.\t27.\tB.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité du village de Fort Coulonge \u2014 Municipality of the Village of Fort Coulonge\t\t\t\t\t\t\t Bertrand, Mrs.Rose.\t7,980 pi.ca.sq.ft.\t237.\t\t81,051.43\tS 308.76\t8254.83\t8 1,615.02 Municipalité du canton de Leslie\u2014 Municipality of the Township of Leslie\t\t\t\t\t\t\t \t8 a.plus ou moins / more or less.4 a.plus ou moins / more or less.27 a.plus ou moins / more or less.1 a.plus ou moins / more or less.1 a.plus ou moins / more or less.\tP.40.\t1.\t8 12.02 45.02 139.81 14.60 14.60\t8 13.19 53.09 136.02 4.37 4.37\t8 14.54 27.66 59.65 13.41 13.41\t8 39.75 125.77 335.48 32.38 32.38 Collin* Mrs Harlen B\t\tP.40.P.31A.P.31B.\t1.3.\t\t\t\t ffillinti lvfra Hlrlpn R\t\t\t3.\t\t\t\t Collins, Mrs.Harlen B.\t\tP.32A.\t3.\t\t\t\t 2144 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Nom sur rôle Name on roll Collins, Mrs.Harlen B.Collins, Mrs.Harlen B .Collins, Mrs.Harlen B .Collins, Mrs.Harlen B.Collins.Mrs.Harlen B.Collins, Mrs.Harlen B.Collins, Mrs.Harlen B.Day, Brian.Gladman, K.C.Law, Peter., Lockeya, W.Edward.Laviolette, Napoléon, Est.Lafleur, Maril Est.Superficie Area 1 a.plus ou moins / more or less.75 a.plus ou moins / more or teas.70 a.plus ou moins / more or less.65 a.plus ou moins / more or less.70 a.plus ou moins / more or less.60 a.plus ou moins / more or less.50 a.plus ou moins / more or less.19,166 p.c.sq.ft.10,850 p.c sq.ft.49,658 p.c.sq.ft.30.G28 p.c.sq.ft.80% de /of Mde/o/la.61%de/o/ M de/of 1 a.Lota nos\tRang Range\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal P.32B.\t3.\t$ 14.61\tS 4.37\t8 13.41\t$ 32.39 27.\t3.\t18.69\t13.16\t15.73\t47.67 28.\t3.\t13.81\t13.12\t14.85\t41.78 29.\t3.\t13.81\t4.37\t13.27\t31.45 30.\t3.\t13.81\t13.15\t14.85\t41.81 P.34.\t3.\t11.19\t13.12\t14.38\t38.69 P.35.\t3.\t11.19\t13.13\t14.38\t38.70 6.\tC.\t12.02\t13.20\t14.64\t39.76 P.21.\t1.\t56.51\t26.38\t24.92\t107.81 17.\tc.\t33.48\t19.65\t19.56\t72.69 \tD.\t12.02\t21 05\t15 95\t49.02 P.30C.\t2.\t61.36\t63.24\t28.83\t133.43 P.30A.\t2.\t39.16\t40.60\t24.36\t104.12 \t\t\t\t\t Pontiac Protestant School Board McCrea, W.J.\t\tP.23.\t2.\t8 121.99\t8 4.78\tS 32.82\t$ 159.59 Municipalité de Clapham \u2014 Municipality of Clapham\t\t\t\t\t\t\t Rice, David W.& W.Brandford.Rice, David W.& W.Brandford.Rice, David W.& W.Brandford.Rice, David W.& W.Brandford.\t60 a.60 a.60 a.60 a.60 a.\t4B.6B.8A.8A.7A.\t1.1.a.2.2.\t8 12.02 12.02 12.02 44.41 12.02\t8 21.26 21.26 21.26 127.91 21.26\t8 15.99 15.99 16.99 41.02 15.99\t8 49.27 49.27 49.27 213.34 49.27 \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Huddersfield\u2014 Municipality of Huddcrsfleld\t\t\t\t\t\t\t Cartier, Paul Est.\t\tIB.2B.\t4.4.\t8 20.27 17.84\t8 41.76 34.40\t8 21.16 19.40\t8 83.18 71.64 \t\t\t\t\t\t\t Municipalité du canton de Litchfield \u2014 Municipality of the Township of Litchfield\t\t\t\t\t\t\t \t\t28A-56.P.27-93.\t7.\t8 10.97 8.22 24.19 92.01\t8 16.26 11.97\t8 14.92 13.63 14.35 26.60\t8 42.16 33.82 38,64 118.67 \t\t\t7.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t7.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S mars 1975, 107' aimée, 11° 10 2145 Pontiac School Board \t\t\t\tTaxes\tTaxes\t\t Nom sur rôle\tSuperficie\tLots nos\tRang\tmun.\tscol.\tFrais\t Name on roll\t\t\t\t\t\t\tTotal \tArea\t\tRange\tMun.\tSchool\tCosts\t \t\t\t\ttaxes\ttaxes\t\t Sloan, Mrs.Bart ley Est.\t\t8A.\t6.\t$ 65.61\tS 242.24\t$ 65.41\t$ 373.26 Sloan, Mrs.Bartley Est.\t\tP.7.\t9.\t7.42\t29.00\t16.56\t52.98 Municipalité du canton de Granet (non organisé) \u2014 Municipality of the Township of Granet 'unorganised) Jackson Landing (Fred Jackson).Bl.B Bât.seulement situés sur le Bldgs only situated on.Bâtisses seulement situés au Lac Victoria (Kawastaguta Bay) à l'extrémité nord-ouest du bloc B, rang 6, canton Granet.comté de Pontiac, connu sous le nom de « Jackson Landing », parc Lavérendrye.6.$2,210.44 $407.88 $ 2.618.32 Buildings only, situated on the North East side of Lake Victoria (Kawastaguta Bay), located on the extreme northwest corner of Block B, Range 6 of the unorganized township of Granet in the County of Pontiac, commonly known as Jackson Landing in Lavérendrye Park.Municipalité du canton de Mansfield & Pontefract \u2014 Municipality of the Township of Mansfield & Pontefract Belair, Arthur (Mansfield).Bertrand, Albert (Mansfield).Dyelle, Alderic (Mansfield).Dean, Ernest.Bât.seulement Bldgs only Pontefract.P.23.P.13-18.P.28-1.36.3.1.2.6.S 18.00 86.00 79.00 29.00 18.95 177.83 157.80 $ 16.65 57.49 52.62 15.22 Municipalité du village de Portage du Fort \u2014 Municipality of the Village of Portage du Fort Ballard, Rev.L.H.\t\t92.\t\t$ 90.03\t$ 152.07\t$ 53.60\tS 295.70 Commission\tscolaire protestante de Pontiac \u2014\t\t- Pontiac Pr\tolestant School Board\t\t\t Gravelle, Russell., 189A.$ 12420 $ 168.29 $62.65 $ 355.14 Municipalité scolaire de Portage du Fort \u2014 School Municipality of Portage du Fort Murdock, Wayne .Murdock, Terence.Murdook, Terence, P.28.27B .28E.1.\tS 274.25\t$ 200.36\tS 95,43 2.\t\t55.97\t20.07 2.\t\t157.76\t38.40 570.04 76.04 196.16 Municipalité de Pontiac \u2014 Municipalily of Pontiac Proulx, Peter Jr.| I »A- Un immeuble situé dans la canton de Onslow, comté de Pontiac, connu et désigné comme étant le lot onze A, rang six, aux plan et livre de renvoi officiels dudit oanton de Onslow, contenant en superficie, plus ou moins, cent acres de terre, avec bâtisses dessus érigées.| 6.|$ 245.85 |$ 487.68 |$H2.04 |$ 875.57 All that parcel or tract of land lying and situated in the Township of Onslow, in the County of Pontiac, known and designated as lot number 11A in the Sixth Range, according to the official plan and book of reference of the said Township of Onslow, containing one hundred acres of land, more or less, together with the buildings thereon ereoted. 2146 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March S, 1975, Vol.107, No.10 \t\t\t\tTaxes\tTaxes\t\t Nom sur rôle\tSuperficie\tLots nos\tRang\tmun.\tscol.\tFrais\tTotal Name on roll\tArea\t\tRange\tMun.\tSchool\tCosts\t \t\t\t\ttaxes\ttaxes\t\t Hickey.John William.\t\tSB.\tS.\t8 318.14\tg 238.96\t8110.28\t8 667.38 Un immeuble situé dans le canton de Onslow, comté de Pontiac, connu et désigné comme étant le lot huit B, rang cinq, aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Onslow, contenant en superficie, plus ou moins, cent quatorze acres de terre, avec bâtisses dessus érigées, et tous les membres et circonstances s'y rattachant.Hickey.John William.| | 7B.Un immeuble situé dans le canton de Onslow, comté de Pontiac, connu et désigné comme étant le lot 7B.rang cinq, aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Onslow, contenant en superficie, plus ou moins, cinquante-sept acres de terre, avec bâtisses dessus érigées et tous les membres et circonstances s'y rattachant.All tnat parcel or tract 01 lanu iymg «tu wsuaw >» ship of Onslow, in the County of Pontiac, known and designated as lot eight Bin the Fifth Range, according to the official plan and book of reference of the said Township of Onslow containing one hundred and fourteen acres of land, together with the buildings thereon erected and all members and appurtenances thereunto belonging.J 5.1 69.69 I 53.05 I 32.09 | 154.83 All that parcel or tract of land lying and situate in the Township of Onslow, in the County of Pontiac, known and designated as lot 7B, in the Fifth Range, according to the official plan and boo k of reference of the said Township of Onslow containing fifty-seven acres of land, together with the buildings thereon erected and all members and appurtenances thereunto belonging.Chapman, Joseph Guillaume.23C-3.23C-1.23C-2.Un immeuble situé dans le canton de Onslow, comté de Pontiac, connu et désigné comme étant les lots 1, 2 et 3 de la subdivision du lot 23C, rang 4, canton d'Onslow.Cet immeuble mesurant dans sa ligne est 110'5.dans sa ligne nord 117'5.103'2\", dans sa ligne ouest, 118'I0\" dans sa ligne sud.Ladite étendue de terrain étant bornée comme suit: à l'est par le lot no 4, de la subdivision du lot no 23C, au nord par une route étant le lot no 18 de ladite subdivision du lot no 23C, à l'ouest par une autre partie de ladite subdivision du lot no 23C, propriété de Edgur J.Léger ou représentants, et au sud par la rive de la rivière Outaouais.Proulx, Irene MacDonald.4.\t\t\t 4.\t\t\t 4.\t70.70\t103.98\t61.44 236.12 All that piece or parcel of land known and described as being lots numbers 1, 2 and 3 of the official subdivision of lot 23C in the Fourth Range of the Township of Onslow, said parcel of land measuring 110'5\" on its east boundary.117'5\" on its north boundary.103'2\"onits west boundary and 118'10\" on its south boundary, said piece of land being bounded as follows: to the east by lot No.4 of subdivision of lot No.23C to the north by a road being lot No.18 of said subdivision of lot No.23C.to the west by another part of said subdivision of lot No.23C belonging to Edgar J.Léger or representatives, and to the south by the shore of the Ottawa River.y2 S.253.P.256 H N.258 Un immeuble connu et désigné comme étant S-H 253 et P.256.Cet immeuble mesurant 14' x 130' et borné comme suit : au nord par le résidu du no 256; au sud par la ligne entre no 256 et no 257; à l'est par le lot 253 et à l'ouest par un chemin appelé Mill Road; mesures anglaises et plus ou moins aux plan et livre de renvoi officiels dudit village de Quyon.La demie sud (S-J^ 253) mesure 65' dans ses lignes nord et sud x 60' dans ses lignes est et ouest; la demie-nord du lot (N-J-£ 258) aux plan et livre de renvoi officiels dudit village de Quyon, bornée au nord par le chemin situé entre les rangs 3 et 4, à l'est par une partie du lot 1, au sud par la partie sud du lot 2, à l'ouest par une partie du lot 6.209.90 163.95 97.29 471.14 A certain emplacement known and designated as being the exact south half of lot number 253-H and a part of lot Pt.256 composed of a parcel of land measuring 14' in width on all the length of said lot that is one hundred and thirty feet (130') and bounded as follows: To the north by the residue of lot 256, to the south by the division line between lots 256 and 257; to the east by lot No.253 and to the west by a road called Mill Road; the whole as it is now English measures and more or less and according to the official plan and book of reference of the Village of Quyon.The exact south half of lot 253-S-Hz measures 66' in its north and south lines and 60' in its east and west lines; the north half of lot (N-J4 258) on the official plan and in the book of reference for the said Village of Quyon, bounded on the north by the road running between Ranges 3 and 4, on the east by a part of lot 1 ; on the south by the south part of lot 2, on the west by a part of lot 6.Brazeau, Armand.| I P.350 Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot 350, aux plan et livre de renvoi officiels du village de Quyon, ledit immeuble étant la partie ouest de la parcelle de terrain achetée de Gordon Ross par le vendeur, aux termes d'une donation, passée devant Me Harland Cameron Rowat, notaire, et enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Pontiac, le 27 juillet 1945, sous le no 62313; commençant à un point situé du côté nord de l'autoroute au coin sud-est de la propriété de M.Martineau et de la propriété de Maria Pessigo, de là, en direction nord le long de la clôture formant la limite est de la propriété de M.Martineau sur une distance de 215' plus ou moins, jusqu'à une autre clôture formant la limite nord-est de la propriété de Martineau; de là, vers l'est le long d'une autre clôture formant la limite sud de la propriété de M.Stan- -1 | 432.14 l 272.49 | 126.83 1 831.46 An immoveable property known and described as being part of lot Pt.350 upon the official plan and book of reference for the Village of Quyon, the said immoveable, being the west part of the parcel of land acquired by the vendor from Gordon Ross, under the terms of a donation, passed before Me, Harland Cameron Rowat, Notary, registered at the Registry Office for the Division of Pontiac, on the 27th of July, 1945, under 62313; commencing at a point situate on the north side of the highway situate on the southeast corner of the property owned by Mr.Martineau the property of Maria Pessigo, from that point northerly along the fence marking the easterly limit of the property of Mr.Martineau a distance of 215' more or less, to another fence marking the northeasterly of the Martineau's property; thence easterly along another fence marking GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mars 1975, 107' année, n° 10 2147 \t\t\t\tTaxes\tTaxes\t\t Nom sur rôle\tSuperficie\tLots nos\tRang\tmun.\tscol.\tFrais\t \t\t\t\t\t\t\tTotal Name on roll\tArea\t\tRange\tMun.taxes\tSchool taxes\tCosts\t ton sur une distance de 110' plus ou moins: de là, vers le sud en suivant une ligne parallèle à la limite est de la propriété du vendeur sur une distance de 88' ; de là, vers l'ouest sur toute la distance qui se trouve jusqu'à la limite nord de l'autoroute; de là, vers l'ouest le long de la limite nord de ladite autoroute sur une distance de 114' plus ou moins, jusqu'au point de départ; le tout borné comme suit: vers le sud par l'autoroute; à l'ouest par la propriété de Martineau; vers le nord par la propriété de M.Standon et vers l'est par la propriété du vendeur; tel que le tout se trouve actuellement, avec toutes les bâtisses dessus érigées, membres et circonstances.Brazeau, Armand.I | P.350.Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot trois cent cinquante (Ptie 350) aux plan et livre de renvoi officiels du village de Quyon, mesurant soixante-six pieds en front sur le chemin public, route no 8 sur cent trente-deux pieds de profondeur (66' x 132') plus ou moins, et borné comme suit : Au nord par le chemin public, ou route no 8; à l'est par une autre partie du même lot.vendue à M.Liguori Leblanc; au sud par une autre partie du même lot vendue ce jour à M.Domina Brazeau et à l'ouest par une autre partie du même lot, vendue ce jour à M.Léonard Chevrier; le tout tel qu'il se trouve actuellement; avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non apparentes affectant ledit immeuble.Brazeau, Armand.I I P.350.Un immeuble situé dans la ville de Quyon.comté de Pontiac.province de Québec, consistant en un terrain de forme rectangulaire formé d'une partie du lot Ptie 350 aux plan et livre de renvoi officiels dudit village de Quyon, ledit emplacement mesurant 65' de largeur sur une profondeur de 200'.mesures anglaises et plus ou moins et le tout borné comme suit: au sud, par le chemin public: au nord, par autre partie du même lot, propriété de Bazil Stanton ou représentants, à l'est par autre partie du même lot, propriété d'une certaine dame Ellen Rosette et à l'ouest par une autre partie du même lot Ptie 350.the southerly limit of the property of Mr.Stanton a distance of 110' more or less; thence southerly following a line parallel to the easterly limit of the property of the vendor and at a distance of 88', westerly therefrom all the distance to the northerly limit of the Highway; thence westerly along the northerly limit of said highway a distance of 114' more or less to the commencement point; the whole bounded as follows: southerly by the highway; westerly by the Martineau's property; northerly by the property of Mr.Stanton and easterly by the property of the vendor; with all the buildings thereon erected members and appurtenances, as the whole now exists.I 1$ 37.52 |S 8.75 IS 18.C3 |$ 65.60 An immoveable designated as part of lot No.350 on the plan and in the book of reference for the Village of Quyon, measuring 66 feet in front on the public road.Highway No.8 by 132 feet in depth, more or less and bounded as follows: On the north by the public road, to the east by another part of the same lot, sold to Liguori Leblanc; on the south by another part of the same lot sold to Domina Brazeau and on the west by another part of the same lot sold to Léonard Chevrier.The whole as it now subsists, with and subject to all active and passive, apparent or non-apparent servitudes attaching to said immoveable.I I 373.20 I 180.99 | 109.75 | 663.94 An immoveable situated in the Town of Quyon, County of Pontiac, Province of Québec, consisting of a piece of land o* rectangular configuration being a part of lot No.Pt.350 on the official plan and in the book of reference for the Village of Quyon, measuring 65' x 200', bunded as follows: on the south, by the public road, on the north by another part of the same lot, property of Basil Stanton or representatives, on the east by another part of the same lot, property of Mrs.Ellen Rosette and on the west by another part of the same lot Pt.350.Commission scolaire protestante de Pontiac \u2014 Pontiac Protestant School Board Moreau, L.E.Ancienne mun.de / Former Mun.South Onslow.16-4.$ 49.39 8 123.49 8 41.12 8 214.00 Municipalité du village de Shawville \u2014 Municipality of the Village of Shawville Crawford, Wilmer.Thompson.251-25.P.297.696.37 322.78 582.24 355.46 8222.15 132.08 8 1,400.76 810.32 Municipalité du canton de Thome \u2014 Municipality of the Township of Thome Hodgins, Edmund Holt, Est.Eugene Holt, Est.Eugene Caron, Aurell.Presley, Elwood.Presley, Elwood.Presley, Elwood.20 a.\t6.\t2 40 a.\t13B.\t2 40 a.\t14B.\t2 \tP.39.\t6 \t>AB.63A.\t6 \t53B.\t6 \t54.\t6 9.75\t8 13.84\t8 14.25\tS 37.84 6.24\t11.08\t13.12\t30.44 6.24\t11.08\t13.12\t30.44 26.35\t61.68\t25,85\t113.88 3.92\t30.86\t16.26\t51.04 3.92\t30.76\t16.24\t60.92 3.92\t30.64\t16.22\t60.78 2148 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Commission scolaire protestante (le Pontiac \u2014 Pontiac Protestant School Board Nom sur rôle Name on roll\tSuperficie Area\tLots nos\tRang Range\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal \t\tP.29\tE.\t\tt 141.97 65.89 13.74 105.81\tg 35.55 21.86 12.47 29.05\tt 177.52 87.75 26.21 134.86 \t\tP.16.\t9.\t\t\t\t \t\tP.A-4.P.37A.\tE.\t\t\t\t \t\t\t6.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité du canton de Watham & Bryson \u2014 Municipality of the Township of Watham A\t\t\t\t\t\tBryson\t Mascho, William.\t\tP.12.\tB.\tS 9.26\tS 46.94\t$ 20.12\tS 76.32 \t\t\t\t\t\t\t Québec, le 22 février 1975.6021S-10-2-o Le secrétaire-trésorier, C.Robillard.Municipalité du comté de Dorchester Avis est par les présentes donné par Henri-Paul Bouffard.secrétaire-trésorier de la municipalité du comté de Dorchester que les immeubles ci-dessous décrits seront vendus à l'enchère publique, pour taxes municipales et / ou scolaires dues et les frais encourus, JEUDI le HUITIÈME jour de MAI 1975, en la Salle du Conseil de Comté, à Ste-Hénédine, à DIX heures de l'avant-midi, à moins que lesdites taxes et les frais aient été payés avant le jour ci-dessus indiqué.Campbell's Bay, Québec, February 22, 1975.C.Robillard, 60218-10-2-o Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Dorchester Notice is hereby given by Henri-Paul Bouffard, Secretary-Treasurer for the Municipality of the County of Dorchester, that the underdescribed immovables will be sold by public auction for municipal and / or school taxes due and costs, THURSDAY the EIGHTH day of MAY 1975 in the Hall of the Council, in Ste-Hénédine at TEN o'clock in the morning, unless said taxes and costs be paid before the day above mentioned.Municipalité de St-Benjamin \u2014 Municipality of St-Benfamin Propriétaire Owner\tLot\tRang Range\tCanton Township\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal Bélanger, Fernand.Bélanger, Fernand.\tP.849.P.843.\t14.14.\tCrambourne.\t\t$246.59 47.16 10.90 67.70 60.30 80.71 94.30\tS 11.72 2.65 2.54 4.59 1.60 4.61 6.30\t$ 258.31 49.81 13.44 60.29 61.90 85.32 10U.60 Bélanger, Fernand.Mc Clintock.Georges.Poulin, Martin.\tP.766.P.872 .P.18, P.19.P.7.7.\t13.6.3.D.F.\tCrambourne.Cumberland Mills.\t\t\t\t Veilleux, Andréa (Théodule).Veilleux, Andréa (Théodule).\t\t\tWatford.Watford.\t\t\t\t Municipalité de Frampton \u2014 Municipality of Frampton\t\t\t\t\t\t\t Turmel, Robert.\t5.\t1.\tFrampton.\t\t$138.18\t* 6.96\tS 145.14 \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de St-Isidore Village \u2014 Municipality of St-Isidore Village\t\t\t\t\t\t\t Parent, Marc.\tP.449.P.257.\t\tRue Coulombe____ Ste-Gencviève.\t$239.75 236.00\t\t\t8 239.75 236.00 \t\t\t\t\t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.8 mars 1975.107\u2022 aimée, n' 10 2149 Municipalité de Ste-Justine \u2014 Municipality of Ste-Justir.e Propriétaire Owner\tLot\tRang Range\tCanton Township\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal Fortier.Joseph-Emile.Lachance, Emmanuel.\t233-P.234.\t4.\tWare\t8186.04\t$106.27 19.10\t8 25.39 4.48\t$ 317.70 23.58 \t\t7.\tWare.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Ste-Germaine \u2014 Municipality of Ste-Gertnaine\t\t\t\t\t\t\t \tP.52.\t1\tWare\t$ 78.78\t\t8 2.00\tS 80.78 \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Ville Lac-Etchemin \u2014 Municipality of Ville Lac-Etchemin\t\t\t\t\t\t\t Bouchard, Denis.\tP.17, P.18.\t1.1\tWare\t8 47.72 2.30 2.30 6.90\t$187.58 9.06 27.14\tS 12.31 2.00 4.40 5.20\t8 247.61 4.30 15.76 39.24 \tP.18.\t\tWare\t\t\t\t \tP.17, P.18.P.536, P.537.\t1.3.\tWare\t\t\t\t Fournier, Damase.\t\t\tStandon.\t\t\t\t Municipalité de Ste-Germaine \u2014 Municipality of Ste-Gcrmaine\t\t\t\t\t\t\t Gourde, Fernand.Leclerc, Léonidas.\t262.\t4.\tWare.\t\t8117.53 192.92\t8 7.20 11.05\t$ 124.73 203.97 \tP.337.\t6.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Ste-Germaine-Station \u2014 Municipality of Ste-Germaine-Station\t\t\t\t\t\t\t \tP.247, P.248____\t4\tWare\t8 31.62\t8124.30 117.53\t$ 9.50 7.20\t$ 165.42 124.73 Campagnat, Mme Micheline a/s Mme Léon Poulin.\tP.172.\t3.\tWare.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Ville Lac-Etchemin \u2014 Municipality of Ville Lac-Etchemin Centre de Ski du Mont Orignal | 318 & 319, >4 S.0.318| 5.(Superficie: 750 x 1,000).| Crambourne.|$ 19.55 (Area: 750 x 1,600).|8 2.00 8 21.55 Municipalité du Lac-Etchemin \u2014 Municipality of Lac-Etchemin Bouchard, Louis.Breton, Arthur.Damase, Fournier.Nadeau, Nelson.Poulin, Grégoire.Pouliot, Mme Paul-Emile.#33 .33 #47 .33 26.22-1.47-13.47-33-4.Ware.Ware.Ware Ware.Ware.Ware.8143\t36\t8 8.36\t8 151.72 244\t22\t12.84\t257.06 281\t63\t3.82\t285.45 327\t40\t16.53\t343.93 677\t35\t27.40\t704.75 608\t52\t42.55\t651.07 Municipalité de St-Prosper \u2014 Municipality of St-Prospcr \t18B-19.\t6N.E.\tWatford.\t$ 38.25\t$125.77\t$ 12.62\t$ 170.e4 \t\t\t\t\t\t\t 2150 Quebec on ici.il gazette, March s, ms.Vol.jo?.No.jo Municipalité de St-Zacharie Paroisse \u2014 Municipality of St-Zacharie Parish Propriétaire Owner\tLot\tRang Ranoe\tCanton Township\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal Julien, Napoléon.\tP.3.\t6.\tMetgermette-Nord\tS 7.80\tS 31.70\t8 4.50\t$ 44.00 Municipalité de St-Zacharie Village \u2014 Municipality of Sl-'/.acharic Village\t\t\t\t\t\t\t Provost, Gabriel.Lariviére Robert (Ed).\tP.31.P.33.\t\tMctgermctte-Nord Metgermette-Norl\t\t$112.70 98.1G\t$ 7.08 6.29\t$ 119.78 104 45 \t\t5-E.\t\t\t\t\t Donne à Stc-Hénédinc.ce 25c jour de février 1975.Given at Stc-Hénédine, this twenty-fifth day of February 1975.Le secrétaire-trésorier, Henri-Paul Bouffard, 60200-10-2-o Henui-Paii.Bouffard.60200-10-2-o Secretary-Treasurer.Liquidation \u2014 Loi de la Winding-Up Act LA CAISSE POPULAIRE DES EMPLOYES FEDERAUX DE L'EST DU QUEBEC (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de « LA CAISSE POPULAIRE DES EMPLOYES FEDERAUX DE LEST DU QUEBEC ->, tenue à Québec le 11 juillet 1973.il a été résolu à l'unanimité que les affaires de ladite caisse soient liquidées et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi des caisses d'épargne et de crédit et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.André Desroehers soit nommé liquidateur.Québec, le 21 février 1975.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ii0244-o Albert Jessop, LA CAISSE POPULAIRE DES EMPLOYES FEDERAUX DE L'EST DU QUEBEC (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that, at a special general meeting of the members of \"LA CAISSE POPULAIRE DES EMPLOYES FEDERAUX DE LEST DU QUE-BEC\", held in Québec, on July 11, 1973.it was unanimously resolved that the affairs of said Union be wound up and that the latter be dissolved, pursuant to the Savings and Credit Unions Act and to the Winding-Up Act, and that Mr.André Desrochers be appointed liquidator.Québec, February 21, 1975.(10244 Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1975, 107' annfe, n° 10 2151 Vente par licitation Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( OUY LEFORT.dentiste, rési-No 05-012116-74.< VJ dant et domicilié au 42, rue ' Principale.Ste-Agathe-des-Monts.district de Terrebonne, et DAME LOUISET-TE LEFORT, veuve non remariée de feu Pierre Liboi-ron, résidant et domiciliée à 44, Prieur, dans les ville et district de Montréal, et JACQUES LUSSIER, fonctionnaire, résidant et domicilié au 10795, rue Waverley, dans les ville et district de Montréal, tous trois ès-qualité.héritiers de la succession de feu Angelina Roy Lussier, de son vivant, résidant et domiciliée à Montréal, demandeurs, rs PIERRE-YVES GIROUX, résidant et domicilié à 2200, rue Chapdeleine.app.902, Ste-Foy.district de Québec, et DAME LIETTE GIROUX, épouse séparée de biens de Louis Monier.résidant et domiciliée au 5340, rue Nante, Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, tous deux ès-qualité, héritiers de la Succession de feu Angelina Roy Lussier, de son vivant, résidant et domiciliée dans les ville et district de Montréal, défendeurs.Conformément au jugement de l'Honorable Juge Ruston B.Lamb, de la Cour Supérieure, pour le district de Montréal, en date du 21e jour de janvier 1975.ordonnant la licitation de l'immeuble ci-après décrit: \u2022 Un emplacement sans bâtisse, situé à Montréal, ayant front sur le côté nord-ouest du boulevard Mai-sonneuve, borné d'un côté par la rue Cartier et de l'autre côté par la rue Dorion, ayant une superficie de douze mille cent quatre-vingts pieds et quatre dixièmes de pied carré, mesure anglaise plus ou moins, et composé des subdivisions sept.huit.neuf-A, et du lot un de la subdivision six, toutes du lot originaire six cent quinze (615-7-8-9A et 6-1), et du lot originaire cinq cent soixante et un de la partie nord-ouest du lot cent soixante (561 et P.N.O.560) tous des plans et livre de renvoi officiels du quartier Ste-Marie.ladite partie nord-ouest du lot cinq cent soixante (560) mesurant cinquante-deux pieds et huit dixièmes de pied de largeur et trente-cinq pieds de profondeur et étant bornée en front au sud-est par le boulevard Maisonneuve ou résidu dudit lot cinq cent soixante (560); en arrière au nord-ouest par ledit lot cinq cent soixante el un (561); d'un côté au nord-est par la rue Dorion et de l'autre côté au sud-ouest, par partie de ladite subdivision 615-8, avec et sujet à tous droits et servitudes, s'y rattachant tel que le tout subsiste.> Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Montréal.10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le DIXIÈME jour d'AVRIL 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif.Le shfrif adjoint.Cour Supérieure.Paul St-Martin.Montréal, le 26 février 1975.60237-o Sale by Licitation Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( pUV LEFORT.dentist, resid-No.05-012116-74.< vj ing and domiciled at 42 ' principale Street.Sainte-Agathe-des-Monts, District of Terrebonne, and MRS.LOUI-SETTE LEFORT, unremarried widow of the late Pierre Liboiron.residing and domiciled at 44 Prieur, ni the City and District of Montreal, and JACQUES LUSSIER, civil servant, residing and domiciled at 10795 Waverley Street, in the City and District of Montreal, all three in their capacity as heirs to the estate of the late Angelina Roy Lussier, in her lifetime residing and domiciled in Montreal, plaintiffs, vs PIERRE-YVES GIROUX.residing and domiciled at 2200 Chapdeleine Street.Apt.902.Sainte-Fov, District of Québec, and MRS.LIETTE CIROUX, wife separate as to property of Louis Monier, residing and domiciled at 5340 Nante Street, Trois-Rhieres, District of Trois-Rivières, both in their capacity as heirs to the estate of the late Angelina Roy Lussier, in her lifetime residing and domiciled in the City and District of Montreal, defendants.In conformity with a judgment rendered by the Honourable Justice Ruston B.Lamb, of the Superior Court, for the District of Montreal, dated the 21st day of January 1975.ordering the sale by licitation of the following immoveable: \"An emplacement without buildings, located in Montreal, fronting on the northwest side of Maisonneuve Boulevard, hounded on one side by Cartier Street and on the other side by Dorion Street, covering an area of twelve thousand one hundred eighty and four tenths square feet, English measure, more or less, and comprising subdivisions seven, eight, nine-A.and lot one of subdivision six.all of the original lot six hundred fifteen (615-7-8-9A and 6-1) and original lot five hundred sixty-one and the northwest part of lot five hundred sixty (561 and N.W.Pt.560) all on the official plan and in the book of reference for Sainte-Marie Ward, the said northwest part of lot five hundred sixty (560) measuring fifty-two and eight tenths feet in width by thirty-five feet in depth and bounded in front on the southeast by Maisonneuve Boulevard or the remainder of said lot five hundred sixty (560); in rear on the northwest by the said lot five hundred sixty-one (561 ) ; on one side on the northeast by Dorion Street and on the other side on the southwest by a part of said subdivision 615-8, the whole as it presently subsists with and subject to all rights and servitudes attaching thereto.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House of Montreal, 10 Craig Street East, 10th Floor.Room 56.on the TENTH day of APRIL.1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office.Paul St-Martin, Superior Court.Assistant Sheriff.Montreal.February 26.1975.60237 2152 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.March 8.1975.Vol.107.No.10 Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.BEDFORD Canada Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Bedford f/\"\"WASCO INC., demande-No 455-05-000610-74.S V-> resse r.» CORELL IX-< DUSTRIES LIMITED, dé-fenderesse.« Un emplacement sis et situé à Granby.comté de Shefford.connu et désigné comme étant partie des lots numéro cinq cent cinquante-huit et cinq cent cinquante-neuf (Ptie 558 et Ptie 559) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Granby, division d'enregistrement de Shefford, maintenant connues comme étant le lot numéro vingt-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro cinq cent cinquante-huit (558-28) et le lot numéro quatorze de la subdivision officielle du lot originaire numéro cinq cent cinquante-neuf (559-14) aux plan et livre de renvoi officiels susdits.» Pour être vendu au Bureau d'enregistrement de Shefford, à Waterloo.MARDI, le VINGT-DEUXIÈME jour du mois d'AVRIL mil neuf cent soixante-quinze, à TROIS heures de l'après-midi.Cowansville, ce 27 février 1975.Le shérif.60250-0 Antonin Bourassa.Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Bedford ( JEAN MARIE DUPUIS, No 455-05-000134-74.< J commerçant domicilié à Kromptonville, district de St-François, demandeur, vs MOTEL VAL ORFORD, corporation légalement constituée, ayant une place d'affaires à R.R.l Eastman, District de Bedford, défendeur.« La subdivision numéro sept du lot originaire numéro deux cent trente-neuf (239-7) du cadastre officiel du canton de Stukely, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Shefford à Waterloo, MERCREDI, le VINGT-TROISIÈME jour du mois d'AVRIL mil neuf cent soixante-quinze à TROIS heures de l'après-midi.Cowansville.ce 27 février 1975.Le shérif.60252-O ANTON» Bourassa.Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEDFORD Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Bedford I /-WASCO INC.plaintiff No.455-05-O00610-74X V-1 versus CORELL 1NDUS-' TRIES LIMITED, defendant.\"An emplacement lying and situate in Granby, County of Shefford.known and described as being part of lots number five hundred fifty-eight and five hundred fifty-nine (Pt.558 and Pt.559) on the official plan and in the book of reference of the cadastre for the Township of Granby, Shefford Registration Division, now-known as being lot number twenty-eight of the official subdivision of original lot number five hundred fifty-eight (558-28) and lot number fourteen of the official subdivision of original lot number five hundred fifty-nine (559-14) on the aforesaid official plan and in said book of reference.\" To be sold at the Shefford Registrv Office, in Waterloo, on TUESDAY, the TWENTY-SECOND day of APRIL, one thousand nine hundred seventy-five, at THREE o'clock in the afternoon.Cowansville, February 27, 1975.Antonin Bourassa, 60250 Sheriff.Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Bedford I JEAN MARIE DUPUIS, No.455-05-000134-74.< J merchant, residing in ' Bromptonville, District of Saint-François, plaintiff, vs MOTEL VAL ORFORD, a corporation legally incorporated, having a place of business on Rural Route No.1, Eastman, District of Bedford, defendant.\"Subdivision number seven of original lot number two hundred thirty-nine (239-7) on the official cadastre for the Township of Stukely, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Shefford Registry Office, in Waterloo, on WEDNESDAY, the TWENTY-THIRD day of APRIL, one thousand nine hundred seventy-five at THREE o'clock in the afternoon.Cowansville, February 27, 1975.Antonin Bourassa.60252 Sheriff. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mars 1975.107- année, n° jo 2153 Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Bedford i \"D EAL PARENT, demanderesse, vs No 3410.{ SHEFFORD LUMBER COM- l PANV LIMITED, défendeur.Une ferme sise et située dans le Canton est de Farnham (Que.) et composée des lots suivants, savoir: Les numéros vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre c;nt trois (403-24-25-26-27-28-29-30-31).et L;s lots numéro six.sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt et un, vingt-deut, vingt-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre c:nt dsux (402-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 23-21-22-25).du cidastre officiel de la partie est du Canton de Farnham.Pour être vendu au Bureau d'enregistrement de Brome, à Knowlton, district de Bedford.JEUDI, le VINGT-QUATRLÈME jour du mois d'AVRIL 1975 à DEUX heures de l'après-midi.Cowansville, ce 27 février 1975.Le shérif, 60254-o Antonin Bourassa.Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Bedford I P)AME LUCILLE SCHINCK, deman-No 2651.< -L-* deresse.vs MARCEL GINCE, dé-l fendeur.« Un certain terrain faisant partie du lot numéro vingt « J » (Pt.20J) du dixième rang du canton de Granby, paroisse Ste-Cécile-de-Milton, décrit et borné comme suit: Commençant sur le côté nord du chemin public, sur la ligne de division entre les lots 21E et 20.1; de là vers l'est, le long du chemin public susdit, une distance de cent quarante pieds; de là tournant à angle droit vers le nord, une distance de cent vingt pieds; de là tournant à angle droit vers l'ouest, une distance de quarante pieds; de là tournant à angle droit vers le nord, une distance de deux cent cinquante pieds; de là tournant à angle droit vers l'ouest, une distance de cent pieds; de là longeant la ligne ouest du lot 20.1 une distance de trois cent soixante-dix pieds, jusqu'au point de départ.Avec bâtisses dessus construites.Borné au nord, à l'est, par le résidu dudit 20J.au sud par le chemin public, à l'ouest par le lot 21E ou propriété de Bernard Boyer ou représentants.* Pour être vendu au Bureau d'enregistrement de Shefford, à Waterloo, district de Bedford, MARDI, le VINGT-DEUXIÈME jour du mois d'AVRIL 1975, à DEUX heures de l'après-midi.Cowansville, ce 27 février 1975.Le shérif, 60257-o Antonin Bourassa.Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Bedford I *D EAL PARENT, plaintiff, vs SHEF-No.3410.< ^ FORD LUMBER COMPANY l LIMITED, defendant.A farm lying and situate in the eastern part of the Township of Farnham.P.Q.and comprising the following lots: Lots numbers twenty-four, twenty-five, twenty-six.twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty and thirty-one of the official subdivision of original lot number four hundred and three (403, 24-25-26-27-28-29-30-31).and: Lots numbers six, seven, eight, nine, ten.eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two and twenty-three of the official subdivision of original lot number four hundred and two (402-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23).on the official cadastre for the eastern part of the Township of Farnham.To be sold at the Brome Registry Office, in Knowlton, District of Bedford, on THURSDAY, the TWENTY-FOURTH day of the month of APRIL 1975 at TWO o'clock in the afternoon.Cowansville, February 27, 1975.Antonin Bourassa, 60254 Sheriff.Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Bedford { \"K/fRS.LUCILLE SCHINCK.plaintiff, No.2651À ts MARCEL GINCE, defendant.\"A certain piece of land forming part of lot number twenty \"J\" (Pt.20J) in the Tenth Range of the Township of Granby, Parish of Sainte-Cécile-de-Milton, described and bounded as follows: Starting on the north side of the public road, on the dividing line between lots 21E and 20J; thence towards the east, along the aforesaid public road over a distance of one hundred forty feet; thence turning at right angles towards the north, over a distance of one hundred twenty feet; thence turning at right angles towards the west, over a distance of forty feet; thence turning at right angles towards the north, over a distance of two hundred fifty feet; thence turning at right angles towards the west, over a distance of one hundred feet; thence along the west line of lot 20J over a distance of three hundred seventy feet, up to the starling point.With the buildings erected thereon.Bounded on the north and on the east by the remainder of said lot 20J.on the south by the public road, on the west by lot 21E.i.e., the property owned by Bernard Boyer or representatives.\" To be sold at the Shefford Registry Office, in Waterloo, District of Bedford, on TUESDAY, the TWENTY-SECOND day of APRIL, one thousand nine hundred seventy-five, at TWO o'clock in the afternoon.Cowansville, February 27, 1975.Antonin Bourassa, 60257 Sheriff. 2154 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 8, 1975, Vol.107, No.10 Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Québec f yvAME BEATRIX PIMM YOUNG, No 774,959 \\ veuve de John Young, de Vancou- ' ver-Ouest, Colombie Britannique, et y résidant au numéto 570, 18e Rue, appartement 9, demanderesse, vs GORDON F.H.CLEMENTS, administrateur, des ville et district de Montréal, province de Québec, et y résidant au numéro 4085, avenue Kensington, défendeur.« Ce certain emplacement vacant situé dans le canton de Sutton, comté de Brome, faisant partie du lot numéro cinq cent quatre-vingt-dix-huit (598) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Sutton, et borné comme suit: Au nord par un chemin public: au sud par la ligne de division entre les cinquième et sixième rangs; d'un côté, vers l'est, par le résidu dudit lot cinq cent quatre-vingt-dix-huit: et de l'autre côté, vers l'ouest, par le lot numéro cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (599), ladite partie mesurant six cent quarante pieds (640') de largeur sur toute la profondeur qu'il existe entre ledit chemin public et ladite ligne de division entre les cinquième et sixième rangs, la ligne est de ladite propriété présentement hypothéquée étant parallèle à la ligne de division entre lesdits lots cinq cent quatre-vingt-dix-huit et cinq cent quatre-vingt-dix-neuf, et située à une distance de six cent quarante pieds (640') de ladite ligne de division entre lesdits lots cinq cent quatre-vingt-dix-huit et cinq cent quatre-vingt-dix-neuf.Toutes les mesures données ci-dessus sont en mesure anglaise, et plus ou moins.Ladite partie du lot cinq cent quatre-vingt-dix-huit (598) présentement décrite est délinééc en rouge sur un tracé annexé au titre antérieur de l'emprunteur.Telle que ladite propriété se trouve présentement avec tous ses droits, membres et circonstances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Brome à Knowlton, district de Bedford, JEUDI, le VINGT-QUATRIÈME jour d'AVRIL 1975, à TROIS heures de l'après-midi.Cowansville, ce 27 février 1975.Le shérif, 60255 Antonin Bourassa.Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Bedford l ROULAIS & COUTURE INC., No 11286.< *-> demandeurs, vs ROLAND VER-} TEFEUILLE, défendeur.« Un terrain, de forme rectangulaire, situé dans la municipalité de Rainville, sur le côté sud-ouest de la route 40, connu et désigné comme étant partie du lot numéro cent quatre-vingt (Ptie lot no 180) du cadastre officiel de la Paroisse Saint-Romuald-de-Farnham.Ledit terrain, mesurant cent vingt-cinq pieds (125') dans ses lignes nord-est et sud-ouest et deux cents pieds (200') dans ses lignes sud-est et nord-ouest, mesures anglaises, est borné comme suit: Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Québec t T^AME BEATRIX PIMM YOUNG, No.774,959s widow of the late John Young, I of West Vancouver, British Columbia, and there residing at 570 - 18th Street, Apartment 9, plaintiff, vs GORDON F.H.CLEMENTS, Executive of the City and District of Montreal, Province of Quebec, and there residing at 4085 Kensington Avenue, defendant.\"That certain vacant emplacement situated in the Township of Sutton, County of Brome, forming part of lot five hundred and ninety-eight (598) of the official plan and hook of reference of the Township of Sutton, and bounded as follows: To the north by a public road; to the south, by the line of division between the Fifth and Sixth Ranges; on one side, towards the east, by the remainder of said lot five hundred and ninety-eight; and on the other side, to the west, by lot number five hundred and ninety-nine (599), said part measuring six hundred and forty feet (640') in width by the entire depth between the said public road and the said line of division between the Fifth and Sixth Ranges, the eastern boundary of the said property hereby hypothecated being parallel to the line of division between said lots five hundred and ninety-eight and five hundred and ninety-nine, and at a distance of six hundred and forty feet (640') from the said line of division between said lots five hundred and ninety-eight and five hundred and ninety-nine.All the above measurements are English measure more or less.The said part of lot five hundred and ninety-eight (598) hereby described is shown edged in red on a sketch annexed to a previous title of the borrower.As the said property now subsists with all its rights, members and appurtenances.\" To be sold at the Brome Registry Office in Knowlton, District of Bedford, on THURSDAY, the TWENTY-FOURTH day of APRIL, 1975, at THREE o'clock in the afternoon.Cowansville, February 27, 1975.Antonin Bourassa, 60255-o Sheriff.Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Bedford ( TJOULAIS & COUTURE INC., plain-No.11286.< -D tiffs, vs ROLAND VERTE-
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.