Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 février 1975, Partie 1 samedi 1 (no 5)
[" OFF A11E8 G3/ PTIE1 EX.2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° S 1115 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Editeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazelle officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contientdesavis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazelle officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mardi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le lundi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be s.'ecified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Thuesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Monday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 1116 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: S5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1) : du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, S10.X.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: S3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, S20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Quebec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Quebec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Editeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1976, 107' année, n° 6 1117 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Compagnies \u2014 Loi des Companies Act Lettres patentes (1 \" partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Norn / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ACCOMMODATION AGAPO INC.1359-4460 ADMINISTRATION R.M.H.LTEE.and its English version R.MJI- ADMINISTRATION LTD.1369-7701 AGENCE D'ASSURANCE GENERALE BILL KLEIN INC.and its English version BILL KLEIN GENERAL INSURANCE AGENCY INC.1369-8412 AGENCE DE VOYAGE LAHOUD INC.and its English version LAHOUD TRAVEL AGENCY INC.1360-1605 AMENAGEMENT DOMAINE DES LACS INC.et sa version anglaise DOMAIN OF LAKES DEVELOPMENT INC.1370-6016 APPAREILS ORTHOPEDIQUES B.B.G., INC.and its English version B.B.G.ORTHOPEDIC APPLIANCES, INC.1370-6148 ATELIER DE CARROSSERIE OUTAOUAIS INC.et sa version anglaise OUTAOUAIS AUTO BODY SHOP INC.1370-3137 AZTECART INC.1360-0680 BOURMOND LIMITEE.et sa version anglaise BOURMOND LIMITED 1360-6679 BOUTIQUE CALECHE INC.1370-4507 BOUTIQUE LE COIN DE L'AMITIE INC.1359-3363 CABLODIFFUSION DE LA RIVE-NORD INC.1361-1728 CALCULATEC INC.1359-8701 CAMPING HAUT-DES-COTES INC.1360-2660 900, 9e Avenue, Charny 450, rue Sherbrooke est, app.200C, Montréal 30 09 74 23 09 74 5767, avenue Decelles, Montréal.23 10 74 285, rue Jean-Talon est, Montréal.03 12 74 Montréal 05 12 74 Westmount.06 12 74 150, Adrien-Robert, Hull.Montréal 1, Place Ville-Marie, suite 930, Montréal 2050, rue Crescent, Montréal.3200, boulevard Lapinière, Brossard.Québec.6020, de Salaberry, Montréal.46, Belle-Rivière, Mirabel.07 11 74 01 11 74 06 12 74 20 11 74 .25 09 74 10 01 75 23 10 74 13 11 74 1118 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Nom J Name Siège social / Head Office Incorporation Date CAMPING LAC AUX BOULEAUX INC.1360-6868 CENTRE DOMICILIAIRE DU VILLAGEOIS INC.1358-6664 CENTRE MINI PRIX BELANGER INC.1360-0283 CENTRE DE SERVICE OUELLET & POIRIER INC.1360-7148 COFFRAGE C.K.LTEE.et sa version anglaise C.K.FRAMEWORK LTD.1360-3535 LES COFFRAGES DE L'EST INC.1360-5415 LA COMPAGNIE D;ADMINISTRATION ALBRIGHT LTEE and its English version ALBRIGHT MANAGEMENT COMPANY LTD.1370-6494 LA COMPAGNIE DE GESTION RENE LAFRANCE INC.1360-5258 COMPAGNIE DE GESTION THEO CHRISTIE LTEE.and its English version THEO CHRISTIE HOLDINGS LTD.1370-5587 CONSTRUCTION G.BESNER INC.et sa version anglaise G.BESNER CONSTRUCTION INC.1359-5376 CONSTRUCTION G.I.LTEE.and its English version G.I.CONSTRUCTION LTD.1360-4608 LA CORPORATION DEMENAGEMENT CLAREMONT.and its English version CLAREMONT DEVELOPMENT CORPORATION 1370-5496 CRAVATE LARAL INC.and its English version LARAL CRAVAT INC.1370-5710 RENE J.CYR INC.1370-4127 DACTYLO CAPITALE LTEE et sa version anglaise CAPITAL DACTYLO LTD.1360-7973 YVON DESROSIERS INC.1360-8815 GERARD DION & FILS INC.1370-4556 DUBE & ROY INC.1360-0069 JOS DUBREUIL ET FILS LTEE.1360-8807 Kingsey.09 12 74 Sainte-Foy.20 08 74 2466, rue Bélanger est, Montréal.31 10 74 Saint-Lambert.10 12 74 3012, Godefroy, Quartier Fabreville, 19 11 74 Laval 221, rue Adamsville, Bromont.02 12 74 4265, Edouard-Montpetit.Montréal.10 12 74 300, rue St-Sacrement.chambre 320, 29 11 74 Montréal 3555, boulevard Métropolitain, app.02 12 74 800, Montréal Gatineau.04 10 74 650.rue Sic-Marguerite.Montréal .27 11 74 465, avenue Claremont, Westmount.02 12 74 1435.rue Bleury, app.303, Montréal .03 12 74 87, rue Robert, Chateauguay.18 11 74 Ancienne-Lorette.13 12 74 Causapscal.18 12 74 166, rue St-Patrice.Saint-Liboire____ 21 11 74 Lorrainville.30 10 74 Sainte-Hénédine.18 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n\" 5 1119 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ECOLE DE SKI DE L'OUEST INC.and its English version WESTERN SKI SCHOOL INC.1370-3426 LES ENDUITS DE POLYURETHANE SPECIAL T.INC.et sa version anglaise SPECIAL T.POLYURETHANE COATINGS INC.1360-5068 11,774, boulevard Gouin, Pierrefonds .12 11 74 LES ENTREPRISES BEAU RIVAGE LTEE 1359-5863 LES ENTREPRISES BELMOS INC.1360-6975 LES ENTREPRISES CLAUDE MICHAUD INC.1370-4010 ENTREPRISES D'ELECTRICITE GERVAIS ROCH INC.1370-4895 LES ENTREPRISES J.-M.LAROUCHE INC.1360-3147 ENTREPRISES MIROJA INC.and its English version MIROJA ENTERPRISES INC.1370-3962 LES ENTREPRISES MONTPELLIER LTEE.et sa version anglaise MONTPELLIER ENTERPRISES LTD.1370-7583 EQUIPEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE CANADIEN LTEE and its English version CANADIAN HEALTH EQUIPMENT LTD.1370-4069 EXCAVATIONS L.CLOUTIER INC.1360-6694 EXECUMEDIC LTEE.and its English version EXECUMEDIC LTD.1370;:3392 FER ORNEMENTAL CONCORDIA LTEE.et sa version anglaise CONCORDIA METAL WORK LTD.1360-6744 FERMES RICHARD INC.1360-6538 FERMES W.DAME & FRERE INC.1370-5561 FERRONNERIE FERMONT INC.1360-3378 FILICO INC.1360-5670 LES FILS A COUDRE COMMERCIAUX M.K.LTEE.and its English version M.K.COMMERCIAL SEWING THREADS LTD.1360-3857 159, 4e Avenue.LaSalle.Montréal.Amos.227, Mgr De Belmon, Boucherville.28, Lusignan, L'Epiphanie.Port-Cartier.5757, avenue Decelles, suite 400, Montréal Montpellier Montréal.2207, Du Rhin, Québec.175, Stillview, app.138, Pointe-Claire.Laval.495, chemin Rive-Sud, Farnham.Saint^Chrysostome.Fermont.50, Place Crémazie, bureau 206, Montréal 12, Westpark, Dollard-des-Ormeaux 18 11 74 08 10 74 09 12 74 18 11 74 25 11 74 18 11 74 15 11 74 18 12 74 18 11 74 06 12 74 12 11 74 09 12 74 06 12 74 02 12 74 19 11 74 03 12 74 22 11 74 1120 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date FLEURISTE KAREN INC.and its English version KAREN FLORIST INC.1370-5918 FOURNITURE DARTS MARTIAUX ORIENTALE INC.and its English version ORIENTAL MARTIAL ARTS SUPPLIES INC.1369-6141 LES FOURRURES GILLES PERRON INC.1360-2156 Sainte-Thérèse 04 12 74 GALERIE CELINE INC.et sa version anglaise CELINE GALLERY INC.1360-6819 GARAGE JACQUES DAIGNEAULT INC.1360-7189 GARAGE JOSEPH JOLICOEUR INC.1370-4614 GERARD & FILS, BIJOUTIERS INC.and its English version GERARD & SON, JEWELLERS INC.1370-5504 GESTION VINGT-DEUX SOIXANTE-DIX LTEE.and its English version TWENTY-TWO SEVENTY HOLDING LTD.1360-7825 N.L.GINGRAS INC.1360-5183 ANDRE GIROUARD & FILS INC.1360-8088 LA GRANGE RUSTIQUE DU LAC SERGENT 1361-0936 LES GRAPHIQUES S.N.LTEE.and its English version S.N.GRAPHICS LTD.1370-5702 HABITATIONS GRENADE LTEE.and its English version GRANADA HOMES LTD.1370-3723 IDSA (CANADAS INC.1359-9691 IMMEUBLES GALVA LTEE.and its English version GALVA REALTIES LTD.1370-6445 IMMEUBLES HADERA LTEE.and its English version HADERA REALTIES LTD.1370-6437 IMMEUBLES METIL INC .1359-7513 LES IMMEUBLES T.S.C.INC.1360-0960 Montréal.10 09 74 2840, avenue de Lyon, Longueuil.Outremont.2374, rue Grant, Montréal.108, rue Levis, Joliette.Montréal.6165, rue Sherbrooke ouest, app.319, Montréal 3, rue de la Paix, Saint-Henri.60, du Filtre, Victoriaville.154, boulevard St-Vincent, Jouvence.Montréal.Montréal.1, Place Ville-Marie, app.930, Montréal 1, Place Ville-Marie, app.3635, Montréal 1, Place Ville-Marie, app.3635, Montréal IMPRIMERIE L.I.M.A.INC.1360-7163 Saint-Georges.Val-d'Or.2526, rue Watt, Sainte-Foy.12 11 74 09 12 74 10 12 74 21 11 74 02 12 74 12 12 74 29 11 74 13 12 74 06 01 75 03 12 74 13 11 74 29 10 74 10 12 74 10 12 74 17 10 74 04 11 74 10 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1121 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LES INDUSTRIES MANIC INC.1360-3527 Port-Cartier.LES INDUSTRIES SAGO INC.et sa version anglaise SAGO INDUSTRIES INC.1369-8592 LES INVESTISSEMENTS FABIEN INC.1360-7064 LES INVESTISSEMENTS LUMANT LTEE.and its English version LUMANT INVESTMENTS LTD.1360-2958 INVESTISSEMENTS LYFRAN INC.and its English version LYFRAN INVESTMENTS INC.1370-6155 JOAILLERIE ROBERT FAUBERT INC.1360-0515 LANDRICHARD LIMITEE.1359-9873 JACQUES LATENDRESSE INC.1360-8617 DANIEL LA VOIE INC.1370-5413 G.LEGAULT ci FILS INC.1360-9573 M.LOGUSH INC.J370-5884 MAÇONNERIE BOUFFARD INC.1360-9524 MAÇONNERIE PICHE ET ROBERT INC.1370-6676 LE MAGASIN 1,001 FANTAISIES LTEE.1370-1073 MAISONS MOBILES BEAUCE LTEE et sa version anglaise MOBILE HOMES BEAUCE LTD.1361-1660 MATELAS MARTIN INC.1370-6718 MEGATROLINC.1370-3848 MENUISERIE J.K.LTEE.and its English version J.K.WOODWORK LTD.1360-7353 MERCERIE L.GOULET INC.1360-6215 METAUX SATELLITE INC.and its English version SATELLITE METAL INC.1370-0299 LE MIEL PUR DU LAC ST-JEAN INC.1359-8305 9737, boulevard Ste-Anne, Sainte-Anne-de-Beauprè 5513, rue Vemeuil, Anjou.1, Carré Westmount, Montréal.1, Place Ville-Marie, suite 1734, Montréal 50, rue Dufferin, Salaberrv-de-Valleyfield 114, rue Ste-Louise, Saint-Jean-de-Matha 7180, Route 18, Chertsey.6130, Montée St-Calixte.Saint-Cal ixte 5960.rue Alphonse, Brossard.44, avenue Russell, Mont-Royal.Route rurale numéro 1.Sainte-Rosalie Saint-Jovite.5646, rue Bertrand, Brossard.Saint- Joseph-de-Beauce.5786, Souligny, Montréal.6392, rue Notre-Dame ouest, Montréal Montréal.62A, rue Cherrier, Repentigny 69, Président Kennedy, Blainville 10 30 09 15 11 74 09 74 12 74 11 74 06 12 74 09 30 17 29 23 04 23 11 22 10 12 14 11 06 25 12 74 10 74 12 74 11 74 12 74 12 74 12 74 12 74 10 74 01 76 12 74 11 74 12 74 12 74 11 74 Hébertville.21 10 74 1122 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.6 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date MODES CUTI QUE INC.and its English version CUTIQUE FASHIONS INC.1370-4317 ROLAND MONAST LTEE.1360-3907 RENAUD MORISSETTE INC.1356-9041 MULTISOL INC.1370-4863 NAUTITEC INC.1370-2717 DAVID OUELLET LTEE.1360-2719 PAPIER & FICELLE CANADIEN LTEE .and its English version CANADIAN PAPER * TWINE LTD.1360-7098 PIERRE-FRANCIS, BIJOUTIER INC.1370-7013 LES PLACEMENTS GAZELLE LTEE.and its English version GAZELLE HOLDINGS LTD.1360-5191 LES PLACEMENTS JEAN-CLAUDE BRUNELLE INC.1360-2263 LES PLACEMENTS P.B.L.LTEE.1360-6614 LES PLACEMENTS PENTAGAM INC.1370-4648 PLANAM INC.1360-5969 PLOMBERIE CHRISTIAN LAROCQUE INC.1360-3543 LES PNEUS MATTHIEU INC.1360-8112 POLISSAGE DE MEUBLES MATTE (QUEBEC) INC.and its English version MATTE FURNITURE POLISHING (QUEBEC) INC.1360-9334 LES POMPES CARTIER INC.et sa version anglaise CARTIER PUMPS INC.1370-6663 LES PRODUCTIONS SNACK INC.1370-4713 PROVISIONS APPLETON INC.and its English version 'APPLETON PROVISIONS INC.1360-2727 LES PUBLICATIONS AFFA LTEE.1360-7841 3,400 boulevard Métropolitain est, Montréal 414, rue Notre-Dame.Gatineau.840.Place Désormeaux, Sherbrooke 151, 7e Avenue, Laval-des-Rapides 29, rue St-Louis, Saint-Esprit.La Pocatière.12.020, rue Albert Hudon, Montréal Nord Montréal 800, Carré Victoria, app.612.Montréal Saint-Eustache.Aima.514, Champlain, Saint-Jean.Saint-Nicolas.8276, rue Ledoux, Saint-Hyacinthe .851, rue St-Georges, Saint-Jérôme.2830, rue Lafrance.Saint-Laurent- 19 11 74 23 12 74 03 06 74 26 11 74 04 11 74 14 11 74 09 12 74 13 12 74 29 11 74 12 11 74 02 12 74 22 11 74 04 12 74 19 11 74 13 12 74 19 12 74 140, 8e Avenue.Saint-Ambroise.02 12 74 1595, rue Saint-Hubert, Montréal.3593, avenue Appleton, app.10, Montréal Québec 22 11 74 14 11 74 12 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1915, 107' année, n° 5 1123 Nom / Name PUBLICITE COGEM INC.and its English version COGEM ADVERTISING INC.1370-7823 PUBLICITE GEORGES & FILS INC.1370-4135 QUINCAILLERIE BOURGAULT INC.1360-9672 QUINCAILLERIE R.C.O.INC.1359-3157 REDISTRIBUTION INTERRIVE INC.et sa version anglaise INTERSHORE REDISTRIBUTION INC.1360-3949 RESTAURANT ETOILE DU NORD INC.et sa version anglaise NORTH STAR RESTAURANT INC.1360-2016 RESTOSERV.INC.1356-2103 PIERRE ROBERGE ET ASSOCIES INC.1370-5033 DENIS ROUSSEAU INC.1360-8989 S.H.R.M.QUEBEC INC.1360-6769 SABLE PONT ROUGE INC.1360-3188 LES SABLIERES LAURENTIENNES LTEE.1370-4465 SALON V.E.INC.1370-5470 SERVICES ADMINISTRATIFS V.B.K.INC.et sa version anglaise V.B.K.ADMINISTRATIVE SERVICES INC.1370-8490 LES SERVICES ALIMENTAIRES LORRAINE (QUEBEC) INC.and its English version LORRAINE FOOD SERVICES (QUEBEC) INC.1360-0911 SERVICES FINANCIERS CANSWI LTEE.et sa version anglaise CANSWI FINANCIAL SERVICES LTD.1370-4283 SERVICE GUY LAFONTAINE INC.1359-4254 LES SERVICES TRANSITAIRES CAN-AM QUEBEC LTEE.and its English version CAN-AM FREIGHT SERVICES QUEBEC LTD.1360-5779 SOCIETE D'EMBALLAGE A.C.E.LTEE.and its English version A.C.E.PACKAGING CORPORATION LTD.1360-4954 Incorporation Siège social / Head Office Date 1420, rue Sherbrooke ouest, 19 12 74 Montréal 6585, Casgrain, Montréal.18 11 74 Rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli.20 12 74 1,984, Route Nationale numéro 2, 24 09 74 Sainte-Foy ForestvUle.22 11 74 174, rue St-Louis, Pointe-Gatineau.11 11 74 1090, avenue Murray, Québec.01 05 74 4470, de Salaberry, app.204, Montréal 26 11 74 16, rue Principale, Saint-Jean-de-Dieu.19 12 74 615, Dorchester ouest, app.1010, 09 12 74 Montréal 200, boulevard Notre-Dame, Pont- 18 11 74 Rouge 179, Roseval, Laval.20 11 74 1117, rue Ste-Catherine ouest, app.02 12 74 606, Montréal 612, rue St-Jacques, suite 703, 30 12 74 Montréal 10,600, Secant, Anjou.04 11 74 1155, boulevard Dorchester ouest, 19 11 74 app.3900, Montréal 1249, Dornier, Fleurimont.04 11 74 465, rue St-Jean, app.605, Montréal .03 12 74 4527, Plamondon, Montréal.28 11 74 1124 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.6 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date TECHSEL INC.1359-7026 LES TOILETTES CHIMIQUES MODERNES ET A CHASSE J.B.INC.and its English version J.B.MODERN CHEMICAL AND FLUSH TOILETS INC.1360-4178 TRANSIT P.M.INC.1370-7618 TRAVAUX D'USINAGE GENERAUX KONCZ INC.and its English version KONCZ GENERAL MACHINE WORKS INC.1370-2360 MARCEL VALLIERES INC.1360-9177 VENTES D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES O DASH INC.and its English version 0.DASH ELECTRICAL SALES INC.1360-93ÔU VENTILATION C.A.S.(DORCHESTER) INC.1370-6817 VETEMENTS SPORTS PO-GOL INC.and its English version PO-GOL SPORTSWEAR INC.1370-4408 AS.WILSON.LANDRIAU ET ASSOCIES LTEE.1370-4986 Montréal.15 10 74 5005, rue Irwin, LaSalle.26 11 74 423, rue Jean-Claude.Bois-des-Filions.17 12 74 7699, 18e Avenue, Saint-Michel.31 10 74 2026, 1ère Avenue, Québec.19 12 74 415, avenue Bourque, suite 132, 19 12 74 Dorval 17, rue Morin, Saint-Anselme.12 12 74 9475, rue Meilleur, Montréal.09 10 74 204, Notre-Dame ouest, app.23.26 11 74 59795-0 Le directeur du service de» compagnies, Pierre Desjardins.59795-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Administrateurs (Article 84) Directors (Section 84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont modifié le nombre de leurs administrateurs whose names follow have changed the number of their directors tel qu'indiqué ci-après.as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of company Date de constitution Date of incorporation Nombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Previous number Nouveau nombre New number BEDFORD INDUSTRIES LTD.LES INDUSTRIES BEDFORD LTEJE 1213-7907 LE CENTRE AMICAL DE JONQUIERE INC.1359-8024 EASTERN CLAIMS ADJUSTERS (QUEBEC) LTD.AGENTS DE RECLAMATIONS DE L'EST (QUEBEC) LTEE 4027-64 GU8 EISENKRAFT INC.1108-9299 14 01 70 21 10 74 10 09 64 24 09 42 7 10 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1976, 107' année, n' 5 1125 Nom de la compagnie Name of company Date de constitutions Dale of incorporation Nombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Previous number Nouveau nombre New number EZHIL INVESTMENTS LTD.30 08 62 13589-62 FOREX INC.23 10 68 1212-7718 GESTION MAXWELL LTEE.06 08 73 MAXWELL HOLDINGS LTD.733392 HAUTE COIFFURE DARRELL LTEE.13 05 64 DARRELL HAUTE COIFFURE LTD.1122-7071 LANA-LEE FASHIONS INC.13 06 47 1114-7501 THE QUEBEC VENEER INDUSTRIES COMPANY 10 03 34 LIMITED LES INDUSTRIES DE PLACAGE DE QUEBEC LIMITEE 342-34 SERIGRAPHIE DRUMMOND INC.04 03 74 1354-8060 SERVICES DE RECLAMATIONS MIRON ET 26 10 74 BOYTE INC.1370-1511 SOCIETE CANADIENNE DE GESTION EN RE- 26 05 70 ASSURANCE.INC.et sa version anglaise REINSURANCE MANAGEMENT COMPANY OF CANADA.INC.2322-70 5 6 4 4 3 4 4 59795-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre De&jardinb.69795-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a accordé des lettres patentes supplémentaires à: Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes AGENCE INTERNATIONALE DE CREDIT 31 05 63 11 12 74 Etendant les pouvoirs / Extending the 2392-63 powers.ARGON INDUSTRIAL CORP.04 11 63 06 09 74 Modifiant le capital / Altering the capital.4706-63 L'ASSOCIATION SPORTIVE DES POLICIERS 03 02 68 28 10 74 1.Modifiant le capital / Altering the capital.D'AS6EST08 INCORPOREE 2.Etendant les pouvoirs / Extending the 13061-57 powers.3.Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent. 1126 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.6 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes CHARLES-E.BEDARD LTEE.22 11 66 1167-8242 BONAIR INVESTMENTS CORPORATION.22 12 61 16179-61 03 11 71 CAST AMERIQUE DU NORD (AGENCES) LTEE and its English version CAST NORTH AMERICA (AGENCIES) LTD.716882 CENTRE LINGUISTIQUE DU SAGUENAY.15 09 71 3254-71 CHANTEX INC.17 04 46 2933-45 CHENEVERT LTEE.13 12 51 15170-51 LA CORPORATION DES LOISIRS DE SAINT-ZEPHIRIN 1401-66 26 07 66 CREDIT LYONNAIS CANADA LIMITED 10 01 74 CREDIT LYONNAIS CANADA LIMITEE 1357-1542 LES CREDITS SUBITO LIMITEE.29 09 67 4138-67 LES DEVELOPPEMENTS D.D.O.INC.15 12 60 and its English version D.D.O.DEVELOPMENT INC.1143-6540 LES DISTRIBUTIONS PERROT LTEE.08 05 72 et sa version anglaise PERROT DISTRIBUTIONS LTD.722609 DOMAINE MARLBORO INC.20 04 70 1757-70 DORIA BOISJOLI LTEE.19 12 63 1184-2523 EQUILEASE LTEE.19 06 61 et sa version anglaise EQUILEASE LTD.1129-7421 GINGRAS.GILBERT 4 ASS.INC.24 08 71 714484 11 12 74 1.Modifiant le capital I Altering the capital.2.Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent.27 11 74 Modifiant le capital I Altering the capital.07 11 74 1.Ancien nom / Former name: SEALEASE LTD.2.Etendant les pouvoirs / Extending the powers.25 10 74 1.Modifiant les pouvoirs/Modifying the powers.2.Augmentant la valeur des biens immobiliers / Increasing the value of immoveable properly.29 11 74 Modifiant le capital / A Uering the capital.05 12 74 1.Ancien nom / Former name: RAOUL CHENEVERT LIMITEE.2.Modifiant le capital / Altering the capital.3.Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent.16 12 74 1.Augmentant la valeur des biens immobiliers / Increasing the value of immoveable property.2.Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent.06 01 75 1.Modifiant le capital / Altering the capital.2.Modifiant quelques dispositions des lettres patentes / Amending some provisions of the letters patent.06 12 74 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent.30 10 74 Ancien nom / Former name: COLUMBIA BUILDERS SUPPLY CO.02 12 74 1.Ancien nom / Former name: DOMAINE PERROT LTEE.2.Etendant les pouvoirs / Extending the powers.24 09 74 1.Modifiant le capital I Altering the capital.2.Modifiant les privilèges et restrictions Modifying the privileges and restrictions.26 11 74 Modifiant le capital I Altering the capital.18 10 74 Ancien nom / Former name: EQUILEASE COMPANY LTD.19 11 74 Ancien nom / Former name: GINGRAS GILBERT, COTE, TREMBLAY 4 ASSOCIES. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n' 6 1127 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changée INOV (CANADA) INC.01 09 70 3788-70 JERDEB ENTERPRISES LTD.06 07 65 3095-65 LOCATIONS DELOCO INC.30 01 67 390-67 MINIBUS FOREST INC.16 04 74 1367-8016 NU-WAY LAMBSKINS LTD.28 10 47 1139-8005 30 12 74 1.Modifiant le capital I Altering the capital.2.Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provi-eione of the letters patent.05 11 74 Modifiant le capital / Altering the capital.13 06 74 1.Ancien nom / Former name: RESTAURANT QUATRAIN INC.2.Modifiant le capital / A Itering the capital.3.Etendant les pouvoirs / Extending teh powers.4.Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / A mending certain provisions of the letters patent.28 10 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers.04 06 68 Ancien nom / Former name: NU-WAY LAMBSKIN PROCESSORS LIMITED.LES PLACEMENTS EN CO-PROPRIETE VARODUC INC.1222-69 17 03 69 PLOMBERIE CHAUFFAGE J.L.R.LIMITEE 14 04 71 1214-1784 LES PROPRIETES CONSOLIDEES CONSOP 29 03 74 LTEE and its English version CONSOP CONSOLIDATED PROPERTIES LTD.1367-5633 S7-.LAWRENCE BRICK CO.LIMITED.22 04 24 LA BRIQUETERIE 8T-LAURENT LIMITEE 1140-0108 STE.THERESE HOUSING INC.18 07 57 12294-67 8ECOMAT LTEE.16 01 59 14368-68 SERVICE D'AUTO M.8.R.INC.19 08 67 and its English version M.SR.AUTO SERVICE INC.1149-9829 SERVICES PUBLI-PHARM.INC.16 06 74 1366-6619 27 12 74 1.Ancien nom I Former name: LES PLACEMENTS VARODUC INC.2.Modifiant le capital / Altering the capital.3.Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent.06 11 74 Étendant les pouvoirs / Extending the powers.27 11 74 Modifiant le capital / Altering the capital.06 11 74 Modifiant le capital / Altering the capital.14 11 74 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes ' Amending certain provisions of the letters patent.06 12 74 1.Ancien nom I Former name: INTERNATIONAL CARRIERS' TERMINALS LTD.2.Modifiant le capital / Altering the capital 3.Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent.01 11 74 Ancien nom I Former name: GATINEAU AUTO LTD.09 08 74 1.Modifiant le capital I Altering the capital.2.Modifiant quelques dispositions des lettres patentes / Amending some provisions of the letters patent.3.Chaniccaut le nombre de» administrateur* Changing the number of directors. 1128 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.6 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes LE TEMPLE INTERNATIONAL DES REVELATIONS SPIRITUELLES THE INTERNATIONAL TEMPLE OF SPIRITUAL REVELATIONS 737548 03 07 73 24 10 74 Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent.TREBOR CANADA LTD.15 09 59 1114-3369 URQUIJO CANADA INC.21 02 74 1357-5667 19 11 74 Modifiant le capital / Altering the capital.30 10 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers.59795-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Debjardins.59795-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Changement de nom Change of name Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la T.oi des compagnies Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a approuvé les règlements de changement de nom suivants: panies Act, he has approved the by-laws changing the name of: Nouveau nom / New name Ancien nom Former name Incorporation Date ALARMES MIRABEL INC.SYSTEMES D'ALARME METRO 19 08 74 et sa version anglaise INC.MIRABEL ALARMS INC.et sa version anglaise 1369-3957 METRO ALARM SYSTEMS INC.NORMAND BOLDUC INC.MOTEL DE LA MARQUISE INC.23 08 66 2918-66 CONSTRUCTION SUD-OUEST LTEE.SOUTH WEST PAVING & LANDS- 27 05 64 etsa version anglaise CAPE COMPANY LTD.SOUTH WEST CONSTRUCTION LTD.1118-0973 GAUDET, CARON & ASSOCIES INC.LES AGENCES VIC GAUDET 13 04 73 736832 INC.VIC GAUDET AGENCIES INC.LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PLANETE LTEE.PLANET CONSTRUCTION LTD.12 04 73 et sa version anglaise CONSTRUCTION PLANETE PLANET ELECTRIC LTD.LTEE 736809 MATERIAUX DE CONSTRUCTION TRAHAM INC.TRAHAM ET FRERES INC.06 12 64 1134-2789 LES METAUX PRESSES QUEBEC INC.QUEBEC METAL PRESSING INC.06 04 46 et sa version anglaise QUEBEC METAL PRESSING INC.1156-1792 SOCIETE TERRES ARMEES LTEE.SOCIETE TERRES ARMEES INC.16 04 70 et sa vertion anglaise REINFORCED EARTH COMPANY LTD.1210-1705 50795-O Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59795-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 6 1129 Domicile légal (Article 30) Legal domicile (Section 30) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont établi leur bureau principal ou l'ont changé whose names follow have established their principal office or tel qu'indiqué ci-après.have changed it as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Domicile légal Legal domicile Date Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse .Veto address ACCURATE LOCKSMITHS OF MONTREAL 09 INC.SERRURIERS EXACTS DE MONTREAL INC.2223-69 L'ASSOCIATION DES HOPITAUX DE LA PRO- 18 VINCE DE QUEBEC THE ASSOCIATION OF HOSPITALS OF THE PROVINCE OF QUEBEC 13879-62 ASSOCIATION DES RESIDENTS DU DO- 05 MAINE WAEGENER INC.12816-62 LES ATELIERS BODYGUARD LTEE.23 BODYGUARD SHOPS LTD.2271-67 ATELIER CARMATECH INC.16 1359-1516 AUXILIARY SERVICE CORPS OP THE 15 ORDER OF MALTA (.QUEBEC) CORPS DE SERVICE AUXILIAIRE DE L'ORDRE DE MALTE (QUEBEC) 714388 BERNCAM LIMITEE.03 and its English version BERNCAM LIMITED 1369-9202 BIJOUTERIE R.A.LAROSE INC.26 R.A.LAROSE JEWELLERY INC.2553-70 CAFETERIA DESCOTEAUX 4 HARDY INC.22 3891-71 CAMPING STE-AGATHE-DES-MONTS INC.04 3216-68 CANYON REALTIES LTD.07 13254-62 CAVEN DEVELOPMENT'CO.LTD.06 COMPAGNIE D'AMENAGEMENT CAVEN LTEE 736518 CENTRE COMMUNAUTAIRE DU QUARTIER 12 ST-EDOUARD DE MONTREAL 2513-71 CENTRE INDUSTRIEL DE SEPT-1LES INC.08 et sa version nnglaise SEPT-ILES INDUSTRIAL CENTER INC.1370-3210 05 69 Saint-Laurent.12 62 505.boulebard Dorchester ouest, Montréal.1179, boulevard Décarie, Saint-Laurent.276, rue St-Jacques ouest, Montréal.07 62 Saint-Luc.95, rue Lemay, Saint-Luc.05 67 Montréal.1095.rue St-André, Montréal.09 74 Port-Cartier.117, Portages-des-Mousses, Port-Cartier.11 71 Montréal.434.Tour de la Bourse, Place Victoria, Montréal.10 74 Montréal.7101, avenue Park.5e étage.Montréal.05 70 Laprairie.408, rue Ste-Elizabeth, Laprairie.07 71 Lasalle.9465, rue Eastman, Lasalle.07 68 Sainte-Agathe-des-Monts.50.rue St-Joseph, Sainte- Agathe-des-Monts.08 62 1155, Dorchester ouest, 1010, Ste-Catherine ouest app.2601, Montréal.app.926, Montréal.03 73 4141, rue Sherbrooke 4460, rue Sherbrooke ouest, Montréal.ouest, Montréal.10 72 Montréal.11 74 Montréal.6246, rue De Norman-ville, Montréal.1, Place Ville-Marie, app.1636, Montréal. 1130 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address CERCLE SOCIAL FEMININ DE VILLE MONT-ROYAL, INC.3242-50 CHE G.CORNELI PIZZA ET SPAGHETTI INC.939-68 30 03 60 Mont-Royal.23 02 68 7196, rue St-Hubert, Montréal.CIMENT MICHAUD & BEDARD LTEE.1169-6564 CINE LAURENTIDES INC.3330-63 LA CLINIQUE METROPOLITAINE DU SEIN INC.2367-71 COMPTAMATIC (MONTREAL) INC.723158 20 06 61 Malartic.07 08 63 Montréal.17 06 71 Montréal.CONSTRUCTION F.T.B.INC.F.T.B.CONSTRUCTION INC.1356-0686 CROYDON ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES CROYDON INC.1138-8923 CUIR APACHE INC.and its English version APACHE LEATHER INC.1369-0458 DECOR SAINT-PIERRE INC.1369-5061 DIVERSIFIED DEVELOPMENT CORPORATION CORPORATION D'AMENAGEMENTS DIVERSIFIES 1355-2914 DOUBLE \" F \" FISH & GAME CLUB.C.C.P.108-65 E.Z.CONSTRUCTION INC.8-67 ENSEIGNE VICTO LTEE.1168-2946 LES ENTREPRISES MARCHAND LIMITEE.1149-0366 LES ENTREPRISES PIERRE SENECAL LTEE.PIERRE SENECAL ENTERPRISES LTD.734041 FASHION CLEANERS CORP.14397-61 LES FERMES JEAN-TALON INC.729426 LES FERMES KIRKLAND INC.K1RKLAND FARMS INC.1176-67 FUJI INDUSTRIAL SUPPLIES LTD.2657-66 06 06 72 Montréal.25 04 74 Sainte-Anne-de-Bellevue.18 10 67 Montréal.17 07 74 65, Louvain ouest, Montréal.29 08 74 Montréal.18 02 74 7250, Mile End, Montréal.05 10 66 Shawville.20 12 66 Montréal.04 08 67 Victorlaville.12 05 61 Sainte-Catherine-d'Alexan-drie-de-la-Prairie.14 09 73 L'Acadie.08 09 61 Montréal.23 11 72 Montréal.21 03 67 Montréal.04 06 65 456, rue Craig ouest, Bureau 502, Montréal.100, rue Thornton, Mont-Royal.3961, rue Masson, Montréal.191, rue Fournière, Malartic.1500, rue Stanley, Montréal 2276.rue Papineau, Montréal.225, rue Notre-Dame ouest, Montréal.26, rue Meloche, Sainte-Anne-de-Bellevue.5664, rue King Edward, Montréal.9100, boulevard St-Lau-rent, Montréal.8687, 8e Avenue, Montréal.2340, rue Lucerne, app.27, Montréal.Shawville.100, Côte Vertu, app.607, Montréal.303, Notre-Dame est, Victoriaville.21, avenue Lamarche, Sainte-Catherine-d'A-lexandrie-de-la-Prairie.194, Ruisseau-des-Noyers, l'Acadie.6480, rue Somerled, Montréal.1850, Place du Canada, Montréal.1245, rue Sherbrooke ouest, app.1205, Montréal.360.rue St-Jacques ouest, Montréal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er février 1975, 107' année, n° 5 1131 Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address GILTEX HOSIERY LTD.04 02 59 Montréal.550, Beaumont, Montréal.10593-59 LE GROUPE FOSBEC INC.30 10 74 Montréal.3, Place Ville-Marie, 1370-2170 suite 116, Montréal.HAMEL AUTO BODY INC.16 10 62 127A.rue St-Denis, 10, rue Grand-Trunck, 14136-62 Saint-Lambert.Saint-Lambert.HAYESST UART & CO.LIMITED.27 03 29 Montréal.297.rue Duke, Montréal.411-29 .IEANNOTTE GABANNA ET ASSOCIES INC.21 07 71 1444, rue Normand, 1695, boulevard le Corbu- 1215-4324 Laval.sier.app.202, Laval.L.M.J.CO.INC.25 08 65 121.Fernlea Crescent, 375.avenue Dobie.3781-65 Mont-Royal.Mont-Royal.LEGER HOIST EQUIPMENT INC.19 07 71 9590, rue Berri, Montréal.7995, 17e Avenue, PALANS ET OUTILLAGES LEGER INC.Montréal.3212-71 R.MASON INC.27 06 74 Richmond.115.rue Manning, 1357-5436 Richmond.MERICO LIMITED.21 01 63 Montréal.6170.boulevard Métro- 315-63 politain est, Montréal.MENUISERIE MONT-ROYAL INC.18 10 74 Saint-Laurent.631.rue Stinson.Saint- 1370-0802 Laurent.METRO INVESTMENTS LTD.09 01 52 Montréal.550.Beaumont, app.401, 1474-52 Montréal.WILFRID MONGEON LIMITEE.25 06 74 Gatineau.582, rue Notre-Dame.1357-3795 Gatineau.NATIONAL SURPLUS SALES INC.31 08 71 Montréal.2032.boulevard St- 1214-1883 Laurent, Montréal.OMORIAS MEAT & GROCERY LTD.30 01 68 Montréal.965.rue Jean-Talon, ouest.1101-5088 Montréal.PARC DE L'ANCRAGE INC.25 11 68 Rivière-du-Loup.82, boulevard Cartier, 5305-68 Rivière-du-Loup.WILLIAM PENCER & ASSOCIES LTEE.22 11 73 500, Place d'Armes, 1420.rue Sherbrooke ouest.WILLIAM PENCER & ASSOCIATES LTD.suite 1200, Montréal.app.601, Montréal.738S04 PETITCLERC ET DARVEAU INC.30 11 59 Québec.25S, rue Monaco, Québec.16462-59 PLACEMENT REGIONAL (ROUYN) INC.10 04 59 Rouyn.10, rue McQuaig.Rouvn.12184-59 HARRY L.RODIER & ASSOCIES INC.23 10 74 5165, chemin Queen 50.boulevard Crémazie and its English version Mary.Montréal.ouest.Montréal HARRY L.RODIER & ASSOCIATES INC.1359-8784 ROVALMOUNT CONSTRUCTION LIMITED\u2014 15 03 39 Montréal.178.avenue Willodale.1117-6013 Montréal.S.E.I.M.INC.12 01 67 Matane.616, rue St-ROdempteur.5077-06 Matane.S.P.RADIAL SERVICE INC.14 04 70 215, boulevard Labelle.tifiô, boulevard Labellc.1193-3154 Laval.Laval. 1132 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February Ut, 1975, Vol.107, No.5 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous addrese Nouvelle adresse New address LES SERVICES DE PROTECTION LA BANNIERE DE QUEBEC LTEE BANNER PROTECTION SERVICES OF QUEBEC LTD.1367-8388 SHALINSKY, BIERBRIER & PERELMAN INC.14836-62 SOCIETE D'EXPERTISES ET DE RECOMMANDATIONS FINANCIERES (S.E.R.F.) INC.1999-70 18 04 74 625; avenue Président-Kennedy, bureau 903, Montréal.9500.rue Meilleur, Montréal.TOPPERS BY JOSE INC.1108-6527 YVES-JACQUES, LE BOTTIER INC.1367-8057 18 12 62 Montréal.4847, Jean-Talon ouest, Montréal.08 05 70 2635.boulevard Liégeois, 1001.avenue Begon, Sainte-Foy.Sainte-Foy.27 06 68 Montréal.720, rue Ste-Catherine ouest, Montréal.17 04 74 Amos.2, 10e Avenue est, Amo 59795-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59795-0 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Lettres patentes (3' partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions.Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Name Siege social / Head office Incorporation Date ASSOCIATION DES CAMIONNEURS ARTISANS DE LA REGION No 10 735611 ASSOCIATION DES DIPLOMES EN GEOGRAPHIE DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE INC.(A.D.G.U.S.) 1356-8803 L'ASSOCIATION DES EMPLOYES DU PARC NATIONAL DE LA MAURICIE INC.1359-9162 CENTRE DE REHABILITATION DOMREMY DE PRINCEVILLE INC.1359-5020 CLUB ARCHER ALMA INC.1360-7221 CLUB D'AGE D'OR DE STE-PERPETUE INC.1360-0267 CLUB DE L'AGE D'OR ST-VINCENT-MARIE.1360-4202 LE CLIB OPTIMISTE ST-PROSPER BE.UCE-SUD QUEBEC INC.1300-4830 Laval.14 12 74 Département de Géographie, Université 05 U 74 de Sherbrooke, Sherbrooke Shawinigan.25 10 74 220, rue St-Jean-Baptiste sud, Princeville 03 10 74 Aima.10 12 74 Sainte-Perpétue.31 10 74 Montréal-Nord.26 11 74 Saint-Prosper.17 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° ô 1133 Nom / Name LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ARABESQUE DE BEAUCE INC.1360-0200 CLUB DE PETANQUE HAUTERIVE INC.1359-8313 LES COMETES DE ST-SIMON INC.1361-1173 LA CORPORATION DES DETENTEURS DE PERMIS D'ALCOOL DU QUEBEC 1361-0597 LA FEDERATION DES C.L.S.C.DU QUEBEC.1370-6551 FEDERATION DE MOTO-TOURISME DU QUEBEC.1357-1609 LA FONDATION MARC-AURELE FORTIN.1370-2238 HOCKEY INTER-CITE DE SHAWINIGAN-SUD INC.1360-1224 LA LIGUE DYNAMIQUE DES PROPRIETAIRES DE TAXIS DE LONGUEUIL INC.1369-5689 LA LIGUE DYNAMIQUE DES PROPRIETAIRES DE TAXIS DE MONTREAL INC.1358-6581 LA LIGUE D'ECHECS DE MONTREAL INC.et sa version anglaise THE MONTREAL CHESS LEAGUE INC.1370-3731 LA LIGUE DE HOCKEY MINEURE DE RIGAUD.1370-5488 LA LIGUE DE TAXIS DE L'AGGLOMERATION D'ALMA INC.1360-3741 REGIONALE DES JEUNES CHAMBRES DE QUEBEC INC.1360-1174 LA RESERVE DE SECOURS DE LA PETITE NATION.1357-4330 RESIDENCE L'AMITIE SARAGUAY (1974) INC.1360-7908 SANTE TIERS-MONDE.1361-0704 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU TEMISCOUATA INC.1360-3261 LE STUDIO DE POTERIE HOPKINS.and its English version HOPKINS POTTERY STUDIO 1360-3642 Ô9795-U Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59795-q Pierre Desjardinb, Director of the Companies Service, Incorporation Siège social / Head Office Date 705, 23e Rue, Saint-Georges Ouest .31 10 74 Hauterive.21 10 74 2e Rang, Saint-Simon.08 01 76 2, Place Québec, suite 836, Québec .03 01 76 Montréal.10 12 74 75, rue Chartier, Sherbrooke.13 06 74 Montréal.31 10 74 L'aréna Municipale de Shawinigan- 06 11 74 Sud, 1600, 118e Rue.Shawinigan-Sud 3795.Prince-Charles, Saint-Hubert.06 09 74 Montréal.07 11 74 Montréal.13 11 74 Rigaud.02 12 74 Aima.20 11 74 Québec.06 11 74 760, rue St-André, Saint-André-Avellin 31 10 74 Montréal.11 12 74 Bureau de l'AESSUL, local 0219, 30 12 74 Faculté de Médecine, Pavillon Vandry, Université Laval, Sainte-Foy Saint-Joseph-de-la-Rivière-Bleue.18 11 74 Montréal.20 11 74 1134 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.6 Siège social (Article 84) Head office (Section 84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont changé leur siège social tel qu'indiqué ci- whose names follow have changed their head office as indicated après.hereinafter.Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie Xamc of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address ASSOCIATED BRICK MANUFACTURERS.14 03 55 Montréal.153, chemin Fichley, LIMITED.Hampstead.10662-55 BELMORE IMPORTING INC.23 02 70 Montréal.1782, Boudrias IMPORTATIONS BELMORE INC.Saint-Laurent.1196-3584 HERBERT BIRSE CARTAGE INC.26 05 53 Montréal.8511, rue Grenache, 10959-53 Anjou.BOUTIQUE CARLOTTA INC.16 12 70 Montréal.1034, boulevard du 1204-9441 Séminaire, Saint-Jean.CARTIER METALS CORP.07 06 65 506.69e Avenue.5801.avenue Monkland, 2688-65 Chomedey, Laval.Montréal.CHAMPLAIN ISOLATION INC.25 07 67 1783, rue Georges.Route 204, Saint-Jean- 3059-67 Laflèche.Port-Joli.CHAUFFAGE LA PROVIDENCE, INC.21 12 73 Saint-Joseph.485, rue Sainte-Louise 739096 La Providence.LA CIE GAGNON LTEE.09 10 56 Saint-Félicien.131, Lechasseur 1165-0702 bureau 103, Beloeil.CLUB DE TIR SAINT-LAURENT INC.20 02 68 Saint-Laurent____ 6662 1ère Avenue SAINT-LAURENT SHOOTING CLUB INC.Montréal 4778-1967 COMACT INC.11 05 38 Saint-Ephrem.4000, 40e Rue, Saint- 1029-1938 Georges-Ouest.LES CONSTRUCTIONS PIERRE QUEVILLON 13 06 74 Saint-Bruno-de-Montar- 465 rue Victoria PIERRE QUEVILLON CONSTRUCTION ^ Saint-Lambert! LTD.1368-6548 CONSTRUCTION ROLAND MICHAUD LTEE.07 01 71 348, 15e Rue.Laval____ 1483 rue Lapointe 1208-7615 Val-d'Or.D'AOUST ET MONTPETIT AUTO LTEE.08 04 68 Route rurale numéro 5.Chatham.1359-68 Lachute.jea?,£ej!££rreaux ET ASSOCIES 15 08 72 271, 3e Rue est.Amos.58, avenue des Cèdres, 724537MITEE VaI-d'0r' DOMAINE DES ERABLES INC.12 09 60 15452, Bois-Châtel.580, chemin Cherrier 13882-60 Pierrefonds.Saint-Raphaël-de- ' l'Ile-Bizard.EMPIRE GEAR & MACHINE LTD.23 07 63 Montréal.401 boulevard Lebeau 1116-5354 Saint-Laurent.LES ENTREPRISES F.RENAUD INC.10 01 66 7445, rue Vittel, 3 Place Bellerive F.RENAUD ENTERPRISES INC.Saint-Léonard.app.2010,Lavoï /6-66 LES ENTREPRISES MORIN, LTEE.19 12 62 5956, Sherbrooke est, 496, rue Port neuf 15125-62 Montréal.Longueuil. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1976, 107' année, n° 5 1135 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address LES ENTREPRISES QUEMONT LTEE.QUEMONT ENTERPRISES LTD.11188-61 EQUIPEMENT DE BUREAU DRANCY INC.DRANCY BUSINESS EQUIPMENT INC.1367-4007 07 03 61 9550, boulevard Ray-Lawson, Anjou.EVANNE INC.13727-60 FER & METAL RAMA INC.et sa version anglaise RAMA IRON & METAL INC.1369-8972 LA FERME ST-POLYCARPE INC.1589-67 GESTION CONSEIL DE MONTREAL INC.1359-6499 GUARDIAN POLY INDUSTRIES LTD 3730-70 HERVE HOULE LIMITEE.13658-59 MAURICE HOULE & ASSOCIES INC.MAURICE HOULE ci ASSOCIATES INC.4683-67 CLAUDE HUPPE LTEE.1262-68 IMMEUBLES BOURGEOIS LTEE.3384-67 IMMEUBLES LYRE LTEE.and its English version LYRA REALTIES LTD.1369-3270 INDUSTRIAL GASES & SUPPLIES LIMITED 3773-66 J & L SALES INC.1116-1916 KIARNEY INVESTMENTS LTD.3952-71 ANDRE LABROSSE INC.2312-65 LANIEL (CANADA) INC.1128-0633 LES MARCHES D'ALIMENTATION L'EQUIPE LIMITEE L'EQUIPE FOOD MARKETS LIMITED 1881-63 MARINA MYLES LIMITED.3480-69 METRO FUELS INC.LES PETROLES METRO INC.4608-68 25 03 74 Montréal.30 08 60 Montréal.02 10 74 46, Châtillon, Dollard-des-Ormeaux.08 11 67 Saint-Polycarpe.11 10 74 Laval.19 08 70 515, 4e Avenue, Lachine.29 07 59 Saint-Simon.13 12 67 Montréal.20 03 68 2301, rue Sauriol, Montréal.03 08 67 2415, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy.03 08 74 1, Place Ville-Marie, suite 3635, Montréal.16 09 66 5339, rue Crowley, Montréal.31 10 66 Montréal.27 01 71 3637, boulevard Métropolitain est.Montréal.12 08 66 Pierrefonds.30 12 65 151.rue Rockland, Mont-Royal.10 05 63 Montréal.13 07 69 1309.Redpath-Crescent, Montréal.07 10 68 Montréal.1, Place Ville-Marie, suite 2220, Montréal.7370.rue Mirabeau, Brossard.2105, avenue Decelles, Saint-Laurent.100 A, Montée Masson, Laval.231, rue St-Charles, Dorion.110, Place Crémazie.app.1450, Montréal.205, boulevard Harwood, Dorion.8360, Bougainville.Montréal.110.rue Willowdale, Outremont.339, avenue de la Promenade, Boisbriand.4855, 2e Avenue ouest, Charlesbourg.868, chemin Queens, Saint-Lambert.5870, Andover, Montréal.145, rue Navarre, Saint-Lambert.13095, rue Sherwood, Drive, Pierrefonds.580, chemin Cherrier, Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard.7101, route Transcanadienne, Saint-Laurent.11,601, boulevard Albert-Hudon, Montréal-Nord.706, Devon Place, Baie-d'Urfé.230, rue Norman, Saint-Pierre. 1136 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1976, Vol.107, No.5 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Siège social Head office Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address MINES DUBEL INC.DUBEL MINES INC.738151 HENRI MIRON AUTOMOBILE LTEE.12553-57 MORWIN ASSOCIATES INC.294-65 PAYETTE & SIMMS INC.1134-6277 PLACEMENTS ASSISE LTEE.4513-64 PLACEMENTS J.A.D.INC.et sa version anglaise J.A.D.INVESTMENTS INC.1369-3858 PLANET CONSTRUCTION LTD.CONSTRUCTION PLANETE LTEE 736809 LES PORTES ET MOULURES LA VIGNE INC.1354-2493 QUEMONT CONSTRUCTION LTD____ QUEMONT CONSTRUCTION LTEE 12570-59 RELEVES AERIENS GAR-X LTEE.GAR-X AIR SURVEY LTD.3350-71 LES RESTAURANTS CROQUE-MITAINE INC.1358-2929 M.RIOPELLE LIMITEE.12892-55 ROCAN ENTERPRISES LTD 13797-58 ST.CASIMIR VENEER & PLYWOOD LTD.1174-1188 SAGUENAY ANCHOR CLUB INC.993-67 SERVICE JURIDIQUE UNIVERSITAIRE INC.3208-71 SERVIT CONSTRUCTION LIMITED.251-65 SOUND 21 LTD.1203-3437 LES STRUCTURES D'ACIER JACQUES INC.JACQUES STRUCTURAL STEEL INC.1215-5313 SYNERGISTEX INC.730779 SYSTEMES D'ALARME METRO INC.et sa version anglaise METRO ALARM SYSTEMS INC.1369-3967 14 09 73 388.rue St-Jacques, Montréal.05 09 57 Route rurale numéro 1, Saint-Jérôme.26 01 65 Montréal.17 05 56 Saint-Jean.13 10 64 Montréal.19 08 74 Pierrefonds 12 04 73 Montréal.14 12 73 409, 66e Rue ouest, Charlesbourg, 30 04 59 9550, boulevard Ray-Lawson.Anjou.18 10 71 Val-d'Or 05 08 74 946, boulevard de la Rivière-du-Sud, Saint-François 29 10 55 Montréal.24 10 58 630, 63e Avenue.L'Abord-à-Ploufle.25 01 67 270.rue St-Aubin, Saint-Laurent.08 03 67 Arvida.21 06 71 Sainte-Foy.20 01 65 Montréal.25 11 69 Westmount.03 06 71 Montréal.21 02 73 80, rue St-Pierre, Québec.19 08 74 Longueuil.11, Nelson, Val-d'Or.1141, boulevard Lasalle, Bellefeuille.790, rue Bégin, Saint-Laurent.300, Arran, Saint-Lambert.2780, rue Barry, Brossard.15981, boulevard Gouin ouest, Sainte-Geneviève.1457, boulevard Lau-rentide, Laval.1415.Faucher, Sainte-Sainte-Foy.1, Place Ville-Marie, app.2220, Montréal.1, Place Laval, app.200, Laval.1461, rue Maguire, Sillery.1455, boulevard Mont-Royal, Outremont.41, avenue Brentwood, Beaconsfield.22.rue Reims, Lorraine.5, rue Duvernay, Jonquière.537, boulevard Charest est.Québec.8094.rue Roche-Sur-Yon.Anjou.6000, Côte-de-Liesse, Saint-Laurent.1239, boulevard Ste-Croix, Saint-Laurent.3116.rue Noorduyn, Saint-Laurent.3333., Métropolitain est, suite 700, Montréal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er février 1975, 107' année, n° 5 1137 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie -\u2014- Name of Ike company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Precious address New addrees TORNADO MFG.CORP.27 11 64 Montréal.9101.rue Montée Louis-H.1117-3077 Lafontaine, Anjou.A.VALENTE LTD.05 05 69 Laval.585, rue Fleury ouest, 2099-69 Montréal.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 59795-0 Pierre Desjardins.59795-0 Director of the Companies Service.Abandon de charte Surrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions.Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a accepté l'abandon de la charte de: panies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Incorporation Dissolution Nom / Name Date Date BERGERON CHAMPAGNE PETROLEUM INC.29 05 63 17 01 76 1152-4212 ANTONIO CHABOT INC.27 09 67 07 02 75 1154-3345 CIE D'INFORMATIQUE DE GESTION LTEE.27 08 71 17 01 76 3614-71 COMMISSION DES PARCS DE WINDSOR INC.20 08 66 27 12 74 3707-65 CONSTRUCTION TRANS-LAURENTIDE LTEE.15 09 64 31 01 75 TRA NS-LAU REN TIDE CONSTRUCTION LTD.4068-64 DRAPERIES FLEUR DE LYS LTEE.18 10 67 17 01 75 4405-67 LES EDITIONS CARREFOUR LIMITEE.21 02 64 17 01 75 348-64 FERME AVICOLE ST-ESPRIT CO.LTEE.23 04 56 31 01 75 10982-56 FRABEL INVESTMENT INC.16 09 64 18 01 75 4118-1964 G.M.R.CONSTRUCTION INC.31 05 66 04 01 75 1828-66 B.GILBERT AUTO INC.05 07 65 18 01 75 3108-1966 HOCHELAGA AUTO PARTS LTD.20 05 60 17 01 75 12292-60 KAPPA DEVELOPMENT CORP.05 05 60 18 01 75 12038-60 L'EVENEMENT-JOURNAL INC.17 11 38 17 01 75 2481-38 MAKI CORPORATION.29 03 54 03 01 75 CORPORATION MAKI 10848-54 1138 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Nom / Name Incorporation Dissolution Date Date RONESS-SMITH FURS INC.648-1966 RUFIANGE & FILS LTEE.10402-61 ST.MARTIN SUPPLIES INC.12011-54 SERVICE DE PNEUS STADIUM (1971) INC.STADIUM TIRE SERVICE (1971) INC.3009-71 SIVAN INVESTMENT CORP.10395-58 \"THE T.BATON CO.LIMITED OF MONTREAL.LA COMPAGNIE T.EATON DE MONTREAL LIMITEE 1104-6943 TWENTIETH CENTURY INVESTMENT CORPORATION.11695-59 VANMAL INC.14695-62 15 02 66 01 02 61 16 08 54 02 06 71 03 02 58 26 03 25 20 03 59 21 11 62 18 01 75 06 12 74 10 01 75 27 12 74 17 01 75 24 01 75 03 01 76 17 01 75 59795-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59795-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Fusion de compagnies Amalgamation of Companies Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes autorisant la fusion de : The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted letters patent authorizing the amalgamation of: Nom de la nouvelle compagnie Name of new company Siège social Head office Fusion Amalgamation Date Nom des compagnies fusionnées Names of companies amalgamated LES IMMEUBLES TRIADE INC.and its English version TRIAD REALTY INC.1361-0951 1320, rue Beaubien, 01 01 75 LE BISTRO DU SPORT INC.Montréal.TRIAD REALTY CORPORA- TION 69795-0 Le directeur du service aes compagnies, Pierre Desjardins.69795-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Demandes d'abandon de charte Applications for Surrender of Charter SERVICE DE RETOUCHES ST-PASCAL INC.Prenez avis que la compagnie « SERVICE DE RETOUCHES ST-PASCAL INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 59820-o Jean-Pierre Gignac.SERVICE DE RETOUCHES ST-PASCAL INC.Notice is given that \"SERVICE DE RETOUCHES ST-PASCAL INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Jean-Pierre Gignac, 59820 Attorney for the company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 6 1139 FORTY-EIGHT HUNDRED PIE IX BLVD.INC.Avis est par les présentes donné que « FORTY-EIGHT HUNDRED PIE IX BLVD.INC.», ayant son siège social dans les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 10e jour de janvier 1975.Les procureurs de la compagnie, 59804-o Stein & Stein.FORTY-EIGHT HUNDRED PIE IX BLVD.INC.Notice is herebv given that \"FORTY-EIGHT HUNDRED PIE IX BLVD.INC.\", having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Ccmpanies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 10th day of January, 1975.Stein & Stein, 59804-o Attorneys for the company.J.L.LACERTE & FILS LTEE Prenez avis que la compagnie « J.L.LACERTE & FILS LTEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Grand'Mère, le 10 janvier 1975.La secrétaire de la compagnie, 59805-o Gabrielle D.Lacerte.J.L.LACERTE & FILS LTEE Notice is given that \"J.L.LACERTE & FILS LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Grand'Mère, January 10, 1975.Gabrielle D.Lacerte, 59805-O Secretary of company.BELOEIL DEVELOPMENT INC.Prenez avis que la compagnie « BELOEIL DEVELOPMENT INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, Bertrand, Guérard, Tétreault & Bleau.Laval, Que.59814-o BELOEIL DEVELOPMENT INC.Notice is given that \"BELOEIL DEVELOPMENT INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Bertrand, Guérard, Tétreault & Bleau, Attorneys for the company.Laval, Que.59814 LES CONSTRUCTIONS BER-GER INC.LES CONSTRUCTIONS BER-GER INC.Prenez avis que la compagnie « LES CONSTRUCTIONS BER-GER INC.» demandera au ministre des pnstitutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, Bertrand, Guérard, Tétreault & Bleau.Laval, Que.59816-0 S.E.C.A.INC.Prenez avis que la compagnie « S.E.C.A.INC.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 14 janvier 1975.Les procureurs de la compagnie, Dansereau, Daoust et al.59821-0 E.Jolicoeur.Notice is given that \"LES CONSTRUCTIONS BER-GER INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Bertrand, Guérard, Tétreault & Bleau, Attorneys for the company.Laval, Que.59816 S.E.C.A.INC.Notice is given that \"S.E.C.A.INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Montreal, January 14, 1975.Dansereau, Daoust et al.E.Jolicoeur, 59821 Attorneys for the company.LAÇASSE ET CHAMPAGNE INC.Prenez avis que la compagnie « LAÇASSE ET CHAMPAGNE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Me Robert L'Heuheux, notaire.St-Lambert-de-Lévis, Que.59852-0 LAÇASSE ET CHAMPAGNE INC.Notice is given that \"LAÇASSE ET CHAMPAGNE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Me.Robert L'Heureux, notary.Attorney for the company.St.Lambert-de-Lévis, Que.59852 1140 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 CLEMAC (QUEBEC) INC.Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies, « CLEMÀC (QUEBEC) INC.» donne par les présentes avis de son intention de demander au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte, l'annulation de sa charte et la dissolution de la compagnie.Daté ce 15e jour de janvier, 1975.(Sceau) Le secrétaire, 59815-0 S.S.Hultgreen.DARON INVESTMENT CORP.Avis est par les présentes donne que la compagnie « DARON INVESTMENT CORP.».constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 10 janvier 1975.Les procureurs de la compagnie, 59817 Lechter & Segal.HEPET MACHINERY INC.MACHINERIE HEPET INC.Avis est donné que \u2022HEPET MACHINERY IXC.\u2014 MACHINERIE HEPET INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Richmond, district de St-Fran-çois, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Les procureurs de la requérante, Richard & Rémillard.St-Laurent, Que.59818-0 BRIANYL LTD.Avis est par les présentes donné que « BRIANYL LTD.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, ayant son siège social à Drummond-ville, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 8 janvier 1975.Le secrétaire.59839-0 R.Elischer.CLEMAC (QUEBEC) INC.Under the provisions of the Companies Act, \"CLEMAC (QUEBEC) INC.\" hereby gives notice that it intends to apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender the charter of the company, for cancellation of the charter and for the dissolution of the company.Dated this 15th day of January, 1975.(Seal) S.S.Hultgreen, 59815-0 Secretary.DARON INVESTMENT CORP.Notice is hereby given that \"DARON INVESTMENT CORP.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, January 10th, 1975.Lechter & Segal, 59817-0 Attorneys for the company.HEPET MACHINERY INC.MACHINERIE HEPET INC.Notice is hereby given that \"HEPET MACHINERY INC.\u2014MACHINERIE HEPET INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Richmond, District of St-Francois, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Richard & Rémillard, Attorneys for petitioner.St.Laurent, Que.59818-0 BRIANYL LTD.Notice is hereby given that \"BRIANYL LTD.\".a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Drummond-ville, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Montreal, January 8, 1975.R.Elischer, 59839-0 Secretary.CENTRE MARTEL & FRERES INC.Prenez avis que la compagnie « CENTRE MARTEL & FRERES INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Québec, ce trente et unième jour de décembre 1974.Le procureur de la compagnie.Jean Deblois.05.rue Stc-Annc, Québec.59850-o CENTRE MARTEL & FRERES INC.Notice is given that \"CENTRE MARTEL & FRERES INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Ccoperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter.Québec, this thirty-first day of December, 1974.Jean Derlois, Attorney for Ihe company.65 Stc.Anne Street, Québec.59850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1141 REXVILLE DEVELOPMENT INC.Avis est donné que la compagnie « REXVILLE DEVELOPMENT INC.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Donné à Montréal, ce 16e jour de janvier 1975.Les procureurs de la compagnie, Kaufman, Respitz, Sederoff, 59819 Shugar & Segal.RESTAURANT L'AMBASSADEUR DE STE-FOY INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « RESTAURANT L'AMBASSADEUR DE STE-FOY INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte ».Les procureurs de la compagnie, Bhérer, Bernier, Loubier, Côté & Ass.Québec, Que.59824-0 COMITE REGIONAL OUTAOUAIS DE LA FEDERATION DES LOISIRS-DANSE DU QUEBEC Prenez avis que la compagnie « COMITE REGIONAL OUTAOUAIS DE LA FEDERATION DES LOISIRS-DANSE DU QUEBEC» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Hull, le 9 janvier 1975.Les procureurs de la compagnie, 689, Boul.St-Joseph, Bergeron & Gaudreau.Hull, Que.59851-0 Compagnie de fidéicommis CONTINENTAL TRUST COMPANY LA COMPAGNIE DE FIDUCIE CONTINENTAL Avis de changement d'adresse du bureau principal dans la Prorince Avis est donné que « CONTINENTAL TRUST COMPANY \u2014LA COMPAGNIE DE FIDUCIE CONTINENTAL », compagnie constituée par lettres patentes émises en conformité de la Loi des compagnies fiduciaires (Canada), a déménagé son bureau principal dans la Province de suite 3235, Place Ville-Marie, Montréal à suite 950, 2055, rue Peel, Montréal.REXVILLE DEVELOPMENT INC.Take notice that \"REXVILLE DEVELOPMENT INC.\", a company incorporated under the Companies Act, and having its head office at Montreal, Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 16th day of January, 1975.Kaufman, Respitz, Sederoff, Shugar & Segal, 59819-o Attorneys for the company.RESTAURANT L'AMBASSADEUR DE STE-FOY INC.Notice is hereby given that \"RESTAURANT L'AMBASSADEUR DE STE-FOY INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Bhérer, Bernier, Loubier, Côté & Ass., Attorneys for the company.Québec, Que.59824 COMITE REGIONAL OUTAOUAIS DE LA FEDERATION DES LOISIRS-DANSE DU QUEBEC Notice is given that \"COMITE REGIONAL OUTAOUAIS DE LA FEDERATION DES LOISIRS-DANSE DU QUEBEC\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Hull, January 9, 1975.Bergeron & Gaudreau, 689 St.Joseph Blvd., Attorneys for the company.Hull, Que.59851 Trust Company CONTINENTAL TRUST COMPANY LA COMPAGNIE DE FIDUCIE CONTINENTAL Notice of change of address of head office in the Province Notice is given that \"CONTINENTAL TRUST COMPANY-LA COMPAGNIE DE FIDUCIE CONTINENTAL\", a company incorporated by letters patent issued in accordance with the provisions of the Trust Companies Act (Canada), has moved its head office in the Province from Suite 3235 Place Ville-Marie, Montreal to Suite 950, 2055 Peel Street, Montreal.59833-0 Le secrétaire, S.R.Anderson.59833-0 S.R.Anderson, Secretary. 1142 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission < proprio motu » (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.LTI \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion < proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regu- lation 2, s.2.3) i 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1976, 107' année, n° 5 1143 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.\u2022 Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes Montréal Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trucking Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur MPV QPV Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Regular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCV QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA Air Ferroviaire MSF QSF Rail Rose Pmi* Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve Mauve Brun Brown M 000001 Q 000001 M 100001 Q 100001 M 200001 Q 200001 M 300001 Q 300001 M 400001 Q 400001 M 500001 Q 500001 M 600001 Q 600001 M 700001 Q 700001 M 800001 Q 800001 M 900001 Q 900001 à M 002000 àQ 001000 à M 103000 àQ 102000 à M 210000 à Q 205000 à M 303000 àQ 302000 à M 402000 à Q 401000 à M 504000 àQ 503000 à M 601000 àQ 600500 à M 700500 à Q 700500 à M 800500 àQ 800500 à M 900500 à Q 900500 MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport \u2014 passengers MPE \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers / Montreal public transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers / Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal public transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab MCR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking QCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage / Québec regular transportation \u2014 trucking 1144 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV \u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal bulk transportation \u2014 trucking QCV \u2014 Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking ML \u2014 Montréal location / Montreal leasing QL \u2014 Québec location / Québec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation \u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Québec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 air MSF \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rail QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Québec specialized transportation \u2014 rail II \u2014Avis d'introduction de requêtes: La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of applications: The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Rôle Q-2629 Q-501388-D-003 CHARLES C1MON CP.88 St-Valérien (Rimouski) (Que.) Rôle Q-2645 Q-502180-D-003 GASTON TRÊPANIER 20, 62e Rue Lac-à-la-Tortue (Champlain) (Que.) Rôle Q-2787 14893-V-C-l 14893-V GRENIER EXPRESS INC.4055, 12e Avenue CP.175 Shawinigan-Sud (Que.) Requérante / Applicant 1736-V DERY EXPRESS INC.2443, rue Coutu Shawinigan (Que.) Intimée / Respondent Rôle Q-2788 Q-502546-D-001 LUCIEN HÊON 1590, boul.St-Louis St-Louis-de-Francc (Champlain) (.Que.) et/and Q-504787-D-001 RENÉ DE MONTIGNY 1271, boul.St-Alexis St-Louis-de-France (Champlain) (Que.) Le requérant, qui possède une attestation Q-501388-D-0O3, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région No 1.N.B.Nouvelle publication remplaçant celle du 21 décembre 1974.qui était erronée.Le requérant demande un permis de camionnage en vrac, pour le transport de neige, de catégorie Entrepreneur, dans la région No 4.N.B.Nouvelle publication remplaçant celle du 4 janvier qui était erronée.Convocation: Demande de vérification des services de transport fournis par la partie intimée à la demande de la partie requérante.Demande de transfert: Le requérant.Lucien Héon, demande à la Commission de transférer à: René De Montigny 1271.boul.St-Alexis St-Louis-de-France Comté de Champlain (Que.) le permis ou l'attestation Q-502546-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région No 4, de catégorie Entrepreneur.The applicant who holds a certificate No.Q-501388-D-003.requests a bulk trucking permit.Artisan class, for region No.1.Note: New publication replacing the one dated December 21, 1974, which was erroneous.The applicant requests a bulk trucking permit, for the transport of snow, Contractor class, in region No.4.Note: New publication replacing the one dated January 4, 1975, which was erroneous.Summons: Application for verification of the transport services provided by the respondent, at the applicant's request.Application for transfer: Lucien Héon requests the Commission to transfer to: René De Montigny 1271 St-Alexis Blvd.St^Louis de France County of Champlain.P.Q.permit or certificate Q-502546-D-001, which he holds, to effect bulk trucking in region No.4, Contractor class. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n\" o 1145 Rôle Q-2789 7573-V-D-2-TF GERMAIN TRANSPORT ENR.(Robert Germain) 70, avenue St-Georges C.P.22 St-Basile tPortneuf) (Que.) Rôle Q-2790 719-V-D-2-TF LES DÉMÉNAGEMENTS CÔTÉ LTÉE 840.St-Vallier ouest Québec (Que.) Rôle Q-2791 1650-A-D-3 LES AUTOBUS LACHANCE INC.C.P.91 St-Martin-de-Beauce (Que.) GOM 1B0 Rôle Q-2792 354-A-D-2 AUTOBUS DUPONT LTÉE 240, 3e Rue Québec 3 (Que.) Le requérant demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses tarifs actuels d'une moyenne d'environ 20% pour le transport de marchandises en vertu des clauses a, b et c de son permis.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to increase by an average of 20% its present tariffs for the transport of merchandise, pursuant to clauses a, b and c of its permit.La requérante demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses tarifs d'environ 15% pour le transport local dans le Québec-Métropolitain.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to increase by a approximately 15% its tariffs for local transport in Métropolitain Québec.Service additionne) : Classe: Autobus.Service: Voyages à charte-partie originant de tous les points où il a droit d'effectuer de tels voyages, à destination des diverses frontières Québec-États-Unis.Québec-Ontario, Qué-bec-Nouveau-Brunswick, (tous ports d'entrée).La requérante détient le permis de service touristique qui se lit ainsi: Classe: Service touristique (Autobus et minibus).La requérante demande de modifier le service qui se lit ainsi: Service: Service touristique à horaire fixe de Ste-Foy, Québec au Mont-Ste-Anne et, au retour, en passant par Cap-Tourmente.Parcours: Boulevard Laurier-Grande-Allée-Rue St-Louis-Place d'Armes-Rue Ste-Anne-Côte de la Fabrique-Rue St-Jean-Côte du Palais-Boulevard des Capucins-De la Canardière-Boulevard Ste-Anne-Roiïte 15B de l'Ange-Gardien jusqu'à Ste-Anne-.de-Beaupfé-Beau-pré-Mont-Ste-Anne.Retour: Mont-Ste-Anne - St-Joachim - Cap-Tourmente-Route 15A au boulevard Ste-Anne-Québec-Ste-Foy.pour qu'à l'aveni il se lise ainsi: Service touristique (Autobus) à horaire fixe de Ste-Foy, Québec à Ste-Anne-de-Beau-pré-Mont-Ste-Anne et, au retour, en passant par Cap-Tourmente.Le guide sera muni d'un amplificateur de voix.Parcours: Boulevard Laurier-Grande-Allée-Rue St-Louis-Place d'Armes-Rue Ste-Anne-Côte de la Fabrique-Rue St-Jean-Côte du Palais-Boulevard des Capucins-De la Canardière-Boulevard Ste-Anne-Route 15B de l'Ange-Gardién jusqu'à Ste-Anne-de-Beaupré-Beau-pré-Mont-Ste-An ne.Au retour, Mont-Ste-Anne-St-Joachim-Cap-Tourmente-Route 15A au boulevard Ste-Anne-Québec-Ste-Foy.Tarif calculé à tant par tête: $12 par personne adulte J6 par personne-enfant (moins de 12 ans) Ce taux inclut le prix d'un repas et de la remontée en gondole du Mont-Ste-Anne.Additional service: Class: Bus.Service: Charter trips originating from any point where it is authorized to effect such trips, to various borders: Quebec-United States, Quebec - Ontario, Québec - New-Brunswick, (all ports of entry).The applicant holds the sightseeing service permit which reads as follows: Class: Sightseeing tour (Bus and minibus) The applicant requests to modify the service, which reads as follows: Service: Sightseeing tour according to a fixed schedule, from Ste-Foy, Québec City to Mont-Ste-Anne and, on the return trip, via Cap-Tourmente.Route: Laurier Boulevard - Grande Allée - St-Louis Street \u2014 Place d'Armes \u2014 Ste-Anne Street \u2014 De la Fabrique Hill \u2014 St-Jean Street \u2014 Du Palais Hill \u2014 Des Capucins Boulevard \u2014 De la Canardière \u2014 Ste-Anne Boulevard \u2014 Highway 15B from L'Ange-Gardien to Ste-Anne-de-Beaupré \u2014 Beaupré \u2014 Mont-Ste-Anne.Return: Mont-Ste-Anne \u2014 St-Joachim \u2014 Cap-Tourmente \u2014 Highway 15A to Ste-Anne Boulevard \u2014 Québec City \u2014 Ste-Foy.to read as follows in the future: Sightseeing tour (Bus) according to a fixed schedule from Ste-Foy, Québec City to Ste-Anne-de-Beaupré, Mont Ste-Anne and, on the return trip, via Cap-Tourmente.The guide shall be equipped with a microphone.Route: Laurier Boulevard \u2014 Grande Allée \u2014 St-Louis Street \u2014 Place d'Armes \u2014 Ste-Anne Street \u2014 De la Fabrique Hill \u2014 St-Jean Street \u2014 Du Palais Hill \u2014 Des Capucins Boulevard \u2014 De la Canardière \u2014 Ste-Anne Boulevard \u2014 Highway 15B from L'Ange-Gardien to Ste-Anne-de-Beaupté - Mont-Ste-Anne.On the return trip, Mont-Ste-Anne, St-Joachim - Cap-Tourmente - Highway 15A to Ste-Anne Boulevard - Québec City - Ste-Foy.Tariff calculated on a per-person basis: S12 per adult $6 per child (under 12 years of age) The rate includes the price of a meal and the ride on the gondola lift at Mont-Ste-Anne. 1146 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 L'horaire pour ce service est: Départ - 09.00 boulevard Laurier (Holiday Inn) Arrivée - 10.30 Ste-Anne-de-Beaupré Départ - 11.30 Ste-Anne-de-Beaupré Arrivée - 12.00 Mont-Ste-Anne Départ \u2014 15.00 Mont-Ste-Anne Arrivée \u2014 15.30 Cap Tourmente Départ \u2014 16.30 Cap-Tourmente Arrivée \u2014 17.30 Québec Arrivée \u2014 18.00 Ste-Foy.De plus, la requérante demande d'ajouter à son permis les trois services suivants: Service touristique (Autobus) avec une durée minimale de cinq heures de Ste-Foy, Québec à Ste-Anne-de-Beaupré.Mont-Ste-Anne et, au retour, en passant par Cap-Tourmente.Parcours: Boulevard Laurier-Grande-Allée-Rue St-Louis-Place d'Armes-Rue Ste-Anne-Côte de la Fabrique-Rue St-Jean-Côte du Palais-Boulevard des Capucins-De la Canardière-Boulevard Ste-Anne-Route 15B de'l'Ange-Gardien jusqu'à Ste-Anne-de-Beaupré-Beau-pré-Mont-Ste-Anne.Et au retour, Mont-Ste-Anne.Et au retour, Mont-Ste-Anne - St-Joa-chim-Cap-Tourmente \u2014 Route 15A au boulevard Ste-Anne-Québec-Ste-Foy.Taux: S250 pour un autobus 47 passagers.Le guide sera muni d'un amplificateur de voix.Service touristique (Autobus) à horaire fixe de Québec à Ste-Anne-de-Beaupré.Mont-Ste-Anne et, au retour, tour de ville dans Québec.Parcours: Boulevard St-Cyrille - Turnbull - Grande-Allée-Rue St-Louis-Place d'Armes-Rue Ste-Anne - Cook - Dauphine - D'Youville - Côte d'Abraham-Rue de la Couronne-4e Rue-4e Avenue-De la Canardière-Boulevard Ste-Anne-Route 15B de l'Ange-Gardien jusqu'à Ste-Anne-de-Beaupré - Beaupré - Mont-Ste-Anne.Et au retour, Mont-Ste-Anne-Route 15A au boulevard Ste-Anne et entrée à Québec par la rue Dorchester-Côte d'Abraham-Autoroute Dufferin-Boulevard St-Cyrille-Turnbull-Grande-Allée jusqu'à l'entrée Bougainville des Plaines-Terrasse Gray-Monu-ments (sculpture '67)-Musée Monument Wolfe-(Parc Jeanne d'Arc)-Arrêt 10 minutes sur les Plaines-Sortie des Plaines-Passage devant le Parlement-Rue St^Louis-Château Frontenac-Place d'Armes-Rue Ste-Anne-Rue Desjardins-Hôtel de Ville (cathédrale)-Rue Buade-Port Dauphin-des Remparts-Rue Lacroix-Rue St-Paul-Dalhousie-Place Royale, (arrêt de 20 à 30 minutes)- et retour au point d'origine.Conditions: Le tarif à tant par tête est le suivant: $8 par personne adulte $4 par personne-enfant (moins de 12 ans) Horaire: Départ.Québec.13.00 Arrivée, Ste-Anne-de-Beaupré.14.00 Départ, Ste-Anne-de-Beaupré, 15.00 Arrivée, Mont-Ste-Anne.16.15 Départ, du Mont-Ste-Anne.15.30 Tour de ville de Québec, terminus vers 18 heures.The schedule for this service is as follows: Departure: 9:00 o'clock a.m.on Laurier Boulevard (Holiday Inn) Arrival: 10:30 a.m.Ste-Anne-de-Beaupré Departure: 11:30 Ste-Anne-de Beaupré Arrival: 12:00 Mont-Ste-Anne Departure: 3.00 p.m.Mont-Ste-Anne Arrival: 3:30 o'clock p.m.at Cap-Tour- mente _ Departure: 4:30 p.m.at Cap-Tourmente Arrival: 5:30 p.m.in Québec City Arrival: 6:00 p.m.in Ste-Foy.Moreover, the applicant requests that the following three services be added to its permit: Sightseeing tour (Bus) of a minimum duration of five hours, from Ste-Foy, Québec City to Ste-Anne-de-Beaupré, Mont-Ste-Anne and.on the return trip, via Cap-Tourmente.Route: Laurier Boulevard - Grande-Allée - St-Louis Street - Place d'Armes - Ste-Anne Street - De la Fabrique Hill - St-Jean Street - Du Palais Hill - Des Capucins Boulevard -De la Canardière - Ste-Anne Boulevard -Highway 15B from L'Ange-Gardien to Ste-Anne-de-Beaupré - Beaupré - Mont Ste-Anne.And on the return trip, Mont Ste-Anne - St-Joachim - Cap-Tourmente - Highway 15A to Ste-Anne Boulevard - Québec - Ste-Foy.Rate: $250 for a 47-passenger bus.The guide shall be equipped with a microphone.Sightseeing tour (Bus) according to a fixed schedule, from Québec City to Ste-Anne-de-Beaupré, Mont-Ste-Anne and, on the return trip, tour of the City of Québec.Route: StrCyrille Boulevard - Turnbull - Grande-Allée - St-Louis Street - Place d'Armes -Ste-Anne Street - Cook - Dauphine - D'You-ville - D'Abraham Hill - De la Couronne Street - 4th Street - 4th Avenue - De la Canardière - Ste-Anne Boulevard - Highway 15B from L'Ange-Gardien to Ste-Anne-de-Beaupré - Beaupré - Mont-Ste-Anne.And on the return trip.Mont-Ste-Anne - Highway 15A to Ste-Anne Boulevard entering Québec City by Dorchester Street - D'Abraham Hill - Dufferin Autoroute - St-Cyrille Boulevard - Turnbull - Grande-Allée to the Battlefields Park entrance on Bougainville Street -Gray Terrace - Monuments (\"67 sculptures) - Museum - Wolfes Monument - (Joan of Arc Park) - 10-minute stop in the Battlefields Park - Leaving the Park - Passing in front of the Parliament Building - St-Louis Street - Château Frontenac - Place d'Armes - Ste-Anne Street - Desjardins Street - City Hall (Cathedral) - Buade Street - Port Dau- hin - Des Remparts - Lacroix Street - St-aul Street - Dalhousie - Place Royale (20 to 30-minute stop) - and return to the starting point.Conditions: The per-person tariff is the following: $8 per adult $4 per child (less than 12 years old) Schedule: Departure: Québec, 1:00 p.m.Arrival: Ste-Anne-de-Beaupré, 2:00 p.m.Departure: Ste-Anne-de-Beaupré, 3:00 p.m.Arrival: MonUSte-Anne, 3:15 p.m.Departure: from Mont-Ste-Anne, 3:30 p.m.Tour of the City of Québec, terminal at about 6:00 p.m. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1147 Le guide sera muni d'un amplificateur de voix.Service touristique (Autobus) avec une durée minimale de cinq heures de Québec à Ste-Anne-de-Beaupré, Mont-Ste-Anne et, au retour, tour de ville dans Québec.Parcours : Boulevard St-Cyrille - Turnbull - Grande-Allée-Rue St-Louis-Place d'Armes-Rue Ste-Anne - Cook - Dauphine - D'Youville - Côte d'Abrahma-Rue de la Couronne-4e Rue-4e Avenue-De la Canardière-Boulevard Ste-Anne-Route 15B de l'Ange-Gardien jusqu'à Ste-Anne-de-Beaupré - Beaupré - Mont-Ste-Anne.Et au retour, Mont-Ste-Anne-Route 15A au boulevard Ste-Anne et entrée à Québec par la rue Dorchester-Côte d'Abraham-Autoroute Duflèrin-Boulevard St-Cyrille-Turnbull-Grande-Allée jusqu'à l'entrée Bougainville des Plaines-Terrasse Gray-Monu-ments (sculpture '67)-Musée-Monument \\Vo!fe-(Parc Jeanne d'Arc)-Arrêt 10 minutes sur les Plaines-Sortie des Plaines-Passage devant le Parlement-Rue St-Louis-Château Frontenac-Place d'Armes-Rue Ste-Anne-Rue Desjardins-Hôtel de Ville (cathédrale)-Rue Buade-Port Dauphin-des Remparts-Rue Lacroix-Rue St-Paul-Dalhousie-Place Royale, (arrêt de 20 à 30 minutes)-et retour au point d'origine.Rôle Q-2793 Q-504469-D-001 GASTON VAILLANCOURT Ste-Aurélie (Dorchester^ (Que.) Rôle Q-2794 Q-504468-D-001 HERMEL ROUSSEAU St-Cyprien (Rivière-du-Loup) (Que.) Rôle Q-2795 Q-501450-D-001 AURÉLIEN GAUTHIER St-Gabriel (Rimouski) (Que.) Rôle Q-2797 18027-V-D-l LES ENTREPRISES DU NORD-OUEST INC.C.P.25 Chemin Evain Rouyn (Que.) Siège social: / Head office: Languedoc (Abitibi-Est) (Que.) Mise en cause Conditions: Tarif $250 pour un autobus 47 passagers.Le guide sera muni d'un amplificateur de voix.Région No 3 Entrepreneur 12-13 Le requérant demande un permis de camionnage en vrac, transport de bois non ouvré, de catégorie entrepreneur, pour la région No 3.Région No 3 Entrepreneur 12-13 Le requérant demande un permis de camionnage en vrac, transport de bois non ouvré, dans la région No 3, de catégorie Entrepreneur.Le requérant, qui possède une attestation Q-501450-D-0U1, demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région No 1.Demande de transfert d'actions: M.Ernest Bujold a vendu les 19,999 actions ordinaires qu'il possédait dans la compagnie mise en cause.On demande l'autorisation à la Commission de ce faire conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi des transports.Ancienne distribution: Rolland Brandbois, président Ernest Bujold, vice-président Jeannine Rondeau-Grandbois, sec.-trésorière Anita Lafrenière-Bujold Nouvelle distribution: Rolland Grandbois, président Jean Grandbois.vice-président Jeannine Rondeau-Grandbois, sec.-trésorière Lucien Grandbois Actions ordinaires 19.999 19,999 1 1 39,997 1 I The guide shall be equipped with a microphone.Sightseeing tour (Bus) of a minimum of five hours, from Québec to Ste-Anne-de-Beaupré, Mont-Ste-Anne and, on the return trip, tour of Québec City.Route: St-Cyrille Boulevard, Turnbull - Grande-Allée - St-Louis Street - Place d'Armes - Ste-Anne Street - Cook - Dauphine - D'Youville - D'Abraham Hill - De la Couronne Street -4th Street - 4th Avenue - De la Canardière -Ste-Anne Boulevard - Highway 15B from L'Ange-Gardien to Ste-Anne-de-Beaupré -Beaupré - Mont-Ste-Anne.And.on the return trip, Mont-Ste-Anne - Highway 15A to Ste-Anne Boulevard, entering Québec City by Dorchester Street - D'Abraham Hill -Dufferin Autoroute - St-Cyrille Boulevard -Turnbull - Grande-Allée to the entrance to the Battlefields Park on Bougainville Street -Gray Terrace - Monuments ('67 sculptures) - Museum - Wolfe's Monument - (Joan of Arc Park) - 10-minute stop in the Battlefields Park - Leaving the Park - Passing in front of the Parliament Buildings - St-Louis Street -Château Frontenac - Place d'Armes - Ste-Anne Street - Desjardins Street - City Hall (Cathedral) - Buade Street - Port Dauphin -Des Remparts - Lacroix Street - St-Paul Street - Dalhousie - Place Royale (20 to 30-minute stop) - and return to the starting point.Conditions: Tariff: $250 for a 47-passenger bus.The guide shall be equipped with a microphone.Region No.3 Contractor 12-13 The applicant requests a bulk trucking permit, transport of rough timber, Contractor class, for Region No.3.Region No.3 Contractor 12-13 The applicant requests a bulk trucking permit, Contractor class, for the transport of rough timber, in region No.3.The applicant, who holds certificate Q-501450-p-001, requests a bulk trucking permit, Artisan class, for region No.1.Application for transfer of shares: Mr.Ernest Bujold has sold the 19.999 common shares which he held in the company mise en cause.Authorization to do so is requested from the Commission in conformity with the provisions of section 39 of the Transport Act.Former Allotment: Common shares Rolland Grandbois, president: 19,999 Ernest Bujold, vice-president 19,999 Jeannine Rondeau-Grandbois, 1 secretary-treasurer : Anita Lafrenière-Bujold 1 New Allotment: Rolland Grandbois, president: 39,997 Jean Grandbois, vice-president: 1 Jeannine Rondeau-Grandbois, 1 secretary-treasurer: Lucien Grandbois 1 1148 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Rôle Q-2799 1389-DY & 2015-DYV-D-l BÊRUBÉ AUTOMOBILES INC.St-Philippe-de-Néri (Kamouraska) (Que.) Rôle Q-2802 13963-V-D-5 SPEEDWAY TRANSPORT LIMITED 20, boul.Marie-Victorin Bouchcrville (Que.) Nouvelle demande: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services de location comme suit: Service 1: Location à long terme de voitures et familiales.Service 2: Location à court terme de voitures et familiales.Service 3 : Location à long terme de camions.Service 4: Location à court terme de camions.Modification de permis: La requérante qui détient le permis No 13963-V dont les clauses a et b se lisent comme suit: n) Transport général - longue distance -route - De Montréal et Québec à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (point d'entrée: Ste-Rose-du-Dégelis) et retour, pour le transport de marchandises destinées aux Provinces Maritimes ou en provenant, suivant autorisation.b) Transport général - longue distance -route restreinte - irrégulier - De la frontière Québec-Nouveau-Brunswick à Montréal et les points intermédiaires situés à l'ouest de la ville de Québec, via les routes suivantes: a) Routes Nos 2-19 (vers Grand'Mère), 31 vers Joliette.6) Routes Nos 2-20 (route transcanadienne) et route No 9.c) Routes Nos 2-5-20 (régionale) - 20 (route transcanndienne).d) Routes Nos 2-20 (route transcanadienne) - 22 vers Sorel.- 3.e) Routes Nos 2-1-40./) Routes Nos 2-5-39-1.g) Routes Nos 2-5-1.Le voyage de retour doit être effectué avec un chargement minimum de dix tonnes par expéditeur, à l'exception de Trois-Rivières, où les chargements en lots brisés sont autorisés.Droits additionnels: 1.Nonobstant le paragraphe 10 de l'article 47 de l'Ordonnance générale sur le camionnage, la détentrice est autorisée, en vertu de la clause 6 de son permis, à desservir les points hors-parcours suivants: St-Casimir, Pont-Rouge et Lennoxville.2.La détentrice du permis est autorisée à suivre des itinéraires d'emprunt en voyageant en transit aux Etats-Unis pour rejoindre les Provinces Maritimes, notamment: via les routes 1, 50 et 5 vers le poste douanier de Rock Island: via la route 7 vers le poste douanier de Philipsburg; via les routes 9c et 9 vers le poste douanier de Blackpool.3.En donnant les services autorisés par la clause b et le droit additionnel No 2, la détentrice est autorisée à desservir les points suivant: Abbotsford, Philipsburg, St-John, Iberville, St-Constant et Blackpool.Droit additionnel se rattachant aux clauses a et 6 concernant l'utilisation de plaques amovibles RT.En exploitant les clauses a et b de son permis entre la frontière Québec-Nouveau-Brunswick ou entre la frontière Québec-Etats-Unis des points situés au Québec, et New application: .The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following leasing service: Service 1: ., Long-term leasing of automobiles and station wagons.Service 2: .Short-term leasing of automobiles and station wagons.Service 3: Long-term leasing of trucks.Service 4 : Short-term leasing of trucks.Modification de permis: The applicant which holds permit No.13963-V of which clauses o and 6 read as follows: (a) General trucking - long distance - route \u2014 From Montreal and Québec City to the Québec - New Brunswick border (port of entry: Ste-Rose-du-Dégelis) and return, for shipments consigned to or originating in the Maritime Provinces, as authorized.(b) General trucking \u2014 long distance - restricted route - irregular - From the Québec - New Brunswick border to Montreal and intermediate points west of Québec City via the following routes: (a) Highways Nos.2-19 (To Grand'Mère), 31 to Joliette.(6) Highways Nos.2-20 (Trans-Canada Highway) and Highway No.9.(c) Highways Nos.2-5-20 (Regional) - 20 (Trans-Canada Highway).(d) Highways Nos.2-20 (Trans-Canada Highway) - 22 to Sorel, 3.(e) Highways Nos.2-1-40.(/) Highways Nos.2-5-39-1.(g) Highways Nos.2-5-1.Return is authorized on the basis of a minimum cargo of a ten tons for one shipper, except for Trois-Rivières, where L.T.L.shipments can be accepted.Additional rights: 1.Notwithstanding paragraph 10 of article 47 of the General Order on Trucking, the holder is authorized, in virtue of clause b to serve the following off-route points: St-Casimir, Pont-Rouge and Lennoxville.2.The permit-holder is authorized to use alternate routes through the United States as \"in transit\" routes (corridor) the Maritime Provinces in the following manner: via highways 1, 50 and 5 to port of entry: Rock Island, via highway 7 to port of entry: Philipsburg; highways 9c and 9 to port of entry: Blackpool.3.In giving the services authorized by clause b and additional right 2, the holder is authorized to serve the following points: Abbotsford, Philipsburg, St-John, Iberville, St-Constant and Blackpool.Additional right to clauses a and b for the use of RT Revolving plates.When operating under clauses a and b of its permit between the Québec - New Brunswick border, and alternatively, between the Québec - United States border to or from GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1149 Rôle Q-2803 15-V-D-16 TRANSPORT D'ANJOU INC.373 Témiscouata C.P.430 Rivière-du-Loup (Que.) que la détentrice est autorisée à desservir, cette dernière est autorisée à utiliser des plaques amovibles RT délivrées par la Régie, ces dernières devant être posées sur les remorques de transporteurs non attitrés détenant des permis délivrés par leurs juridictions respectives, lesdites remorques ayant été échangées à des points précis au Nou-veau-Brunswick, suivant autorisation afin de poursuivre ledit service dans la province de Québec.Le droit additionnel mentionné ci-dessus est soumis aux dispositions de l'arrêté en conseil No 3760, en date du 7 octobre 1970, relatif à l'utilisation des plaques amovibles RT délivrées par le Service des véhicules automobiles, sur les remorques immatriculées par des juridictions n'ayant pas d'accord de réciprocité avec la province de Québec, demande à la Commission des transports du Québec de modifier lesdites clauses a et 6 afin qu'elles se lisent comme suit à l'avenir: a) Transport général - longue distance -route - De Montréal, Mirabel et Québec à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (point d'entrée: Ste-Rose-du-Dégelis) et retour, pour le transport de marchandises destinées aux Provinces Maritimes ou en provenant, suivant autorisation.6) Transport général - longue distance -route restreinte - irrégulier - De la frontière Québec-Nouveau-Brunswick à Mirabel et Montréal ainsi qu'aux points intermédiaires situés à l'ouest de la ville de Québec et entre cette dernière ville et Montréal, via les route suivantes: a) Routes Nos 2-19 (vers Grand'Mère) -31 vers Joliette.6) Routes Nos 2-20 (route transcanadienne) et route No 9.c) Routes Nos 2-2-20 (régional) -20 (route transcanadienne).d) Routes Nos 2-20 (route transcanadienne) - 22 vers Sorel, 3.e) Routes Nos 2-1-40./) Routes Nos 2-5-39-1.g) Routes Nos 2-5-1.Le voyage de retour doit être effectué avec un chargement minimum de dix tonnes par expéditeur, à l'exception de Trois-Rivières où les chargements en lots brisés sont autorisés.Les droits additionnels, qui se rattachent présentement aux clauses mentionnées ci-dessus, seront applicables auxdites clauses sous leur forme modifiée.Modification de permis: La partie requérante, détentrice du permis numéro 15-V, dont les clauses a et k se Usent comme suit: a) Transport général - longue distance -route - a) De Rivière-du-Loup à Montmagny et Québec et Montréal via routes 2, 2-A, et retour.En donnant le service autorisé par la clause a de son permis, la détentrice a le droit et l'obligation de faire la cueillette et la livraison des marchandises, au moins deux fois par semaine, dans toutes les localités situées dans les districts électoraux-provinciaux de L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata, ainsi qu'à Biencourt et Lac-des-Aigles.oints as authorized in the Province of Qué-ec, the holder is authorized to utilize RT Revolving plates of the Board on trailers of non-authorized carriers holding permits issued by their own jurisdiction, such trailers having been interchanged at specific localities of New Brunswick, as authorized for furtherance of the service in the Province of Québec.The additional right above mentioned is subordinate to the stipulations of Order in Council No.3760 dated October 7th, 1970, regarding the utilization of RT Revolving plates of the Motor Vehicle Service on trailers originating from jurisdictions which do not enjoy reciprocity privileges with the Province of Québec.has applied to the Québec Transport Commission to modify said clauses a and b so that they read in the future: (a) General trucking - long distance - rou-te- From Montreal, Mirabel and Québec City to the Québec - New Brunswick border (port of entry: Ste-Rose-du-Dégelis) and return, for shipments consigned to or originating in the Maritime Provinces, as authorized (6) General trucking - long distance - restricted route - irregular - From the Québec - New Brunswick border to Mirabel and to Montreal and intermediate points west of Québec City between said Québec City and Montreal via the following routes : (a) Highways Nos.2-19 (To Grand'Mère), 31 to Joliette.(6) Highways Nos.2-20 (Trans-Canada Highway) and Highway No.9.(c) Highways Nos.2-2-20 (Regional) -(Trans-Canada Highway).(d) Highways Nos.2-20 (Trans-Canada Highway) - 22 to Sorel, 3.(e) Highways Nos.2-1-40.(/) Highways Nos.2-5-39-1.(0) Highways Nos.2-5-1.Return is authorized on the basis of a minimum cargo of a ten tons for one shipper, except for Trois-Rivières, where L.T.L.shipments can be accepted.The additional rights presently applying to the above mentioned clauses shall apply to the said clauses as amended.Modification of permit: The applicant, holder of permit No.15-V, of which clauses a and k read as follows: (a) General trucking - long distance -route - (a) From Rivière-du-Loup to Montmagny, Québec and Montreal via Highways Nos.2 and 2A, and return.When providing the service authorized under clause a of its permit, the holder shall have the right and obligation to pick up and deliver goods, at least twice a week, in all the localities situated in the Provincial Electoral Districts of L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup and Témiscouatu, as well as in Biencourt and Lac-des-Aigles, 1150 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Rôle Q-2804 7737-V-D-5 BELLECHASSE TRANSPORT INC.3600, boul.Hamel Québec Requérante / Applicant Droit additionnel: En donnant le service prévu par cette clause, la détentrice est autorisée à effectuer la livraison de bois préparé dans un rayon de 75 milles de Québec et dans un rayon de 100 milles de Montréal, ainsi qu'à Lambton et à Lac-Mégantic.Restrictions: 1.Le droit additionnel n'autorise pas la détentrice à donner un service de cueillette à St-Pamphile et à Tourville dans le comté de L'Islet.2.Ce droit additionnel n'autorise pas non plus la détentrice à effectuer des livraisons de bois aux endroits situés dans le comté d'Arthabaska ainsi qu'à Develuyville (Ni-colet).k) Transport général - longue distance -route restreinte - k) De St-Jean-Port-Joli et L'Islet à Montréal et retour.demande à la Commission des transports de modifier lesdites clauses pour qu'elles se lisent comme suit à l'avenir: a) Transport général - longue distance -route - a) De Rivière-du-Loup à Montmagny et Québec, Montréal et Mirabel et retour.En donnant le service autorisé par la clause o de son permis, la détentrice a le droit et l'obligation de faire la cueillette et la livraison des marchandises au moins deux fois par semaine dans toutes les localités situées dans les districts électoraux provinciaux de L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata, ainsi qu'à Biencourt et Lac-des-Aigles.k) Transport général - longue distance -route restreinte - k) De St-Jean-Port-Joliet L'Islet à Montréal et Mirabel, et retour.Modification de permis: La requérante, détentrice du permis numéro 7737-V, dont les clauses c.d, e, h, j, et m se lisent comme suit: d) Transport général - longue distance -route - De Québec à Montréal, et retour.Droit additionnel: En donnant le service précité, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises à L'Ancienne-Lorette.Val-St-Michel, Lac-St-Charles.Lo-retteville.Village Huron.Valcartier, St-Emile Beaupré, Ste-Anne-de-Beaupré: ce service, devra être donné aux taux déposés à la Commission par la détentrice pour chacun de ces endroits.d) Transport général - longue distance -route restreinte - De St-Charles (Bellechasse) à Montréal, et retour.Droit additionnel: A l'occasion du service précité, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises dans toutes les localités du district électoral provincial de Bellechasse, ainsi que dans St-Henri (Lévis).e) Transport général - longue distance -route restreinte - De St-Prosper (Dorchester) à Montréal, et retour.Droit additionnel: A l'occasion du service précité, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises dans toutes les Additional right: ,___.When providing the service authorized by this clause, the holder shall be authorized to effect the delivery of dressed lumber within a radius of 75 miles from Québec City and within a radius of 100 miles from Montreal, and to Lambton and Lac-Mégantic.Restrictions: .1.The additional right does not authorize the holder to provide a pick-up service in St-Pamphile and in Tourville in the County of L'Islet.\u201e .2.Nor does this additional right authorize the holder to effect the delivery of lumber in the localities situated in the County of Ar-thabaska and Daveluyville, County of Nicolet.(,k) General trucking - long distance -restricted route - (i) From St-Jean-Port-Jol i and L Islet to Montreal, and return.m _ requests the Québec Transport Commission to modify said clauses to read as follows in the future: (a) General trucking - long distance -route - (a) From Rivière-du-Loup to Montmagny and Québec City, Montreal and Mirabel, and return.When providing the service authorized under clause a of its permit, the holder has the right and obligation to pick up and deliver goods, at least twice a week, in all the localities situated in the_ Provincial Electoral Districts of L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup and Témiscouata.as well as in Biencourt and Lac-des-Aigles.(k) General trucking - long distance -restricted route \u2014 (k) From St-Jean-Port-Jol i and L'Islet to Montreal and Mirabel and return.Modification of permit : The applicant, holder of permit No.7737-V.of which clauses c, d, e, h, j and m read as follows: (c) General trucking - long distance -route - From Québec City to Montréal, and return.Additional right: When providing the aforesaid service, the holder shall be authorized to pick up and and deliver goods in Ancienne Lorette.Val-St-Michel.Lac-St-Charles.Loretteville, Village Huron.Valcartier.St-Emile.Beaupré.Ste-Anne-de-Beaupré; this service shall be provided according to the rates filed with the Commission by the holder, for each of these points.(if) General trucking - long distance -restricted route - From St-Charles (Bellechasse) to Montreal, and return.Additional right: When providing the aforesaid service, the holdershall be authorized to pick up and deliver goods in all the localities situated in the Provincial Electoral District of Bellechasse, as well as in St-Henri, County of Levis.(e) General trucking - long distance -restricted route - From St-Prosper.County of Dorchester to Montreal, and return.Additional right: When providing the aforesaid service, the holder shall be authorized to pick up and deliver goods in all the localities situated in GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1151 localités du district électoral provincial de Dorchester, à l'exception de Scott, ainsi qu'à ville St-Georges-Ouest (Beauce).h) Transport général - longue distance -route restreinte - De Cap-Santé, St-Basile.Pont-Rouge et Donnacona à Montréal, et retour.j) Transport général - longue distance -route restreinte - DeSte-Marie (Beauce) à Plessisville, Richmond, Sherbrooke, St-Hyacinthe, Montréal et Québec, et retour.m) Transport général - longue distance -route - De Nicolet et de Ste-Angèle à Montréal et retour.Droits additionnels: 1.Ce service comprend aussi les points intermédiaires entre Ste-Angèle et Yamaska (cette localité incluse), ainsi que St-Célestin, St-Léonard et Ste-Monique.2.En donnant les services autorisés par la clause m de son permis, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises à Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine, via le pont de Trois-Rivières, nonobstant les dispositions de l'Ordonnance générale No 7225 du 22 février 1972.demande à la Commission des transports d'amender lesdites clauses de façon à ce qu'elles se lisent comme suit à l'avenir: c) Transport général - longue distance -route - De Québec à Montréal et Mirabel, et retour.Droit additionnel: En donnant le service précité, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises à L'Ancienne-Lorette, Val-St-Michel.Lac-St-Charles, Lo-retteville, Village Huron, Valcartier, St-Emile.Beaupré, Ste-Anne-de-Beaupré; ce service devra être donné aux taux déposés à la Commission par la détentrice pour chacun de ces endroits.d) Transport général - longue distance -route restreinte - De St-Charles (Bellechasse) à Montréal et Mirabel, et retour.Droit additionnel: A l'occasion du service précité, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises dans toutes les localités du district électoral provincial de Bellechasse, ainsi que dans St-Henri (Lévis).c) Transport général - longue distance -route restreinte - De St-Prosper (Dorchester) à Montréal et Mirabel, et retour.Droit additionnel: A l'occasion du service précité, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises dans toutes les localités du district électoral provincial de Dorchester, à l'exception de Scott, ainsi qu'à ville St-Georges-Ouest (Beauce).h) Transport général - longue distance -route restreinte - De Cap-Santé, St-Basile, Pont-Rouge et Donnacona à Montréal et Mirabel, et retour.f) Transport général - longue distance -route restreinte - the Provincial Electoral District of Dorchester, except Scott, and in the Town of St-Georges-West, County of Beauce.(A) General trucking - long distance -restricted route - From Cap-Santé, St-Basile, Pont-Rouge and Donnacona to Montreal, and return.0) General trucking - long distance -restricted route - From Ste-Marie.County of Beauce, to Plessisville, Richmond, Sherbrooke, St-Hyacinthe, Montreal and Québec, and return.(m) General trucking - long distance -route - From Nicolet and Ste-Angèle to Montreal, and return.Additional rights: 1.This service also covers intermediate points between Ste-Angèle and Yamaska (this locality included), as well as St-Céles-tin, St-Léonard and Ste-Monique.2.When providing the services authorized by clause m of its permit, the holder shall be authorized to pick up and deliver goods in Trois-Rivières, Trois-Rivières-West and Cap-de-la-Madeleine, via the Trois-Rivières Bridge the foregoing notwithstanding the provisions of the General Order No.7225 dated February, 1972.requests the Transport Commission to modify sais clauses to read as follows in the future: (c) General trucking - long distance -route - From Québec City to Montreal and Mirabel, and return.Additional right: When providing the aforesaid service, the holder shall be authorized to pick up and deliver goods in Ancienne-Lorette, Val-St-Michel, Lac-St-Charles.Loretteville, Village Huron.Valcartier, St-Emile, Beaupré.Ste-Anne-de-Beaupré; this service shall be provided according to the rates filed with the Commission by the holder, for each of these points.(d) General trucking - long distance -restricted route - From St-Charles, County of Bellechasse, to Montreal and Mirabel, and return.Additional right: When providing the aforesaid service, the holder shall be authorized to pick up and deliver goods in all the localities situated in the Provincial Electoral District of Belle chasse, as well as in St-Henri, County of Levis.(e) General trucking - long distance -restricted route - From St-Prosper, County of Dorchester, to Montreal and Mirabel, and return.Additional right: When providing the aforesaid service, the holder shall be authorized to pick up and deliver goods in all the localities situated in the Provincial Electoral District of Dorchester, except Scott, as well as in the Town of St-Georges-West, County of Beauce.(h) General trucking - long distance -restricted route - From Cap-Santé, St-Basile, Pont-Rouge and Donnacona to Montreal and Mirabel, and return.(j) General trucking - long distance -restricted route - 1152 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Rôle Q-2805 5427-V-D-3 RIMOUSK1 TRANSPORT LIMITÉE 377, 2ème Rue est Rimouski (Que.) De Ste-Marie (Beauce) à Plessisville, Richmond, Sherbrooke, St-Hyacinthe, Montréal, Mirabel et Québec, et retour.m) Transport général - longue distance -route - De Nicolet et de Ste-Angèle à Montréal et Mirabel, et retour.Droits additionnels: 1.Ce service comprend aussi les points intermédiaires entre Ste-Angèle et Yamaska (cette localité incluse), ainsi que St-Célestin, St-Léonard et Ste-Monique.2.En donnant les services autorisés par la clause m de son permis, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises à Trois-Rivières.Trois-Riviè-res-Ouest et Cap-de-la-Madeleine, via le pont de Trois-Rivières, nonobstant les dispositions de l'Ordonnance générale No 7225 du 22 février 1972.Tous les droits additionnels présentement contenus dans le permis numéro 7737-V et afFectant les clauses ci-dessus mentionnées continueront à s'appliquer auxdites clauses telles que modifiées.Modification de permis: La partie requérante, détentrice du permis numéro 5427-V, dont les clauses e et d M lisent comme suit: c) Transport général - longue distance -route - c) De Rimouski et MontrJoli à Montma-gny.Québec, Montréal et Pointe-Claire, via les routes 6, 10, 2 et 2-A, et alternativement via les routes 6, 10, 2 et 9, et retour.En donnant ce service de route, la détentrice aura le droit et l'obligation de desservir régulièrement, au moins deux fois par semaine, toutes les localités sur les routes 6 et 6-A.d) Transport général - longue distance -cueillette et livraison - d) En donnant le service prévu à la clause précédente, la détentrice aura le droit et l'obligation de faire irrégulièrement la cueillette et la livraison des marchandises dans toutes les localités situées dans les six comtés provinciaux de Rimouski, Matane, Matapédia, Bonaventure, Gaspé-Nord et Gaspé-Sud.Droit additionnel re : clauses c et d : En donnant les services décrits aux clauses c et d, la détentrice est autorisée à donner un service de transport il toutes les localités situées dans le comté de Saguenay, au nord-est de Forestville (cette localité incluse) et retour, via route No 15, en utilisant les services maritimes des transbordeurs et les services des détenteurs de permis sur la Rive-Nord.Demande à la Commission des transports de modifier la clause c de son permis de façon à ce qu'elle se lise à l'avenir comme suit* c) Transport général - longue distance -route - c) De Rimouski et Mont-Joli à Montma-gny, Québec, Montréal, Pointe-Claire et Mirabel, et retour.En donnant ce service de route, la détentrice aura le droit et l'obligation de desservir régulièrement, au moins deux fois par semaine, toutes les localités sur les routes 6 et 6-A.N.B.- Les droits additionnels s'appliquant présentement aux clauses c et d s'appliquent à la clause c telle que modifiée.From Ste-Marie, in the County of Beauce, to Plessisville.Richmond, Sherbrooke, St-Hyacinthe.Montreal, Mirabel and Québec City and return.(m) General trucking - long distance -route - From Nicolet.and from Ste-Angèle to Montreal and Mirabel, and return.Additional rights: 1.This service also covers intermediate points between Ste-Angèle and Yamaska (this local ity included), as well as St-Célestin, St-Léonard, and Ste-Monique.2.When providing the services authorized by clause m of its permit, the holder shall be authorized to pick up and deliver goods in Trois-Rivières, Trois-Rivières-West and Cap-de-la-Madeleine, via the Trois-Rivières Bridge, the foregoing notwithstanding the provisions of General Order No.7225, dated February 22.1972.All additional rights presently contained in permit No.7737-V and relating to the above-mentioned clauses shall continue to apply to said clauses, as modified.Modification of permit: The applicant, holder of permit number 5427-V, of which clauses e and d read as follows: (c) General trucking - long distance -route- (c) From Rimouski and Mont-Joli to Montmagny, Québec City, Montréal and Pointe-Claire, via Highways 6, 10, 2 and 2-A, and alternatively via Highways 6, 10, 2 and 9, and return.When providing this highway service, the holder shall have the right and obligation to serve all localities situated on Highways 6 and 6-A, on a regular basis, at least twice a week.{d) General trucking - long distance -pick-up and delivery - (d) When providing the service stipulated in the previous clause, the holder shall have the right and obligat ion to pick up and deliver goods on an irregular basis, in all localities situated in the following: six provincial counties: Rimouski, Matane, Matapédia, Bonaventure, Gaspé-North and Gaspé-South.Additional right attaching to clauses c and d: When providing the services described in clauses c and d, the holdershall be authorized to provide a transport service in all localities situated in the County of Saguenay.to the northeast of Forestville (including this locality) and return, via Highway No.15, utilizing the ferry services and the services of permit-holders on the North Shore.Requests from the Transport Commission that clause c of its permit be modified in order to read henceforth as follows: (c) General trucking - long distance -route - (c) From Rimouski and Mont-Joli to Montmagny, Québec City.Montreal, Pointe-Claire and Mirabel, and return.When providing this highway service, the holder shall have the right and obligation to serve all localities on Highways 6 and 6-A, regularly, at least twice a week.Note - The additional rights applying presently to clauses c and d also apply to clause c as modified. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107< année, n° 5 1153 Rôle Q-2806 2278-V-D-6 HAMEL TRANSPORT LIMITÉE 1041.rue St-Chri3tophe St-Félicien (Que.) Rôle Q-2307 16903-V-D-8 CARTIER TRANSPORT INC.153, rue Maltais Sept-Hea (Que.) Modification de permis: La requérante, détentrice du permis numéro 2278-V, dont les clauses c, / et * se lisent comme suit: c) Transport général - longue distance -route - De StrFélicien à Québec et Montréal, et retour.En donnant les services autorisés par la clause c de son permis, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison dans toutes les municipalités des districts électoraux provinciaux ae Roberval.St-Jean, Jonquière, Kénogami, Chicoutimi et Dubuc./) Transport restreint - longue distance -route restreinte - De Montréal, Québec, Chicoutimi et Roberval à tous les endroits situés dans les districts électoraux provinciaux de Chicoutimi, Jonquière, Kénogami, Lac St-Jean, Roberval de même qu'à Chibougamau et à tous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles de cette dernière localité et à tous les endroits situés à dix (10) milles de chaque côté de la route St-Félicien-Chi-bougamau pour le transport, par camiors citernes, de produits pétrolifères, dont la capacité maximum ne devra dépasser 4,000 gallons.a) Transport général - longue distance -route - De Montréal à Québec, et retour, via route No 20.demande à la Commission des transports une modification de son permis afin que lesdites clauses se lisent à l'avenir comme suit: e) Transport général - longue distance -route - De St-Félicien à Québec, Montréal et Mirabel, et retour.En donnant les services autorisés par la clause c de son permis, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison dans toutes lea municipalités des districts électoraux provinciaux de Roberval, St-Jean, Jonquière, Kénogami, Chicoutimi et Dubuc./) Transport restreint - longue distance -route restreinte - De Montréal, Mirabel, Québec, Chicoutimi et Roberval à tous les endroits situés dans les districts électoraux provinciaux de Chicoutimi, Jonquière.Kénogami, Lac St-Jean, Roberval de même qu'à Chibougamau et à tous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles de celte dernière localité et.à tous les endroits situés à dix (10) milles de chaque côté de la route St-Félicien-Chi-bougamau pour le transport, par camions citernes, de produits pétrolifères, dont la capacité maximum ne devra dépasser 4,000 gallons.a) Transport général - longue distance -route- De Montréal et Mirabel à Québec, et retour, via route No 20 et routes donnant accès à Mirabel.Tous les droits additionnels présentement contenus dans le permis numéro 2278-V et s'appliquant aux clauses ci-dessus mentionnées continueront de s'appliquer aux dites clauses telles que modifiées.Modification de permis: La partie requérante, détentrice du permis numéro 16903-V, dont la clause c se lit comme suit: c) Transport général - longue distance -route - Modification of permit: The applicant, holder of permit number 2278-V, of which clauses c, / and a read as follows: (c) General trucking - long distance -route- From St-Félicien to Québec City and Montreal, and return.When providing the services authorized by clause c of its permit, the holder shall be authorized to pick up and deliver goods in all the municipalities of the Provincial Electoral Districts of Roberval, St-Jean.Jonquière, Kénogami, Chicoutimi and Dubuc.(/) Restricted trucking - long distance -restricted route - From Montréal, Québec City, Chicoutimi and Roberval to all points located in the Provincial Electoral Districts of Chicoutimi, Jonquière, Kénogami, Lac St-Jean, Roberval including Chibougamau and all points located within a radius of thirty (30) miles from this last locality and to all points located within a distance of ten (10) miles on either side of the St-Félicien-Chibougamau Highway for the transport of petroleum products by tank truck of a maximum capacity of 4,000 gallons.(a) General trucking - long distance -route - From Montreal to Québec City, and return, via Highway No.20.requests from the Transport Commission that its permit be modified in order that said clauses read henceforth as follows: (c) General trucking - long distance -route- From St-Félicien to Québec City, Montréal and Mirabel, and return.When providing the services authorized by clause c of its permit, the holder shall be authorized to pick-up and deliver goods in all the municipalities of the Provincial Electoral Districts of Roberval, St-Jean, Jonquière.Kénogami, Chicoutimi and Dubuc.(/) Restricted trucking - long distance -restricted route - From Montreal.Mirabel, Québec City.Chicoutimi and Roberval to all points located in the Provincial Electoral Districts of Chicoutimi, Jonquière.Kénogami, Lac St-Jean, Roberval including Chibougamau and all points located within a radius of thirty (30) miles from this last localiy and to all points located within a distance of ten (10) miles on either side of the St-Félicien-Chibougamau Highway for the transport of petroleum products by tank trucks of a maximum capacity of 4,000 gallons.(a) General trucking - long distance -route - From Montreal and Mirabel to Quebec City, and return, via Highway No.20 and Highways leading to Mirabel.All the additional rights presently included in permit number 2278-V and attaching to the abovementioned clauses shall continue to apply to said clauses as modified.Modification of permit: The applicant, holder of permit number 16903-V, of which clause c read as follows: (c) General trucking - long distance -route - 1154 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Rôle Q-2808 7147-V-D-6 L.THIBODEAU TRANSPORT INC.228, 2e Avenue Portneuf (Que.) c) De Sept-Iles.Baie-Ccmeau, Forestville, Tadoussac à Québec, Trois-Rivières et Montréal, et retour.Droits additionnels: 1.En donnant les services autorisés par son permis, la détentrice est autorisée au transport par camion isotherme et chauffé, fardiers et véhicules spécialement agencés pour le transport de ménages et d'ameublements usagés.3.En donnant les services autorisés par la clause c du présent permis, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises à tous les points situés sur la route 15, entre St-Fidèle et Moisie, ces deux points inclus.Demande à la Commission des transports de modifier ladite clause pour qu'elle se lise comme suit à l'avenir: c) Transport général - longue distance -route - c) De Sept-Iles, Baie-Comeau, Forestville, Tadoussac à Québec, Trois-Rivières, Montréal et Mirabel, et retour.N.B.- Tous les droits additionnels présentement contenus dans le permis numéro 16903-V et affectant la clause ci-dessus mentionnée continueront à s'appliquer à ladite clause telle que modifiée.Modification de permis: La requérante, détentrice du permis numéro 7147-V, dont les clauses c, f, h, l, et n se lisent comme suit: c) Transport général - longue distance -route restreinte - De Portneuf à Québec et Montréal, et retour.Droit additionnel: En donnant le service en vertu de la clause e de son permis, la détentrice pourra faire usage de camions isothermes./) Transport général - longue distance -route - De Québec à Montréal, et retour, à l'exclusion des points intermédiaires.Droits additionnels attachés à la clause /: 1.Pour donner le service autorisé en vertu de la clause / de son permis, la détentrice devra déposer à la Régie des taux spécifiques pour la cueillette et la livraison des marchandises à Valcartier.à toutes les municipalités de l'Ile d'Orléans et à St-Félix-de-Cap-Rouge, St-Augustin-de-Desmaures, ville de l'Ancien-ne-Lorette, paroisse de l'Ancienne-Lorette, cité de Loretteville.village de St-Emile, ville de Bélnir: ville de Notre-Dame-des-Laurentides, municipalité de Lac-St-Charles.ville de Val-St-Michel.ville d'Orsainville.municipalité de Ste-Thérèse-de-Lisieux.2.En donnant le service en vertu de la clause / de son permis, la détentrice pourra faire usage de camions isothermes.h) Transport général - longue distance -route restreinte - De Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Yamachiche et St-Barthélé-my à Montréal, et retour, pour le transport de marchandises destinées aux cinq premiers endroits ou en provenant, sauf le transport de produits ou marchandises destinés à la Fabrique de Produits Laitiers Laurentide Limitée (Crino) ou en provenant.1.Transport général - longue distance -route restreinte - De Shawinigan, Grand'Mère, Ste-Flore.St-Boniface.Baie-Shawinigan, Almaville, St-Mathieu il Trois-Rivières, Joliette, Montréal et retour.(c) From Sept-Iles.Baie-Comeau, Forestville.Tadoussac to Québec City.Trois-Rivières and Montreal, and return.Additional rights: 1.When providing the services authorized by its permit, the holder shall be authorized to use temperature-controlled and heated trucks, floats and specially equipped vehicles for the transport of household goods and used furniture.3.When providing the services authorized by clause c of the present permit, the holder shall be authorized to pick-up and deliver goods to all points located along Highway 15, between St-Fidèle and Moisie, these two points included.requests from the Transport Commission that aaid clause be modified in order to read henceforth as follows: (e) General trucking - long distance -route - (c) From Sept-Iles, Baie-Comeau, Forestville, Tadoussac to Québec City.Trois-Riviires, Montreal and Mirabel, and return.Note - All the additional rights presently included in permit number 16903-V and attaching to the abovementioned clause shall continue to apply to said clause as modified.Modification ol permit: The applicant, holder of permit number 7147-V, of which clauses c,f, k, I and n read as follows: (c) General trucking - long distance - restricted route - From Portneuf to Québec City, and Montreal, and return.Additional right: When providing the service authorized by clause c of its permit, the holder may use temperature-controlled trucks.(/) General trucking - long distance - route- From Québec City to Montreal, and return, excluding intermediate points.Additional rights attaching to clause /: 1.In order to provide the service authorized in virtue of clause / of its permit, the holder shall file with the Board specific rates for the pick up and delivery of goods in Valcartier, in all the Municipalities of the Island of Orléans and in St-Félix-de-Cap-Rouge, St-Augustin-de-Desmaures.Town of Ancienne-Lorette.Parish of Ancienne-Lorette, City of Loretteville, Village of St-Emile, Town of Bélair, Town of Notre-Dame-des-Laurenti-des.Municipality of Lac-St-Charles.Town of Val-St-Michel.Town of Orsainville, municipality of Ste-Thérèse-de-Lisieux.2.When providing the service authorized by clause / of its permit, the holder may use temperature-controlled trucks.(A) General trucking - long distance - restricted route - From Trois-Rivières.Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac.Yamachiche and St-Barthe-lémy to Montreal, and return, for the transport of goods destined to or originating from the first five points, except for the transport of products or goods destined to or originating from the Fabrique de Produits Laitiers Laurentide Limitée (Crino).1.General trucking - long distance - restricted route - From Shawinigan, Grand'Mère, Ste-Flore.St-Boniface, Baie-Shawinigan! Almaville.St-Mathieu to Trois-Rivières, Joliette, Montreal and return. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1155 Rôle Q-2809 4724-V-D-2 MAGNY TRANSPORT INCORPORÉ 162, boul.Mercier Amos (Que.) n) Transport général - longue distance -route restreinte - irrégulier - De St-Elie, Charette et St-Mathieu à Shawinigan, Grand'Mère, Trois-Rivières, Joliette, Montréal et Québec, et retour.Droit additionnel: La détentrice est autorisée à transporter des marchandises dans des camions, remorques et semi-rem orques réfrigérés et isothermes.demande à la Commission des transports une modification de son permis afin que les-dites clauses se lisent à l'avenir comme suit: c) Transport général - longue distance -route restreinte - De Portneuf à Québec, Montréal et Mirabel et retour.Droit additionnel: En donnant le service en vertu de la clause c de son permis, la détentrice pourra faire usage de camions isothermes./) Transport général - longue distance -route - De Québec à Montréal et Mirabel, et retour, à l'exclusion des points intermédiaires.Droits additionnels attachés à la clause /: 1.Pour donner le service autorisé en vertu de la clause / de son permis, la détentrice devra déposer à la Régie des taux spécifiques pour la cueillette et la livraison des marchandises à Valcartier, à toutes les municipalités de l'Ile d'Orléans et à St-Félix-de-Cap-Rouge, St-Augustin-de-Desmaures.ville de l'Ancienne-Lorette, paroisse de l'Ancienne-Lorette.cité de Loretteville.village de St-Emile, ville de Bélair, ville de Notre-Dame-des-Laurentides.municipalité de Lac-St-Charles.ville de Val-St-Michel.ville d'Or-sainville, municipalité de Ste-Thérèse-de-Lisieux.2.En donnant le service en vertu de 1 a clause /) de son permis, la détentrice pourra faire usage de camions isothermes.h) Transport général - longue distance -route restreinte - De Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Yamachiche et St-Barthélé-my à Montréal et Mirabel et retour, pour le transport de marchandises destinées aux cinq premiers endroits ou en provenant, sauf le transport de produits ou marchandises destines à la Fabrique de Produits Laitiers Lau-rentide Limitée (Crino) ou en provenant.1.Transport général - longue distance -route restreinte - De Shawinigan, Grand'Mère, Ste-Flore, St-Boniface, Baie-Shawinigan, Almaville, St-Mathieu à Trois-Rivières, Joliette, Montréal et Mirabel et retour.n) Transport général - longue distance -route restreinte - irrégulier - De St-Elie.Charette et St-Mathieu à Shawinigan, Grand'Mère, Trois-Rivières, Joliette, Montréal, Mirabel et Québec, et retour.Droit additionnel: La détentrice est autorisée à transporter des marchandises dans des camions, remorques et semi-remorques réfrigérés et isothermes.Modification de permis: La requérante, détentrice du permis numéro 4724-V dont les clauses d et j de même que la clause numéro 1 ajoutée par décision de la Commission des transports en date du 22 octobre 1974 se lisent comme suit: d) Transport général - longue distance -route restreinte - (n) General trucking - long distance - restricted route - irregular - From St-Elie, Charette and St-Mathieu to Shawinigan, Grand'Mère.Trois-Rivières, Joliette, Montreal and Québec City, and return.Additional right: The holder shall be authorized to transport goods in refrigerated and temperature-controlled trucks, trailers and semi-trailers.requests from the Transport Commission that its permit be modified so that said clauses read henceforth as follows: (c) General trucking - long distance - restricted route - From Portneuf to Québec City, Montreal and Mirabel, and return.Additional right: When providing the service authorized by clause c of its permit, the holder shall use temperature-controlled trucks.(/) General trucking - long distance - route- From Québec City to Montréal and Mirabel, and return, except intermediate points.Additional rights attaching to clause /: 1.In order to provide the service authorized in virtue of clause / of its permit, the holder shall file with the Board specific rates for the pick up and delivery of goods in Valcartier, in all the municipalities of the Island of Orléans and in St-Félix-de-Cap-Rouge, St-Augustin-de-Desmaures, Town of Ancienne-Lorette, Parish of Ancienne-Loret-te.City of Loretteville, Village of St-Emile.Town of Bélair, Town of Notre-Dame-des-Laurentides, Municipality of Lac-St-Charles, Town of Val-St-Michel, Town of Orsainville, Municipality of Ste-Thérèse-de-Lisieux.2.When providing the service in virtue of clause / of its permit, the holder may use temperature-controlled trucks.(A) General trucking - long distance - restricted route - From Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Yamachiche and St-B îrthé-lémy to Montreal and Mirabel, and return, for the transport of goods destined to or originating from the first five points, except for the transport of products or goods destined to or originating from the Fabrique de Produits Laitiers Laurentide Limitée (Crino).1.General trucking - long distance - restricted route - From Shawinigan, Grand'Mère, Ste-Flore, St-Boniface, Baie-Shawinigan, Almaville, St-Mathieu to Trois-Rivières, Joliette, Montreal and Mirabel and return.(n) General trucking - long distance - restricted route - irregular - From St-Elie, Charette and St-Mathieu to Shawinigan, Grand'Mère.Trois-Rivières.Joliette, Montreal.Mirabel and Québec City, and return.Additional right: To holder shall be authorized to transport goods in refrigerated and temperature-controlled trucks, trailers and semi-trailers.Modification of permit: The applicant, holder of permit number 4724-V in which clauses d and and also clause number 1 added by a decision of the Transport Commission rendered on October 22, 1974, read as follows: (r: chool Board.DECISIONS DE LA COMMISSION «PROPRIO MOTU» /DECISIONS 'PROPRIO MOTU'' BY THE COMMISSION No\tDate\tRequérants Applicants\tG page\tO.Q.date\tCause Case\tDécisions QCR-9I5\t20-01-75\t19884-V-P-l LUCIEN SIMONEAU\t9643\t28-12-74\tO-2680\t La Commission annule, à toutes Tins que de droit, le permis No 19884-V détenu par Lucien Simoneau.QCR-916 20-01-75 38I8-V-P-1 BEAUCE EXPRESS INC.The Commission cancels, for all legal purposes, permit No.19884-V held by Lucien Simoneau.1 9643 128-12-74 1 0-2681 La Commission: 1.rescinde sa décision QCR-486 du 19 mars 1974; 2.autorise Beauce Express Inc.à donner à l'avenir la clause n suivante: Transport général - longue distance - rayon -De St-Joseph-de-Beauce et de Beauce-Jonction à ailleurs dans la municipalité du comté de Beauce, et retour.The Commission: 1.cancels its decision QRC-486 dated March 19, 1974; 2.authorizes Beauce Express Inc.to operate the following clause n in the future: General trucking - long distance - radius -From St-Joseph-de-Beauce and Beauce-Jonction to other points in the County Municipality of Beauce.and return.QCR-917 20-01-75 9633-V-P-2 [ |JEAN BOUCHARD La Commission décrète la remise du cautionnement de $50 fait par Bouchard Transport Enrg.dans la cause 0-492 (décision QCR-835).QCS-489 20-01-75 I3963-V-P-4 SPEEDWAY EXPRESS LTD.Voiturier-roulier / Carrier 23038-V GLENDON W.NICE Voiturier-remorqueur Haulaway operator La Commission annule les permis de tiré et tireur conjoints de: Speedway Express Ltd.No 13963-V et Nice.Glendon W.No 23038-V.j 9642 128-12-74 JQ-2678 | The Commission orders the reimbursement of ihe deposit of $50 made by Bouchard Transport Enrg.in case 0-492 (decision QCR-835).9643 28-12-74 Q-2679 The Commission cancels the joinl carrier's and haulaway operator's permits held by: Speedway Express Ltd.No.13963-V and Nice.Glendon W.No.23038-V. 1202 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 197Ô, Vol.107, No.5 No\tDate\tRequérants Applicants\tG.C page\t>.Q.date\tCause Care\tDécisions OSM-62\t16-01-75\t142-N-P-l TRANSPORT MARITIME ST-BERNARD LIMITEE\t9499\t21-12-74\tQ-2628\t La Commission rescinde sa décision QSM-42 rendue le 4 septembre 1974, vu le non-paiement des droits.The Commission cancels its decision OSM-42 rendered on September 4, 1974, considering the fact that the duties have not been paid.QCV-2084 16-01-75 IQ-5037I3-PI I ROLAND GELINAS La Commission révoque, à toutes fins que de droit, la décision QCV-1392 autorisant la délivrance d'un permis de camionnage en vrac à M.Roland Gélinas.QCV-2085 16-01-75 O-504135-P-00I FERNAND GUILLEMETTE La Commission: 1.revise le troisième paragraphe du dispositif de la décision MCV-2259; | 2.autorise, en faveur de Fcrnand Guillcmcllc.la délivrance d'un permis de camionnage en vrac, de catégorie «région» el de catégorie «Artisan» pour la région No 4.conformémenl aux dispositions du règlement 12.9296 14-12-74 0-2569 The Commission revokes, for all legal purposes, decision QCV-1392 authorizing the issue of a bulk trucking permit to Mr.Roland Gélinas.9296 14-12-74 Q-2570 The Commission: i.revises the third paragraph of the conclusion of decision 2.in conformity with the provisions of Regulation 12, author izes the issue of a bulk trucking permit Region class and Artisan class, for Region No.4, in behalf of Femand Guillemette.AUDIENCES PUBLIQUES I PUBLIC HEARINGS QCR-919 I 22-01-75 | 6793-V-D-6 BRAZEAU TRANSPORT INC.La Commission prend acte du retrait de la demande par le requérant.QCR-920 22-01-75 | 6793-V-D-8 BRAZEAU TRANSPORT INC.La Commission: 1.prend acte que la Commission a déjà statué sur l'objet de la demande; 2.déclare rayer du rôle la présente demande.QCR-921 QCS-490 OPV-414 QSM-64-TF QL-233 22-01-75 20-01-75 22-01-75 16-01-75 20-01-75 3337 04-05-74 Q-1027 The Commission acknowledges the applicant's withdrawal of its request.3844 25-01-74 Q-1168 The Commission: 1.acknowledges that the Commission has already rendered a decision on the subject matter of the request; 2.declares that this request is being deleted from the roll.23594-V-D-1 ALBERT DESORMEAUX 23771-V-D-l TRANSPORT BIENCOURT INC.BIENCOURT EXPRESS INC.1741-A-D-l LAVIGNE TRANSPORT (Raymond Lavigne) 162-N-D-l-TF TRAVERSE MATANE GODBOUT LIMITEE 162-DYL-D-l GERALD LAGACE LTEE 1133 B2-02-74 3356 7251 4447 3356 04-05-74 08-12-73 15-06-74 04-05-74 Q-0632 Q-1089 Q-0427 Q-1277 Q-I089-A Rejetée I Rejected Accordée I Granted Rejetée / Rejected Rejetée I Rejected Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1203 No\tDale\tRequérants Applicants\tJournal Newspaper\tDate\tCause Case\tDécisions OCV-2086 QCV-2087 QCV-2088 QCV-2089 QCV-2090 QCV-2091\t17-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75\tQ-502621-ADD-001 ROCH ROY TRANSPORT LIMITEE Demande d'atteslation additive Request for an additional certificate Q-502621-ADD-002 ROCH ROY TRANSPORT LIMITEE Demande d'attestation additive Request for an additional certificate O-502621-ADD-003 ROCH ROY TRANSPORT LIMITEE Demande d'attestation additive Request for an additional certificate Q-502621-ADD-004 ROCH ROY TRANSPORT LIMITEE Demande d'attestation additive Request for an additional certificate O-502621-ADD-005 ROCH ROY TRANSPORT LIMITEE Demande d'attestaiion additive Request for an additional certificate Q-502621-ADD-006 ROCH ROY TRANSPORT LIMITEE Demande d'attestation additive Request for an additional certificate\tLe Soleil Le Soleil Le Soleil Le Soleil Le Soleil Le Soleil\t22, 23, 25 nov.74 22, 23, 25 nov.74 22, 23, 25 nov.74 22, 23, 25 nov.74 22, 23, 25 nov.74 22, 23, 25 nov.74\tQ-0757 Q-0758 Q-0759 Q-0760 Q-0761 0-0762\tAccordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted No\tDale\tRequérants Applicants\tG.page\t3.Q.date\tCause Case\tDécisions MCR-1498 MCV-4074 MCR-1500 MCR-1507 MCR-1508 MCS-967 MCS-969\t17-01-75 20-01-75 21-01-75 21-01-75 21-01-75 22-01-75\t23596-V-D-l M.DENIS LEMAY Nouvelle demande 1 New application 14891-V-D-l GAETAN CHARTRAND Modification de permis Modification of permit 23709-V-D-l M.ALCIDE LAROSE Nouvelle demande 1 New application 939-V-D-l HYMAN MENDELSSOHN Requérant-vendeur Applicant-vendor GOODFELLOW TRANSPORT INC.Requérant-acquéreur Applicant -purchaser Transfert de permis Transfer of permit 23752-V-D-l MICHEL PRAIRIE Nouvelle demande / New application 21339-V-D-3 DEL TRANSPORT LTEE Modification de permis Modification of permit\t2989 2992 2986 4462 4458 4443\t20-04-74 20-04-74 20-04-74 15-06-74 15-06-74 15-06-74\tM-1657 M-1666 M-1641 M-2144 M-2135 M-2119\tAccordée / Granted Accordée / Granted Rejelée / Rejected Rejelée / Rejected Accordée / Granted Accordée / Granted 1204 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No\tDale\tRequéranls Applicants\tG.< page\tD.Q.date\tCause Case\tDécisions ML-514 MPV-424 MPV-426\t22-01-75 17-01-75 22-01-75\t674-DYV-D-l MERCIER LEASING CO.Droit additionnel / Additional right 1475-A SERVICE VOYAGEURS VAUDREUIL INC.Modification de permis Modification of permit 459-A LA CIE DE TRANSPORT DES LAURENTIDES LTEE Modification de permis Modification of permit\t4441 1673 1673\t15-06-74 02-03-74 02-03-74\tM-2111 M-1121 M-1117\tAccordée / Granted Rejetée / Rejected Rejetée / Rejected SEANCES EN CHAMBRE I SITTINGS IN CHAMBERS QCR-913 I 16-01-75 2403I-V-D-1 GEORGES EMILE TARDIF QCR-914-TF 116-01-75 10694-V-D-I-TF J.P.BLANCHETTE LIMITEE Modification de tarifs Tariffs modification OCR-918-TF 121-01-75 15332-V-D- 1-TF ] YAMACHICHE TRANSPORT ENR.Modification de tarifs Tariffs modification QPT-3004-TF| 16-01-75 | Q-24-012-D-I-TF LA LIGUE DE TAXI DE VAL D'OR INC.La Commission abroge à toutes fins sa décision rendue le 27 novembre 1974.8670 7629 8031 5785 16-11-74 12-10-74 26-10-74 17-08-74 Q-2356 O-2071 0-2159 Q-l562 Accordée / Granted Accordée avec restriction Granted with restriction Accordée / Granted The Commission cancels its decision rendered on November 27, 1974, for all legal purposes.QPT-3005 16-01-75 Q-20013 LA LIGUE DE TAXIS DE RIVIERE DU LOUP INC.a/s Oscar Pelletier, prés.Demande pour être reconnue comme le groupe représentatif des détenteurs de permis de propriétaires de véhicules-taxis de l'agglomération de Rivière-du-Loup, A-13.QPT-3006 120-01-75 8448 09-11-74 O-2270 Accordée / Granted Requests recognition as Ihe representative group of holders of taxicab owners' permits for the conglomeration of Rivière-du-Loup, A-13.8034 26-10-74 0-2182 Accordée / Granted O-20027-D-1 LA LIGUE DE TAXIS DE LA BAIE 1NC.| a/s M.Georges A.Dallaire Demande pour être reconnue comme le groupe représentatif des Requests recognition as the representative group of holders of détenteurs de permis de propriétaires de véhicules-taxis de l'agglo- taxicab owners' permits for Ihe conglomeration of La Baie, A-27.meralion de la Baic.A-27.QPT-3007 20-01-75 8241 02-11-74 2210 Accordée / Granted O-20037-D-I LA LIGUE DE TAXIS DE RIMOUSKI INC.a/s M.Albert Gagnon.prés.Demande pour être reconnue comme le groupe représentatif des Requests recognition as the representative group of holders of ieJ?r,'l\"rSJer/Crm'\\ ProP\"é'aireS dC vénjcules-'\"is de I'»g8l°- 'axicab owners' permits for the conglomeration of Rimouski.QPV-415 22-01-75 1470-A-D-1 GERARD TREMBLAY Requérant-vendeur Applicant-vendor 8667 16-11-74 0-2333 Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' aimée, n° 5 1205 No\tDate\tRequérants Applicants\tG.page\tO.Q.date\tCause Case\tDécisions QL-232 OCV-2092 QCV-2093 QCV-2094 OCV-2095 MCR-1497 TF MCV-4073 TF MCR-1499 MCR-1503\t16-01-75 20-01-75 20-01-75 20-01-75 20-01-75 14-01-75 20-01-75\t53-A AUTOBUS ALPHONSE DROLET LIMITEE Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Permit transfer I083-DYV-D-I LOCATION BRAZEAU INC.BRAZEAU LEASING INC.O-503368-D-004 BERTRAND GAGNE Requérant-cédant Applicant-transferror O-504655-D-003 J.ANDRE LARUE INC.Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfer! d'attestation Transfer of certificate Q-501591-D-001 GERMAIN GIRARD Requéranl-cédant Applicant-transferror Q-504654-D-001 MARTIAL PARENT Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert d'attestation Transfer of certificate O-50I480-D-001 MAURICE LEBEL (Carmen Lebel, légataire universelle) Requéranl-cédant Applicant-transferror Q-504676-D-001 MME CARMEN LEBEL Requérante-cessionnaire Applicant-transferee Transfert d'attestation Transfer of certificate Q-504144-D-001 JEAN-GUY GUILLEMETTE Requérant-cédanl Applicant-transferror Q-504680-D-001 GILLES BOULET Requéranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert d'attestation Transfer of certificate 572-V-D-l-TF EXPRESS TRANS-METROPOL1TAIN LTEE Modification de tarif Tariff modification 8353-V-D-2 SHERRINGTON TRANSPORT INC.Modification de permis Modification of permit 645-V-D-2 H.SMITH TRANSPORT COMPANY LTD.Modification de permis Modification of permit\t1538 8452 8665 8665 8670 7643 4795 7882\t23-02-74 09-11-74 16-11-74 16-11-74 16-11-74 12-10-74 29-06-74 19-10-74\tQ-0678 Q-2300 0-2322 0-2321 0-2355 M-3317 M-2322 M-3376\tAccordée telle qu'amendée / Granted as amended.Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 1206 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No Dale Requérants Applicants G.O.Q.page date Cause Case Décisions MCR-1504 MCV-4076 MCR-1505 MCR-1506 MCR-1509 20-01-75 21-01-75 21-01-75 21-01-75 MCR-1510 21-01-75 MCR-I51I MCR-I5I2 MCR-1513 TF MCS-968-TF 21-01-75 21-01-75 23974- V-D-l ELWOOD'S TRUCKING LTD.Nouvelle demande New application 24004- V-D-l CHARLES EMILE BOISVERT Nouvelle demande New application 23958-V-D-2 ROBERT BEAUVAIS Nouvelle demande New application 4292-V-D-l R.R.HARBEC TRANSPORT INC.Requérant > vendeur Applicant-vendor AS.TRANSPORT GENERAL ENRG.Requéranl-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permit 299-V-D-l DIAL TRANSPORT LIMITED Mise en cause GERARD PILON RENE BERTRAND Succession de / Estate of CHARLEMAGNE LACROIX RAPID TIN SALES & SERVICE LTD.Requérants-vendeurs Applicant- vendors GORDON R.CAMBELL JOHN D.CAMBELL LORENA R.CAMPBELL Requérants-acquéreurs Applicant-purchasers Transfer! d'actions Transfer of shares 299-V-D-2 DIAL TRANSPORT LIMITED Mise en cause GORDON R.CAMPBELL JOHN D CAMPBELL LORENA M CAMPBELL Requérants-vendeurs Applicant-vendors HEINZ KIEFER Requéranl-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'actions Transfer of shares 8993-V-D-l MICHEL BENARD Requcianl-vendeur Applicant-vendor DEMENAGEMENT MONT-BRUNO INC Requéranic-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permit 2530-V-D-l-TF ALLEN'S CARTAGE LIMITED Modification de tarif Tariff modification 7643 7892 7892 9008 12-10-74 19-10-74 M-3316 M-3413 19-10-74 M-3412 30-11-74 5651 10-08-74 5651 10-08-74 7627 7013 M-3989 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted M-2722 M-2723 12-10-74 28-09-74 M-3286 M-3160 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1207 No Date\tRequérants Applicants\tG.page\t3.O.date\tCause Case\tDécisions MCR-1514 TF MCR-1517 24-01-75 TF MCR-1518 24-01-75 TF MCR-1519 24-01-75 TF MCR-1520 24-01-75 TF MCR-1521 24-01-75 TF MCS-972-TF MCR-1522 24-01-75 TF MCR-1523- 24-01-75 TF MCR-1515 22-01-75 TF MCR-I5I6 22-01-75 TF MCS-965 20-01-75 MCS-966 21-01-75 ML-S11 21-01-75\t122I8-V-D-2-TF CHOQUETTE TRANSPORT LTEE Modification de tarif Tariff modification 30003-D-47-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Modification de tarif Tariff modification 30003-D-46-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Modification de tarif Tariff modification 30003-D-45-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Modification de tarif Tariff modification 30003-D-44-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Modification de tarif Tariff modification 300O3-D-48-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Modification de tarif Tariff modification 30003-D-51-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Modification de tarif Tariff modification 30004-D-33-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASSOCIATES Modification de tarif Tariff modification 3O0O6-D-25-TF NIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU INC.Modification de tarif Tariff modification 3O0O3-D-53-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Modification de tarif Tariff modification 18679-V-D-1 DORVAL TRANSPORT INC.Modification de permis Modification of permit 10374-V-D-2 AI MOVING & TRANSPORT LTD.Modification de permis Modification of permit 1364-DY-D-l GARAGE POIRIER & FILS LTEE Nouvelle demande / New application\t7644 8068 8066 8065 8061 8069 8687 9164 8041 9167 7879 8036 8046\t12-10-74 26-10-74 26-10-74 26-10-74 26-10-74 26-10-74 16-11-74 07-12-74 26-10-74 07-12-74 19-10-74 26-10-74 26-10-74\tM-3319 M-3558 M-3557 M-3556 M-3555 M-3559 M-3776 M-4156 M-3453 M-4180 M-3365 M-3429 M-3485\tAccordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 1208 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No Dale Requéranls Applicants G.O.Q.page dale Cause Case Décisions ML-512 ML-513 21-01-75 21-01-75 MCR-1524 TF MCR-1525 TF MCS-973 MCV-4094 MCV-4089 24-01-75 24-01-75 24-01-75 23-01-75 23-01-75 MCV-4090 23-01-75 82-DYV & 445-DY-D-l VIAU DRIVE YOURSELF INC.Changement de place d'affaires Change of place of business 870-DYV PEEGEE TRUCK RENTALS QUEBEC LTD.Requérante-venderessc Applicant-vendor TR1VAN LIMITED Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permit 30004-D-34-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N.Modification de tarif Tariff modification 30007-D-13-TF SOUIHhKN MOTOR CARRIERS RATE CONFERENCE Modification de tarif Tariff modification 4552-V-D-5 CHOUINARD & FRERE LIMITEE Voiturier-remorqueur Haulaway operator BRAZEAÛ TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier Transport par remorquage Haulaway operator M-503089-D-1 REAL LEFEBRE Requérant-vendeur Applicant- vendor M-50559I-D-I GUY ASSELIN Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'attestation Transfer of certificate M-504946-D-001 REAL FOURNIER Requérant-vendeur Applicant-vendor M-5059I2-D-OOI JEAN MARIE LEGAULT Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'attestation Transfer of certificate M-503293-D-O0I EMILE BEAULIEU Requérant-vendeur Applicant-vendor M-5O5927-D-O01 MARCEL BELLEROSE Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'attestation Transfer of certificate 8039 6322 26-10-74 07-09-74 M-3442 M-2961 Accordée / Granted Accordée / Granted 9164 9166 7891 8995 07-12-74 07-12-74 19-10-74 M-4157 M-4165 M-3405 23-12-74 M-3831 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 8460 8673 09-11-74 16-11-74 M-3624 M-3636 Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n\" 5 1209 No Dale Requérante Applicants G.O.Q.page dale Cause Case Décisions MCV-4091 23-01-75 MCV-4092 23-01-75 M-500044-D-001 |ALBERT GEOFFROY Requérant- vendeur Applicant-vendor I M-505929-D-001 | ANDRE LOISELLE Requéranl-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'allestalion Transfer of certificate M-5O1536-D-O06 BELANGER & FILS INC.Requéranl-vendeur Applicant-vendor I M-505928-D-001 | ANDRE MORISSETTE Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'attestation Transfer of certificate IM-505185-D-O01 I DENIS LAFOND Requérant-vendeur Applicant-vendor I M-50590I-D-001 I PIERRE LAFOND Requéranl-acquéreur Applicant-purchaser Transfer! d'attestation Transfer of certificate Q-52009 I ASSOCIATION DES CAMIONNEURS ARTISANS DE LA REGION No 9 INC.Demande de poste d'affeclion «artisan» pour la région No 9.8674 16-11-74 M-3640 Accordée / Granted 8675 16-11-75 M-3643 Accordée / Granted MCV-4093 23-01-75 8675 16-11-74 M-3670 Accordée / Granted QCV-2096 21-01-75 4427 15-06-74 0-1244 OCV-2097 21-01-75 Q-52002 ASSOCIATION DES CAMIONNEURS ARTISANS DE LA REGION No 2 INC.Demande de posle d'affectalion «artisan» pour la région No 2.MCV-4095 MCV-4096 23-01-75 24-01-75 Request a permit \"Artisan class' 4426 15-06-74 Q-1241 Request a permit \"Artisan class M-502690-D-1 ROLAND LANDRIAULT Requérant-vendeur Applicant-vendor M-505932-D-1 JACQUES GODIN Requéranl-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'allestalion Transfer of certificate M-500610-D-001 IRENEE LESSARD Requéranl-vendeur Applicant- vendor M-505571 CHRISTIAN CHAVIER Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'allestalion Transfer of certificate 9000 9006 30-11-74 30-11-74 M-3896 Accordée / Granted for Region No.9.Accordée / Granted for Region No.2.1 Accordée / Granted M-3951 Accordée / Granted 1210 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No\tDale\tRequéranls Applicants\tG.page\t0.0.date\tCause Case\tDécisions MCV-4097 MCV-4098 MCS-970 MCS-971-TF ML-515 ML-516 ML-517 MPV-425 MPT-8110 MPT-8111 MPT-8112\t24-01-75 24-01-75 23-01-75 23-01-75 23-01-75 23-01-75 23-01-75 22-01-75 21-01-75 21-01-75 20-01-75\tM-505226-D-I LUCIEN LATREILLE Requérant-vendeur Applicant-vendor M-505930-D-1 NORMAND PAQUhl It Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Transfert d'attestation Transfer of certificate M-503S67-D-1 CAMILLE RIVARD Requérant-vendeur Applicant-vendor M-505650-D-I RAYMOND DUBOIS Requérant-acquéreur Applicani-purchaser Transfert d'attestation Transfer of certificate 24027-V-D-1 LUC MADELEINE Nouvelle demande New application 713-V-D-3-TF LAKESHORE INTERNATIONAL MOVERS & WAREHOUSING LTD.Modification de tarif Tariff modification 86-DY & 108-DYV D-l AVIS TRANSPORT OF CANADA LTD.Modification de permis Modification of permit 1370-DY D-l MARKO TRUCK RENTAL ENRG.Modification de permis Modification of permit 1044-DY & 127-DYV-D-l LOCATION JEAN LEGARE LTEE Modification de permis Modification of permit 2096-A-S-14 METROPOLITAIN PROVINCIAL (1967) INC.Modification de permis Modification of permit M-20023-D-1 LA LIGUE DE TAXI DE BELOEIL INC Reconnaissance de ligue de taxi Recognition of laxi league M-200390 REJEAN SABOURIN Nouvelle demande New application M-204624 CLAUDE BLOU1N Requérant-cédant Applicant-transferror M-206070 ROMA BEAULIEU Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t9014 4466 9006 130 9004 9011 7890 9319 7879 9005\t30-11-74 15-06-74 30 11-74 11-01-75 30-11-74 30-11-74 19-10-74 14-12-74 19-10-74 20-11-74\tM-4026 M-2165 M-3953 M-5093 M-4521 M-3941 M-3996 M-3402 M-4238 M-3360 M-3949\tAccordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Désistement / Withdrawal Désistement / Withdrawal Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1211 No\tDale\tRequérants Applicants\tG.page\tO.Q.date\tCause Case\tDécisions MPT-8113 MPT-8114 MPT-8115 MPT-8116 MPT-8117 MPT-8118\t20-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75 20-01-75 20-01-75\tM-204806 ANDRE LEMIRE Requérant-cédant Applicant-transferror M-205589-D-2 DENIS HAMEL Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-203438-D-4 KEL TAXIS LTD Requérant-cédant Applicant-transferror M-202781-D-8 FELLEGI DEZSO Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-202859-D-1 LOUIS FRASCADORE Requérant-cédant Applicant-transferror M-206079 GERARD DAVID Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-203I28-D-4 KOSY KORNER TAXI CO.LTD.Requérante-cédante Applicant-transferror M-206062 JOSEPH ZELOV1CS Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-204750 CECILE KATZ Requérante-cédante Applicant-transferror M-206088 URBANO DI SABATO Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-201414 CLAUDE ST-LOU1S Requérant-cédant Applicant-transferror M-204914-D-2 JEAN-GUY SIGOUIN Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit\t9006 9000 9000 9000 9005 9005\t30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74\tM-3950 M-3899 M-3900 3901 M-3942 M-3943\tAccordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 1212 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No\tDale\tRequérants Applicants\tG.page\tO.Q.date\tCause Case\tDécisions MPT-8119 MPT-8120 MPT-8121 MPT-8122 MPT-8123 MPT-8124 MPT-8125\t20-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75 16-01-75\tM-204107 YHIZEL KARABEL Requérant-cédant Applicant-transferror M-206086 BEN AMI SHLOMO Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-203459-D-6 ROMA LEGER Requérant-cédant Applicant-transferror M-206074 ANTOINE BELLICER Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfer! de permis Transfer of permit M-204554 PAUL COURCELLES Requéranl-cédanl Applicant-transferror M-206066 GUILDOR THERIAULT Requéranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-200844 EUGENE PARE Requérant-cédanl Applicant-transferror M-206068 ROLAND THIBAULT Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfer! de permis Transfer of permit M-200956-D-4 MME ARMAND LINCOURT Requéranle-cédante Applicant-transferror M-205834-D-7 MARIO VENAFRO Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfer! de permis Transfer of permit M-200951-D-7 MME ARMAND LINCOURT Requérante-cédante Applicant-transferror M-205834-D-I0 MARIO VENAFRO Requéranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-200956-D-1 MME ARMAND LINCOURT Requérante-cédanle Applicant-transferror\t9005 8998 8998 8999 9000 9000 8998\t30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74\tM-3944 M-3885 M-3886 M-3887 M-3897 M-3898 M-3879\tAccordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1213 No\tDate\tRequérants Applicants\tG.page\tO.Q.date\tCause Case\tDécisions MPT-8126 MPT-8127 MPT-8128 MPT-8129 MPT-8130 MPT-8131\t16-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75 17-01-75\tM-205834-D-5 MARIO VENAFRO Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-203128-D-6 KOSY KORNER TAXI CO.LTD.Requérante-cédante Applicant-transferror M-206076 HENRI ST-MAURICE Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-20U956-D-3 MME ARMAND LINCOURT Requérante-cédante Applicant-transferror M-205834-D-6 MARIO VENAFRO Requérant-cessionnaire Appl icant-transfe ree Transfert de permis Transfer of permit M-200956-D-5 MME ARMAND LINCOURT Requérante-cédante Applicant-transferror M-205834-D-8 MARIO VENAFRO Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-200956-D-6 MME ARMAND LINCOURT Requérante-cédante Applicant-transferror M-205834-D-9 MARIO VENAFRO Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-203662-D-1 MONS INVESTMENT REG'D.Requérante-cédante Applicant-transferror M-206069-D-1 SPIROS KAPOGIANATOS Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-203662-D-6 MONS INVESTMENT REG'D.Requérante-cédante Applicant-transferror\t8997 8998 8998 8998 8998 8998\t30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74 30-11-74\tM-3878 M-3880 M-3881 M-3882 M-3883 M-3884\tAccordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 1214 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No Dale Requérants Applicants G.O.Q.page date Cause Case Décisions MPT-8132 MPT-8133 MPT-8134 MPT-8135 MPT-8136 MPT-8137 M-206075 JOANNES TOMAVAS Requéranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit 20-01-75 IM-203156-D-1 DAVID LALLOUZ Requéranl-cédanl Applicant-transferror M-206081 NAPOLITANO H1LDEBERT Requéranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit 20-01-75 IM-201315-D-I CLAUDE DUMOULIN Requéranl-cédanl Applicant-transferror M-206084 MICHEL LEBLANC Requéranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit 20-01-74 M-203629-D-2 ERNEST KROUS Requérant-cédant Applicant-transferror M-206078 JOAO FERNANDES Requéranl-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit 20-01-75 I M-205603 AIME PORTUGAIS Requéranl-cédanl Applicant-transferror M-206083 LIONEL CARDIN Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit 20-01-75 [ M-2O039-D-1 LA LIGUE DE TAXI DE ST-HYACINTHE INC.Reconnaissance de ligue de laxi Recognition of laxi league 22-01-75 I M-20008 D-l LA LIGUE DE TAXI DE LAVAL INC.Reconnaissance de ligue de taxi Recognition of taxi league 9005 \u2022 30-11-74 M-3945 Accordée / Granted 9005 30-11-74 M-3946 Accordée / Granted 9005 9005 30-11-74 30-11-74 5304 5283 27-07-74 27-07-74 M-3947 Accordée / Granted M-3948 M-2651 M-901 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1215 AUDIENCES PUBLIQUES\u2014TRANSPORT PUBLIC \u2014 ECOLIERS PUBLIC HEARINGS \u2014 PUBLIC TRANSPORT \u2014 STUDENTS No Requérants Applicants Décisions OPE-136 à Ito QPE-152 QPE-136 OPE-137 QPE-I38 QPE-139 QPE-140 OPE-141 OPE-142 QPE-143 OPE-144 QPE-145 QPE-146 QPE-147 OPE-148 QPE-149 OPE-150 QPE-151 QPE-152 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 15-01-75 O-I00027-D-1 COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE L'AMIANTE Requérante / Applicant JEAN-THOMAS PERRON D-l-6 JACQUES LORENZO D-l-7 BERNARD LAROCHELLE D-l-9 PAUL BOULET D-l-11 ROSARIO PERREAULT D-l-12 LUCIEN ROY D-l-13 RENALD GOUIN D-l-14 LAURIER POMERLEAU D-l-15 JOSEPH PLANTE D-l-16 ALBERT FILION D-l-17 JEAN-PAUL BOLDUC D-l-18 ERNEST CLOUTIER D-l-19 DONAT ST-LAURENT D-l-20 HERCULE GOULET D-l-21 CYRILLE HEBERT D-l-22 HENRI LESSARD D-l-23 LAPOINTE, CHAMPAGNE & DELISLE ENR.D-l-25 Entrepreneurs / Contractors MINISTRE DES TRANSPORTS Intervenant I Intervener Détails de la demande: Demande parue dans les journaux «Le Soleil» et la «Tribune» les 15 et 16 octobre 1974.Particulars of application: Application published in the newspapers on October 15 and OPE-171 22-01-75 O-I00068-D-1 LA CIE D'AUTOBUS RIMOUSKI LTEE Détails de la demande: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 17 et 18 décembre 1974.0-1683 | La Commission fixe comme prix des contrais adjugés par la requérante aux entrepreneurs les prix pour lesquels ils ont soumissionnés.IThe Commission fixes as the price of the contract awarded by the applicant to each of the contractors mentioned the price which he tendered.\"Le Soleil\" and Ihe \"Tribune\" 16th.1974.Q-2184 j La Commission approuve le prix de transport du contrat négocié entre La Commission scolaire régionale du Bas-Sl-Laurenl et la Cie Autobus Rimouski Limitée.IThe Commission approves the price of the transport contract concluded between La Commission scolaire régionale du Bas-St-Laurenl and La Cie Autobus Rimouski Limitée.Particulars of application: Application published in \"Le Soleil\" newspaper on December 17 and 18th.1974.OPE-172 22-01-75 Q-100003-D-2 AUTOBUS CHEVRETTE INC.Q-1658 La Commission approuve le prix du contrai négocié entre La commission scolaire régionale de la Mauricie et Autobus Chevrette Inc.IThe Commission approves the price of the transport contract concluded between La commission scolaire régionale de la Mauricie and Autobus Chevrette Inc. 1216_QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5__ No\tDate\tRequérant Applicant\tCause Case\tDécisions OPE-173\t22-01-75\tO-100069-D-1 DUBE & DESROSIERS TRANSPORT INC.\tQ-2183\tLa Commission approuve le prix de transport du contrat négocié entre La commission scolaire régionale du Bas-St-Laurent et Dubé & Desrosiers Transport Inc.IThe Commission approves the price of the transport contract concluded between La commission scolaire régionale du Bas-Sl-Laurent and Dubé & Desrosiers Transport Inc.Détails de la demande: Particulars of application: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 17 et 18 dé- Application published in \"Le Soleil\" newspaper on december cembre 1974.17 and I8th.1974.22-01-75 O-I000I8-D-I & Q-100018-D-3 COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE ST-FRANÇOIS Requérante / Applicant OPE-153 22-01-75 AUTOBUS BOILEAU ENR.D-l-l QPE-154 22-01-75 AUTOBUS DRUMMONDVILLE LTEE D-l-2 QPE-155 22-01-75 BEN-VAL TRANSPORT INC.D-l-3 QPE-156 22-01-75 BOURGAULT & FILS ENR.D-l-4 QPE-157 22-01-75 DECELLES & FRERES INC.D-l-5 QPE-158 22-01-75 LEO-PAUL DESSERRES D-l-6 QPE-159 22-01-75 FERNAND FRENCHETTE D-l-7 QPE-160 22-01-75 JEAN GAMELIN D-l-8 OPE-161 22-01-75 HEBERT & BLANCHARD ENR.D-l-9 QPE-162 22-01-75 HEROUX CLEMENT INC.D-l-10 QPE-164 22-01-75 PAUL LECLERC D-l-12 QPE-165 22-01-75 MME MARIE LEMIRE D-l-13 QPE-166 22-01-75 LES ENTREPRISES GIRARDIN INC.D-l-14 QPE-167 22-01-75 LUCIEN MENARD D-l-15 OPE-168 22-01-75 ROGER PROVOST D-l-16 QPE-169 22-01-75 MAURICE TESSIER D-l-17 OPE-170 22-01-75 ROSARIO TURCOTTE D-l-18 Entrepreneurs / Contractors MINISTRE DES TRANSPORTS Intervenant / inten'ener Détails de la demande: Demande parue dans le journal «La Tribune» les 17 et 18 décembre 1974.0-1659 0-1773 La Commission statue comme prix des contrats adjugés par la requérante à chacun des entrepreneurs un prix autre que celui pour lesquels ils ont soumissionné.IThe Commission fixes as the price of the contract awarded by the applicant to each of the contractors mentioned, the price which he lit tendered.Particulars of application: Application published in ihe cember 17 and 18lh.1974.La Tribune\" newspaper on De- OPE-163 22-01-75 O-I000I8-D-1 & 0-1000I8-D-3 COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE ST-FRANÇOIS Requérante I Applicant O-I000I8-D-I-I1 GERARD JOYAL Entrepreneur / Contractor LE MINISTRE DES TRANSPORTS Intervenant / Intervener Q-1659 Q-1773 La Commission statue, comme prix du contrat adjugé par la partie requérante à l'entrepreneur.Gérard Joyal.le prix pour lequel il a soumissionné.The Commission fixes as the price of the contract awarded by the applicant to the contractor Gérard Joyal.the price which he/it tendered.Details de la demande: Particulars of application: Demande parue dans le journal «Le Nouvelliste» les 17 et 18 Application published in \"Le Nouvelliste\" newspaper on de-décembre 1974.cember 17 and 18lh.1974. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1217 Délails de la demande: Demande parue dans le journal «La Tribune» les 17 el 18 décembre 1974.Particulars of application: Application published in the \"La Tribune\" newspaper on de-ccmber 17 and 18th.1974.No Requérant Applicant Décisions QPE-174 a/to OPE-183 QPE-174 QPE-175 QPE-176 OPE-177 QPE-178 OPE-179 OPE-180 OPE-181 QPE-I82 QPE-183 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 O-100003-D-1 COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE LA MAURICIE Requérante / Applicant AUTOBUS GERARD JUNEAU D-l-10 ALIDE A.DESAULNIERS INC.D-l-1 GERALD DOUCET D-l-2 BERNARD V.GELINAS D-l-3 GERMAIN.CHAREST.VEILLETTE ASSOCIES D-l-4 JACQUES PAQUIN D-l-5 LEONARD BOISVERT D-l-6 J.CLAUDE GERVAIS D-l-7 RENE TOUPIN D-l-8 AUTOBUS CHEVRETTE INC.D-l-9 Entrepreneurs / Contractors MINISTRE DES TRANSPORTS Intervenant I Intervener Q-1657 La Commission slalue.comme prix des contrais adjugés par la requérante aux entrepreneurs, les prix pour lesquels ils ont soumissionnés.IThe Commission fixes as the price of the contract awarded by the applicant to each of the contractors mentioned.the price which he lit tendered.Details de la demande: Demande parue dans le journal «Le Nouvelliste» les 17 el 18 décembre 1974.Particulars of application: Applicaiion published in \"Le cember 17 and 18th.1974.QPE-184 alto OPE-187 OPE-184 QPE-185 QPE-186 QPE-187 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 O-I00002-D-I COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DU BAS ST-LAURENT Requérante / Applicant ADALBERT LEVESQUE D-l-13 FERNAND GIRARD D-l-12 TRANSPORT ECOLIER B1C ENR D-l-15 HORACE CORBIN D-l-21 Mises en cause L'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS D'ECOLIERS DU QUEBEC Intervenante / Intervener 0-1565 Nouvelliste\" newspaper on de- La Commission slalue sur les prix des contrats des mises en cause des prix autres que les montants des soumissions.77ie Commission fixes as the price of the contract of each of the mise en cause an amount other than that of his/its tenders.Détails de la demande: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 5 el 6 août 1974.QPE-188 a/to\\ QPE-195 QPE-188 OPE-189 QPE-190 QPE-191 QPE-192 QPE-193 OPE-194 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 22-01-75 O-I00002-D-I COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DU BAS-ST-LAURENT.Requérante / Applicant EMILE DIONNE D-l-l GERARD HALLE D-l-10 GILLES DESCHENES D-l-14 ERNEST CORBEIL D-l-17 VOTRE CHOIX TRANSPORT INC.D-l-20 GEORGES TREMBLAY D-l-22 GASTON LAVOIE D-l-23 Particulars of applicaiion: Application published in \"Le Soleil\" newspaper on August 5 and 6th.1974.0-1565 La Commission statue comme prix des conlrats les prix pour lesquels les mises en cause ont soumissionné.IThe Commission fixes the prices of the contracts as being the prices which the mises en cause have tendered. 1218 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No Requérant Applicant Décisions QPE-195 22-01-75 |TRANSPORT SCOLAIRE RIMOUSKI LIMITEE D-l-241 Mises en cause IL'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS D'ECOLIERS DU QUEBEC Intervenante / Intervener Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 5 et 6 août 1974.Application published in \"Le Soleil\" newspaper on August 5 and 6th.1974.PERMIS SPÉCIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Période de validité Period of validity QS-762 3552-V-S-S Cause: Q-0763 TRANSPORT THEBERGE LIMITEE Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 23, 25 et 26 novembre 1974.Accordée.QS-763 I Cause: Q-0792 692-A-S-3 | AUTOBUS FORTIN & POULIN INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Journal de Québec» les II.12 et 13 décembre 1974.Accordée.QS-764 Cause: Q-0754 234I4-V-S-2 | DENIS TRANSPORT (1972) LIMITEE Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Journal de Québec» le 30 novembre et les 2.3 et 4 décembre 1974.Rejetée.Ce permis spécial est valide jusqu'au 30 juin 1975 ou jusqu'à décision finale de la Commission selon l'éventualité qui se présentera la première.IThis special permit is valid unlil June 30.1975.or pending final decision by the Commission, whichever occurs first.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Soleil\" newspaper on November 23, 25 and 26th.1974.Granted.Du 14 Janvier 1975 au 13 janvier 1976 I From January 14th.1975 to January 13th.1976.Particulars of application and decision: Application published in the \"Journal de Québec\" newspaper on December II.12 and I3th.1974.Granted.Particulars of application and decision: Application published in the \"Journal de Québec\" newspaper on November 30(h.and December 2, 3 and 4th, 1974.Rejected OS-765 I Cause: O-0778 24095-V-S-l I G.& C.TRUCKING REG'D.(Guy L.Martin & Clarence Martin .).Voiturier-remorqueur / Haulaway operator 15-V TRANSPORT D'ANJOU INC.Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Journal de Québec» les 4, 5 et 6 décembre 1974.Accordée.QS-766 Cause: Q-0789 15186-V-S-l FORESTVILLE TRANSPORT INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 18, 19 et 20 décembre 1974.Accordée.Du 7 janvier 1975 au 8 septembre 1975.I From January 7th.1975 to September 8th.1975.Particulars of application and decision: Application published in \"Journal de Québec\" newspaper on December 4.5 and 6th, 1974.Granted.Valide jusqu'au 31 juillet 1975./ Valid unlil July 31.1975.Particulars of application and decision: Application published in \"Le Soleil\" newspaper on December 18.19 and 20th.1974.Granted. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1219 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.\tNom du requérant Name of Applicant\tPériode de validité Period of validity QS-767 1391-DY & 2018-DYV-S-l\tCause: Q-0798 LOCATION D'AUTOMOBILES F.C.MATANE LIMITEE\t Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 6, 7 et 8 novembre 1974.Rejetée.QS-768 10207-V-S-2 Cause: Q-0795 ITESSIER & FILS LIMITEE Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 19, 20 et 21 décembre 1974.Accordée.QS-769 Cause: Q-0799 2589-A-S-l RAYMOND THIBAULT Détails de la demande et de la décision: Rejetée.OS-770-S 3503-A-S-2 Cause: Q-0794 ROMEO BOUDREAU Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» les 11, 12 et 13 décembre 1974.Accordée.MS-1208-TF | I930-V-S-3-TF MRS-0597 PROVOST CARTAGE INC.Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «La Presse» le 27, 28 et 29 novembre 1974.Accordée.MS-1209 I 24093-V-S-l MRS-0694 1 JOSEPH BOUCHARD Voiturier-remorqueur / Haulaway operator KINGSWAY FREIGHT LINES LTD.Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 28.29 et 30 novembre 1974.Accordée.MS-1210 2594-A-S-5 MRS-0685 METROPOLITAIN SUD (1967) INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 17, 18 et 19 octobre 1974.Accordée.Particulars of application and decision: Application published in \"Le Soleil\" newspaper on November 6.7 and 8th.1974.Rejected.Valide jusqu'au 16 juillet 1975.I Valid until July 16.1975.Particulars of applicaiion and decision: Application published in the \"Le Soleil\" newspaper on December 19.20 and 21st.1974.Granted.Particulars of application and decision: Rejected.Du 16 janvier 1975 au 15 janvier 1976.I From January I6lh.1975 to January I5lh.1976.Particulars of application and decision: Application published in \"Le Soleil\" newspaper on December 11.12 and 13th.1974.Granted.I Période de 12 jours après l'expiration des délais de fournir preuve de publication décrété en décision: MS-1142-Tt*.IA period oj 12 days following the expiration of the delays to furnish proof of publication as decreed in decision: MS-1142-TF.Particulars of application and decision: Application published in ihe \"La Presse\" newspaper on November 27.28 and 29th.1974.Granted.Du 6 janvier 1975 au 31 décembre 1975 ou décision finale.I From January 6.1975 to December 31, 1975 or final decision.Particulars of applicaiion and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on November 28, 29 and 30th.1974.Granted.I Du 27 décembre 1974 au 23 décembre 1975 ou décision finale./ From December 27.1974 to December 23.1975 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on October 17, 18 and 19th, 1974.Granted.MS-1211-TF 30003-S-9-TF MRS-0695 \\ BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC Détails de la demande et de la décision: Modificalion de tarifs en vertu de l'article 2.64 du règlement No 2.Accordée.Du 7 janvier 1975 au 7 juillet 1975./ From January 7.1975 to July 7 1975.Particulars of application and decision: Modification of tariff in virtue of 2.64 of Regulation No.2.Granted. 1220 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.\tNom du requérant Name of Applicant\tPériode de validité Period of validity MS-I212-TF\t30003-S-10-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.\tDu 7 janvier 1975 au 7 juillet 1975 1 From January 7.1975 to July 7 1975.Détails de la demande et de la décision: Modification de tarifs en vertu de l'article 2.64 du règlement No 2.Accordée.MS-I213 1930-V-S-5 MRS-0691 PROVOST CARTAGE INC.Requérant / Applicant ALLIED CHEMICAL CORPORATION Requérante conjointe / Joint applicant.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «La Presse» le 13, 14 et 16 décembre 1974.Accordée.MS-12I4-S Particulars of application and decision: Modification of tariff in vinue of 2.64 of Regulation No.2.Granted.Du 10 janvier 1975 au 31 décembre 1975 ou décision finale./ From January 10, 1975 to December 31, 1975, or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"La Presse\" newspaper on December 13.14 and 16th, 1974.Granted.3617-A-S-l MRS-0686 L'ASSOCIATION POUR LE PROJET DES CITOYENS NOIRS DE COTE DES NEIGES Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Montréal Matin» le 7, 8 et 9 décembre 1974.Accordée.Du 27 décembre 1974 au 27 juin 1975 qu décision finale.I From December 27, 1974 to June 27.1975 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Montréal Matin\" newspaper on December 7.8 and 9th.1974.Granted.MS-1215 I 1733-V-S-2 MRS-0711 |D.DONNELLY LIMITED Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 27.28 et 30 décembre 1974.Rejetée.MS-1216 12797-V-S-l MRS-0709 BELLEMARE EXPRESS INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Montréal Matin» le 7.8 et 9 décembre 1974.Rejetée.MS-1217 37-A MRS-0699 LES AUTOBUS DESHA1ES LTEE Requérantc-vcnderesse / Applicanl-vendor 2079-A-S-7 VOYAGEUR INC.Requérante-acquéreur / Applicant-purchaser Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Soleil» le 13.14 et 16 décembre 1974 et dans «La Presse» le 12.13 et 14 décembre 1974.Rejetée.MS-1218 Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on December 27, 28 and 30lh, 1974.Rejected.Particulars of application and decision: Application published in the \"Montréal Matin\" newspaper on December 7.8 and 9th.1974.Rejected.I69I-A MRS-0698 I LES AUTOBUS DE LA RIVE SUD LTEE Rcquérante-venderessc / Applicant-vendor 37-A LES AUTOBUS DESHAIES LTEE Requérante-acquéreur / Applicant-purchaser Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «La Presse» le 12.13 et 14 décembre 1974 et dans le «Le Soleil» le 13.14 et 16 décembre 1974.Rejetée.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Soleil\" newspaper on December 13.14 and I6th.1974 and \"La Presse\" newspaper on December 12.13 and 14th.1974.Rejected.Particulars of application and decision: Application published in the \"La Presse\" newspaper on December 12, 13 and 14, 1974 and \"Le Soleil\" newspaper on December 13.14 and 16th.1974.Rejected. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° B 1221 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Période de validité Period of validity MS-1219 24076-V-S-l MRS-0697 |LES ENTREPRISES SANITAIRES RM.INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Journal de Montréal» le 30 novembre 1974 et le 1 et 2 décembre 1974.Rejetée.MS-1220 I24037-V-S-I MRS-0605 | LES MESSAGERIES LOR1BEC ENRG.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Jour» le 14, 15 et 16 octobre 1974.Rejetée.MS-1221 M-504U6-A-001 MRS-0674 M-504116-A-O02 MRS-0675 GARAGE LAJEUNESSE INC.Détails de la demande et de la décision: 2 permis additifs pour zone 8.pour transport de matière de construction de routes avec camions.Rejetée.MS-1222 M-503672-A-001 MRS-0672 ALBERT HAMEL1N Détails de la demande et de la décision: 1 permis additif pour région 10 pour transport de la neige et travaux de voirie.Rejetée.MS-1223 24073-V-S-l MRS-0668 ROBERT TOURANGEAU Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 23, 25 el 26 novembre 1974.Accordée.MS-1224 10043-V-S-2 MRS-0707 OVERNITE EXPRESS LIMITEE Délails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal « Le droit d'Ottawa» le 23, 24 el 26 décembre 1974.Accordée.MS-1225 1 24092-V-S-l MRS-0702 | HOWARD SHAFFER Voiturier-remorqueur / Haulaway operator 17376-V KINGSWAY FREIGHT LINES LTD.Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal « Le Devoir» le 21, 22 et 23 novembre 1974.Accordée.MS-1226 Particulars of application and decision: Application published in ihe \"Journal de Montréal\" newspaper OK November 30.1974 and December 1.2nd.1974.Rejecled.24094- V-S-1 DONALD MORRISON Voiturier-remorqueur / Haulaway operator Particulars of application and decision: Applicaiion published in ihe \"Le Jour\" newspaper on October 14, 15 and I6lh.1974.Rejected.Particulars of application and decision: 2 additive permits for zone 8, for Ihe transport, by truck, of road construction material.Rejecled.Particulars of application and decision: 1 additive permit for region 10.for the transport of snow and road works.Rejected.Du 5 décembre 1974 au 3 décembre 1975 ou décision finale.I From December 5.1974 to December 3.1975 or final decision.Particulars of application and decision: Applicaiion published in Ihe \"Le Devoir\" newspaper on November 23.25 and 26th, 1974.Granted.25 Janvier 1975.I January 25.1975.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Droit d'Ottawa\" newspaper on December 23, 24 and 26th.1974.Granted.Du 10 Janvier 1975 au 31 décembre 1975 ou décision finale./ From January 10.1975 to December 31, 1975 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on November 21, 22 and 23rd, 1974.Granted.Du 10 Janvier 1975 au 31 décembre 1975 ou décision finale.I From January 10.1975 or final decision. 1222 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant 17376-V KINGSWAY FREIGHT LINES LTD.Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 21.22 et 23 novembre 1974.Accordée.MS-1227 I 24099-V-S-l ROY PERRON Voiturier-remorqueur / Haulaway operator 17376-V KINGSWAY FREIGHT LINES LTD.Voilurier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 21.22 et 23 novembre 1974.Accordée.MS-1228 I 24100-V-S-l GEMZMER FROATS 17376-V KINGSWAY FREIGHT LINES LTD.Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 21.22 et 23 décembre 1974.Accordée.MS-1229 22375-V-S-l MRS-0722 | E.W.WILLS CARTAGE LTD.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 13, 14 et 16 décembre 1974.Rejetée.MS-1230 365-V-S-4 MRS-0723 I FORGET TRANSPORT INC Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Journal de Montréal» le 3.4 et 5 janvier 1975.Rejetée.MS-1231 I7396-V-S-2 MRS-0721 RICHELIEU MILK TANKERS INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal (.Le Devoir » le 30 décembre 1974 le 3 et 4 janvier 1975.Rejetée.MS-1232 24087-V-S-l MRS-0703 TRUCK DELIVERY SERVICE LTD.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 16, 17 et 18 décembre 1975.Accordée.Période de validité Period of validity Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on November 21, 22 and 23rd, 1974.Granted.Du 10 Janvier 1975 au 31 décembre 1975 ou décision finale.I From January 10.1975 to December 31.1975 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on November 21.22 and 23rd.1974.Granted.Du 10 Janvier 1975 au 31 décembre 1975 ou décision finale.I From January 10.1975 to December 31.1975 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on December 21.22 and 23rd.1974.Granted.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on December 13.14 and 16th.1974.Rejected.Particulars of application and decision: Application published in the \"Journal de Montréal\" newspaper on January 3.4 and 5lh, 1975.Rejected.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on December 30th.1974 and January 3 and 4th.1975.Rejected I Du 20 janvier 1975 au 31 décembre 1975 ou décision finale./ From January 20, 1975 to December 31.1975 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on December 16, 17 and 18th.1975.Granted. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1223 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.\tNom du requérant Name of Applicant\tPériode de validité Period of validity MS-1235\t23987-V-S-2 MRS-0717 EDMOND LECLERC Voiturier-remorqueur / Haulaway operator 13963-V SPEEDWAY EXPRESS LIMITED Voiturier-roulier / Carrier\tDu 15 janvier 1975 au 15 décembre 1975 ou décision finale./ From January 15.1975 to December 15.1975 or final decision.Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal « Le Jour» le 20.21 et 23 décembre 1974.Accordée.MS-1236 24107-V-S-l SERGE BEAUCHAMP Voiturier-remorqueur / Haulaway operator 13963-V SPEEDWAY EXPRESS LIMITED Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal « Le Devoir» le 8.9 et 11 octobre 1974, Accordée.MS-1237 Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Jour\" newspaper on December 20.21 and 23rd.1974.Granted.Du 15 Janvier 1975 au 14 janvier 1976 ou décision finale.I From January 15.1975 to January 14.1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on October 8, 9 and 11th, 1974.Granled.6553-V-S-2 PH.LANCTOT & FILS TRANSPORT LTEE Details de la demande et de la décision: Particulars of application and decision: Demande parue dans le journal «Montréal Matin» le 21.22 el Application published in Ihe \"Monlréal Malin\" newspaper on 23 décembre 1974.December 21.22 and 23rd, 1974.Re jetée.Rejecled.MS-1238 I14902-V-S-3 MRS-0613 BOERIO TRANSFERT CO.LTD.Voiturier-remorqueur / Haulaway operator 8123-V JOHN N.BROCKLESBY TRANSPORT LTD Voiturier-roulier I Carrier Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal « Le Devoir» le 1, 2 el 4 novembre 1974.Accordée.Du 11 novembre 1974 au 10 novembre 1975 ou décision finale.I From November 11, 1974 to November 10.1975 or final decision.MS-1239-S I 3380-A MRS-0719 COMMISSION DES TRANSPORTS DE VILLE DE LAVAL Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 27.28 et 30 décembre 1974.Accordée.Particulars of applicaiion and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on November 1.2 and 4th, 1974.Granted.Du 16 janvier 1975 au 1 mai 1975.I From January LA I 16.1975 to May 1.1975.MS-1240-S 3380-A-0007-S-2 MRS-0720 COMMISSION DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE LAVAL Détails de la demande el de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 27.28 el 30 décembre 1974.Accordée.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on December 27.28 and 30th.1974.Granted.Du 16 janvier 1975 au I mai 1975.I From January 16.1975 toMay I.1975.Particulars of application and decision: Application published in Ihe \"Le Devoir\" newspaper on December 27.28 and 30lh.1974.Granted.MS-1241-TF I 30003-S-l l-TF MRS-0730 Du 22 janvier 1975 au 22 juillet 1975.I From Janu- BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.ary 22.1975 to July 22.1975.Details de la demande el de la décision: Particulars of application and decision: Modification de tarif en venu de l'article 2.64 du règlement Modification of tariff in virtue of seclion 2.64 of Regulation No 2.No.2.Accordée.Granted 1224 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant MS-I242-S I 3046-A-S-6 MRS-0715 LAURENTIAN SCHOOL AND CAMP BUS REG'D Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 17, 18 et 19 décembre 1974.MS-1243 | 24103-V-S-l MRS-0710 GARY V.MASON Voiturier-remorqueur /Haulaway operator 659-V SMITH TRANSPORT CO.LIMITED Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal «Le Devoir» le 7, 9 et 10 décembre iy/4.Période de validité Period of validity Du 16 janvier 1975 au 30 juin 1975 ou décision finale.From January 16.1975 to June 30.1975 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on December 17.18 and 19th.1974.Du 10 Janvier 1975 au 9 Janvier 1976 ou décision finale.I From January 10.1975 lo January 9, 1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on December 7, 9 and 10th.1974.SEANCES EN CHAMBRE \u2014TRANSPORT PAR VEHICULE-TAXI SITTINGS IN CHAMBERS \u2014 TRANSPORT BY TAXICAB No Date Requérant Applicant Demande de permis Application for permit Catégorie Class Aggl.Congl.Région Cause Case Décision 2443 20-01-75 O-202071 LUCIEN VALLEE Ordinaire Ordinary A-53 Sept-Iles QT-2381 Accordée Granted QPT- 59707-o Jugements: Jugements rendus par le Tribunal des transports et publiés conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi des transports (Chapitre 55 des Lois du Québec de 1972).33-000115-74-8 CENTRAL TRUCK LINES LIMITED, appelante, m BLAIS & LANGLOIS INC., intimée.Jugement du 8 novembre 1974.Appel d'une décision de la Commission des transports du Québec, rendue le 16 août 1974, par laquelle elle délivre à l'intimée le permis spécial sollicité.Le Tribunal fait droit à l'appel, sans frais, infirme la décision de la Commission, rejette la requête de l'intimée et refuse de lui délivrer le permis spécial sollicité.Judgments: Judgments rendered by the Transport Tribunal and published in accordance with the provisions of section 68 of the Transport Act (Chapter 55 of the Statutes of Québec, 1972).33-000115-74-8 CENTRAL TRUCK LINES LIMITED, appellant, M BLAIS & LANGLOIS INC., respondent.Judgment rendered on November 8, 1974.Appeal from a decision of the Québec Transport Commission, rendered on August 16, 1974, whereby the Commission issued the special permit requested by the respondent.The Tribunal grants the appeal, without costs, quashes the decision of the Commission, rejects the application of the respondent and refuses to issue the special permit requested by the respondent. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n' 5 1225 33-000376-74 MAHEU TRANSPORT INC., appelante, M GOD-FROY PRLMEAU et J.LEBOEUF CARTAGE INC., intimés.Jugement du 8 novembre 1974.Appel d'une décision de la Commission des transports du Québec, rendue le 27 juin 1974, qui délivrait à l'appelante un permis pour certains services de transport et autorisait simultanément l'intimé, Godfrey Primeau, à supprimer ces services et annulait son permis.Le Tribunal fait droit à l'appel, sans frais, modifie la décision de la Commission des transports du Québec rendue le 27 juin 1974 en y supprimant le paragraphe 2 du dispositif.33-000386-74 PERRON TRANSPORT LIMITEE, appelante, m VICTORIEN PERRON, intimé.Jugement du 8 novembre 1974.Appel d'une décision rendue par la Commission des transports du Québec le 12 juin 1974, par laquelle elle délivre un permis spécial à l'intimé.Le Tribunal fait droit à l'appel, sans frais, infirme et annule la décision de la Commission des transports du Québec rendue le 12 juin 1974, rejette la requête de l'intimé et refuse de lui délivrer le permis spécial sollicité.33-000398-74 LES AUTOBUS HEBERT INC.appelante, m METROPOLITAIN PROVINCIAL (1967) INC., intimée.Jugement du 8 novembre 1974.Appel d'une décision rendue par la Commission des transports du Québec, le 4 juillet 1974, accueillant une requête de l'intimée.Le Tribunal fait droit à l'appel, sans frais, infirme la décision de la Commission des transports du Québec rendue le 4 juillet 1974 et rejette la requête de l'intimée.33-000497-74 GERALD MARCIL et YVES PATENAUDE.appelants, et LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC, mise en cause.Jugement du 8 novembre 1974.Appel d'une décision rendue par la Commission des transports du Québec, le 25 juin 1974, laquelle rejetait, sans frais, leur requête du 19 juin 1974.Le Tribunal rejette l'appel sans frais, et, confirme la décision de la Commission des transports du Québec rendue le 25 juin 1974.33-000036-74-6 VISITE TOURISTIQUE DE QUEBEC INC., appelante, n JOSEPH FARRAH, intimé.Jugement du 29 novembre 1974.Appel d'une décision rendue par la Commission des transports du Québec, le 19 avril 1974, par laquelle elle 33-000376-74 MAHEU TRANSPORT INC., appellant, vs GOD-FROY PRIMEAU and J.LEBOEUF CARTAGE INC., respondents.Judgment rendered on November 8, 1974.Appeal from a decision of the Québec Transport Commission, rendered on June 27, 1974, whereby a permit for certain transport services was issued to the appellant, and whereby, at the same time, the respondent, Godfrey Primeau was authorized to discontinue said services, his permit was revoked.The Tribunal grants the appeal, without costs, modifies the decision rendered by the Québec Transport Commission on June 27, 1974, by deleting paragraph 2 of the conclusions.33-000386-74 PERRON TRANSPORT LIMITEE, appellant, is VICTORIEN PERRON, respondent.Judgment rendered on November 8, 1974.Appeal from a decision of the Québec Transport Commission, rendered on June 12, 1974, whereby a special permit was issued to the respondent.The Tribunal grants the appeal, without costs, quashes and annuls the decision rendered by the Québec Transport Commission on June 12, 1974, rejects the application of the respondent and refuses to issue the special permit requested by the latter.33-000398-74 LES AUTOBUS HEBERT INC., appellant, w METROPOLITAIN PROVINCIAL (1967) INC.respondent.Judgment rendered on November 8, 1974.Appeal from a decision of the Québec Transport Commission, rendered on July 4, 1974, entertaining an application of the respondent.The Tribunal grants the appeal, without costs, quashes the decision rendered by the Québec Transport Commission on July 4, 1974, and rejects the application of the respondent.33-000497-74 GERALD MARCIL and YVES PATENAUDE, appellants, and THE QUEBEC TRANSPORT COMMISSION, mise en cause.Judgment rendered on November 8, 1974.Appeal from a decision of the Québec Transport Commission, rendered on June 25, 1974, in which it rejected, without costs, their application dated June 19, 1974.The Tribunal rejects the appeal, without costs, and confirms the decision rendered by the Québec Transport Commission on June 25, 1974.33-000036-74-6 VISITE TOURISTIQUE DE QUEBEC INC., appellant, vs JOSEPH FARRAH, respondent.Judgment rendered on November 29, 1974.Appeal from a decision of the Quebec Transport Commission rendered on April 19, 1974, in which it 1226 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 délivrait un permis spécial de service touristique à l'intimé.Le Tribunal accueille l'appel, sans frais, et procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue en première instance, infirme la décision de la Commission des transports du Québec rendue le 19 avril 1974 et révoque la décision rendue par la Commission le 18 mars 1974.33-000096-74-0 LES ENTREPRISES M.H.T.LTEE et FEDERATED MOBILE TRANSPORT INC.et L.R.TRANSPORT INC., appelantes, vs LA VOIE TEXACO SERVICE ENR., intimé.Jugement du 3 décembre 1974.Appel d'une décision rendue par la Commission des transports du Québec, le 24 juillet 1974, par laquelle elle délivrait un permis spécial à l'intimé.Le Tribunal accueille l'appel, sans frais, infirme la décision de la Commission des transports du Québec rendue le 24 juillet 1974 et, procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue en première instance, rejette la requête de l'intimé et refuse de lui délivrer le permis spécial demandé.33-000463-74 TREMBLAY EXPRESS LTEE, appelante, vs ANDRE AUCLAIR, intimé, et MICHEL TRANSPORT INC., et TRANSPORT DALLAIRE LTEE, mises en cause.Jugement du 18 décembre 1974.Appel d'une décision rendue par la Commission des transports du Québec, le 29 juillet 1974, par laquelle elle accueillait une requête de l'intimé aux fins de rejeter l'opposition produite par l'appelante le 15 mai 1974.Le Tribunal rejette l'appel, sans frais.59797-o issued a special permit for sightseeing tours services to the respondent.The Tribunal grants the appeal, without costs, and while proceeding to render the decision that should have been rendered in the first instance, quashes the decision rendered by the Québec Transport Commission on April 19, 1974 and revokes the decision rendered by the Commission on March 18, 1974.33-000096-74-0 LES ENTREPRISES M.H.T.LTEE and FEDERATED MOBILE TRANSPORT INC.and L.R.TRANSPORT INC.appellants, m LA VOIE TEXACO SERVICE ENR., respondent.Judgment rendered on December 3, 1974.Appeal from a decision of the Québec Transport Commission, rendered on July 24, 1974, in which a special permit was issued to the respondent.The Tribunal grants the appeal, without costs, quashes the decision rendered by the Québec Transport Commission on July 24, 1974 and, while proceeding to render the decision that should have been rendered in the first instance, rejects the application of the respondent and refuses to issue the special permit requested.33-000463-74 TREMBLAY EXPRESS LTEE.appellant, tu ANDRE AUCLAIR, respondent, and MICHEL TRANSPORT INC., and TRANSPORT DALLAIRE LTEE, mises en cause.Judgment rendered on December 18, 1974.Appeal from a decision of the Québec Transport Commission, rendered on July 29, 1974, whereby it granted an application by the respondent for the purpose of rejecting the objection submitted by the appellant on May 15, 1974.The Tribunal rejects the appeal, without costs.59797-0 Liquidation \u2014 Loi de la CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE LA COMPAGNIE CONSUMERS GLASS LTEE (Lot des caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de la « CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE LA COMPAGNIE CONSUMERS GLASS LTEE », tenue à La Prairie, le 27 octobre 1974, il a été résolu à l'unanimité que les affaires de ladite caisse soient liquidées et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi des caisses d'épargne et de crédit et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que maître Yves Périgny soit nommé liquidateur.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 59825-o Albert Jessoi\\ Winding-Up Act CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE LA COMPAGNIE CONSUMERS GLASS LTEE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that a special general meeting of the members of the \"CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE LA COMPAGNIE CONSUMERS GLASS LTEE\", held in La Prairie, on October 27, 1974, it was unanimously resolved that the affairs of the said union be wound up and that the latter be dissolved, pursuant to the Savings and Credit Unions Act and to the Winding-Up Act, and that Me Yves Périgny be appointed liquidator.Québec, January 16, 1975.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 59825 Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n\" 5 1227 LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PAUL-APOTRE (Loi des caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de « LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PAUL-APOTRE», tenue à Québec, le 30 novembre 1974, il a été résolu à l'unanimité que les affaires de ladite caisse soient liquidées et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi des caisses d'épargne et de crédit et de la I.oi de la liquidation des compagnies et que M.J.T.Payeur soit nommé liquidateur.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 59863-0 Albeiit Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PAUL-APOTRE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that, at a special general meeting of the members of \"LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PAUL-APOTRE\", held in Québec on November 30, 1974, it was unanimously resolved that the affairs of said caisse be wound up and that the latter be dissolved, pursuant to the Savings and Credit Unions Act and to the Winding-Up Act, and that Mr.J.T.Payeur be appointed liquidator.Québec, January 16, 1975.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 59863 Companies and Cooperatives.Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Nom des compagnies Name of the companies en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites compagnies.En conséquence, lesdites compagnies sont censées n'avoir jamais été dissoutes en vertu de ladite loi, sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.Le directeur du service des compagnies, 59795-0 Pierre Desjardiss.Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act, he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Dissolution Gazette officielle No Date Official Gazette No.16 02 74 7 04 06 74 18 22 12 73 61, 12 10 74 41 22 12 73 61 24 08 73 34 12 10 74 41 02 03 74 9 pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said companies.Consequently, the said companies are considered as having never been dissolved under the said Act, without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.Pierre Desjardins.59795-0 Director of the Companies Service.CARILLON ENTREPRENEUR-ELECTRICIEN LTEE.LA COMPAGNIE DTMPRIMERLE ET DE PUBLICATION DE LA RIVE-SUD LIMITEE MAISON D'EDITION H.M.INC.NETTOYEUR MAGIQUE LTEE.NORMANDIE AUTOMOBILE LTD.TONKA CONSTRUCTION INC.TOP STYLES INC.WELL-MADE CRAVAT MANUFACTURING COMPANY INCORPORATED 1228 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1976, Vol.107, No.5 Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Annirude Narine Avis est par les présentes donné que Annirude Narine, résidant et domicilié au 1655 est, rue Sauvé, app.11, Montréal, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom de Annirude Narine en celui de Andrew Narine.Montréal, ce 31 décembre 1974.Les procureurs du requérant.Mes.Shadley, Melançon 59744-4-2-0 & Associés, avocats.Alain-Roland Forgues Avis est par les présentes donné que M.Alain-Roland Forgues, résidant et domicilié au 227, rue Barker à Cowansville, district de Bedford, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour obtenir un décret changeant son nom de Alain-Roland Forgues à celui de Alain-Roland Miltimorc.Cowansville, ce 15e jour de janvier 1975.Le procureur du requérant, 59776-4-2-0 Me André Bachand.Robert Papamichael Avis est donné que Robert Papamichael, domicilié au 6312, Arthur-Chevrier, app.8, Montréal-Nord, Québec, présentera au lieutenant-gouverneur en conseil une requête pour le changement de son nom en celui de Robert Michael, tel que prévu par les dispositions de la Loi du changement de nom.Montréal, ce 30 décembre 1974.Les procureurs du requérant, 59806-5-2-o Archambault & Lapierre.Kurt Thomas Andreas Schwartzlose Une application sera faite au lieutenant-gouverneur en conseil par Kurt Thomas Andreas Schwartzlose du 727, rue Buchanan, ville St-Laurent, gentilhomme en retraite, pour le changement de nom à Thomas Holmes et pour le bénéfice de sa femme Else Jensen.Montréal, le 17 décembre 1974.Le procureur du requérant, 59808-5-2-o Emmanuel Cooke, c.r.Jean Morin Avis est donné que Jean Morin administrateur, domicilié au 309, Des Saules Ouest, Québec 3, déposera une requête auprès du ministre de la justice de la province de Québec pour changer son nom de Jean Morin en celui de Jean-Luc Morin et qu'à défaut de toute opposition auprès dudit ministre, ce dernier recommandera d'effectuer le changement de nom demandé.Québec, cc 23e jour de décembre 1974.59812-5-2-0 Jean Morin.Change of name \u2014 Act Applications Annirude Narine Take notice that Annirude Narine, residing and domiciled at 1655, Sauvé Street East, Apt.11, Montreal, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Annirude Narine to Andrew Narine.Montreal, December 31st, 1974.Mes.Shadley, Melançon & Ass., lawyers, 59744-4-2-0 Attorneys for the petitioner.Alain-Roland Forgues Notice is hereby given that Mr.Alain-Roland Forgues, residing and domiciled at 227, Barker street in Cowansville, district of Bedford, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Mr.Alain-Roland Forgues to Mr.Alain Roland Miltimorc.Cowansville, this 15th day of January 1975.Me André Bachand, 59776-4-2-0 Attorney for the Petitioner.Robert Papamichael Notice is given that Robert Papamichael, domiciled at 6312 Arthur-Chevrier, Apartment 8, Montreal-North, Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Robert Michael, as provided under the provisions of the Change of Name Act.Montreal, December 30, 1974.Archambault & Lapierre, 59806-5-2 Attorneys for the applicant.Kurt Thomas Andreas Schwartzlose Application will be made to the Lieutenant-Governor in Council by Kurt Thomas Andreas Schwartzlose of 727 Buchanan St., City of St.Laurent, retired gentleman, to change his name to Thomas Holmes which will also benefit his wife Else Jensen.Montreal, December 17, 1974.Emmanuel Cooke, q.c, 59808-5-2-o Attorney for applicant.Jean Morin Notice is given that Jean Morin, executive, domiciled at 309 Des Saules West, Québec 3, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec for an order changing his name of Jean Morin to that of Jean-Luc Morin and failing any objection to that effect, the Minister will recommend that this change of name be effected as requested.Québec, this 23rd dav of December, 1974.59812-5-2 Jean Morin. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1229 Michel Deniers Avis par les présentes est donné que Michel Demers, présentement sans emploi, domicilié et résidant au 8405, rue Lajeunesse, à Montréal, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Michel De-moors.Montréal, 11 décembre 1974.L'avocat du requérant, 59807-5-2-o Me Paule Lafontaine.Michel Deniers Notice is hereby given that Michel Demers, presently unemployed, domiciled and residing at 8405 Lajeunesse Street in Montreal, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to that of Michel Demoors.Montreal, December 11, 1974.Me Paule Lafontaine, 59807-5-2 Attorney for the applicant.Jancu Jean Stefanescu Avis est par les présentes donné que Jancu Jean Stefanescu, teneur de livres, résidant et domicilié au 5049, avenue Victoria, Montréal (Québec), s'adressera au ministre de la justice de la province de Québec afin de changer son nom en celui de Jancu Jean Senater, ce changement de nom devant également profiter à son épouse, dame Regina Schwartz, domiciliée à la même adresse, ainsi qu'à ses enfants, Sanda Stefanescu, sa fille, domiciliée au 6A, chemin du Pusscy, Genève (Suisse) et à son fils Niky Stefanescu, joaillier, des ville et district de Montréal, domicilié et résidant au 2200, Noël, Montréal (Québec), son épouse, Ruth Zeller et leurs enfants mineurs, Leonard Stefanescu et David Stefanescu.Montréal, le 5 novembre 1974.Le procureur du requérant, 59813-5-2 Barry Biberman.Jancu Jean Stefanescu Notice is hereby given that Jancu Jean Stefanescu, bookkeeper, residing and domiciled at 5049 Victoria Avenue, Montreal, Que., will apply to the Minister of Justice for the Province of Québec in order to change his name to Jancu Jean Senater, the name of his wife.Dame Regina Schwartz of the same address will be changed by the present application, as well as of his children, Sanda Stefanescu, his daughter, domiciled at 6A Chemin du Pussey, Geneva, Switzerland, and his son Niky Stefanescu, jeweller, of the city and district of Montreal, domiciled and residing at 2200 Noel, Montreal, Que., as well as his wife, Ruth Zeller and their minor children Leonard Stefanescu and David Stefanescu.Montreal, November 5th, 1974.Barry Biberman, 59813-5-2-o Attorney for petitioner.Raphaël Haber Hoyeck Avis est donné par les présentes qu'une requête sera présentée au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, en vertu de la Loi du changement de nom, 13-14 Elizabeth II, chapitre 77, demandant le changement de nom suivant: Raphaël Haber Hoyeck, ingénieur civil, de la cité de Westmount, district de Montréal, et y résidant au numéro 80, avenue Sommer-ville, en celui de Ralph Haber Howard.Montréal, le 10 janvier 1975.Le procureur du requérant, 59845-5-2 Mortimer J.Constantine.Raphaël Haber Hoyeck Notice is hereby given that an application will be made to the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, under the Change of Name Act, 13-14 Eliz., II, Chap.77, requesting the following change of name: Raphaël Haber Hoyeck, Civil Engineer, of the City of Westmount, District of Montreal, and therein residing at 80 Sommerville Avenue, to Ralph Haber Howard.Montreal, January 10th, 1975.Mortimer J.Constantine, 59845-5-2-0 Attorney for Petitioner.François Khiryati Avis est, par les présentes, donné que François Khiryati, domicilié et résidant au 7101 rue Beaudrière, appartement 7, Ville d'Anjou, district de Montréal, s'adressera au ministère de la Justice afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de François Coriaty, ledit changement de nom devant bénéficier à sa femme Dame Rosine Coussa et à ses enfants mineurs, Michel et Nancy.Montréal, le 21 janvier 1975.Les procureurs du requérant.De Grandpré, Colas, Amyot, I.esaoe, 59847-5-2-0 Deschênes & Godin.François Khiryati Notice is hereby given that François Khiryati, domiciled and residing at 7101 Beaudrière street, apartment 7, Town of Anjou, district of Montreal, will apply to the Minister of Justice for an order changing his name to that of François Coriaty, said change of name to also benefit his wife, Mrs.Rosine Coussa and their minor children Michel and Nancy.Montreal, January 21st 1975.De Grandpré, Colas, Amyot, Lesage, Deschênes & Godin, 59847-5-2-0 Attorneys for the applicant. 1230 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Edward Juziliastis Prenez avis que monsieur Edward Juziliastis, pompier, domicilié au 1020 rue Stephens, cité de Verdun, district de Montréal, s'adressera au ministre de la Justice de la province de Québec, pour demander la permission de changer de nom et de porter désormais le nom de Edward Juzalaitis.Monsieur Edward Juziliastis est l'époux de Pauline Jasmin-Juziliastis et le père de Carol Pauline, Joanne Edwina et Sharon Diane Juziliastis, dont le nom de famille serait changé à la suite de cette requête.Montréal, ce lie jour de décembre 1974.Les procureurs du requérant, CoUSINEAU, VaILLANCOURT 59846-5-2-0 & Cadieux.Edward Juziliastis Take notice that Mr.Edward Juziliastis, fireman, domiciled at 1020 Stephens street.City of Verdun District of Montreal, will transmit to the Minister of Justice of the Province of Québec, an application for a change of name and to be named hereafter Edward Juzalaitis.Mr.Edward Juziliastis is married to Pauline Jasmin-Juziliastis and is the father of 3 childrem, namely Carol Pauline, Joanne Edwina and Sharon Diane Juziliastis, whose family name would be changed pursuant to this application.Montreal, this 11th day of December 1974.cousineau, vaillancourt & Cadieux, 59846-5-2 Attorneys for applicant.Dumitru-Mina Ionescu ct Stefania-Elena Isbasoiu-Ionescu Avis est donné que monsieur Dumitru-Mina Ionescu, pharmacien et son épouse Dame Stefania-Elena Isbasoiu-Ionescu, pharmacienne, domiciliés au numéro 5815 rue St-André, Montréal, province de Québec, district de Montréal, s'adresseront au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir un décret changeant leurs noms de Dumitru-Mina Ionescu en celui de Dimitrie-Mina Ionesco et Stefania-Elena Isbasoiu-lonescu en celui ce Stéphanie-Elena Isbasoiu-Ionesco.Montréal, ce 13 janvier 1975.59848-5-2-0 Le notaire, André Morais.Dumitru-Mina Ionescu et Stefania-Elena Isbasoiu-lonescu Take notice that Mr Dumitru-Mina Ionescu, pharmacist, and his wife Mrs Stefania-Elena Isbasoiu-lonescu, phamacist, whose address is 5815 St-André Street, Montreal, Province of Québec, district of Montreal, will apply by petition to the Lieutenant-Governor in Council, Province of Québec, for the purpose of asking him for a decree, changing their names from Dumitru-Mina Ionescu to Dimitrie-Mina Ionesco and Stefania-Elena Isbasoiu-lonescu to Stéphanie-Elena Isbasoiu-Ionesco.Montreal, this 13th of January, 1975.André Morais, 59848-5-2-0 Notary.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Change of name \u2014 Act Granted Josée Marie Audet Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 8 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Marie Berthe Fernande Rita Audet en celui de Josée Marie Audet.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-o Robert Normand, c.n.Josée Marie Audet It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Berthe Fernande Rita Audet to that of Josée Marie Audet, by order number 8, dated January 8, 1975.Quebec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.John Meguerditch Hrant Balian Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 9 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Meguerditch Hrant Balian en celui de John Meguerditch Hrant Balian.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice.59798-o Robert Normand, c.n.John Meguerditch Hrant Balian It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Meguerditch Hrant Balian to that of John Meguerditch Hrant Balian, by order number 9.dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1er février 1975, 107' année, n* 5 1231 Y van Marc André Blain Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 10 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Ivan Marc André Bcaudet en celui de Y van Marc André Blain.Quélioc.le 16 janvier 1975.Le «ou.i-mini.ilrc de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Y van Marc André Blain It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Ivan Marc André Beaudet to that of Y van Marc André Blain, by order number 10, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c.59798 Deputy Minister of Justice.Joseph Chenoj Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 11 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph Kenou en celui de Joseph Chenoy.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Joseph Chenoy It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Kenou to that of Joseph Chenoy.by order number 11, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c.59798 Deputy Minister of Justice.Barr> Stephen Dollin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 12 du S janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Barry Stephen Delitsky (Dollin) en celui de Barry Stephen Dollin.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Barry Stephen Dollin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Barry Stephen Delitsky (Dollin) to that of Barry Stephen Delitsky (Dollin), by order number 12, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Lawrence Kaley Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 13 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Lawrence Kalibaba en celui de Lawrence Kaley.\"\"Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Joseph Elisée Clément Laflamme Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 14 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph Elisée Clément Clermont en celui de Joseph Elisée Clément Laflamme.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-o Robert Normand, c.r.Lawrence Kaley It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Lawrence Kalibaba to that of Lawrence Kaley, by order number 13, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Joseph Elisée Clément Laflamme It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name,of Joseph Elisée Clément Clermont to that of Joseph Elisée Clément Laflamme, by order number 14, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Joseph Arthur Narcisse Lamoureux Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 15 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph Arthur Narcisse Sauvé en celui de Joseph Arthur Narcisse Lamoureux.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Joseph Arthur Narcisse Lamoureux It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Arthur Narcisse Sauvé to that of Joseph Arthur Narcisse Lamoureux, by order number 15.dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice. I 1232 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Jan Marek Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 16 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Jan Jech en celui de Jan Marek.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Oleg Jonathan Michaels Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 17 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Oleh Michaelchuk en celui de Oleg Jonathan Michaels.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-o Robert Normand, c.r.Jan Marek It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Jan Jech to that of Jan Marek, by order number 16, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Oleg Jonathan Michaels It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Oleh Michaelchuk to that of Oleg Jonathan Michaels, by order number 17, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Marie Yvonne Lucile Périard Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 18 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Marie Yvonne Lucile Périllard en celui de Marie Yvonne Lucile Périard.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-o Robert Normand, c.r.Joseph François Guy Claude Yves Daniel St-Cyr Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 24 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph François Guy Claude Yves St-Cyr en celui de Joseph François Guy Claude Yves Daniel St-Cyr.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Ernest Robert Sharpc Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 20 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Ernest Robert Schacht en celui de Ernest Robert Sharpc.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Harold Sharpc Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 19 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Harold Adolphus Schacht en celui de Harold Sharpe.Québec, le 16 janvier 1975.Ije sous-ministre de la justice, 59798-0 Rorert Normand, ch.Marie Yvonne Lucile Périard It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Yvonne Lucile Périllard to that of Marie Yvonne Lucile Périard, by order number 18, dated January 8.1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Joseph François Guy Claude Yves Daniel St-Cyr It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph François Guy Claude Yves St-Cyr to that of Joseph François Guy Claude Yves Daniel St-Cyr, by order number 24, dated January 8, 1975.Québec, January 16,1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Ernest Robert Sharpe It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Ernest Robert Schacht to that of Ernest Robert Sharpe, by order number 20, dated January 8,1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, o9798 Deputy Minister of Justice.Harold Sharpc It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Harold Adolphus Schacht to that of Harold Sharpc, bv order number 19, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c., 59798 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n' 5 1233 Léon Yehouda Simon Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 21 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Léon Abboud en celui de Léon Yehouda Simon.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-minislre de la justice, 59798-o Robert Normand, c.r.Dorothy Starr Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 22 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Dorothy Staroselski en celui de Dorothy Starr.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Joseph Michel Sylvain Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 23 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph Rosius Sylvain en celui de Joseph Michel Sylvain.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Frederick Richard Turner Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 25 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Frederick Richard Perry en celui de Frederick Richard Turner.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798-0 Robert Normand, c.r.Joseph Marcel Réal Jean Vézina Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 26 du 8 janvier 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph Marcel Réal Jean en celui de Joseph Marcel Réal Jean Vézina.Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre de la justice, 59798 Raymond Normand, c.r.Léon Yehouda Simon It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Léon Abboud to that of Léon Yehouda Simon, by order number 21, dated January 8, 1975.Québec, January 16,1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Dorothy Starr It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Dorothy Staroselski to that of Dorothy Starr, by order number 22, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Joseph Michel Sylvain It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Rosius Sylvain to that of Joseph Michel Sylvain, by order number 23, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Frederick Richard Turner It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Frederick Richard Perry to that of Frederick Richard Turner, by order number 25, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Joseph Marcel Réal Jean Vézina It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Marcel Real Jean to that of Joseph Marcel Réal Jean Vézina, by order number 24, dated January 8, 1975.Québec, January 16, 1975.Robert Normand, q.c, 59798 Deputy Minister of Justice.Demandes à la Législature Applications to Legislature Ville de Trois-Rivières Ouest Avis est par les présentes donné que la Ville de Trois-Rivières Ouest s'adressera lors de la prochaine session législative à l'Assemblée Nationale pour qu'une loi soit adoptée dans le but de lui permettre de verser une pension annuelle de $2.000 à l'ancien directeur de son Service des Incendies, M.J.Émilien Launier.sa vie durant.Les procureurs de la requérante, Chartier, Ménard, 59859-5-4-0 Govrdeav & Godjn.Town of Trois-Rivières West Notice is hereby given that the Town of Trois-Rivières West, will apply to the National Assembly, at its next session, for the adoption of an act granting it the power to pay an annual pension of $2,000 to Mr.J.Émilien Launier.the former director of its Fire Department, during his lifetime.Chartier, Menard, Gourdeau & Godin, 59859-5-4-0 Attorneys for the petitioner. 1234 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 GAGNON ET ARCHAMBAULT ARCHITECTES Avis est par les présentes donné que Normand C.Gagnon et Maurice E.Arcliambault, architectes, domiciliés respectivement dans la ville de Boucherville et dans la ville de Westmount, s'adresseront à l'Assemblée Nationale du Québec à sa présente ou prochaine session, ou à sa session ultérieure, afin d'obtenir l'adoption d'un bill pour faire confirmer leurs droits de propriété sur les lots 1 (un) à 7 (sept) de la subdivision du lot originaire 1200 (mille deux cents), sur les lots 1 (un) à 9 (neuf) et 9a (neuf a) de la subdivision du lot originaire 1201 (mille deux cent un) et sur les lots 1202 (mille deux cent deux) et 1202a (mille deux cent deux a) du cadastre du quartier St-Antoine et pour éteindre les servitudes de passage qui ont été créées sur quelques-uns de ces lots par les propriétaires originaires de ces lots, W.William L.Maltby et al.et pour toutes autres fins.Fait à Montréal, ce 16 janvier 1975.Les procureurs des requérants, Allaire, L'Heureux, Gratton 59774-4-4-0 & Blain.Hôpital Saint-Charles de St-Hyacinthc Hôpital Saint-Charles de St-Hyacinthe fait savoir qu'elle s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, au cours de la prochaine session, pour demander sa dissolution.Janvier 1975.Les procureurs de la pétitionnaire, Geoffrion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marchessault, 59801-5-4-o Mercier & Greenstein.Hôpital Général Saint-Vincent de Paul de Sherbrooke Hôpital Général Saint-Vincent de Paul de Sherbrooke fait savoir qu'elle s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, au cours de la prochaine session, pour demander sa dissolution.Janvier 1975.Les procureurs de la pétitionnaire, Geoffrion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marchessault, 59802-5-4-o Mercier & Greenstein.Hôpital Saint-Joseph de Granby Hôpital Saint-Joseph de Granby fait savoir qu'elle s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, au cours de la prochaine session, pour demander sa dissolution.Janvier 1975.Les procureurs de la pétitionnaire, Geoffrion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marchessault, 59803-5-4-o Mercier & Greenstein.GAGNON AND ARCHAMBAULT ARCHITECTS Public notice is hereby given that Normand C.Gagnon et Maurice E.Archambault, architects living respectively in the City of Boucherville and in the City of Westmount will apply to the Québec National Assembly during its current or next session or the following one, for the passing of a bill regarding the confirmation of their property rights on lots 1 (one) to 7 (seven) of the subdivision of original lot number 1200 (one thousand two hundred), on lots 1 (one) to 9 (nine) and 9a (nine a) of the subdivision of original lot number 1201 (one thousand two hundred one) and lots 1202 (one thousand two hundred two) and 1202a (one thousand two hundred two a), of St-Antoine Ward and to extinguish servitudes of right of way which have been created on some of these lots by the original owners, Mr.William L.Maltby and al.and for all other purposes.Montreal, January 16, 1975.Allaire, L'Heureux, Gratton & Blain, 59774-4-4-0 Attorneys for petitioners.Hôpital Saint-Charles de St-Hyacinthe Notice is hereby given that Hôpital Saint-Charles de St-Hyacinthe will apply to the National Assembly of Québec, to ask for its dissolution.January 1975.Geoffrion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marchessault, Mercier & Greenstein, 59801-5-4-o Attorneys for the petitioner.Hôpital Général Saint-Vincent de Paul de Sherbrooke Notice is hereby given that Hôpital Général Saint-Vincent de Paul de Sherbrooke will apply to the National Assembly of Québec, to ask for its dissolution.January 1975.Geoffrion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marchessault, Mercier & Greenstein.59802-5-4-o Attorneys for the petitioner.Hôpital Saint-Joseph de Granby Notice is hereby given that Hôpital Saint-Joseph de Granby will apply to the National Assembly of Québec, to ask for its dissolution.January 1975.Geoffrion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marchessault, Mercier & Greenstein, 59803-5-4-o Attorneys for the petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1235 RELIURE GALA INC.GALA BOOKBINDING INC.Avis est donné que la compagnie « RELIURE GALA INC.\u2014GALA BOOKBINDING INC.».constituée le 17 août 1973 par lettres patentes émises par le ministère des institutions financières, compagnies et coopératives confirmant un acte d'accord entre les compagnies « RELIURE IMPERIALE INC.» et « C.GA-LARNEAU & CO.LIMITEE », demandera l'adoption d'une loi privée pour modifier la clause de conversion du capital-actions des deux compagnies fusionnantes dans ledit acte d'accord et dans lesdites lettres patentes, et à cet effet déposera un projet de loi privé devant l'Assemblée Nationale du Québec.Emis à Montréal, le 12 novembre 1974.59775-4-4-0 Me André J.Therrien, avocat.Avis divers Succession Raymond Parenteau Avis est par les présentes donné que dame Lise Latour.ménagère, demeurant à Drummondville.1295.rue Caya.a accepté, sous bénéfice d'inventaire, par acte signé devant Me Gérard Fradet, notaire, à Drum-mondville.215.rue Lindsay, le vingt et un août mil neuf cent soixante-quatorze, enregistré au bureau d'enregistrement de Drummond le vingt-trois août mil neuf cent soixante-quatorze sous le numéro 209739.la succession de feu Raymond Parenteau, son époux, en son vivant conseiller en orientation, domicilié à Drummondville, 1295, rue Caya.Drummondville, le 21 janvier 1975.Le notaire, 215 rue Lindsay, Gérard Fradet.Drummondville.P.Q.59834-o Succession Frank Wesley Fletcher Avis est donné que le 6 août 1974 par un acte d'acceptation déposé et enregistré au bureau d'enregistrement de Bonaventure.sous le numéro 35290, le 17 janvier 1975, les soussignés, agents et procureurs pour Jessie Grace Boden-Stonehouse, domiciliée au 68 de la rue Pearl.Nashua.New Hampshire, Etats-Unis, et Freida Fletcher-White, domiciliée sur la 3e Avenue, West Hiannisport, Massachusetts, Etats-Unis, ont accepté sous bénéfice d'inventaire la succession du défunt Frank Wesley Fletcher, de son vivant d'Escu-minac, comté de Bonaventure.Deux mois après la publication du présent avis, les soussignés procéderont au règlement de toutes les réclamations reçues par eux.Fait à Québec, le 22 janvier 1975.Flynn, Rivard, Jacqies, Cimon.2 Chauveau, Lessard & Le May.CP.670, Québec 4, Que.59865-0 RELIURE GALA INC.GALA BOOKBINDING INC.Notice is given that \"RELIURE GALA INC.\u2014 (.ALA BOOKBINDING INC.\", incorporated on August 17.1973 by letters patent issued by the Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, confirming a deed of agreement between \"RELIURE IMPERIALE INC.\" and \"C.GALAR-NEAU & CO.LIMITEE\", will petition for the passing of a private bill to amend the clause converting the share capital of the two amalgamating companies in said deed of agreement and in said letters patent, and will table a private bill to this effect before the National Assembly of Québec.Dated at Montreal, this 12th day of November 1974.59775-4-4 Me André .1.Therrien, Lawyer.Miscellaneous Notices Estate of Raymond Parenteau Notice is hereby given that Mrs.Lise Latour, housewife, residing at 1295 Caya Street, in Drummondville.has accepted, under benefit of inventory, under the terms of a deed executed before Me Gérard Fradet, notary, 215 Lindsay Street, Drummondville.on the twenty-first of August one thousand nine hundred seventy-four, registered at the Drummond Registry Office on the twenty-third of August one thousand nine hundred seventy-four under number 209739, the estate of the late Raymond Parenteau, her husband, in his lifetime guidance counsellor, domiciled at 1295 Caya Street, Drummondville.Drummondville, January 21.1975.Gérard Fradet, 215 Lindsay Street, Notary.Drummondville, P.Q.59834 Estate of Frank Wesley Fletcher Public notice is given that on the 6th day of August 1974, by a deed of acceptance deposited and registered at the Registry Office of Bonaventure under No.35290 on the 17th day of January 1975.the undersigned, solicitors acting for Jessie Grace Boden-Stonehouse, domiciled on 68.Pearl Street, Nashua.New Hampshire.U.S.A., and Freida Fletcher-White, domiciled on 3rd Avenue, West Hiannisport, Massachusetts, U.S.A., have accepted under benefit of inventory the estate of Frank Wesley Fletcher, deceased, in his lifetime of Escuminac, County of Bonaventure.Two months after the publication of the present notice, the undersigned will proceed with the settlement of all claims deposited with them.Signed at Québec, this 22nd day of January 1975.Flynn, Rivard.Jacques, Cimon.2 Chauveau Lessard & Le May.CP.670 Québec 4, Que.59865-o 1236 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Succession René Boivin Avis public est donné que Gérald Boivin, professeur, domicilié au 312, rue Massey, Repentigny, Québec, a accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de M.René Boivin, en son vivant à l'emploi de Fiduciaires de l'Alcan Limitée, domicilié au 490, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière.Québec, par acte passé le treize janvier mil neuf cent soixante-quinze (1975), devant Me Lorraine Delorme, notaire, 4555 est, rue Beaubien, Montréal, Québec et enregistré le vingt janvier mil neuf cent soixante-quinze (1975), au bureau d'enregistrement de Chicoutimi, sous le numéro 282,391.Montréal, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-quinze (1975).59864-o Gérald Boivin.Estate of René Boivin Public notice is given that Gérald Boivin, teacher, domiciled at 312 Massey Street, Repentigny.Québec, has accepted, under benefit of inventory, the estate of René Boivin.employee, in his lifetime, of Fiduciaires de l'Alcan Limitée, domiciled at 490 Saint-Jean-Baptiste Street, Jonquière, Québec, by a deed executed on the thirteenth day of January, one thousand nine hundred seventy-five (1975) before Me Lorraine Dclorme, notary, 4555 Beaubien Street East, Montreal.Québec, and registered on the twentieth day of January, one thousand nine hundred seventy-five (1975) in the Chicoutimi Registry Office under number 282,391.Montreal, this twenty-second day of January, one thousand nine hundred seventy-five (1975).59864 Gérald Boivin.Ville de Montréal Avis de rachat Aux détenteurs des obligations payables en monnaie légale de la République Fédérale d'Allemagne de l'émission « 7% Deutsche Mark Loan of 1969 » de la ville de Montréal, Province de Québec, Canada.AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que la ville de Montréal a l'intention de racheter et rachètera le 1er avril 1975, conformément à l'article 3, section 2, des conditions d'emprunt, les obligations suivantes payables en monnaie légale de la République Fédérale d'Allemagne de l'émission ci-dessus mentionnée échéant le 1er avril 1989 énumérées ci-dessous, à 100% de leur valeur nominale plus les intérêts courus à la date de rachat, à savoir : 3,500 obligations au montant de capital de DM 1,000 chacune Numéro de la série 1 - Numéros des obligations 00001 - 03500 inclusivement 800 obligations au montant de capital de DM 6,000 chacune Numéro de la série 1 - Numéros des obligations 70001 - 70300 inclusivement Les obligations ainsi rappelées pour rachat deviendront dues et payables et seront payées, au choix du détenteur, en monnaie légale de la République Fédérale d'Allemagne, au bureau principal de Berliner Handels-Gesellschaft, Frankfort (Main), et/ou à toute autre banque énuméréc à l'artic|e 6, section 1, des conditions d'emprunt, sur présentation et remise desdites obligations avec tous les coupons d'intérêt échéant après le 1er avril 1975.A compter du et après le 1er avril 1975, l'intérêt sur les obligations ainsi rappelées pour rachat cessera et les coupons d'intérêt échéant subséquemment à cette date seront nuls.Daté à Montréal, ce dixième jour de décembre 1974.Ville de Montréal, Roger Bélanger, 59831-0 Directeur des Finances.City of Montreal Notice of Redemption To the holders of debentures payable in the legal currency of the Federal Republic of Germany of the issue \"7% Deutsche Mark Loan of 1969\" of the City of Montreal, Province of Québec, Canada.PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City of Montreal intends to and will redeem on April 1, 1975, pursuant to article 3, section 2, of the conditions of loan, the following debentures payable in lawful money in the Federal Republic of Germany of the above-mentioned issue due on April 1, 1989, listed below at 100% of the face value thereof plus accrued interest to the redemption date, namely: 3,600 debentures in the principal amount of DM 1,000 each Séries number 1 - Debentures numbers 00001 -03500 inclusive 300 debentures in the principal amount of DM 6,000 each Series number 1 - Debentures numbers 70001 -70300 inclusive The debentures so called for redemption will become due and payable and will be paid, at the option of the holder, in lawful money of the Federal Republic of Germany, at the principal office of Berliner Handels-Gesellschaft, Frarikfurt (Main), arid/or at any other bank listed in article 6, section 1, of the conditions of loan, upon presentation and surrender of the said debentures with all interest coupons maturing after April 1, 1975.From and after April 1, 1975, interest on the debentures so called for redemption will cease and interest coupons maturing subsequent to that date will be void.Dated at Montreal, this tenth day of December, 1974.City of Montreal, Roger Bélanger, 59831-0 Director of Finance. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n\" 5 1237 VILLE-JOIE DU ROSAIRE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a déclaré la corporation « VILLE-JOIE DU ROSAIRE », constituée en corporation par lettres patentes émises, le 12 février 1965, en vertu de l'article 22 de la Loi constituant en corporation Les Dominicaines du Rosaire, 12-13 Elizabeth II, chapitre 112, dissoute en vertu de l'article 22 précité, cette dissolution devant prendre effet à compter du soixantième jour de la publication du présent avis dans la Gazelle officielle du Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59866-0 Cong.1-65 VILLE-JOIE DU ROSAIRE The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that he has declared \"VILLE-JOIE DU ROSAIRE\", incorporated by letters patent issued on February 12, 1965, under section 22 of the Act to incorporate Les Dominicaines du Rosaire, 12-13 Elizabeth II, Chapter 112, dissolved under the aforementioned section 22, such dissolution to take effect on the sixtieth day following the date of publication of this notice in the Québec Official Gazette.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.59866 Cong.1-65 L'EGLISE DU CHRIST DE L'OUEST DE L'ISLE INC.and its English version WEST ISLAND CHURCH OF CHRIST INC.Avis est donné par les présentes que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a délivré des lettres patentes en date du 4e jour de juillet 1974, constituant en corporation, régie par la Loi des corporations religieuses, chapitre 75 des Lois de 1971, Dennis L.Dilley, ministre du culte, du 4358.rue Château.William J.Coates, courtier d'assurances, du 14,926, rue Gratton, tous deux de Pierrefonds, et Henry Hugh L.Pratley, ingénieur, du 5, avenue Thornhill, Westmount.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $100,000.Le siège social de la nouvelle corporation est situé au 4358, rue Château, Pierrefonds.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59795 1357-6541 FIDUCIE DU QUEBEC et sa version anglaise QUEBEC TRUST Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies de fidéicommis et de la Loi des compagnies de Québec, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives d'accorder des lettres patentes supplémentaires en date du 5e jour de décembre 1974, à la compagnie « SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC \u2014 QUEBEC TRUST COMPANY ».1° changeant son nom en celui de « FIDUCIE DU QUE-BEC et sa version anglaise QUEBEC TRUST ».2° augmentant le capital-actions de la compagnie de $5,000,000 à $25,000,000; le capital-actions additionnel étant divisé en 200.000 actions ordinaires de $100 chacune, de sorte que le capital-actions de la compagnie est de $25,000,000 divisé en 250,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59795-0 14049-62 L'EGLISE DU CHRIST DE L'OUEST DE L'ISLE INC.and its English version WEST ISLAND CHURCH OF CHRIST INC.Notice is hereby given that letters patent bearing dated the 4th day of July.1974, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to constitute as a corporation governed by the Religious Corporations Act.Chapter 75, Statutes of 1971.Dennis L.Dilley, pastor, 4358 Château Street.William J.Coates, insurance broker, 14926 Gratton Street, both of Pierrefonds and Henry Hugh L.Pratley, engineer, 5 Thornhill Avenue.Westmount.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may own or hold is to be limited, is $100,000.The head office of the new corporation is at 4358 Château Street, Pierrefonds.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.59795-0 1357-6541 FIDUCIE DU QUEBEC et sa version anglaise QUEBEC TRUST Notice is given that, pursuant to the Trust Companies Act and to the Québec Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to grant supplementary letters patent dated the 5th day of December, 1974, to \"SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC \u2014QUE-BEC TRUST COMPANY\", 1.changing its name to that of \"FIDUCIE DU QUEBEC et sa version anglaise QUEBEC TRUST\".2.increasing the share capital of the company from $5,000.000 to $25,000,000; the additional share capital being divided into 200,000 common shares of $100 each, in order that the $25,000,000 share capital of the company shall be divided into 250,000 common shares of $100 each.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.59795 14049-62 1238 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 Succession Viateur Prévost Avis est par les présentes donné que M.Jean Deslauriers, journalier, domicilié au 2857, rue Ontario est, Montréal, Québec, nommé tuteur à Francis Prévost, enfant mineur de dame Hélène Leroux et de feu Viateur Prévost, et ce suivant ordonnance de la Cour supérieure du district de Montréal, rendue le 18 novembre 1974 par le protonotaire adjoint, et portant le numéro 14-003788-74 des dossiers de ladite Cour, a accepté, sous bénéfice d'inventaire, pour ledit Francis Prévost, la succession de son défunt père.Viateur Prévost, en son vivant domicilié à Montréal, lieu de son décès, sans laisser de testament, le tout suivant acte exécuté devant Me Bernard Fauteux, notaire, 6269, boulevard Maurice-Duplessis, (app.No 101) à Montréal-Nord, Québec, daté le 23 décembre 1974 et enregistré au bureau d'enregistrement de Montréal sous le numéro 2573356.Un inventaire des biens du défunt a été fait devant le notaire Me Bernard Fauteux, et peut être consulté à ses bureaux, à l'adresse ci-dessus mentionnée.Après deux mois du présent avis, le tuteur, pour le bénéficiaire Francis Prévost, paiera les créanciers à mesure qu'ils se présenteront, selon la loi.Donné à Montréal-Nord, ce 13e jour de janvier 1975.Le notaire, 59830-o Me Bernard Fauteux.Ville de Brossard Avis est par les présentes donné que la ville de Brossard s'adressera par requête au lieutenant-gouverneur en conseil de cette province, aux fins d'obtenir des lettres patentes amendant la « Loi constituant en corporation la ville de Brossard», 6-7, Eliz.II, chapitre 106, en abrogeant l'article 19 concernant le Fonds de roulement, ainsi que l'article 20 concernant la procédure dans le cas de violation aux règlements municipaux relatifs à la circulation et à la sécurité publique, et remplaçant lesdits articles par les dispositions correspondantes de la Loi des cités et villes.Donné à Brossard, ce 20e jour de janvier 1975.Le procureur, 59809-o Me Claude Desmarais.Estate of Viateur Prévost Public notice is hereby given that Mr.Jean Dcslau-riers.labourer, domiciled at 2857 Ontario Street East, Montreal, P.Q., appointed tutor to Francis Prévost, minor child or Mrs.Hélène Leroux and of the late \\ ia-teur Prévost, according to an order of the Superior Court of the District of Montreal, rendered on November 18,1974 by the Assistant Prothonotary, and bearing number 14-003788-74 of the records of said Court, has accepted, under benefit of inventory, for the said Francis Prévost, the estate of his late father, Viateur Prévost, domiciled in his lifetime in Montreal, where he died intestate, the whole according to a document executed before Me Bernard Fauteux, notary, 6269 Maurice-Duplessis Boulevard, (Apt.No.101), Monlreal-North, Province of Québec, dated December 23, 1974 and registered in the Registry Office of Montreal under number 2573356.An inventory of the property of the deceased has been made before Me Bernard Fauteux, notary and is available for consultation at his office located at the address mentioned hereinabove.Two months from this notice, the tutor to the beneficiary, Francis Prévost, will pay the creditors as they present their claims, according to law.Given in Montreal-North, this 13th day of January, Me Bernard Fauteux, 59830 Notary.Town of Brossard Notice is hereby given that the Town of Brossard will apply, by petition to the Lieutenant-Governor in Council of this Province, in order to obtain Letters Patents amending \"An Act to Incorporate the Town of Brossard\", 6-7, Eliz.II, chapter 106, by abrogating section 19 concerning the Working Fund, and also section 20 concerning the procedure in case of violation of the municipal by-laws relating to traffic and public safety, and by replacing the said sections by the corresponding sections of the Cities and Towns Act.Given at Brossard, this 20th day of January, 1975.Me Claude Desmarais, 59809-o Attorney.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions CAISSE POPULAIRE DE EAST-HEREFORD (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a approuvé la requête des caisses d'épargne et de crédit « LA CAISSE POPULAIRE DE PÀQUETTEVILLE » et «LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-HENRI-DE-HEREFORD », datée du 7 novembre 1974 demandant la confirmation de l'acte d'accord prévoyant la fusion de ces deux caisses.CAISSE POPULAIRE DE EAST-HEREFORD (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the petition of the Savings and Credit Unions \"LA CAISSE POPULAIRE DE PAQUETTEVILLE\" and \"LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ST-HENRI-DE-HEREFORD\", dated November 7, 1974, requesting the confirmation of the deed of agreement providing for the amalgamation of these two caisses. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1239 Le nom de la caisse résultant de cette fusion est: « CAISSE POPULAIRE DE EAST-HEREFORD .Le siège social de cette caisse est situé à East-Hereford dans le district électoral de Mégantic-Compton.Le territoire dans lequel la caisse pourra recruter ses membres sera: « Canton de Hereford, paroisse de East-Hereford et paroisse St-Venant-de-Hereford ».Cette caisse sera affiliée à l'Union régionale de Sherbrooke des Caisses Populaires Desjardins.Québec, le 13 janvier 1975.Le sous-minisire des institutions financières, compagnies et coopératives, 59828-0 Albert Jessop.The name of the caisse resulting from this amalgamation is: \"CAISSE POPULAIRE DE EAST-HEREFORD\".The head office of this caisse is located in East-Hereford, in the Electoral District of Mégantic-Compton.The territory in which the caisse may recruit its members shall be: \"Township of Hereford, Parish of East-Hereford and Parish of Saint-Venant-dc-Hcre-ford\".This caisse shall be affiliated to \"L'Union régionale de Sherbrooke des Caisses Populaires Desjardins\".Québec, January 13, 1975.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 59828 Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-BERNARD DE MONTREAL (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 8 avril 1974.par « LA CAISSK POPULAIRE DE ST-BERNARD DE MONTREAL» modifiant son territoire qui était « celui de la ville de Montréal » en celui des « Villes de Montréal, de Montréal-Est et d'Anjou et des cités de Pointe-aux-Trembles et de Saint-Léonard ».Québec, le 16 janvier 1975.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 59829-0 Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-BERNARD DE MONTREAL (Savings and Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le CINQUIÈME jour de MARS 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 20 janvier 1975.59842-o DRUKER.in his capacity as trustee in the bankruptcy of LAMBERT & FILS LTEE ET AL, mis en cause.\"An immoveable located at 3480 Simpson in Montreal comprising the following: (A) Subdivision number one of original lot number seventeen hundred thirty-one (1731-1) on the official plan and in the book of reference for the Saint-Antoine Ward; (B) Subdivisions numbers U-two and I-two of original lot number seventeen hundred twenty-six (1726-U-2 and 1-2) on said official plan and in said book of reference for the Saint-Antoine Ward.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Montreal Court House.10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56.on the FIFTH day of MARCH, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 20, 1975.59842 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal l TiAME AURORE CREPEAU No 05-010723-74.< CHARPENTIER, veuve t non remariée de Monsieur Paul Charpentier et demeurant et domiciliée en la cité de Lachine, district de Montréal, demanderesse, vs GUY CHARPENTIER, demeurant et domicilié au numéro 661 de la rue William McDonald, en la cité de Lachine, district de Montréal, défendeur.« Cet immeuble ayant front sur la rue William Mac-Donald, en la cité de Lachine, et composé comme suit: a) de la subdivision numéro quatre-vingt-sept du lot originaire numéro sept cent-cinquante-quatre (754-87) aux plan et livre de renvoi officiels de la ville de Lachine, mesurant suivant le cadastre, quarante-sept pieds et six pouces de largeur, par une profondeur de cent trente-neuf pieds et quatre pouces dans sa ligne de côté est et cent vingt-six pieds et sept pouces dans sa ligne de côté ouest, mesure anglaise plus ou moins.6) de la résubdivision numéro trois de la subdivision numéro quatre-vingt-cinq du lot originaire numéro sept cent cinquante-quatre (754-85-3) auxdits plan et livre de renvoi officiels de la ville de Lachine, mesurant quarante-sept pieds et six pouces de largeur par une profondeur de neuf pieds, mesure anglaise et plus ou moins.Avec toutes les bâtisses dessus construites, incluant celle portant les numéros 655, 657 et 661 de ladite rue William MacDonald.La ligne limitative ouest dudit emplacement a cependant été modifiée et fixée par bornage avec les propriétaires riverains tel qu'il appert de deux jugements rendus par le juge Ignace J.Deslauriers, de la Cour Supérieure de la province de Québec, pour le district de Montréal en date du vingt-huit juin mil neuf cent soixante et un (1961), enregistrés au bureau d'enregis- Fieri Fadas de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court - District of Montreal C \\/fRS.AURORE CREPEAU No.05-010723-74X AVI CHARPENTIER, unre-' married widow of Mr.Paul Charpentier, residing and domiciled in the City of Lachine, District of Montreal, plaintiff, vs GUY CHARPENTIER, residing and domiciled at 661 William MacDonald Street, City of Lachine, District of Montreal, defendant.\"That immoveable fronting on William McDonald Street, in the City of Lachine, and comprising the following: (a) Subdivision number eighty-seven of original lot number seven hundred fifty-four (754-87) on the official plan and in the book of reference for the City of Lachine, measuring according to the cadastre forty-seven feet and six inches in width by a depth of one hundred thirty-nine feet and four inches in its easterly side line and of one hundred twenty-six feet and seven inches in its westerly side line, English measure and more or less.(b) resubdivision number three of subdivision number eighty-five of original lot number seven hundred fifty-four (754-85-3) on the said official plan and book of reference for the City of Lachine, measuring forty-seven feet and six inches in width by a depth of nine feet, English measure and more or less.With all the buildings erected thereon, including that one bearing numbers 655, 657 and 661 of said William McDonald Street.The westelry boundary line of said emplacement has however been modified and established by marking out with the riverside owners as it appears from two judgments rendered by the Honourable Ignace J.Deslauriers, judge of the Superior Court for the Province of Québec, District of Montreal, on the twenty-eighth day of June one thousand nine hundred sixty-one 1308 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 1st, 1975, Vol.107, No.5 trement de la division d'enregistrement de Montréal sous les numéros 1549354, 1549354 et 1548355.Tels jugements ont été rendus pour faire suite au rapport des arpenteurs-géomètres qui a été homologué suivant jugements rendus par le juge André Deniers, de la Cour Supérieure de la province de Québec pour le district de Montréal, en date du dix-huit mars mil neuf cent soixante (I960), enregistrés audit bureau d'enregistrement de Montréal, sous les numéros 1469744 et 1469746.Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes ses circonstances et dépendances, et toutes servitudes actives ou passives s'y rattachant, sans exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le QUATRIÈME jour de MARS 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 20 janvier 1975.59843-o (1961), registered at the Registry Office of the Montreal Registration Division as numbers 1549354, 1549354 and 1548355.Said judgments have been rendered following the report of the land-surveyors which has been ratified according to the judgments rendered by the Honourable André Demers, judge of the Superior Court for the Province of Québec, District of Montreal, on the eighteenth day of March, one thousand nine hundred sixty (1960), registered at said Montreal Registrv Office, under numbers 1469744 and 1469746.As the whole now subsists with all its appurtenances and dependencies, and all active and passive servitudes attaching thereto, without exception or reservation.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the FOURTH day of MARCH, 1975, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 20, 1975.59843 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: (TA LAURENTIENNE, Cour Supérieure, ; J-< COMPAGNIE MU-No 200-05-003597-742A TUELLE D'ASSURANCE, ' corporation légalement constituée, ayant son siège social à 500 est, Grande-Allée, Québec 4, P.Q.vs J.MARCEL ROY, domicilié à 53, Duchâtel, Beauport, Québec, P.Q., et LE REGISTRA-TEUR du bureau de la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.'- 1.Le lot numéro soixante-huit des subdivisions du lot originaire numéro mille cent soixante-huit (1168-68) du cadastre officiel de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec; 2.La redivision un des subdivisions du lot numéro seize des subdivisions du lot originaire numéro mille cent soixante-sept (1167-16-1) du cadastre susdit.Le tout avec la maison à un (1) seul logement dessus construite, et autres bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Le mur nord-est de la maison érigée sur les susdits lots est mitoyen avec le mur sud-ouest de la maison érigée sur les lots 1167-16-2 et 1167-17-1 du même cadastre, et ce, par destination du père de famille.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, P.Q., le SEPTIÈME jour de MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif J.-Roland Renault.Québec, le 27 jamvier 1975.59857-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: [TA LAURENTIENNE, Superior Court, ) *-> COMPAGNIE MU-No.200-05-003597-742.S TUELLE D'ASSURANCE, \\ a corporation legally incorporated, having its head office at 500 Grande-Allée East, Québec 4, P.Q., vs J.MARCEL ROY, domiciled at 53 Duchâtel, Beauport, Québec, P.Q., and THE REGISTRAR for the Québec Registration Division Office, mis en cause.\"1.Lot number sixty-eight of the subdivisions of original lot number one thousand one hundred sixty-eight (1168-68) on the official cadastre for Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Québec Registration Division; 2.Redivision one of subdivisions of lot sixteen of the subdivisions of original lot number one thousand one hundred sixty-seven (1167-16-1) on the aforesaid cadastre.The whole with a single dwelling house and other buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.The northeastern wall of the house erected on the aforesaid lots is common with the southwestern wall of the house erected on lots 1167-16-2 and 1167-17-1 of same cadastre, the foregoing by destination set up by the previous owner.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 Saint-Pierre Street, Québec, P.Q., on the SEVENTH day of MARCH, 1975, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, January 27, 1975.59857 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1975, 107' année, n° 5 1309 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: (TA LAURENTIENNE, Cour Supérieure, ) *-> COMPAGNIE MU-No 200-05-003598-740.) TUELLE D'ASSURANCE, ( corporation légalement constituée, ayant son siège social à 500 est, Grande-Allée, Québec 4, P.Q., vs J.MARCEL ROY, domicilié à 53, Duchatel, Beauport, Québec, P.Q.et LE REGISTRA-TEUR au bureau de la division d'enregistrement de Québec mis en cause.« 1.La redivision deux de la subdivision seize du lot originaire numéro mille cent soixante-sept (1167-16-2) du cadastre officiel pour la paroisse de St-Ambroise de la Jeune-Lorette, Quartier Neufchâtel, division d'enregistrement de Québec; 2.La redivision un de la subdivision dix-sept du lot originaire numéro mille cent soixante-sept (1167-17-1) du même cadastre susdit.Le tout avec la maison à un (1) seul logement dessus construite, rue Rigaud, et autres bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Le mur sud-ouest de la maison érigée sur les susdits lots est mitoyen avec le mur nord-est de la maison érigée sur les lots 1168-68 et 1167-16-1, et ce, par destination du père de famille.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, P.Q.le SEPTIÈME jour de MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 27 janvier 1975.59856-0 RICHELIEU Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal C COMPAGNIE MIRON LIMI-No 05-010-342-72.< v-
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.