Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 1 (no 22)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1974-06-01, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" GAZETTE QUÉBEC £ OFFICIELLE OFFICIAL -DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES PART 1 JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° 22 4055 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des a vis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, do The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once, In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon ; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 4056 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, 815 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20.from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dcbé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings.Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4057 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou pius; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed A.M.A.CORPORATION OF CANADA.25742 ABSAM MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).27753 AGENCE MARITIME INC.21034 ALBEE FRUIT EXCHANGE INC.29025 ALBERTA PETROLEUM LIMITED.153729 ALKAY INVESTMENTS LTD.28464 ALMA SERVICE STATION LTD.27754 ALOUETTE REALTY LTD.42054 AMCA PHARMACEUTICALS LTD.28491 AMEUBLEMENT JEAN TALON FURNITURE INC.28718 L'AQUEDUC STE-DOROTHEE LIMITEE.28757 ARCO ELECTRIC INC.28643 AREA MOTORS LTD.21013 ARGUS DEVELOPMENT CORPORATION.25616 L'ASSOCIATION DES COTOYENS DE BORDEAUX INC.27622 ASSOCIATION D'HABITATION STE-FOY .28049 L'ASSOCIATION DES HOMMES D'AFFAIRES DU QUARTIER FRONTENAC INC.27808 Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Québec.1973 Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1932 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.St-Joseph-d'Alma.1953,1955 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1954, 1956 à/to 1973 incl.Ville Lemoyne.1956 à/to 1973 mol.Montreal.1971 et/and 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Québec.1956 à/to 1973 incl.Montréal.1956 à/to 1973 incl. 4058 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.W___ Nom de la compagnie Name of the company L'ASSOCIATION DES MARCHANDS PLACE HOTEL DE VILLE.27704 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE RIMOUSKI INCORPOREE.28720 ASSOCIATION DES RESIDENTS DU QUARTIER « PARC DEAMOND ».27866 ASSOCIATION DE SKI NAUTIQUE DE MONTREAL .27438 L'ASSOCIATION DE L'UNION NATIONALE DE MAISON-NEUVE INCORPOREE.27463 ASTRAKA (CANADA) LIMITED.28240 LES ATELIERS LAURENTIENS LTEE.27920 LES ATELIERS NAUD & FRERES, LIMITEE.28385 THE AYLMER AND SOUTH HULL HUMANE SOCIETY.27724 BEACON ENTERPRISES LTD.28722 BEAULIEU & FILS AUTOMOBILE LIMITEE.28794 BECK-KERTIS DESIGNS INC.25835 BEL AIR CLOTHING INC.27491 BELLEVUE TELEVISION SALES CORPORATION.25836 G.E.BELLIVEAU LTEE.27508 BENJAMIN G.CHURCH LTD.28367 BERGEVIN INCORPOREE.20726 BERKE'S SNACK BAR LTD.28854 BEST GRADE LUMBER & PLYWOOD CO.LTD.28069 BIJOUTERIE COMET INC.28796 NOEL BLANCHETTE LIMITEE.20691 BOREAL CONSTRUCTION CO.27821 BOULEVARD CYCLE CO.LTD.25743 BRISEBOIS PLOMBERIE INC.28952 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Québec.1953.1956.1958 à/to 1973 incl.Rimouski.1959 à/to 1973 incl.Québec.1953, 1956 à/to 1973 incl.Montréal.1953.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1953, 1955 à/to 1973incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montréal.1953, 1960 à/to 1973 incl.St-Félicien.1955 à/to 1973 incl.Aylmer.1954, 1955, 1957 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Québec.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Laurierville.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Ste-Rose.1953, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Montréal.1970, 1973 Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1956, i960 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1970 incl.1972 Malartic.1970 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1965 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106- année, n° SZ 4059 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed JOS.BRODRIQUE & FILS LIMITEE.20119 BROMPTON COPPER CORPORATION LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).25697 BRUCK MILLS RECREATION CLUB.20192 BRUGGI THEATRICAL SHOES INC.29119 BUCKINGHAM HUMANE SOCIETY.20230 Québec.Sherbrooke .BUFFET BON GOUT LTEE.27870 BURROWES ALUMINUM WINDOWS (QUEBEC) LIMITED.27570 Cowans ville.Montreal.Buckingham.Montréal.Montreal.C.H.G.B.LTEE 20331 CANADIAN COAT & APRON SUPPLY LTD.20650 CANADIAN COMMODITY EXCHANGE INC.20657 CANADIAN FENTS LIMITED .27630 CANADIAN RULER, LIMITED.28856 CANADIAN VELOUTEX COMPANY LIMITED .28797 CANIMPEX CO.LTD.28496 CAPE CITADEL CONSTRUCTION INC.27499 CASA BIANCA INC.25790 CENTAUR ELECTRIC CONTRACTORS LTD.27571 CENTRE DE TELEVISION LTEE.25625 CHAJET BRISTLES LIMITED.25933 CHAMPEAU FRERES LTEE.29184 CHAMPLAIN TEXTILES LTD.29185 CHAMPS D'OR RIGAUD VAUDREUIL LIMITEE.153730 CHARLIE'S NEWS STAND INC.27631 Ste-Anne-de-la-Poca-tière.CHECK ROOM SERVICE COMPANY LIMITED.26192 Montreal.Montreal.Montreal.Bedford.Montreal.Montreal.Québec.Montréal.Montreal.Montréal.Montreal.Montréal.Montreal.Montréal.Sept-Iles.Montreal.1967.1968, 1971 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1971 et/and 1973 1957 à/to 1973 incl.1973 1956 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1949 à/to 1958 incl.1960 à/to 1962 incl.1964 à/to 1969 incl.1970 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1972 et/and 1973 1953 à/to 1955 incl.1958 à/to 1973 incl.1956 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1958 à/to 1973 incl.1955 à/to 1958 incl.1961 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1953, 1954, 1955, 1957 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1957 à/to 1973 incl.1960, 1961, 1964 à/to 1973 incl.1932 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl. 4060_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971, Vol.106, No.22 _ Nom de la compagnie Name of the company CHESTER INVESTMENTS LIMITED.28589 CHINCHILLA ST-FELICIEN LTEE.29079 CHISWICK INVESTMENTS LIMITED.25837 CITADEL REALTIES LIMITED.27689 LA CITE MODELE DE SHAWINIGAN INC.28381 CLUB DE BASEBALL ASBESTOS INCORPOREE.27486 CLUB DE BASEBALL DE VALLEYFIELD INCORPORE.27445 CLUB NAUTIQUE DU LAC ST-LQUIS .26194 CLUBS JUVENILES DE LA POLICE DE GRANBY INC.28728 LE COLISEE DE SOREL INC.27590 COLLEGIANA INC.27757 COMFORT SHOES INC.28497 LE COMITE DES LOISIRS DE STE-AURELIE.27992 COMITE DE VIE PAROISSIALE « ST-RODRIGUE ».27483 COMMISSARIAT DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME DE HULL INCORPORE 25630 LE COMPTOIR D'ASSURANCES LIMITEE.20974 P.X.COS8ETTE & FILS INC.27814 BERNARD COTE INC.28648 COWANSVILLE JUVENILE RECREATION CLUB.27634 W.H.CURRIE EXPRESS AND STORAGE LTD.27988 JEROME DESJARDINS LIMITEE.28196 DISTRIBUTION INTERPROVINCIALE DU LIVRE LTEE.84903 DODETTE FASHIONS INC.28735 DOMINION LOGGING & CONTRACTING LTD.21555 DONTA CORPORATION .28250 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Québec.1964 à/to 1973 incl.St-Félicien.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Shawinigan-sud.1954 à/to 1973 incl.Asbestos.1963 à/to 1973 incl.Valleyfield.1954 à/to 1973 incl.Ile-Perrot.1953 à/to 1973 incl.Granby.1956 à/to 1973 incl.Sorel.1965,1966,1972,1973 Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Ste-Aurélie.1954 à/to 1973 incl.Charlesbourg.1953 à/to 1973 incl.Hull.1953 à/to 1973 incl.Cap-de-la-Madeleine .1962, 1971 à/to 1973 incl.Amos.1955, 1957, 1959, 1961, 1965 Ville Lemoyne.1958 à/to 1973 incl.Cowansville.1957, 1959, 1961 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.°-uébec.1956 à/to 1960 incl.1963, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er juin 197L 106' année, n' 4061 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed DORE LINGERIE MFG.CO.INC.27635 DRUMMOND STAINLESS STEEL CO.LTD.28864 DUMAS * DUMAS LTEE.28863 EASTERN TOWNSHIPS VENDING CO.INC.27449 ELECTRICAL MOTOR SERVICE LTD.28866 EMOND & FORTIN INCORPOREE 28318 EMPIRE EQUIPMENT CO.25941 LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ET D'IMMEUBLE DE ROUVILLE LTEE.27593 Montréal.Drummondville.Montréal.Sherbrooke.Montreal.Ste-Foy.Montreal.Montréal.ENTREPRISES MONTCALM INC.34554 LES ENTREPRISES TETREAULT LTEE.56862 ETOILE DES MERS.INC.28118 LA FANFARE D'AMOS.27861 FAR EAST TRADING CO.LTD.28074 FLEURU8-AMERICA INC.26295 FOREST HOMES DEVELOPMENT CO.LTD 28961 FRANKEL HOME FURNITURE INC.29150 GAGNON & FILS LTEE.28189 G.GAGNON & FRERE FOURRURE LIMITEE.28809 GARAGE PAQUIN LTEE.27762 GASPE EXPLORERS LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).26023 GILL SECURITIES LIMITED 28743 GLAMOUR GARMENT MFG.CO.LTD.27969 GODARD 4 FRERE LTEE.27913 GRANBY DRYER FELT CO.LTD.28665 GRANBY FURNITURE MANUFACTURING INC.27640 Hull.St-Martin.Montréal.Amos.Montreal.Québec.Mont-Royal.Montreal.Ste-Thérèse.Montréal.Lennox ville.Montreal.Montreal.Montreal.Montréal.Granby.Granby.1966 à/to 1973 incl.1956 à/to 1973 incl.1954.1960 à/to 1973 incl.1956 à/to 1973 incl.1961 à/to 1973 incl.1957 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1953 à/to 1959 incl.1961 à/to 1973 incl.1968, 1971 à/to 1973 incl.1961 à/to 1973 incl.1954, 1955.1958 a/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1954 à/to 1958 incl.1960 à/to 1973 incl.1954 à/to 1957 incl.1963 à/to 1973 incl.1954, 1956, 1957, 1960 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1953, 1954, 1956 à/to 1973 incl.1953, 1958 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl. 4062 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st.1971, Vol.106, No.22__ Nom de la compagnie Name of the company LES HABITATIONS M.GENEST LTEE.128736 M AI il: I I.I.& BRUCE INC.27582 HANSA LLOYD COMPANY .26026 HARRINGTON MINING CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY).25706 HARTLEY-FLEURQUIN FLOORING COMPANY LIMITED.25946 HEBERT METALCRAFT CO.28745 HIGHWAY FURNITURE INC.27765 HILL MCNAIR CONSTRUCTION LTD.28667 HOTEL CENTRAL LIMITEE.4885 L'HOTEL DU LAC DES SEIZE ILES INC.28339 HOTEL ROGER LTEE.28259 I.G.O.FENTON CONSTRUCTION LTD.27642 ICELAND SALES 4 SERVICE LTD.29046 ROLAND IMBLEAU INC.28436 LES IMMEUBLES ARCO LTEE.28711 INSTITUT CANADIEN DE RADIESTHESIE.29084 INTERNATIONAL BOND AND SHARE OF QUEBEC LTD.28502 INTERPROVINCIAL RESEARCH 4 DEVELOPMENT CO.(CANADA) LTD.28379 ISLAND HOMES INC.28462 JACK'S CLOTHING STORE INC.28329 H.JASMIN LTEE LTD.25908 DAVID JASON LTD.27802 JET PLUMBING 4 HEATING CO.INC.28671 JEUNE COMMERCE DE JULIETTE INCORPOREE.28530 JEUNE COMMERCE DE MONTMAGNY.INC.28596 Montmagny.1955 à/to 1973 incl.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.L'Abord-à-Plouffe.1954, 1957 à/to 1973 incl.Lennoxville.1954 à/to 1973 incl.St-Martin.1954 à/to 1973 incl.Seize-Ile».1954 à/to 1956 incl.1959 à/to 1973 incl.Senneterre.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1957 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1953, i960 à/to 1973 incl.Montreal.1957 4/^ 1973 inci Miette.1959 à/to 1973 inc| GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° 82 4063 Nom de la compagnie Name of the company ROGER JODOIN INC.29172 JOLLY ROGER MOTORCYCLE CLUB-VERDUN.27586 A.JOLY INCORPOREE.9197 JONEK LTD.25752 O.KAHN'S HOTEL LTD.25800 J.ROBERT KAINE LIMITEE.28504 KENT TELEVISION & JEWELLERY CO.LTD.28753 KIWANIS CLUB OF ST.EUSTACHE-SUR-LE-LAC.28754 KLASSEY SHOE STORE INCORPORATED.9481 MARCEL LAÇASSE LIMITEE.28820 PAUL LACHAPELLE LIMITEE.28774 LAKE ACCESS ENTERPRISES LTD.27520 THE LAKEVIEW RESIDENTS' ASSOCIATION.27934 LAPIERRE AUTOMOBILES INC.29015 G.A.LAPOINTE.INC.26022 LARRY LTD.28467 LAURIER FINANCE INC.85358 LAVAL NEWS & CIGAR STORE, INC.25711 LAVOIE & TREMBLAY, LTEE.28335 LAWAND MANUFACTURING LIMITED.28507 YVON LEGRIS LIMITEE.29143 HERVE LEHOUX INC.68355 LESAGE AUTOMOBILE LIMITEE.28338 LIGUE DE HOCKEY DEPRESSION INC.28707 LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE DE SOREL INC.27460 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1953 à/to 1973 incl.Verdun.1953 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montreal.1953 à/to 1973 incl.Ste-Agathe-des-Monts.1953 à/to 1973 incl.Québec.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.St.Eustache-sur-le-Lac.1955, 1962 à/to 1973 incl.Montreal.1944, 1947, 1956, 1957, 1960 à/to 1973 incl.Montréal.1960 à/to 1973 incl.Montréal-Nord.1962 à/to 1973 incl.Dorval.1953, 1955 à/to 1973 incl.Lakeview.1953 à/to 1973 incl.Buckingham.1957 à/to 1973 incl.Montréal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Québec.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.St-Bruno.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1954, 1955, 1957 à/to 1973 incl.Montréal.1958 à/to 1973 incl.St-Tite.1967 à/to 1973 incl.Mont-Laurier.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1956, 1958 à/to 1973 incl.Sorel.1953 à/to 1973 incl. 4064 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22___ Nom de la compagnie Name of the company L'INDUSTRIEL VILLE MARIE LIMITEE.25759 LION STEEL EQUIPMENT LTD.25640 HANSA LLOYD COMPANY (NO PERSONAL LIABILITY).25706 LES LOISIRS DE ST-DAVID INC.29107 MARCHE SUPERIEUR INCORPOREE.28401 LES MARQUIS DE JONQUIERE INC.28598 LE MANOIR MERCIER.21201 LE MASKOUTAIN INC.28337 MERCURY SEWING MACHINE COMPANY LIMITED.25642 METIERS NADEAU LOOMS INC.29241 EUSTACHE MICHAUD INCORPORE.28806 INGRID MICHELE INC.27643 MID-TOWN PLUMBING & HEATING COMPANY LIMITED.25715 P.H.(BILL) MITCHELL INC.28692 MOCCA ESPRESSO CAFE BAR LTD.27885 MONCANA INCORPOREE.28767 MAURICE MONGEAU TIRE SALES LTD.28512 MOQUIN & VIDA INC.27662 MORGAN & BARIL INC.20C99 MARY MORGAN INC.28762 MORIGRAN HOSIERY MILLS LIMITED.28982 NATIONAL CARTON SPECIALTIES LTD.21719 NORTH AMERICAN ASBESTOS COMPANY LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).21309 NORTH STAR DEVELOPMENT CORPORATION.28600 Montreal.1954 à/to 1973 incl.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Ville Marie.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.St-David.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Jonquière.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1973 St-Hyacinthe.1962, 1963, 1966 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1957,1958, 1960 à/to 1973 incl.Montréal.1953, 1954, 1956 à/to 1958 incl.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Rosemont.1957 à/to 1961 incl.1964, 1966 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1958 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° 28 4065 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed NORTHEAST INTERNATIONAL OIL & DRILLING CO.INC.25716 NOUVEAU THEATRE LAURENTIEN INC.27887 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE ST-ETIENNE- DES-GRES 28090 OLYMPIC RESTAURANT INC.27601 ORELAND MINING CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY) 28266 MICHAEL PALANGIO LTD.27468 PAPER CUTTING & TRADING CO.LTD.25915 T.M.PARKER INC.25684 PARKWAY AMUSEMENTS LIMITED.27471 PEANUT VENDOR LTD.25801 PLOMBERIE & CHAUFFAGE FRIGON PLUMBING & HEATING INC.27716 POLY-CONSTRUCTION INC.27544 PRECISION C.INC.91995 LES PRODUITS ALIMENTAIRES EVERY DAY INC.27464 PRODUITS DE CIMENT DU LAC-ST-JEAN LTEE .21964 PRODUITS NAPS INC.27607 PROTECTION INC.6823 PROVINCE OF QUEBEC RACING ASSOCIATION, INC.6840 PROVINCIAL DISTRIBUTING COMPANY LIMITED.29133 QUALITY PLUMBING & HEATING LIMITED.28829 QUEBEC BOND & SHARE CORPORATION.28830 QUEBEC BOTTLED GAS INC.28396 QUEBEC NORTH MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) 28397 QUEBEC ORE & STEEL DEVELOPMENT CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY) 25802 Montreal.Saint-Lin.St-Etienne-des-Grès.Montreal.Montreal.Mount Royal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Thetford-Mines.Vallée-Jonction.Montréal.St-Jérôme.Baie-Comeau.Montréal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.St-Jérôme.St-Michel.Montreal.1953 à/to 1973 incl.1953, 1955 à/to 1973 incl.1955 à/to 1973 incl.1956 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1964, 1966 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1963 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1957 à/to 1973 incl.1955 à/to 1973 incl.1973 1953 à/to 1973 incl.1954 à/to 1962 incl.1970 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1951, 1971 à/to 1973 incl.1956 à/to 1973 incl.1954, 1956 à/to 1973 incl.1955 à/to 1973 incl.1955 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1956 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl. 4066 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.n___ Nom de la compagnie Name of the company RAINBOW FOOD PRODUCTS LIMITED.021639 RAWDON IRON AND TITANIUM INC.(NO PERSONAL LIABILITY) 28223 LE REFRIGERATEUR MODERNE LIMITEE.28679 REGAL TAXIS LIMITED.5930 LA REVUE MODERNE,INCORPOREE.6063 A.REYBURN LTD.29115 RIGAUD MOTOR SALES INC.27834 RIVIERA CONSTRUCTIONS INC.48603 ROBITAILLE SERVICE STATIONS LTD.28992 RORA INC.28995 ROULEAU REFRIGERATION et RADIO INC.28404 ROYER CONSTRUCTION, LTEE.27837 ST.RAYMOND SALES LIMITED.21937 SEASONAIRE SPORTSWEAR LTD.27931 SENACA HOLDINGS LTD.7294 SHELL CONSTRUCTION COMPANY.27611 SICO APPLIANCES LIMITED.25549 H.L, SINGER CO.28008 SOCIETE DES APPLICATIONS DU PLASTIQUE SODAP INC.115646 SOCIETE GENERALE DE FINANCE INC.8378 SOCIETE DE PUBLICATION METROPOLITAINE LIMITEE.26918 LES SPORTS FRONTENAC INC.27771 THE SPRINGVALE COMMUNITY ASSOCIATION.21468 SUPERIOR SPECIAL DELIVERY EXPRESS.28702 TELEFILM CO.29064 Montréal.1955 à/to 1973 incl.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1968.1971 à/to 1973 incl.Marieville.1955, 1956, 1957, 1960.1963 à/to 1973 incl.Levis.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Outremont.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Rigaud.1957 à/to 1973 incl.Repentigny.1959 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montréal.1954, 1955.1958 à/to 1973 incl.Sweetsburg.1954 à/to 1973 incl.St-Henri.1960, 1963 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Ville Lemoyne.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1970 et/and 1973 Montréal.1953 à/to 1973 incl.Québec.1953, 1956, 1958, 1961 à/to 1973 inc.Lachine.1962 à/to 1964 incl.1973 Montreal.1962 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 197L 106' année, n° 22 4067 Nom de la compagnie Name of the company Adresse AddreB8 Rapports non produits Returns not filed TRICAN PETRO-CHEMICAL CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY) 27847 TRIO CONSTRUCTION AND REALTIES LIMITED.25548 TWIN CITY BOAT COMPANY.29109 UNITED ENTERPRISES LTD.28788 UNIVERSAL LOAN & FINANCE CORP.27899 VALCARTIER INDUSTRIES LIMITED.28143 VALLEE MACHINE WORKS CO.LTD.25551 VINET ELECTRIC & CIE.29070 VOLDAR FUR COMPANY.29260 VOX POP INC.27482 WARWICK LUMBER MILL LIMITED.28704 WELIA CONTINENTAL MODES INC.28414 WICK BROTHERS INC.27556 WRIGHTVILLE BUILDING SUPPLIES CO.LTD.21867 Montreal.1955.1957, 1958, 1961 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Québec.1953, 1965 à/to 1973 incl.Québec.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Beauharnois.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1953, 1955 à/to 1973 incl.Warwick.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1955, 1959 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Hull.1971 à/to 1973 incl.57401-o Lo Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.Lettres patentes annulées vants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.57401-o Pierre Desjardins.Directors of the Companies Service.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazette of this second notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date A.B.C.ELECTRORAMA CO.LTD.63534 A.B.C.STENCIL MACHINE & AMEUBLEMENT DE BUREAU INC.58288 A.G.CONSTRUCTION LTEE.41192 A-l PRESS INC.50339 Montreal.Québec.Montréal.Montreal.21 11 1961 29 11 1960 11 09 1957 29 07 1959 -1068 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971, Vol.106, No.22 Nom de la compagnie Name of the company ABAiDEX MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).26069 ABITIBI GLASSHEAT INC.25:ii;s ABITIBI METALS MINES LTD.(LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE).23627 ACONIC MINING CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY).23630 ADDINGTON REALTY CORP.49720 ADRIENNE DRESS SHOP LTD.26006 AEROPORT BELAIR INC.88887 AGENCES CONSOLIDEES LTEE.61369 LES AGENCES MAURICE GILBERT INC.98593 AIRFIELD DEVELOPMENT COMPANY.25560 AIRVILLE GARDEN DEVELOPMENT INC.55S2fi ALFIN INVESTMENTS LTD.50749 AL-LEN WASTE CORP.25294 LES ALLIES DE LA BAIE, INC.23365 AMEUBLEMENT NATIONAL LTEE.92430 AMEUBLEMENTS DU QUEBEC INC.24726 LES AMUSEMENTS GILBERT INC.117601 APOLLO DISTRIBUTORS INC.116261 LES AQUEDUCS CODERRE, LIMITEE.27656 ARMOR CONSTRUCTION INC.81988 ARMURALINC.69262 STEVE ARTHUR REALTIES INC.77379 ART'S MEN'S WEAR LTD.24732 ASSOCIATED REAL ESTATE APPRAISERS INC.23510 L'ASSOCIATION CATHOLIQUE D'ETUDES BIBLIQUES AU CANADA .23518 Adresse Incorporation Addreêt Date Montreal.02 04 1952 Amos.29 05 1952 Val d'Or.12 07 1961 Montreal.01 02 1952 Montreal.20 04 1959 Montreal.07 10 1952 St-Jean-Chrysostome.23 11 1965 Montréal.14 08 1959 Laval.22 06 1967 Montreal.29 07 1952 Montreal.02 06 1960 Montreal.08 07 1959 Montreal.21 06 1952 Bagotville.13 06 1951 Montréal.04 07 1966 Montréal.14 02 1952 St-Georges.26 03 1970 Montreal.02 01 1970 Montréal.19 05 1963 Duvernay.30 10 1964 Montréal.27 12 1961 Montreal.25 02 1964 Montreal.14 02 1952 Westmount.29 06 1951 Montréal.03 07 1951 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 4069 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date L'ASSOCIATION DES CITOYENS DE LA PAROISSE DE SAINT-CONRAD.25101 L'ASSOCIATION DES DAMES AUXILIAIRES DE L'HOPITAL ST- JOSEPH DE ROSEMONT INC.25709 ASSOCIATION DES EPICIERS-LICENCIES DE SEPT-ILES INC.41193 ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE (A.G.E.U.S.).34655 ASSOCIATION DU PARC GOMIN INC.63021 ASSOCIATION DES PARENTS DE LA REGION YAMASKA.96500 ASSOCIATION PARENTS-MAITRES DE VERDUN INC.61910 L'ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE ST-JEAN- BAPTISTE.COMTE DE DRUMMOND.22766 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA PAROISSE DE STE- THERESE INCORPOREE.68106 ASSOCIATION DU QUEBEC POUR ENFANTS ARRIERES (DIVISION ST-JEROME.79522 ASSOCIATION RECREATIVE D'ANJOU INC.66160 ASSOCIATION SPORTIVE DU CAP-DE-LA-MADELEINE.24725 ASSOCIATION SPORTIVE DE PINCOURT ILE PERROT INC.23799 L'ASSOCIATION SPORTIVE DE ST-BRUNO DE (KAMOURASKA) INC.23483 L'ASSOCIATION DE LA SURVEILLANCE MUNICIPALE DES TROIS- RIVIERES INC.24893 ASSOCIATION DES TAVERNIERS DE LA CITE DE SHAWINIGAN FALLS ET DU DISTRICT INC.22649 LES ASSURANCES LORQUET INC.97793 LES ATHLETIQUES DE SOREL INC.65249 ATTA GIRL FROCKS LIMITED.22866 AU RENARD BLEU INC.23800 AUBERGE LE ROUET INC.115668 AUTO TRANSMISSION INCORPOREE.66501 St-Léonard-de-Port-Maurice.23 04 1952 Montréal.12 08 1952 Sept-Ues.Sherbrooke.Québec.St-Hyacinthe Verdun.St-Jean-Baptiste.Ste-Thérése-de-Blain-ville.12 09 1957 31 01 1956 29 09 1961 23 02 1967 21 08 1961 17 04 1951 28 08 1962 St-Jérôme.02 07 1964 Ville d'Anjou.Cap-de-la-Madeleine.Pincourt.St-Bruno.Trois-Rivières.» 26 06 1962 16 04 1952 .06 09 1951 .23 06 1951 .29 03 1952 Shawinigan-Falls.Montréal.St-Joseph-de-Sorel.Montreal.Montréal.Val David.Montréal.15 02 1951 15 05 1967 14 05 19C2 22 03 1961 07 09 1951 10 11 1969 03 05 1962 4070 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971, Vol.106, No.22__ Adresse Incorporation Address Date Montreal.03 11 1950 Montreal.06 03 1951 Montreal.30 06 1965 Montreal.25 11 1950 Montréal.25 06 1952 Ste-Rose-du-Dégelé- 30 09 1946 L'Ancienne-Lorette.19 10 1966 Montreal.27 06 1952 Montreal.14 06 1952 Duvernay.23 11 1964 Montréal.08 01 1968 Montreal.15 08 1912 Montreal.26 09 1952 Québec.18 06 1952 Montreal.14 02 1952 Montreal.23 06 1955 St-Laurent.02 10 1959 Québec.21 02 1946 Montréal.29 02 1952 Montréal.06 02 1952 Montréal.26 07 1951 Pierrefonds.24 02 1971 Québec.29 03 1941 Montréal.23 05 1951 Asbestos.01 03 1963 Nom de la compagnie Name of the company AUTO-COIN LAUNDRY INC.21993 AUTOMATIC HEAT WATER & POWER CO.LTD.22811 LES BALLETS METROPOLITAINS DU CANADA.86275 THE BANKERS' BUILDING LIMITED.22112 BARBIERI & DESAUTELS LIMITEE.25431 J.P.BEAULIEU LTEE.4681 ARMAND BEAUMONT INC.93862 BEAUMUR (CANADA) LIMITED.25461 BELAIR WIRE PRODUCTS INC.25456 BELANGER & FRERES, INC.82192 MARCEL BELISLE INC.101885 BELLERIVE GARAGE & AUTO COMPANY LIMITED.152410 BELVEDERE COPPER CORPORATION LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).25926 BERUBE & DUGAL INC.25386 BLUE VALLEY CORP'N.24739 BLUENOSE CORPORATION.33225 AIME BOILEAU INC.52424 BOIS CONTREPLAQUES DE QUEBEC, INC.19748 J.N.BOLDUC, LIMITEE.24829 O.BOLDUC INC.24776 BONNIE BELLE INC.23671 ERIC BRANT REALTIES INC.123983 C.BROWN COMPANY.20169 C.W.CORPORATION.23204 CADETS ET MAJORETTES NOTRE-DAME D'ASBESTOS INC.71469 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, 71° 22 4071 Nom de la compagnie Name of the company CAFE CAN CAN INC.20361 CAMERON COPPER MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).24742 CAMP DOM BOSCO INC.78324 M.J.CAMPBELL & CO.LTD.26043 CANADIAN BERGOM CO.LIMITED.25515 CANAVA AMERICAN WATCH FACTORY LTD.25487 CARDIN CONSTRUCTION LIMITED.26523 CARLETON CANDY CORPORATION.24547 CARNAVAL KIWANIS SAGUENAY.76056 CARPET SERVICE ENTERPRISES INC.71469 CARTIER MORTGAGE AND REALTY LTD.78328 CARTIER VILLE EXPRESS LTEE.25932 CENTENNIAL RENOVATORS LTD.96590 CENTRALE OBTEJISTE DE SOREL INC.24540 LE CENTRE D'AMUSEMENTS DE BASSIN, INC.67065 LE CENTRE GEORGES VEZINA INC.85876 LE CENTRE PAROISSIAL DES LOISIRS DE L'EPIPHANIE INC.71474 CENTRE RECREATIF DE MATAPEDIA INC.59768 CENTRE SOCIAL OUVRIER DE VILLE JACQUES-CARTIER (CSOVJC).24517 CENTRE SOCIAL DE ST-TITE-DES-CAPS INC.54223 LE CENTRE SPORTIF DE STE-THERESE INC.25140 LE CERCLE DE CROQUET DE WARWICK.24873 CERCLE SOCIAL ET RECREATIF DE LACHINE.22653 CERCLE SPORTIF DE VAN BRUYSSELS INC.23495 E.H.CERNY CO.LTD.23649 Adresse Incorporation Address Date Montréal.02 09 1949 Montreal.13 02 1952 Salaberry-de-Valleyfield.05 05 1964 Montreal.03 10 1952 Montreal.09 07 1952 Québec.23 06 1952 Val d'Or.18 12 1952 Châteauguay.14 01 1952 Jonquière.30 12 1963 Montreal.15 03 1963 Montreal.28 04 1964 Montréal.22 09 1952 Montreal.08 03 1967 Sorel.08 03 1952 Iles-de-la-Madeleine____ 11 06 1962 Chicoutimi.02 06 1965 L'Epiphanie.22 03 1963 Matapédia.25 05 1961 Jacques-Cartier.29 02 1952 St-Tite-des-Caps.17 12 1959 SU-Thérèse-de-BlainviUe 25 04 1952 Warwick.28 04 1952 Lachine.14 02 1951 VanBruyssels.05 11 1952 Montreal.10 08 1951 4072 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106.No.22__ Adresse Incorporation Address Date St-Georges.07 11 1968 Montreal.12 09 1952 Chambly.06 11 1969 Montmorency.03 05 1952 Laval.20 04 1966 Omerville.25 03 1970 Montreal.30 11 1950 Cherry-River.21 04 1961 Boucherville.13 04 1961 Lachine.24 02 1954 St-Jean-Port-Joli.21 06 1951 Québec.12 02 1952 Duvemay.13 12 1963 Grand'Mère.05 04 1952 VictoriaviUe.30 07 1952 Montréal.04 12 1960 Verdun.21 02 1952 St-Hilaire.24 04 1952 Lejeune.16 06 1952 Montreal.12 02 1952 St-Jovite.06 07 1951 Pierrefonds.11 01 1968 Magog.19 04 1968 St-Simon-les-mines.25 01 1961 Ste-Adèle.28 01 1969 Nom de la compagnie Name of the company LES CHAINES BOILARD LTEE.107632 CHALKBOARD SALES 4 RESURFACING LTD.25934 CHAMBLY IRVING INC.114516 LA CHAMBRE DE COMMERCE DES JEUNES DE MONTMORENCY.25247 CHATELAINES DE LAVAL.90534 CHAUSSURES KARYNE LTEE.117518 CHAVIGNY MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).22061 CHERRY RIVER HUNTING CLUB INC.125717 CHEZ LOULOU INC.60262 CHEZ MAURICE LIMITEE.29721 CHOUINARD INC.23458 LA CIE D'EMBOUTEILLAGE LAURENTIENNE LTEE.24743 CIE W.H.TRANSPORT LTEE.75773 CINE-CLUB DE GRAND'MERE INC.24676 LA CINEMATHEQUE DES BOIS-FRANCS.25405 P.M.CINQ-MARS INC.22093 CIRCLE AMUSEMENTS LTD.24746 CITIZENS' ASSOCIATION OF OTTERBURN PARK.24875 CLEAR BROOK MILL LTD.25463 CLEMENT REALTIES INC.24747 O.CLOT GRAPHITE MINES CO.LTD.23563 CLOVERDALE SERVICE CENTRE INC.101902 CLUB DES AIDES MOBILE8 MAGOG-ORFORD.102623 CLUB DES AUTOMOBILES DE LA PAROISSE DE ST-SIMON-LES- MINES, COMTE DE BEAUCE.22201 CLUB AUTO-NEIGE LOU-GAROU.108152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 197L 106' année, n° SS 4073 Nom de la compagnie Name of the company CLUB AUTO-NEIGE VILLE-MARIE.120217 CLUB DE BASEBALL ST-EUSTACHE LTEE.24551 CLUB LES DISPONIBLES DE SHERBROOKE INC.100456 CLUB FINA INC.125137 CLUB DE GOLF BEL-AIR (68) INC.105237 CLUB MONTCALM DE JULIETTE.26056 THE CLUB NAUTIQUE KANASUTA BOAT CLUB INC.21838 CLUB OPTIMISTE DE VILLE DES LAURENTIDES.134747 CLUB RECREATIF DE ST-CYPRIEN INC.92140 LE CLUB DE SKI MONT GIVRE INC.25045 CLUB DE SKI MONT-ORFORD-MAGOG.31337 CLUB SPORTIF DES TROIS VILLAGES.103094 CLUB ST-URBAIN.131849 CLUB DE YACHT LE CHENAL INC.96044 COLONIAL CONSTRUCTION LIMITED.24811 COLUMBIA SERVICES LTD.17074 COMITE DES CITOYENS DE NOTRE-DAME-DE-FATIMA.24525 LE COMITE DES CHEMINS D'HIVER DU LAC SORCIER.22896 COMITE DES LOISIRS DE BRIGHAM INC.89773 COMITE SECURITE LANAUDIERE.85780 LE COMITE DES SPORTS D'HIVER DE WARWICK INC.71029 COMMONWEALTH EXPLORATION LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).25302 COMMONWEALTH TRADERS LTD.24881 COMMONWEALTH TRADING CO.LTD.17193 COMPACT AGENCY (ANJOU) INC.114067 Adresse Incorporation Addreee Date Saint-Joseph-de-la-Poin- 10 09 1970 te-de-Lévy.St-Eustache.31 01 1952 Sherbrooke.11 10 1967 St-Michel-des-Saints____ 27 04 1959 St-Augustin.19 06 1968 Joliette.18 11 1952 Rouyn.07 11 1950 Laurentides.11 01 1972 St-Cyprien.18 07 1966 Amqui.08 04 1952 Magog.19 10 1954 Beebe-Plain.20 02 1968 Québec.18 02 1952 Repentigny.30 01 1967 Montreal.28 02 1952 Montreal.11 11 1949 Ville-de-Jacques-Cartier.17 09 1951 Grand'Mère.19 03 1961 East-Farnham.17 01 1966 Joliette.20 07 1965 Warwick.19 04 1963 Montreal.16 06 1952 Montreal.18 03 1962 Montreal.21 08 1939 Montreal.09 10 1969 4074 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.June 1st.1971.Vol.106.No.22___ Adresse Incorporation Addreês Date Montreal.02 02 1970 Montreal.09 10 1969 Montreal.09 10 1969 Québec.07 06 1952 Jacques-Cartier.09 05 1961 Montreal.01 02 1963 Chicoutimi.20 07 1965 Cap-aux-Meules.15 11 1967 Ste-Adèle.14 09 1964 Montreal.11 12 1950 Rosemont.10 11 1959 Montreal.07 05 1952 Montreal.23 07 1963 Montreal.21 06 1961 Richmond.13 02 1951 N.D.-du-Sacré-Coeur.23 10 1963 Greenfield-Park.10 01 1963 Montréal.19 11 1956 Montreal.07 04 1972 Montréal.18 04 1951 Drummondville.14 05 1952 St-Hubert.15 02 1967 Montreal.11 OS 1917 Montréal.27 01 1953 Nom de la compagnie Name of the company COMPACT AGENCY (LARIVIERE) INC.117045 COMPACT AGENCY (ST-MICHEL) INC.114069 COMPACT AGENCY (ST-VINCENT-DE-PAUL) INC.114188 LA COMPAGNIE DE HACHES «INTERNATIONAL\" LTEE.25318 LES COMPAGNONS DE CARJAC.59513 CONICO MINING AND DEVELOPMENT CO.LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).70913 CONSEIL DES ASSOCIATIONS PARENTS-MAITRES DE LA CITE DE CHICOUTIMI.85778 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DES ILES-DE- LA-MADELEINE INC.100922 CONSEIL D'EXPANSION DES LAURENTIDES.8090G CONSOLIDATED TOWER COMPANY LIMITED.22208 CONSTANEL DEVELOPMENT CO.LTD.22002 CONTINENTAL STEEL COMPANY LIMITED.25233 CONTUK AGENCIES LIMITED.73431 CORONATION SOCIAL CLUB INCORPORATED.23460 LA CORPORATION DES MAITRES HORLOGERS-BIJOUTIERS DU QUEBEC.22935 CORPS MAJORETTES NOTRE-DAME-DU-SACRE-COEUR.74985 COSMOS INVESTMENT CORP.70568 CHARLES COTE INC.38192 COYNE CANADIAN ENTERPRISES LTD.136815 CREDIT LINCOLN INC.23092 CREMERIE DRUMMONDVILLE LIMITEE.25234 CROYDON TRANSPORT LTEE.96608 CUSSON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.107723 DFTL.INC.26755 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° 22 4075 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date YVON DAIGLE ASSURANCES LTEE.80657 MAURICE DAOUST INC.68312 T.DE GRUCHY LTEE.25124 DEGUIRE AVENUE LTD.24692 ROGER DENIS & FILS.LTEE.23813 DEPOSITORS MORTGAGE CORPORATION.55253 JOHN DER ASSOCIATES LTD.135508 DESMELOIZES MINING CORPORATION, LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).25437 PAUL DESORMEAU LIMITEE.25263 YVON DESPATIE INC.76795 LES DEVELOPPEMENTS BRICARD INC.80772 DEWAGA RIFLE CLUB INC.23277 DOLLAR UP SALES LTD.26018 DORSO LIGHTER COMPANY LIMITED .23386 J.A.DOUCET LIMITEE.21951 DRUMMOND PARK COMMUNITY ASSOCIATION.42180 DRUMMOND SWIMMERS PARENTS ASSOCIATION 25150 DRUMMOND-PEEL MERCANTILE INC.23534 R.DUBE INC.25120 DUBREUIL INC.23209 DUDE AUTOMOBILE INC.88412 THE DUKE OF YORK'S ROYAL CANADIAN HUSSARS RIDING ASSOCIATION.14770 EASTERN TOWNSHIP HOTEL & RESORT DEVELOPMENTS LTD.66346 Ste-Thérèse.Beauharnois.Laprairie.Montreal.Montréal.Montreal.Rosemère.Rouyn.Montréal.Terrebonne.Montréal.Montreal.Montreal.Montreal.St-Jacques-des-Piles.Beaconsneld.Montreal.Montreal.Montréal.Montréal.St-Jean.Montreal.EAU DE JAVEL LA VOIE INC.40530 Sweetsburg.Rimouski.17 08 1964 24 08 1962 03 04 1952 11 02 1952 06 09 1951 04 05 1960 20 03 1972 03 07 1952 03 05 1952 27 01 1964 26 08 1964 11 06 1951 08 10 1952 09 06 1951 30 10 1950 14 01 1958 30 04 1952 04 07 1951 02 04 1952 09 05 1951 01 10 1965 26 02 1935 04 05 1962 18 06 1957 4076 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.June Itt, 1974, Vol.106, No.« Nom de la compagnie Adresse Incorporation Marne of the company Addrett Date EDIFICE SHERBROOKE INC.110339 ELECTRONIQUE B.M.G.INC.119595 ELFIN TOGS LIMITED.25438 ELITE HOMES INC.67903 ROGER ENAULT LTEE.112159 LES ENTREPRISES D'ABITIBI LTEE.57457 LES ENTREPRISES AUCLAIR 4 LALIBERTE INC.136912 ENTREPRISES DOUVILLE LTEE.30369 LES ENTREPRISES GAGNE-POUPART INC.139948 LES ENTREPRISES LUCIEN MAILHOT INC.115171 LES ENTREPRISES TERBALD INC.121491 LES ENTREPRISES DE TUILES, MARBRE ET TERRAZZO INC.118160 EVBEC LTD.81021 EXPOSITION COMMERCIALE DE VERDUN INC.23699 LA FEDERATION CANADIENNE-FRANÇAISE DES ANCIENS ELEVES DE LA COMPAGNIE DE JESUS INC.70439 FEDERATION DES TAVERNES ET DES BRASSERIES DU QUEBEC INC.131780 FERME ST-FRANÇOIS INCORPOREE.22658 FERRONNERIE BELMONT LIMITEE.24817 W.A.FISHBOURNE INC.26499 FLEMMING INC.103173 FLORISTS ASSOCIATES INC.23461 FLY-MASTER CORPORATION OF CANADA.26237 FOURWINDS APARTMENTS INC.26148 F RAG PUBLICATIONS INC.95382 Sherbrooke.U 04 1969 Montréal.16 07 1970 Montreal.05 06 1952 Montreal.07 08 1962 Jacques-Cartier.26 06 1969 Macamic.30 09 1960 Laval.06 06 1972 Ville Jacques-Cartier.11 05 1954 St-Léonard.26 09 1972 Granby.10 11 1969 Longueuil.28 10 1970 Laval.20 04 1970 Montreal.17 09 1964 Verdun.17 10 1951 Montréal.15 01 1963 Montréal.02 11 1971 St-François-de-Sales- 16 02 1951 Sherbrooke.18 03 1962 Montreal.25 06 1952 Montreal.12 03 1968 Montreal.20 06 1951 Montreal.27 06 1952 Montreal.28 04 1952 Montreal.13 j2 1966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° 4077 Nom de la compagnie Same of the company Adresse .'1 rl/lrrss Incorporation Date FREEMAN-GOODRIDGE LTD.23807 FREIGHT-LIFT INC.24.XS3 G 4 C REALTY LTD .79448 PAUL GAGNON INC.62188 GARAGE GENDRON (PORT-CARTIER) LTEE.61979 GARAGE RIVE SUD LTEE 61980 GARIEPY 4 GRENIER INC.118803 THE GEM MOTEL LTD.127531 GENERAL SPORTSWEAR 4 RAINWEAR COMPANY.24698 GENEREUX MOTOR LIMITED.24699 GEVRY AUTOMOBILE INCORPOREE.23462 GIANT CHIBOUGAMAU MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) 25239 GLOBEX LTEE.227267 GOUIN CLEANERS INC.96458 GOULD BROS LTD.7808 GRANBY ELECTRICAL WINDING LIMITED.25945 GRAYHOUSE REALTIES INC.25241 GROVEDALE CONSTRUCTION AND REALTY CO.LTD.22067 GYPSY CAFE LIMITED 23921 H.S.CONSTRUCTION CO.23089 HABITACH INC.116186 LES HABITATIONS DE LA RIVE SUD LTEE.77233 HAMPSTEAD RECREATIONAL ASSOCIATION.22851 HARRINGTON HARBOUR SPORTS INC.109597 HELLENIC SOCIAL DEVELOPMENT CORP.(MONTREAL) 120933 Montreal.Dorval.Montreal.Montreal.Port-Cartier.St-Rédempteur.Beauport.Montreal.Montreal.Montreal.Waterloo.Montreal.Québec.Montreal.Montreal.Granby.Montreal.Lai- bine.Montreal.Montreal.Montreal.Iii'in-In'n\"ilk- .Hampstead.Hauterive.07 09 1951 13 03 1952 17 06 1964 28 07 1961 27 07 1961 29 06 1961 15 06 1970 29 04 1971 11 02 1962 01 02 1952 04 07 1951 10 05 1952 18 02 1959 14 02 1967 13 12 1949 26 09 1952 14 05 1952 20 11 1950 17 10 1961 02 05 1951 11 11 1969 21 02 1964 11 05 1951 26 02 1969 16 09 1970 Montreal. 4078 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971, Vol.106, No.22 Nom de la compagnie Name of the company HENRY'S PRODUCTS LIMITED.25389 HOME SPECIALTIES INC.25158 HOT LINE FASHIONS COMPANY LIMITED.130190 HOTEL BEEBE INC.135149 HOTEL PRINTING CO.INC.81574 HOTEL SOULANGES INC.24756 HOTEL-DIEU DU SACRE-COEUR DE JESUS.25523 HUDSON CURLING CLUB INC.24977 IMMEUBLES AMBOUR INC.73377 LES IMMEUBLES BEMEX INC.23548 LES IMMEUBLES CINQUANTE-CINQUANTE LTEE.118825 LES IMMEUBLES JEANFANAUD INC.69314 INDUSTRIAL FREIGHTING LTD.41279 INDUSTRIAL PAINTING & FINISHING INC.5293 LES INDUSTRIES BEL-C LTEE.111286 LES INDUSTRIES FERCRAFT INC.23231 INFORMATIQUE S G F LTEE.120005 INTERNATIONAL COSMETICS CORPORATION.5475 ISLAND INDUSTRIES CORPORATION.23542 ISLE ST.JEAN HOLDING CO.52866 J.P.PLASTERING CO.LTD.24830 JABIL CREATIONS LTD.107672 JAKMAR SHOE MANUFACTURING INC.107520 ALEX JARJOUR INC.103995 KARCIL INVESTMENTS LTD.84407 Adresse Incorporation Address Date Montreal.08 04 1952 Montreal.28 04 1952 Montreal.02 09 1971 Beebe Plain.08 03 1972 Montreal.15 10 1964 Rivière-Beaudette.18 02 1952 Dolbeau.25 06 1952 Hudson.25 03 1952 Québec.16 07 1963 Montréal.11 07 1951 Montréal.18 06 1970 Ste-Foy.13 11 1962 Levis.18 09 1957 Montreal.04 12 1945 Granby.03 04 1969 Montreal.18 05 1951 Montréal.18 06 1970 Montreal.02 11 1946 Montreal.04 07 1951 Montreal.05 11 1959 Montreal.20 02 1952 Montreal.04 11 1968 Montreal.30 10 1968 Sherbrooke.30 04 1968 St-Léonard.18 03 1965 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n\" 22 4079 Nom de la compagnie Name of the company ALEX KAY REALTIES INC.96354 KEEN CARTAGE CO.LTD.22889 KENMAC CHIBOUGAMAU MINES LIMITED .(NO PERSONAL LIABILITY) 24831 KENT, POIRIER, RACINE INC.24704 L.P.AUTO SALES INC.70216 LABERGE RACING INC.137062 LABORATOIRE DORCHESTER LIMITEE.23465 LES LABORATOIRES SATELLITE LTEE.71271 LAC PARADIS LUMBER LTD.81793 L'AIGUILLON LTEE.67668 F.LAJOIE INC.128534 ROBERT LAJOIE INC.109465 OMER LALONDE CONSTRUCTION LTEE.66255 LANOUETTE & LANOUETTE LTEE .24762 LAURENTIAN TRAIL RIDERS ASSOCIATION .24963 LAURENTIDE CONFECTIONS LTD.25442 LAVAL DECORATIONS INC.89825 LAVAL PAPER BOX LTD.43417 CHARLOTTE LECLAIRE INC.113964 LEECOL HOLDINGS INC.88665 LEFF'S TELEVISION SALES & SERVICE LTD.25372 LEMAC CO.LTD.117422 E.H.LEMAY, LIMITED.16484 THE LEVIS WOOLLEN MILL LTD.24719 Adresse Incorporation Address Date Montreal.01 02 1967 Montreal.20 03 1961 Montreal.08 03 1952 Montréal.31 01 1952 Lemoyne.09 01 1963 Beauport.03 05 1972 St-Malachie.20 06 1951 Montréal.05 03 1963 Lac Paradis.19 10 1964 Montréal.26 07 1962 Sept-Iles.15 06 1971 Hull.27 02 1969 Rivière-Beaudette.10 04 1963 Sillery.11 02 1952 Ville St-Laurent.16 05 1952 Québec.17 06 1952 Laval.21 01 1966 Laval-des-Rapides.27 03 1958 Ste-Thérèse.01 10 1969 Ste-Adèle.09 11 1965 Montreal.22 04 1952 Verdun.11 03 1970 Montreal.13 03 1924 Levis.11 02 1952 4080 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Nom de la compagnie Name of the company LA LIGUE DE BASE-BALL LAURENTIDES INDEPENDANTE AMATEUR SENIOR 25165 LIGUE DES CITOYENS DU QUARTIER ST-MICHEL.75039 LIGUE DE FOOTBALL INTERMEDIAIRE DE L'EST INC.50931 LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE LA MUNICIPALITE DE ST-JEAN-EUDES INC.48058 LIGUE DES PROPRIETAIRES DE POINTE-AU-PIC INC.96660 LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE ST-FELIX-DU-CAP-ROUGE.81441 LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE ST-JEROME INCORPOREE .54022 LA LIGUE DES PROPRIETAIRES < ST-JOSEPH ».24836 LIGUE DES PROPRIETAIRES DE LA TERRASSE DUVERNAY.74698 LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE VICTORIAVILLE.22967 LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLE DE ST-TITE.25381 LIGUE TRIFLUVIENNE JUNIOR B.70325 LOGA CONSTRUCTION INC.133024 A.LOISELLE INC.24728 LES LOISIRS DU CHALET DES SPORTS DE THETFORD-MINES LTD.54485 LES LOISIRS DE COATICOOK INC.65811 LOISIRS DE NATASHQUAN INC.92404 LES LOISIRS ST-DENIS INC.24962 LES LOISIRS DE STE-FLORENCE INC.138626 LOISIRS ST-FRANÇOIS-XAVIER (CHICOUTIMI) INC.232249 LOU INDUSTRIES INC.102929 LOUP'S INC.22085 LOUVAIN INDUSTRIAL CENTRE INC.89594 MAC LANDE AGENCIES LTD.82966 Adresse Incorporation Address Date St> Jérôme.29 04 1962 Troia-Rivières.29 10 1963 Granby.12 08 1959 St-Jean-Eudes.20 03 1959 Pointe-au-Pic.20 02 1967 St-Félix-du-Cap-Rouge .07 10 1964 St-Jérôme.04 02 1960 St-Joseph-de-Sorel.29 02 1952 Trois-Rivières.08 10 1963 Victoriaville.28 05 1951 St-Tite.04 07 1952 Trois-Rivières.16 11 1962 Laval.20 12 1971 St-Timothée.19 02 1952 Thetford-Mines.29 02 1960 Coaticook.01 03 1962 Natashquan.30 06 1966 Montréal.08 05 1952 Ste-Florence.31 05 1972 Chicoutimi.14 08 1964 Lav«l.07 03 1968 Montreal.20 11 1950 MoI>tfeal.17 12 1965 Montreal.28 12 1964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° 22 4081 Nom de la compagnie Name of the company MACKAYVILLE SOCIAL CLUB.21840 MAÇONNERIE LAVAL INC.115614 THE MAINE LUMBER CORPORATION LTD.114696 LES MAJORETTES JACINTHES DE ST-LUC INC.135800 LA MANUFACTURE DE MEUBLES DE RIVIERE-DU-LOUP, INC.25166 MARCOUX TRANSPORT INC.84414 MARIETTE MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) .25458 MAR-ROSE CONSTRUCTION CO.48423 MATERIAL INDUSTRIES LTD.25255 MAURICE TABAH DE SOREL INC.116623 McGUIRE PRESS LIMITED.25445 MENUISERIE CHARLESBOURG INC.116877 MICHAEL SPORTSWEAR INC.25540 MITCHELL FOURRURES LTEE.24771 MODERN-AGE LIMITEE.24709 MONTREAL APPLIANCE SERVICE CORPORATION LTD.25257 MONTREAL JEWISH BAKERS ASSOCIATION INC.24711 MONTREAL (MTL) MECHANICAL PRECISION INC.43545 MONTREAL STAINED GLASS & ART WORKS LTD.88671 MONTREAL THERMO KING SALES & SERVICE INC.88004 MONZA INC.84167 L.MORELLO & SONS INC.23000 MORIN SECURITIES LTD.23551 MAURICE MURPHY AUTOMOBILE INC.23361 MURRAY CONSTRUCTION INC.106495 Adresse Incorporation Address Date Mackayville.07 11 1960 Laval.09 12 1969 Ste-Hélène.30 10 1969 St-Luc.28 12 1971 Rivière-du-Loup.30 04 1952 Berthierville.08 03 1965 Montreal.10 07 1952 Montreal.04 03 1959 Montreal.03 05 1952 Joliette.26 01 1970 Montreal.11 06 1962 Charlesbourg.16 02 1970 Montreal.17 07 1952 Montréal.22 02 1952 Québec.11 02 1952 Montreal.09 05 1952 Montreal.01 02 1952 Montreal.15 04 1958 Pierrefonds.16 11 1965 Repentigny.04 10 1965 Vimont.04 03 1966 Montreal.27 03 1951 Montreal.18 07 1951 St>Joseph-de-Sorel.25 04 1951 SepHles.13 09 1968 4082_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.June 1st, 1971, Vol.106, No.SS___ Nom de la compagnie Name of the company H.MURRAY INC.23874 N.B.L.HOLDINGS LTD.25542 NATIONAL PATTERN & WOOD WORKING COMPANY LIMITED.24773 NORANDA COPPER KINGS HOCKEY CLUB.22918 NORMAN DONUTS LTD.104092 NORMENTAL ATHLETIC ASSOCIATION INC.12326 NORTH BELLETERRE GOLD MINES LIMITED.(NO PERSONAL LIABILITY) 223305 NOUVEAUTES FRANÇAISES INCORPOREE.25176 NOVATEX LTD.24775 NU-DAY ENTERPRISES LTD.64537 O & B MANUFACTURING CO.78741 O.T.J.STE-ROSALIE.90592 L'OEUVRE DE L'ASSISTANCE AUX SOURDS-MUETS.16841 L'OEUVRE RECREATIVE DES JEUNES DE MARIA.25174 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE BIENVILLE INC.23337 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX ET LOISIRS DU LAC EDOUARD 79868 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE ST-BARNABE-SUD.22719 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX ET SERVICE DES LOISIRS DE LA PAROISSE ST-JOSEPH DE ST-HYACINTHE INCORPOREE 22718 ONYX-FOURNIER LTEE.108845 OTTERBURN SOFT BALL LEAGUE AND PLAYGROUND ASSOCIATION 18119 LOÏC PAGE LIMITEE.90045 PARE-BRISE QUEBEC, INC.116887 PARK ELECTRIC CO.LTD.108846 PARSONS & GORDON LTD.43000 Adresse Incorporation Address Date Québec.12 09 1951 Montreal.18 06 1952 St-Michel.21 02 1952 Noranda.21 05 1951 Montreal.09 05 1968 Normetal.26 10 1939 Montreal.03 08 1944 Québec.30 04 1952 Montreal.21 02 1962 Montreal.10 01 1962 St-Valentin.13 05 1964 Ste-Rosalie.04 03 1966 Québec.26 03 1946 Maria.02 05 1952 Lauzon.30 07 1951 Lac-Edouard.08 07 1964 St-Barnabé-Sud.09 04 1951 St-Joseph-de-St- 09 04 1951 Hyacinthe Montréal.06 12 1968 St-Hilaire.12 10 1948 Montréal.08 02 1966 Québec.13 02 1970 Montréal.21 01 1969 Montreal .l2 02 1958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° 22 4083 Nom de la compagnie Name of the company PERMANENT PLUMBING LTD.127996 LES PETROLES BURTON INC.64749 PHILLIPS SQUARE GARAGE LTD.6318 PINE LAKE DEVELOPMENT CORP.59657 LES PLACEMENTS DES ECORES INC.82996 LES PLACEMENTS MICHEL LTEE.102403 PLOMBERIE AVENUE LAURIER LTEE.23812 POINTE-AUX-FRANÇAIS LUMBER LIMITED.23946 POLYMAT INC.73043 PONTBRIAND TAXIMETER LTD.25982 PONTIAC INSURANCE AGENCY INC.23295 PRESTO CONNECTORS COMPANY LIMITED., 24778 PRINCE RESTAURANT LIMITED.25181 PRO-CHAR PRODUCTS INC.107934 LES PRODUCTIONS TELEAC INC.124525 LES PRODUITS CHAMPIGNY INC.73703 PROGRESSIVE AGENCIES & MAIL ORDER INC.23654 PROSPECTO EXPLORATIONS INC.(NO PERSONAL LIABILITY).99555 LES PUBLICATIONS LE FOU DE BASSAN LTEE.94197 PUBLICITE FRANÇAISE INC.24780 QUEBCO INC.124080 R.-B.TRANSPORTATION LTD.92002 LE RANCH DES SPORTIFS INC.73706 L.A.RAYMOND CONSTRUCTION LTEE.53377 THE RED SHOE SHOP LTD.128439 Adresse Incorporation Address Date Montreal.28 05 1971 Amqui.19 01 1962 Montreal.12 07 1926 Montreal.10 02 1961 Montréal.18 12 1964 Montréal.08 02 1968 Montreal.19 09 1951 Québec.10 10 1951 Québec.13 06 1963 Montreal.22 09 1952 Montreal.19 05 1951 Montreal.11 02 1952 Montreal.25 04 1952 Montreal.18 11 1968 Montréal.15 03 1971 Orsainville.23 07 1963 Montreal.03 07 1951 Montreal.24 07 1967 Montreal.27 10 1966 Montréal.21 02 1952 Val d'Or.19 02 1971 Drummondville.27 05 1966 Montreal.23 07 1963 Montreal.26 11 1959 Montreal.15 06 1971 4064 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971, Vol.106, No.22__ Nom de la compagnie Same of the company LE REFUGE DU SKIEUR.25057 REGAL KNITTING MILLS LTD.25984 RENAISSANCE INVESTMENT & LOAN CORPORATION.25985 RENE OPTICS (QUEBEC) LIMITED.132080 RENTAL SERVICE INC.26183 LES RESTAURANTS MARIE-CLAIRE INC.77166 RICHARD 5-10-15 LTEE.25184 RICHELIEU SECURITIES LIMITED.24716 ROLAND ROBITAILLE INC.102004 ROCK CORPORATION LTD.25268 ROYAL ELK LUMBER CO.LTD.25478 ROYAUX DE LAVAL INC.90986 RUBBER DUCKIE PRODUCTION INC.136518 ST.FRANCIS CURLING CLUB INC.22473 ST-HENRY-S MEAT & PROVISION MARKET INC.22111 ST.JOHNS RADIO CLUB.22641 ST-RAYMOND PROPERTIES LIMITED.21936 SABLIERE GREGOIRE INC.84197 SAINT-DENIS-MESSIER & ASSOCIES INC.94533 LES SAGUENEENS SENIOR INC.90355 ANDRE SAVOIE INC.115829 SCIERIE GUYENNE INC.96730 SECTION 44 (SHAWINIGAN FALLS) LEGION CANADIENNE (B.E.S.L.) INC.25382 SELECT HOMES LTD.59103 Montreal .16 01 1961 Adresse Incorporation Addrett Date Lauzon.10 06 1952 Montreal.19 09 1952 Montreal.22 09 1952 Montreal.20 10 1971 Montreal.25 04 1952 Lery.19 02 1964 Havre St-Pierre.26 04 1952 Montreal.01 02 1952 L'Ancienne-Lorette.17 01 1968 Montreal.02 05 1952 Roberval.26 06 1952 Laval.29 03 1966 Montreal.03 06 1972 Drummondville.03 03 1951 Montreal.24 11 1950 St-Jean.30 03 1951 Montreal.02 11 1950 Ste-Mélanie.10 03 1965 Montreal.12 09 1963 Chicoutimi.25 02 1966 Repentigny.11 12 1969 Guyenne.01 03 1967 Shawinigan Falls.03 07 1962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971,, 106' année, n° 22 4085 Nom de la compagnie A'ame of the company SERVICE DIRECTIONNEL DE TRANSPORT ET D'ESCORTE DE MONTREAL INC.134383 SERVICE DES LOISIRS DE ST-LOUIS-DE-GONZAGUE INC.25051 SERVICE DE PERCEPTION CAP-DIAMANT INC.103847 S.SIMARD CONSTRUCTION LTEE.24562 W.A.SNYDER LTD.22796 LA SOCIETE D'ADMINISTRATION DES PLANS DE BIEN-ETRE (METIERS GENERAUX) REGIONS DE MONTREAL 111623 LA SOCIETE D'ADMINISTRATION DES PLANS DE BIEN-ETRE 111678 LA SOCIETE CHIMIQUE VALCO LTEE.100511 LA SOCIETE DES FEMMES UNIVERSITAIRES DE MONTREAL.23696 SOCIETE DE GESTION DES HETRES LTEE.119904 SOCIETE INDUSTRIELLE ST-PASCAL INC.79503 SOCIETE DES INGENIEURS PROFESSIONNELS DE SOREL.24992 LA SOCIETE TAGEMA INC.82521 SOGELIN INC.86261 SOREL COMMUNITY CLUB.23136 SOUTH CHIBOUGAMAU MINING LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) 23619 STANDARD FUR COMPANY.22012 STETSON CLOTHING CO.8858 SUPREME INSURANCE AGENCIES LTD.25189 TABAGIE DU ROYAUME INC.134056 TABAH SHOES & HANDBAGS MANUFACTURING INC.116440 TAMARA MINING LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).40088 TAVERNE LA CHOPE INC.95847 TAVERNE DEMERS INC.77642 Adresse Incorporation Address Date St-Léonard.10 02 1972 Montréal.07 04 1952 Québec.23 04 1968 Ste-Julienne.29 01 1952 Montreal.02 03 1951 Montréal.03 06 1969 Montréal.03 06 1969 Québec.28 09 1967 Montreal.11 10 1951 Grand' Mère.16 07 1970 StvPaseal.18 06 1964 Sorel.21 05 1952 Montréal.09 12 1964 Dollard-des-Ormeaux.09 06 1965 Sorel.26 06 1951 Montreal.31 07 1951 Montreal.14 11 1950 Montreal.31 03 1934 Montreal.29 04 1952 Chicoutimi.18 01 1972 Joliette.21 01 1970 Montreal.01 05 1957 Québec.12 01 1967 Montréal.28 02 1964 4086 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971,, Vol.106, No.22___ Adresse Incorporation Address Date Montreal.14 07 1964 Montreal.10 02 1949 Montréal.23 05 1952 Montrael.16 07 1965 Montreal.19 05 1952 Montreal.28 10 1959 Montreal.18 02 1960 Montreal.08 06 1966 Mount Royal.07 06 1951 Québec.07 04 1952 Québec.27 11 1950 Montréal.12 07 1951 IlePerrot.04 09 1970 Montreal.06 04 1964 Montreal.14 05 1971 Ste-Thérèse-de-Blainville 28 05 1952 Anjou.25 10 1961 Montréal.23 04 1970 St-Antoine-des- 31 08 1966 Laurentides Verdun.21 06 1963 Verdun.10 05 1952 Verdun.19 12 1950 Montreal.21 06 1952 Montreal.24 07 1934 Cap-aux-Meules.19 02 1952 Nom de la compagnie Name of the company TERREBONNE GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD.80078 TEXTILE REMNANTS LTD.14237 THEATRE LUXOR LIMITEE.25362 THREE STAR HOLDINGS LTD.86877 TIMELY TOGS INC.25292 TOPSALL INC.52689 THE TRADITIONAL JAZZ CLUB OF MONTREAL INC.54349 TRANSCRANE INC.92243 TRANSOCEAN TRADING INC.23336 TRANSPORT ANDRE GREGOIRE LIMITEE.25052 TRANS-PROVINCIAL COMMUNICATION INC.22105 ADJUTOR TREMBLAY LTEE.23474 J.E.ARMAND TRUDEAU INC.120838 TURGEL FUR COMPANY LTD.78186 TURPIN CHEMICALS INC.127129 UNITED HOTELS LIMITED.26426 UPPER QUEBEC IRON CORPORATION.63720 VARIETES JACQUES & ROBERT INC.119008 VARIETES LAURENTIDES INC.93433 VERDUN MINOR SOCCER ASSOCIATION.72050 VERDUN RUGBY FOOTBALL CLUB.25272 THE VERDUN SAILING CLUB .22015 VICTOR CAFETERIA LTD.25465 VICTORIA SPORTING CLUB INC.15989 .VIGNEAU AUTOMOBILES LTD.24793 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° 22 4087 Nom de la compagnie Name of the company VIMONT SECURITIES LTD.24649 LE VIMONTAIS INC.79876 VIMY TRANSPORT LIMITEE.23562 J.A.VOYER & FILS LIMITEE.24767 W & SONS INVESTMENT CORP.110435 WOLFUS & ROMAN FUR MFG.INC.32025 L.YOUNG DRESSES INC.22086 ZION GARDENS CONVALESCENT HOSPITAL INC.87509 Le directeur du service des compagnies, 57401-o Pierre Desjardins.Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Nom des Compagnies Name of the Companies en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites compagnies.En conséquence, lesdites compagnies sont censées n'avoir jamais été dissoutes en vertu de ladite loi, sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.Le directeur du service des compagnies, 57401-o Pierre Desjardins.Adresse Incorporation Address Date Montreal.29 01 1952 Vimont.30 07 1964 SOMichel.06 07 1961 Ste-Marie.20 02 1952 Montreal.17 03 1969 Montreal.08 02 1955 Montreal.20 11 1950 Montreal.01 09 1965 Pierre Desjardins, 57401-o Director of the Companies Service.Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act.he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Dissolution Gazette officielle No Date Official Gazette No.12\t01\t74\t2 29\t12\t73\t52 06\t10\t73\t40 13\tin\t73\t41 13\t10\t73\t41 12\t01\t74\t2 12\t01\t71\t2 16\t02\t71\t7 10\t11\t73\t45 05\t05\t73\t18 17\t11\t73\t46 17\t11\t73\t40 pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said companies.Consequently, the said companies, are considered as having never been dissolved under the said Act, without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.Pierre Desjardins, 57401-o Director of the Companies Service.L'ASSOCIATION QUEBECOISE DES TECHNIQUES DE L'EAU.LES BOURGUIGNONS DE JOLIETTE INC.CLUB DE CHASSE ET PECHE DES POTVINISTES.CLUB MASKI.CLUB ST-FIRMIN.LE COMITE DES LOISIRS DE LABELLE.LA CORPORATION DOMICILIAIRE NOTRE-DAME DU FOYER INC.GEORGE KARAISKAKIS ROUMELIOTIAN SOCIETY OF MONTREAL HAROLD LI.ÎDWICK ASSOCIATES INC.LOUISEVILLE EXPRESS INC.MASHAL INTERNATIONAL AGENCIES LTD.PIERREFONDS WEST RESIDENTS' ASSOCIATION. KISS QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Lettres patentes (I™ partie)\tLetters Patent (Part 1) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act.he has granted letters patent incorporating: Nom / Name\tIncorporation Siège social / Head Office Date A.L.O.CONSTRUCTION LTD.CONSTRUCTION A.L.G.LTEE 1367-7869 A.R.DRY WALL INC.MUR SEC A.R.INC.1367-8768 AGENCE DE MANUFACTURIERS JEAN-LOUIS INC.JEAN-LOUIS MANUFACTURERS AGENCY INC.1367-8305 LES AMENAGEMENTS INDUSTRIELS DE FARNHAM LTEE 1367-9733 ANTIPOLLUTION GLOBE INC.GLOBE ANTIPOLLUTION INC.1367-9766 ASTAK INC.1356-0495 ATELIER DE DEBOSSELAGE REAL MARCOUX LIMITEE.REAL MARCOUX BODY SHOP LIMITED 1354-9282 ATLANTIC HOME IMPROVEMENTS INC.AMELIORATIONS DOMICILIAIRES ATLANTIQUE INC.1367-5673 AUTOMOBILES DU ROI INC.DU ROI AUTOMOBILES INC.1356-5536 L'AUXILIAIRE TECHNIQUE DU CANADA LTEE.1367-6622 MARCEL BEDARD & ASSOCIES LTEE.1355-7731 BLACK ROSE INVESTMENT INC.LES PLACEMENTS ROSE NOIRE INC.1367-9428 PHILIPPE BLANCHETTE INC.1356-1170 BOIS MEGANTIC INC.1367-8677 BOUTIQUE AVITAL IMPORT-EXPORT INC.BOUTIQUE IMPORT-EXPORT AVITAL INC.1367-4023 100 Montée Masson, Duvernay, Laval 11 04 74 2250, Guy Street, Room No.706.Montreal 22 04 74 8337 Place Chanceaux, Anjou.18 04 74 389, rue Principale Est, Farnham.25 04 74 Montréal.15 02 74 2840, rue Bouchard, app.601, Sainte- 24 04 74 Odile Sherbrooke.15 03 74 7881, boulevard Décarie, chambre 201, 29 03 74 Montréal 114.rue Du Roi, Asbestos.16 05 74 Montréal.04 04 74 Beauport.10 04 74 Montréal.25 04 74 Amos.26 04 74 8025, Léonard de Vinci, Montréal.22 04 74 1465 Drummond Street, Montreal.25 03 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° SS 4089 Nom / Name Incorporation Siège social / Head Office Date 436 Jean-Talon West, Montreal.25 04 74 1835 MonUtoyal Street East, Mont- 22 04 74 real 31 St.James Street West, Montreal.11 03 74 Boulevard Taschereau, Greenfield Park 30 04 74 Montréal.03 04 74 Montréal.05 04 74 Montreal.21 03 74 300 est, boulevard de la Concorde, 14 03 74 Laval.1420 Sherbrooke Street West.Suite 402, 23 04 74 Montreal.427, Radisson, Mont Saint-Hilaire- 25 03 74 Route Rurale No 1, Rock Forest.28 04 74 2350, rue St-Patrick, Montréal.10 04 74 Sainte-Adèle.05 03 74 Centre d'Achat Centreville, Longueuil 08 04 74 Montreal.03 05 74 13 Côte de Courville, Courville.16 04 74 1065 St.Lawrence Boulevard, Montreal 30 04 74 5717, Monkland Ave, Montréal.29 04 74 Place Vieille Capitale, local 402, 2815, 29 04 74 boulevard Laurier, Sainte-Foy.1424, Fullum, Montréal.28 04 74 2609, boulevard Versant-Nord, Sainte- 02 05 74 Foy.BOUTIQUE JOLIE NONI INC.JOLIE NONI BOUTIQUE INC.1367-4080 BOUTIQUE L'ECHELLE INC.1367-8685 BRAHORNE ENTERPRISES LIMITED.LES ENTREPRISES BRAHORNE LIMITEE 1367-1557 LA BRASSERIE DE LA GALANTERIE INC.1368-0012 LA BRASSERIE DES SPORTIFS DE LA RIVE SUD INC.THE PUB OF SPORTSMEN OF THE SOUTH SHORE INC.1355-5099 BRASSERIE SISPARIS (VILLE DU SOLEIL) INC.1367-6804 RONALD BROWN STEIN & ASSOCIATES INC.RONALD BROWNSTEIN & ASSOCIES INC.1367-3330 CENTRE CHIRURGICAL S.C.E.L.LTEE.1367-2183 CENTRE COMMERCIAL VENISE LTEE.1367-8941 CENTRE D'ACHAT MONT ST-HILAIRE INC.MONT ST-HILAIRE SHOPPING CENTRE INC.1367-4262 CENTRE DE TRAITEMENT ANTI-ROUILLE DE L'ESTRIE LTEE 1356-1204 CENTRE DU CAMION ST-PIERRE INC.ST-PIERRE TRUCK CENTER INC.1367-1474 CENTRE MEDICAL STE-ADELE INC.1354-3848 CENTREVILLE RESTAURANT INC.RESTAURANT CENTREVILLE INC.1367-7257 CENTURY INVESTMENTS LTD.LES PLACEMENTS SIECLE LTEE 1368-0814 CHAUFFAGE DE LA CAPITALE INC.1355-8341 LA CIE D'INVESTISSEMENTS WAH HING LTEE.WAH HING INVESTMENTS CO.LTD.1368-0210 CIMTEL (QUEBEC) INC.1367-9555 CLUB DE PECHE & DE CHASSE ST-PAUL (1974) INC.ST.PAULS FISHING & HUNTING CLUB (.1971) INC.1356-1212 COMBUSTIBLES LES AILES INC.1367-5186 LA COMPAGNIE DE FINANCE NORDIBEC LTEE.1356-2525 4090 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22_ Nom / Name CONSTRUCTION ASCOT LTEE.ASCOT CONSTRUCTION LTD.1367-9659 CONSTRUCTION F.T.B.INC.F.T.B.CONSTRUCTION INC.1366-0586 CONSTRUCTION L.MARTEL INC.1368-0301 CONSTRUCTION L.N.R.INC.1367-7794 CORPORATION DE PLACEMENTS HYPOTHECAIRES WESTGATE WESTGATE MORTGAGE CORPORATION 1367-9253 CREATIONS MARLO INC.MARLO CREATIONS INC.1368-0970 LES CUIRS DE KAMOURASKA INC.KAMOURASKA LEATHER GOODS INC.1356-2723 CUISINE TECNA INC.1367-9360 LES CUISINES LAURENTIDE (1974) INC.LAURENTIDE KITCHENS (1974) INC 1367-4486 CYTCO INVESTMENT CORPORATION.LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS CYTCO 1367-8727 K.M.DAVIS INC.1367-8198 DEPANNEUR JEAN MARCHAL INC.1367-1458 DIRECT FILTER SERVICE INC.SYSTEMES DE VENTILATION DIRECTE INC.1367-7505 LES DISQUES DU NOUVEAU MONDE INC.NEW WORLD RECORDS INC.1356-1733 DUSSIM INC.1354-7526 ECOSERV QUEBEC INC.1367-6267 ECRO INC.1367-1292 LES EDITIONS ET LES PRESSES D'ANJOU LTEE.1367-4213 ELITE BLEACHERY INC.BLANCHISSERIE ELITE INC.1368-0582 ELLIOT JEWELLERY INC.BIJOUTERIE ELLIOT INC.1367-7810 Incorporation Siège social / Head Office Date 8680 - 10th Avenue, Montreal.26 04 74 Sainte-Anne de Bellevue.25 04 74 Longueuil.07 02 74 Montréal.10 04 74 1999, Roland Therrien, Longueuil.24 04 74 5800 St.Denis Street, Montreal.05 03 74 Saint-Pascal.06 05 74 10014, St-Vital, Montréal-Nord.25 04 74 2520 boulevard Labelle, Chomedey, 26 03 74 Laval.5490 Royalmount Avenue, Mount 22 04 74 Royal 5605, Pinedale, Côte SaintvLuc.17 04 74 4366 est, rue Beaubien, Montréal.11 03 74 144 St.Peter Street, Montreal.19 03 74 Montréal.30 04 74 20, rue Genest, Saint-Romuald 14 03 74 d'Etchemin.1405, Iberville, Montréal.03 04 74 200, rue DeGaspé, app.1403, 15 03 74 Ile-des-Soeurs.8401 boulevard RayLawson, Anjou.25 03 74 6750, Esplanade, Montréal.02 05 74 4977 Queen Mary Road, Montreal 10 04 74 (Snowdon). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 197k, 100' année, n° 22 4091 Nom / Name LES ENCADREMENTS ROLLAND INC.ROLLAND PICTURE FRAMES INC.1367-9519 ENCHANBEC COMPANY LIMITED.SOCIETE ENCHANBEC LIMITEE 1355-7665 LES ENTREPRISES DOMINIQUE FORTIN INC.1355-8150 ENTREPRISES FERNAND GAGNON INC.1355-1361 LES ENTREPRISES GILLES VILLENEUVE INC.1367-8776 LES ENTREPRISES GILMO INC.1367-9295 LES ENTREPRISES J.A.L.INC.1368-0947 LES ENTREPRISES JEAN ET RAY INC.1355-4688 LES ENTREPRISES MENARIS INC.1367-2951 LES ENTREPRISES METRONIC INC.METRONIC ENTERPRISES INC.1367-9501 LES ENTREPRISES MICHEL BILODEAU INC.1367-9337 LES ENTREPRISES MOURAND INC.1367-9782 LES ENTREPRISES NORMAND THEROUX INC.1356-1760 ENTREPRISES ROBERTO INC.1367-1961 ENTREPRISES V.B.L.INC.1354-3582 EQUIPEMENT DE BUREAU DRANCY INC.DRANCY BUSINESS EQUIPMENT INC.1367H1007 EDDY FISET LTEE.1367-4114 LA FONDERIE OUELLET INC.1354-7690 FORTIN & FRECHETTE INC.1356-1329 GUY FOURNIER & ASSOCIES INC.1367-8834 WILLIE FOURNIER & ASS.INC.1367-7703 FURNITRAD INC.1367-8586 LES GALERIES LOUISEVILLE INC.1367-8644 Incorporation Siège social / Head Office Date 2350, Guy Street.Montreal.25 04 74 Cowansville.10 04 74 545, 1ère Avenue, Québec.11 04 74 101, de la Savane, Sainte-Anne-des- 20 03 74 Monts.730, Rivière Bayonne Sud, 22 04 74 18 rue St-Paul.Oka.24 04 74 1565 Est, rue Rachel, Suite 306, 10 04 74 Montréal.Thedford-Mines.02 04 74 Galerie des Laurentides, Saint-Antoine 19 03 74 6075, Albert Lozeau, Saint-Léonard.25 04 74 Cowansville.25 04 74 Route rurale 11, St-Faustin.01 04 74 Laprairie.10 05 74 1395 ouest, Maisonneuve, Montréal.18 03 74 100 Place Lemoyne, Longueuil.05 03 74 Montréal.25 03 74 Longueuil.25 03 74 Saint-Léonard d'Aston.13 03 74 12, rue Notre-Dame, Saint-Henri.30 04 74 Montréal.23 04 74 3244, rue Beaubien, Montréal.10 04 74 Saint-Hyacinthe.19 04 74 360, rue St-Jacques, bureau 1606, 19 04 74 Montréal. 4092 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971, Vol.106, No.22 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date GARAGE JEAN PAUL DUCLOS INC.1367-4163 GEMME.AUTO INC.1367-9527 GEOTEK INC.1355-3003 GESTION CONSOLIDEC INC.1354-9068 Chemin St-Elie, Sherbrooke.Granby.990, Begin, Québec.57, rue Commerciale, Levis.GESTION YANIS LIMITEE.YANIS HOLDING LIMITED 1356-0560 YVON GIRARD INC.1355-5263 6751 Place Pascal-Gagnon, Montréal-Nord.LES HABITATIONS CHAMPVERT INC.1367-8545 HABITATS LA BELLE MAISON INC.1355-6493 Pointe-au-Pic.5170, Peguy Street, Saint-Hubert.Route 122, Saint-Germain-de-Grantbam.JEAN HANCISSE INC.1368-0293 HARMUR CONTRACTING INC.\u201e.LES ATELIERS HARMUR INC.* 1367-4270 HELLENIC BILLIARDS ic SNACK BAR INC.CASSE-CROUTE & BILLARDS II El.I.E.N [QUE INC.1367-9063 HOSEIN.RAKHIT & ASSOCIES LTEE.BOBBIN, RAKHIT & ASSOCIATES LTD.1367-1565 Montréal.3575, St.Lawrence Boulevard, Montréal.25 03 74 26 04 74 27 03 74 15 03 74 25 04 74 04 04 74 19 04 74 05 04 74 31 01 74 25 03 74 5319 Park Avenue, Montreal.24 04 74 19 St.Francis Boulevard, Châteauguay.K« £SMEnBLE8 CATARAQUI INC.3291.Chemin Ste-Foy.Québec.1 \u2022ioo\u2014d 1u4 LESIMMEUBLES MERME LTEE.1155 Ouest, boulevard Dorchester.1367-4544 Suite 8l8f Montréal.WM-0M0 EUBLES PERFECTA INC170 Grande-Allée ouest, Québec.?SRSSm QUATRERE INC.4575 boulevard Laurier Saint- 1367-8099 Hubert.IMPORTATIONS & EXPORTATIONS B.L.M.INC.5450.Royalmount Avenue.idfctfù ™ & BXPORT ,NC- Mount Royal.1368-0269 1368Eî30ri03SEMENTS MONT-BELLEVUE INC.86 Wellington North, Sherbrooke.''MS^SSSff^SSSS^^67.0Oueat.rueSt-Jac (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.IT! \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en VTac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.LT \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 4108 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971, Vol.106, No.22 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) vérification de permis annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.* permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes M ontrêal Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport\tVoyageur Passenger\tMPV\tQPV\tRose Pin* \tÉcolier Student\tMPE\tQPE\tRouge foncé Dark red \tTaxi Taxicab\tMPT\tQPT\tJaune orange Orange Transport général General trucking\tCamionnage régulier Regular trucking\tMCR\tQCR\tOrange brûlé Burnt orange \tCamionnage spécialisé Specialized trucking\tMCS\tQCS\tVert pâle Light green \tTransport en vrac Bulk transportation\tMCV\tQCV\tVert foncé Dark green Location Leasing\tLocation Leasing\tML\tQL\tBleu pâle Light blue Transport spécialisé Specialized transportation\tMaritime Water Aérien Air\tMSM M SA\tQSM QSA\tBleu foncé Dark blue Mauve M auve \tFerroviai re Rail\tMSF\tQSF\tBrun Brown M 000001 Q 000001 M 100001 Q 100001 M 200001 Q 200001 M 300001 Q 300001 M 400001 Q 400001 M 500001 Q 500001 M 600001 Q 600001 M 700001 Q 700001 M 800001 Q 800001 M 900001 Q 900001 à M 002000 à Q 001000 à M 103000 àQ 102000 à M 210000 à Q 205000 à M 303000 àQ 302000 à M 402000 àQ 401000 à M 504000 àQ 503000 à M 601000 à Q 600500 à M 700500 àQ 700500 à M 800500 àQ 800500 à M 900500 àQ 900500 MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport ¦\u2014 passengers MPE \u2014 Montréal transport public \u2014- écoliers / Montreal public transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers,' Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal public transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport ¦\u2014 taxicab MCR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking QCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage / Québec regular transpoitation \u2014 trucking GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4109 MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV \u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal btdk transportation \u2014 trucking QCV \u2014 Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking ML \u2014 Montréal location / Montreal leasing QL \u2014 Québec location / Québec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation \u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Québec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 atr MSF \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rail QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Québec specialized transportation \u2014 rail II \u2014 Avis d'introduction de requêtes: La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of applications: The Commission gives notice of its intention to decide on the following proceedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.Rôle Q-1171 1204-V-D-2 G.GAGNÉ TRANSPORT LTÉE 617 rue Béchard Ville Vanier Québec 8, Que.et/and G.GAGNÉ TRANSPORT ENR.(Yves Côté, Roland Cantin, Roger Desnoyers et Dame Nicole Côté) 851, De Beaujeu Québec, Que.Cession de la propriété du système de transport (vente).G.Gagné Transport ltée demande l'autorisation de céder à: G.Gagné Transport Enr.(Yves Côté.Roland Cantin, Roger Desnoyers et Dame Nicole Côté) 851, De Beaujeu Québec, Que.la propriété du système de transport suivant: Permis No 1204-V: I.Transport général de marchandises: a) Transport général - service local - a) Québec et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite cité.b) Transport général - longue distance -rayon - 6) De Québec à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite cité, en suivant les routes principales, et retour.II.Pour le transport de meubles neufs, fournitures de magasins, bureaux, musées, hôpitaux et autres établissements, l'équipement électronique et des accessoires auxiliaires nécessaires tels que panneaux de contrôle, tabulateurs, multiplicateurs et interprêteurs non emballés: 1.Transport restreint - local - territoire - 1.A Québec et de tout point à un autre dans un rayon de 50 milles des limites de ladite cité de Québec.2.Transport restreint - longue distance -rayon - 2.De Québec et de tout point situé dans un rayon de cinquante milles des limites de la cité de Québec à tout point situé dans un rayon de 150 milles des limites de ladite cité de Québec, et retour.3.Transport restreint - longue distance -territoire - Transfer of ownership of a transportation service (sale).G.Gagné Transport ltée requests authorization to transfer to: G.Gagné Transport Enr.(Yves Côté.Roland Cantin, Roger Des-noyers and Mrs Nicole Côté) 851 De Beaujeu Québec, P.Q.the ownership of the following transportation service : Permit No.1204-V.I.General transport of goods: (a) General trucking - local service - (a) Québec and all points not beyond 5 miles from the limits of said City.(6) General trucking - long distance -radius - (b) From Quebec to all points located within a radius of 30 miles from the limits of said City, along the main highways, and return.II.For the transportation of new furniture and supplies for stores, offices, museums, hospitals and other establishments, electronic equipment and the necessary auxiliary parts such as control panels, tabulators, multipliers and interpreters, all such goods non-crated : 1.Restricted trucking - local - territory - 1.To Québec City and from any point to any other point located within a radius of 50 miles from the limits of said City of Québec.2.Restricted trucking - long distance -radius - 2.From Québec and any point located within a radius of 50 miles from the limits of Québec City to any point located within a radius of 150 miles from the limits of said City of Québec, and return.3.Restricted trucking - long distance -territory - 4110 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.W 3.De tout point à un autre dans les limites de la province de Québec pourvu que la distance entre ces deux points soit de plus de cent milles.4.Transport restreint - longue distance -route restreinte - 4.De toutes les localités situées dans la province de Québec à la frontière du Nou-veau-Brunswick, et retour via toutes les routes et tous les ports d'entrée.6.Transport restreint - longue distance -route restreinte - 6.De toutes les localités situées dans la province de Québec à la frontière de la province de l'Ontario et retour, via toutes les routes et tous les ports d'entrée.6.Transport restreint - longue distancée -route restreinte - 6.De toutes les localités situées dans la province de Québec à la frontière des États-Unis, et retour, via toutes les routes et tous les ports d'entrée.7.Transport restreint - longue distance -route restreinte - en transit - 7.D'une frontière de la province de Québec à une autre frontière, via toutes les routes et tous les ports d'entrée; en transit.Restrictions re/clauses 1,2,3,4,5, 6 et 7: 1.Les véhicules utilisés pour effectuer le transport des marchandises précitées doivent être enregistrés à la Province et à la Commission, et lesdits véhicules devront être du genre des vans spécialisées, normalement utilisées pour le transport de ménages et ameublements usagés.2.Le détenteur de ce permis ne peut transporter son bureau de la cité de Québec à tout autre endroit sans une autorisation préalable et écrite de la Commission, et il ne peut, ni directement ni indirectement, sans une autorisation préalable de la Commission, tenir un bureau dans toute localité de la province de Québec autre que la ville de Québec.3.Le détenteur de ce permis, sans une autorisation préalable et écrite de la Commission, ne peut établir, maintenir ou exploiter, ni directement, ni indirectement, un terminus ou un entrepôt dans un endroit de la Province autre que la cité de Québec, que ce soit pour fins de recevoir, délivrer ou organiser des expéditions de ménages et d'ameublements usagés.4.La marchandise qui sera transportée en vertu des clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sera restreinte aux item neufs et non emballés listés dans le permis, dans leur mouvement initial du manufacturier au consommateur à condition que ladite marchandise soit destinée à faire partie de l'établissement du consommateur.5.Le service autorisé par la clause 6 dudit permis ne sera opéré que conjointement avec le certificat complémentaire obtenu de l'Ontario Highway Transport Board et daté du 29 janvier 1969.6.Le service autorisé par la clause No 4 de ce permis ne sera opéré que conjointement avec le certificat de la Motor Carrier Board, Classe F-Extra-Provinciale, portant le numéro 281 et daté du 17 décembre 1968.7.Le service autorisé par la clause No 6 de ce permis ne sera opéré que conjointement avec le certificat complémentaire émis en faveur de United Van Lines Inc., par l'Inter- 3.From any point to any other point located within the limits of the Province of Québec provided that the distance between such two points exceed one hundred miles.4.Restricted trucking - long distance -restricted route - 4.From any point located in the Province of Québec to the New Brunswick border, and return, via any route and any port of entry.5.Restricted trucking - long distance -restricted route - 5.From any point located in the Province of Québec to the Ontario border and return, via any route and any port of entry.6.Restricted trucking - long distance -restricted route - 6.From any point located in the Province of Québec to the United States border and return, via any route and any port of entry.7.Restricted trucking - long distance -restricted route - in transit - 7.From any border of the Province of Québec to any other border, via any route and any port of entry; in transit.Restrictions to clauses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7: 1.The vehicles utilized to effect the transport of the aforesaid goods must be registered in the Province and with the Commission; said vehicles must be special vans normally utilized for the transport of household goods and used furniture.2.The permit-holder shall not transfer its office from the City of Québec to any other point in the Province without first obtaining written authorization from the Commission; furthermore, he may not, either directly or indirectly, maintain an office in any locality in the Province of Québec, other than the City of Québec, without first obtaining authorization from the Commission.3.The holder of the present permit may not, without written authorization from the Commission, establish, maintain or operate, either directly or indirectly, a terminal or warehouse in any locality in the Province of Québec other than the City of Québec, whether it be for the purpose of receiving, delivering or preparing shipments of household goods and used furniture.4.The goods that are to be transported according to clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 shall be restricted to the new and non-crated items listed in the present permit, in their original movement from the manufacturer to the consumer, on condition that the said goods be destined to become part of the consumer's premises.5.The service authorized by clause 5 of said permit shall only be operated concurrently with a complementary certificate issued by the Ontario Highway Transport Board, and dated January 29, 1969.6.The service authorized by clause 4 of the present permit shall only be operated concurrently with certificate No.281, Class F, Extra-Provincial, issued by the Motor Carrier Board, and dated December 17, 1968.7.The service authorized by clause 6 of this permit shall only be operated concurrently with a complementary certificate bearing No.MC-67234 Sub.1, issued to United Van GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4111 state Commerce Commission, portant le No MC-67234 Sub.1, et daté du 16 juillet 1945.8.Les services autorisés par les clauses 4, 5, 6 et 7 de ce permis ne seront opérés que conjointement avec un permis, certificat ou autre autorisation à être émis par les autorités compétentes ayant juridiction dans la localité d'origine ou de destination des marchandises transportées dont copie aura été déposée au dossier.Droit additionnel re: clause 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7: Le détenteur de ce permis a le droit d'agir comme courtier en transport pour les fins d'accepter les commandes, pour le transport d'équipement électronique et les accessoires nécessaires tels que panneaux de contrôle, tabulateurs, multiplicateurs et interpréteurs non emballés, et de transférer lesdites commandes à être exécutées, suivant ses propres connaissements ou autres documents, pourvu que le détenteur continue, auprès du client, a être responsable, même si le transport est effectué par un autre camionneur, détenteur du permis de la Commission.III.Transport de ménages et ameublements usagés: a) Transport restreint - local - territoire - a) A Québec et de tout point à un autre dans un rayon de 50 milles des limites de la cité de Québec.b) Transport restreint - longue distance -rayon - 6) De Québec et de tous les points situés dans un rayon de 50 milles des limites de la cité de Québec à tous les points situés dans un rayon de 150 milles des limites de la cité de Québec et retour.c) Transport restreint - longue distance -territoire - e) De tout point à un autre dans les limites de la province de Québec, pourvu que la distance entre ces deux points soit de plus de 100 milles.d) Transport restreint - longue distance -route restreinte - d) De toutes les localités situées dans la province de Québec à la frontière du Nouveau-Brunswick, et retour, via toutes les routes et tous les ports d'entrée, pour le transport de ménages et d'ameublements usagés destinés à une localité du Nouveau-Brunswick ou en provenant.e) Transport restreint - longue distance -route restreinte - e) De toutes les localités situées dans la province de Québec à la frontière de l'Ontario, et retour, via toutes les routes et tous les ports d'entrée, pour le transport de ménages et d'ameublements usagés destinés à une localité de l'Ontario ou en provenant./) Transport restreint - longue distance -route restreinte - /) De toutes les localités situées dans la province de Québec à la frontière des Etats-Unis, et retour, via toutes les routes et tous les ports d'entrée.g) Transport restreint - longue distance -route restreinte - en transit - g) D'une frontière de la province de Québec à une autre frontière, via toutes les routes et tous les ports d'entrée, en transit.Restrictions: 1.Le service autorisé par la clause e de ce permis ne sera opéré que conjointement avec le certificat complémentaire obtenu de l'On- Lines Inc.by the Interstate Commerce Commission, and dated July 16, 1945.8.The services authorized by clauses 4, 5,6 and 7 of this permit shall only be operated concurrently with a permit, certificate or any other authorization to be issued by the competent authorities having jurisdiction in the locality of origin or of destination of the goods transported, copy of which authorization shall have been filed.Additional right re: clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7: The holder of this permit shall be entitled to act as transport broker for the purpose of taking orders for the transport of electronic equipment and auxiliary devices required such as control panels, tabulators, multipliers and interpreters, said goods non-crated, and to transfer the said orders to be executed according to its own bills of lading or any other documents, provided that the permit-holder continue to be responsible to the customer, even if said transport is provided by another carrier that holds a permit from the Commission.III.Transport of used furniture and household goods: (a) Restricted trucking - local - territory - (a) To Québec City and from any point to any other point located within a radius of 50 miles from the limits of said City of Québec.(b) Restricted trucking - long distance -radius - (b) From Québec and any point located within a radius of 50 miles from the limits of the City of Québec to any point located within a radius of 150 miles from the limits of said City of Québec, and return.(c) Restricted trucking - long distance -territory - (c) From any point to any other point located within the limits of the Province of Québec, provided that the distance between such two points exceed one hundred miles.(d) Restricted trucking - long distance -restricted route - (d) From any locality situated in the Province of Québec to the New Brunswick border, and return, via any route and any port of entry, for the transport of household goods shipped to or originated from a locality in New Brunswick.(e) Restricted trucking - long distance -restricted route - (e) From any point located in the Province of Québec to the Ontario border, and return, via any route and any port of entry, for the transport of household goods and furniture shipped to or originating from a locality in Ontario.(/) Restricted trucking - long distance -restricted route - , w du permis du roulier, ledit permis portant le numéro 1079-V.Permit number 1770-V (a) General trucking - local service -(a) St-Hyacinthe and ail points not beyond 5 miles from the limits of said point.(6) General trucking - long distance - radius - (6) From St.Hyacinthe to all points located within a radius of 30 miles, and return; (c) Restricted trucking - long distance -radius - (c) From St.Hyacinthe to anv other point in the Province and return, for the transportation of building materials.(See report, attached hereto).The applicant requests that a modification be made to its present permit which reads as follows: Class of permit: Bus Service.Service : Transportation of passengers on charter trips from Ste.Agathe-des-Monts to any point located within a radius of sixty (60) miles from Ste.Agathe-des-Monts.and return, adding the following points of departure: \"St.Adolphe-d'Howard, Ste.Agathe North, Ste.Agathe South, Préfontaine, Lac Manitou and Ivry\".Transfer of ownership of transport service (sale of taxi).Douranos Donstantinos requests the Commission to transfer to: Douranos Georges 10380 Terrase Fleury, Apt.23.Montreal.certificate number M-202713, which he holds, to entitle him to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of ownership of transport service (sale of taxi).Paquette, René requests the Commission to transfer to: Deslandes Marc 71 Des Chênes Ave.St.Basile-le-Grand certificate number M-204038 D-l, which he holds, to entitle him to serve conglomeration A-24, St.Bruno.Transfer of ownership of transport service (sale of taxi).Dupré, Robert requests the Commission to transfer to: St-Cyr, Roger 773 Sherbrooke Lachine certificate number M-203530, which he holds, to entitle him to serve conglomeration A-12, West of Montreal.The haulaway operator requests the Québec Transport Commission to authorize him to provide the following transportation service, according to the prescribed conditions: Class: Restricted trucking - haulaway only -Service: Haulaway service to haul the trailers (empty or loaded) belonging to the joint applicant, Genesse Transport Inc.(1079-V), which shall act as carrier; the foregoing according to clauses c, /, v, w, of the carrier's permit bearing No.1079-V. 4120 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971, Vol.106, No.22 Rôle M-2005 17681-V D-l MEUNERIE STE-ROSALIE INC.160.de l'Eglise Ste-Rosalie (Bagot).Que.Rôle M-2006 1716-V D-l PILON THE MOVER REC'D.(Léo Pilon operant sous le nom de / operating under the name of) 369A, Avenue Grande Côte St-Eustaohe (Deux-Montagnes), Que.Rôle M-2007 0659-V D-3 KINGSWAY TRANSPORTS LIMITED 10,525.Côte de Liesse Dorval.Que.Rôle M-2008 9659-V D-4 KINGSWAY TRANSPORTS LIMITED 10,525 Côte de Liesse Dorval.Que.Rôle M-2009 12290-V D-l LARIVIÈRE TRANSPORT LIMITÉE Boul.Henri-Bourassa Montehello.Cté Papineau, P.Q.Rôle M-2010 23761-V D-l FORTIN, ROBIN 82, Lac Noël St-Colomban.P.Que.Voiturier-remorqueur Haulaway operator et I and CENTRAL TRUCK LINES LTD, C.P.1180, Val d'Or Abitibi est, P.Québec Voiturier-roulier Carrier operator Modification de permis.La partie requérante demande qu'à la clause a suivante: a) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - o) De Montréal à Ste-Rosalie et à tous les clients de AU.Marquette A Fils Inc., aux endroits situés dans un rayon de soixante- Îuinze (76) milles de St-Rosalie au sud du leuve St-Laurent, soit ajoutée l'expéditeur suivant: Ogil vie Flour Mills - Division de la boulangerie et de l'institution.Cession de la propriété du système de transport (suite à demande d'incorporation par la requérante).La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de céder la propriété du système de transport qu'elle exploite à la compagnie Les Déménageurs Pilon Inc.- Pilon the Movers Inc., dont elle possède la majorité des actions et dont le siège sera au même endroit.Actionnaires: Léo Pilon, Président 98 actions Jeannine Pilon Gougeon.Vice-Présidente 1 action Jean-Claude Gougeon, Secrétaire 1 action La requérante demande l'autorisation de louer à long terme 7 camions (tracteurs) dont la description apparaît au contrat de location, de North Continent Capital Ltd.Ce contrat de location se termine le 28 avril 1980.La requérante demande l'autorisation de louer à long terme 8 camions (tracteurs) dont la description apparaît au contrat de location de Laurentide Financial Corporation Ltd.Ce contrat de location se termine le 28 avril 1980.La requérante désire être autorisée à donner le service suivant: Classe: Transport restreint-longue distance\u2014route restreinte - contrat - véhicules isothermes - Service: De toutes les pépinières situées dans la province de Québec aux différentes localités situées dans les comtés étant sous la juridiction du ministère des Terres et Forêts, division Hull, à savoir: Hull, Gatineau, Pontiac, Papineau, Labelle, Argenteuil.pour le transport de plants de reboisement pour le compte du ministère des Terres et Forêts, et retour avec marchandises refusées et/ou avariées.Le voiturier remorqueur demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - remorquage seulement -Service: Transport par remorquage, pour tirer les remorques vides ou chargées du requérant conjoint: Central Truck Lines Ltd.(8665-V), qui agira comme voiturier roulier.Ce service sera effectué en vertu des clauses a à 6b inclusivement du permis du roulier, ledit permis portant le numéro 8566-V.Modification of permit: .___, The applicant requests that the name ot the following shipper be added to the loi-lowing clause a: (a) Restricted trucking - long distance-restricted route - contract - (o) From Montreal to Ste.Rosalie and to all the customers of Alf.Marquette & Fils Inc.at points located within a radius of seventy-five (75) miles from Ste.Rosalie, south of St.Lawrence River.Ogilvie Flour Mills - Bakery and Institution Division.Transfer of ownership of a transportation service (in conformity with the applicant's request for incorporation).The applicant requests authorization from the Commission to transfer the ownership of the transportation service that it operates at Les Déménageurs Pilon Inc.- Pilon the Movers Inc., in which it owns the majority of the shares, and whose head office shall remain at the same address.Share-holders Léo Pilon.Président 98 shares Jeannine Pilon Gougeon.Vice-President 1 share Jean-Claude Gougeon, Secretary 1 share The applicant requests authorization to lease, on a long-term basis, from North Continent Capital Ltd.7 trucks (tractors) whose description appears on the lease.This lease shall expire on April 28, 1980.The applicant requests authorization to lease, on a long-term basis, from Laurentide Financial Corporation Ltd., 8 trucks (tractors) whose description appears on the lease.This lease shall expire on April, 28, 1980.The applicant whishes to be authorize to provide the following service: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - temperature-controlled vehicles - Service : From all nurseries located in the Province of Québec to the various localities situated in the counties under the jurisdiction of the Department of Lands and Forests, Hull Division, namely: Hull, Gatineau, Pontiac, Papineau.Labelle.Argenteuil.for the transportation of reforestation plants on behalf of the Department of Lands and Forests, and return with refused and/or spoil goods.The haulawav operator requests the Quebec Transport Commission to authorize him to provide the following transportation service, according to the prescribed conditions: Class: Restricted trucking - haulaway only -Sen-ice : Haulaway service to haul the trailers (empty or loaded) belonging to the joint applicant Central Truck Lines Ltd.(8565-V), which shall act as carrier; the foregoing according to clauses a to 66 inclusive of the carrier s permit bearing No.8565-V. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971, 106' année, n° S3 4121 Rôle M-2012 1177 DY & 883 DYV D-2 LOCATION MINICO LTÉE, MINICO LEASING LTD., 10765, Boul.Lajeunesse, Montréal, P.Q.Rôle M-2013 757 DY D-l LES ENTREPRISES B.C.ENRG., (Dame Florence Léveillé -Charbonneau, pour la succession Bernard Charbonneau, opérant sous le nom de) 418, 15e Rue, Laval-des-Rapides, Québec Rôle M-2014 M-501638 D-l POULIN, GASTON 75 Route 40A Ste-Brigide Comté Iberville, P.Q.Rôle M-2015 M-500815 D-2 ST-PIERRE, MAURICE St-André Est Comté Argenteuil, P.Q.Droits additionnels : La requérante demande & la Commission des transports du Québec l'autorisation d'exploiter une succursale de location additionnelle au numéro 1072, boulevard des Lauren-tides, ville de Laval, province de Québec.Offrir les services de location suivant : Service 1 : Location à long terme (un an et plus) de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) ; Service 2: Location à long terme (un an et plus) de véhicules de promenade (automobiles conventionnelles et familiales).Transfer de permis et changement d'adresse: La requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation d'exploiter sous les mêmes nom et raison social le permis que détenait autrefois feu son époux, Bernard Charbonneau, opérant alors sous le nom de Les Entreprises B.C.Enrg., permis 757-DY, lequel se lit comme Suit: Location de véhicules de promenade à court terme, au 8695 de la rue De Gaspé, app.1, Montréal et au 7275 est, rue Sherbrooke.Montréal aux personnes désirant passer leur examen en vue de l'obtention de leur permis de conducteur ou de chauffeur.La requérante demande, au surplus, l'autorisation de changer ses places d'affaires de la façon suivante: le 8695 de la rue De Gaspé, app.1, Montréal pour le 26 ouest, rue Jean-Talon, Montréal, le 7275 est, rue Sherbrooke, Montréal pour le 6025 est, rue Jean-Talon, Montréal Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation de céder au requérant acheteur: Lamarche, Gilles (M-605566 D-l) 45 Bord-de-l'Eau Iberville Comté Iberville, P.Q.la propriété du système de transport de camionnage en vrac suivant: Attestation No M-501638 D-l qu'il détient pour le camion suivant: International 1963 Série No 1800CW26782GB F-230-309 1973 Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation de céder au requérant acheteur: St-Pierre, Fernand (M-606680 D-l) St>-André Est Rang Rivière Rouge Comté Argenteuil, P.Q.la propriété du système de transport de camionnage en vrac suivant: Attestation No M-500815 D-2 qu'il détient pour le caimon suivant: International 1970 Série No C058985 F-262-257 1974 Additional rights: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to operate an additional leasing branch at: 1072 Boulevard des Laurentides, City of Laval, Province of Québec: To give the following leasing sendees: Service 1: Leasing of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) on a long term basis (one year or over) ; Service 2: Leasing of pleasure vehicles (automobiles and station wagons) on a long term basis (one year or overj.Transfer of permit and change of address: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to operate under the same name and style the permit formerly held by her late husband, Bernard Charbonneau, operating then under the name of Les Entreprises B.C.Enrg., permit number 757-DY, which reads as follows: Leasing of pleasure vehicles on a short-term basis, at 8695 De Gaspé Street, Apt.1, Montreal and at 7275 Sherbrooke Street East, Montreal to persons who wish to pass a test in order to qualify for a driver's or chauffeur's licence.Moreover, the applicant requests authorization to change its places of business as follows : 8695 De Gaspé Street, Apt.1, Montreal for 26 Jean-Talon Street West, Montreal 7275 Sherbrooke Street East, Montreal for 6025 Jean-Talon Street East, Montreal Transfer of ownership of transport service (sale).The applicant requests authorization to transfer to the applicant purchaser: Lamarche, Gilles (M-505566 D-l) 45 Bord-de-l'Eau Iberville Iberville County, P.Q.the ownership of the following bulk transport service : Certificate No.M-501638 D-l, which he holds for the following truck: 1963 \"International\" Serial No.1800CW26782GB F-230-309 1973 Transfer of ownership of transport service (sale).The applicant requests authorization to transfer to the applicant purchaser: St-Pierre, Fernand (M-506680 D-l) St-André East Rang Rivière Rouge Argenteuil County, P.Q.the ownership of the following bulk transport service: Certificate No.M-500815 D-2, which he holds for the following truck: 1970 \"International\" Serial No.C058985 F-262-257 1974 4122 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 197A, Vol.106, No.22 Rôle M-2016 M-501993 D-l GOHIER, PIERRE 761 Rivière Nord St-Eustache Comté Deux-Montagnes, P.Q.Rôle Q-l 193 872-V-D-l J.L.P.BRETON INC.641 ouest, Christophe-Colomb Québec.Que.Mise en cause Rôle Q-l 194 13483-V-D-l JOSEPH LAMOTHE & FILS INC.176, Jacques-Cartier Donnacona (Portneuf) Rôle Q-l 195 Q-201992 MONSIEUR GASTON QUIRIAULT 3636 Des Sureaux Orsainville Requérant-acheteur Applicant purchaser et / and Q-200028 MONSIEUR MAURICE AUGER 4900, 5e Avenue Charlesbourg Requérant-vendeur Applicant vendor Le requérant qui possède l'attestation No M-501993 D-l pour opérer dans la région 6 \u2014 Entrepreneur \u2014 demande que cette attestation soit transférée dans la région 10, sans changement d'adresse.Changement de contrôle dans la compagnie (transmission d'actions par décès).Feu Leopold Breton a légué à son fils, Jean-Paul, toutes les actions qu'il possédait dans la mise en cause.On demande l'autorisation à la Commission de ce faire, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi des transports.Distribution actuelle: Jean-Paul Breton.62 actions Leopold Breton.51 actions Dame Lucina Linteau Breton.10 actions Roland Breton.1 action Nouvelle distribution: Jean-Paul Breton.112 actions Dame Germaine D.Breton.10 actions Guy Breton.1 action Roland Breton.1 action Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis les services suivants: Transport général - longue distance -rayon - De Donnacona et de tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville à ailleurs dans le district électoral-provincial de Portneuf, et retour.Transport restreint - longue distance -rayon - De Donnacona et de tout point situé dans le district électoral-provincial de Portneuf à ailleurs dans la province, et retour, pour le transport de marchandises provenant de ou destinées aux commissions scolaires du comté de Portneuf.La requérante demande la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de Monsieur Maurice Auger portant le No Q-200028.The applicant, which owns certificate number M-501993 D-l to operate in region b \u2014 Contractor \u2014 requests that this cetrificate be transferred to region 10, without any change of address.Modification of control in the company (transfer of shares by succession).The late Leopold Breton has bequeathed to his son, Jean-Paul, all the shares which he owned in the company mise en cause.Authorization to do so is requested from the Cora-mission, under the provisions of section 39 of the Transport Act.Present distribution: Jean-Paul Breton.62 shares Leopold Breton.51 shares Dame Lucina Linteau Breton .10 shares Roland Breton.1 share New distribution : Jean-Paul Breton.112 shares Mrs.Germaine D.Breton.10 shares Guy Breton.1 share Roland Breton.1 share Modification of permit.The applicant requests that the following services be added to its permit: General trucking - long distance - radius - From Donnacona and all points located within a distance of five (5) miles from the limits of said Town to any point in the Provincial Electoral District of Portneuf, and return.Restricted trucking - long distance - radius From Donnacona and all points located in the Provincial Electoral District of Portneuf to any point in the Province, and return, for the transport of goods originated from or destined to the school boards of the County of Portneuf.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf certificate No.Q-200028 held by Mr.Maurice Auger.Rôle Q-l 196 Q-200523 D-4 MONSIEUR EDGAR TREMBLAY 527 St-Germain Est Rimouski Est Requérant-vendeur Applicant vendor et/and Cession de la propriété du système de transport (vente).Monsieur Edgar Tremblay demande a la Commission de transférer à Monsieur Lucien Lévesque l'attestation No Q-200623 D-4 qu'il détient.Transfer of ownership of a transportation system (sale).Mr.Edgar Tremblay requests the Trans-S?V«Somm'ssion to transfer certificate No.Q-200523 D-l which he holds, to Mr.Lucien Lévesque. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° S3 4123 MONSIEUR LUCIEN LÉVESQUE 320 rue Dollard Rimouski Requérant-acheteur Applicant purchaser Rôle Q-l 197 14556-V-D-2 DAY & ROSS LTD.P.O.Box 540 Hartland, N.B.EOJ 1N0 Siège social / Head Office: St.John, N.B.Bureaux d'affaires au Québec Places of business in Québec: 1500 Montarville Blvd., Boucherville, Que.1250 Borne St., Québec City, Que.Rôle Q-l 198 2680-V-D-l R.GERVAIS TRANSPORT ENR.(Rosaire Gervais) 371 rue Principale St-Narcisse (Champlain) et / and TRANSPORT R.GERVAIS LTÉE 371 rue Principale St-Narcisse (Champlain) La requérante demande à la Commission l'autorisation légale de transférer au nom de Day & Ross Ltd.les véhicules qui sont utilisés en vertu d'un contrat auquel elle est partie, soit les véhicules dont elle n'est pas le propriétaire réel, afin de pouvoir les immatriculer et les utiliser dans la province de Québec en vertu des permis et des autorisations qui ont été accordés à la compagnie Day & Ross Ltd.Lorsque le contrat prendra fin entre la compagnie Day & Ross Ltd.et l'autre partie contractante, ou en cas de vente du véhicule par cette dernière, le véhicule devra être transféré au nom de ladite partie contractante, de façon que l'acheteur ne puisse s'exempter de payer la taxe de vente.Un tel transfert doit être confirmé au moyen d'une déclaration signée et délivrée pour chaque véhicule, par la compagnie Day & Ross Ltd., selon une formule qui convienne à la Commission, laquelle déclaration devra demeurer aux dossiers du ministère des transports pendant toute la durée de l'exploitation du contrat pour le compte de cette compagnie.Cession de la propriété du système de transport (vente).R.Gervais Transport Enr.(Rosaire Gervais) demande l'autorisation de céder à la compagnie: Transport R.Gervais ltée 371 rue Principale St-Narcisse (Champlain) la propriété du système de transport suivant: Permis No 2680-V: a) Transport général - service local - a) St-Narcisse et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite municipalité.b) Transport général - longue distance -rayon - 6) De St-Narcisse à tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 30 milles des limites de ladite municipalité, et retour.c) Transport général - longue distance -route restreinte - irrégulier - c) De St-Narcisse à Montréal, Québec et retour.d) Transport général - longue distance -route restreinte - régulier - (au moins 2 fois par semaine) d) De St-Narcisse, St-Luc-de-Vincennes, St^Sévérin-de-Proulxville, St-Adelphe et St-Stanislas à Montréal et retour.e) Transport restreint - longue distance -toute restreinte - contrat - c) A St-Tite de Grand'Mère, pour le transport de cuir et de matériel servant à la fabrication de gants, pour le compte de Consumera Glove Co.Limited./) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - /) De St-Narcisse à ailleurs dans la province et retour, pour le transport de marchandises pour le compte de Matelas Suprême Inc., Feutre National Inc., Specto-metal Inc., tous de St-Narcisse.The applicant requests from the Commission legal authority to transfer vehicles under contract with Day & Ross Ltd., of which Day & Ross Ltd.is not the beneficial owner, into the name of the company in order to licence and operate them within the province of Québec under the permits and authority granted to Day & Ross Ltd.And upon termination of any agreement between Day & Ross Ltd.and the contractor or the sale of the vehicle by the contractor, to transfer the same back into the name of the contractor, so that payment of sales tax is not avoided thereby.Such transfer to be performed by means of a signed statement issued in respect of each vehicle by Day & Ross Ltd.in form suitable to the Commission, to be on file with the Minister of Transport at all times during operation on behalf of the company.Transfer of ownership of transport service (sale).R.Gervais Transport Enr.(Rosaire Gervais) requests authorization to transfer to: Transport Gervais Ltée 371 Principale Street St-Narcisse (Champlain) the ownership of the following transport system: Permit No.2680-V: (a) General trucking - local service - (a) St.Narcisse and all points located within a distance of 5 miles from the limits of said Municipality.(o) General trucking - long distance -radius \u2014 (6) From St.Narcisse to all points located within a distance of 30 miles from the limits of said Municipality, and return.(c) General trucking - long distance -restricted route - irregular - (c) From St.Narcisse to Montreal.Québec, and return.(d) General trucking - long distance -restricted route - regular - (at least twice a week).(d) From St.Narcisse, St.Luc-de-Vincen-nes, St.Sévérin-de-Prouxville, St.Adelphe and St.Stanislas to Montreal and return.(c) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (c) To St.Tite from Grand'Mère, for the transport of leather and fabrics used in glove-manufacturing, on behalf of Consumers Glove Co.Limited.(/) Restricted trucking - long distance -radius - contract - (/) From St.Narcisse to other points in the Province and return, for the transport of commodities on behalf of Matelas Suprême Inc., Feutre National Inc., Spectometal Inc., all of St.Narcisse. 4124 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1971, Vol.106, No.22 Rôle Q-l 199 Q-200161 MME JEANNINE DENIS St-Alban Cté Portneuf Rôle Q-1200 12446-V-D-l ST-AMANT MAURICE St-Alban Village Cté de Portneuf et / and 7737-V-D-3 BELLECHASSE TRANSPORT INC.3600 boul.Hamel Québec, Que.Rôle Q-l201 7801-V-D-l LAMPRON GEORCES-ÊTIENNE (décédé) 1421 rue Principale St-Etienne-des-Grèa Cté de St-Maurice et / and DAME GERMAINE HEATCOAT-LAMPRON (légataire universelle) (universal legatee) Rôle Q-1205 15384-V D-l TF BLAIS GABRIEL 118, St-Jean St-Isidore, Cté Dorchester, P.Q.g) Transport restreint - longue distance -route restreinte - g) De Joliette St-Narcisse, Mont-Carmel, St-Tite, St-Maurice et Lac-à-la-Tortue, pour le transport de ciment en sacs.h) Transport général - longue distance -route restreinte - h) St-Stanislas à Trois-Rivières, et retour.t) Transport général - longue distance -route restreinte - i) De St-Adelphe.St-Thècle, St-Stanislas, St-Séverin et St-Tite à Québec, et retour.j) Transport général - longue distance -route restreinte - j) De St-Adelphe, St-Stanislas et St-Séverin à Montréal, et retour.k) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - k) De St-Basile (Portneuf) à St-Stanislas, St-Adelphe, St-Séverin, St-Narcisse, St-Tite, St-Thècle, St-Prosper, Ste-Geneviève et St-Tiinothée.pour le transport de ciment en sacs, pour le compte de Ciment Québec Inc.I) Transport restreint - longue distance -rayon - /) De St-Stanislas et de tous points situés dans un rayon de 30 milles dudit endroit, sauf Trois-Rivières, Shawinigan et Grand' Mère à ailleurs dans la province, et retour, pour déménagement.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec un permis de propriétaire, pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans la région ou la municipalité de St-Alban, comté de Portneuf.Cession de la propriété du système de transport (vente).Maurice St-Amant demande l'autorisation de céder à la compagnie: Bellechasse Transport Inc.7737-V 3600 boul.Hamel Québec, Que.la propriété du système de transport suivant : Permis No 12446-V: Transport général - St-Alban et environs et occasionnellement de St-Alban à Québec et retour, pour le transport de marchandises destinées à St-Alban ou en provenant.Transmission du système de transport (suite à un décès).La légataire universelle demande l'autorisation d'exploiter le système de transport qu'opérait de son vivant, son époux, feu Georges-Etienne Lampron, à savoir: Transport général - service local -St-Etienne-des-Grès et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite municipalité; Transport général-longue distance-rayon-De St-Etienne-des-Grès à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles et retour.Le requérant demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter et de modifier ses tarifs selon les clauses du permis de transports de marchandises portant le No 15384-V.Tout intéressé peut obtenir une copie des taux proposés en s'adressant à la Commission des transports du Québec.(g) Restricted trucking - long distance -restricted route - ._\u201e (g) From Joliette to St.Narcisse, Mont-Carmel, St.Tite, St.Maurice Lac-a-la-Tortue.for the transport of cement in bags.(A) General trucking - long distance -restricted route - (h) St.Stanislas to Trois-Rivières and return.(t) General trucking - long distance -restricted route - (t) From St.Adelphe, St.Thècle, St.Stanislas, St.Séverin and St.Tite to Québec and return.0) General trucking - long distance -restricted route - O) From St.Adelphe, St.Stanislas and St.Séverin to Montreal, and return.(fc) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (fc) From St.Basile (Portneuf) to St.Stanislas, St.Adelphe, St.Séverin.St.Narcisse, St.Tite.St.Thècle, St.Prosper, St.Geneviève and St.Timothée, for the transport of cement in bags, on behalf of Ciment Québec Inc.(/) Restricted trucking - long distance -radius - (0 From St.Stanislas and all points located within a radius of 30 miles from the said point, except Trois-Rivières, Shawinigan and Grand'Mère, to other points in the Province, and return, for the moving of household goods.The applicant requests from the Québec Transport Commission an owner's permit for transport by taxicab in the region or Municipality of St.Alban, County of Portneuf.Transfer of ownership of a transport service (sale).Maurice St-Amant requests authorization to transfer to: Bellechasse Transport Inc.7737-V 3600 Hamel Blvd.Québec.Québec, the ownership of the following transport service: Permit No.12446-V : General trucking - St.Alban and vicinity and occasionally from St.Alban to Québec and return, for the transport of goods destined to or originating from St.Alban.Transfer of a transport service (following death).The universal legatee requests authorization to operate the transport service operated by her husband, the late Georges-Etienne Lampron, during his lifetime, to wit: General trucking - long distance - radius -St.Etienne-des-Grès and all points located within a distance of five miles from the limits of said municipality; General trucking - long distance - radius -From St.Etienne-des-Grès to any point located within a radius of 30 miles and return.The applicant requests from the Transport Commission authorization to increase and modify its tariffs according to the clauses of permit No.15384-V for the transport of goods.Any interested person may obtain a copy of the proposed tariffs by applying to the Québec Transport Commission. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4125 Rôle Q-1206 12352-V D-l TF LES DÉMÉNAGEMENTS LAVERGNE ENR.(Jean-Paul Lavergne) 1412, 47ième Rue Shawinigan Cté St-Maurice.P.Q.G9N 5B5 Rôle Q-1207 7148-V D-l TF J.E.ROY INC.126, Commerciale St-Henri Cté Lévis, P.Q.Rôle Q-l208 795-V D-l TF MARCEL MOREL ENR.562, rue Latourelle Québec 4, P.Q.G1R 1E3 Rôle Q-l209 22678-V D-l TF MINGAN TRANSPORT ENR.(Franklin Vibert) Longue Pointe de Mingan, Cté Saguenay, P.Q.Le requérant demande 1 autorisation de The applicant requests authorization to majorer ses taux horaires pour le déménage- increase its hourly rates for local moving in ment local à Shawinigan.Shawinigan.Taux actuels / Present rates Taux proposés / Proposed rates 1 camion 2 hommes $14.00/l'heure 1 camion 1 homme 814.00/1'heure / truck, 2 men 14.00 per hour 1 truck 1 man 14.00 per hour Aide additionnel 4.00/1'heure ch.1 camion 2 hommes 19.00/1'heure Extra man 4.00 per hour each 1 truck S men 19.00 per hour 1 camion 3 hommes 24.00/1'heure 1 truck S men 24.00/per hour 1 camion 4 hommes 29.00/heure / truck 4 men 29.00 per hour Aide additionnel 5.00/heure ch.Extra man 6.00 per hour each La requérante demande à la Commission The applicant requests from the Transport des transports l'autorisation d'augmenter ses Commission authorization to increase its taux actuels, pour le transport de pommes de present rates, for the transport of potatoes on terre pour le compte de Joseph Edmond Roy, behalf of Joseph Edmond Roy, to read as pour qu'ils se lisent comme suit: follows: Pommes de terre / Potatoes Taux par 100 lbs.Minimum Rate per 100 lbs.Minimum De Grand Falls, N.B.à Québec 80.45 45,000 lbs.From Grand Palls.N.B.to Québec De Clair, N.B.à Québec 0.40 45,000 lbs.From Clair, N.B.to Québec Distance de Québec Taux additionnel par 100 lbs.Distance from Québec Extra charge per 100 lbs.là 50 milles /1 to B0 miles «0.05 50 à 100 milles/ 60 to 100 miles 0.10 100 à 150 milles /100 to 150 miles 0.16 150 à 200 milles /150 to 200 miles 0.20 200 et plus /200 miles or over 0.26 Le requérant demande à la Commission The applicant requests from the Transport des transports l'autorisation d'augmenter ses Commission authorization to increase its tarifs de déménagement comme suit : moving rates as follows: Taux actuels / Present rates ABC 1 camion 2 hommes / 1 truck 2 men.$14.00 $19.00 $24.00 1 camion 3 hommes/ 1 truck S men.18.00 26.00 33.50 1 camion 4 hommes // truck 4 men.24.00 34.00 43.00 Camion plus de 20 pieds / Truck exceeding 20 feet in length 1 camion 2 hommes / 1 truck 2 men.18.00 $24.00 830.00 1 camion 3 hommes/ / truck S men.24.00 33.00 42.00 1 camion 4 hommes//truck 4 men.30.00 42.00 54.00 Taux au mille / Rate per mile.0.50 Taux proposés / Proposed rates ABC 1 camion 2 hommes 11 truck 2 men.$18.00 $24.00 830.00 1 camion 3 hommes // truck 3 men.24.00 33.00 42.00 1 camion 4 hommes / / truck 4 men.30.00 42.00 54.00 Aide additionnel / Extra man.7.00 Camion plus de 20 pieds / Truck exceeding 20 feet in length 1 camion 2 hommes/1 truck 2 men.$22.00 $29.00 $36.00 1 camion 3 hommes /1 truck S men.29.00 39.00 50.00 1 camion 4 hommes /1 truck 4 men.36.00 60.00 64.00 Aide additionnelJ Extra man.7.00 Taux au mille / Rate per mile.0.60 du mille parcouru per mile travelled Le requérant demande à la Commission The applicant requests from the Transport des transports l'autorisation d'augmenter ses Commission authorization to increase its tarifs pour le transport de marchandises entre rates for the transport of goods between Min-Mingan et l'aéroport Longue-Pointe-de-Min- gan and Longue-Pointe-de-Mingan Airport, gan, Rivière St-Jean, Magpie et Rivière-au- Rivière St.Jean, Magpie and Rivière-au-Tonnerre.Tonnerre.Le tarif No 2 remplace le tarif No 1.Tariff No.2 replaces tariff No.1.Les intéressés peuvent consulter les nou- Interested parties may consult the new veaux taux en s'adressant à la Commission rates by applying to the Québec Transport des transports du Québec.Commission. 4126 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.33 Rôle Q-1210 Q-52509 D-l TF LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION COOPÉRATIVE DES CAMIONNEURS DE LA CÔTE-NORD 851, Boul.Laflèche Hauterive, Cté Saguenay, P.Q.Dionne.Fortin, Roy, Bégin & Associés Rôle Q-1211 Q-202017 MADAME THÉRÈSE RUEST DUBÊ 59 Bois Sept-Iles Requérant-acheteur Applicant purchaser et / and Q-200045 D-l AUTOBUS SEPT-ÎLES (Robert Nadeau) 270 Ave Joliette Sept-Iles Requérant-vendeur Applicant vendor Rôle Q-1212 2755-A-D-l TAXI GAGNON (1965) INC.70, 30e Rue Ville de Gagnon Cté Duplessis Requérante / Applicant (Dist.-jud.No 97 Québec) Rôle Q-1213 Q-201131 MONSIEUR MAURICE BOUTIN 573, 3e Rue app.1 Chibougamau Rôle Q-1214 73-A D-2 TF AUTOBUS DES BOIS FRANCS LIMITÉE R.R.No 1, C.P.384 Plessisville Cté Mégantic, P.Q.Rôle Q-1215 2908-A D-l TF DOUCET GÉRALD 1301, rue Principale, St-Jean-des-Piles Cté Champlain, P.Q Les Membres de l'Association Coopérative des Camionneurs de la Côte-Nord demandent à la Commission des transports du Québec la fixation de nouveaux taux de transport pour le camionnage en vrac dans la région No 9.Les intéressés peuvent consulter les taux proposés en s'adressant à la Commission des transports du Québec, 585, boul.Charest est.Québec.P.Q.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de Autobus Sept-Iles (Robert Nadeau) portant le No Q-200045 D-l.Modification de permis.Aux fins d'ajouter la clause suivante: Classe de permis : Autobus Service : Transport en commun de Ville de Gagnon à Fire Lake, et retour.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec un permis de propriétaire, pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de Chibougamau A.46.La requérante, détentrice d'un permis pour le transport de passagers par autobus, demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses taux actuels pour les circuits urbains et Cégep.The members of l'Association Coopérative des Camionneurs de la Côte-Nord request from the Québec Transport Commission the fixing of new transport rates for bulk trucking in Region No.9.Interested parties may consult the proposed rates by applying to the Québec Transport Commission, 585 Charest Blvd.East, Québec.P.Q.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in her behalf certificate No.Q-200045 D-l.held by Autobus Sept-Ues (Robert Nadeau).Modification of permit.For the purpose of adding the following clause : Class of permit: Bus Service : Public transport from the Town of Gagnon to Fire Lake, and return.The applicant requests from the Québec Transport Commission an owner's permit for transport by taxicab in the Conglomeration of Chibougamau A.46.The applicant, holder of a permit for the transport of passengers by bus, requests from the Transport Commission authorization to increase its present rates for the urban and the Cegep routes.Taux actuels Present rates 5 billets pour / S tickets for Passage simple / Single fare 6 billets pour / 6 tickets for Passage simple / Single fare Circuit urbain Urban Route S 1.00 Etudiants Students 0.20 1.00 Travaillants Workers 0.20 Circuit CEGEP CEGEP Route 10 passages pour /10 rides for 5.50 Plessisville 10 passages pour /10 rides for 5.00 Prineeville Le requérant demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses taux pour le transport d'étudiants le midi à Ste-Flore et Grand-Mère: Taux actuels $2.60 pour 20 passages Taux proposés $3.00 pour 20 passages Taux proposés Proposed fares 6 billets pour / G tickets for $1.00 Passage simple / Single fare 0.25 6 billets pour / B tickets for 1.00 Passage simple / Single fare 0.25 10 passages pour/lOrides for 6.50 10 passages pour/10 rides for 6.00 The applicant requests from the Transport Commission authorization to increase its rates for the transport of students, at noontime, to St.Flore and Grand'Mère: Present rates $2.50 for 20 tickets Proposed rates 83.00 for 20 tickets GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' armée, n° 22 4127 Rôle Q-1216 2873-V D-2 TF LAMOTHE QUÉBEC INC.209, 9ième Rue Noranda Cté Rouyn-Noranda, P.Q.Rôle Q-1217 9608-V D-l TF MICHAUD VITAL St-Philippe de Néri Cté Kamouraska, P.Q.Rôle Q-1218 245-N D-3 TF AGENCE MARITIME INC.C.P.156, Station « B » Québec 2, P.Q.Rôle Q-1219 150-N D-l TF LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES DU ST-LAURENT INC.126, St-Pierre Québec, P.Q.Rôle Q-1220 Q-500820 MONSIEUR MAURICE MORIN 128 Bellevue Nord St-Lambert Cté Lévis, P.Q.et / and Q-502090 MONSIEUR EDDY MORIN 146 Bellevue St-Lambert Cté Lévis, P.Q.Rôle Q-1221 Q-500234 MONSIEUR VICTOR DUROCHER 120, 4e Rang Prouxville Cté Champlain, P.Q.et / and La requérante demande à la Commission des transports l'autorisation de reviser ses taux actuels pour le service de grues et le déménagement de machinerie.Le tarif No 3 annule le tarif No 2.Les intéressés peuvent consulter les taux à la Commission des transports du Québec.Le requérant demande a la Commission des transports l'autorisation d'augmenter certains de ses tarifs en vertu des clauses de son permis: Taux actuels Present rates 3 0.50 le 100 lbs 0.60 per CWT 0.75 le 100 lbs.0.76 per CWT 1.50 1e 100 lbs.1.60 per CWT 4.50 4-60 3.00 S.00 10.00 de l'heure 10.00 per hour Les autres taux demeurent inchangés.La requérante demande la fixation de taux apparaissant au supplément No 1 du tarif B.C.-S.I.No 9.Les intéressés peuvent consulter les taux à la Commission des transports du Québec.Les membres de l'Association des Propriétaires de Navires du St-Laurent Inc.demandent à la Commission des transports une augmentation de taux pour le transport de bois de pulpe par caboteur pour la saison de navigation 1974.Les intéressés peuvent consulter les taux en s'adressant à la Commission des transports du Québec.Région 3: 12.14 Artisan Cession de la propriété du système de transport (vente).Maurice Morin demande l'autorisation de céder par vente à Eddy Morin 146 Bellevue St-Lambert Cté Lévis, P.Q.la propriété du système de transport suivant: Attestation Q-500820 Personne physique, propriétaire d'un camion depuis le 14 avril 1972 immatriculé au Québec, possédant actuellement un camion Ford 1973 portant le No de série 4818061160633, demande à la Commission de transférer l'attestation Q-500820 à Eddy Morin afin de lui permettre de faire du camionnage en vrac, catégorie « Artisan », dans la région No 3.Région 4l 12.14 Artisan Cession de la propriété du système de tr nsport (vente).Vioior Durocher demande l'autorisation de céder par vente à The applicant requests from the Transport Commission authorization to revise its present rates for crane service and the moving of machinery.The tariff No.3 cancels tariff No.2.Interested parties may consult the rates filed with the Québec Transport Commission.The applicant requests from the Transport Commisson authorization to increase some of its rates according to the clauses of its permit : Taux proposés Proposed rates 80.20 le morceau 0.20 per item 1.25 CWT 1.25 per CWT 2.00 CWT 2.00 per CWT 5.00 6.00 4.00 4.00 20.00 de l'heure 20.00 per hour Epicerie Groceries Veneer Plywood Meubles Furniture Frigidaires Refrigerators Minimum Minimum Local et rayon 30 milles Local and within a radius of 30 miles Other rates remain unchanged.The applicant requests the fixation of rates appearing in Supplement No.1 to tariff B.C.-S.I.No.9.Interested parties may consult the rates filed with the Québec Transport Commis- The members of l'Association des Propriétaires de Navires du St-Laurent Inc.requests from the Transport Commission an increase in rates for the transport of pulpwood by coaster, for the 1974 navigation season.Interested parties may consult the rates by applying to Québec Transport Commission.Region 3: 12.14 Artisan Transfer of ownership of a transport system (sale).Maurice Morin requests authorization to transfer, by sale, to Eddy Morin 146 Bellevue St.Lambert County of Levis, P.Q.the ownership of the following transport system : Certificate Q-500820 Natural person, owner, since April 14,1972, of a truck registered in Québec, and presently the owner of a 1963 \"Ford\" truck bearing serial No.4818061160633, requests the Commission to transfer certificate Q-500820 to Mr.Eddy Morin, in order to enable the latter to operate a bulk transport service, Artisan class, in region No.3.Region 4: 12.14 Aftisan Transfer of the ownership of a transport service (sale).Mr.Victor Durocher requests authorization to transfer by sale to 4128 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Q-502084 MONSIEUR ROGER ST-CYR 501, Principale Batiscan Cté Champlain, P.Q.Rôle Q-1222 1441-A-D-l AUTOBUS SEPT-ÎLES LTEE 270, Joliette Sept-Ues Cté Mingan, P.Q.(Dist.-jud.No 99 Québec) Rôle Q-1223 10207-V-D-3 TESSIER & FILS LTÉE 4 rue Lavallée C.P.1390 Baie-Comeau (Saguenay) Rôle Q-1224 23790-V-D-l JEAN-MARIE DUPUIS 30 ave.Lepage-Sud Aima (Lac St-Jean-Est) Roger St-Cyr 501, Principale Batiscan Cté Champlain, P.Q.la propriété du système de transport suivant: Attestation Q-500234 Personne physique, propriétaire d'un camion depuis le 14 avril 1972 immatriculé au Québec, possédant actuellement un camion Mercury 1965 portant le No de série 1417516L205359H, demande à la Commission de transférer l'attestation Q-500234 à Roger St-Cyr afin de lui permettre de faire du camionnage en vrac, catégorie « Artisan n dans la région No 4.Modification de permis.Modification du permis 1441-A pour que les services 1, 2 et 3 se lisent à l'avenir comme suit: Classe de permis: Autobus Service 1: a) Service interurbain: Baie-Comeau -Hauterive, et points intermédiaires, et retour.6) Service urbain à l'intérieur de la ville de Hauterive.Selon les parcours, horaire et tarif déposés.Service 2: De Sept-Iles à Baie-Comeau et points intermédiaires, et retour.Parcours à suivre : Route 138 et les villes et municipalités suivantes : Baie-Comeau, Franquelin, Godbout, Baie-Trinité, Ilets-Caribou, Pointe-aux-Anglais, Pentecôte, Port-Cartier, Ecores, Ste-Mar-guerite, Clarke City, Baie-des-Sept-Ues et Sept-Iles.Terminus: Baie-Comeau et Sept-Iles: subordonnés aux règlements municipaux.Service 3: De Baie-Comeau au site de Manicouagan 3 avec droit de desservir les points intermédiaires, et sur demande, au site de Manicouagan 5 et au-delà, avec droit de desservir les points intermédiaires, et retour.Terminus: 1.Baie-Comeau selon entente avec les autorités municipales.2.Manicouagan 3 selon entente avec Hydro-Québec.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De Chute-aux-Outardes à Hauterive, Baie-Comeau.Port-Cartier et Sept-Iles, et retour avec marchandises avariées ou refusées, pour le transport de bois ouvré, pour le compte de La Scierie Manicouagan Inc.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint - service local - contrat- Aima et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite cité, pour le transport de petits colis, pour le compte de la compagnie Bell Téléphone.Roger St-Cyr 501 Principale Batiscan County of Champlain, P.Q.the ownership of the following transport service : Certificate Q-500234 Natural person, owner, since April 14, 1972, of a truck registered in Québec, and presently the owner of a 1965 \"Mercurv\" truck bearing serial number 1417516L205359H, requests the Commission to transfer certificate Q-500234 to Mr.Roger St-Cyr, in order to enable the latter to operate a bulk trucking service, Artisan class, in region No.4.Modification of permit.Modification of permit 1441-A so that services 1, 2, and 3 may read henceforth as follows: Class of permit: Bus Service 1: (a) Inter-urban service: Baie-Comeau -Hauterive, and intermediate points, and return.(6) Urban service within the limits of the Town of Hauterive.According to routes, schedule and tariff filed.Service 2: From Sept-Ues to Baie-Comeau and intermediate points, and return.Routes: Highway 138 and the following Towns and Municipalities: Baie-Comeau, Franquelin, Godbout, Baie-Trinité.Ilets-Caribou, Pointe-aux-Anglais, Pentecôte, Port-Cartier, Ecores, Ste.Marguerite, Clarke City, Baie-des-Sept-Iles and Sept-Iles.Terminal : Baie-Comeau and Sept-Iles: subject to municipal by-laws.Service 3: From Baie-Comeau to Manicouagan 3 with the right to serve intermediate points, and on requests, to Manicouagan 5 and beyond, with the right to serve intermediate points and return.Terminal : (1) Baie-Comeau as per agreement with municipal authorities.(2) Manicouagan 3 as per agreement with Hydro-Québec.Modification of permit.The applicant requests that the following service be added to its permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Chute-aux-Outardes to Hauterive, Baie-Comeau, Port-Cartier and Sept-Ues, and return, with damaged or returned goods, for the transport of worked timber, on behalf of La Scierie Manicouagan Inc.Application for a permit.The applicant requests the following transport permit: Restricted trucking - local service - contract - From Alma to all points located within a radius of 5 miles from the limits of said City, ÏmST of parcel8'on *** GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4129 Rôle Q-1225 8316-V-D-l ANTONIO CÔTÉ 1163 boul.Lefebvre St-Félicien (LacSt-Jean-Ouest) et / and GASTON TREMBLAY 1167 boul.Lefebvre St-Félicien (Lac St-Jean-Ouest) Rôle M-2018 22130-V D-l CAMLEX TRANSPORT INC.46 rue Milton Ville St-Pierre, Lachine 645, Que.Rôle M-2019 1551-V D-l SPEEDY CARTAGE CO.(Harry Migicovsky) 5316, St-Dominique Montréal, P.Québec Requérant-vendeur Applicant vendor 12191-V IRVING SCULNICK & SONS INC.700, Montée de Liesse Ville St-Laurent Montréal, P.Québec Requérant-acquéreur Applicant purchaser Rôle M-2021 20581-V D-l MR.ARTHUR GISI 54 Forest Ave.Leamington, Ont.Cession de la propriété du système de transport (vente).Antonio Côté demande l'autorisation de céder à: Gaston Tremblay 1167 boul.Lefebvre St-Félicien (Lac St-Jean-Ouest) la propriété du système de transport suivant: Permis No 8316-V: Transport général - service local - St-Félicien et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites dudit endroit; Transport général - longue distance - rayon De St-Félicien à tous les endroits sur un rayon de 30 milles, et retour; Transport général - longue distance - rayon De St-Félicien à ailleurs dans les districts électoraux-provinciaux de Chicoutimi, Du-buc, Jonquière-Kénogami, Roberval et Lac St-Jean, et retour.La requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation de donner le service suivant: a) Transport général - service local - a) Ville St-Pierre et tous les points situés dans un rayon de 5 milles des limites de ladite municipalité.b) Transport général - longue distance -rayon - b) De Ville St-Pierre à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite ville, et retour.Ce permis est demandé en substitution des clauses a et b du permis autrefois détenu par Camlex Transport Inc.et qui sont résiduaires après le transfert des clauses d'explosifs en faveur de C.I.Whitten Transfer (Québec) Inc.Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation de céder à la compagnie: Irving Scul-nick & Sons Inc.(12191-V) la propriété du système de transport suivant: Permis 1551-V a) Transport général - local - a) Montréal et toute les localités situées à une distance ne dépassant pas 5 milles de limites de ladite ville.b) Transport général - long distance - b) De Montréal à toutes les localités situées dans un rayon de 30 milles des limites de ladite ville.Transfert de permis: Arthur Gisi demande l'autorisation de céder à: Agostino Migliore, requérant-acquéreur, 46, ave Penhurst, app.1, Toronto, Ont.le service de transport suivant, conformément auxdisposîtons de l'article 36 de la Loi des transports.Permis No 20581-V Transport restreint - longue distance -rayon - De la frontière Québec-Ontario (postes douanier: Rivière-Beaudette, Pointe-Fortune et Grenville) à toutes les localités situées au Québec, à l'exception de St-Rémi-de-Na-pierville, pour le transport de fruits et de Transfer of the ownership of a transportation service (sale).Mr.Antonio Côté requests the authorization to transfer to: Gaston Tremblay 1167 Lefebvre Blvd.St-Félicien (Lake St.John-West) the ownership of the following transport service : Permit No.8316-V: General trucking - local service \u2014 St.Félicien and all points located within a radius of 5 miles from the limits of said Town; General trucking - long distance - radius -From St.Félicien to all points located within a radius of 30 miles, and return; General trucking - long distance - radius -From St.Félicien to the Provincial Electoral Districts of: Chicoutimi, Dubuc, Jon-quière-Kéuogami, Roberval and Lake St.John, and return.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following service: (o) General trucking-local service- (a) Town of St.Pierre and all points located within a radius of 5 miles from the limits of said Municipality.(b) Genera! trucking - long distance - radius - (b) From the Town of St.Pierre to all points located within a radius of 30 miles from the limits of said Town, and return.This permit is requested to replace clauses a and b of the permit formerly held by Camlex Transport Inc., and which remain following the transfer, to C.I.Whitten Transfer (Québec) Inc., of the clauses pertaining to explosives.Transfer of ownership of a transportation service (sale).The applicant requests authorization to transfer to: Irving Sculnick & Sons Inc.(12191-V) the ownership of the following transportation service : Permit: 1551-V (a) General trucking - local - (o) Montreal and all localities situated within a distance of 6 miles from the limits of said City (b) General trucking - long distance - (b) From Montreal to all localities situated within a radius of 30 miles from the Hmits of said City.Transfer of the permit: Arthur Gisi requests the authorization to transfer to : Agostino Migliore, applicant purchaser 46 Penhurst Ave., Apt.1, Toronto, Ont.the following transport in accordance with the stipulations of the article 36 of the Transport Act.Permit No.20581-V Restricted trucking - long distance - radius - From the Québec-Ontario border (ports of entry: Rivière-Beaudette, Pointe-Fortune and Grenville) to all localities situated in the province of Québec, excepted St.Rérai-de-Napierville, for the transportation of fresh 4130 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.SS Rôle M-2022 22130-V D-3 CAMLEX TRANSPORT INC.46, rue Milton Ville St-Pierre, Que.Rôle M-2023 21947-V D-l NORMAND BÉLANGER 515,rue Laneur Ville LaSalle, P.Que.Rôle M-2024 23765-V D-l MONSIEUR REAL ROGER 1566.rue Laforest Ville Lemoyne, Que.légumes frais (à l'exception des fruits et des légumes en conserves ou congelés), et retour avec les contenants vides usagés seulement ; points d'origine ou de destination: localités situées dans les comtés suivants: Essex, Kent et Lambton (Ont.).Restriction : Ce permis est délivré en conjonction avec le permis complémentaire No X-1360 en date du 13 septembre 1973, délivré par l'Ontario Highway Transport Board.Modification de permis (droit additionnel) La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis, le service suivant: Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - De Lachine à tous les points situés dans un rayon de 200 milles, et retour, pour le transport d'équipement, outillage, accessoires, etc.utilisés sur les chantiers de construction du Dominion Bridge Co.Ltd.et pour le compte de cette compagnie, à l'exclusion des matériaux de construction.Restriction : Le transport autorisé par la présente clause est restreint à l'usage de petits camions à ridelles seulement, à l'exclusion de tracteurs et remorques.Le requérant dont la clause c de son permis se lit comme suit: Classe: c) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat \u2014 Service: c) De Montréal à tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 125 milles des limites de ladite ville, et retour, (à l'exclusion des endroits compris dans le rayon de 30 milles, tel que couvert par la clause b).pour le transport de meubles antiques ou reproductions d'antiquités, pour le compte de Fraser Bros.Limited.demande à ce que cette clause se lise à l'avenir comme suit: Classe: Transport restreint - longue distance -rayon - contrat -Service: De Montréal à tous les endroits situés sur une distance de 200 milles des limites de ladite ville, et retour (à l'exclusion des endroits dans le comté de Montmagny), pour le transport de meubles antiques ou reproductions d'antiquités, pour le compte de Fraser Bros.Limited.Nouvelle demande de permis: La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner aux conditions réglementaires, les services de transport suivants: a) Transport restreint - service local -contrat \u2014 a) Montréal et toutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de la ladite ville.b) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - b) De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles de cette localité, et retour.fruits and vegetables (excluding canned and/or frozen fruits and vegetables), and return with empty used containers oniy-origin or destination: points in the Counties of Essex, Kent and Lambton, Ont.Restriction: This permit is issued in conjunction with the complementary permit No.X-1360 dated September 13, 1973 of the Ontario Highway Transport Board.Modification of permit (additional right).The applicant requests the Commission to add the following service to its permit: Restricted trucking - long distance -radius - contract - From Lachine to all points located within a radius of 200 miles, and return, for the transport of machinery, equipment, parts, etc.utilized on the construction sites of Dominion Bridge Co.Ltd.and on behalf of said Company, except for building materials.Restriction: The transport authorized by the present clause shall be restricted to the utilization of small stake trucks only, excluding tractors and trailers.The applicant, who holds a permit in which clause c read as follows: Class: (c) Restricted trucking - long distance -radius - contract - Service: (c) From Montreal to all points not beyond 125 miles from the limits of said City, and return, (except points included in the 30-mile radius covered by clause 5, for the transport of antique furniture or reproductions thereof, on behalf of Fraser Bros.Limited.requests that said clause read henceforth as follows: Class: Restricted transport - long distance -radius - contract \u2014 Service: From Montreal to all points located over a distance of 200 miles from the limits of said City, and return (except for points in the County of Montmagny), for the transport of antique furniture or reproductions thereof, on behalf of Fraeer Bros.Limited.New application a permit: The applicant requests to the Commission authorization to provide, under the prescribed conditions, the following transport services: (a) Restricted trucking - local service -contract \u2014 (a) Montreal and all localities situated within a distance of 5 miles from the limits of said City.(b) Restricted trucking - long distance -radius - contract \u2014 (b) From Montreal to all point located within a radius of 30 miles from this Locality, and return. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n\" 22 4131 Rôle M-2025 11237-V D-l W.MOSES INC.1667, rue Cabot Montréal 205, Que.Rôle M-2026 11217-V D-3 ATOMIC TRUCK CARTAGE LTD.400, rue Norman Ville St-Pierre, Montréal 645, Que.c) Transport restreint - longue distance -territoire - c) De Montréal à tousles pointssituésdans la province de Québec, et retour.d) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - d) De Montréal à la frontière Québec-Ontario (tous les ports d'entrée), à destination des points de l'Ontario à l'est de la route 29 circulant de Brockville à Arnprior.Dans Ions les cas, pour le transport de meubles neufs et usagés, et retour avec marchandises refusées et avariées pour le compte des marchands et fabricants suivants: E.Bouthillier inc.Entreprises Maisonneuve inc.Livrairie Boulevard inc.Meubles & Equipements Mespar ltée Mobilier Lucerne inc.Salem Furniture Reg'd.Cession des clauses a et o de la propriété du système de transport (vente).W.Moses Inc.demande l'autorisation de céder à: Zéphirin Lyonnais, requérant-acquéreur 4326, rue Parthenais Montréal, Que.la propriété des clauses a et b du système de transport suivant, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi des transports.Permis No 11237-V.a) Transport général - service local - a) Verdun et toutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville.b) Transport général - longue distance -ravon - b) De Verdun à toutes les localités situées dans un rayon de 30 milles des limites de ladite ville, et retour.Si le transfert des clauses a et b est accordé, la requérante-venderesse, continuera d'opérer les clauses c à g incl.de son permis.Modification de permis (droits additionnels) .La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis, les services suivants: 1.Transport restreint - longue distance -rayon - 1.De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de 300 milles, et retour, pour le transport de matériaux de construction, pour le public en général.2.Transport restreint - longue distance -route restreinte - 2.De Montréal aux frontières Québec-Ontario (tous ports d'entrée) à destination de tous les points de l'Ontario, et retour, pour le transport de matériaux de construction pour le public en général.3.Transport restreint - longue distance -route restreinte - 3.De Montréal aux frontières Québec-Etats-Unis (tous ports d'entrée) à destination des états de New York, New Jersey, Maryland, Washington D.C.Maine, Ver-mont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Pennsylvanie, et retour, pour le transport de matériaux de construction, pour le public en général.(c) Restricted trucking - long distance -territory - (c) From Montreal to all points located in the Province of Québec and retunr, (d) Restricted trucking - long distance -restricted route - (d) From Montreal to the Québec-Ontario Border (any port of entry), final destination: points in Ontario lying east of Highway 29, which runs from Brockville to Arnprior.In all cases, for the transport of household goods, and return with refused and damaged goods, on behalf of the following merchants and manufacturers: E.Bouthillier inc.Entreprises Maisonneuve inc.Librairie Boulevard inc.Meubles & Equipements Mespar ltée Mobilier Lucerne inc.Salem Furniture Reg'd.Transfer of the ownership of clauses o and 6 of a transport service (sale) W.Moses Inc.requests authorization to transfer to: Zéphirin Lyonnais applicant purchaser 4326 Parthenais Street Montreal.P.Q.the ownership of clauses a and b of the following transport service, in conformitv with the provisions of section 36 of the Transport Act.Permit number 11237-V (a) General trucking - local service - (a) Verdun and all localities situated within a distance of five miles from the limits of said City.(6) General trucking - long distance -radius- (b) From Verdun to all localities situated within a radius of 30 miles from the limits of said City, and return.If the transfer of clauses a and b is granted, the applicant vendor shall continue to operate clauses c to g inclusive of its permit.Modification of permit (additional right) The applicant requests the Commission to add the following services to its permit: 1.Restricted trucking - long distance -radius - 1.From Montreal to all points located within a radius of 300 miles, and return, for the transport of building materials, for the public at large.2.Restricted trucking - long distance -restricted route - 2.From Montreal to the Québec - Ontario border (any port of entry), destination: all points of Ontario, and return, for the transport of building materials for the public at large.3.Restricted trucking - long distance - restricted route - 3.From Montreal to the Québec - United States border (any port of entry), destination: the following States: New York, New Jersey, Maryland, Washington, D.C., Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Pennsylvania, and return, for the transport of building materials, for the public at large. 4132 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Rôle M-2027 22104-V D-2 CAPITOL TRUCK LINES INC.2500, Alamenda St., Compton, California, U.S.A.Adresse au Québec: 11242, boul.Gouin Montréal 477.P.Québec Rôle M-2028 23814-V D-l REAL GRÉGOIRE 84, rue Principale St-Jacques-le-Mineur, P.Que.Rôle M-2029 17396-V D-l RICHELIEU MILK TRANSPORT INC.400, boul.Richelieu Richelieu Cté Rouville, Que.La partie requérante, dont la clause a se lit comme suit: a) Transport restreint - longue distance -route restreinte - véhicule citerne - spécial - a) De Montréal à la frontière Québec-Etats-Unis (postes douaniers: Highgate Springs, VT., et Rouses Point, New-York) pour le transport de gaz naturel liquéfié, dans ses remorques citernes à double coque (destination: Boston, Massachusetts).Restriction : Ce permis ne sera utilisé qu'avec un certificat complémentaire qui doit être délivré par ri.C.C., et que la requérante devra déposer auprès de la Commission avant le 30 avril 1973.demande h la Commission que cette dernière clause se lise dorénavant comme suit: a) Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte - réservoirs spécialisés -a) Service: De Montréal aux frontières Québec-Etats-Unis (tout poste douanier), pour le transport de gaz naturel liquéfié, dans des semi-remorques à double coque, destination: tous les points aux Etats-Unis.Remarques: Ladite clause devra encore être exploitée en conjonction avec un permis complémentaire approprié qui doit être délivré par ri.c.c.En plus, la requérante demande, que.dans la restriction, la date limite à laquelle elle doit fournir à la commission un permis complémentaire de 1T.C.C., soit le 30 avril 1973, soit reportée au 31 décembre 1974.La partie requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir le droit de donner, les services de transport suivants : Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte -Service : De St-Jacques à St-Hyacinthe et Bedford et retour: pour le transport de grains et moulée en vrac avec camion muni d'une souffleuse pour le public en général.Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte -Service : De Montréal à St-Hvacinthe et Bedford et retour; pour le transport de grains et moulée en vrac avec camion muni d'une souffleuse pour le public en général.La partie requérante, dont la clause e du permis se lit comme suit: e) Transport restreint - longue distance -rayon - citerne - e) De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de 200 milles de ladite ville, et retour, pour le transport, par camion citerne, de gazoline, huile légère, huile lourde, kérosène et asphalte liquide pour le public en général.demande à la Commission d'étendre son rayon d'action comme suit: e) Transport restreint - longue distance -rayon - citerne - e) De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de 500 milles de ladite ville, et retour, pour le transport, par camion citerne, de gazoline, huile légère, huile lourde, kérosène et asphalte liquide pour le public en général.The applicant, clause o of whose permit reads as follows: ,.(a) Restricted trucking-long distance- restricted route-specialized tank unit - (a) From Montreal to the Québec-U^tJ.border (ports of exit : Highgate Springs, \\ .T., and Rouses Point, N.Y.) for the transportation of liquified natural gas, in vacuum jacketed tank trailers (destination: Boston, Mass.).Restriction: This permit shall bo utilized solely in conjunction with a complementary certificate to be issued by the I.C.C.that the applicant will be required to file with the Board before April 30tb, 1973.requests from the Commission that the latter clause read henceforth as follows: (a) Class: Restricted trucking - long distance - restricted route - special tank -(a) Service: From Montreal to the Quebec-United States border (ports of entry) for the transport of liquified natural gas, in vacuum-jacketed semi-trailers destinations: all points in the United States.Notes: Said clause shall be operated in conjunction with a complementary permit to be issued by the I.C.C.Moreover, the applicant requests that the deadline for filin/; with the Commission a complementary permit from the I.C.C, namely April 30, 1973, be postponed until December 31, 1974.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following transport services: Restricted trucking - long distance - restricted route -Service: From St.Jacques to St.Hyacinthe and Bedford and return; for the transport of grain and feed (meal) in bulk by truck equipped with a blower, for the public at large.Class: Restricted trucking - long distance - restricted route -Service: From Montreal to St.Hyacinthe and Bedford and return; fro the transport of grain and feed (meal) in bulk by truck equipped with a blower, for the public at large.The applicant, which holds a permit of which clause e reads as follows: (c) Restricted trucking - long distance -radius - tank - (e) From Montreal to all points located within a radius of 200 miles from said City, and return, for the transport of gasoiine, light oil, heavy oil, kerosene and liquid asphalt, by tank truck, for the public at large-requests the Commission to extend its radius of operation as follows: (e) Restricted trucking - long distance -radius - tank - (e) From Montreal to all points located within a radius of 500 miles from said City, and return, for the transport of gasoline, light oil, heavy oil, kerosene and liquid asphalt, by tank truck, for the public at large GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106- année, n° SS 4133 Rôle M-2030 14470-V D-2 ACTIVE CARTACE LIMITED 1065, Martin Grove Road Rexdale, Ontario Au Québec: 4848, rue Dunn Montréal, P.Québec Rôle M-2031 23758-V D-l MONSIEUR RAYMOND DUMONT 348, 4e Rue Ile Perrot, Que.Rôle M-2032 14995-V D-l WINDSOR WOOD CHIPS COMPANY LTD.217 A, rue Principale Windsor (Richmond), Que.La requérante demande l'autorisation de donner les services suivants: Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte -Service: De la frontière Québec-Ontario (poste douanier: Rivière-Beaudette) en transit à travers ta province de Québec jusqu'à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (tout poste douanier) ; pour le transport d'acier provenant de points situés aux Etats-Unis, et qui a été ou sera transporté en transit à travers l'Ontario, et retour, (Destinations ou points d'origine : points dans les provinces suivantes : Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, l'Ile du Prince-Edouard et Terre-Neuve.Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte -Service : De la frontière Québec-Ontario (poste douanier: Rivière-Beaudette) en transit à travers la province de Québec jusqu'à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (tout poste douanier): pour le transport d'acier, de tuyaux, de poteaux en métal et en béton précontraint: origine: points autorisés dans la province de l'Ontario; destination: points situés dans les provinces suivantes : Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile du Prince-Edouard et Terre-Neuve.Restrictions: Ce permis sera exploité avec le certificat No MC-116770 délivré par l'Interstate Commerce Commission, sous sa forme modifiée, avec et le permis No X-179 de l'Ontario Highway Transport Board, sous sa forme modifiée.Remarque: Si un tel permis est accordé, le requérant devra, de plus, soumettre à la Commission des permis complémentaires à être émis par les autorités des Provinces Maritimes concernées.Nouvelle demande de permis: La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - circuit - De Montréal à la frontière Québec-Ontario (port de sortie: Pointe-Fortune) à Hawkes-bury et Ottawa, et retour, via le port d'entrée de Hull, à Hull et Grenville, ainsi que les points intermédiaires situés sur la route 8 entre Hull et Grenville, ainsi qu'à Dorion et Montréal, via routes 17 et 2, pour le transport de journaux, pour le compte de The Gazette, Sunday Express et Guy Barailhé -Agent Montréal Matin.Cession de la propriété du système de transport (vente).Windsor Wood Chips Company Ltd.demande l'autorisation de céder à: R.B.D.Transport Inc.Requérant-acquéreur 217A, rue Principale Windsor (Richmond), Que.la propriété du système de transport suivant, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi des transports.Permis No 14695-V Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De Rivière-du-Loupetl'Isle Verte.Québec, aux frontières Québec - Etats-Unis (ports d'en- The applicant wishes to be authorized to give the following services: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route -Service: From the Québec - Ontario border (port of entry: Rivière-Beaudette), in transit through the Province of Québec, to the Quebec - New-Brunswick border (all ports of entry) ; for the transportation of steel originating from points in the United-States, and which has been or shall be brought in transit through the Province of Ontario, and return.(Destinations or Origins: Points in the Province of New-Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, and Newfoundland.Class: Restricted trucking - long distance - restricted route -Service: From the Québec - Ontario border (port of entry: Rivière-Beaudette) in transit through the Province of Québec, to the Quebec - New-Brunswick border (all ports of entry): for the transportation of steel, pipe, metal and prestressed concrete pole; originating at points as authorized in the Province of Ontario and destined to points in the Provinces of New-Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island and Newfoundland; and return.Restriction : This permit is to be operated in conjunction with Interstate Commerce Commission certificate No.MC-116770 as amended and Ontario Highway Transport Board permit No.X-179 as amended.Note: However, if this permit is granted, the applicant shall file with the Commission complementary permits issued by the authorities of the Maritimes Provinces concerned.New application for a permit: The applicant requests from the Commission authorization to provide, under the prescribed conditions, the following transport service: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - route - From Montreal to the Québec - Ontario border (port of exit: Pointe-Fortune) to Hawkesbury and Ottawa, and return, via port of entrv of Hull, to Hull and Grenville.and also the intermediate points located on Highway 8 between Hull and Grenville, and also to Dorion and Montreal, via Highway 17 and 2.for the transport of newspapers, on behalf of The Gazette.Sunday Express and Guy Barailhé.agent for Montreal Matin.Transfer of ownership of a transportation service (sale).Windsor Wood Chips Company Ltd.requests authorization to transfer to: R.B.D.Transport Inc.Applicant purchaser 217A Principale Street Windsor (Richmond).Que.the ownership of the following transport service, in conformity with the provisions of section 36 the Transport Act.Permit number 14595-V Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Rivière-du-Loup and l'lsle Verte, Québec, to the Québec - United States 4134 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Rôle M-2033 22933-V D-l MORGAN DRIVE AWAY INC.2.800 Lexington Ave.West Elkart, Indiana 46514, U.S.A Au Québec: 190 Willowdale No 307 Montréal 257, P.Que.tree: Rock Island.Stanhope et Lacolle) pour le transport de tourbe (peat moss) pour le compte de Valfei Peat Moss, Coaticook, Quebec.(Cette marchandise est exempte des règlements de l'Interstate Commerce Commission).La requérante désire être autorisée à donner les services suivants: Classe 1: 1.Transport restreint - longue distance -rayon - Service: 1.De la frontière Québec-Etats-Unis (tout poste douanier) à tous les points situés au Québec: pour le remorquage, au moyen de service de transport avec chauffeur (drive-away), de transport par camion (truck-away) ou de transport par remorquage (towaway) lors de leur déplacement initiai ou ultérieur, de remorques destinées a être tirées par des véhicules de promenade, de roulottes, de maisons mobiles, de bâtiments ou parties de bâtiments préfabriqués, entiers, démontés ou sectionnés, comprenant l'équipement et les matériaux rattachés à la construction et au parachèvement de ces bâtiments, Icrsque leur transport coïncide avec le déplacement de ces derniers, de véhicules récréatifs, de campeurs, de voitures de camping, de maisons motorisées et d'abris mobiles, sur leurs propres roues ou sur des systèmes de roues indépendants fournis par les expéditeurs de ces marchandises.Classe 2: 2.Transport restreint - longue distance -rayon - Service: 2.De la frontière Québec-Ontario (tout poste douanier) à tous les points situés au Québec, pour le remorquage, au moyen de services de transport avec chauffeur (dri ve-away ).de transport par camion (truckaway) ou de transport par remorquage (towaway) lors de leur déplacement initial ou ultérieur, de remorques destinées à être tirées par des véhicules de promenade, de roulottes, de maisons mobiles, de bâtiments ou parties de bâtiment préfabriqués, entiers, démontés ou sectionnés, comprenant l'équipement et les matériaux rattachés à la construction et au parachèvement de ces bâtiments, lorsque leur transport coïncide avec le déplacement de ces derniers, de véhicules récréatifs, de campeurs, de voitures de camping, de maisons motorisées et d'abris mobiles, sur leurs propres roues ou sur des systèmes de roues indépendants fournis par les expéditeurs de ces marchandises; ces marchandises provenant des Etats-Unis et ayant été tirées en transit à travers la province de l'Ontario.Restrictions: 1.Le service oi-dessus mentionné devra être exploité aveo le certificat No MC-103993 et les documents « subs » y annexés et délivrés par l'Interstate Commerce Commission des Etats-Unis.2.Le service ci-dessus mentionné devra être exploité avec un certificat « en transit » qui doit être délivré par l'Ontario Highway Transport Board et être déposé auprès de la Commission des transports du Québec.3.Pour obtenir ce permis, le détenteur uevra se procurer des plaques amovibles C.T.devant être utilisées suivant les conditions applicables à ces plaques \u2022 C.T.\u2022 amovibles.border, (ports of entry: Rock Island, Stanhope and Lacolle) for the transport of peat moss on behalf of Valfei Peat Moss, Coaticook, Québec.(This merchandise shall be exempt from Interstate Commerce Commission regulations) .The applicant wishes to be authorized to give the following services: Class 1 : ,, , .1.Restricted trucking - long distance -ra- 'Service: 1.From the Quebec-United States border (all ports of entry) to all points in the Province of Québec; for the haulage, in drive-away, truckaway and/or towaway service, on their initial or secondary movements, of trailers designed to be drawn by passenger automobiles, house trailers, /nobile homes, buildings or sections of building», prefabricated, complete, knocked down or in sections, including equipment and materials incidental to the erection and completion of such buildings when transported therewith, recreational vehicles, campers, camp coaches, motorhomes and portable shelters, on their own wheels or on wheel systems supplied by the shippers of such commodities.Class 2: 2.Restricted trucking - long distance - radius Service: 2.From the Québec-Ontario border (all ports of entry) to all points in the Province of Québec, for the haulage, in drive-away, truckaway and/or towaway service, on their initial or secondary movements, of trailers designed to be drawn by passenger automobiles, house trailers, mobile homes, buildings, or sections of buildings, prefabricated, complete, knocked down or in sections, including equipment and materials incidental to the erection and completion of such buildings when transported therewith, recreational vehicles, campers, camp coaches, motorhomes and portable shelters, on their own wheels or on wheel systems supplied by the shippers of such commodities ; originating at the United-States and which has been hauled in transit through the Province of Ontario.Restrictions: 1.The above mentioned service is to be operated in conjunction with a certificate No.MC-103993 and subs attached thereto and issued by the Interstate Commerce Commission of the United States.2.The above mentioned service is to be operated in conjunction with an \"In Transit\" Certificate to be issued by the Ontario Highway Transport Board and which must be filed with the Québec Transport Commission.3.The permit is subject to the holder obtaining each year C.T.revolving plates to be used under the conditions applicable to such C.T.revolving plates. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n1 22 4135 Rôle M-2034 23669-V D-l NEWBURY TRANSPORT & SUPPLIES LIMITED P.O.Box 9 Haggarty street Newbury, Ontario Rôle M-2035 418-V D-l ANTONIO GOYEJTE TRANSPORT LTÉE 1, Avenue Antonio-Goyette, B.P.88 Ste-Martine (Châteauguay), Que.Rôle M-2036 18738-V D-l RACINE TRANSPORT ENRG.(Jean, Denis, Paul, Laurier, Georges & Fernand, opérant sous le nom de / operating under the name of) 200, rue Cartier Granby, (Shefford), Que.Rôle M-2037 18483-V D-l-TF COMPTOIR DES CULTIVATEURS ENRG.360 Brière St-Jérôme Cté Terrebonne, P.Que.Rôle M-2038 1558-V D-l TF C.BARBER CARTAGE LTD.425, Boul.Guimond Longueuil, P.Q.Rôle M-2039 16023-V D-4 TF HOWELL FORWARDING QUÉBEC LIMITED 8321 Royden Road Montréal, P.Q.H4P 2J8 La requérante désire obtenir l'autorisation de donner le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - véhicule isotherme - De la frontière Québec-Etats-Unis (tous les postes douaniers) à toutes les localités situées dans la province de Québec, pour le transport d'emballages-cadeaux de fruits, de fleurs coupées, de fougère et de plantes à feuillage, dans des véhicules isothermes, pour les marchands en général.(Points d'origine des marchandises: Etat de la Floride, E.-U.) Conditions: 1.Les marchandises ci-dessus mentionnées sont exemptées des règlements de l'Interstate Commerce Commission et aucun certificat ou permis ne sera délivré par ladite Commission.2.Les véhicules utilisés pour le transport de la marchandise ci-dessus mentionnée devront être immatriculés en bonne et due forme dans la province de Québec et auprès de la Commission des transports.Modification de permis (droit additionnel).La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis, le service suivant : Transport restreint - longue distance -route restreinte - De la frontière Québec-Ontario (tous ports d'entrée) à Ste-Martine et dans un rayon de 200 milles des limites de ladite municipalité et retour pour le transport de marchandises originant de ou destinées à H.J.Heinz Company of Canada Ltd., Leamington, Ont.Modification de permis (droit additionnel) La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis, le service suivant: Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - De Montréal à toutes les localités situées dans un rayon de 300 milles des limites de ladite ville, pour le transport de farine en vrac par camion citerne muni d'une souffleuse pour le compte de Farine Phénix Limitée.Demandons une augmentation de 80.10 la poche de 100 lbs de farine.Représentant environ 28% et 33% selon les distances pour le compte de: Maple Leaf Mills Limited Ogilvie Flour Mills Limited Robin Hood Flour Mills Limited.Demande d'augmentation de taux horaires pour service local sur le déménagement et autres genres de service.Augmentation approximative de 20%.Modification au Tarif 15 de Howell Forwarding 1.Augmentation de 5i le cent livres sur les taux de cueillette à Montréal.2.Augmentation d'environ 9% sur les taux: a) De Marchandise générale b) D'exceptions c) D'espèces vers l'Ouest Canadien The applicant wishes to obtain the right to give the following transportation service: Restricted Trucking - long distance - restricted route - insulated unit \u2014 From the Quebec-United States border (all ports of entry) to all localities situated in the Province of Québec, for the transportation of gift fruit packs, cut flowers, fern and foliage plants, with insulated units, for merchants in general.(Origin of the goods: the State of Florida, U.S.A.) Conditions : 1.The above mentioned goods are exempt from regulations under the Interstate Commerce Commission Act and no certificate or permit is issued by the said Commission.2.Vehicles utilized for the transportation of the above mentioned goods must be fully registered with the Province of Québec and with the Transport Commission.Modification of permit (additional right) The applicant requests the Commission to add the following service to its permit: Restricted trucking-long distance-restricted route - From the Québec-Ontario border (any port of entry) to Ste.Martine and within a radius of 200 miles from the limits of said Municipality, and return, for the transport of goods originating from or shipped to H.J.Heinz Company of Canada Ltd., Leamington, Ont.Modification of permit (additional right) The applicant requests the Commission to add the following service to its permit: Restricted trucking - long distance - radius - contract \u2014 From Montreal to all localities situated within a radius of 300 miles from the limits of said City, for the transport of flour in bulk, by tank truck equipped with a blower, on behalf of Farine Phénix Limitée.The applicant requests an increase of 80.10 per 100-pound bag of flour.Reflecting an increase of approximately 28% and 33%, depending on the distance, on behalf of: Maple Leaf Mills Limited Ogilvie Flour Mills Limited Robin Hood Flour Mills Limited Application for an increase of its hourly rates for local service, moving and other types of service.Approximate increase of 20%.Modification of Howell Tariff No.15 (1) Increase in Montreal Cartage rates of 5* per CWT.2.Increases in rates to Western Canada averaging 9%: (o) General Merchandise Rates (b) Exceptions (c) Commodity Rates 4136 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.Rôle M-2040 16773-V D-2 TF INTERLINE FORWARDERS LTD.3715, rue St-Antoine Montréal, P.Q.Rôle M-2041 30005 D-6 TF MIDDLE ATLANTIC CONFERENCE, Agent P.O.Box 10213 Washington, D.C.20018 ( Membres participants) Rôle M-2042 19926-V D-l TF TRANS CANADA TRANSFER & STORAGE INC.1725, rue Basin Montréal, P.Q.H3J 1S2 Rôle M-2043 17673-V D-l TF GABRIEL YERGEAU 170, Boul.Coakley Asbestos.P.Q.Proc: Me Alain F.Tardif C.P.178 Asbestos, P.Q.JIT 3N1 Modification des taux applicables entre Montréal et points dans les provinces suivantes: le Manitoba, la Saskatchewan, l'Al-berta et la Colombie Britannique, représentant une augmentation approximative de Demande de fixation de tarif: 1.Supplément 15 du tarif 33-P (Taux de classe et de marchandises applicables entre le Québec (Canada) et les endroits suivants: Delaware, district de Columbia, Maryland, New-Jersey, New-York, Pennsylvanie, Tennessee (Bristol seulement), Virginie et Virginie de l'Ouest.2.Supplément 4 au tarif 34-1 (Taux de classe et d'espèces applicables entre le Québec (Canada) et les états suivants: Connecticut, Maine Massachusetts.New-Hampshire, Rhode-Island.Vermont.3.Supplément 4 au tarif S-293C (Taux de marchandises applicable entre le Québec (Canada) et les états suivants: Maryland, Massachusetts, New-Jersey, New-York et Pennsylvanie.4.Supplément 1 au tarif des taux gouvernementaux 4-M (taux d'espèces applicables aux chargements complets) pour le Gouvernement des Etats-Unis.Réductions et augmentations des taux et des prix applicables pour le compte de transporteurs adhérant au taux international déposé par le Middle Atlantic Conference.Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les suppléments déposés auprès de la Commission des transports du Québec.La requérante demande une augmentation moyenne de 15% sur les taux qui figurent présentement au dossier.Tableau des tarifs pour le transport effectué par le détenteur du permis No 17673-V.Ancien tarif / Former Tariffs Tarif j\\ la livre / Rate per pound 0- 5 livres $0.40 par colis 0- 5 lbs.$0.40 per parcel 5-15 lbs.inc.$0.50 par colis 5-15 lbs.inc.S0.60 per parcel 15 et plus $0.05 de la livre 15 or more $0.06 per lb.Tarif horaire / Hourly rate: Camion J-j tonne avec chauffeur 85.00/hre J^-ton truck with driver: $6.00 per hour Avec chauffeur et aide $8.00/hre With driver and helper: $S.OO per hour Camion 1 tonne avec chauffeur $7.00/hre One-ton truck with driver: $7.00 per hour Avec chauffeur et aide $10.00/hre With driver and helper: $10.00 per hour Tarif au mille: / Rate per mile: Hors limite de la ville d'Asbestos: 80.30 par mille simple en sus du tarif horaire.Modification of rates from Montreal to points in Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia with an approximate increase of 9^%.Application for fixation of tariff 1.Supplement 15 to Tariff 33-P (Class and Commodity Rates Between Province of Québec, Canada and Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Tennessee (Bristol only), Virginia and West Virginia.2.Supplement 4 to Tariff 34-1 (Class and Commodity Rates between Province of Québec, Canada and Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island and Vermont.3.Supplement 4 to Tariff S-293C (Commodity Rates between Province of Québec, Canada and Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York and Pennsylvania.4.Supplement 1 to Government Rate Tariff 4-M (Commodity Rates on Truckload Shipments) for the United States Government.Reductions and Increases in rates and charges applicable for account of motor carriers party to international rate filed by Middle Atlantic Conference.For any additional information please refer to the supplements filed with the Québec Transport Commission.Request an average of 15% increase over rates actually filed.List of tariffs for transport operated by the holder of permit number 17673-V.Nouveau tarif / New Tariffs Tarif à la livre / Rate per pound 0- 5 livres $0.60 par colis 0- 6 lbs: $0.60 per parcel 5-15 lbs.inc.$0.80 par colis 5-16 lbs inc.$0.80 per parcel 15 et plus $0.05 de la livre 16 or more: $0.06 per lb.Tarif horaire / Hourly rate: Camion ^ tonne avec chauffeur $8.00/hre '/i-ton truck with driver: $8.00 per hour Avec chauffeur et aide $12.00/hre With driver and helper: $1S.00 per hour Camion 1 tonne avec chauffeur $10.00/hre One-ton truck with driver: $10.00 per hour Avec chauffeur et aide 814.00/hre With driver and helper: $14.00 per hour Tarif au mille / Rate per mile: Hors limite de la ville d'Asbestos: $0.50 par mille simple en sus du tarif horai- Outside.the limits 0/ the Town of Asbestos: $0.30 per mile, one-way, over and above the hourly rate.Outside the limits of the Town of Asbestos: $0.60 per mile, one-way, over and above the hourly rate. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n\" 22 4137 Rôle M-2044 30004 D-13 TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N.555 Dixon Road Rexdale, Ontario M9W 1H8 (Membres participants Participating members) Adresse au Québec : C.H.G.C.1434 ouest, rue Ste-Catherine, suite 404 Montréal, P.Q.H3G 1R4 Proc.: Me Gérard Corbeil 465, rue St-Jean.suite 605 Montréal.H2Y 2R6 Tarif spécial applicable au service à contrat B.T.Q.No 4074, effectué par la compagnie Servall Transport Limited, pour le compte des Compagnies Consumers Glass Limited et Dominion Glass Company Limited.Servall Transport Limited special tariff covering contract service T.B.Q.No.4074, for Consumers Glass Limited and Dominion Glass Company Limited.Rôle M-2045 3571-A - (D.l.) GARFIELD HEIGHTS COACH LINE, INC.43 Harrison St.Bedford, Ohio.U.S.A.Requérante / Applicant La requérante demande l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Permis en vue d'effectuer, à titre occasionnel, des voyages à charte partie, en autobus dans la province de Québec via des routes irrégulières; le point de départ sera situé dans le comté de Cuyahoga (Ohio, E.-U.), le point de destination sera situé au Québec.On entrera au Québec par l'une ou l'autre des frontières Québec - Ontario et Québec - Etats-Unis ; sortie via les mêmes frontières.The applicant is asking for authorization to operate following service: Class of permit: Autobus service.Service : Permit to operate occasional charter bus trips into the Province of Québec over irregular routes from origin in the County of Cuyahoga.State of Ohio, U.S.A.Entry to the Province of Québec being from its border with the Province of Ontario and/or the U.S.A.exiting the same.Rôle M-2046 3572-A-(D.l.) CONWAY'S BUS SERVICE 3220 Mendon Road Cumberland Rhode-Island .(02864) U.S.A.Requérante / Applicant La requérante demande l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service : La requérante demande l'autorisation d'exploiter un permis de transport à charte partie pour les voyageurs et leurs bagages dans le même véhicule.Les passagers prennent l'autobus à certains postes douaniers situés entre le Québec et les états suivants: Maine, New-Hampshire, Vermont et New-York jusqu'à tous points situés au Québec, et retour aux postes douaniers donnant accès aux états du Maine, New-Hampshire, Vermont et New-York.The applicant is asking for authorization to operate the following service: Class of permit: Autobus service.Service : Permission is respectfully requested to operate as a charter carrier in transportation of passengers and their baggage in the same vehicle with passengers beginning at points of entry into Québec from the states of Maine, New-Hampshire, Vermont and New York to all points in the Province of Québec, and return to points of entry into the states of Maine, New-Hampshire, Vermont and New Yord.Rôle M-2047 0003 - (D.l.) COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L'OUTAOUAIS 54, rue Front, Hull.CHull), P.Que.Requérante / Applicant La Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation d'effectuer des voyages à charte partie à partir de chacune des municipalités du territoire de la Communauté régionale de l'Outaouais, le tout tel que décrit au chapitre 86 des lois de 1969, dans un rayon de 300 milles desdites municipalités, et retour.The Outaouais Regional Community Transit Commission requests from the Québec Transport Commission authorization to operate charter trips starting from each of the municipalities in the territory of the Outaouais Regional Community, within the meaning of Chapter 85, Statutes of 1969, within a radius of 300 miles from said municipalities, and return.67403-o 4138 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » : La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.I \u2014Notice \"proprio motu\" by the Commission: The Commission gives notice of its intention to decide on the following procedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.Rôle M-2048 2835-ATL-P-l ALFRED L'ESPÉRANCE 6.rue Cornwall Ville Mont-Royal Montréal 304 P.Q.Rôle Q-1202 692-A-P-l AUTOBUS LANDRY LIMITÉE AUTOBUS FORTIN & POULIN INC.Q-28 LÉON CLOUTIER Aux fins d'annuler, à la demande du détenteur, le permis No 2835-ATL.Aux fins de compléter la décision numéro QPV-269, rendue le 2 avril 1974, pour disposer des montants déposés avec les requêtes de demande de révision de la décision rendue par le commissaire en séance.For the purpose of cancelling, as requested by the applicant, permit No.2835-ATL.For the purpose of completing decision number QPV-269.rendered on April 2,1974, to dispose of the sums deposited with requests for the revision of a decision rendered by the Commissionner in sitting.AUTOBUS FORTIN & POULIN INC.Rôle Q-l 204 5045-V-P-l Q-303 TRANSPORT THIBAULT INC.450.rue Père Lacombe Québec Rôle Q-1203 17824-V-P-l LOUIS-PHILIPPE GRAVEL 2302, rue Roussel Chicoutimi-Nord Québec Rôle Q-1251 7147-V-P-l L.THIBODEAU TRANSPORT INC.228 - 2ième Avenue Ville Portneuf (Portneuf) Rôle Q-1252 22173-V-P-l CHO-BO INC.C.P.38 St-Georges-Est Cté de Beauce Aux fins de réviser, pour cause, la décision numéro QS-292, rendue le 11 avril 1974, et délivrer un permis spécial, vu l'urgence, pour la compagnie Westinghouse Canada Limitée, de faire transporter ses appareils électro-ménagers non emballés et emballés chez ses concessionnaires ou devant servir comme exhibits, et l'absence d'autres détenteurs pour assurer un tel genre de service.Aux fins de: 1.annuler la clause a du permis, laquelle est une duplication de la nouvelle clause d; 2.réviser l'Ordonnance du 26 novembre 1971 alors que la Régie des Transports avait omis de réécrire la restriction relative la clause b; 3.redésigner les comtés de Lac St-Jean, Roberval et Chicoutimi par les nouveaux districts électoraux provinciaux de Chicoutimi, Dubuc, Jonquière, Lac St-Jean et Roberval.Aux fins de réviser la décision du 25 avril 1974 (QS-317.7147-V-S-l, rôle Q-332), quant à la mention d'une opposition de Guilbault Transport Inc., laquelle ne concernait pas cette requête.Aux fins de réviser la décision du 8 avril 1974 (QCR-523.22173-V-D-l.rôle Q-192), pour disposer du cautionnement de la partie opposante, Fox & Ginn Inc.For the purpose of revising, for just cause, decision number QS-292, rendered on April 11, 1974.and of issuing a special permit, considering the emergency of the situation, viz that have its non-packed and packed electrical appliances delivered to its dealers, or to sites where they will be used as exhibits, and considering that no other permit-holders would be available to provide such a service.For the purpose of: (1) Cancelling clause a of the permit, which is a duplicate of the new clause d: (2) Revising the Order dated November 26.1971, wherein the Transportation Board had failed to reword the restriction relating to clause b; (3) Re-designating the Counties of Lake St.John, Roberval and Chicoutimi according to the limits of the new Provincial Electoral Districts of Chicoutimi, Dubuc, Jonquière, Lac St.Jean and Roberval.For the purpose of revising the decision dated April 25.1974 (QS-317, 7147-V-S-l, roll Q-332).with regard to the mention of an objection by Guilbault Transport Inc., which did not concern said application.For the purpose of revising the decision dated April 8, 1974 (QCR-523,22173-V-D-l roll Q-192), to dispose of the deposit made by the applicant, Fox & Ginn Inc.Rôle Q-1253 10-V-P-l GUILBAULT TRANSPORT INC.220 rue Principale St-Charles-de-Grondines Cté de Portneuf Aux fins de réviser la décision du 4 avril 1974 (QCR-517.10-V-D-2, rôle Q-27).quant au montant du dépôt remis à la partie requérante.For the purpose of revising the decision dated April 4.1974 (QCR-517, 10-V-D-2, roll Q-27).with regard to the amount of the deposit reimbursed to the applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° êS 4139 Rôle Q-1259 201-V-P-l GERALD DESMARAIS 9e Rang St-Léonard (Nicolet) Que.Rôle Q-1260 22498-V-P-l LE DÉMÉNAGEUR DU NORD LTÉE 167.rue Napoléon Sept-Iles (Saguenay) Que.Rôle Q-1261 22498-V-P-2 LE DÉMÉNAGEUR DU NORD LTÉE 167, rue Napoléon Sept-Iles (Saguenay) Que.Rôle Q-1262 3312-V-P-l CARON & FILS TRANSPORT INC.C.P.100 Cap St-Ignace Cté de Montmagny Rôle Q-1263 Q-54,001 P-l LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS-ARTISANS INC.Rôle M-2049 1733-V P-l D.DONNELLY LTD.191, Murray Montréal 102, P.Que.Rôle M-2057 1991-V-D-l ADRIEN MASSE Coteau-du-Lac (Vaudreuil-Soulanges) Que.et/and M-397-P-1 MAHEU TRANSPORT INC.Rôle M-2184 19641-V S-l P-l LÉO FOURNIER'S TRANSPORT INC.Swanton Vermont, U.S.A.Adresse au Québec Address in Québec: Salderbury Street, Valleyfield, P.Q.Aux fins de vérifier le permis no 201-V et révoquer ledit permis s'il y a lieu.Aux fins de réviser la décision du 25 avril 1974, dans la cause Q-117, relativement au montant déposé par la requérante.Aux fins de réviser ou révoquer le permis numéro 22498-V.Aux fins de réviser la décision du 29 avril 1974 (QCR-533, 3312-V-D-l, cause Q-16), quant au montant du dépôt confisqué à la partie requérante.Aux fins de corriger la décision QCV-1TF MCV 10TF en date du 29 avril 1974.a) pour statuer sur le dépôt de cautionnement des requérants, et 6) pour rayer du dispositif (item 7), dans la liste des dépôts à rembourser, le nom de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, cette intervenante n'ayant pas effectué de dépôt de cautionnement (voir p.8 de la décision).Afin de corriger la date d'expiration apparaissant sur la décision de la Commission MCV-1 du 9 janvier 1974 en ce qui concerne la restriction de la clause i du permis 1733-V et de reporter ladite date au 31 décembre 1974.Aux fins de: a) statuer sur les droits et obligations de son détenteur: b) classifier ledit permis ; c) préciser si ledit permis autorise le droit de desservir Valleyfield et divers autres endroits; \\d) révoquer ou transférer l'attestation de camionnage en vrac No 501 706.Nom: Léo Fournier's Transport Inc.Swanton Vermont.U.S.A.Adresse au Québec: Salderbury Street Valleyfield, P.Q.Permis: 19641-V S-l Cause: MRS-0140 Aux fins de reviser et de corriger la décision M.S.665 du 13 mai 1974, pour que le service accordé soit tel que demandé et publié, c'est-à-dire en précisant: « Par remorques spécialement équipées pour le chargement par la pesanteur et par pression d'air » - au lieu de « par camion à benne basculante.» For the purpose of verifying permit number 201-V and revoking said permit, if required.For the purpose of revising the decision dated April 25, 1974, in case Q-117, with regard to the amount deposited by the applicant.For the purpose of revising or revoking permit number 22498-V.For the purpose of revising the decision dated April 29.1974 (QCR-533.3312-V-D-l.case Q-16), with regard to the amount of the deposit confiscated from the applicant.For the purpose of correcting decision QCV-1TF MCV-10TF, dated April 29.1974.(o) to render a decision cencerning the deposit made by the applicants, and (6) to delete from the purview (item 7), in the list of deposits to be reimbursed, the name of l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, no deposit having been made by this intervening party.(See page 8 of the decision).For the purpose of correcting the date of expiration appearing on decision MCV-1 rendered by the Commission on January 9, 1974, concerning the restriction to clause i of permit No.1733-V, and to postpone said date to December 31, 1974.For the purpose of: (a) Stipulating the rights and obligations of the holder; (6) Classifying said permit; (c) Specifying whether said permit grants the right to serve Valleyfield and various other localities; (d) Revoking or transferring bulk trucking certificate number 501 706.Name: Léo Fournier's Transport Inc.Swanton Vermont, U.S.A.Address in Québec: Salderbury Street Valleyfield, P.Q.Permit: 19641-V S-l Case: MRS-0140 For the purpose of revising and correcting decision M.S.665, dated May 13, 1974.in order that the service provided may be in accordance with the application and publication, that is specifying: \"Utilizing trailers specially equipped for loading by gravity and by air pressure\" -instead of \"by dump truck\".57403-O 4140 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.SS IV \u2014 Avis de désistement : La Commission donne avis du désistement des requêtes par les requérants dans les affaires suivantes: QDW-54 a) M.MICHEL RICHARD DOSSIER: Q-201317 Désistement de la requête de permis de transport par véhicule-taxi relative à la municipalité de Ma-t agami.QDW-55 M.SERGE RICHARD DOSSIER: 200494 Désistement de la requête de permis de transport par véhicule-taxi relative à la municipalité de Giffard A-32.QDW-56 GAMBLIN.THEODORE D.DOSSIER: 23720-V-D-l ROLE: Q-0955 Désistement de la requête de permis de transport par remorquage pour Speedway Express Ltd.QDW-57 G.CAMBER GIBERSON DOSSIER: 23722-V-D-l ROLE: Q-0967 Désistement de la requête de permis de transport par remorquage pour Speedway Express Ltd.QDW-58 TOWER, JOHN C DOSSIER: 23813-V-S-l ROLE: Q-0365 Désistement de la requête de permis de transport par remorquage pour Speedway Express Ltd.MDW-8 MIDDLE ATLANTIC CONFERENCE DOSSIER: 30005-D-3-TF Désistement de la demande de modification de tarifs.MDW-9 SOUTHERN MOTOR CARRIER RATE CONFERENCE DOSSIER: 30007-D-3-TF Désistement de la demande de modification de tarifs.57403-o IV \u2014 Notice of withdrawal: The Commission gives notice of withdrawal of applications by the applicants in the following proceedings: QDW-54 (a) M.MICHEL RICHARD FILE: Q-201317 Withdrawal of application for a permit for transportation by taxicab in the Municipality of Ma-tagami.QDW-55 M.SERGE RICHARD FILE: 200494 Withdrawal of application for a permit for transportation by taxicab in the Municipality of Giffard A-32.QDW-56 GAMBLIN, THEODORE D.FILE: 23720-V-D-l ROLL: Q-0955 Withdrawal of application for a permit for haulaway transportation for Speedway Express Ltd.QDW-57 G.CAMBER GIBERSON DOSSIER: 23722-V-D-l ROLL: Q-0967 Withdrawal of application for a permit for haulaway transportation for Speedway Express Ltd.QDW-58 TOWER, JOHN C FILE: 23813-V-S-l ROLL: Q-0365 Withdrawal of application for a permit for haulaway transportation for Speedway Express Ltd.MDW-8 MIDDLE ATLANTIC CONFERENCE FILE: 30005-D-3-TF Withdrawal of application for modification of tariffs.MDW-9 SOUTHERN MOTOR CARRIER RATE CONFERENCE FILE: 30007-D-3-TF Withdrawal of application for modification of tariffs.57403-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 19U, 106' année, n° 33 4141 V \u2014 Avis des décisions rendues: La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement N'o 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered: The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation No.2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.DECISIONS DE LA COMMISSION « PROPRIO MOTU » / DECISIONS \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tC page\tr.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QCR-563\t13-05-74\tAvis de la Commission « Proprio Motu » 8565-V CENTRAL TRUCK LINES LTD.\t\t1664\t02-03-74\tM-1212\t La Commission prolonge jusqu'au 31 octobre 1974.le permis temporaire et expérimental émis en faveur de CENTRAL TRUCK LINES LTD.QCR-564 13-05-74 Avis de la Commission « Proprio Motu » 6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.La Commission prolonge jusqu'au 31 octobre 1974, le permis temporaire et expérimental émis en faveur de BRAZEAU TRANSPORT INC.QCR-565 13-05-74 Avis de la Commission 22499-V LES TRANSPORTS DE LA BAIE D'HUDSON INC.La Commission prolonge jusqu'au 31 octobre 1974, le permis temporaire et expérimental émis en faveur de LES TRANSPORTS DE LA BAIE D'HUDSON INC.QCR-566 13-05-74 Avis de la Commission « Proprio Motu » 10694-V J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE La Commission prolonge, jusqu'au 31 octobre 1974, le permis temporaire et expérimental émis en faveur de J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE.QCR-567 13-05-74 Avis de la Commission « Proprio Motu » 2873-V LAMOTHE QUEBEC INC.La Commission prolonge jusqu'au 31 octobre 1974, le permis temporaire et expérimental émis en faveur de LAMOTHE QUEBEC INC.QCR-668 13-05-74 Avis de la Commission « Proprio Motu » 4724^-V MAGNY TRANSPORT INC.La Commission des transports prolonge, jusqu'au 31 octobre 1974, le permis temporaire et expérimental émis en faveur de MAGNY TRANSPORT INC.The Commission extends until October 31, 1974, the experimental and temporary permit issued to CENTRAL TRUCK LINES LTD.1664 02 03 74 M-1212 The Commission extends until October 31, 1974.the experimental and temporary permit issued to BRAZEAU TRANSPORT INC.1664 02-03-74 M-1212 The Commission extends until October 31, 1974, the experimental and temporary permit issued to LES TRANSPORTS DE LA BAIE D'HUDSON INC.1664 02-03-74 M-1212 The Commission extends until October 31.1974, the temporary and experimental permit issued to J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE.1664 02-03-74 M-1212 The Commission extends until October 31, 1974.the exoe-rimental and temporary permit issued to LAMOTHE QUEBEC INC.1664 02-03-74 M-1212 The Transport Commission extends until October 31, 1974, the temporary and experimental permit issued to MAGNY TRANSPORT INC. 4142 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, Mi, Vol.106, No.22 No Date Requérants Applicants Bulletin G.O.Q.page date Cause Case Décisions QPT-44 15-05-74 Q-20000 P-2 Le transport par Véhicule-taxi Fixation des Taux et Tarifs La Commission modifie sa décision rendue le 21 février 1974, concernant la fixation des taux et tarifs pour le transport par véhicule-taxi, comme suit: Fixe le taux de $0.60 pour chaque mille parcouru dans les agglomérations suivantes: A 21 : Baie-Comeau A 22 : Hauterive 3184 27-04-74 Q-1010 The Commission modifies its decision rendered on February 21, 1974, concerning the fixing of rates and tariffs for transport by taxi vehicle, as follows: Fixes the $0.60 rate for each mile covered in the following conglomerations: A 21: Baie-Comeau A 22: Hauterive AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS QCS-309\t14-05-74\t12089-V-D-l\t\t7118\t01-12-73\tQ-411\tAccordée en partie \t\tJEAN-LOUIS CHAINE\t\t\t\t\tPartly granted QCR-571\t13-05-74\t21794-V-D-l\t\t\t\tQ-208\tAccordée / Granted \t\tMESSAGERIE GAGNON ENRG.\t\t\t\t\t QCR-572\t13-05-74\t20784-V-D-l\t\t\t\tQ-68\t \t\tREAL VILLENEUVE\t\t\t\t\t La Commission: 1.Annule les clauses 6 et c 2.Autorise REAL VILLENEUVE à donner le service suivant : De Chicoutimi à tous les endroits situés dans un rayon de 75 milles des limites de ladite cité, pour la livraison de marchandises pour le compte de Woolco.The Commission: 1.Cancels clauses b and c 2.Authorizes REAL VILLENEUVE to provide the following service: From Chicoutimi to any point located within a radius of 75 miles from the limits of the said City, for the delivery of goods on behalf of Woolco.SÉANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS 13-05-74 13-05-74 13-05-74 13-05-74 13-05-74 13-05-74 13-05-74 13-05-74 13-05-74 14-05-74 18627-V-D-5 TRANSOL INC.23718-V-D-l M.ROGER BRUNEAU 20017-V-D-l LA COMPAGNIE GASPESIA-RIMOUSKI LIMITEE 18979-V-D-l M.GERALD PELLETIER 1997-V-D-2 A.CLAVEAU TRANSPORT INC.17007-V-D-l M.ROMEO SIGOUIN 19296-V-D-3 BEL-MONT TRANSIT INC.Q-7610-V-D-2 MAURICE PRESSE Requérant-vendeur Applicant vendor Q-7737-V-D-2 BELLECHASSE TRANSPORT INC.Requérant-acquéreur Applicant purchaser 154-V-D-l TF M.GERARD RUEL Modification de tarifs Modification of tariffs Q-22966-V-D-1 REAL COTE Requérant-vendeur Applicant vendor 1921 1694 1694 1694 1688 1671 1695 1920 1667 2128 09-03-74 02-03-74 02-03-74 02-03-74 02-03-74 02-03-74 02-03-74 09-03-74 02-03-74 16-03-74 Q-822 Q-812 Q-810 Q-808 Q-771 Q-763 Q-813 Q-820 Q-728 Q-833 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Ac cordée / Granted Accordée / Granted Rejetée / Rejected GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4143 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t \t\tFERNAND LAFLAMME\t\t\t\t\t \t\tRequérant-acquéreur\t\t\t\t\t \t\tApplicant purchaser\t\t\t\t\t QCR-574\t14-06-74\t2247-V-D-l TF\t\t1539\t23-02-74\tQ-682\tAccordée / Granted TF\t\tLUCIEN GOSSELIN Modification de tarifs Modification of tariffs\t\t\t\t\t QCR-575\t14-05-74\t8797-V-D-l TF\t\t1690\t02-03-74\tQ-788\tAccordée / Granted TF\t\tDOLBEC TRANSPORT\t\t\t\t\t \t\tINC.Modification de tarifs Modification of tariffs\t\t\t\t\t QCR-576\t14-05-74\t608-V-D-l TF\t\t1690\t02 03-74\tQ-787\tAccordée / Granted TF\t\tBELLEMARE TRANS-\t\t\t\t\t \t\tPORT LTEE Modification de tarifs Modification of tarifs\t\t\t\t\t QCR-577\t16-05-74\tQ-20224-V-D-1 TF\t\t1672\t02-03-74\tQ-767\tAccordée / Granted TF\t\tM.EMILE CHIQUETTE Modification de tarifs Modification of tariffs\t\t\t\t\t QCR-678\t16-05-74\tQ-23471-V-D-2\t\t2484\t30-03-74\tQ-885\tAccordée / Granted \t\tTRANSPORT FAFARD INC.1FAFARD TRANSPORT INC.\t\t\t\t\t QCR-579\t16-05-74\tQ-4366-V-D-1\t\t2484\t30-03-74\tQ-888\tAccordée / Granted \t\tGEORGES BLOUIN\t\t\t\t\t QCR-580\t16-05-74\t1092-V-D-l\t\t1671\t02-03-74\tQ-758\tAccordée / Granted \t\tQUEBEC TRANSPORT\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t\t \t\tRequérante- venderesse\t\t\t\t\t \t\tApplicant vendor\t\t\t\t\t \t\t11377-V\t\t\t\t\t \t\tMICHAUD & SIMARD\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t\t \t\tRequérante-acquéreur\t\t\t\t\t \t\tApplicant purchaser\t\t\t\t\t QCR-S81\t16-06-74\t10409-V-D-l TF\t\t1691\t02-03-74\tQ-789\tAccordée / Granted TF\t\tTRANSPORT CAPCO INC.Modification de tarifs Modification of tariffs\t\t\t\t\t QL-132\t13-05-74\tQ-257-V-D-1\t\t2131\t16-03-74\tQ-841\tAccordée / Granted \t\tTREMBLAY EXPRESS\t\t\t\t\t \t\tLIMITEE\t\t\t\t\t \t\tTREMBLAY EXPRESS\t\t\t\t\t \t\tLIMITED\t\t\t\t\t QL-133\t13-05-74\t647-DY-D-l &\t\t1589\t02-03-74\tQ-776\tAccordée / Granted \t\t375-DYV-D-l\t\t\t\t\t \t\tHAUTERIVE DRIVE\t\t\t\t\t \t\tYOURSELF ENR.\t\t\t\t\t QL-134\t13-06-74\t131-DYL LES PRODUITS PETROLIERS CHAMPLAIN LTEE\t\t2600\t28-04-73\t\t La Commission: 1.Confirme le droit additionnel de M.Yvon Chabot permis 23056-V, à tirer la ou les remorques propriété de LES PRODUITS PETROLIERS CHAMPLAIN LTEE 2.Annule à toutes fins que de droit le dossier 131-DYL.The Commission : 1.Confirms the additional right entitling Mr.Yvon Chabot, permit 23056-V, to haul one or more trailers belonging to LES PRODUITS PETROLIERS CHAMPLAIN LTEE 2.Cancels file 131-DYL for all legal purposes.15-05-74 15-06-74 15-05-74 Q-1094-DYV-D-1 GERVAIS EQUIPEMENT INC.Q-1093-DYV-D-1 LOCATION GAETAN LEVESQUE INC.Q-1091-DY-D-1 BEAUPRE AUTO LOCATION INC.2483 2483 2483 30-03-74 30-03-74 30-03-74 Q-874 Q-873 Q-876 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 4144 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.M \t\t\t\tG.O.Q.\t\tCause \t\tRequérants\t\t\tdate\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\t\t \t\tApplicants\t\t\t\tCase QL-138\t16-05-74\tQ-1097-DYV-D-1\t\t2483\t30-03-74\tQ-875 \t\tLOCATION FAFARD ENRG.\t\t\t\t QL-139\t16-05-74\tQ-1302-DY-D-1\t\t2483\t30-03-74\tQ-877 \t\tQUE-BOURG AUTO LIMITEE\t\t\t\t QL-140\t16-05-74\tQ-1092-DYV-D-1\t\t2484\t30-03-74\tQ-880 \t\tLOCATION SPERIBEL INC./ SPERIBEL LEASING INC.\t\t\t\t QPT-43\t13-05-74\tQ-200552 M.PAUL PERRON Requérant-vendeur Applicant vendor Q-201922 M.EMILE BARIL Requérant-acquéreur Applicant purchaser\t\t1920\t09-03-74\tQ-819 Décisions Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted La Commission: 1.Révoque l'attestation délivrée au requérant-vendeur et autorise la suppression du service de transport, par taxi, donné par ce dernier.2.Délivre une attestation en faveur du requérant-acquéreur.The Commission: 1.Cancels the certificate issued to the applicant vendor and authorizes the discontinuance of the transport service provided by the latter.2.Issues a certificate to the applicant vendor.QPT-45 TF QPV-291 QPV-292\t16-05-74 13-05-74 13-05-74\t2782-AT-D-l TF LES TAXIS DE LUXE ENRG.Modification de tarifs Modification of tariffs Q-97 AD-6 AUTOBUS DRUMMOND VILLE LTEE 3372-AD-2 TRANSPORT SECURITAIRE ST-PROSPER INC.\t\t1668 1669 1669\t02-03-74 02-03-74 02-03-74\tQ-735 Q-745 Q-744\tAccordée/Granted Accordée / Granted Accordée / Granted DECISIONS DE LA COMMISSION M-2463, M-4375, M-7212, The said bonds will become due and payable, and they shall be paid and redeemed, in principal and interest, at the above-mentioned date, in legal money of Canada, with interest accrued to August 1st 1974, upon presentation and surrender thereof, together with all interest coupons maturing after August 1st 1974 thereto attached, at any branch of the Bank Canadian National in the Province of Québec or at the principal office of the said bank in Toronto, Ontario.Bonds registered as to principal must be accompanied by all requisite transfer documents.The above $50,000 of bonds shall cease to bear interest as from August 1st 1974.Given at the Town of Anjou, this 6th day of May 1974.Léonce Maltais, 57425-0 Town Clerk.INSTITUT PROVIDENCE (MONTREAL) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a déclaré la corporation «INSTITUT PROVIDENCE (MONTREAL) », constituée en corporation par lettres patentes émises, le 1er juin 1962, en vertu de l'article 14 de la Loi modifiant la charte de la Communauté des Soeurs de Charité de la Providence, (7-8 Elizabeth II, chapitre 176), dissoute en vertu de l'alinéa 4 de l'article 14 de la Loi précitée, cette dissolution devant prendre effet à compter du soixantième jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57459-0 19-62 INSTITUT PROVIDENCE (MONTREAL) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has declared the corporation \"INSTITUT PROVIDENCE (MONTREAL)\", incorporated by letters patent issued on June 1, 1962, pursuant to section 14 of an Act to amend the charter of La Communauté des Soeurs de Charité de la Providence, (7-8- Elizabeth II, Chapter 176), dissolved pursuant to paragraph 4 of section 14 of said Act, such dissolution to take effect from the sixtieth day following the publication of the present notice in the Quebec Official Gazette.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57459 p IQ.02 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4169 TEMISCA SILICE LTEE (Libre de responsabilité personnelle) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes en date du 10e jour de janvier 1974 constituant en corporation: Jean-Caude Gagné, 568, Perreault est, Claude Larouche, 225, Cardinal Bégin ouest, tous deux avocats et Micheline Bourget Cossette, secrétaire, épouse de Paul Cossette, 355, Cardinal Bégin est, tous trois de Rouyn, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais, sous le nom de « TEMISCA SILICE LTÉE » (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital total de $5,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57401-o 1355-8606 Ville du Lac St-Joseph Avis est par les présentes donné que le conseil de la Corporation Municipale de la Ville du Lac St-Joseph, comté de Chauveau, a adopté, à l'unanimité, le 13 mai 1974, une résolution autorisant cette municipalité à présenter une requête au Lieutenant-Gouverneur en conseil, pour l'obtention de lettres patentes supplémentaires.L'objet de ladite requête est d'abroger les dispositions de la charte de la municipalité concernant la division du territoire municipal en quartiers, pour fins électorales, et celle réservant l'accessibilité aux charges municipales aux personnes du sexe masculin, pour les remplacer en totalité par les dispositions de « La Loi des cités et villes du Québec ».Québec, le 27 mai 1974.Le secrétaire-trésorier, 57471-0 Gilles Marcotte, m.sc.c.TEMISCA SILICE LTEE (Libre de responsabilité personnelle) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to the provisions of the Mining Companies Act, he has granted letters patent dated January 10, 1974, incorporating Jean-Claude Gagné, 568 Perreault East, Claude Larouche, 225 Cardinal Begin West, both lawyers and Micheline Bourget Cossette, secretary, wife of Paul Cossette, 355 Cardinal Begin East, all three of Rouyn, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"TEMISCA SILICE LTÉE\" (Libre de responsabilité personnelle), with a total capital stock of $5,000,000, divided into 5,000,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company is located in Rouyn, Judicial District of Rouyn-Noranda.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.57401 1355-8606 Town of Lac St-Joseph Notice is hereby given that on May 13, 1974, the Council of the Municipal Corporation of the Town of Lac St-Joseph, County of Chauveau, unanimously adopted a resolution authorizing said Municipality to petition the Lieutenant-Governor in Council in order to obtain supplementary letters patent.The purpose of said petition is to repeal those provisions of the Municipality's charter that concern the division of the municipal territory into wards, for electoral purposes, and that provision reserving the access to municipal responsibilities to persons of the male sex, and to totally replace said provisions by those of the \"Cities and Towns Act\".Québec, May 27, 1974.Gilles Marcotte, 57471 Secretary-Treasurer.Conseil No 2783 des Chevaliers de Colomb de Louiseville Le « Conseil No 2783 des Chevaliers de Colomb de Louiseville, comté de Maskinongé, P.Q., 159 Notre-Dame Sud, Louiseville comté Maskinongé, P.Q., C.P.161, donne avis, par les présentes, qu'il possède son siège social à l'adresse susmentionnée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth II, chapitre 134) à partir du 6 novembre 1973.Louiseville, 6 novembre 1973.Le grand chevalier, Marcel Page.Le secrétaire-archiviste, 57449-0 Rosaire Dubé.Council No.2783 of the Knights of Columbus of Louiseville Notice is hereby given that \"Council No.2783 of the Knights of Columbus of Louiseville\", 159 Notre-Dame South, Louiseville, County of Maskinongé, P.Q., Post Office Box 161, has its head office at the aforesaid address and that it avail itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Québec (1-2 Elizabeth II, Chapter 134), effective November 6, 1973.Louiseville, November 6, 1973.Marcel Page, Grand Knight.Rosaire Dubé, Registrar.57449 CC-9-73 4170 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Communauté régionale de l'Outaouais La « Communauté régionale de l'Outaouais », par son règlement numéro 50, amendant le règlement numéro 3, a décrété et statué que son siège social est maintenant situé au 490, boulevard St-Joseph, Cité de Hull, Québec.Le secrétaire, 57482-0 Jean-Guy Gariêpy.The Outaouais Regional Community \"The Outaouais Regional Community\" has ordained and enacted, by its by-law No.50 amending by-law No.3, that its corporate seat is now located at 49U, boulevard St-Joseph, City of Hull, Québec.57482-0 Jean-Guy Gariêpy, Secretary.LES ENTREPRISES PROCIDA INC.PROCIDA ENTERPRISES INC.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de lettres patentes, en date du 1er avril 1974, de la compagnie « LES ENTREPRISES PRO-DICA INC.\u2014PROCIDA ENTERPRISES INC.», paru dans la Gazette officielle du 11 mai 1974, numéro 19, à la page 3446, en y remplaçant dans ledit nom le mot «PRODICA », de manière que le nom se lise ainsi: « LES ENTREPRISES PROCIDA INC.\u2014 PROCIDA ENTERPRISES LNC.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57401-o 1355-5776 LES ENTREPRISES PROCIDA INC.PROCIDA ENTERPRISES INC.Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to correct the notice of letters patent, dated April 1st 1974, of \"LES ENTREPRISES PRODICA INC.\u2014 PROCIDA ENTERPRISES INC.\".published in the Québec Official Gazette dated May 11th 1974, number 19, page 3446, by replacing therein the word \"PRODICA\" by the word \"PROCIDA\" so that the name may read as follows: \"LES ENTREPRISES PROCIDA INC.\u2014 PROCIDA ENTERPRISES INC.\".Pierre Desjardins, 57401 Director of the Companies Service.TRANSPORT BAIE DES CHALEURS INCORPORÉE Prenez avis que l'avis concernant le changement de nom de « BERNIER EQUIPEMENT LIMITEE », en celui de « TRANSPORT BAIE DES CHALEURS INCORPOREE », publié dans la Gazette officielle du Québec, 4 mai 1974, numéro 18, à la page 3331, est nul et de nul effet.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57401-o 1460 65 LE CLUB AUTO-NEIGE DE BE^LECOMBE INC.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 28e jour de février 1974, constituant en corporation sans capital-actions, les membres actuels de \"LE CLUB AUTO-NEIGE DE BELLE-COMBE INC.\", déjà constituée en corporation le ou vers le 29 mars 1972, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de 8100,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Belle-combe, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57401-o 1354-2451 TRANSPORT BAIE DES CHALEURS INCORPORÉE Notice is given that the notice concerning the change of name of \"BERNIER EQUIPEMENT LIMITEE\" to that of \"TRANSPORT BAIE DES CHALEURS INCORPOREE\", published in the Québec Official Gazette, dated May 4, 1974, number 18.on page 3331, is null and void.Pierre Desjardins, 57401 Director of the Companies Service.LE CLUB AUTO-NEIGE DE BELLECOMBE INC.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to Part III of the Companies Act.he has granted letters patent, dated the 28th day of February 1974, incorporating as a corporation without share capital, the present members of \"LE CLUB AUTO-NEIGE DE BELLECOMBE INC.\", already incorporated on or about March 29, 1972, pursuant to the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The value of the immoveable property which the corporation may acquire or hold is limited to 8100,000.The head office of the new corporation is located in Beliecombe, Judicial District of Rouyn-Noranda.Pierre Desjahdins, 57401 Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 33 4171 CENTRE AUTO-NEIGE ILE BIZARD Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de mars 1974, constituant en corporation sans capital-actions, les membres actuels de « CENTRE AUTO-NEIGE ILE BIZARD », déjà constituée en corporation le ou vers le 28 janvier 1969, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de 5100,000.Le siège social de la nouvelle corporation est au numéro 15570, rue Boischatel.Pierrefonds, district judiciaire de Montréal.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57401-o 1355-9612 CLUB MOTO-NEIGE LES MILTONNAIS INC.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 27e jour de décembre 1973, constituant en corporation sans capital-actions, sous le nom de « CLUB MOTO-NEIGE LES MILTONNAIS INC.», les membres actuels de « CLUB MOTO-NEIGE STE-CECILE DE MILTON INC.».déjà constituée en corporation le ou vers le 28 septembre 1971, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de 8100,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Sainte-Cécile-de-Milton, district judiciaire de Bedford.Le direceur du service des compagnies, Pierre Desjardins.5740 l-o 1356-0628 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE COURCELLES Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de janvier 1974, constituant en corporation sans capital-actions, les membres actuels de « L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE COURCELLES », déjà constituée en corporation le ou vers le 25 avril 1952, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de 8200,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Cour-celles, district judiciaire de Beauce.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.5740 l-o 1356-0727 CENTRE AUTO-NEIGE ILE BIZARD Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent dated March 25, 1974, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives incorporating without share capital the present members of \"CENTRE AUTO-NEIGE ILE BIZARD\", already incorporated on or about January 28, 1969, pursuant to the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is 8100,000.The head office of the new corporation is located at 15570 Boischatel Street, Pierrefonds, Judicial District of Montreal.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.57401 1355-9612 CLUB MOTO-NEIGE LES MILTONNAIS INC.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent dated December 27, 1973, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives incorporating without share capital, under the name of \"CLUB MOTO-NEIGE LES MILTONNAIS INC.\" the present members of \"CLUB MOTO-NEIGE STE-CECILE DE MILTON INC.\", already incorporated on or about September 28, 1971, pursuant to the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The amount to which the value of the immoveable propertv which the corporation may acquire and hold is to be limited, is 8100,000.The head office of the new corporation is located in Ste.Cécile-de-Milton.Judicial District of Bedford.Pierre Desjardins, Director of the Companies Services.57401 1356-0628 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE COURCELLES Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent dated January 3, 1974, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives incorporating without share capital the present members of \"L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE COURCELLES\", already incorporated on or about April 25, 1952, pursuant to the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be'limited, is 8200.000.The head office of the new corporation is located in Courcelles, Judicial District of Beauce.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.57401 1356-0727 4172 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Succession Rosanna Alain Prenez avis que Monsieur André Huard et son épouse, Dame Jeannette Alain ont renoncé au bénéfice d'inventaire pour accepter purement et simplement la succession de feu Dame Rosanna Alain, veuve de feu Paul Landry suivant acte reçu à Québec par le notaire Pierre Champagne, pratiquant à 880 Chemin Ste-Foy, Québec, le trente mars mil neuf cent soixante-quatorze (1974), enregistré au bureau de la division de Portneuf, à Cap Santé, le dix avril mil neuf cent soixante-quatorze (1974) sous le numéro 207,363.Le notaire.57445-o Pierre Champagne.Estate of Rosanna Alain Notice is hereby given that Mr.André Huard and his wife Mrs.Jeannette Alain have renonced the benefit of inventory to become unconditionnal heirs of the late Mrs.Rosanna Alain, widow of the late Paul Landry by deed passed at Québec before Mtre Pierre Champagne, notary practicing at 880 Ste-Foy Road, Québec, on March 30, 1974 registered at the Office Registration Division of Portneuf, at Cap Santé on April 10, 1974 under number 207,363.Pierre Champagne, 57445-0 Notary.LES SOEURS MISSIONNAIRES DU CHRIST-ROI Avis est donné que la communauté « Les Soeurs missionnaires du Christ-Roi » a changé son siège social de la ville de Gaspé, province de Québec, au 4730 ouest.Boulevard Lévesque, Chomedey, Ville de Laval.La supérieure générale, 57447-0 S.Germaine Smith.LES SOEURS MISSIONNAIRES DU CHRIST-ROI Notice is given that \"Les Soeurs missionnaires du Christ-Roi\" has transferred its head office from the City of Gaspé, Province of Québec, to 4730 Lévesque Boulevard West, Chomedey, City of Laval.Sr.Germaine Smith, 57447 Superior General.Paroisse St.Thomas More, de Saint-Jean Avis est donné conformément à l'article 2 de la Loi des Fabriques (Chapitre 76 des lois de la 1ère session de 1965) que Monseigneur Gérard-Marie Coderre.évêque catholique romain de Saint-Jean-de-Québec, a, par décret daté du 1er avril 1974, changé les limites de la paroisse nationale St.Thomas More, du diocèse de Saint-Jean-de-Québec.VEvêque catholique romain de Saint-Jean, t Gérard-Marie Coderre.57448-0 1355-8101 Parish of St.Thomas More, St.Jean Notice is given that in conformity with section 2 of the Fabrique Act (Statutes of 1965, 1st Session, Chapter 76) Monsignor Gérard-Marie Coderre, Roman Catholic Bishop of Saint-Jean-de-Québec, has.by a decree dated April 1.1974, changed the limits of the National Parish of St.Thomas More, in the diocese of Saint-Jean-de-Québec.t Gérard-Marie Coderre, Roman Catholic Bishop of Saint-Jean.57448 1355-8101 Conseil No 3326 des Cheval ii r - de Colomb de St-André de Sutton Le « Conseil No 3326 des Chevaliers de Colomb de St-André de Sutton », 1 rue Pleasant, Sutton, Québec, donne avis, par les présentes, qu'il possède son siège social à l'adresse susmentionnée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth 11, chapitre 134) à partir du 1 janvier 1974.Sutton, Québec, le 14 décembre 1973.Le Grand Chevalier, Charles Talbot.Le secrétaire-achiviste, Pierre Blanchette.57450-o CC-11-73 Council No.3326 of the Knights of Columbus of St.André de Sutton Notice is hereby given that \"Council No.3326 of the Kinghts of Columbus of St.André-de-Sutton\", 1 Pleasant St., Sutton, Québec, has its head office at the aforesaid address and that it avails itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Québec (1-2 Elizabeth H, Chapter 134), effective January 1, 1974.Sutton, Québec, December 14,1973.Charles Talbot, Grand Knight.Pierre Blanchette, Registrar.57450 CC-11-73 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974.106' année, n° 22_4173 Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Conformément à l'article 44 de la Loi sur l'évaluation foncière, j'ordonne que les limites du territoire du district de révision de Montréal du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec soient modifiées pour y inclure cette partie du territoire où La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue a compétence en matière d'évaluation foncière.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Québec, le 13 mail974.Le ministre des affaires munucipales.Victor C.Goldbloom.Québec Real Estate Assessment Board of Revision Pursuant to section 44 of the Real Estate Assessment Act, I hereby order that the limits of the territory of the Montreal District of the Québec Real Estate Assessment Board of Revision be modified to include therein this part of the territory where the Lake Té-miscamingue School Board has jurisdiction over land evaluation.The present order shall come into force on the date of its publication in the Québec Official Gazette.Québec, May 13, 1974.Victor C.Goldbloom.57451 Minister of Municipal Affairs.Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Conformément à l'article 44 de la Loi sur l'évaluation foncière, j'ordonne que les limites du territoire du district de révision de Québec du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec soient modifiées pour y inclure le territoire de la cité de Rouyn.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Québec, le 8 mai 1974.Le ministre des affaires municipales, 57451-o Victor C.Goldbloom.Québec Real Estate Assessment Board of Revision Pursuant to section 44 of the Real Estate Assessment Act, I hereby order that the limits of the territory of the Québec District of the Québec Real Estate Assessment Board of Revision be modified to include therein the territory of the City of Rouyn.The present order shall come into force on the date of its publication in the Québec Official Gazette.Québec, May 8, 1974.Victor C.Goldbloom, 57451 Minister of Municipal Affairs.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Avis de correction (Lettres patentes) Notice of correction (Letters patent) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a autorisé la correction de lettres patentes suivantes: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has authorized the correction of the letters patent issued to the following companies or corporations: Nom / Name\tSiège social Incorporation Head office Date\tModifications Corrections INSTALLATIONS ELECTRIQUES HUNEAULT INC.1354-9522\t947, rue Ste- 19 03 74 Marguerite, Montréal\tRemplaçant le nom / Replacing the name: LES CONSTRUCTIONS HUNEAULT INC.par / by INSTALLATIONS ELECTRIQUES HUNEAULT INC.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 57401-O Pierre Desjardins.57401-O Directors of the Companies Service.Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs 4174 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Ministère des Richesses naturelles Department of Natural Resources Révocation de concessions minières Prenez avis que les concessions minières ci-après énumérées seront révoquées en faveur de la couronne par le ministre, conformément aux articles 202, 204 et 205 de la Loi des mines (ch.34 des Lois du Québec, 1965, 1ère session, et amendements), pour défaut de paiement de la taxe annuelle prévue à l'article 119 de cette loi, à moins que la taxe et les frais de publication n'aient été payés dans les 90 jours qui suivront la dernière publication de cet avis: Revocation of mining concession Pursuant to section 202, 204 and 205 of the mining Act (Québec Statutes 1965, 1st session, ch.34 and modifications), the Minister will revoke for failure to pay the annual tax provided for in section 119 of the said act, the following mining concessions unless the tax and the cost of publication be paid within ninety days following the last publication of this notice: District\tCanton ou\tNo de la\t\tSuperficie\tDate\tLettres électoral\tparoisse\tconcession\tNuméro des lots ou des blocs\ten acres\td'émission\tpatentes Electoral\tTownship\tConcession\tLots or blocks number\t_4rea\tDate of\tLetters district\tor parish\tnumber\t\tin acre\temission\tpatents Laurentides-\tLynch.\t396.\tLot 27.rang IV.\t105.43.\t22-03-52\t04-05-57 Labelle\t\t\tLot 27, range IV.\t\t\t Mégantic\tHampden\t19.\t\t114.\t\t06-09-29 Compton\t\t\tSouthern half of lots 41 and 42.range I.\t\t\t Papineau.\tBuckingham\t313.\tQuart nord-est du lot 14 rang, XI.\t50.\t18-11-40\t \t\t\tNortheastern quarter of the lot 14, range XI.\t\t\t Papineau.\t\t334\tDemie nord du lot 13, rang I.\t50.\t02-03-45\t02-05-55 \t\t\tNorthern half of the lot 13.range I.\t\t\t Roberval.\tDequen.\t407.\t\t50.\t08-03-53\t \t\t\tSouthern half of the lot 2.range III.\t\t\t Rouyn-\tPreissac.\tP.95\tBloc E.\t114.\t17-06-16\t13-12-18 Noranda\t\t\tBlock E.\t\t\t Rouyn-\tBousquet.\t236.\t\t621\t02-10-28\t05-03-29 Noranda\t\t\tBlocks 6 to 15 incl.\t\t\t Québec, le 00 mai 1974.57479-22-2-0 Le sous-ministre, J.-G.Fredette.Québec, May 00, 1973.57479-22-2-0 J.-G.Fredette, Deputy Minister.Liquidation \u2014 Loi de la Winding-Up Act L'ASSOCIATION COOPERATIVE FORESTIERE DE TRINITE DES MONTS (Loi des associations coopératives) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de « L'ASSOCIATION COOPERATIVE FORESTIERE DE TRINITE DES MONTS », tenue à Trinité des Monts, dans le district électoral de Rimouski, le 30 septembre 1973, il a été résolu de liquider la coopérative et qu'elle soit dissoute, ce conformément aux dispositions de la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Donald Michaud soit nommé liquidateur.Le sous-minislre des institutions financières.compagnies et coopératives, 57452-0 Albert Jessop.L'ASSOCIATION COOPERATIVE FORESTIERE DE TRINITE DES MONTS (Coopérative Associations Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of \"L'ASSOCIATION COOPERATIVE FORESTIERE DE TRINITE DES MONTS\", held in Trinité des Monts, in the Electoral District of Rimouski, on September 30, 1973, it was resolved that said Cooperative Association be wound-up and that the latter be dissolved, the foregoing in conformity with the provisions of the Cooperative Associations Act and the Winding-Up Act, and that Mr Donald Michaud be appointed liquidator.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institidions, 57452 Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° SS 4175 LA COMPAGNIE BOWKERAMA LIMITEE BOWKERAMA COMPANY LIMITED Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie « LA COMPAGNIE BOWKERAMA LIMITEE \u2014 BOWKERAMA COMPANY LIMITED », tenue à Granby, le 9 février 1974, il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Philippe A.Jolin, c.a., a été nommé liquidateur.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57453-0 976-69 LA COMPAGNIE BOWKERAMA LIMITEE BOWKERAMA COMPANY LIMITED Notice is given that at a special general meeting of the shareholders of \"LA COMPAGNIE BOWKERAMA LIMITEE \u2014 BOWKERAMA COMPANY LIMITED\", held in Granby, on February 9, 1974, it was resolved that the affairs of the said company be wound up, and that the latter be dissolved, pursuant to the Winding-Up Act, and that Mr.Philippe A.Jolin, c.a., be appointed liquidator.57453 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.976-69 STUDIO VENUS & APOLLON INC.Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie « STUDIO VENUS & APOLLON INC.», tenue à Montréal, le 26 septembre 1973, il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Jean-Pierre Savard a été nommé liquidateur.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57454-0 721611 STUDIO VENUS & APOLLON INC.Notice is given that at a special general meeting of the shareholders of \"STUDIO VENUS & APOLLON INC.\", held in Montreal on September 26, 1973, it was resolved that the affairs of said company be wound up and that the latter be dissolved, pursuant to the Winding-Up Act, and that Mr.Jean-Pierre Savard be appointed liquidator.57454 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.721611 VAL D'OR GOLF CLUB INC.CLUB DE GOLFE VAL D'OR INC.Avis est donné que la compagnie « VAL D'OR GOLF CLUB INC.\u2014 CLUB DE GOLFE VAL D'OR INC.», constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 13 septembre 1957, avec siège social à Val d'Or, a été dissoute le 4 avril 1974, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57455-0 12578-57 VAL D'OR GOLF CLUB INC.CLUB DE GOLFE VAL D'OR INC.Notice is given that \"VAL D'OR GOLF CLUB INC \u2014 CLUB DE GOLFE VAL D'OR INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by-letters patent dated September 13, 1957, with its head office in Val d'Or, was dissolved on April 4, 1974, pursuant to the Winding-Up Act.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57455 12578-57 Nominations Appointments Il a plu au lieutenant-gouverneur de la province de Québec, l'honorable Hugues Lapointe, cp., c.r., de nommer les personnes suivantes comme aides de camp honoraires, en date du 1er juin 1974: lieutenant-colonel Robert-Paul Boucher, c.d.lieutenant-colonel Marcel Belleau, c.d.lieutenant-colonel Michel Giguère, cd.57461-0 Le colonel d'aviation, Gabriel Taschereau, Chef de cabinet et aide de camp principal.The Lieutenant-Governor of the Province of Québec, the Honourable Hugues Lapointe, p.c., tj.c, has been pleased to appoint the following as honorary Aides-de-Camp, as of 1st June 1974: Lieutenant-Colonel Robert-Paul Boucher, c.d.Lieutenant-Colonel Marcel Belleau, c.d.Lieutenant-Colonel Michel Giguère, c.d.57461 Colonel (Air), Gabriel Taschereau, Executive Assistant and First Aide-de-Camp. 4176 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Assemblée nationale National Assembly Projet de loi référé à une Commission parlementaire Avis public est par les présentes donné que le projet de loi 22 intitulé: « Loi sur la langue officielle » a été référé, après la première lecture, pour étude à la commission élue permanente de l'Éducation, des Affaires culturelles et des Communications.Les personnes ou groupes qui désirent se présenter ou se faire entendre devant cette commission ont jusqu'au 10 juin 1974, 17 heures, pour déposer au secrétariat des commissions parlementaires 100 exemplaires de leur mémoire, accompagnés de 200 copies d'un bref résumé.Le tout devra être expédié à la compétence de M.Jacques Pouliot.Secrétaire des Commissions, Chambre 2 \u2014 Édifice A \u2014 Téléphone 643-2722.La première séance de cette commission aura lieu le 11 juin 1974 à 16 heures au Salon rouge de l'Assemblée nationale.Québec, ce 21 mai 1974.Le secrétaire des Commissions, 57393-21-3-0 Jacques Pouliot.National Assembly Bill referred to a Parliamentary Committee Public notice is hereby given that following first reading, Bill 22 \"Official Language Act\" has been referred to the Parliamentary Committee on Education, Cultural Affairs and Communications.Persons or groups who wish to appear before or be heard by this Committee must deposit, before 5 o'clock on June 10th one hundred copies of their briefs together with two hundred copies of a short summary.All documents or memoirs should be forwarded to Jacques Pouliot, Secretary of Committees, Room 2, Building A, Phone number 643-2722.The first meeting will take place on June 11th at the Salon Rouge, National Assembly, at 16 hours.Québec, May 21, 1974.57393-21-3-0 Jacques Pouliot, Secretary of Committees.Curatelle publique Public Curator-ship Succession Joseph Bouthillier Succession de Joseph Bouthillier, en son vivant de 5185, chemin Chambly St-Hubert, P.Q.décédé le 6 mars 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57412-0 Estate of Joseph BouthiUier Estate of the late Joseph Bouthillier, in his lifetime of 5185, Chambly Road S.Hubert, P.Q.who deceased on March 6, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address,- payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6 57412 Succession Joséphine Castonguay Succession de Joséphine Castonguay, en son vivant de Ste-Hélène Kamouraska, décédée le 30 décembre 1966.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que., H2N 1N6 57413-0 Estate of Joséphine Castonguay Estate of the late Joséphine Castonguay, in his lifetime of Ste.Hélène Kamouraska, who deceased on December 30, 1966.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montréal, Que., H2N 1N6 57413.0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4177 Succession René Côté Succession de René Côté, en son vivant d'Arthabaska, décédé le 4 août 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que., H2N 1N6 57414-0 Estate of René Côté Estate of the late René Côté, in his lifetime of Artha-baska, who deceased on August 4, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6 57414-0 Succession Paul Desrochers Succession de Paul Desrochers, en son vivant de 2300, chemin St-Louis Sillery, P.Q.décédé le 17 juillet 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57415-0 Estate of Paul Desrochers Estate of the late Paul Desrochers, in his lifetime of 2300, St.Louis Road Sillery, P.Q.who deceased on July 17, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6 57415-0 Succession J.Armand Filion Succession de J.Armand Filion, en son vivant de 19, rue St-Magloire Rivière-du-Loup, P.Q.décède le 19 octobre 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57416-0 Estate of J.Armand Filion Estate of the late J.Armand Filion, in his lifetime of-19, St.Magloire Street, Rivière-du-Loup, P.Q.who deceased on October 19, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6 57416-q Succession Augustus-Harold Harries Succession de Augustus-Harold Harries, en son vivant de 3415, avenue Girouard, app.601, Montréal, Que., décédé le 29 décembre 1969.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57417-0 Estate of Augustus-Harold Harries Estate of the late Augustus-Harold Harries, in his lifetime of 3415, Girouard Ave., Apt.601, Montreal, Que., who deceased on December 29, 1969.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57417-0 4178 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Succession Pierre Miquclon Succession de Pierre Miquelon, en son vivant de 2551, rue Portland, Sherbrooke, Que., décédé le 18 septembre 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57418-o Succession J.M.A.Racctte Succession de J.M.A.Racette, en son vivant de 1681 St-André, Montréal, Que., décédé le 15 avril 1955.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310 boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57419-o Succession Ariette Tremblay Succession de Ariette Tremblay, en son vivant de 6500, rue St-Vallier, Montréal, Que., décédée le 20 février 1971.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal, Que.H2N 1N6 57420-o Estate of Pierre Miquelon Estate of the late Pierre Miquelon, in his lifetime of 2551, Portland Street, Sherbrooke, Que.who deceased on September 18, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57418-0 Estate of J.M.A.Racette Estate of the late J.M.A.Racette, in his lifetime of 1681 St-André, Montreal, Que., who deceased on April 15th, 1955.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57419-o Estate Ariette Tremblay Estate of the late Ariette Tremblay, in her lifetime of 6500, St.Vallier, Montreal, Que., who deceased on February 20, 1971.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2X 1N6 57420-o Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions CAISSE D'ECONOMIE DE L'ESTRIE (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 14 mai 1973 par la « LA CAISSE D'ECONOMIE DES ENSEIGNANTS DE L'ESTRIE », changeant son nom en celui de « CAISSE D'ECONOMIE DE L'ESTRIE » et de changer son groupe qui était « les enseignants et les employés des CAISSE D'ECONOMIE DE L'ESTRIE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the bylaw adopted on May 14, 1973 by the \"CAISSE D'ECONOMIE DES ENSEIGNANTS DE L'ESTRIE\", changing its name to that of \"CAISSE D'ECONOMIE DE L'ESTRIE\" and changing its group which was that of \"the teachers and employees GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4179 commissions scolaires faisant partie de la commission scolaire régionale de l'Estrie, les enseignants et les employés de la commission scolaire régionale de l'Estrie, les enseignants, les employés et les étudiants du collège d'enseignement général et professionnel de Sherbrooke, les enseignants, les employés et les étudiants de l'Université de Sherbrooke, les employés de Seroc Inc., les employés de l'Association Coopérative d'Economie Familiale de l'Estrie, les membres du Club Coopératif de Consommation de Frontenac, les employés de l'Association Catholique des Enseignants de l'Estrie et les membres du club coopératif de consommation de Sherbrooke » en celui de « les enseignants et les employés des commissions scolaires faisant partie de la commission scolaire régionale de l'Estrie, les enseignants et les employés de la commission scolaire régionale de l'Estrie, les enseignants, les employés et les étudiants du collège d'enseignement général et professionnel de Sherbrooke, les enseignants, les employés et les étudiants de l'Université de Sherbrooke, les employés de Seroc Inc., les employés de l'Association Coopérative d'Economie Familiale de l'Estrie, les membres du Club Coopératif de Consommation de Frontenac, les employés de l'Association Catholique des Enseignants de l'Estrie, les membres du club coopératif de consommation de Sherbrooke, les employés du Conseil Central des Syndicats Nationaux de Sherbrooke Inc.(CSN), les employés de Domtar Packaging Ltd.(à East Angus), les employés de l'Hôpital Frère André, les employés de Domtar Woodlands Ltd.(à East Angus), les employés de l'Hôpital St-Joseph du Lac Mégantic ».Québec, le 22 avril 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57423-0 Albert Jessop.of the school boards being part of the Estrie Regional School Board, the teachers and employees of the Estrie Regional School Board, the teachers, employees and students of the Sherbrooke General and Vocational College, the teachers, employees and students of Sherbrooke University, the employees of Seroc Inc., the employees of l'Association Coopérative d'Economie Familiale de l'Estrie, the members of Club Coopératif de Consommation de Frontenac, the employees of l'Association Catholique des Enseignants de l'Estrie and the members of the Sherbrooke consumers' cooperative club\" to that of \"the teachers and employees of the school boards being part of the Estrie Regional School Board, the teachers and employees of the Estrie Regional School Board, the teachers, employees and students of the Sherbrooke General and Vocational College, the teachers, employees and students of Sherbrooke University, the employees of Seroc Inc., the employees of l'Association Coopérative d'Economie Familiale de l'Estrie, the members of Club Coopératif de Consommation de Frontenac, the employees of l'Association Catholique des Enseignants de l'Estrie, the members of the Sherbrooke consumers' cooperative club, the employees of the Conseil Central des Syndicats Nationaux de Sherbrooke Inc.(CSN), the employees of Domtar Packaging Ltd.(in East Angus), the employees of Frère André Hospital, the employees of Domtar Woodlands Ltd.(in East Angus), the employees of St.Joseph du Lac Mégantic Hospital\".Québec, April 22, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57423 Companies and Cooperatives.Ministère des institutions Department of Financial financières, compagnies Institutions, Companies et coopératives and Cooperatives Assurances Insurance SERVICE FIRE INSURANCE COMPANY OF NEW-YORK Avis de changement de nom Avis est par les présentes donné que « SERVICE FIRE INSURANCE COMPANY OF NEW-YORK », constituée en corporation sous l'empire des lois de l'état de New-York, États-Unis d'Amérique, et enregistrée au Service des assurances du Québec sous le numéro 468, a changé son nom en celui de « NORTH AMERICAN COMPANY FOR PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE ».Donné à Chicago, Illinois, États-Unis d'Amérique, le 1er avril 1974.Le Vice-Président, 57422-22-2-0 Thomas-F.Newman, Jr.SERVICE FIRE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK Notice of change of name Notice is hereby given that \"SERVICE FIRE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK\", incorporated under the laws of the State of New York, United States of America, and registered with the Department of Insurance of Québec under number 468, has changed its name to \"NORTH AMERICAN COMPANY FOR PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE\".Given at Chicago, Illinois, United States of America, the 1st of April 1974.Thomas F.Newman, Jr., 57422-22-2-0 Vice President. 4180 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st.1974, Vol.106, No.22 FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA », dont le siège social est situé à Seattle, Washington, Etats-Unis d'Amérique, a cessé de faire affaires dans le Québec le 15 mars 1974; Attendu que ladite compagnie a produit au Service des assurances, le 15 mars 1974, une déclaration assermentée à l'effet qu'elle n'avait, au 15 mars 1974, aucune obligation au Québec.En conséquence, avis est par les présentes donné que les permis et certificat d'enregistrement de « FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA » sont annulés à compter du 15 mars 1974.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 15 mai 1974.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le Surintendant des assurances, 57421-22-2-0 Roger-A.Camaraire.FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Notice of Cancellation of Licence and Certificate of Registration Whereas \"FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA\", whose head office is situated at Seattle, Washington, United States of America, has ceased to do business in Québec as from the 15th of March 1974; Whereas the said company has filed, on the 15th of March 1974, with the Insurance Branch, a sworn declaration to the effect that it had, as of the 15th of March 1974, no obligations in Québec.Therefore, notice is herebv given that the licence and certificate of registration of \"FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA\" are cancelled as from the 15th of March 1974.Given at the office of the Insurance Branch.Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 15th of May 1974.For the Minister of Financial Institutions, Companies an! Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire.57421-22-2-o Superintendent of Insurance.Société d'habitation du Québec Québec Housing Corporation Cité de Joliette Avis public de l'application du programme de renovation Conformément aux articles 33 et 34 de la Loi de la Société d'Habitation du Québec (15-16 Elizabeth II, chapitre 55), avis public est, par les présentes, donné que le Conseil Municipal de la Cité de Joliette a adopté, lors d'une assemblée régulière du Conseil tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil le 22 avril 1974, le programme prioritaire addendum numéro 3, concernant les lots 547-P-l, 547-P-2 du cadastre de la Ville de Joliette Division d'Enregistrement de Joliette, addendum connu sous le nom de « PERIPHERIE PONT CHEVALIER ».Les principaux travaux à exécuter consistent à acquérir les bâtiments visés au programme pour les raisons de vétusté ou de réaménagement.De plus, le Conseil de la Cité de Joliette procédera à un réaménagement de voirie.Les nouvelles réglementations et modifications aux règlements existants, adoptées en vertu de ce programme et devant entrer en vigueur en vertu de l'article 41 de la Loi de la Société d'Habitation du Québec au moment où le territoire dans lequel elles doivent s'appliquer est décrété « zone de rénovation », sont les suivantes: le règlement de construction avec ses modifications, le règlement de zonage et le code du bâtiment.City of Joliette Public notice for the carrying out of a renewal program Pursuant to sections 33 and 34 of the Québec Housing Corporation Act, (15-16 Elizabeth II, Chapter 55), public notice is hereby given that, at a regular meeting of the Municipal Council of the City of Joliette, held on April 22, 1974, at the Council's usual meeting place, said Council adopted addendum number 3 to the priority program, concerning lots 547-Pt-l and 547-Pt-2 of the cadastre for the City of Joliette, Joliette Registration Division, which addendum is known under the name of \"PERIPHERIE PONT CHEVALIER\".The principal improvement works consist in purchasing the buildings contemplated in the program because of their state of decrepitude or need for improvement.Furthermore, the Council of the City of Joliette will undertake a road improvement program.The new regulations and modifications to existing bylaws which were adopted in connection with this program and which will come into force, pursuant to section 41 of the Québec Housing Corporation Act, at the time when the territory in which they are to apply is declared \"renewal zone\", are the following: the Building Bylaw with its modifications, the Zonage Bylaw and the Building Code. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' aimée, n° 22 4181 Les intéressés pourront consulter les documents constituant ce programme à l'Hôtel de Ville, 614, Boulevard Manseau à Joliette, aux heures normales d'ouverture des bureaux de la rénovation (téléphone: 756-8055, local 62).De plus, les intéressés pourront se procurer au même endroit une ou des copies du programme prioritaire addendum numéro 3, au prix unitaire selon le coût, mais pas plus de 85.00.Enfin, les intéressés peuvent transmettre par écrit leurs objections au programme à la Société d'Habitation du Québec, Ministère des Affaires Municipales, Complexe « G », 29ième étage, Québec et ce, pas plus tard que le 3ième jour de juillet 1974.Donné à Joliette, ce 23e jour d'avril 1974.(Sceau) L'assislanf-secrétaire-trésorier, 57426-0 Rosaire Beaudry.All interested parties may consult the documents which constitute this program at the City Hall, 614 Manseau Boulevard, in Joliette, during the regular business hours of the Renewal Office (Telephcne: 756-8055, extension 62).Furthermore, all interested parties may obtain copy or copies of addendum number 3 to the priority program at the aforesaid Office for a unit price fixed according to the cost of the document, which price must not exceed 85.00.Lastly, all interested parties may forward their objections to the program, in writing, to the Québec Housing Corporation, Department of Municipal Affairs, Building \"G\", 29th Floor, Québec, not later than July 3, 1974.Established in Joliette, this 23rd day of April, 1974.(Seal) Rosaire Beaudry, 57426 Assistant Secretary-Treasurer.Services de santé et services sociaux \u2014 Loi sur Health Services and Social Services \u2014 Act on CENTRE HOSPITALIER ST-BENOIT Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRE HOSPITALIER ST-BENOIT».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est « CENTRE HOSPITALIER ».Le siège social de l'établissement est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.William Tetley.57401-o 1356-0099 CENTRE HOSPITALIER ST-BENOIT The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has issued letters patent incorporating an establishment under the name of \"CENTRE HOSPITALIER ST-BENOIT\".Said pubic establishment shall be classified as a \"HOSPITAL CENTRE\".The head office of the establishment is in Montreal, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57401 1356-0099 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES CENTRE-SUD Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des loi de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES CENTRE-SUD ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ».Le siège social de l'établissement est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57401-o 1354-5306 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES CENTRE-SUD The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has issued letters patent incorporating an establishment under the name of \"CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES CENTRE-SUD.\" Said public establishment shall be classified as a \"LOCAL COMMUNITY SERVICE CENTRE\".The head office of the establishment is in Montreal, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57401 1354-5306 4182 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.n CENTRE D'ACCUEIL CHAMPLAIN Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRE D'ACCUEIL CHAMPLAIN ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est « CENTRE D'ACCUEIL ».Le siège social de l'établissement est à Brossard, district judiciaire de Montréal.Le minisire des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57401-o 1354-5322 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE L'ILE DE HULL Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 1er mai 1974 à la corporation « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAniES ILE DE HULL, POINTE-GATINEAU ET TOURAINE », changeant son nom en celui de « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE L'ILE DE HULL ».Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57401-o SS: 10-72 CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA FREGATE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 1er nu i 1974 à la corporation « CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DU BAS DU FLEUVE », changeant son nom en celui de « CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA FREGATE ».Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57401-o SS: 34-1973 CENTRES MARRONIERS Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRES MARRONIERS ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est « CENTRE D'ACCUEIL ».CENTRE D'ACCUEIL CHAMPLAIN The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services.Statutes of 1971, Chapter 48, he has issued letters patent incorporating an establishment under the name of \"CENTRE D'ACCUEIL CHAMPLAIN\".Said establishment shall be classified as a \"RECEPTION CENTRE\".The head office of the establishment is in Brossard, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57401 1354-5322 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE L'ILE DE HULL The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 41 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has granted supplementary letters patent, dated May 1, 1974, to the corporation \"CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ILE DE HULL, POINTE-GATINEAU ET TOURAINE\", changing its name to that of \"CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE L'ILE DE HULL\".William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57401 SS: 10-72 CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA FREGATE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 41 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has granted supplementary letters patent, dated May 1, 1974, to the corporation \"CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DU BAS DU FLEUVE\", changing its name to that of \"CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA FREGATE\".William Tetley, Minuter of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57401 SS: 34-1973 CENTRES MARRONIERS The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has issued letters patent incorporating an establishment under the name of \"CENTRES MARRONIERS\".Said public establishment shall be classified as a \"RECEPTION CENTRE\". GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° SS 4183 Le siège social de l'établissement est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57401-q 1355-7145 The head office of this establishment is in Montreal, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57401 1355-7145 CENTRE HOSPITALD2R DE LACHINE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'avril 1974, convertissant « HOPITAL ST-JOSEPH DE LACHINE », constituée le 31 mars 1960 en vertu des dispositions de l'article 14 de la Loi modifiant la charte de La Communauté des Soeurs de Charité de la Providence, chapitre 176 des lois de 1958-1959, en un établissement public sous le nom de « CENTRE HOSPITALIER DE LACHINE».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est « CENTRE HOSPITALIER».Le siège social de l'établissement est à Lachine, district judiciaire de Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.5740l-o 1354-5256 CENTRE HOSPITALIER DE LACHINE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services.Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent dated April 17,1974, converting \"HOPITAL ST-JOSEPH DE LACHINE\", incorporated on March 31, 1960, pursuant to the provisions of section 14 of the Act to amend the charter of La Communauté des Soeurs de Charité de la Providence, Chapter 176 of the Statutes of 1958-59, into a public establishment under the name of \"CENTRE HOSPITALIER DE LACHINE\".Said public establishment shall be classified as a \"RECEPTION CENTRE\".The head office of the establishment is located in Lachine, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57401 1354-5256 Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses JAMES T.BARNES MORTGAGE LOAN COMPANY LA SOCIETE DE PRETS HYPOTHECAIRES JAMES T.BARNES Avis est donné que, le 8 mars 1974, le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a accordé un permis à la compagnie « JAMES T.BAR-NES MORTGAGE LOAN COMPANY \u2014LA SOCIETE DE PRETS HYPOTHECAIRES JAMES T.BARNES », l'autorisant à faire des affaires dans la province, en vertu des dispositions de la Loi des sociétés de prêts et de placements, chapitre 289 des Statuts refondus de 1964.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est monsieur Philip O'Brien, a/s Devencore Realties Ltd., 625, boulevard Dorchester ouest, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 625, boulevard Dorchester ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57401 1354-5140 JAMES T.BARNES MORTGAGE LOAN COMPANY LA SOCIETE DE PRETS HYPOTHECAIRES JAMES T.BARNES Notice is given that, on 8th day of March, 1974, a license was granted by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"JAMES T.BARNES MORTGAGE LOAN COMPANY \u2014 LA SOCIETE DE PRETS HYPOTHECAIRES JAMES T.BARNES\", authorizing it to carry on business in the Province pursuant to the provisions of the Loan and Investment Societies Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 289.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Philip O'Brien, c/o Devencore Realties Ltd., 625 Dorchester Boulevard West, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 625 Dorchester Boulevard West, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57401-o 1354-5140 4184 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 J.S.CUMMINGS, INC.Avis est donné que, en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « J.S.CUMMINGS, INC.» a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est monsieur Thomas V.Lavoie, 800, d'Youville, appartement 1700, Québec.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est situé au 800, d'Youville, appartement 1700, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57401 1355-2146 J.S.CUMMINGS, INC.Notice is given that under the Extra-Provincial Companies Act, \"J.S.CUMMINGS, INC.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Thomas V.Lavoie, 800 d'Youville, Suite 1700, Québec.The principal office of the company in the Province is at 800 d'Youville, Suite 1700, Québec, judicial District of Québec.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57401-o 1355-2146 Ventes pour taxes Sales for taxes Ville de Saint-Luc Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Cyrisse Morrissette, greffier de la corporation municipale de la ville de Saint-Luc.que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique en la Salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de Saint-Luc.JEUDI le VINGT-SEPTIÈME jour de JUIN 1974 à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêts, plus les frais subséquent?encourus à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant la vente.La Commission municipale de Québec, par décision en date du 6 mars 1974, a autorisé une enumeration abrégée des numéios cadastraux des immeubles, le tout conformément aux dispositions de l'article 550 de la Loi des cités et villes de la province de Québec.Town of Saint Luc Public notice is hereby given by the undersigned, Cyrisse Morrissette, clerk of the municipal corporation of the town of Saint-Luc, that the immovables hereinafter mentioned will be sold by public auction in the Council Hall of the Town of Saint-Luc, place where the council holds its meetings, on THURSDAY the TWENTY-SEVENTH day of JUNE 1974, at TEN o'clock in the morning for municipal, school taxes, interests plus the fees subsequently incurred unless such taxes, interest and fees are paid before the sale, to the undersigned.The Québec Municipal Commission, by a decision dated March 6, 1974, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immovables under the dispositions of the article 550 of the compilation of Statutes concerning Cities and Towns Act of the Province of Québec.Noms Names Nos de cadastre Cadastral numbers Taxes Roger Labelle.3-035.Roger Labelle.3-037.Roger Labelle.3-038.Raymond, Paul-Aimé.5-005.Roy, Camille.6-117! Stephanatos, Angelo.8-116.Stephanatos, Angelo.8-117.Kabamaras, Anasthasia.8-123.Lambrou, Kostantinos.8-138! Papas, Paula.8-160.Xanthopoulos, Despina.8-161.Terzopoulos, Nick Mme.8-162.Terzopoulos, Nick Mme.! 8-163! Kakaletris, Spiros.8-170 Vaggale, Stranoula.8-208.Vlahas, Theodoros.8-264 Taxes munie.\tIntérêts\tscolaires\tIntérêts\tTotal M unie.\tInterest\tSchool\tInterest\t taxes\t\ttaxes\t\t $ 26.03\tS 1.14\t\t\tS 27.17 26.79\t1.17\t\t\t27.96 26.79\t1.17\t\t\t27.96 16.37\t0.65\t\t\t17.02 21.63\t0.91\tS 12.27\t$ 1.90\t36.71 10.38\t0.43\t\t\t10.81 10.48\t0.43\t\t\t10.91 22.55\t0.96\t22.47\t3.16\t49.14 10.48\t0.43\t9.72\t1.94\t22.57 18.11\t0.74\t12.27\t1.90\t33.02 10.48\t0.43\t6.14\t1.46\t18.51 10.48\t0.43\t6.14\t1.46\t18.51 10.48\t0.43\t6.14\t1.46\t18.51 13.07\t0.67\t\t\t13.64 13.40\t0.57\t6.14\t1.46\t21.57 10.48\t0.43\t9.72\t1.94\t22.57 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4185 Taxes Taxes Noms Nos de cadastre munie.Intérêts scolaires Intérêts Total Names Cadastral numbers Munie.Interest School Interest taxes taxes Tertis.Nick.8-273.Tenia.Nick.I-2!! Boletis.ChristoB.8-288.Boletis.John.8-289.Stamatopoulos, Christo.8-291.Kriskirror, Demireigil.8-312.Lachance, Emmanuel.12-017.Lachance, Emmanuel.12-018.Lachance, Emmanuel.12-019.Mailloux, Claude.12-082.Lamarche, Hermenegille.15-003.Fortier.L.B.& Weitzel, T.H.16-021 Fortier, L.B.& Weitzel, T.H.15-022.Bélanger, Gérard.15-025.Fortier, Rolland.15-055.Véronneau.Laurent.15-062.Racicot, Gilles.15-073.Fortier, L.B.& Weitzel, T.H.16-079.Fortier, L.B.& Weitzel, T.H.15-080.Fortier.L.B.& Weitzel.T.H.16-081.Fortier.Rolland.15-083.Fortier, L.B.& Weitzel.16-085.Fortier, Rolland.15-090.Fortier.Rolland.15-093.Fortier, Rolland.15-094.Fortier, Rolland.16-095.Fortier, L.B.& Weitzel.15-096.Fortier, L.B.& Weitzel.15-099.Blondeau, Yvon et ai.16-104.Bélanger, Gérard.15-126.Despré.Hervé Mme.15-127.Fortier, Rolland.16-129.Fortier, Rolland.15-131.Fortier, Rolland.15-133.Fortier, Rolland.16-135.Fortier, Rolland.16-136.Fortier.Rolland.15-137.Fortier.Rolland.15-138.Fortier.Rolland.15-139.Fortier, Rolland.16-143.Fortier, Rolland.16-144.Fortier, Rolland.16-147.Fortier, Rolland.16-148.Fortier, Rolland.16-149.Fortier, Rolland.16-153.Fortier, Rolland.15-156.Fortier, Rolland.16-157.Fortier, Rolland.15-159.Fortier, Rolland.16-160.Fortier.Rolland.15-163.Laçasse, Guy.15-170.Fortier, Rolland.16-171.Fortier, Rolland.15-172.Fortier, Rolland.15-173.Fortier, L.B.A Weitzel.16-182.Fortier, Rolland.16-186.Fortier, Rolland.15-187.Fortier, Rolland.15-188.Fortier, Rolland.16-189.Fortier, Rolland.16-190.Venise Développement Co.16-195.Fortier, Rolland.16-206.Fortier, Rolland.15-207.Fortier, Rolland.15-208.Fortier, Rolland.15-209.Fortier, Rolland.16-210.Fortier, Rolland.15-211.Fortier, Rolland.16-218.Fortier, L.B.A Weitzel.15-219.Fortier.L.B.& Weitiel.15-221.Fortier.L.B.& Weitzel.16-222.S 12.29\tS 0.52\t\t\t8 12.81 22.86\t0.97\t\t\t23.83 13.41\t0.58\t$ 13.92\tS 3.84\t31.75 13.40\t0.57\t13.92\t3.84\t31.73 10.48\t0.43\t3.04\t0.17\t14.12 \t\t12.27\t1.90\t14.17 198.95\t9.64\t91.48\t11.24\t311.31 198.10\t9.60\t91.48\t11.24\t310.42 198.14\t9.60\t91.48\t11.24\t310.46 100.93\t4.95\t\t\t105.88 109.54\t1.61\t\t\t111.15 26.77\t1.25\t\t\t28.02 26.77\t1.25\t\t\t28.02 26.77\t1.25\t\t\t28.02 548.92\t26.55\t\t\t575.47 21.15\t0.88\t\t\t22.03 91.51\t4.34\t\t\t95.85 20.04\t0.92\t\t\t20.96 20.02\t0.92\t\t\t20.94 13.90\t0.60\t\t\t14.50 13.89\t0.60\t\t\t14.49 20.82\t0.95\t\t\t21.77 13.89\t0.60\t\t\t14.49 14.44\t0.63\t\t\t15.07 16.21\t0.72\t\t\t16.93 16.22\t0.72\t\t\t16.94 25.29\t1.18\t\t\t26.47 16.19\t0.67\t\t\t15.86 28.49\t1.33\t\t\t29.82 24.87\t1.15\t\t\t26.02 22.09\t1.01\t\t\t23.10 17.30\t0.77\t\t\t18.07 17.01\t0.77\t\t\t17.78 17.01\t0.77\t\t\t17.78 12.78\t0.55\t\t\t13.33 14.11\t0.62\t\t\t14.73 14.11\t0.62\t\t\t14.73 14.12\t0.62\t\t\t14.74 14.12\t0.62\t\t\t14.74 14.12\t0.62\t\t\t14.74 15.26\t0.68\t\t\t15.94 7.88\t0.30\t\t\t8.18 13.89\t0.60\t\t\t14.49 13.90\t0.60\t\t\t14.50 13.89\t0.60\t\t\t14.49 13.90\t0.60\t\t\t14.50 13.89\t0.60\t\t\t14.49 13.89\t0.60\t\t\t14.49 12.77\t0.55\t\t\t13.32 13.04\t0.57\t\t\t13.61 20.35\t0.93\t\t\t21.28 14.11\t0.62\t\t\t14.73 14.11\t0.62\t\t\t14.73 14.11\t0.62\t\t\t14.73 18.28\t0.83\t\t\t19.11 12.77\t0.55\t\t\t13.32 12.77\t0.55\t\t\t13.32 12.77\t0.55\t\t\t13.32 12.77\t0.55\t\t\t13.32 12.76\t0.55\t\t\t13.31 17.76\t0.80\t\t\t18.56 17.82\t0.80\t\t\t18.62 16.04\t0.71\t\t\t16.75 12.54\t0.54\t\t\t13.08 12.54\t0.54\t\t\t13.08 12.55\t0.54\t\t\t13.09 12.56\t0.54\t\t\t13.10 15.66\t0.69\t\t\t16.35 22.78\t1.04\t\t\t23.82 17.22\t0.77\t\t\t17.99 17.21\t0.77\t\t\t17.98 4186 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June lit, 1974, Vol.106, No.H Noms Names Nos de cadastre Taxes munie.Cadastral numbers Munie.Intérêts Interest Taxes scolaires School Intérêts Interest Total taxes\t\ttaxes\t\t S 14.27\t8 0.62\t\t\tS 14.89 14.27\t0.62\t\t\t14.89 14.87\t0.65\t\t\t15.52 14.87\t0.65\t\t\t15.52 14.87\t0.65\t\t\t15.52 14.87\t0.65\t\t\t15.52 14.87\t0.65\t\t\t15.52 16.76\t0.75\t\t\t17.51 15.76\t0.69\t\t\t16.45 21.76\t1.00\t\t\t22.76 11.70\t0.49\t\t\t12.19 20.17\t0.92\t\t\t21.09 14.21\t0.62\t\t\t14.83 23.09\t1.07\t\t\t24.16 18.29\t0.83\t\t\t19.12 230.37\t11.21\t% 34.71\t$ 4.17\t280.46 168.23\t8.09\t\t\t176.32 13.40\t0.57\t\t\t13.97 13.47\t0.58\t\t\t14.05 17.55\t0.75\t16.11\t2.46\t36.87 17.53\t0.75\t16.11\t2.46\t36.85 12.77\t0.51\t16.11\t2.46\t31.85 9.84\t0.40\t\t\t10.24 21.71\t0.92\t38.25\t5.19\t66.07 12.88\t0.55\t3.04\t0.17\t16.64 8.03\t0.31\t13.60\t2.45\t24.39 11.77\t0.50\t6.14\t1.46\t19.87 10.81\t0.45\t5.86\t0.69\t17.81 702.11\t29.87\t\t\t731.98 .1.278.72\t59.98\t245.25\t18.62\t1,602.57 148.25\t7.21\t7.25\t0.31\t163.02 150.95\t7.36\t7.25\t0.31\t165.87 40.36\t1.84\t23.72\t3.30\t68.22 40.35\t1.84\t22.72\t3.30\t68.21 40.31\t1.84\t12.27\t1.90\t56.32 264.37\t12.09\t451.82\t53.46\t781.74 74.22\t3.36\t42.59\t4.24\t124.41 129.67\t6.13\t42.60\t4.24\t182.64 273.31\t13.32\t42.59\t44.24\t333.46 152.56\t7.20\t94.24\t11.14\t265.14 123.43\t5.79\t30.66\t3.53\t163.41 147.46\t6.99\t30.66\t3.53\t188.64 161.67\t7.70\t43.28\t4.76\t217.41 145.45\t6.89\t30.66\t3.53\t186.53 149.64\t7.10\t30.66\t3.53\t190.93 90.47\t4.14\t43.10\t4.76\t142.47 311.93\t15.15\t138.39\t16.59\t482.06 160.78\t7.66\t\t\t168.44 \t\t36.07\t3.76\t39.83 65.20\t2.84\t57.40\t6.51\t131.95 107.91\t4.98\t58.88\t6.73\t178.50 413.69\t18.70\t370.38\t39.10\t841.77 43.89\t1.81\t\t\t45.70 68.70\t2.51\t61.40\t7.02\t129.63 305.47\t10.22\t\t\t315.69 56.25\t2.35\t36.80\t3.30\t98.70 56.27\t2.35\t36.80\t3.30\t98.72 120.53\t5.66\t\t\t126.09 61.81\t2,67\t\t\t64.48 145.83\t6.87\t86.81\t9.80\t249.31 129.24\t6.04\t33.71\t3.48\t172.47 167.34\t8.02\t36.84\t4.13\t216.33 Taxes\t\tTaxes\t\t munie.\tIntérêts\tscolaires\tIntérêts\tTotal Munie.\tInterest\tSchool\tInterest\t taxes\t\ttaxes\t\t «508.53\t«24.82\t\t\tS533.35 Fortier, Rolland.15-226.Fortier, Rolland.15-227.Fortier, Rolland.15-229.Fortier.Rolland.15-231.Fortier, Rolland.15-232.Fortier.Rolland.15-233.Fortier.Rolland.15-234.Fortier, Rolland.16-235.Fortier, Rolland.15-236.Fortier, Rolland.15-237.Fortier.Rolland.15-244.Laçasse, Guy.15-246.Fortier, Rolland.15-248.Fortier.L.B.& Weitzel.15-249.Fortier, Rolland.15-250.Pronto Construction Inc.19-072.Hébert, Rita Mme.19-090.Lachance, Paul.19-114.Si-Martin, Léo.19-176.Ouimet, René.27-285.Ouimet, René Mme.27-286.Vincent, Marcel.27-288.Lapierre, Raymond.48-016.Béland Thérèse.53-006.Daigneault.Anatole.53-025.Vanier.André Mme.53-038.Philly, Georges Mme.53-196.Hudson Holdings Ltd.63-056.Mailloux.Roméo.94-004.Nicol, Louis.99-017.Daigneault & Frère Inc.139-288.Daigneault & Frère Inc.139-290.Pronto Construction Inc.139-291.Pronto Construction Inc.139-292.Daigneault, Anatole et/and Achille.139-294.Gariêpy, Yvon.214-000.Boucher, Léonce.217-199.Beucher, Léonce.217-200.Beucher, Léonce.217-201.Rathé, Roger.217-260.Oryschuck.Eugen.217-277.Oryschuck, Eugen.217-278.Pawagiotis, Iliadis.217-283.Oryschuck, Eugen.217-287.Oryschuck, Eugen.217-294.Panagiotis, Iliadis.217-298.Paquette, Sylvio Mme.217-313.Nadon, Marcel.217-324.Lanctôt, Jean.218-049.Ouimet, René.218-079.Nareau, Lucien.218-080.Asch, Cliffort Mrs.218-082.Pichette, Lucien.218-114.Lachance, Régis.218-20O! Cloutier, Maurice.222-011.Labrecque, Réal.224-042.Labrecque, Réal.224-043 Skytta, Elias.224-060.Rousseau, Félix et Mme.233-276.Deslongchamps, Madeleine.235-062.Cloutier, Jean-Marie.236-135.Véronneau, Suzanne.236-169.Noma Names Herman Koehler. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1971,, 106' année, n° 22 4187 Taxes Taxes Noms munie.Intérêts scolaires Intérêts Total Names Munie.Interest School Interest taxes taxes Partie du lot 2-17, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, appartenant à Hermann Koehler, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 101,769.Description: Partie du lot numéro dix-sept de la subdivision officielle du lot numéro deux au cadastre officiel de la paroisse Saint-Luc, mesurant cent quatre-vingt-huit pieds et six dixièmes dans sa ligne est, ladite ligne étant le prolongement de la ligne ouest du lot numéro trois de ladite subdivision, sur quatre-vingt-dix-huit pieds et demi de profondeur, le tout mesure anglaise, plus ou moins; la ligne sud et la ligne sud-ouest de la présente partie de lot étant formées par le trécarré des lots numéros quatre et cinq de ladite subdivision et par la ligne ouest de la présente partie de lot, formant un angle droit avec sa ligne nord.Paul Clouâtre.Partie du lot 3, du cadastre de la Paroisse de Saint-Luc, appartenant à Paul Clouâtre, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 56,759.Description : Partie du lot 3 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant cent quatre-vingts pieds de largeur sur cent quatre-vingt pieds de profondeur, le tout mesure anglaise plus ou moins; borné en front à l'est par le terrain de Arthur Vivier, au nord par partie du même lot numéro trois appartenant à Arthur Clouâtre, au sud et à l'ouest encore par partie du même lot numéro trois restant au vendeur.Ledit Paul Clouâtre a par la suite vendu une partie dudit lot 3, tel qu'il appert de la vente enregistrée le 31 août 1973, sous le No 117,830, se décrivant comme suit: Partie du lot 3 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, contenant cent quatre-vingts pieds de largeur sur cent quatre-vingts pieds de profondeur, mesures anglaises, et bornée à l'est par partie dudit lot, appartenant à Arthur Vivier, au nord par partie dudit lot, appartenant à Arthur Clouâtre, au sud et à l'ouest par le résidu dudit lot; Cette vente a été consentie à Le Directeur des Terres destinées aux Anciens Combattants.Frank Stamatopoulos et / and John Evgenis.Partie du lot 8, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par lesdits Frank Stamatopoulos et John Evgenis, suivant titre d'acquisition No 101,247.Description : Partie du lot numéro 8, du cadastre officie) de la paroisse de Saint-Luc, mesurant quarante-sept pieds dans sa ligne sud; cent soixante-huit pieds et cinq dixièmes de pied dans sa ligne est; cent vingt-deux pieds et quatre dixièmes de pied dans sa ligne nord et cent quatre-vingt-onze pieds et cinq-dixièmes de pied dans sa ligne sud-ouest.Le tout mesure anglaise, et plus ou moins; Borné: vers le sud-ouest par le chemin public; d'un côté; vers le sud: par partie du lot No 5 dudit cadastre; en arrière: par ladite subdivision dudit lot No 8 et de l'autre côté; par partie dudit lot No 8 appartenant à M.Schneider ou représentants; Contenant en superficie 14,272 pieds carrés.Arsène Mailloux.Partie du lot 12, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par Arsène Mailloux suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 54,211, savoir: Description : Une terre connue comme étant le lot numéro 12 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant ladite terre, trois arpents de front, par trente arpents de profondeur, le tout plus ou moins, sans garantie de mesure précise, le tout plus ou moins, devant tourner au profit ou à la perte de l'acquéreur.A distraire dudit lot No 12, deux lisières de terrain vendues au ministère de la voirie, aux termes d'un acte enregistré à Saint-Jean, sous le No 43.038.Part of lot 2-17, on the cadastre for the Parish of St.Luc.belonging to Hermann Koehler, according to his title-deed registered under number 101,769.Description: Part of lot number seventeen of the official subdivision ol lot number two of the official cadastre of the Parish of St.Luc, measuring one hundred eighty-eight feet and six tenths of a foot in its east line, said line being the continuation of the west line of lot number three of the said subdivision, by ninety-eight feet and a half in depth, the whole English measure, more or less; the south line and the southwest line of the present part of lot being formed by the \"trait-carré\" line of lots numbers four and five of the said subdivision and the west line of the present part of lot forming a right angle with its north line.$320.34 8 14.09 S306.29 t 25.56 «666.28 Part of lot 3, on the cadastre for the Parish of St.Luc, belonging to Paul Clouâtre, according to his title-deed registered under number 56,759.Description: Part of lot 3 on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring one hundred eighty feet in width by one hundred eighty feet in depth, the whole English measure, more or less; bounded in front on the east by the property of Arthur Vivier, on the north by part of said lot number three belonging to Arthur Clouâtre, on the south and west again by a part of same lot number three remaining the property of the vendor.At a later date, the said Paul Clouâtre sold a part of said lot 3, as it appears from the deed of sale registered on August 31, 1973, under number 117,830, which (part) may be described as follows: Part of lot 3 on the official for the Parish of St.Luc, measuring one hundred eighty feet in width by one hundred eighty feet in depth.English measures, and bounded on the east by a part of said lot belonging to Arthur Vivier, on the north by a part of said lot belonging to Arthur Clouâtre, on the south and west by the remainder of said lot.This sale was authorized in favour of the Director, the Veterans' Land Act.57.53 2.41 59.94 Part of lot 8, on the cadastre for the Parish of St.Luc, acquired by the said Frank Stamatopoulos and John Evgenis, according to title-deed number 101,247.Description: Part of lot number 8 on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring forty-seven feet on its south line; one hundred sixty-eight and five tenths feet on its east line; one hundred twenty-two and four tenths feet on its north line and one hundred ninety-one and five tenths feet on ils southwest line.The whole in English measure, and more of less: Bounded towards the southwest by the public road; on one side towards the south by part of lot No.5 of said cadastre; in rear by said subdivision of said lot No.8 and on the other side by part of said lot No.8 belonging to Mr.Schneider or representatives; Covering an area of 14,272 square feet.1,540.96 61.32 1,592.28 Part of lot 12 on the official cadastre for the Parish of St-Luc, acquired by Arsène Mailloux according to his title-deed registered under No.54,211, namely: Description : A farm known as being lot number 12 on the official cadastre for the Parish of St.Luc.said farm measuring three arpents in front, by thirty arpents in depth, the whole more or less, without guarantee as to precise measurement, the whole more or less, any profit or loss borne by the purchaser.Less and to withdraw from said lot No.12, two strips of land sold to the Roads Department, under the terms of a deed registered in St.Jean, under No.43,038. 4188 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Noms Names Taxes munie.Munie, taxes Intérêts Interest Taxes scolaires School taxes Intérêts Interest Total A distraire ce que dessus décrit, diverses parties dudit lot 12, vendues aux termes des actes suivants, par ledit Arsène Mailloux, savoir: Par acte enregistré sous le No 54,619 vente à Dame Armand Mailloux; Par acte enregistré sous le No 54,647, vente à J.A.Dussault; Par acte enregistré sous le No 54,805, vente à Alberta Mailloux; Par acte enregistré sous le No 55,750, vente à Gilbert Lan-glois; Par acte enregistré sous le No 56,000, vente à Raoul Lapal-me; Par acte enregistré sous le No 57,269, vente à Gilbert Langlois; Par acte enregistré sous le No 58,862, vente à Raoul Lapal-me; Par acte enregistré sous le No 58,896, vente à François Mailloux; Par acte enregistré sous le No 59,105, échange entre Arsène Mailloux et Raoul Lapalme; Par acte enregistré sous le No 69,147, vente à Fernand Lajoie; Par acte enregistré sous le No 61,630, vente à Ulysse Mailloux ; Par acte enregistré sous le No 65,511, vente a Antonio Mailloux; Par acte enregistré sous le No 64,656, correction entre Arsène Mailloux et Antonio Mailloux; Par acte enregistré sous le No 64,890, vente à Armand Mailloux; Par acte enregistré sous le No 65,043, vente à Joseph Bonal-do; Par acte enregistré sous le No 65,147, vente à Johnny McDonald; Par acte enregistré sous le No 72,247, vente à Rodrigue Trudeau ; Par acte enregistré sous le No 73,429, vente à Louis Du-fresne; Par acte enregistré sous le No 74,349, correction entre Arsène Mailloux et Louis Dufresne; Par acte enregistré sous le No 74,412, vente à Pierre Benoit; Par acte enregistré sous le No 83,079, correction entre Arsène Mailloux et Pierre Benoit; Par acte enregistré sous le No 84,322, vente à Le Ranch des Six Inc.; Par acte enregistré sous le No 84,700, modification entre Arsène Mailloux et Antonio Mailloux; Par acte enregistré sous le No 86,127, vente à Jacques Mailloux; Par acte enregistré sous le No 88,668, vente à Normand Langlois; Par acte enregistré sous le No 89,700, vente à Jean Baccichet & al.; Par acte enregistré sous le No.90,387, correction par René Baccichet; Par acte enregistré sous le No 88,355, un avis d'expropriation; Par acte enregistré sous le No 98,824, vente par Arsène Mailloux, à Sa Majesté, (Voirie) faisant suite à l'enregistrement No 88,355.Dame Hildegard Eisa Knuepper divorcée de/divorced from Erich Werner Hauptmann Partie du lot 13, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par Dame Hildegard Eisa Knuepfer, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 102,652, savoir: Description : Partie du lot 13, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant cent quarante pieds de largeur dans ses lignes nord et sud, par cent pieds de profondeur; le tout mesure an- To withdraw from aforesaid lot the various parts of said lot 12, sold by said Arsène Mailloux, under the terms of the following deeds, namely : By deed of sale to Mrs.Armand Mailloux registered under the No.64,619; ., By deed of sale to J.A.Dussault registered under the No.54.647; By deed of sale to Alberta Mailloux registered under the No.54,805; By deed of sale to Gilbert Langlois registered under the No.55.750; By deed of sale to Raoul Lapalme registered under the No.66.000; By deed of sale to Gilbert Langlois registered under the No.57,269; By deed of sale to Raoul Lapalme registered under the No.58,862: By deed of sale to François Mailloux registered under the No.58,896; By deed of exchanges between Arsène Mailloux and Raoul Lapalme registered under the No.59,105; By deed of sale to Fernand Lajoie registered under the No.59,147; By deed of sale to Ulysse Mailloux registered under the No.61,630; By deed of sale to Antonio Mailloux registered under the No.65,511; By deed of correction between Arsène Mailloux and Antonio Mailloux registered under the No.64,656; By deed of sale to Armand Mailloux registered under No.64,890; By deed of sale to Joseph Bonaldo registered under No.65,043; By deed of sale to Johnny McDonald registered under No.65,147; By deed of sale to Rodrigue Trudeau registered under No.72.247; By deed of sale to Louis Dufresne registered under No.73,429; By deed of correction between Arsène Mailloux and Louis Dufresne registered under No.74,349; By deed of sale to Pierre Benoit registered under No.74,412; By deed of correction between Arsène Mailloux and Pierre Benoit registered under No.83.079; By deed of sale to Le Ranch des Six Inc.registered under No.84,322; By deed of modification between Arsène Mailloux and Antonio Mailloux registered under No.84,700; By deed of sale to Jacques Mailloux registered under No.86.127: By deed of sale to Normand Langlois registered under No.88.668; By deed of sale to Jean Baccichet et al registered under No.89.700; By deed of correction by René Baccichet registered under No.90,387; oo%rdeed' ie' notice of expropriation, registered under No.88,355; By deed of sale by Arsène Mailloux to Her Majesty, (Roads) registered under No.98,824.following upon registration No.OO.OOO.S 32.21 S 1.44 S 33.65 -wYm °k '\"w3, uï( cadas'\"> of the Parish of St.Luc, pur-tttïïSLS?H!lde^rd Eisa Knuepfer according to her title-deed registered under No.102,652, namely: Description : T \u201enam.2f.10' 13, on.the official cadastre for the Parish of St.»nd S.nfhr\"8 °nu hundr?d forty feet in width on its north and south lines, by one hundred feet in depth; the whole GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° S3 4189 Noms Names Nos de cadastre Cadastral numbers Taxes munie.Munie, taxes Intérêts Interest Taxes scolaires School taxes Intérêts Interest Total glaise, borné, cettedite partie de lot, en front vers le nord par le lot No 13-144 (rue); vers l'est et l'ouest, par parties du lot originaire No 13, et vers le sud par les lots 12-73, et 12-79, dudit cadastre.English measure; said part of lot bounded in front towards the north by lot No.13-144 (street); towards the east and west, by parts of the original lot No.13, and towards south by lots 12-73 and 12-79 on said cadastre.Fabien Charbonneau.Partie du lot 99.du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par Fabien Charbonneau, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 88,143.Description : Partie du lot 99 du cadastre offic'el de la paroisse de Saint-Luc, contenant soixante-dix pieds de largeur, de l'est à l'ouest, sur cent quinze pieds de profondeur, mesures anglaises, bornée en front au nord par le terrain de M.St-Arnaud ou représentants, au sud par le lot No.99-1 (rue ) à l'est par partie dudit lot No 99 appartenant audit M.St-Arnaud ou représentants et à l'ouest par partie de ce dernier lot appartenant au vendeur ou représentants.Jose Arruda Da Ponte Pereira.Partie du lot 159, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par José Arruda Da Ponte Pereira, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 83,777.Description : Partie du lot 159, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant soixante-quinze pieds de largeur, en front, le long de sa ligne nord-ouest, soixante-quinze pieds de largeur, en arrière, le long de sa ligne sud-est, et quatre-vingt-quinze pieds de profondeur dans chacune de ses lignes nord-est et sus-ouest, formant une superficie de 7.125 pieds carrés, mesure anglaise, plus ou moins; et bornée cettedite partie, en front, vers le nord-ouest, d'un côté, et vers le nord-est et de l'autre côté vers le sud-ouest, par parties non subdivisées dudit lot originaire No 159 et en arrière, vers le sud-est, par partie du lot originaire No 151, dudit cadastre.Jaime Pereira De Almeida et Bonifacio Pereira De Almeida.Partie du lot 159, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par lesdits Jaime Pereira De Almeida et Bonifacio Pereira De Almeida, suivant leur titre d'acquisition enregistré sous le No 98,429, savoir: Description: Partie du lot 159, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant quatre-vingt-quinze pieds dans ses lignes nord et sud, deux cent vingt-cinq pieds dans ses lignes est et ouest, et bornée de tous les côtés par d'autres parties dudit lot 159.mesure anglaise, plus ou moins.Isaias Albino Paposo.Partie du lot 159, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par Isaias Albino Paposo, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 99,632, savoir: Description: Partie du lot 159, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant quatre-vingt-quinze pieds dans ses lignes nord et sud, et cent cinquante pieds dans ses lignes est et ouest et bornée de tous les côtés par parties dudit lot 159, mesure anglaise, plus ou moins.Joas Das Dores Vala Ferreira.Partie du lot 159.du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise de Joas Das Dores Vala Ferreira, suivant son titre d acquisition enregistré sous le No 94,894, savoir: Description : Partie du lot 159, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant quatre-vingt-quinze pieds dans ses lignes nord et sud et soixante-quinze pieds dans ses lignes est et ouest; et bornée de tous les côtés par ledit lot 159, mesure anglaise, plus ou moins.$456.03 $8.24 $464.27 Part of lot 99, on the cadastre for the Parish of St.Luc, acquired by Fabien Charbonneau, according to his title-deed registered under No.88,143.Description: Part of lot 99 on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring seventy feet in width, from east to west, by one hundred fifteen feet in depth, English measure, bounded in front on the north by the piece of land belonging to Mr.St-Arnaud or representatives, on the south by lot No.99-1 (street), on the east by part of said lot No.99 belonging to the said Mr.St-Arnaud or representatives and on the west by part of the latter lot belonging to the vendor or representatives.23.59 1.09 834.35 $5.63 64.66 Part of lot 159 on t he cadastre for the Parish of St.Luc, pur\" chased by Jose Arruda Da Ponte Pereira, according to his title-deed registered under No.83,777.Description : Part of lot 159 on the official cadastre for the Parish of St-Luc, measuring seventy-five feet in width, in front, along its northwest line, seventy-five feet in width, in the rear, along its southeast line, and ninety-five feet in depth on each of its northeast and southeast lines, covering an area of 7,125 square feet, English measure, more or less; said part bounded in front, towards the northwest, on one side, and towards the northeast and on the other side towards the southwest, by non-subdivided parts of said original lot No.159 and in the rear, towards the southeast, by part of original lot No.151, on said cadastre.57.57 2.65 103.04 13.08 176.34 Part of lot 159 on the cadastre for the Parish of St.Luc, acquired by the said Jaime Pereira De Almeida and Bonifacio Pereira De Almeida, according to their title-deeds registered under No.98,429, to wit: Description : Part of lot 159 on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring ninety-five feet on its north and south lines, two hundred twenty-five feet on its east and west lines, and bounded on all sides by other parts of said lot 159, English measure, more or less.12.27 1,90 14.i7 Part of lot 159 on the cadastre for the Parish of St.Luc, acquired by Isaias Albino Paposo, according to his title-deed registered under No.99,632, to wit: Description : Part of lot 159 on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring ninety-five feet on its north and south line and one hundred fifty feet on its east and west lines, and bounded on all sides by parts of said lot 159, English measure, more or less.19.20 0.87 20.07 Part of lot 159 on the official cadastre for the Parish of St.Luc, acquired from Joas Das Dores Vala Ferreira, according to his title-deed registered under No.94,894, namely: Description : Part of lot 159 on the official cadastre for the Parish of St-Luc, measuring ninety-five feet on its north and south lines and seventy-five feet on its east and west lines; and bounded on all sides by said lot 159, English measure, more or less. 4190 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Taxes Taxes Noms munie.Intérêts scolaires Intérêts Total Names Munie.Interest School Interest taxe» taxes Dame Gwendolyne Hope, épouse de / wife of Leo Raymund Wilde.S 294.86 9 11.83 Partie du lot 185, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par Dame Leo Raymond Wilde, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 91,346, savoir: Description: .Partie du lot 185.du cadastre officiel de la paroisse de saint-Luc, mesurant cent quatre-vingts pieds de largeur par cent quatre-vingts pieds de profondeur, mesure anglaise, bornée vers le nord par partie dudit lot vendue à la province de Québec (ministère de la Voirie) vers l'est et vers le sud par partie dudit lot 195 appartenant à John L'Ecuyer, et vers l'ouest par parties du même lot appartenant à J.L'Ecuyer et Robert Davy ou représentants.8 306.69 Part of lot 185 on the cadastre for the Parish of St.Luc, acquired by Mrs.Léo Raymond Wilde, according to her title-deed registered under No.91,346, namely: Description: Part of lot 185 on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring one hundred eighty feet in width by one hundred eighty feet in depth, English measure, bounded towards the north by part of said lot sold to the Province of Québec (Roads Department), towards the east and south by part of said lot 185 belonging to John L'Ecuyer.and towards the west by parts of said lot belonging to John L'Ecuyer and Robert Davy or representatives.Raymund Wilde.Partie du lot 185.du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par Raymund Wilde, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 104,224, savoir: Description : Partie du lot 185.du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant cent quatre-vingt-deux pieds dans sa ligne nord, deux cent cinq pieds et cinq dixièmes de pied dans sa ligne est, deux cent quarante-quatre pieds et cinq dixièmes de pied dans sa ligne sud-ouest et contenant en superficie 18.300 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins, bornée vers le nord par une autre partie dudit lot 185, vers l'est par le lot 185-2 et une autre partie dudit lot 185, et vers le sud-ouest par le lot originaire 184.49.89 1.95 51.84 Part of lot 185 oo the cadastre for the Parish of St.Luc, acquired by Raymund Wilde according to his title-deed registered under No.104.224.namely: Description : Part of lot 185 on the official cadastre (of the Parish of St.Luc, measuring one hundred eighty-two feet on its north line, two hundred five and five tenths feet on its east line, two hundred forty-four and five tenths feet on its southwest line and covering an area of 18,300 square feet, English measure, more or less, bounded towards the north by another part of said lot 185, towards the east by lot 185-2 and by another part of said lot 185 and towards the southwest by original lot 184.Cradon Investment Corporation.Le lot 187-1, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc.acquis par Cradon Investment Corporation suivant enregistrement No 108,667.Description: Lot de figure irrégulière, borné vers le sud-est par le chemin public (Laprairie-St-Jean) sur une distance de cinq cent trente pieds, et par partie du lot 187-2 sur une distance de deux cent quatre-vingt-quinze pieds; vers le sud-ouest par partie du lot 187 sur une distance de trois raille huit cent quatre-vingt-treize pieds; vers le nord-ouest par le chemin public sur une distance de sept cent soixante-dix-sept pieds et deux dixièmes de pied; versle nord-est par le lot 187-3 sur une distance de cinq cent vingt-huit pieds et trois dixièmes de pied et par partie du lot 187-2, sur une distance quarante-deux mille soixante et un pieds; vers l'est par une partie du lot 187-2, sur une distance de cinquante-quatre pieds.Contenant en superficie 43,01 arpents, mesure anglaise.Cradon Investment Corp.a par la suite vendu ledit lot 187-1 dudit cadastre, il Robert B.Pickering, In Trust, suivant vente enregistrés sous le No.120.055.Denis Roy (Rémillard et Roy Inc.).Partie du lot 198.du cadastre de la paroisse de Saint-Luc.acquise par Denis Rov.suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 108,132.savoir: Description: Partie du lot 198, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant trois cents pieds de largeur par deux cent soixante-cinq pieds de profondeur, mesure anglaise plus ou moins et bornée comme suit: Au sud-ouest par le chemin public (Boulevard St-Luc) au sud-est, au nord-est et au nord-ouest par d autres parties dudit lot No.198 restant la propriété de la veiideresse (Roulottes Champlain Ltée).le coin sud-est étant situé A trois cent quatre-vingt-seize pieds de la rue Grant.$ 1,639.24 $ 118.99 1.758.23 Lot 187-1 of the cadastre for the Parish of St.Luc, acquired by Cradon Investment Corporation according to registration No.108,667.Description : A lot of irregular configuration, bounded towards the southeast by the public road (Laprairie-St.Jean) over a distance of five hundred thirty feet, and by a part of lot 187-2 over a distance of two hundred ninety-five feet; towards the southwest by part of lot 187 over a distance of three thousand eight hundred ninety-three feet: towards the northwest by the public road over a distance of seven hundred seventy-seven and two-tenths feet; towards the northeast by lot 187-3 over a distance of five hundred twenty-eight and three-tenths feet and by a part of lot 187-2, over a distance of forty-two thousand sixty-one feet; towards the east by a part of lot 187-2, over a distance of fifty-four feet.Covering an area of 43.01 arpents, English measure.At a later date.Cradon Investment Corp.sold said lot 187-1 on said cadastre to Robert B.Pickering, in trust, according to a deed of sale registered under No.120,055.197.23 7.93 270.67 25.80 501.63 Part of lot 198 on the cadastre for the Parish of St.Luc, acquired by Denis Roy, according to title-deed registered under No.108.132, to wit: Description: Part of lot 198 on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring three hundred feet in width by two hundred sixty-five feet in depth, English measure, more or less, and bounded as follows: on the southwest by the public road (St.Luc Boulevard) on the southeast, on the northeast and on the northwest by other parts of said lot No.198 remaining the property of the vendor (Roulottes Champlain Ltée), the southeast corner being located at a distance of three hundred ninety-six feet from Grant Street. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 197i, 106' année, n° SS 4191 Taxes Taxes Noms Nos de cadastre munie.Intérêts scolaires Intérêts Total Names Cadastral numbers Munie.Interest School Interest taxes taxes Par acte enregistré sous le No 108,183, ledit Denis Roy déclare que suivant acte de vente enregistré sous le No 108,132 et ci-dessus mentionné, il a acquis une partie dudit lot 198, ci-dessus décrite, alors qu'il agissant pour une compagnie en voie d'incorporation et devant être incorporée sous le nom de o Rémillard et Roy Inc.» Et que cettedite compagnie a depuis obtenu ses lettres patentes, et en conséquence est devenu propriétaire de l'immeuble décrit à l'acte enregistré sous le No 108,132.Alidor Hamois.Partie du lot 227, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par Alidor Harnois, suivant son titre d'acquisition enregistré sous Le No 58.265, savoir: Description: Partie du lot 227, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant cinquante pieds anglais de largeur sur toute la profondeur qui peut se trouver entre le chemin public actuel et le canal Chambly, borné à l'est par le canal Chambly, au nord par partie du même lot appartenant à Oscar Provencher, à l'ouest par le chemin public et au sud par une autre partie du même lot appartenant à Henri Many.Dame Simone Bessette, épouse de / wife of Jean Gélineau.Partie du lot 231, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquise par Dame Jean Gélineau, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 89,428, savoir: Description: Partie du lot 231, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, contenant cent pieds anglais de largeur sur toute la profondeur pouvant exister entre le chemin public et la rivière Richelieu ou canal de Chambly et bornée en front, à l'est, par ladite rivière, en profondeur par ledit chemin public, d'un côté vers le sud, par partie dudit lot, appartenant à Réjean Guérin.et de l'autre côté par partie dudit lot, restant à Dame Blanche Bessette, veuve de Arsène Pierre.Roland Fortier.Partie du lot 231, du cadastre de la paroisse de Saint-Luc, acquises par Roland Fortier, suivant son titre d'acquisition enregistré sous le No 83,646, savoir: Description : 1.Partie du lot 231, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, mesurant trente pieds de largeur, mesure anglaise, par toute la profondeur se trouvant entre le chemin et la rivière; et bornée vers l'ouest par le chemin public, vers le nord par partie du même lot appartenant à Henri Jalbert, vers l'est, par la rivière et vers le sud, par partie du même lot appartenant à M.Renaud ou représentants.2.Partie dudit lot 231, mesurant cent cinquante pieds de largeur par huit cent vingt-cinq pieds de profondeur; mesure anglaise, plus ou moins, bornée vers l'est par le chemin public, vers le sud, par partie dudit lot 231 appartenant à M.Kneep, en arrière, par partie dudit lot 231 appartenant à Dame Pierre ou représentants et d'un côté, vers le nord, par partie dudit lot 231 appartenant à M.Narcisuis ou représentants.By a deed registered under No.108,183, the said Denis Roy declares that, according to a deed of sale registered under No.108,132 and mentioned hereinabove, he acquired a part of said lot 198 hereinabove described, acting then on behalf of a company in process of incorporation and to be incorporated under the name of \"Rémillard et Roy Inc.\", and that said company has since obtained its letters patent, and consequently, has become proprietor of the immoveable described in the deed registered under No.108,132.165.43 6.89 121.35 6.47 300.14 Part of lot 227, on the cadastre for the Parish of St.Luc, purchased by Alidor Harnois, according to his title-deed registered under No.58,265, anmely: Description: Part of lot 227.on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring fifty English feet in width by the whole depth that may be measured between the present public road and the Chambly Canal, on the north by a part of said lot belonging to Oscar Provencher, on the west by the public road and on the south by another part of same lot belonging to Henri Many.20.61 0.91 28.34 4.12 63.98 Part of lot 231, on the cadastre for the Parish of St.Luc, acquired by Mrs.Jean Gélineau.according to her title-deed registered under No.89,428.namely: Description: Part of lot 231, on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring one hundred English feet in width by the whole depth that may be measured bttween the public road and the Richelieu River or Chambly Canal and bounded in front, on the east, by the said River, on its length by the said public road, on one said towards the south, by a part of said lot belonging to Réjean Guérin, and on the other side by a part of said lot remaining the property of Mrs.Blanche Bassette, widow of Arsène Pierre.12.44 0.54 12.98 Parts of lot 231, on the cadastre for the Parish of St.Luc.acquired by Roland Fortier.according to his title-deed registered under No.83,646, namely: Description: 1.Part of lot 231, on the official cadastre for the Parish of St.Luc, measuring thirty feet in width, English measure, by the whole depth that may be measured between the road and the River; and bounded towards the west by the public road, towards the north by a part of said lot belonging to Henri Jalbert, towards the east by the River and towards the south, by a part of said lot belonging to Mr.Renaud, or representatives.2.Part of said lot 231, measuring one hundred fifty feet in width by eight hundred twenty-five feet in depth.English measure, more or less, bounded towards the east by the public road, towards the south, by a part of said lot 231 belonging to M.Kneep, in the rear, by a part of said lot 231 belonging to Mrs.Pierre, or representatives and on one side, towards the north, by a part of said lot 231 belonging to Mr.Narcisuis, or representatives.Donné à Saint-Luc ce 13 mai 1974.Given at Saint-Luc, this May 13, 1974.(Sceau) Le greffier, (Seal) Cybisse Morrissettf, 57309-21-2-o Cybisse Mobbissette.57309-21-2 Clerk. 4192 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol- 106, No.22 Municipalité du comté des Iles de la Madeleine Avis public est, par les présentes donné, par le soussigné, Marc-A.Boudreau, secrétaire-trésorier du Conseil de Comté des îles de la Madeleine que les lots et parties de lots ci-après mentionnés seront vendus à l'enchère publique, au Palais de Justice de Havre-Aubert, MERCREDI, le TROISIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de l'avant-midi, pour taxes municipales et scolaires dues sur ces immeubles à moins que ces diverses taxes et frais ne soient payés avant la vente, à savoir: Dans la municipalité de l'Ile du Havre-Aubert Et connu au cadastre officiel de l'Ile du Havre-Aubert: Comme appartenant à Wilfred Chevrier, le lot No 969 contenant 827,640 pi.ca.lot 2211 contenant 686,000 pi.ca.lot No 2284 contenant 91,000 pi.ca.Taxes municipales: $12.72; taxes scolaires: 837.63; frais: $7.42.Total: $57.77.Comme appartenant à David A.Lapierre, lot No 1974 contenant 45,600 pi.ca.lot No 2024 contenant 43,560 avec bâtisses dessus construites, lot No 2240 contenant 424,580 pi.ca., lot No 2246 contenant 183,300 pi.ca.lot No 2351 contenant 158,000 pi.ca.Taxes municipales: $97.64; taxes scolaires: $59.12; frais: $2.20.Total: $158.96.Comme appartenant à Syndic J.Alexandre Danse-reau et occupé par Henri J.Lapierre.lot No 1594 contenant 163,300 pi.ca.avec bâtisses dessus construites.Taxes municipales: $17.48; taxes scolaires: $92.00; frais: $11.89.Total: $121.37.Dans la municipalité de l'Étang-du-Nord Et connus au cadastre officiel de l'Étang-du-Nord: Comme appartenant à Daniel P.LeBlanc.Lot No 2498 contenant 214.280 pi.ca., lot No 2491 contenant 217,940 pi.ca.avec bâtisses dessus construites.Taxes scolaires: $112.32; frais: $21.18.Total: $133.50.Comme appartenant à Mme Conrad Thériault, lot No 1948 contenant 55,200 pi.ca.Taxes municipales: $2.49; taxes scolaires: $6.24; frais: $5.01.Total: $13.74.Dans la municipalité de Fatima Et connu au cadastre officiel de Fatima: Comme appartenant à Fred P.Arseneau, lot No 665 contenant 316,400 pi.ca.Taxes municipales: $12.63; taxes scolaires: $15.23; frais: $6.11.Total: $33.97.Comme appartenant à Yvon Bellefleur, lot No 665-A contenant 316,400 pi.ca.Taxes scolaires: $15.23; frais- $3.58.Total: $18.81.Comme appartenant à Joseph A.Bourgeois, lot No 393-A contenant 5,480 pi.ca.Taxes municipales: $6.90; taxes scolaires: $8.87; frais: $4.41.Total: $20.18.Comme appartenant à Suce.Joseph H.Cyr, lot No 558 contenant 24,505 pi.ca.avec bâtisse dessus construite.Taxes municipales: $38.74; taxes scolaires: $92.87; frais: $16.04.Total: $147.65.Municipality of the County of Magdalen Island Public notice is hereby given by the undersigned, Marc-A.Boudreau.Secretary-Treasurer of the County Council of Magdalen Island, that the lots or parts of lots hereafter mentioned will be sold by public auction, in the Court House, at Havre-Aubert, on WEDNESDAY, the THHtD day of JULY 1974, at TEN o'clock in the forenoon, for municipal and school taxes due upon for municipal and school taxes due upon these immoveables, unless the said taxes and costs be paid before the sale, to wit: In the municipality of Ile du Havre-Aubert And known on the cadastre of Ile du Havre-Aubert: As belonging to Wilfred Chevrier, lot No.969 containing 827.640 s.f.lot No.2211 containing 686,000 s.f., lot No.2284 containing 91.000 s.f.Municipal taxes: $12.72; school taxes: $37.63; costs: $7.42.Total: $57.77.As belonging to David A.Lapierre, lot No.1974 containing 45,600 s.f., lot No.2024 containing 43,560 s.f.with building, lot No.2240 containing 424,580 s.f., lot No.2246 containing 183,300 s.f.lot No.2351 containing 158,000 s.f.Municipal taxes: $97.64; school taxes: $59.12; costs: $2.20.Total: $158.96.As belonging to Syndic J.Alexandre Dansereau and occupied by Henri J.Lapierre.lot No .1594 containing 163.300 s.f.with building.Municipal taxes: $17.48; school taxes: $92.00; costs: $11.89.Total: 8121.37.In the municipality of Étang-du-Nord And known on the cadastre of Étang-du-Nord: As belonging to Daniel P.Leblanc, lot No.2498 containing 214,280 s.f.lot No.2491 containing 217.940 s.f.with building.School taxes: 8112.32; costs: 821.18.Total: 8133.50.As belonging to Mrs Conrad Thériault, lot No.1948 containing 55,200 s.f.Municipal taxes: $2.49; school taxes: $6.24; costs: $5.01.Total: $13.74.In the municipality of Fatima And known on the cadastre of Fatima: As belonging to Fred P.Arseneau, lot No.665 containing 316,000 s.f.Municipal taxes: $12.63; school taxes: $15.23; costs: $6.11.Total: $33.97.As belonging to Yvon Bellefleur, Lot No.665-A containing 316,400 s.f.School taxes: $15.23; costs: $3.58.Total: $18.81.As belonging to Joseph A.Bourgeois, lot No.393-A containing 5,480 s.f.Municipal taxes: 86.90; school taxes: $8.87; costs: $4.41.Total: 820.18.As belonging to Estate Joseph H.Cyr lot No.558 containing 24,505 s.f.with building.Municipal taxes: 838.74; school taxes: $92.87; costs: $16.04.Total: $147.65. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n\" n 4193 Comme appartenant à Odipha Devost, lot No 823 contenant 9,572 pi.ca.avec bâtisses dessus construites.Taxes municipales: $54.28; taxes scolaires: $70.96; frais: $13.64.Total: $138.88.Dans la municipalité de Cap-aux-Meules Et connu au cadastre officiel de Cap-aux-Meules: Comme appartenant à Julien H.Gaudet, lot No 1482 contenant 5,810 pi.ca.Taxes municipales: $1.80; frais: $0.88.Total: $2.68.Dans la municipalité de Havre-aux-Maisons Et connu au cadastre officiel de l'île-du-Havre-aux-Maisons.Comme appartenant à Alva Arseneau, lot No 300 contenant 57,710 pi.ca.lot No 953 contenant 240,000 pi.ca.lot 787 contenant 402,950 pi.ca.avec bâtisses dessus construites.Taxes municipales: $58.75; taxes scolaires: $69.36; frais: $1.76.Total: $129.87.Donné à Havre-aux-Maisons, îles de la Madeleine, ce 8e jour de mai 1974.Le secrétaire-trésorier, 57312-21-2-0 Marc-A.Boudreau.As belonging to Odipha Devost, lot No.823 containing 9,572 s.f.with building Municipal taxes: $54.28; school taxes: $70.96; costs: $13.64.Total: $138.88.In the municipality of Cap aux Meules And known on the cadastre of Cap-aux-Meules: As belonging to Julien H.Gaudet, lot No.1482 containing 5,810 s.f.Municipal taxes: $1.80; costs $0.88.Total: $2.68.In the municipality of Havre-aux-Maisons And known on the cadastre of Havre-aux-Maisons.As belonging to Alva Arseneau, lot No.300 containing 57,710 s.f.lot No.953 containing 240,200 s.f.lot No.787 containing 402,950 s.f.with building.Municipal taxes: $58.75; school taxes: $69.36; costs: $1.76.Total: $129.87.Given at Havre-aux-Maisons, Magdalen Island, this 8th day of May 1974.Marc-A.Boudreau, 57312-21-2-0 Secretary-Treasurer.Cité de Jonquiëre Avis public est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la cité de Jonquière, que les immeubles ci-dessous désignés seront vendus à l'enchère publique à l'Hôtel-de-Ville de la cité de Jonquière, 320, St-Domi-nique, Jonquière, JEUDI, le VINGT-SEPTIÈME jour de JUIN 1974 à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires ainsi que les intérêts et frais subséquents encourus à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.City of Jonquière Public notice is hereby given by the undersigned, City Clerk of the City of Jonquière that the immoveables described hereunder, will be sold by public auction, at the City Hall of the City of Jonquière, 320 St.Dominique Street, Jonquière, THURSDAY, the TWENTY-SEVENTH day of JUNE 1974, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy to the payment of municipal and school taxes with accrued interests and costs incurred thereon unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale.\t\t\tTaxes\tTaxes\t Nom et prénom\tAdresse\t\tMun.\tScol.\t \t\tDescription\t\t\tTotal Name and surname\tAddress\t\tM unie.\tSchool\t Rôle / RoU\t\t\ttaxes\ttaxes\t Thibeault, René.\t640, Montfort,\t2S-A-308, Rg.3.P.21-A-195,\t8 559.02\ti 1,890.25\tS 2,449.27 \tJonquière\tRg.IV\t\t\t Leclerc, Jean-Marc .\t.436, Notre-Dame,\t25-B-202, Rg.3.\t208.95\t578.23\t787.18 \tJonquière\t\t\t\t La Commission Municipale du Québec par sa décision en date du 25 février 1974 a autorisé une enumeration abrégée des lots cadastraux des immeubles sous l'autorité de l'article 550 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193).Donné à Jonquière, ce 14e jour de mai 1974.Copie certifiée.Le greffier, 57313-21-2-0 Marcel Juxo.The Québec Municipal Commission, by a decision dated February 25th 1974, has authorized an abriged form of cadastral numbers of the immoveables under the authority of article 550 of the Cities and Towns Act (S.R.Q.1964, Chapter 193).Given at Jonquière, this 14th day of May 1974.Certified Copy.Marcel Julo, 57313-21-2-q Cily Clerk. 4194 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 19U, Vol- 106, No.U La ville de Waterville Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, que l'immeuble suivant: nom du propriétaire: Manoir Waterville Inc., No cadastre 75, Village de Waterville, 39,928 pi.ca.de superficie, bâti, taxes municipales §3,856.55, intérêts 8309.30, total $4,165.85 sera vendu à l'enchère publique (selon la loi), à l'Hôtel de Ville de Waterville, Que., soit le lieu où le Conseil tient ses sessions, VENDREDI, le CINQUIEME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et autres redevances payables à la municipalité, à moins que celles-ci ainsi que les frais encourus ne me soient payés personnellement avant le jour fixé pour la vente.Donné à Waterville, ce 10e jour de mai 1974.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, 57314-21-2-q Arthur Drouin.The Town of Waterville Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the aforesaid municipality, that the immoveable hereinafter mentioned: name of proprietor: Manoir Waterville Inc., lot No.75, Village of Waterville, 39,928 sq.ft., built, municipal taxes $3,856.55, interest $309.30, total $4,165.85 will be sold by public auction (according to law), in the Town Hall, Waterville, Que., being the place where the Council holds its meetings, on FRIDAY, the FIFTH day of JULY 1974, at TEN o'clock in the forenoon, for municipal taxes, and other debts due to the municipality, unless the said taxes with all costs incurred are paid to me before the day of the sale.Given at Waterville, this 10th day of May 1974.(Seal) Arthur Drouin, 57314-2 l-2-o Secretary-Treasurer.Ville de Rosemère Avis public est par les présentes donné par le soussigné greffier de la susdite municipalité que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique au poste Police-Incendie, 428 Grande-Côte, Rosemère, comté de Terrebonne, Que., MERCREDI le DIX-NEUVIÈME jour de JUIN, mil neuf cent soixante-quatorze à DIX heures du matin (heure avancée de l'est) pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais subséquemment encourus à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.La Commission municipale du Québec par décision en date du 16 mai 1974 a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles sous l'autorité de la Loi des cités et villes, article 550 (S.R.Q.1974, chapitre 193).Town of Rosemère Public notice is hereby given by the undersigned clerk of the aforesaid municipality that the properties hereinafter described will be sold by public auction at the Police and Fire Station, 428 Grande-Côte, Rosemère, County of Terrebonne, Que., on WEDNESDAY, the NINETEENTH day of JUNE, nineteen hundred seventy-four, at TEN o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time, ,to satisfy the payment of the municipal and school taxes, with interest, plus the costs which shall subequently be incurred unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.The Québec Municipal Commission by a decision dated May 16, 1974, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of Article 550 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1974, Chapter 193).Taxes Taxes Noms de propriétaires No du cadastre munie.scol.Name of proprietors Cadastral No.Munie.School taxes taxes Watkins, Mrs.Vina.35-17, -18.Poirier, George.33-17.Rolland, Mme Nicole.29-11, -10.Coulombe, D.& Paquette, N.31-6.Cadieux, Mme May.24-19.Cadieux, Mme May.24-20.Cadieux, Mme May.24-&1.Cadieux, Mme May.P.24-6, -7 .'.'.Cadieux, Mme May.p.24-8.L'Heureux, Mme Graziella.24-23.Mc.Carty, Erroll.241-201.\u201e, \u2022 , 301\"2 Noms, Mrs.Joanne.p ,40-67 .Tingman, Wallace.30-71.Spathodia Land Corp.241-171 Spathodia Land Corp.45-76, -76 Spathodia Land Corp.235-18.Spathodia Land Corp.' 236-17-2, -15-2 '.Spathodia Land Corp.235-16., -17-1 40.51\tS 63.02 368.61\t4.96 612.19\t7.79 400.86\t571.78 80.18\t8.71 521.26\t9.16 271.99\t8.71 403.16\t15.76 241.22\t11.04 699.99\t17.33 1,266.44\t 1,878.17\t1,157.86 1,038.37\t540.01 239.46\t20.55 450.57\t6.94 439.96\t0.01 496.64\t0.01 451.41\t0.01 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 88 4195 Taxes Taxes Noms de propriétaires No du cadastre munie.scol.Vante of proprietors Cadastral No.Munie.School taxes taxes Spathodia Land Corp.Terai, Henrico.Nault, Florian.Nault, Florian.Nault, Florian.Nault, Florian.Corbeil, Ouy.Ross, Roland.Beausite inc.Oakes, Owen.Robitaille, Yves.Bourbeau, Mme Charles.Lussier, Gérard.Roberge, Jean.Dupuis, Aurel.Adler, David.Rolland, Mme Nicole.GroUchall Dev.Co.Ltd.Suce.Achille Billet, a/s G.Poirier Guérin, Mme E.Suce.A.Billet, a/s G.Poirier.Provost, Raymond.Pitt-Taylor, Douglas.Walker, Clyde.Naegle, Gaston.Saletti, Orlando.Saletti, Orlando.Saletti, Orlando.Reggio Constr.Ltd.Reggio Constr.Ltd.Rust, Mr-.Maria.Terzi, Henrico.Bianchi, Eddy.Hébert, Jean.Charron, René.Silvers, S.c7o Mrs.J.Collyer.Trerice, Nelson.Trerice, Nelson.Trerice, Nelson.Tomlinson, Robert.Watkins, Mra.Vina.Leslie, Gordon.Mosli, Willi.Hagenkoetter, H.Donut Boy Inc.L.Claude Mercure Syndic.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Est.Geo.Tylee.Martin, Earl.Mordiko, S.Beaulieu, Henri.Valentino, Nicola.Les propriétés métropolitaines ltée.Les propriétés métropolitaines ltée.Boutet, Antonio.237-227, -228.938.77 29.98 241-174 .239.46 10.16 45-74,-72,-73.1,304.56 42.96 45-63, -65, -64 .1,304.56 14.15 45-67 .490,65 14.16 45-68,-69 .869.70 28.55 44-15,-14 35-63-1 .1,257.48 862.20 35-65-2,-66-1.642.85 234.78 236-7-3 .2.72 1.62 236-8.738.88 57.75 P.73-4 .488.35 1.09 73-16.P.73-6 .325.67 6.89 45-129,-156.480.68 42.34 237-203.344.73 6.89 P.45-98,45-97 .1,540.35 237.04 36-92,-93,-94,-95,-90,-82,-83, 4,963.65 8,022.36 -84, -89.-90, -91 29-16,-17 .490.19 0.43 36-72,-73.716.46 46.86 37-43, P.37-42 .1,010.97 2,067.99 241-282.17.72 12.04 53-27.1,068.67 2,409.63 27-36,-32.683.72 70.91 26-27, P.26-25, P-26-25-1.229.89 69.02 34-101-1,-100-2 .750.68 180.66 30-269.57.53 0.43 30-161-2-2,-161-2-1,30-160-2-1, 738.66 63.06 -160-2-2, 30-156-2 .459.62 32.54 30-155-1,-154-1,-154-2,-153-2.813.43 68.95 66-59.623.56 29.59 66-67 .661.08 25.87 65-73.1,108.33 167.19 31-41.446.56 12.04 27-71,-72.700.56 24.15 29-149.512.79 24.79 33-28,-29.689.46 13.79 272-72.68.06 76.18 272-73.79.37 106.74 272-65.77.57 103.30 272-68.79.37 103.30 41-106.692.66 294.23 35-22.-3-3 .352.82 37.94 35-3-5, -3-6, P.35-20, 35-24, -25.942.22 466.42 29-34.943.83 59.95 40-40.-41.707.05 260.86 237-156,-157.949.06 136.27 28-43.1,297.65 184.00 52-23-2,-23-1.516.34 68.50 52-22 .516.34 68.48 52-17,-16-2 .598.05 143.02 62-16-1,-15 .577.00 82.82 52-14.384.34 62.97 52-21.405.37 114.40 62-8,47-6,-31 .407.38 120.10 62-7, 47-5, -30 .390.34 71.37 62-6,47-4,-29 .390.34 71.37 52-5,47-3,-28 .390.34 62.64 62-4,47-2-1,-2-2,47-26 .311.28 54.17 47-27.-1,52-3 .317.28 73.22 62-2 .381.34 45.65 65-16-2 .27.00 21.30 237-243.338.66 91.11 928-88.390.25 P.929-3, 929-4 .213.31 110.99 19-13, 18-9.39.83 110.14 18-8.39.83 110.14 16-34 .452.89 38.81 4196 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol- 106, No.22 Les immeubles susdits sont tous aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Thérèse-de-Blain-vile, division d'enregistrement de Terrebonne, et situés dans la ville de Rosemère.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles.Donné à Rosemère, ce 22e jour de mai, 1974.Le greffier, 57311-21-2-0 Mme Ph.Gardiner.The above immoveables are all on the official plan and book of the Parish of Ste Thérèse-de-BIainville, Registry Division of Terrebonne, and situated in the Town of Rosemère.The said sale will be made with all active and passive servitudes, apparent or occult, attached to the said properties.Given at Rosemère, this 22nd day of May, 1974.Mrs.Ph.Gardiner, 57311-21-2-0 Town Clerk.Ville de Cadillac Rouyn-Noranda Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la Ville de Cadillac, que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique, à l'Hôtel de Ville de Cadillac, situé au No 2 de la rue Dumont, MERCREDI le DIXIÈME jour de JUILLET 1974, à DEUX heures de l'après-midi pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, des rentes annuelles de baux emphytéotiques, balances dues sur l'achat de terrains, avec intérêts, plus les frais subséquemment encourus à moins que ces taxes, rentes, balances, intérêts, dépenses ne soient payés avant la vente: Town of Cadillac Rouyn-Noranda Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the Town of Cadillac, that the properties hereafter designed will be sold by public auction, at the Town Hall of Cadillac, located at No.2 Dumont Street, on WEDNESDAY, the TENTH day of JULY 1974, at TWO o'clock in the afternoon, to satisfy the payment of municipal and school taxes, annual income from long-term leases, balances due on land purchases, together with interest, plus costs subsequently incurred, unless said taxes, interest and costs be paid before the sale.\t\tTaxes\tTaxes\t\t \tNo\tmunie.\tscol.\tRentes\t Noms\tBloc-Lot\t& int.\t& int.\tannuel.\tTotal Names\t\tMunie.\tSchool\t\t \tNo.\ttaxes\ttaxes\tAnnual\t \tBlock-Lot\t& int.\tdint.\trents\t M.Messrs.Huen & Wong Toy.Wilmarie Enterprises Ltd.Wilmarie Enterprises Ltd.Wilmarie Enterprises Ltd.Raoul Bourgeois.Succ-Est.Antonio Beaubien.Succ.-Est.Antonio Beaubien.Succ-Est.Antonio Beaubien.46-141.\t8 321.\t62 S\t14.\t32 $\t7\t,00 46-220.\t.1,184.\t11\t1,079.\t28\t\t 46-221.\t64.\t23\t34.\t55\t2.\ton 46-222.\t33\t.04\t16.\t15\t2\t.00 46-245.\t62\t29\t\t\t16\t.00 46-472.\t185\t.72\t\t\t4\t.00 46-473.5N\t605\t.19\t\t\t7\t00 46-488.\t83\t16\t\t\t4\t00 I 342.94 2,263.39 90.78 51.19 68.29 189.72 612.19 87.15 Donné à Cadillac, Rouyn-Noranda.province de Québec, ce 23e jour de mai 1974.Le secrétaire-trésorier, 57444-22-2-0 Marcel Bordeleau.Given at Cadillac.Rouvn-Noranda, Province -of Québec, this 23rd day of May 1974.Marcel Bordeleau, 57444-22-2-0 Secretary-Treasurer.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Change of name \u2014 Act Granted Serge Bélan Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1628 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Serge Balaine en celui de Serge Bélan.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Serge Bélan It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Serge Balaine to that of Serge Bélan, by order number 1628, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c., 57404 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106- année, n° SS 4197 James Nathan Bellin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1629 du 8 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de James Nathan Belinsky en celui de James Nathan Bellin.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.James Nathan Bellin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of James Nathan Belinsky to that of James Nathan Bellin, by order number 1629, dated May 8, 1974.Québec, May 16.1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Vincent Cosentino Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1630 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Innocenzo Cosentino en celui de Vincent Cosentino.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Vincent Cosentino It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Innocenzo Cosentino to that of Vincent Cosentino, by order number 1630, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Basil Bill Christophe Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1631 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Vasilios Hristwo en celui de Basil Bill Christophe.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.q.Basil Bill Christophe It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Vasilios Hristwo to that of Basil Bill Christophe, by order number 1631, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Barbara Christophe Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1634 du 8 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Varvara Hristou en celui de Barbara Christophe.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Barbara Christophe It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Varvara Hristou to that of Barbara Christophe by order number 1634, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Nicholas Christophe Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1632 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Nickolas Hristou en celui de Nicholas Christophe.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Nicholas Christophe It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Nickolas Hristou to that of Nicholas Christophe, by order number 1632, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Théodore Christophe Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1633 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Theodoros Christou en celui de Théodore Christophe.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Théodore Christophe It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Theodoros Christou to that of Théodore Christophe, by order number 1633, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice. 4198 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 John Drake Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1635 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de John Zadorozny en celui de John Drake.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.John Drake It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of John Zadorozny to that of John Drake, by order number 1635, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Stephen Irwin Gray Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1636 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Stephen Irwin Silverstein en celui de Stephen Irwin Gray.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Stephen Irwin Gray It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Stephen Irwin Silverstein to that of Stephen Irwin Grav, by order number 1636, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Fred Jass Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1637 du 8 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Manfred Jaskulla en celui de Fred Jass.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Fred Jass It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Manfred Jaskulla to that of Fred Jass, by order number 1637, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Daniel Lavertu Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1638 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph Jean-Paul Daniel Fournier en celui de Daniel Lavertu.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Daniel Lavertu It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Jean-Paul Daniel Fournier to that of Daniel Lavertu, by order number 1638, dated May 8, 1974.Québec.May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Gaétan Lavoie Il a plu au lieutenant-gouverneur en ccnseil, par le décret numéro 1639 du 8 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Joseph Abel Rivier en celui de Gaétan Lavoie.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice.57404-o Robert Normand, c.r.Gaétan Lavoie It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Abel Rivier to that of Gaétan Lavoie, by order number 1639, dated Mav 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Stephen Lukianiec Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1640 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Stefan Rystschuk en celui de Stephen Lukianiec.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Stephen Lukianiec It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Stefan Rystschuk to that of Stephen Lukianiec, by order number 1640, dated May 8, 1974.' Québec, May 16, 1974.Robeht Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4199 Joseph Henri Maurice Pierre Romanini Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1641 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph Henri Maurice Pierre Parent en celui de Joseph Henri Maurice Pierre Romanini.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Bernice Silverman Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1642 du 8 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Bernadette Marie Lefebvre en celui de Bernice Silverman.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Rachel Silverman Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1643 du 8 mai 1974 d'effectuer le changement de nom de Rachelle Lefebvre en celui de Rachel Silverman.Québec, le 16 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57404-o Robert Normand, c.r.Syndicats professionnels SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DU GRAND-PORTAGE (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 3 avril 1974, il a autorisé le changement de ncm de « ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU GRAND-PORTAGE », dont la constitution, sous le ncm originaire de « ASSOCIATION DES INSTITUTRICES DE LA CITE DE RIVIERE-DU-LOUP», a été autorisée le 12 février 1953, et dont le siège social est situé à Rivière-du-Loup, en celui de « SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DU GRAND-PORTAGE», et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives, Albert Jessop.57460-o SP: 384-53 Joseph Henri Maurice Pierre Romanini It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Henri Maurice Pierre Parent to that of Joseph Henri Maurice Pierre Romanini, by order number 1641, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Bernice Silverman It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Bernadette Marie Lefebvre to that of Bernice Silverman, bv order number 1642, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c.57404 Deputy Minister of Justice.Rachel Silverman It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Rachelle Lefebvre to that of Rachel Silverman, bv order number 1643, dated May 8, 1974.Québec, May 16, 1974.Robert Normand, q.c, 57404 Deputy Minister of Justice.Professional Syndicates SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DU GRAND-PORTAGE (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, on April 3, 1974, he authorized the change of name of \"ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU GRAND-PORTAGE\", whose incorporation, under the original name of \"ASSOCIATION DES INSTITUTRICES DE LA CITE DE RIVIERE-DU-LOUP\", was authorized on February 12, 1953, and whose head office is located in Rivière-du-Loup, to that of \"SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DU GRAND-PORTAGE\", the foregoing, pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57460 SP: 384-53 4200 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 L'ASSOCIATION DES PRINCIPAUX DE CHAMBLY (Loi des syndicats -professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis que le 11 avril 1974, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « L'ASSOCIATION DES PRINCIPAUX DE CHAMBLY », avec siège social situé au numéro 3455, avenue Soissons, Longueuil, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57478-0 SP: 41-73 L'ASSOCIATION DES PRINCIPAUX DE CHAMBLY (Professional Syndicates Act) Notice is given that on April 11, 1974, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives authorized the constitution of a professional syndicate, under the name of \"L'ASSOCIATION DES PRINCIPAUX DE CHAMBLY\", with its head office located at 3455 Soissons Avenue, Longueuil, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57478 SP: 41 -73 SYNDICAT DES EMPLOYES DE SYNDICATS ET DES ORGANISMES COLLECTIFS DU QUEBEC (SESOCQ) (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 25 février 1974, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « SYNDICAT DES EMPLOYES DE SYNDICATS ET DES ORGANISMES COLLECTIFS DU QUEBEC (SESOCQ) » avec siège social situé à Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57480-o SP: 76-73 SYNDICAT DES EMPLOYES DE SYNDICATS ET DES ORGANISMES COLLECTIFS DU QUEBEC (SESOCQ) (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on February 25, 1974, he authorized the constitution of a professional syndicate under the name of \"SYNDICAT DES EMPLOYES DE SYNDICATS ET DES ORGANISMES COLLECTIFS DU QUEBEC (SESOCQ)\" whose head office is located in Laval, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57480 SP: 76-73 Associations cooperatives Cooperative Associations ASSOCIATION COOPERATIVE DES CONSOMMATEURS-JARDINIERS (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « ASSOCIATION COOPERATIVE DES CONSOMMATEURS-JARDINIERS ».Le siège social de cette association coopérative est situé à Repentigny, Québec, dans le district électoral de L'Assomption.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57456-0 Albert Jessop.ASSOCIATION COOPERATIVE DES CONSOMMATEURS-JARDINIERS (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of \"ASSOCIATION COOPERATrv'E DE CONSOMMATEURS-JARDINIERS\", a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in Repentigny, Québec, in the Electoral District of L'Assomption.57456 Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, ?i° 22 4201 COOPERATIVE FUNERAIRE DU NORD-OUEST QUEBECOIS (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « COOPERATIVE FUNERAIRE DU NORD-OUEST QUEBECOIS ».Le siège social de cette association coopérative est situé à La Sarre.Québec, dans le district électoral d'Abitibi-ouest.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, ' 57457-0 Albert Jessop.COOPERATIVE FUNERAIRE DU NORD-OUEST QUEBECOIS (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of \"COOPERATIVE FUNERAIRE DU NORD-OUEST QUEBECOIS\", a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in La Sarre, Québec, in the Electoral District of Abitibi-West.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57457 Companies and Cooperatives.LA HERONNIERE, COOPERATIVE DE PRODUCTION ARTISANALE DE CARLETON (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « LA HERONNIERE, COOPERATIVE DE PRODUCTION ARTISANALE DE CARLETON ».Le siège social de cette association coopérative est situé à Carleton, Québec, dans le district électoral de Bonaventure.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57458-0 Albert Jessop.LA HERONNIERE, COOPERATIVE DE PRODUCTION ARTISANALE DE CARLETON (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of \"LA HERONNIERE COOPERATIVE DE PRODUCTION ARTISANALE DE CARLETON\", a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in Carleton, Québec, in the Electoral District of Bonaventure.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57458 Companies and Cooperatives.Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for Village de Normandin Comté de Lac St-Jean-Ouest Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Floriant Girard, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 348, rue St-Cyrille, Village de Normandin, comté du Lac St-Jean-Ouest, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 18 juin 1974, pour l'achat de $112,000 d'obligations du village de Normandin, comté du Lac St-Jean-Ouest, datées du 1er juillet 1974 et remboursables en série du 1er juillet 1975 au 1er juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juillet 1974.Village of Normandin County of Lake St.John-West Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Floriant Girard, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 348 St.Cyrille Street, Village of Normandin, County of Lake St.John-West, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, June 18, 1974, for the purchase of a bond issue of $112,000 for the Village of Normandin, County of Lake St.John-West, dated July 1, 1974 and redeemable serially from July 1, 1975 to July 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudiction purposes only, interest will be calculated as from July 1, 1974. 4202 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.82 Tableau d'amortissement \u2014 $112,000 \u2014 20 ans Date Capital 01 07 1975.$2,500 01 07 1976.2,500 01 07 1977 .2,500 01 07 1978 .2,500 01 07 1979.2,500 01 07 1980 .5,000 01 07 1981.5.000 01 07 1982 .5,000 01 07 1983.5,000 01 07 1984.5,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $8,500, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er juillet 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $8,500.et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.Le village de Normandin s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Redemption table \u2014 SI 13,000 \u2014 30 years Date Capital 01 07 1985.86,000 01 07 1986 .6.500 01 07 1987 .6,500 01 07 1988 .6,500 01 07 1989 .6,500 01 07 1990 .8,500 01 07 1991.8,500 01 07 1992 .8,500 01 07 1993 .8,500 01 07 1994.8,500 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-ycar fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $8,500 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of July 1, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $8,500, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Village of Normandin agrees not to bring out new-bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after July 1, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° SS 4203 Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 131 \u2014 $90,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 133 \u2014 $22,000 \u2014 travaux au centre sportif.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 18 juin 1974, à 8 heures du soir, Hôtel de ville, 348, rue St-Cyrille, Village de Normandin, comté du Lac St-Jean-Ouest, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Normandin (Comté du Lac St-Jean-Ouest), ce 23 mai 1974.Le secrétaire-trésorier, Floriant Girard.Hôtel de ville, 348, rue St-Cyrille, Village de Normandin, Comté du Lac St-Jean-Ouest, P.Q.Téléphone: 274-2004, code 418.57441-0 The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 131 \u2014 $90,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 133 \u2014 $22,000 \u2014 improvement works at the sports centre.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Tuesday, June 18, 1974, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 348 St.Cyrille Street, Village of Normandin, County of Lake St.John-West, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Normandin (County of Lake St.John-West), May 23, 1974.Floriant Girard, Secretary-Treasurer.Town Hall, 348 St.Cyrille Street, Village of Normandin, County of Lake St.John-West, P.Q.Telephone: 274-2004, code 418.57441 Village de Brownsburg Comté d'Argenteuil Avis public est par les présent s donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Vincent Charbonneau, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 300, rue Hôtel de Ville, Case postale 40, Village de Brownsburg, comté d'Argenteuil, P.Q., G0V-1A0, jusqu'à 7.30 heures du soir, lundi, le 17 juin 1974, pour l'achat de $188,500 d'obligations du village de Brownsburg, comté d'Argenteuil, datées du 30 juin 1974 et remboursables en série du 30 juin 1975 au 30 juin 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 30 juin et 30 décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 30 juin 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $188,500 \u2014 20 ans Date Capital 30 06 1975.$ 6,500 30 06 1976.6,500 30 06 1977 .7,500 30 06 1978.8,000 30 06 1979.8,000 30 06 1980.8,500 30 06 1981.9,000 30 06 1982 .9,500 30 06 1983.10,000 30 06 1984.10,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.Village of Brownsburg County of Argenteuil Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Vincent Charbonneau, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 300 Hôtel de Ville Street, Post Office Box 40, Village of Brownsburg, County of Argenteuil, P.Q., G0V-1A0, until 7:30 o'clock p.m., on Monday, June 17, 1974, for the purchase of a bond issue of'$188,500 for the Village of Brownsburg.County of Argenteuil, dated June 30, 1974 and redeemable serially from June 30, 1975 to June 30, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on June 30th and December 30th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 30, 1974.Redemption table \u2014 $188,500 \u2014 SO years Date Capital 30 06 1985.$ 6,000 30 06 1986.6,500 30 06 1987.6,500 30 06 1988.6,500 30 06 1989 .7,500 30 06 1990 .7,500 30 06 1991.7,500 30 06 1992.7,500 30 06 1993.8,000 30 06 1994.41,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year. 4204 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol- jgg; No- 38 2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $4,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 30 juin 1994 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 30 juin 1994 au montant de $41.000, comprend un solde de $33,000, renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date Capital 30 06 1995.$ 2,500 30 06 1996 .2,500 30 06 1997.3,000 30 06 1998.3,000 30 06 1999.3,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $41,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 30 juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.Le village de Brownsburg s'engage à ne pas émettre ne nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 30 juin 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 118 \u2014 $38,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 128 \u2014 $60,000 \u2014 travaux à la station de pompage; 131 \u2014 $90,000 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue à 7.30 heures du soir, lundi, le 17 juin 1974, Hôtel de ville, 300, rue Hôtel de Ville, Case postale 40, Village de Brownsburg, comté d'Argenteuil, P.Q.G0V-1A0 2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as HE ROYAL TRUST COM-No.05-014526-73X 1 PANY, a body politic and ' corporate duly incorporated according to law having its head office and principal place of business in the City of Montreal, plaintiff; versus M.G.A.DEVELOPMENT CORP., a body politic and corporate duly incorporated according to law, having its head office in the City and District of Montreal, and ARTHUR MARON, executive, of the City and District of Montreal, defendants, and THE REGISTRAR of the Registration Division of Montreal, mil en cause.\"That certain emplacement fronting on Lakeshore Road, in the City of Pointe-Claire, known and designated as subdivision lot number one thousand and fifty-seven of original lot number fifty-seven (57-1057) of the official plan and book of reference of the Parish of Pointe-Claire measuring one hundred and forty-two feet and one tenth of a foot (142.1') in front in its southeast line, one hundred and twenty-seven feet (127') in rear in its northwest line, one hundred and twenty-nine feet and eight tenths of a foot (129.8') on one side to the southwest and one hundred and fifty-six feet (156') on the other side to the northeast, and having an area of eighteen thousand nine hundred and ninety-one square feet (18,991 sq.ft.) English measure and more or less.With the six-storey apartment building in the course of construction thereon, as yet bearing no civic number.Subject to the restrictions concerning Montreal International Airport registered at Montreal Registry Office under the number 1270629; As the said property now subsists, together with all its rights, members and appurtenances, without exception or reserve of any kind on the part of the borrower and with and subject to all servitudes, active and passive, apparent and non-apparent, affecting same and together with all equipment and machinery and accessories, moveable and immoveable (including replacements, substitutions and after-acquired properties located or placed in, upon or about the property), intended to be used in the operation of the apartment building, all of which are hereby deemed to be immoveable by destination.\" To be sold at the Sheriff's Office Montreal Court House, 10 Craig Street East 10th Floor, Room 56, on the SECOND day of JULY 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, May 24, 1974.57465-0 422S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.SS Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Québec Cour Municipale de la Ville de Roxboro District of Montréal No 18-000559-741.t \\ 711,LE DE DOLLARD DES DDO 1144/73 < V ORMEAUX, demanderes-l se, ts VICTOR PAPPALARDO, défendeur.1.Les subdivisions 1 et 2 du lot originaire 261 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sainte-Geneviève avec bâtiments y érigés; 2.La subdivision 15 du lot originaire 261 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sainte-Geneviève; 3.La partie non-subdivisée du lot originaire 261 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sainte-Geneviève mesurant cent quatre-vingts pieds et neuf dixièmes de pied (180.9') dans une première ligne nord-ouest, trois cent quatre-vingt-quatre pieds (384') dans sa ligne nord-est, cent quatre-vingt-un pieds et neuf dixièmes de pied ( 181.9') dans une première ligne sud-est, cent vingt pieds (120') dans sa première ligne sud-ouest, cent pieds (100') dans une deuxième ligne nord-ouest, quatre-vingts pieds (80') dans une deuxième ligne sud-ouest, vingt pieds (20') dans sa troisième ligne nord-ouest, cent pieds (100') dans sa troisième ligne sud-ouest, cent vingt pieds (120') dans sa deuxième ligne sud-ouest, quatre-vingt-quatre pieds (84') dans sa quatrième ligne sud-ouest, ayant une superficie de quarante-neuf mille quatre cent dix-huit (49,418) pieds carrés, plus ou moins, mesure anglaise, et bornée comme suit: Vers le nord-ouest par une partie du lot originaire 261 et par les subdivisions 1 et 2 du lot originaire 261; Vers le nord-est par la subdivision 15 du lot originaire 261; Vers le sud-est par une partie de la subdivision 2 du lot originaire 262 et par une partie de la subdivision 1 du lot originaire 261 ; Vers le sud-est par une partie du lot originaire 261 expropriée par le ministère de la Voirie et par les subdivisions 1 et 2 du lot originaire 261.Avec bâtiments et circonstances dessus construits.Telles saisie et vente desdits immeubles doivent être exécutées par le shérif du district de Montréal sous réserve du droit de rachat par le propriétaire ou ses représentants légaux tel qu'il est stipulé dans les dispositions de la Loi des cités et villes (S.R.Q., ch.193).» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le QUATRIÈME jour de JUILLET 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 23 mai 1974.57464 Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Québec Municipal Court of the town of Roxboro District of Montreal No.18-000559-741./ TOWN OP DOLLARD DES DDO 1144/73 { -1 ORMEAUX, plaintiff, vs { VICTOR PAPPALARDO, defendant.1.Subdivisions 1 and 2 of original lot 261 on the official plan and book of reference of the Parish of Ste-Geneviève with buildings thereon erected; 2.Subdivision 15 of original lot 261 on the official plan and book of reference of the Parish of Ste-Geneviève ; 3.Unsubdivided part of original lot 261 on the official plan and book of reference of the parish of Ste-Geneviève measuring one hundred and eighty feet and nine tenths of a foot (180.9') in a first northwest line, three hundred and eighty four feet (384') in its northeast line, one hundred and eighty-one feet and nine tenths of a foot (181.9') in a first southeast line, one hundred and twenty feet (120') in its first southwest line, one hundred feet (100') in a second northwest line, eighty feet (80') in a second southwest line, twenty feet (20') in its third northwest line, one hundred feet (100') in its third southwest line, one hundred and twenty feet (120') in its second southeast line, eighty-four feet (840 in its fourth southwest line, having a superficial area of fourty nine thousand four hundred and eighteen (49,418) square feet, more or less, English measures, and bounded as follows: Towards the northwest by part of original lot 261 and by subdivisions 1 and 2 of original lot 261; Towards the northeast by subdivision 15 of original lot 261; Towards the southeast by part of subdivision 2 of original lot 262 and by part of subdivision 1 of original lot 261; Towards the southeast by part of original lot 261 expropriated by the Road Department and by subdivisions 1 and 2 of original lot 261.Together with buildings and appurtenances thereon erected.Such seizure and sale of the said immoveables by the Sheriff of the District of Montreal to be performed under the reserve of the subject to the right of redemption of the owner or his legal representative as provided for by the provisions of the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chap.183).\" To be sold at the Sheriff's Office Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the FOURTH day of JULY 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, May 23, 1974.57464-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° Sê 4229 Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( \"D OSE BOISSÉE, résidant et No 05-742993-67X \" domiciliée au 5709, rue Bé-' langer, des Cité et district de Montréal, demanderesse; vs VICTORIN GERMAIN, résidant et domicilié au 1695 rue Le Corbusier, app.203, à Chomedey, Ville de Laval, district de Montréal, défendeur, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.« Un emplacement ayant front sur la rue Valois, en la Ville de Laval, connu et désigné comme étant la subdivision numéro cent quinze du lot originaire numéro trois cent trente-six (336-115) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin, division d'enregistrement de Laval.Avec une maison dont le mur nord-est, est mitoyen, portant les numéros civiques 344 et 346 de ladite rue Valois.Tel que le tout se trouve actuellement, sans exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155, boulevard Je Me Souviens, à Laval, P.Q., le TROISIÈME jour de JUILLET 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 22 mai 1974.57463-0 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: t -piDUCIE PRET ET RE-Cour Supérieure, J L VENU, corporation lé-No 200-05-000187-745.j gaiement constituée, ayant ' son siège social au 850, Place d'Youville, en les cité et district de Québec, vs LÉON JANSSENS VAN DER SANDE, résidant au Lac Beauport, district de Québec et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.« 1.Un terrain formé d'une partie des lots numéros quatre.vingt-quatre-cinq (84-5 ptie), quatre-vingt-cinq-six partie (85-6 ptie) et deux cent quatre-vingt-dix partie (290 ptie) du cadastre officiel de la paroisse de St-Dunstan-du-Lac-Beauport, comté de Québec, de figure irrégulière, borné vers le nord-est par une partie du lot numéro deux cent quatre-vingt-dix (290), vers l'est par une partie des lots numéros deux cent quatre-vingt-dix (290), quatre-vingt-quatre-cinq (84-5) et quatre-vingt-cinq-six (85-6), vers le sud-ouest par une autre partie du lot numéro deux cent quatre-vingt-dix (290) et vers le nord-ouest par le lot numéro deux cent quatre-vingt-onze (291), contenant en superficie vingt mille pieds carrés, plus ou moins, mesure anglaise, plus particulièrement décrit comme suit: Commençant au point A à l'extrémité nord de la propriété du Docteur Lebon ou représentants, sur la ligne de division entre des lots numéros deux cent qua- Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( T) OSE BOISSÉE, residing and No.05-742993-67X lv domiciled at 5709 Bélanger I Road, in the City and District of Montreal, plaintiff; vs VICTORIN GERMAIN, residing and domiciled at 1695 Le Corbusier Street, Apt.203, in Chomedey, City of Laval, District of Montreal, defendant, and THE REGISTRAR for the Laval Registration Division, mis en cause.\"An emplacement fronting on Valois Street, in the City of Laval, known and described as being subdivision number one hundred and fifteen of original lot number three hundred and thirty-six (336-115) on the official plan and in the book of reference for the Parish of St.Martin, Laval Registration Division.With a house, whose northeast wall is a party-wall, bearing civic numbers 344 and 346 of said Valois Street.As the whole now subsists without any exception or reservation.\" To be sold at the Laval Registration Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, located in Laval, P.Q.on the Third day of JULY, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, May 22, 1974.57463 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit / FIDUCIE PRET ET RE-Superior Court J VENU, a corporation No.200-05-000187-745.1 legally constituted having its \\ head office at 850 Place d'Youville in the City and District of Québec, versus LEON JANSSENS VAN DER SANDE, residing in Lac Beauport, District of Québec, and THE REGISTRAR for the Québec Registration Division, mis en cause.\"1.A piece of land consisting of a part of lots numbers eighty-four-five (84-5 Pt), eighty-five - six part (85-6 Pt) and two hundred ninety part (290 Pt) on the official cadastre for the Parish of St.Dunstan-du-Lac-Beauport, County of Québec, said lot of irregular configuration, bounded towards the northeast by a part of lot number two hundred ninety (290), towards the east by a part of lots number two hundred ninety (290), eighty-four-five (84-5) and eighty-five-six (85-6), towards the southwest by another part of lot number two hundred ninety and towards the northwest by lot number two hundred ninety-one (291), and covering an area of twenty thousand square feet, more or less, in English measure, more precisely described as follows: Starting at point A located at the north end of the property of Doctor Lebon or representatives, on the dividing line between lots numbers two hundred ninety 4230 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, June lai, 1974, Vol.106, No.n tre-vingt-dix et deux cent quatre-vingt-onze\", de là, dans une direction sud-est le long d'une ligne droite formant un angle de 39°30' à gauche, avec ladite ligne de division, une distance de soixante-dix-neuf pieds et six dixièmes (79.6') au point B; de là, dans une direction sud-est, le long d'une ligne droite formant un angle de deflection de 0.25' à gauche avec la ligne précédente, une distance de quatre-vingt-quatre pieds et un dixième (84.1') au point C sur la ligne de division entre les lots numéros quatre-vingt-cinq-six et deux cent quatre-vingt-dix (85-6 et 290); de là.dans une direction sud-ouest le long de la ligne de division formant un angle de deflection de 36.35', à droite avec la ligne précédente, une distance de quarante-deux pieds (42') au point D; de là, dans une direction sud-est le long d'une ligne droite formant un angle de deflection de 90.00' à gauche avec ladite ligne de division entre les lots nos quatre-vingt-cinq-six et deux cent quatre-vingt-dix (85-6 et 290) une distance de soixante-dix pieds (70') au point G; de là.dans une direction nord le long d'une ligne droite formant un angle de deflection de 111.39', à gauche avec la ligne précédente une distance de deux cent trente-six pieds et six dixièmes (236.6') au point « D »; de là, dans une direction nord-ouest le long d'une ligne droite formant un angle de deflection de 19.04 à gauche avec la ligne précédente une distance de cent neuf pieds et sept dixièmes (109.7') au point « G » sur la ligne de division entre les lots nos deux cent quatre-vingt-dix et deux cent quatre-vingt-onze (290 et 291) de là, dans une direction sud-ouest le long de ladite ligne de division formant un angle de deflection de 136.21 à gauche avec la ligne précédente une distance de cent trente pieds (130) au point de commencement « A»; toutes les distances sont en mesure anglaise; 2.Une lisière de terrain faisant partie des lots numéros quatre-vingt-cinq - six et quatre-vingt-quatre - cinq (85-6 et 84-5 pties) au cadastre officiel de la paroisse de St-Dustan-du-Lac-lleauport.comté de Québec, ayant neuf cents pieds carrés (900 pi.car.) mesure anglaise, plus ou moins, délimité en rose sur un plan qui demeure annexé à la minute No 2737 de Me I.avery Sirois, notaire, et plus spécialement décrite comme suit : Commençant au point « A » sur ledit plan, au point d'intersection de la limite est du terrain appartenant à Monsieur Emilien Blondeau avec la limite générale ouest du chemin privé: de là, dans une direction générale sud en suivant ladite limite générale ouest du chemin privé jusqu'à son point d'intersection avec ladite limite est du terrain appartenant à Monsieur Emilien Blondeau, au point « B » ; de là, dans une direction nord, en suivant ladite limite est du terrain dudit Monsieur Emilien Blondeau jusqu'au point de commencement « A > ; 3.Un terrain de figure triangulaire, faisant partie du lot numéro deux cent quatre-vingt-dix (290 ptie) du cadastre officiel de la paroisse de St-Dunstan-du-Lac-Beauport, borné vers le nord par une autre partie du lot appartenant à Mademoiselle Juliette Thibault ou représentants, vers l'est par les lots numéros deux cent quatre-vingt-onze - un et deux cent quatre-vingt-onze - and two hundred ninetv-one; thence, in a southeasterly direction along a straight line, forming an angle of 39\"30', to the left, with said dividing line, over a distance of seventy-nine and six tenths feet (79.0) up to point B; thence, in a southeasterly direction, along a straight line forming deflection angle of 0 25 to the left with the preceding line over a distance of eighty-four and one-tenth feet (84.1') up to point C on the dividing line between lots numbers eighty-five-six and two hundred ninety (85-6 and 290); thence, in a southwesterly direction along the dividing line forming a deflection angle of 36 35', to the right, with the preceding line, over a distance of forty-two feet (42 ) up to point D; thence, on a southeasterly direction along a straight line forming a deflection angle of 90 00', to the left, with the said dividing line between lots numbers eighty-five-six and two hundred ninety (85-6 and 290) over a distance of seventy feet (70') up to point G; thence, in a northerly direction along a straight line forming a deflection angle of 111.39', to the left, with the preceding line over a distance of two hundred thirty-six and six-tenths feet (236.6') up to point \"D\"; thence, in a northwesterly direction along a straight line forming a deflection angle of 19.04, to the left, with the preceding line over a distance of one hundred nine and seven-tenths feet (109.7') to point \"G\" on the dividing line between lots numbers two hundred ninety and two hundred ninety-one (290 and 291), thence, in a southwesterly direction along said dividing line forming a deflection angle of 136 21, to the left, with the preceding line over a distance of one hundred thirty feet (130') up to the starting point \"A\"; all measurements are in English measure; 2.A strip of land forming part of lots numbers eighty-five-six and eighty-four-five (85-6 and 84-5 Pts) on the official cadastre for the Parish of St.I)unstan-du-Lac-Beauport, County of Québec, covering an area of nine hundred square feet (900 sq.ft.).English measure, more or less, outlined in pink on the plan which remains attached to record No.2737 of Me l.avery Sirois, notary, said strip of land more precisely described as follows: Starting at point \"A\" on said plan, at the point of intersection of the east limit of the lot belonging to Mr.Emilien Blondeau with the general west limit of the private road: thence, in a general southerly direction along said general west limit of the private road up to its point of intersection with said east limit of the lot belonging to Mr.Emilien Blondeau, up to point \"B\"; thence, in a northerly direction, along said east limit of the lot belonging to said Mr.Emilien Blondeau up to the starting point \"A\"; 3.A certain piece of land of triangular configuration being part of lot number two hundred ninety (290 Pt) on the official cadastre for the Parish of St.Dunstan-du-Lac-Beauport, bounded towards the north by another part of the lot belonging to Miss Juliette Thibault or representatives, towards the east by lots numbers two hundred ninety-one-one and tow hundred GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° SS 4231 cinq (291-1 et 291-5) et vers le sud-ouest par une autre partie dudit lot deux cent quatre-vingt-dix (290 ptie) appartenant à Monsieur Emilien Blondeau, ledit terrain étant plus spécialement décrit comme suit: Commençant à un point situé à une distance de deux cent soixante-six pieds et cinq dixièmes (266.5') au sud du chemin public sur la ligne separative des lots numéros deux cent quatre-vingt-dix et deux cent quatre-vingt-onze - un; de là, dans une direction sud, le long de ladite ligne separative, une distance de quatre-vingt-quatre pieds et cinq dixièmes (84.5') ; de là, dans une direction nord-ouest, une distance de cent cinq pieds et huit dixièmes (105.8'); de là, dans une direction est, une distance de soixante-trois pieds (63.0') jusqu'au point de départ; lequel terrain contient une superficie de deux mille six cent soixante et un pieds carrés (2661 pi.car.) mesure anglaise; étant entendu que le mur de pierre limitant au nord-est la propriété de Monsieur Blondeau servira de limite commune entre les deux propriétés; 4.Tous les droits de location que la venderesse pourrait avoir sur un terrain connu et désigné comme étant partie des lots numéros quatre-vingt-quatre, quatre-vingt-quatre - cinq, quatre-vingt-cinq - six et deux cent quatre-vingt-dix (84 ptie, 84-5 ptie, 85-6 ptie et 290 ptie) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de St-Dunstan-du-Lac-Beauport, plus longuement décrits dans l'acte passé devant le notaire Lavery Sirois le quatorze juillet mil neuf cent quarante-quatre, enregistré à Québec sous le No 288,358; 5.Le droit de stationnement pour trois automobiles, établi à perpétuité, en faveur du terrain décrit au premier paragraphe comme fonds servant contre le lot numéro quatre-cingt-cinq - six (85-6) du cadastre de la paroisse de St-Dunstan-du-Lac-Beauport, tel que plus longuement décrit dans l'acte enregistré à Québec sous le No 274,329; 6.Le droit de puiser de l'eau à la source desservant actuellement le Manoir St-Castin, établi à perpétuité en faveur du terrain décrit au premier paragraphe contre cette partie du lot numéro quatre-vingt-quatre (84 ptie) du cadastre de la paroisse de St-Dunstan-du-Lac-Beauport où se trouve située la source et appartenant à Manoir St-Castin Inc., avec les droits de passage et d'installation de tuyaux, tel que le tout est plus longuement décrit dans un acte enregistré à Québec sous le No 274,329; 7.Le droit de passage à la plage publique du Lac Beauport, établi à perpétuité en faveur du terrain décrit au premier paragraphe contre le lot numéro quatre-vingt-cinq - sept (85-7) du cadastre de la paroisse de St-Dunstan-du-Lac-Beauport, tel que plus longuement décrit dans un acte enregistré à Québec sous le No 274,329; Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au Bureau d'enregistrement de Québec, 116 rue St-Pierre, Québec, P.Q.le DOUZIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de lavant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renadlt.Québec, le 27 mai 1974 .57470-o ninety-one-five and towards the southwest by another part of said lot two hundred ninety (290 Pt) belonging to Mr.Emilien Blondeau, said piece of land being more precisely described as follows: Starting at a point located at a distance of two hundred sixty-six and five-tenths feet to the south of the public road on the dividing line between lots numbers two hundred ninety and two hundred ninety-one-one; thence, in a southerly direction along said dividing line over a distance of eighty-four and five tenths feet (84.5'); thence, in a northwesterly direction, over a distance of one hundred five and eighty-tenths feet (105.8'); thence, in a easterly direction, over a distance of sixty-three feet (63.0') up to the starting point; said piece of land covering an area of two thousand six hundred sixty-one square feet (2661 sq.ft), English measure; it is agreed that the stone wall bounding the property of Mr.Blondeau on the northeast shall be used as common limit between the two properties; 4.All the leasing rights that the vendor may have on a piece of land known and described as being part of lots numbers eighty-four, eighty-four-five, eighty-five-six and two hundred ninety (84 Pt, 84-5 Pt, 85-6 Pt and 290) on the plan and in the book of reference of the official cadastre for the Parish of St.Dunstan-du-Lac-Beauport more fully described in the deed executed before Lavery Sirois, notary, on July fourteenth, one thousand nine hundred forty-four, and registered in Québed under No.288,358; 5.A parking right for three cars, granted in perpetuity, benefitting the piece of land described in the first paragraph as servient tenement against lot number eighty-five-six (85-6) on the cadastre for the Parish of St.Dunstan-du-Lac-Beauport, as more fully described in the deed registered in Québec under No.274,329 ; 6.The right to draw water from a spring presently serving the Manoir St-Castin, established in perpetuity, to benefit the piece of land described in the first paragraph, against that part of lot number eighty-four (84 Pt) of the cadastre for the Parish of St.Dunstan-du-Lac-Beauport, where the spring is located and which belongs to Manoir St-Castin Inc., with a right of way and the right to lay pipes, the whole as more fully described in a deed registered in Québec under No.274,329; 7.The right of way to the public beach of Lake Beauport, established in perpetuity, to benefit the piece of land described in the first paragraph, against lot number eighty-five-seven (85-7) on the cadastre for the Parish of St.Dunstan-du-Lac-Beauport, as more fully described in a deed registered in Québec under No.274,329; With the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, P.Q., on the TWELFTH day of JULY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec May 27, 1974.57470 4232 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: t p LAUDE MI VILLE INC.Cour Provinciale, ) ^\u2014' corporation légalement No 200-02-000403-743.\\ constituée, ayant une place f, d'affaires au 4820, 5e Avenue est, Charlesbourg, P.Q., vs PIED CARRE INC., corporation légalement constituée, ayant une place d'affaires au 1815 boul.Masson, Les Saules, district de Québec.«Le lot 52-11-1 partie du cadastre officiel de la paroisse de l'Ancienne-Lorette.Le lot 52-15-1 partie du cadastre officiel de la paroisse de l'Ancienne Lorette, et le lot 52-61 partie du cadastre officiel de la paroisse de l'Ancienne-Lorette, le tout avec bâtisses ci-dessous construites, circonstances et dépendances, ledit immeuble portant les numéros civiques 1805-1815 et 1825 du boulevard Masson, Les Saules, district de Québec.» Pour être vendu au Bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, P.Q-, le NEUVIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de l'avant-midi.r Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 27 mai 1974.57467-o Fieri Facias de Terris Québec, to wit: l pLAUDE MIVILLE INC.Provincial Court, ) ^ a corporation legally in-No.200-02-000403-743.) corporated, having a place of ( business at 4820-5th Avenue East, Charlesbourg, P.Q, vs PIED CARRE INC., a corporation legally incorporated, having a\u2022 P'açe of business at 1815 Masson Blvd., Les Saules, District of Québec._ ., , , .\"Lot 52-11-1, part of the official cadastre of the Parish of Ancienne-Lorette.Lot 52-15-1, part of the official cadastre of the Parish of Ancienne-Lorette, and lot 52-61, part of the official cadastre of the Parish of Ancienne-Lorette, the whole with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, the said immoveable bearing civic numbers 1805-1815 and 1825 Masson Boulevard, Les Saules, District of Québec.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, P.Q., on the NINTH day of JULY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, May 27, 1974.57467 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: (pÉRARD VINCENT, domicilié Cour Supérieure, J au 816, rue Painchaud, app.3, No 5076-D \\ Québec, contre GERTRUDE BOU-' LANGER, domiciliée au 388, rue Lockwell, app.15, Québec.« 1.Un terrain ou emplacement situé au Lac-Sergent, connu et désigné comme étant une partie du lot numéro six, subdivision du lot originaire numéro quatre cent soixante et un (461-6 ptie) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour la paroisse de St-Raymond, comté de Portneuf, mesurant soixante-cinq pieds (65') borné comme suit: au nord par l'autre partie du terrain ci-après décrit, au sud par le lac Sergent, à l'est par un passage de dix pieds (10') appartenant à Éphrem Ro-chette et à l'ouest par le résidu dudit lot 461-6, avec le chalet dessus construit, circonstances et dépendances.2.Un morceau de terrain situé au Lac-Sergent, en arrière de l'immeuble ci-dessus décrit, mesurant soixante-cinq pieds (65') de largeur par soixante-dix pieds (70') du côté est et environ cinquante pieds (50') du côté ouest et borné comme suit: à l'est à un chemin de dix pieds (10') appartenant à Éphrem Rochette, au sud au terrain ci-dessus décrit, à l'ouest à Lucien Plamon-don et au nord au chemin public, ledit morceau de terrain étant une partie du lot quatre cent soixante et un (461 ptie) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de St-Raymond, comté de Portneuf, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Portneuf, Cap-Santé, comté Portneuf, le DIXIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Québec, le 27 mai 1974.Le shérif adjoint, J.Roland Renault.57468-0 Fieri Facias de Terris Québec, to wit : ( ÉRARD VINCENT, domiciled at Superior Court,) ^ 816 Painchaud Street, Apt.3, No 5076-D.) Québec, versus GERTRUDE BOU-V LANGER, domiciled at 388 Lockwell Street, Apt.15, Québec.1.\"A piece of land or emplacement located in Lac-Sergent, known and described as being a part of lot number six, subdivision of original number four hundred sixty-one (461-6 Pt.) on the official plan and in the book of reference of the cadastre for the Parish of St.Raymond, County of Portneuf, measuring sixty-five feet (65') and bounded as follows: on the north by the other part of the piece of land hereinafter described, on the south by La-Sergent, on the east by ten-foot path (10') belonging to Éphrem Rochette and on the west by the remainder of said lot 461-6, with the cottage erected thereon, app- rtenances and dependencies.2.A piece of land located in Lac-Sergent, at the rear of the above-described immoveable, measuring sixty-five feet (65') in width by seventy feet (70') on the east side and approxinu-tely tifty feet (50') on the west side and bounded as foil ws: on the east by a ten-foot lane (10') belonging to Éphrem Rochette, on the south by the above-described piece of land, on the west by the property of Lucien Plamondon and on the north by the public road, the said piece of land being a part of lot four hundred sixty-one (461 Pt.) on the plan and in the book of reference of the official cadastre for the Parish of St.Raymond, County of Portneuf, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Portneuf Registry Office, in Cap-Santé, County of Portneuf, on the TENTH day of JULY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, May 27, 1974.5745g GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4233 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir:!' \"RRENETTE & FRERES LTEE, Cour Provinciale, J corporation légalement consti-No 99-152.1 tuée et ayant son siège social à 376, \\ Route Nationale, Ville de Portneuf, district de Québec, contre EMILE SIROIS, domicilié et résidant dans le Grand Rang, à St-Raymond, comté de Portneuf, district de Québec et LE REGISTRATEUR du comté de Portneuf, mis en cause.« Un terrain ou emplacement situé dans la paroisse de St-Raymond, contenant soixante pieds (60') de largeur le long de la route Corcoran sur une profondeur de cent pieds (100'), le tout mesure anglaise, et contenu dans les bornes suivantes: au nord, à la route Corcoran; à l'est et au sud, à M.Charles-Henri Paquet; et à l'ouest, au terrain de M.Réjean Girard; connu et désigné comme étant une partie du lot six cent vingt-sept (Ptie 627) au cadastre officiel pour la paroisse de St-Raymond, comté de Portneuf.Le tout avec bâtisses dessus construites.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Portneuf à Cap-Santé, comté de Portneuf, le ONZIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 27 mai 1974.57466-o SAGUENAY Canada \u2014 Province de Québec District de Saguenay (TA VILLE DE LA MALBAIE, C.P.S.No 4631a Aw corps politique légalement cons- ^ titué ayant son siège social à La Malbaie, comté de Charlevoix, dit district, vs MME ROLLANDE BABINEAU MARTEL, domiciliée et résidante à 63 rue St-Étienne, La Malbaie, comté Charlevoix dit district.« Un certain terrain ou emplacement situé sur le côté sud-ouest de la rue principale de St-Étienne, dans le village de la Malbaie, contenant deux perches de largeur sur neuf perches de profondeur, plus ou moins, étant et composant la partie nord-ouest du lot de terre numéro cinq cent vingt-cinq (525 ptie) du cadastre officiel pour la paroisse de La Malbaie; ensemble avec toutes bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et borné comme suit, savoir: en front au nord-est, à la rue principale du village de La Malbaie, ou rue St-Étienne: à la profondeur, au sud-ouest, au terrain du C.N.R.; tenant d'un côté, au nord-ouest, au lot 524 audit cadastre appartenant à Joseph-Edouard Couturier; tenant d'autre côté, au sud-est.à la partie du même lot 525 audit cadastre appartenant à Lionel Gagnon.Fieri Facias de Teris Québec, to wit: ( \"RRENETTE & FRERES LTEE, Provincial Court, J ¦*- a corporation legally incorpo-No.99-152 j rated and having its head office at ' 376 National Highway, Town of Portneuf, District of Québec, versus ÉMILE SIROIS, domiciled and residing in the \"Grand Rang\", in St.Raymond, County of Portneuf, District of Québec, and THE REGISTRAR for the County of Portneuf, mis en cause.\"A piece of land or emplacement located in the Parish of St.Raymond, measuring sixty feet (60') in width along Corcoran Road by a depth of one hundred feet (100'), the whole in English measure, and bounded as follows: on the north, by Corcoran Road; on the east and on the south, by the property of Mr.Charles-Henri Paquet; and on the west, by the land of Mr.Réjean Girard; known and described as being part of lot six hundred and twenty-seven (Pt.627) on the official cadastre for the Parish of St.Raymond, County of Portneuf.The whole with the buildings erected thereon.\" To be sold at the Portneuf Registration Office in Cap-Santé.County of Portneuf, on the ELEVENTH day of JULY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, May 27, 1974.57466 SAGUENAY Canada \u2014 Province of Québec District of Saguenay I THE TOWN OF LA MALBAIE, S.P.C.No.4631a * bcdy politic legally incorpo- l rated, having its head office at La Malbaie, County of Charlevoix, said District vs MRS.ROLLANDE BABINEAU MARTEL, domiciled and residing at 63 St.Etienne Street, La Malbaie, County of Charlevoix, said District.\"A certain lot or emplacement, located on the southwest side of the main street, or St.Etienne Street, in the Town of La Malbaie, measuring two perches in width, by nine perches in depth, more or less, which is and consists of the northwest part of lot number five hundred twenty-five (Pt.525) on the official cadastre for the Parish of La Malbaie; together with all the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and bounded as follows, namely: in front, on the northeast, by the main street of the Town of La Malbaie, or St.Etienne Street: at the rear, on the southwest by the land belonging to theC.N.R.; adjoining on one side, on the northwest lot 524 on said cadastre belonging to Joseph-Edouard Couturier; adjoining on the other side, on the southeast that part of said lot 525 on said cadastre belonging to Lionel Gagnon. 4234 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 1st, 1974, Vol.106, No.22 Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la 1ère division de Charlevoix à La Malbaie, JEUDI le QUATRIÈME jour de JUILLET 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Pierre Gaudreault.La Malbaie, le 23 mai 1974.57469-o Erratum Objet: Décision MCR-876 Dans l'avis publié dans le numéro 19 de la Gazette officielle du 11 mai 1974, aux pages 3476, 3477, 3478 et 3479, la décision suivante aurait dû apparaître à la fin dudit avis.« La Commission décrète la remise, à toutes les parties mentionnées dans cette décision, des cautionnements déposés avec leurs requêtes en question.» 57403 To be sold at the Registry Office of the 1st Division of Charlevoix at La Malbaie, on THURSDAY, the FOURTH day of JULY 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Pierre Gaudreault, Sheriff's Office, Sheriff.La Malbaie, May 23, 1974.57469 Erratum Re: Decision MCR-876 In the notice published in issue number 19 of the Québec Official Gazette, dated May 11, 1974, on pages 3476, 3477, 3478 and 3479, the following decision should have appeared at the end of said notice: \"The Commission orders the reimbursement, to all parties mentioned in this decision, of the deposits made with their respective requests\".57403 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er juin 1974, 106' année, n° 22 4235 INDEX N© 2 2 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ASSEMBLÉE NATIONALE NATIONAL ASSEMBLY Projet de loi référé à une Commission parlementaire: Bill referred to a Parliamentary Committee: 22 \u2014 Loi sur la langue officielle.4176 22 \u2014 Official Language Act.4176 ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIONS Association coopérative des consommateurs-jardiniers (Formalion).4200 Coopérative funéraire du nord-ouest québécois (Formation).4201 Héronnière, coopérative de production artisanale de Carleton (La) (Formation).4201 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Anjou, ville-town (Rachat, partiel d'obligations-Partial redemption of bonds).4168 Centre auto-neige Ile Bizard (L.P.).4171 Club auto-neige de Beliecombe inc.(Le) (L.P.).4170 Club de moto-neige Les Miltonnais inc.(L.P.).4171 Communauté régionale de l'Outaouais (Siège social).4170 Conseil No 2783 des Chevaliers de Colomb de Louisebille (Const.).4169 Conseil No 3326 des Chevaliers de Colomb de St-André-de-Sutton (Const.).4172 Council No.2783 of the Knights of Columbus of Louiseville (Const.).4169 Council No.3326 of the Knights of Columbus of St.André-de-Sutton (Const.).4172 Entreprises Procida inc.(Les) (L.P.).4170 Estate of Rosanna Alain (Benefit of inventory).4172 Institut Providence (Montréal) (Dissolution).4168 Lac St-Joseph, ville-town (Requête-Pétition).4169 Oeuvre des terrains de jeux de Courcelles (L') (L.P.).4171 Outaouais Regional Community (The) (Head office).4170 Parish of St.Thomas More, St.Jean (Limits changed).4172 Paroisse St.Thomas More, de Saint-Jean (Modification de limites).4172 Procida Enterprises Inc.(L.P.).Soeurs Missionnaires du Christ-Roi (Les) (Siège social-Head office).4172 Succession Rosanna Alain (Benefice d'inventaire).Vian Témisca Silice ltée (L.P.).Transport Baie des Chaleurs incorporée (Annulation).41 '° CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Bélan, Serge.Bellin, James Nathan.* jx1' Cosentino, Vincent.1Q7 Christophe, Basil Bill.Christophe, Barbara.Christophe, Nicholas.Q7 Christophe, Théodore.|Jgg Drake, John.\" \" 41 gg Gray, Stephen Irwin.4\\§% Jass,Fre
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.