Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 9 février 1974, Partie 1 samedi 9 (no 6)
[" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES QUEBEC g OFFICIAL »' GAZETTE PART 1 JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 197i, 106' année, n\" 6 1233 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazelle officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contientdesavis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3, Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Quebec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc.sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazelle officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine: mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once, In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHAULES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher 1234 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, l97i, Vol.106, No.6 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie l):du 1er janvier au 31 décembre, $20: du 1er avril au 31 décembre, S15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « © » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro do facture.L'Editeur officiel du Québec.Ciiarles-Hexri Dl'bk.Cité Parlenu-nlaire.Québec.25 octobre 1!>72.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.F'irst insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) atdouble rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December.$20.from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Chaki.es-Henhi Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25.1972.Pour toute demande renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Téléphone: (41 S) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec.Cité Parlementaire.Québec GIV 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9 février 1974.106' année, n\" 6 1235 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4.5a et suivantsde la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus: les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiques en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act.for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not fded A.J.P.ELECTRONIQUE INC.Lasalle.A & R MOBILE TRANSPORT INC.Cap-de-la-Madeleine.LES AGENCES D'ASSURANCE LASALLE INC.Montreal.AGRA INVESTMENT CO.LTD.Montreal.AMICALE MARISTE BELOEIL INC.Beloeil.L'ASSOCIATION DES ECOLES DE COIFFURE POUR DAMES DE LA PROVINCE DE QUEBEC JACQUES ET PAUL ATTALA INC.RENE BEAUCHAMP ELECTRIQUE INC.J.B.BEAULIEU LTEE.BEAUMANOIR INCORPOREE.BEDE AUTO INC.BELCO KNITTING COMPANY INC.BELLAUTO LTEE.BIG HAS & VAILLANCOURT INC.A.BOISSY COMPAGNIE LIMITEE.BOTANY HALL CLOTHES INC.BOULEVARD DEVELOPMENT CO.INC.BOUTIQUES LES IMPECCABLES INC.M.BURDET INC.I.C.BURNERS LTD.C.& N.FISH & GAME CLUB INC.CAMPBELL & MAC DONALD MOTOR SALES LTD.CASINO DRESS INC.Montréal.Trois-Rivicres.Montréal.Ste-Rose-du-Dégelé.Montréal.Brossard.Montréal.Trois-Rivicres.Fabre ville.St-Lambert.Montreal.Montreal.Boucherville.Montreal.Montreal.Noyan.Lachute.Montreal.1969 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1960, 1970 à/to 1973 incl.1964, 1970 à/to 1973 incl.1967, 1969, 1972 et/and 1973 1940, 1944, 1947 à/to 1973 incl.1971, 1973 1969 à/to 1973 incl.1961 à/to 1966 incl.1970 à/to 1973 incl.1948 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1970 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1964, 1965, 1967 et/and 1968 1957 à/to 1973 incl.1959, 1961 à/to 1973 incl.1964 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1962.1968 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1967.1972 et/and 1973 1952 à/to 1973 incl. 1236 QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE.February 9, 1974, Vol.106, No.6 Nom de la compagnie .Vomc of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LE CENTRE CIVIQUE DE SAINT-PAUL DE LAVALTRIE.CERCLE MUSICAL D'ACTON VALE INC.CHARLEMAGNE CONSTRUCTION INC.LA CIE DE MICA DE MISTASSIBI LTEE (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) LA CIE DE NAVIGATION GAUTHIER INC.CINQ-O-LTEE.CLUB DES AMBASSADEURS DE GATINEAU-BUCKINC.HAM INC.LE CLUB COLOMBIEN.CLUB DES EMPLOYES DE LA COMPAGNIE ELECTRIQUE DU SAGUENAY INC.CLUB PICARDIE.CLUB ROB-RA INC.CLUB TRACADIECHE.COMMERCIAL ADMINISTRATION INC.LA COMPAGNIE DE DEBLAIEMENT DES CHEMINS D'HIVER DE KAMOURASKA INC.LA COMPAGNIE EDOUARD JUTRAS LIMITEE LA COMPAGNIE D'IMPRIMERIE ET DE PUBLICATION DE LA RIVE-SUD LIMITEE LA COMPAGNIE JEAN & CHARLES.COMPAGNIE DE REGRIGERATION NATIONALE LIMITEE.LA COMPAGNIE ROGER POITRAS TRANSPORT.CONNAUGHT COUNTRY CLUB.CONSOLIDATED QUEBEC YELLOWKNIFE MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) CONSTRUCTION PREFABRIQUEE TRIBIC INC.HY COOPER INC.COTE VERTU RIDING SCHOOL INC.SHIRLEY CRANE INC.D.S.& B.ENTERPRISES LTD.DAIGLE & ROSS LIMITEE.1!.DAIGNEAULT LTEE.UAILY PICK-UP & DELIVERY LIMITED.DAINTY DOT SHOES INC.St-Paul-de-Lavaltrie.1950 à/to 1952 incl.1954 à/to 1973 incl.Acton Vale.1964 à/to 1973 incl.Charlemagne.1966.1968 et/and 1973 Ste-Lucie-d'Albanel.1943 à/to 1973 incl.Riviire-du-Loup.1948 à/to 1951 incl.1953 à/to 1973 incl.Lauzon.1955 à/to 1973 incl.Gatineau.1972 et/and 1973 Cadillac.1962, 1968.1969, 1972 et/and 1973 Chicoutimi.1966, 1972 et/and 1973 Quebec.1950 à/to 1973 incl.Port-Alfred.1972 et/and 1973 Carleton.1964 à/to 1970 incl.1972 et/and 1973 Montreal.1965 et/and 1966 Rivière Ouelle.1951 à/to 1973 incl.St-Célestin.1948 à/to 1973 incl.Longueuil.1964 à/to 1973 incl.Montréal.St-Georges.Cadillac.Laval.Montreal.La Prairie.Montreal.St-Laurent.Montreal.V.St-Laurent.Ste-Croix-de-Lotbinière.Montréal.DA-KERR-AD CONSOLIDATED MINES LIMITED (No PERSONAL LIABILITY) Québec.Québec.Toronto.1949.1961, 1963 à/to 1973 incl.1952 à/to 1973 incl.1952 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1955, 1957 à/to 1973 incl.1970, 1972 et/and 1973 1952 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1948.1955 à/to 1973 incl.1949 à/to 1973 incl.1963, 1964, 1966 à/to 1973 incl.1949, 1957 à/to 1973 incl.1951 à/to 1973 incl.1943 à/to 1945 incl.1947 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 février 1974.106' année.n° 6 1237 Nom de la compagnie Xamc n/ the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed DALTNER'S LTD.DAN-D-LAX CORPORATION.DANDY PANTS & SPORTSWEAR INC.O.DANEAU LIMITEE.DANEL SPORTSWEAR INC.DANFORTH IMPORT EXPORT INC.J.DANIS LIMITEE.P.E.D'ANJOU & FILS LIMITEE.DARGENCOURT INC.DARLING INVESTMENTS LIMITED.DARUTH MANUFACTURING CO.LTD.DAVERNA MILLS LIMITED.DE LUXE SILKS & LINGERIE LTD.DEBBAGE & HEWITSON INC.DECHAIX BROTHERS LIMITED.DEFOR CHIBOUGAMAU MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) J.E.DELISLE INC.DELORIMIER CONSTRUCTION LTD.DELTA MACHINE AND MOTOR COMPANY.L.DEMERS & CIE LIMITEE.DEMERS TRANSPORT LTEE.DENIS MACHINE SHOP LIMITED.J.-H.DEPELTEAU INC.DEPENDABLE WATCHSTRAPS CO.LTD.THE DESCHENES RATEPAYERS ASSOCIATION.A.D.DESILETS & CIE LIMITEE.DESJARDINS EXPRESS INC.DESROCHES LIMITEE.FERNAND DESROSIERS INC.DIAMOND FUR BLENDING CORP.(CANADA).H.DIAMOND & SONS INC.DISTRIBUTEURS & MANUFACTURIERS DE LEST CIE LTEE.LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS INDUSTRIELS DE SEPT-ILES LTEE EDMOND DUCHARME INSURANCE AGENCIES LTD.Montreal.1947 a/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Joliette.1946 à/to 1973 incl.Montréal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Rimouski.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1950 i/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1934, 1935, 1950 à/to 1973 incl.Mnntivnl 1964 a/In 1973 in.1 Montreal.1945.1958 à/to 1973 incl.Montreal.1949.1957 à/to 1973 incl.Cap-Santé.1946, 1952 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montréal.1957, 1958, 1959.1962 à/to 1973 incl.St-Apollinaire.I960 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1946.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Deschènes.1952, 1956 à/to 1973 incl.Beloeil.1962.1964.1967 à/to 1973 incl.Ste-Thércse.1961 à/to 1973 incl.Montréal.1947, 1948.1951.1953, 1955 à/to 1957 incl., 1960 à/to 1973 incl.Montréal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montréal.1947 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl. I23S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.10G, No.6 Nom de la compagnie Name of the company J.A.DUCHARME & FILS LIMITEE.DUVERNAY EQUIPEMENT LIMITEE.E.S.P.ELECTRONICS LTD.EMMAUS-GRANBY.ENGORA ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES CALCO LTEE.LES ENTREPRISES CRYSTAL CLAIR DE LAVAL INC.F'AUCHER IMMEUBLES ET PRETS INC.LA FEDERATION D'ESCRIME DU QUEBEC.FEDERATION QUEBECOISE DE LA COMPETITION-MOTO-NEIGE STANLEY FOISY LIMITEE.FREECAN INDUSTRIES INC.GESTION S.A.P.INC.EMILE GIROUX LIMITEE.ADELARD GUAY INC.GUIL INC.OVILA HEBERT INC.HODGE & LLOYD LIMITED.HORI7.0N HOLDINGS INC.HOUDE LAROCHE & CIE LTEE.THE HUT BARBECUE INC.HYCO FUR COMPANY INCORPORATED.D.A.IANNUZZI & SONS INC.IDEAL TEXTILES INC.IDEAL TRADING CORPORATION.THE ILE-PERROT YACHT CLUB INC.IMPERIAL AUTO SALES CORPORATION.IMPRIMERIE FORMULES LEGALES PROVINCIALES LTEE IMPRIMERIE PIGEON LIMITEE.THE INDEPENDANT MERCHANTS ASSOCIATION OF QUE-BEC INDUSTRIES AGRICOLA INC.LES INDUSTRIES LAURENTIENNES LIMITEE.LES INDUSTRIES PATAPEDIA LIMITEE.LES INDUSTRIES THERMO LTEE.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Outremont.1971 a/to 1973 incl.Duvernav.1964 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Granby.1964 à/to 1967 incl.1969, 1971 et/and 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Ste-Anne-des-Monts.1971 à/to 1973 incl.Laval.1973 Québec.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Ste-Agathe-des-Monts.1972,1973 Iberville.1946 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.St-Bruno-de-Montarville 1973 Beauport.1953 à/to 1973 incl.Québec.1950 à/to 1973 incl.St-Pie-de-Bagot.1958, 1060 à/to 1973 incl.Drummondville.1969,1973 Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Ste-Croix.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.N.-D.-de-l'Ile-Pcrrot- 1966 à/to 1968 incl.1970,1971 Montreal.1959 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1937 à/to 1973 incl.Quebec.1946 à/to 1973 incl.Québec.1953 à/to 1973 incl.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Luceville.1950 à/to 1973 incl.Montréal.1970, 1972, 1973 GAZETTÏ.OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974.100' aimée.»° 0 1239 Nom de la compagnie Xame of the compart}/ Adren.se Address Rapports non produits Returns not filed L'INSTITUT CANADIEN DES AFFAIRES PUBLIQUES (I C A P) L'INSTITUT DE MICROBIOLOGIE ET D'HYGIENE DE MONTREAL INTER-BRITISH TRADING CO.INC.INTERKNIT LIMITED.INTERNATIONAL ASBESTOS COMPANY LTD.(SANS RESPONSABILITE PERSONNELLE) JACOBY STUDIOS INCORPORATED.JACOBY'S HOUSE OF ANTIQUES INC.JAGRA IMPORT AND UNDERWEAR COMPANY LIMITED.JARDINIERS UNIS DE QUEBEC INC.JAYCEEAR REALTY CORPORATION.BRUNO JEANNOTTE LIMITEE.JERRI INC.LE JEUNE BARREAU DE QUEBEC INC.LE JEUNE COMMERCE DE GASPE INC.JEUNESSE-VILLE INC.JEWELLERS PLATING LTD.JEWISH CITIZEN'S LEAGUE OF MONTREAL INC.JEWISH SCHOOL PUBLISHING ASSOCIATION INC.JO ANN LINGERIE CORPORATION.JOE'S SANDWICH SHOP INC.JOHNSON FRUIT COMPANY LIMITED.JULIETTE DEMOLITION INC.JOLIETTE FOUNDRY & TOOL WORKS LIMITED.JOLIETTE MACHINE WORKS LIMITED.JOLIETTE TEXTILE CORPORATION.JOLIETTE WORSTED CO.LTD.JONQIJIERE QUILLES LIMITEE.JOSEF INC.H.JOSEPH & CO.INC.JOY FOOTWEAR LTD.JOYEL CORP.JUBILEE MEDECIN ICS CO.JUDDMAR INC.Montreal.1969, 1970, 1971, 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1937, 1953 à/to 1973 incl.¦ \\ Montreal.1952 à/to 1973'incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl Montreal.1950 à/to 1973 inol.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montréal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1936, 1939 à/to 1973 incl.Montreal.1951 a/to 1973 incl.Québec.1936.1957 à/to 1973 incl., 1947 à/to 1951 incl.Gaspé.1953 à/to 1973 incl.Woodlands.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1937, 1939 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Repentigny.1968, 1969 1971.1972 Joliette.1947 à/to 1973 incl.Joliette.1943 à/to 1973 incl.Joliette.1947 à/to 1973 incl.Joliette.1958 à/to 1973 incl.Kénoganii.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1946, 1950 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl. 1240 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 197J,, Vol.106, No.G Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1950, 1971 à/to 1973 incl.St-Ma!achie.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1940 à/to 1973 incl.Montreal.1903 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montréal.1953.1954, 1956 à/to 1973 incl.Shawinigan Falls.1954 à/to 1973 incl.Ste-Angcle-de-Monnoir .1955 à/to 1957 incl., 1963 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1932.1934 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Scott Jonction.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1967.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1957 inch.1962 à/to 1973 incl.St-Joseph-d'Alma.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Strathmore.1945 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Shawinigan.1948, 1950 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Ste-Agathe-des-Monts.1945à/to 1948incl.1962 à/to 1973 incl.Québec.1946, 1947, 1949 à/to 1973 incl.St-Eustache.1949 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1950 à/to 1972 incl.Chicoutimi.1948 à;to 1973 incl.JULEP REALTIES INC.JULIEN ELECTRIQUE COMPANY LIMITEE.J.C.JULIEN LIMITEE.JUNIOR KNITTING MILLS LIMITED.K & G CLOAK CO.C.H.KAISER & SON INC.KANBEC GOLD MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) KANE PRODUCTS INC.KAPP AGENCIES LTD.KARO INCORPOREE.KASTNER LIMITEE.KENMAR TEXTILES LIMITED.KENT TRADING CORPORATION.KERTCHIFF DRESS INC.KEYSTONE OVERALL & PANTS MFG.CO.INC.KNIGHT OF THE ROUND TABLE ALUMNI ASSOCIATION INC.B.KOTLER INC.L.K.PASTRY & DELICATESSEN SHOP LTD.LABORATOIRE CUNARD LIMITEE.LABORATOIRE METROPOLITAIN D'ELECTROENCEPHALOGRAPHIE LTEE LABRADOR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.LAC ST-JEAN AUTOMOBILE LIMITEE.LADOUCEUR AUTO REPAIRS LIMITED.LAFLAMME & LAFLAMME LIMITED.LAFOND & CODERRE, LTEE.LAFONTAINE LTEE.LAHAIE AUTOMOBILE LTEE.LAHAIE INC.LAING'S INN INC.LA LAITERIE LA SUETE LIMITEE.LAITERIE MODERNE DE ST-EUSTACHE LIMITEE.LAITERIE PINARD LIMITEE.LA LAITERIE ST-JEAN-BAPTISTE LIMITEE. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 10G< année, n° G 1241 Nom de la compagnie A'amc of the company LAJOIE GROCERS INCORPORATED.LAKELAND SPORTWEAR INCORPORATED.THE LAKESHORE FOOTBALL CLUB INC.LAM Y & FILS LIMITEE.LANDA FROCKS INC.A.C.LANDRY LIMITEE.LANDRY & MCNEIL INC.LANDRY & PERRY LIMITEE.J.ROBERT LANGELIER SHOE MANUFACTURING CO.LTD.LANGLOIS MOTOR SALES LIMITED.BERNARD LANOIX LIMITEE.M.LANQUETOT & FILS LIMITEE.LENCO FIBRE CANADA CORPORATION.LESSARD POLICE EQUIPMENT & SPORTS INC.LIGUE DE CROSSE DES CANTONS DE L'EST.LORTIE & ROUSSIN INCORPOREE.LOVE-LEE LADY LINGERIE STORES INC.LUMBER & SUPPLY INC.LUSTRALITE CORPORATION.LYNNS LADIES WEAR INC.M.A.KNITTING MILLS LIMITED.M.& A.SHEET METAL WORKS LTD.M.& J.NOVELTY CO.LTD.M.& R.TRADERS INC.MAB LIMITED (LIMITED).MACAMIC INC.MACDONALD SMELTING & REFINING COMPANY LIMITED.D.E.MACLEOD GRANITE INC.THE MAC Y FUR CO.MADEMOISELLE MODES INC.MADISON DRESS INC.MAFCO CORPORATION LTD.MAGASIN BELLE-RIVIERE LIMITEE.MAGASIN GAREAU LIMITEE.MAGMA MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1939 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1960 à/to 1973 incl.Verdun.1944, 1949 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Mont-Joli.1950 à/to 1973 incl.Chutes-aux-Out ardes____ 1951, 1954 à/to 1973 incl.Montréal.1951 à/to 1973 incl.Gaspé.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947, 1957, 1965 à/to 1973 incl.Berthierville.1945, 1948 à/to 1973 incl.Shefford.1938, 1951 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Granby.1969, 1970, 1972 et/and 1973 Giffard.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1964, 1966 à/to 1973 incl.Montreal.1936, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1948, 1951 a/to 1973 incl.Montreal.1946, 1948.1949, 1953 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 St-Georges-de-Beauce.1958 à,to 1973 incl.Granby.1948, 1953 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Grenville.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1950, 1952 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Lachute.1947.1949 à/to 1973 incl.St-Faustin Station.1954 à/to 1973 incl.Hull.1940 à,to 1973 incl. 1242 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 9.1974.Vol.100.Xo.C Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed JAS.H.MAHER & SON LTD.MAILMAN CORPORATION LIMITED.MAIN MOTOR SALES INC.THE MAIN STREET CLUB OF MONTREAL INC.MAISON ADELARD LASALLE LIMITEE.MAISON BOURDON INC.MAISON CHAMBORD LTEE.'.MAISON CHARMAINE LTEE.LA MAISON COLOMBIENNE DE ROBERVAL INCORPOREE LA MAISON DIANA INC.LA MAISON JOSEPH BOUMANSOUR LIMITEE.MAIS(>N NOTRE-DAME-DE-L'ENFANCE.LE MAITRE VOILIER INC.MAITRISE D'ARTS LIMITEE.MAJESTIC INDUSTRIES LIMITED.MALARTIC CLUB.MANHATTAN COMPANY LIMITED.MANOIR INVESTMENTS LIMITED.MANOIR ROCHER PANET INC.MANUFACTURE DE MEUBLES MATANE LTEE.MANSFIELD REALTY CORPORATION LIMITED.MANSIONS MOTORS LIMITED.MANSONVILLE UTILITIES LIMITED.MANUFACTURE DE ROBES ET COSTUMES DE REPENTIGNY INC.MAPLE LEAF CLEANERS & DYERS CO.MAPLE LEAF PEAT LIMITED.MAPLE LEAF TEXTILES LTD .MAPLE LEAF TRANSPORT LIMITED .MAPLE ORCHARDS LIMITED.MAPRON REALTY INC.MARATHON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.MARBO PLASTICS CO.LTD.MARCELLE'S LADIES WEAR INC.MARCHAND & HAMEL AUTOMOBILE LTEE.St-Laurent.1946 à/to 1973 incl.Lachine.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1936, 1939, 1940, 1942 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.-, 1955 à/to 1973 incl.Montréal.1956 à/to 1973 incl.Montréal.1932 à/to 1944 incl.1955 à/to 1973 incl.Roberval.1949 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1951 à/to 1973 incl.Montréal.1945, 1949 à/to 1973 incl.Québec.1947 à/to 1951 incl.1953 à/to 1971 incl.ct/and 1073 Montréal.1946 à/to 1973 incl.Yirtoriaville.1950 à/to 1973 incl.Malartic.1946 à/to 1973 incl.Québec .1947 à/to 1949 incl., 1959 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à, to 1973 incl.LTslet.1960 à/to 1973 incl.Matane.1948.1950 à/to 1973 incl.Beaurepaire.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Sutton.1958 à/to 1973 incl.Repentigny.1972 et/and 1973 St-Laurent.1950 à/to 1973 incl.Rivicre-du-Loup.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Québec.1945 à/to 1973 incl.Beauceville.1957.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1938 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Roberval.1953 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 197.',, 106' aimée, n' G 1243 Nom de la compagnie Xamc of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed MARCHE-DAVIS-MARKET LIMITEE.MARCHE DE FRUITS JACQUES-CARTIER LTEE.MARCHE ST-VALLIER LIMITEE.A.E.MARCOTTE LTEE.MARGIE DON INCORPORATED.SAMUEL MARGOLIS DRESS CORP.MARGOT COATS INC.MARIETTE GOLD MINES LIMITED.MARITIME & GULF LUMBER LIMITED.MARITZER DRESS INC.MAR LEY AGENCIES LIMITED____.MARSHALL ROSS & CO LTD.MARSOUL MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) MARTEL GARAGE CIE LTEE.MARTIN LIMITEE.MARY'S FOOD MARKET INC.LA MASKOUTAINE LIMITEE.L.MASSICOTTE LTEE.MASTER FOOTWEAR INCORPORATED.THE MASTER LADIES-HAIRDRESSERS AND WIGMAKERS GUILD MATANE BEACH COUNTRY CLUB INCORPORE.MATANE WORKS INC.MATERIEL D'IMPRIMERIE LIMITEE.MAXWELL HOLDINGS INC.MAXWELL SPREADS INC.DEANNA MAY INC.MAYBERY HAT INCORPORATED.MAYFAIR FOOD CORPORATION.MAYOU-PENCER CLOTHES INC.McCULLOCH EQUIPMENT CO.LTD.McGILL FUR LIMITED.MCGILL PRINTING LIMITED.MCHARG & WADE LTD.Arvida.1955 à/to 1973 incl.Québec.1950 à/to 1973 incl.Québec.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1960, 1963 à/to 1973 incl.Montreal.1948, 1950 à/to 1973 incl.Montreal.1950.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Amos.1942 à/to 1973 incl.Ste-Félicité.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Québec.1942 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1964 à/to 1973 incl.Cap-de-la-Madeleine____ 1952 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1940, 1942, 1965 à/to 1973 incl.Matane.1942.1943.1946 à/to 1973 incl.Matane.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1949, 1955.1958 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montréal.1934.1941 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1944, 1948 à/to 1973 incl.Montreal.1938, 1958, 1960 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl. 12-14 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.February 9, 1974, Vol.100, A'o.0 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Mégantic.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.St-Jovite.1948.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1949.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1939 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1938 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Québec.____ 1948 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1940 »/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1951 incl.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Toronto.1955 à/to 1973 incl.St-Simon-de-Drummond.1949 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1942.1958 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1947 incl.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1946, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1950 à to 1973 incl.Plessisville.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1957 à,to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1948, 1950 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.D.V.MCLEAN INCORPORATED .MEDICAL ACOUSTIC INSTRUMENTS LIMITED MEGANTIC AERO SERVICE LIMITED.MEGANTIC MILLS LTD.GEORGES MEILLEUR A FILS INC.MEL CLASS 4 LEON PASCAL IMPORTERS LIMITED MEL-BER MANUFACTURING COMPANY MEMPIIREMAGOG WATER POWER ASSOCIATION-INCORPORATED S.MENDELSOHN INC.MEN'S APPAREL INC.LA MENUISERIE CANADIENNE LIMITEE MERCHANTS CLOTHING CO LTD.mercury shoe co ltd.MERRY MAID FASHIONS INC.METAL HEAT TREATING CO.METAL INDUSTRIES INCORPORATED.METALLIC CRYSTAL GAUGE CO LTD.METALORE MINING CORP.LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).METAYER SIMONEAU ET PANNETON LIMITEE.METRO TEXTILES LTD.METROPOLE CLUB INCORPORATED.METROPOLE CONSTRUCTION LTEE.METROPOLITAN BRAIDS LTD.METROPOLITAN GOULET COMPANY LIMITED.METROPOLITAN JEWELLERY MFG.CO.LTD.METROPOLITAN MANUFACTURING 4 SUPPLY CO.LTD.METROPOLITAN SERVICE INCORPORATED.METWOOD PRODUCTS INC.MEUBEAU INC.LE MEUBLE SOMERSET LIMITEE.MIAMI LINGERIE INC.MICHAEL MANUFACTURING COMPANY LIMITED .MICTAW MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) MIDLAND INDUSTRIES LTD. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 fierier 1974, IOC' année, n' G 1245 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed MID-TOWN DRESS INC.MIKLOS INCORPORATED.MILADY HAT MFC CO.LTD .MILE END FRUIT EXCHANGE INCORPORATED.MILICENT'S INCORPORATED.MILK FOR HEALTH INCORPORATED.A.I.MILLER & SONS LTD.THE D.A.MILLER CO.LTD.MILLER TRADING & MANUFACTURING LTD.MILLER'S ECONOMY STORE LIMITED.MILMAR CLEANERS & DYERS INC.MIL-WAR LTD.MIMEO-STENCIL MANUFACTURERS LIMITED.MINES HOLDINGS LIMITED.LES MINES D'OR BELLEHUMEUR LTEE (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE).MINESCO INC.MINESHAFTS LIMITED.MIREILLE INCORPOREE.MISS AMERICA MAID INCORPORATED.MISTASSINI LEAD CORPORATION LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).MODERN AGE MANUFACTURING COMPANY LIMITED.MODERN FROCKS LIMITED.MODERN HOME FURNISHERS LTD.MODERN NOVELTIES & SPECIALITIES LIMITED.-MODERN SPINNERS INC.MODERN TRADERS LTD.MODERN WOOD PRODUCTS LTD.MODERNAIRE INCORPORATED.MODERNITE INDUSTRIES LIMITED.MODES DU JOUR LIMITEE.THE MOLIVER SISTERHOOD AND BROTHERHOOD SOCIETY.MOLYCA MINES LIMITED.MONARCH REALTY & ADMINISTRATION COMPANY.MONETTE FURS INC.THE MONTCALM LUMBER COMPANY INC.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1935.1936, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1953, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1933.1934, 1937 à/to 1973 incl.Verdun.1945, 1950 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.Montreal.1938 à/to 1973 incl.Beam.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Noranda.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Bourlamaque.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Lachine.1953 à/to 1973 incl.Longueuil.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Lachine.1957 à/to 1973 incl.Montréal.1949.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1958 incl.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Rawdon.1950 à/to 1973 incl. 124G QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, A'o.6 Nom de la compagnie -Vame of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Shawbridge.1960 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1949 à/to 1973 incl.Montfort.1934, 1938 à/to 1973 incl.Montreal.1948, 1950 à/to 1973 incl.Montreal.1935, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Outremont.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1936, 1951 à/to 1973 incl.Longueuil.1943 à/to 1945 incl.1949.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1934, 1939 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1943, 1945 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl Montreal;.1932 à/to 1937 incl.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1972 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incj.Montreal.1938, 1949 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1932 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947, 1950 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1941 à/to 1973 incl.Montreal.1933, 1948 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1937 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1954, 1956 à/to 1958 incl.MONT-CASSIN LODGE LTD.MONTEX LIMITED.THE MONTFORT COUNTRY CLUB INC.MONT-LOUIS MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).THE MONTREAL BLANKET COMPANY.MONTREAL BLOUSE & SPORTS WEAR INC.MONTREAL CIVIC CENTRE INCORPORATED.MONTREAL CLOTHING CO.INC.THE MONTREAL DENTAL SUPPLY AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED MONTREAL DIE CASTING CO.LTD.THE MONTREAL ELGAR CHOIR.THE MONTREAL FIGURE SKATING CLUB INCORPORATED.MONTREAL FOOTBALL CLUB INCORPORATED.MONTREAL FRUIT RECEIVERS ASSOCIATION INC.MONTREAL FUEL CELL FORM SUPPLYERS LTD.MONTREAL HARDWOOD FLOORING CO.LTD.MONTREAL HAT & CAP MANUFACTURERS ASSOCIATION INC.MONTREAL HEARING AIDS BUREAU INC.THE MONTREAL HEBREW OLD PEOPLES' AND SHELTERING HOME THE MONTREAL HORSE SHOW, LTD.MONTREAL INDUSTRIES & ENTERPRISES LIMITED.MONTREAL IRON AND METAL SMELTERS, LIMITED____ MONTREAL ISLAND POWER COMPANY.MONTREAL KENNEL ASSOCIATION, INC.MONTREAL KNITTING MILLS INC.MONTREAL MERCHANTS' ASSOCIATION.MONTREAL MODEL RAILROAD CLUB INC.MONTREAL-NEW YORK EXPRESS LTD.MONTREAL ORCHESTRA, INC.MONTREAL-OTTAWA EXPRESS LINE LIMITED.MONTREAL PLASTER WORKS INCORPORATED.MONTREAL & PROVINCIAL SHOE REPAIRERS ASSOCIATION INC.MONTREAL QUARRY LIMITED.MONTREAL TINNING & RETINNING CO.LTD. GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC, 9 fitrier 197.',.10G- année, n\" r, 1247 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed MONTREAL VENEER PANEL INC.MONTREAL WARTIME FUEL COMMITTEE INC.MONTREAL WAX PAPER MANUFACTURING COMPANY LIMITED MOR-ANN FASHIONS INC.MORDAVE REALTY INC.MORDIPAL CONSTRUCTION COMPANY INC.MORENCY MOTOR SALES LTD.MORGAN SILVER CROSS MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) J.B.MORIN & CIE LIMITEE.J.B.MORIN INC.MORIN LUMBER LIMITED.MOR-LITE REALTY CORPORATION.MORTON CLOTHES LTD.MOUNT ROYAL MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) THE MOUNTAIN CASTLE INC.MOUNTAIN CREST MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) MOUNTAIN LIMITED.MOUNTAIN VIEW BUNGALOWS LIMITED.MOUVEMENT POUR LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE INC.MULTI-PRODUCTS LIMITED.MUNDY GRAIN TRIMMERS PATENTS LIMITED.MURRAY COLD STORAGE & WAREHOUSING CO.LTD.MUTUAL ENTERPRISES LTD.MUTUAL INDUSTRIES LIMITED.MUTUAL SPORTSWEAR INCORPORATED.MYRON GLASS FRAME INC.NATALIE INC.NATIONAL ACCESSORIES COMPANY LIMITED.\" NATIONAL CONSTRUCTION CO.LIMITED.NATIONAL FRAMES LIMITED.NATIONAL FRUIT EXCHANGE INCORPORATED.NATIONAL HARDWARE INC.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1933 à/to 1935 incl.Montreal.193S à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Québec.1947 à/to 1949 incl.1962 à/to 1973 incl.Québec.1947 à/to 1973 incl.Garthby.1953, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1945, 1956 à/to 1973 incl.Montreal.195R à/to 1973 incl.Montreal.1937 à/to 1939 incl.1942, 1946 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1950, 1953 à/to 1973 incl.Victoriaville.1972 et/and 1973.Montreal.1942 à/to 1944 incl.1952 à/to 1973 incl.Laval-des-Rapides.1933 à/to 1945 incl.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montréal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à,to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1934 à/to 1936 incl.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl. 1248 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 9, 1971,, Vol.106, No.6 Nom de la compagnie\tAdresse\tRapports non produits Xame of the company\tAddress\tReturns not filed \tMontreal.\t1950 à/to 1973 incl.NATIONAL REALTY & BUILDING COMPANY.\t\t1956 à/to 1973 incl.NATIONAL SHOE REPAIRERS PROTECTIVE\t\t1946, 1952 à/to 1973 incl.ASSOCIATION INCORPORATED\t\t \t\t.1949 à/to 1973 incl.NELSON PLUMBING & HEATING COMPANY LIMITED .\tMontreal.\t1950 à/to 1973 incl.NEMO CONSTRUCTION CO.LTD.\t\t.1946 à/to 1973 incl.NEO-BEAUTY LINE COMPANY LIMITED.\tMontreal.\t1953 à/to 1973 incl.\tMontreal.\t1945, 1948 à/to 1973 incl.THE NEW CHIRIOTTO FARM INC.\tSte-Adèle-en-Haut .\t1953, 1955 à/to 1973 incl.NEW PALACE HOTEL LIMITED.\tMontreal.\t.1950 à/to 1973 incl.NEWS-AD INCORPORATED .\tMontreal.\t1945 à/to 1973 incl.\tLaval.\t1969 à/to 1973 incl.\t\t.1969, 1971 à/to 1973 incl.PERALD INC.\tAmos.\t1971 à/to 1973 incl.PLACEMENTS MEILLEUR INC.\tMontréal.\t1968.1970 à/to 1973 incl.PLANCHERS DOMINION INC.\t\t1961.1962, 1964 à/to \t\t1973 incl.PRAHOVA MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).\tMontreal.\t1952 à/to 1973 incl.PRINCEYTLLE WOODCRAFT LIMITED.\tPrinceville.\t1947 à/to 1973 incl.PROMINENT GARMENT INC.\tMontreal.\t1945, 1951 à/to 1973 incl.PROVINCIAL LABORATORIES LIMITED.\t\t1966 à/to 1973 incl.PUBLICOGRAPHES INC.\t\t1966 à/to 1968 incl.\t\t1971 à/to 1973 incl.PYRAMID METALS INCORPORATED.\tMontreal.\t1953 à/to 1973 incl.QUEBEC EXPLORERS LTD.(LIBRE DE RESPONSABILITE\tMontréal.\t1956 à/to 1973 incl.PERSONNELLE)\t\t QUEBEC MOTOR SALES COMPANY LIMITED.\tSillery.\t1950 à/to 1973 incl.THE QUEBEC MUSICAL COMPETITION FESTIVAL\tMontreal.\t1947 à/to 1973 incl.INCORPORATED\t\t QUEBEC PRECAMBRIAN CORPORATION LIMITED.\t\t1947 à/to 1973 incl.QUEBEC ROKOROL LIMITED.\t\t.1949, 1951 à/to 1973 incl.QUEBEC TEXTILES INC.\tQuébec.\t1954 à/to 1973 incl.R.& G.MACHINE REBUILDERS LTD.\t\t1970 à/to 1973 incl.\t\t1963 à/to 1973 incl.\t\t1970, 1971 et/and 1972 \tRiviere-Beaudette .\t1970 à/to 1973 incl.\t\t1937, 1938.1940 à/to \t\t1973 incl.\t\t.1938 à/to 1945 incl., \t\t1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 férrier Mi, 100' aimée, «° fi 1240 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed RED COMET OF CANADA LTD.REFRIGERATION « GLACIALE » LIMITEE.LA RENARDIERE P.A.ALAIN LIMITEE.RENAUD AND SONS LTD.RENCO LIMITED.REVANNA SPORTSWEAR INC.RHODT METAL WORKS LTD.RIMOIN'S S( TO «1.00 STORES INC.ROBERGE & FILS LTEE.MARCEL ROY & ASSOCIES INC.ST.HUBERT DEPARTMENTAL STORE LTD.ST-LAWRENCE HARDWARE INC.LE SANATORIUM BRUCHESI DE MONTREAL.LE SANATORIUM DE GASPE INC.SANDERS GARMENT INC.SAVANNAH CONFECTIONERY LIMITED.P.A.SAVARD LIMITEE.SCOTT JEWELLERY CO.LTD.SEAFORTH MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).SEAGREEN LABORATOIRES INC.SEAWARD LIMITED.SECRETARIAT DES SYNDICATS CATHOLIQUES DE MONTREAL INCORPORE.SEGUIN CONSOLIDATED MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).JACK SELIGMAN INCORPORATED.H.SELINGER & SONS LTD.LE SENAT DE LA JEUNESSE.LOUIS A.SENDEL CO.SENDEL MACHINERY CORPORATION.SERRURE DE CAPOT GENERAL INC.SERVICE D'AMELIORATIONS LIMITEE.SERVICE D'AVIATION CHARLEVOIX SAGUENAY LTEE.SERVICE DE LAVAGE DE 10 MINUTES LTEE.SERVICE DES LOISIRS DE STE-SCOLASTIQUE.SERVICE PLEATING INCORPORATED.Montreal.1959 à/to 1973 incl.Québec.1949 à/to 1971 incl., et/ and 1973 Québec.1939, 1944, 1947 et/and 1949 à/to 1973 incl.Loretteville.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1940, 1041.1947'à/to 1973 incl.Bagotville.1961 à/to 1973 incl.Laval.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1945, 1955 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1946 à/to 1973 incl.Gaspé.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1935, 1937 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Sillery.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1934 à/to 1973 incl.Montreal.1946, 1948 à/to 1973 incl.Montréal.1946 à/to 1973 incl.Westmount.1964 à/to 1968 incl.et/and 1973 Montréal.1932, 1961 à/to 1973 incl.Mentréal.1939 à/to 1941 incl.1949 à/to 1951 incl., 1965 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1946 à/to 1973 incl.Québec.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Laprairie.1936, 1938 à/to 1973 incl.Bergeronnes.1947 à/to 1973 incl.Québec.1953 à/to 1973 incl.Ste-Scholastique.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1933, 1938 à/to 1973 incl. 1250 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9.1974.Vol.100, No.G Nom de la compagnie Xamc of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.19\" à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1945 »/' 1973 incl- Montrcal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Seven Islands.l96\",\u201e/t,°, l*83S?£ .1969 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Lachine.1946, 1951 à/to 1973 incl.Shawinigan Falls.1946 à/to 1973 incl.Shawinigan Falls.1946, 1948 à/to 1973 incl.Montréal.1939 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl Montréal.1948, 1951 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1948 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1949, 1953 à/to 1964 incl.1967 à/to 1972 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1932, 1937 à/to 1973 incl.Montréal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Québec.1940 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Orsainville.1967.1972, 1973 Ste Julienne.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1937 à/to 1973 incl.Montreal.1942.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1938 à/to 1973 incl.Montréal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1946, 1948 à/to 1973 incl.SERVICE POPULAIRE INC.SERVICE SPORTSWEAR MFG.CO.SERVICE TOOLING CO.LTD.SERVICES PUBLICITAIRES INCORPORES SEVEN EIGHTEEN CORPORATION.SEVEN ISLANDS LIONS CLUB INC.JACK SHACHTER INCORPORATED SHAKESPEARE CLUB.SHAWINIGAN MICA LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) SHAWINIGAN PLYWOOD PRODUCTS LIMITED.SHAWMAQUE GOLD MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) A.SHAYNE INC.SHEFFIELD STEEL BLADE LTD.H.C.SHEFLER INC.SHERBROOKE FEEDS LIMITED SHERBROOKE NEWS COMPANY INCORPORATED.SHERMONT INC.SHILLERB FABRICS INC.SHOECRAFT COMPANY LIMITED.SHULMAN CAP COMPANY LIMITED.SIDNEY TEXTILE CORPORATION.SIGMA PHI DELTA FRATERNITY MONTREAL INC.SIL-BLU GARMENT INC.SILMONT IMPORT INC.SILVER GRANITE COMPANY LIMITED.H.J.SILVER FUR MFG.CO.LIMITED.JACQUES SIMARD INC.SIM-ART INC.SIMIS INC (SERVICE D'INFORMATION DE MONTREAL).SIMIS REALTIES INC.SIMMONS MINING COMPANY LIMITED.J.SIMON & COMPANY LIMITED.THE SIMON SHOE COMPANY LIMITED.J.P.SIMONEAU LTEE.SINOER-.IVCKSON FASHIONS INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974.106' année, n° 0 1251 Nom de lu compagnie A'ame of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Trois-Rivicres.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1947, 1953 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1941 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1939 à/to 1973 incl.Montreal.1953, 1955, 1956, 1958 à/to 1973 incl.Montréal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1939 à/to 1973 incl.Montreal.1942, 1946 à/to 1973 incl.Montreal.1946, 1948 à/to 1973 incl.Montréal.1934 à/to 1973 incl.Montréal.1946 à/to 1949 incl-, 1951 à/to 1973 incl.Québec.1967, 1969 à/to 1973 incl.Ste-Luce-sur-Mer.1950, 1952 à/to 1973 incl.Lachine.1949.1952 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1935, 1940 à/to 1973 incl.Sayabec.1951, 1952, 1955 à/to 1973 incl.Montréal.1945, 1947 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.St-Jenn .1947, 1951, 1952 1954 à/to 1973 incl.DONAT SINOTTE INC.SKALL INC.SKODA & SON LIMITED.SKY CRUISES INCORPORATED.SKYLINE CLOTHES INC.SLATER BROS.INC.,.SMALL GENERAL 5i STORE LTD.SMART CHILDREN'S WEAR INCORPORATED SMART MADE DRESS COMPANY LTD.SMART MISS INC.SMARTWEAR LIMITED.SMEATON BROS.LIMITED.SMILING JUNIORS INC.ARTHUR SMITH FURS INC.SMITH BUILDING SERVICES LTD____ J.SMITH LTEE.W.W.SMITH & COMPANY LIMITED.SMITH'S SANITARY SUPPLY CO LTD SNOWDON DRY CLEANERS INC SOCIETE CANADIENNE D'ASSISTANCE MEDICALE INCORPOREE LA SOCIETE CLASSIQUE.SOCIETE D'ENTRAIDE QUEBEC-HAITI LA SOCIETE GENERALE DE SAINTE-LICE-SUR-MEl; LIMITEE SOCIETE D'HISTOIRE REGIONALE DE LACHINE .SOCIETE IMMOBILIERE MAISONNEUVE LIMITEE LA SOCIETE DE PLACEMENTS ST-GEOliGES LTEE SOCIETE DES PRODUITS DELECTA LIMITEE.LA SOCIETE ST-JEAN BAPTISTE DE SAYABEC.LA SOCIETE DES SECOURISTES DE QUEBEC INC THE SOCIETY HAT MFG.CO.LTD SOIERIES BOELL LIMITEE. 1252 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.February 9.197.',, Vol.106.No.6 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed SOMERLED REALTIES COMPANY LTD.VICTOR C.SOUCISSE & COMPAGNIE INCORPOREE.SOUTH SHORE ECHO LTD.SOUTHERN SLIPPERS (1966) LTD.SPECIALITES LASALLE SPECIALITIES INC.SPORT GUILD INC.STANDARD STEEL PRODUCTS LIMITED.THE STANLEY CLUB INC.STAN RAY COMPANY LIMITED.STELLA DRESS INC.STERLING EMBROIDERY LTD.STERLING FUR COMPANY.STERLING SLIPPER INC.STOKER LIMITEE.STRUCTURES UNIVERSELLES INC.STUART ENTERPRISES LTD.STUDIO ALBERT DUMAS LIMITEE.STUDIO HEBERT LTEE.STYLE SIGNS LTD.TRANS-KEBEC VACUUM (QUE) INC.TREMBLAY LUMBER CO.LTD.TRUMOR SECURITIES LTD.VANGUARD SYSTEM INC.VERA PIZZA INC.MAURICE VERVILLE LIMITEE.W.B.REALTY COMPANY.YOUTH EMPLOYMENT SERVICE CORPORATION Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1938 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1949 incl.1958 à;to 1961 incl., 1963 à/to 1973 incl.St-Rcmi.1972 et/and 1973.Verdun.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1953, 1954 1959 a/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Drummondville.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1950 a/to 1973 incl.Montreal.1949, 1951 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montréal.1947 à/to 1963 incl., et/and 1965 Charlemagne.1972 et/and 1973 Sutton.1957.1959 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Sillery.1967, 1969 à/to 1973 incl.Québec.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1965 à/to 1973 incl.Québec.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973.55834-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.55834-0 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 février 1974, 106' année, n\" 6 1253 Lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4.Sa et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4, Sa and following of the Companies Information Act.the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazette of this second notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date A.E.C.CORPORATION INC.A.X.ELECTRONICS CORP.LES AGENCES LEO GAUTHIER INC.AGENCES M.Gl'AY INC.LES AGENCES MUSICALES SAGUENAY LAC ST-JEAN LTEE.AGENCES TOURISTIQUES CARTIER INC.AHUNTSIC PLUMBING & HEATING CO.LTD.L'AIDE AU FOYER INC.AMENAGEMENTS BAIE PLAISANCE INC.L'ARCHE DES JEUNES.LES ARCHERS LAURENTIENS.ARENA DE LA RIVE SUD INCORPOREE.A RES VILLE GARDENS INC.ARGENTEUIL EQUIPMENT LIMITED.ARGUS PRESS CORP.ARMOIRES DE LUXE INC.ARNEL COMMERCIAL ENTERPRISES LTD.LES ARTS FEMININS DE LA MAURICIE INC.ARVIDA TENNIS CLUB INC.ASSOCIATION DE BASEBALL DE ST-HYACINTHE INC.L'ASSOCIATION DE CAMPING DE CHANDLER INC.ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DU SERPENT NOTRE-DAM E-DU-LAUS.QUE.ASSOCIATION DES CITES DES JEUNES DU QUEBEC.L'ASSOCIATION DES CLUBS DE SERVICE DU QUEBEC METROPOLITAIN INC.L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS AVERTIS.ASSOCIATION DE DANSE A D R Q.L'ASSOCIATION DIOCESAINE DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU DIOCESE DE TROIS-RIVIERES INC.L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS DU CEGEP DE THETFORD INC.ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DU COLLEGE DE JONQUIERE ASSOCIATION DES GROUPEMENTS EN ALIMENTATION INC.St-Laurent.04 12 1908 Montreal.04 11 1970 Jacques-Cartier.26 -06 1969 Jacques-Cartier.24 01 1969 Aima.06 10 1959 Québec.21 11 1966 Montreal.13 07 1960 Rosemont.10 04 1961 Montréal.26 08 1970 Montréal.07 04 1970 Joliette.03 11 1969 Laprairie.12 09 1961 Montreal.05 08 1958 Lachute.08 05 1957 Montreal.02 08 1971 Ville D'Anjou.27 02 1969 Montréal.12 01 1970 Shawinigan.11 11 1968 Arvida.04 07 1967 St-Hyacinthe.17 01 1972 Chandler.10 06 1960 St-Pierre.28 05 1968 HuU.22 12 1966 Québec.29 09 1966 Longueuil.03 05 1971 Québec.22 03 1971 Trois-Rivières.30 11 1961 Thetford-Mines.08 11 1971 Jonquière.02 05 1967 Jonquière.07 10 1970 1254 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, No.6 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Incorporation Address Date Montréal.08 11 1965 St-Calixte.02 06 1969 St-Dunstan-Lac-Beau- 02 08 1968 port Pont-Viau.13 05 1960 St-Georges.18 08 1964 Montréal.01 04 1963 Ste-Victoire-d'Arthabas- 29 11 1963 ka St-Joseph-de-Coleraine .13 08 1970 Montréal.28 05 1964 Lac-Vert.05 07 1967 Longueui!.10 09 1971 Cap-de-Ia-Madeleine____ 28 04 1969 Montréal.19 04 1971 Montréal.24 02 1960 Montréal.16 05 1973 Montréal.28 05 1969 Montreal.12 10 1971 Montréal.22 08 1969 Berthierville.12 10 1971 Montréal.02 09 1966 Montréal.08 02 1972 Montreal.19 11 197\" Montréal.06 03 1968 Aima.06 05 1969 St-Lanibert.01 09 1971 Noranda.28 11 1967 Shawville.18 03 1969 Montréal.23 11 1971 Montreal.10 06 1926 Ste-Agathe.28 12 1966 Marieville.07 06 1967 Montréal.16 05 1963 Aima.13 10 1970 Beauport.07 05 1965 Montreal.30 12 1971 ASSOCIATION JEUNESSE ET CULTURE DU QUEBEC.ASSOCIATION DES LOISIRS DU LAC ROND INC.L'ASSOCIATION NAUTIQUE DU LAC BLEU INC.L'ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC.ASSOCIATION PARENTS MAITRES ST-GEORGES INC.ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CINEASTES.L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DES CHALETS DES EBOULIS INC.L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC BISBAY.ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC MATAMBIN.L'ASSOCIATION DES PROPRIETAUIES DU LAC VERT INC'.ASSOCIATION REGIONALE DE NATATION AMATEUR RIVE-SUD METROPOLITAINE ASSOCIATION TROIS CAP.ASSURANCES PIERRE ALIX INC.LES AUBERGES DE JEUNESSE DU QUEBEC.AUTO C.O.V.INC.AUVICOM INC.AVIAN DEVELOPMENT CORPORATION.AYOTTE & LAMBERT INC.B.G.L.INC.B.H.CONSTRUCTION INC.B.L.M.CONSTRUCTION INC.B.L.R.LANGUAGE SCHOOLS LTD.B.T.H.CONSTRUCTION LTEE.LA BAIE DU NORD FOURRURES INC.YVES BAILLARGEON LTEE.LES BARONS DE ROUYN NORANDA.BARRIF LTD.BAYCO INC.BEACONSFIELD CLUB SHARES LIMITED.CHARLES A.BEAUDIN INC.BEAULE TUILE ET TAPIS INC.BETON MIN VILLE INC.BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET DU SAGUENAY LAC ST-JEAN BIENCO LTEE.BIG VALLEY LIVESTOCK EXPORTERS INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 février 1974.10H' année.n° fi 1255 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date BILRAL INC.THE BLACK AND GOLD ATHLETIC ASSOCIATION INC.BLACKSTONE BUILDING CORPORATION.F.W.BLANCHARD INC.GERARD BLANCHET INC.LE BLE D'INDE PAYSAN INC.BLONDIN LEASING INC.BOEUF SUR LE TOIT INC.LA BOHEME HAUTE COIFFURE INC.BONNEVILLE REALTY INC.GERARD BOUTIN LTEE.BOUTIQUE AU VIEUX GRENIER INC.BOUTIQUE MAXIME INC.BOUTIQUE TAJ MAHAL LTEE.MAURICE BRAULT JOAILLIER INC.C.A.T.A.(L'AGE D'OR).C.L.P.S.INC.CADET CLEANERS LIMITED.LE CAFE TABOURET LTEE.CANTALIA CONSTRUCTION INC.CENTRE ASTRONOMIQUE DE MONTMAGNY INC.CENTRE CIVIQUE DE JOLIETTE INCORPOREE.LE CENTRE COLOMBIEN SAINTE-FOY INC.CENTRE JOUR INC.CENTRE LOISIRS DANSE BAIE DES CHALEURS.CERCLE D'ETUDES EN CONDUITE AUTOMOBILE (C.E.C.A.).ARMAND CHAMPOUX INC.CHAUSSURES MASSY INC.CIDRERIE DE LA VALLEE DU RICHELIEU INC.CINE PARC VAL LOISIR INC.CINEDOME THEATRES LTD.CIRCUIT MT TREMBLANT ST-JOVITE INC.CITADEL SALVAGE CORPORATION.THE CITADEL STEAK HOUSE INC.CITE DES JEUNES DE HULL.CITY EDIBLE REFINING LTD.CLUB AU RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS (LAC ('ACHE) INC.CLUB AUTO NEIGE KM BO DE ROUYN NORANDA INC.Montréal.15 11 1960 Verdun.23 09 1960 Westmount.23 12 1958 Mont-Royal.03 01 1961 Québec.29 12 1970 L'Assomption.05 01 1962 Hull._.27 07 1964 Greenfield Park.06 04 1967 Montréal.27 12 1968 Québec.25 02 1960 Aylmer.14 10 1969 Montréal.05 08 1970 Montréal.18 04 1967 Montréal.15 12 1971 Montréal.28 12 1967 Ville-Marie.17 01 1972 St-Jean.08 11 1971 Montreal.03 00 1970 Montréal.04 07 1967 Ville d'Anjou.13 10 1961 Montmagny.05 05 1954 Joliette.09 04 1969 Ste-Foy.16 02 1968 Québec.06 04 1971 Carleton.18 10 1971 Montréal.23 11 1970 Trois-Rivicres.20 10 1964 Montréal.23 07 1964 St-Basile-le-Grand.28 12 1971 Montréal.25 08 1971 Montreal.28 05 1962 St-Jovite.05 06 1904 Québec.11 04 1956 Montreal.29 11 1968 Hull.13 09 1961 Montreal.29 11 1968 Chibougamau.13 12 1971 Noranda.23 02 1972 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9.1974, Vol 106, No.6 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Address Date CLUB AUTO NEIGE DE STE-MARIE INC.\t\t11\t12\t1964 \t\t07\t11\t1968 CLUB D'AVIATION DE TROIS-RIVIERES INC.\t\t30\t11\t1971 CLUB D'AVIRON DE L'EQUIPE DU QUEBEC INC.\t\t22\t11\t1971 LE CLUB DE BASEBALL LES SAINTS DE SAINTE-THECLE INC\t\t22\t04\t1966 CLUB BI-CLOU-FIL.\t\t26\t06\t1963 CLUB DE CHASSE & PECHE LACHAINE.\tSt-Pierre-de->Vakefield.\t20\t02\t1964 CLUB DE CHASSE ET DE PECHE ST-GERMAIN DES MONTS.\tGiffard.\t03\t07\t1952 \t\t19\t06\t1972 \tSt-Eusèbe.\t13\t03\t1962 \t\t29\t08\t1961 CLUB DE MOTO-NEIGE LES ETOILES DES PINS INC.\t\t16\t08\t1971 \t\t23\tKl\t1968 \t\t07\t11)\t1970 CLUB DES PLAINES INC.\t\t01\t08\t1956 CLUB LE RACCOURCI INC.\t\t18\t04\t1958 \t\t21\t11\t1967 \t\t21\t(17\t1969 \t\t20\t09\t1965 CLUB LA ROSE DES VENTS DU QUEBEC METROPOLITAIN INC.\t\t21\t(12\t1966 LE CLUB DE SKI DE GASPE INC.\tGaspé.\t10\t02\t1964 \tMontréal.\t27\t11\t1970 CLUB SPORTIF POCOMOCO INC.\tSt-Basile.\t25\t08\t1972 LE CLUB SPORTIF DE VICTORIA VILLE INC.\t\t14\t07\t1967 CLUB DE TENNIS DE MATANE.\t\t20\t06\t1956 \tSt-Isidore\t05\t06\t1962 CLUB TROIS-RIVIERES ARCHERS.\t\t09\t06\t1961 \tSorel\t11\t05\t1959 \t\t28\t09\t1970 COMITE DES CITOYENS DE TROIS-RIVIERES.\tTrois-Rivicres.\t07\t07\t1969 COMITE DES LOISIRS DES TROIS RUISSEAUX INCORPOREE.\tL'Anse-au-Griffon.\t23\t06\t1969 LA COMPAGNIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION INC.\t\t25\t05\t1960 COMPTOIR AGRICOLE ST-LOUIS INC.\tSt-Louis-de-Gonzague.\t13\t10\t1971 LE CONCILE DES JEUNES DE SAINT-HYACINTHE.\tSt-Hyacinthe.\t17\t01\t1972 CONSEIL REGIONAL DE BIEN-ETRE DE SHERBROOKE.\t\t13\t03\t1967 \tMontréal.\t10\t03\t1971 \tMontreal.\t07\t04\t1970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 février 197/,, 10G' année, n° G 1257 Nom de la compagnie Name of the company CORKO LTEE.CORNUCUPIA INVESTMENTS LTD.CORPORATION IMMOBILIERE B.& J.INC.LES CYCLONES DE WARWICK.Y.CYR TIRE & AUTO SERVICE LTD.D.R.ROLLING METAL INC.D'AVRAY PROPERTIES LIMITED.DELTA INVESTMENTS INC.DELTA TECHNIQUES LTD.BERNARD DIGUER 5-10-15 INC.DISCOUNT ISTA-PRINTS (D.I.P.) INC.DISTRIBUTION ELITE LTEE.LE DOMAINE DU PERCHOIR INC.DOWNCASTER DEVELOPMENT INC.DROMIL INVESTMENT INC.DUNN ENTERPRISES INCORPORATED.DWELLING LOCATION SERVICE LTD.E.T.SPECIALTIES INC.ECOLOG-MOTIVATION INC.EDIFICE TREVER INC.ELGAR MINING CORP.LIMITED.ENTREPRISES ARC INC.LES ENTREPRISES ARMAND VADEBONCOEUR LTEE.LES ENTREPRISES BLB INC.ENTREPRISES BOCAR INC.LES ENTREPRISES G & C INC.LES ENTREPRISES G.M.M.INC.ENTREPRISES H.O.M.LTEE.LES ENTREPRISES J.J.S.INC.ENTREPRISES HOSPITALITE LIMITEE.LES ENTREPRISES LABRANCHE INC.LES ENTREPRISES LAFLEUR (1961) LTEE.LES ENTREPRISES LALLOUZ INC.LES ENTREPRISES LAURY INC.LES ENTREPRISES MAUPIER INC.LES ENTREPRISES MAUROG INC.LES ENTREPRISES DE MEUBLES LUC GENEST INC.LES ENTREPRISES MONT PLAISANT INC.Adresse Address Incorporation Date Sherbrooke.18 01 1967 Montreal.31 05 1967 St-Laurent.02 07 1964 Warwick.03 08 1964 Montreal.25 09 1968 Cap-de-la-Madeleine____ 21 10 1969 Montreal.11 08 1971 Montreal.08 06 1961 Montreal.23 11 1967 Donnacona.21 03 1962 Montreal.23 II 1970 Montréal.16 02 1961 Montréal.21 11 1972 Montreal.20 08 1968 Drummondville.09 03 1971 Montreal.04 10 1952 Montreal.27 06 1958 Sherbrooke.20 01 1966 Montreal.10 03 1969 Québec.19 03 1971 Montreal.08 11 1971 Trois-Rivières.29 11 1968 Montréal.20 04 1971 La Tuque.13 07 1962 St-Laurent.08 04 1968 Montréal.27 10 1964 Brossard.13 04 1971 Hull.29 10 1971 St-Jean.24 09 1969 Laval.06 08 1968 Granby.22 11 1967 Montréal.23 08 1961 CôteSt-Luc.21 06 1971 Laval.28 05 1969 Jacques-Cartier.23 11 1964 Montréal.21 11 1966 Chicoutimi.04 08 1970 Sherbrooke.04 05 1962 1258 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9.1971,.Vol.100, A'o.6 Nom de la compagnie Name of the company EQUIPEMENT B.G.INC.EURO-STUDIO LIMITEE.FAVRE & FILS LIMITEE.ERNEST FIEDERER SALES INC.FONDATION ARTISTIQUE DE SAINT-JEAN.FONDS MASKA LIMITEE.4 SEASONS DRIVE IN (MASSON) LTD.EDGAR FORCIER & FILS INC.FRONTIER BEAGLE CLUB.G.A.INC.G.G.GRAPHICS INC.G.H.GAGNE AGENCIES INC.LA GANG DU BARBILLON INC.GARAGE A A B LTEE.GARTHBY TRANSPORT LIMITEE.GATINEAU PETROLEUM INC.GAZ OUELLET (1962) LTEE.PAUL GELINAS INC.GELINEAU AUTO PARTS INC.MICHAUD GENDRON INC.GENEREUX CONSTRUCTION INC.GENEVA INVESTMENT LIMITED.GENOA PAINTING INC.GERTO LTEE.GESTNAN LIMITEE.GIGUERE & FRERES INC.THE GOLDEN ARMS CLUB INC.GRANBY HOLDING LTD.GRANBY SPINNING MILLS LTD.GRAND CONSTRUCTION LTD.GRAND PAVILLON (HULL) INC.GRAND TEMPLE PYTHIAN SISTER (P.S.) OF QUEBEC INC.GRANGE 32 INC.GREEK PROGRESSIVE ASSOCIATION OF CANADA INC.GREEK RADIO WIRE PROGRAMS INC.JEAN GRONDIN INC.JACQUES G.GUAY ET ASSOCIES INC.Adresse Incorporation Address Date St-Sulpice.11 08 1964 Laval.09 07 1968 Chicoutimi.30 01 1967 Montreal.01 06 1962 St-Jean.21 07 1970 St-Joseph.28 11 1963 Montreal.17 07 1967 Montréal.26 09 1969 Hinchinbrooke.17 04 1958 Montréal.30 05 1968 Montreal.27 12 1971 Montreal.23 10 1953 Ste-Marie.06 02 1960 Montréal.23 09 1963 Garthhy.30 12 1955 Gatineau.03 09 1968 Montréal.13 07 1962 Montréal.30 12 1966 Stc-Brigide.11 09 1963 Sept-Iles.03 11 1971 St-Jean-de-Matha.22 10 1971 Montreal.14 01 1966 Montreal.05 02 1968 Trois-Rivières.13 01 1970 Montréal.07 07 1971 Shawinigan Falls.18 07 1963 Montreal.21 08 1969 Granby.27 05 1964 Montreal.15 03 1965 Montreal.09 11 1962 Hull.29 12 1967 Montreal.04 11 1965 Québec.28 09 1965 Montreal.14 01 1965 Montreal.25 10 1966 Montréal.14 05 1968 Montréal.17 04 1968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 197.',, 100' année, n° 0 1259 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date LUCIEN HAMEL CONSTRUCTION INC.BERT HARVEY CORPORATION.HELLENIC FOOD INDUSTRIES CO.LTD.HENRI-ETTE DRESS INC.HICKORY INDUSTRIES INTERNATIONAL SALES CORPORATION.HILLTOP NURSERY AND GREENHOUSES LTD.HOTEL PAQUET LTEE.HOTEL ROCHER BLANC LTEE.HOTEL ST-LOUIS (LA SARRE) INC.HOTEL TAILLEFER ET FILS INC.LES HUILES LAFLAMME INC.I & C CONSTRUCTION INC.IMMEUBLES IMPERIAL CIE LTEE.LES IMMEUBLES LABROSSE INC.IMMEUBLES OUTREMONT REALTIES INC.IMMEUBLES ET PRETS J.P.L.INC.INDUSTRIES GRONDIN & DOUCET INC.INTERNATIONAL CINE CLUB INC.INTERNATIONAL PREMIER PIZZA KING CORPORATION.LES INVENTIONS GATIEN & MAJOR LTEE.J & J PROMOTION INC.J & M LEATHER GOODS LTD.J.M.J.HOLDINGS INC.J.P.B.AUTOMATE INC.J.L.JACQUES TRANSPORT INC.JETRONICS CORPORATION.JEUNAC INC.LA JEUNE CHAMBRE DE MONT LAURIER.JEUNE COMMERCE DE LYSTER.LE JEUNE COMMERCE DE QUEBEC-OUEST INC.JOA MANAGEMENT LTD.RAY JOBSON INC.JOLIN CONSTRUCTION LTEE.JOSEPH LE TAILLEUR INC.JUNIOR B DE THETFORD INC.JUNIOR HOLDINGS INC.K & M MEAT MARKET INC.Windsor.27 12 1962 Montreal.27 07 1959 Montreal.21 07 1969 Montreal.30 05 1968 Montreal.02 08 1963 Beaconsfield.24 08 1967 Shelter Bay.07 07 1959 Sacré-Coeur.04 09 1963 La Sarre.06 12 1971 Beauharnois.30 09 1971 Thetford-Mines.08 04 1969 Montreal.22 08 1966 Montréal.28 10 1963 Longueuil.29 01 1971 Outremont.17 07 1957 Sherbrooke.30 09 1970 Laval.12 03 1970 Montréal.16 03 1967 Québec.13 12 1965 Val d'Or.07 10 1966 La Salle.20 06 1969 Montreal.05 06 1968 Montreal.20 02 1961 St-Antoine.02 07 1969 Montréal.03 08 1966 Montreal.23 10 1969 Sherbrooke.30 09 1970 Mont Laurier.23 10 1970 Lyster.11 05 1962 Québec.27 04 1962 Montreal.15 06 1962 Valcartier.29 06 1964 Montréal.09 02 1965 Montréal.12 12 1962 Thetford-Mines.04 11 1966 Montreal.21 03 1960 St-Laurent.05 10 1962 1260 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1971,, Vol.106, So.6 Nom de I» compagnie Same of the company KALO REALTIES LTD.KANAWID INC.KAPRISSE INC.M.KATZ INC.KEMPSON INC.KERNOR CORPORATION.KESSLER INDUSTRIES INC.KIMI'TON DUPUIT AGENCIES LIMITED.KIRON INVESTMENT CORPORATION LTD.KING KONG CAFE DE THETFORD INC.L.B.SERVICE INC.L & M TRANSPORT INC.L.T.L.INC.LA HUE AUTOS (1964) INC.LABELLE ELECTRIQUE INC.LABRADOR OIL INC.LABROSSE EXPANSION BIT CORPORATION R.LACHA PELLE LTEE.LACHINE MAROONS INC.LACHMAS INVESTMENTS INC.LACOMBE INVESTMENTS INC.J.LACOSTE INC.LADUQUESNE INC.LAFOND & VALDAIS INC.LAKESHORE STRUCTURAL STEEL CO.LTD.LA LIBERTE & FILS INC.J.M.LAMBERT AUTOMOBILE INC.LAMBERT CO.LTD.LAMBERT MANAGEMENT CORPORATION.LAMINCO INC.LANBAR CONSTRUCTION CORP.LANDSCAPE SALES CO.LTD.SAM LANDSMAN INC.LANGCO INC.LAURENTIAN SKI-DOO CENTRE INC.J.P.LAVERDIERE INC.OU.LEGER INC.Adresse Address Incorporation Date Montreal.St-Hubert.Montreal.Montreal.St-Hubert.Montreal.St-Laurent.Montreal.Montreal.Thctford-Mines.St-Liboire.Montreal.Ste-Foy.Victoria ville.Rosemère.Montmagny.Lafontaine.St-Vincent-de-Paul.Lachine.Lachine.Montreal.Montreal.Saint-Michel-des-Saints Montréal.Lachine.Jonquière.Shawinigan.Montreal.Montreal.Montréal.Côte-St-Luc.Montreal.Montreal.Montréal.Montreal.Québec.Sherbrooke.12\t06\t1961 13\t02\t1964 .21\t06\t1967 10\t(H\t1959 15\t06\t1960 06\t(>_\u2022\t1962 07\tKl\t1966 11\t03\t1960 08\t02\t1966 13\t02\t1962 24\tKl\t1967 12\t1 1\t1968 26\t07\t1971 09\t01\t1964 28\t09\t1965 01\t.10\t1971 15\t03\t1963 28\t01\t1962 16\t11\t1960 03\t03\t1959 31\t03\t1959 14\tKl\t1964 .03\t1 1\t1971 24\t02\t1966 29\t01\t1969 05\t02\t1963 18\t06\t1963 12\t07\t1951 23\t05\t1952 23\t01\t1970 12\t03\t1954 28\t04\t1960 05\t11\t1959 16\tni\t1969 18\t12\t1964 31\t10\t1961 06\t07\t1959 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, n° 6 1261 Nom de la compagnie S'ame of the company Adresse Address Incorporation Date LEMAIRE AUTO INC.LIBRAIRIE EDIBEC INC.LIGUE DE BALLE MOLLE ST-GEORGES.LIGUE DE HOCKEY INTERMEDIAIRE «A » DE L'EST DU QUEBEC INC.LIGUE DE HOCKEY LAVAL SENIOR INC.LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE BLAINVILLE.LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLE DE CHARLESBOURG LINGERIE LADO INC.LOISIRS DU LAC MASSIE INC.LES LOISIRS DE NORTH HATLEY INC.LOISIRS DE VENISE EN QUEBEC INC.LONG L'EU IL PLASTERING INC.LOU BLACK'S LIVING ROOM \"67\" INC.THEODORE J.LUBBERS CO.INC.M & M INVESTMENTS INC.MAISON ROMEO INC.MAISON EX LTEE.MAISONNEUVE METALS 4 SMELTING INC.MAISONS ECONOMIQUES B.G.INC.LE MANOIR STE-AGATHE INC.MAPLE GROVE ISLAND CORP.MAPLE LEAF TRUCK LINES INC.MARINE COMPUTER CENTER LTD.MAR-LAN INC.MARTIN'S DRIVE IN RESTAURANT INC.MASKINONGE STOCK CAR INC.MASSICOTTE TRANSPORT INC.RODOLPHE MASSON INC.MASTER REALTIES INC.MASTER TILERS CORPORATION.MATOL RESEARCH LIMITED.MATTE 4 ST-ARNAUD AUTOMOBILES INC.McAM LTD.McDONALD-CARTIER LTD.McKAY TRANSPORT INC.M EI LAN INC.MILAIR AVIATION INC.Tracy.08 07 1968 Montréal.23 04 1971 St-Georges.07 01 1958 Sept-Iles.01 03 1967 Laval.29 10 1968 Blainville.03 12 1970 Charlesbourg.07 09 1951 Québec.06 11 1969 St-Jérôme.07 07 1960 North Hatley.26 05 1971 Venise-en-Québec.17 04 1962 Longueuil.22 08 1968 Montreal.27 01 1967 Montreal.28 06 1963 Montreal.26 09 1960 Laval.26 05 1969 Saint-Fclicien.19 09 1968 Laval.08 06 1970 Québec.23 07 1970 Ste-Agathe.20 03 1969 Montreal.08 04 1958 Côte-St-Luc.29 11 1971 Montreal.08 10 1970 Bécancour.03 11 1966 Montreal.08 02 1968 Maskinongé.30 05 1967 Montréal.10 06 1965 Montréal.16 10 1967 Montreal.31 05 1967 Montreal.20 02 1967 Québec.10 04 1945 Montréal.30 07 1968 Jacques-Cartier.12 08 1964 Montreal.28 05 1969 Cookshire.15 05 1958 Montreal.01 09 1960 Westmount.31 10 1969 1262 QUÉBEC OFFICIAI.CA'/.FTTi:.February 9.1974, Vol.106.Ko.6 Nom de la compagnie Name of the company MINING COMPANY OF THF.NORTH LTD.LE MIROIR Dl\" QUEBEC INC.MIZENER ELEVATOR COMPANY.MOBEL CONSTRUCTION LIMITEE.MOBILAB INC.MOBILE MOTEL INC.MOBITAP LTEE .MODAL INC.MOLISE PAVING CO.LTD.MONACCO DEVELOPMENT CORP.MONIK REALTY COUP.MONTREAL J.M.ELECTRIC INC.MONTREAL SWITCHC.EAR INC.MOTEL LE BOCAGE SIGHTSEEING INC.MOUVEMENT LAÏQUE DE LANGUE FRANÇAISE MULTIPLAN INC.MUSEE DE LANAUDIERE.NETTOYEUR MAGIQUE DE L'OUTAOUAIS INC.LE NETTOYEUR « MAISON BLANCHE » INC.NIAGARA MAINTENANCE INC.C.B.NIELSEN & CO.LTD.BRUCE G.NORMAN LIMITED .O.T.J.DE WATER VILLE INC.L'OEIL 1969 INC.OUELLETTE & LAFOREST INC.P.J.B.& ASSOCIATES INVESTMENT CORP.P.N.L.CONSTRUCTION INC.P.V.C.ISOLATION INC.PAGE & PAGE AMEUBLEMENTS INC.PALMER JUNIOR WEAR MFG.CO.INC.PAMORE INVESTMENT CORPORATION.PAN-AM EQUIPMENT AND MACHINERY LTD.PANAME BISTRO INC.PARACHUTE ST-JEAN INC.GUY PARADIS AUTO BODY INC.PIERRE PARANT AUTOMOBILE LTEE.PAR-BIZ INC.Adresse Address Incorporation Date Montreal.06 08 1971 Laval.31 08 1965 Montreal.29 04 1969 Montreal.28 10 1960 St-Hyacinthe.04 07 1962 Montreal.06 10 1966 Montréal.20 11 1967 Mercier.11 04 1968 Montreal.22 09 1961 Montreal.25 08 1965 Montreal.23 01 1959 Montreal.30 08 1967 Montreal .23 03 1967 St-Lambert.01 10 1959 Montréal.04 01 1962 Montréal.10 10 1963 St-Charles-Borromée.25 05 1967 Pointe-Gatineau 06 08 1970 Anjou.10 12 1970 Montréal.12 12 1969 Montreal.11 04 1963 Montreal.06 09 1962 Waterville.11 09 1964 Drummondville.14 03 1969 Montréal.05 04 1968 Montreal.13 11 1969 Lafieche.08 07 1969 Montréal.13 02 1970 Montréal.18 04 1961 Montreal.05 06 1958 Montreal.13 12 1961 Montreal.17 05 1965 Montréal.05 04 1968 St-Jean.30 12 1971 Montreal.07 02 1966 St-Antoine-des-Lauren- 05 02 1959 tides Québec.11 04 1969 GAZETTE OFF ICI ELLE DU QUÉBEC.9 février 1974.100' année.n° 6 1263 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Incorporation Address Date St-Jovite.15 01 1963 Montreal.16 07 1963 Montreal.19 08 1965 Montreal.20 11 1961 Montreal.27 04 1964 Montreal.11 12 1968 Montreal.01 05 1962 Montreal.07 11 19G1 Montreal.28 09 1949 Maniwaki.18 02 1957 St-Eustache.29 06 1971 Trois-Riviores.08 10 1963 Ste-Adcle-en-Bns.26 07 1963 St-Léonard.01 03 1967 Montreal.30 01 1959 Montreal.07 05 1965 Montreal.10 12 1958 Montreal.19 08 1965 Montréal.06 02 1968 Sherbrooke.22 05 1964 Montréal.04 10 1968 Montréal.08 04 1965 Sherbrooke.30 06 1968 Québec.22 06 1961 Montréal.25 05 1954 Montréal.15 05 1964 St-Télesphore.11 03 1971 Teinpleton.09 07 1963 Montréal.30 11 1961 Ste-Madeleine.30 09 1966 l'ierrefonds.16 11 1971 Outremont.16 08 1960 Saint-Lambert.21 02 1968 Ste-AngMe.31 03 1971 Montreal.27 11 1968 La Tuque.29 05 1970 St-Léonard.28 09 1970 LE PARC SAINT-JOVITE INC.PARK CONSTRUCTION LTD.PARK LANE GIFTS LTD.PARK PRODUCTIONS LTD.PARKLAF INC.PARTHIMOS ELECTRIC LAMPSHADES CO.LTD.PASTEUR ST.URBAIN REALTY CORP.PAT REALTIES LTD.PATISSERIE ROSEMONT LTEE.PATRY-JOANIS LTEE.PEINTURES LABELLE INC.J.L.PELLERIN INC.LA PERLE DU LAC INC.PETROLE GAZET INC.PHEASANT LAND INC.PINO LANDSCAPING CO.LTD.THE PLACE D'ARMES ST.JAMES STREET VICTORIA SQUARE BUSINESSMEN'S ASSOCIATION LES PLACEMENTS D.L.R.INC.PLACEMENTS GRATIEN GELINAS INC.PLACEMENTS KAKOL INC.PLACEMENTS LAJEUNESSE LTEE.LES PLACEMENTS LAMARRE LTEE.LES PLACEMENTS MICHEL DROLET INC.PLACEMENTS DE LA MONTAGNE INC.LES PLACEMENTS NUCKLE INC.LES PLACEMENTS RAGILLES DE QUEBEC LTEE.LES PLACEMENTS EDEN INC.PLOMBERIE PAPINEAU LTEE.PLOMBERIE PARIS INC.PLOMBERIE STE-MADELEINE LTEE.POLIGRAPHIC LABEL & TAG (QUEBEC) INC.PORT O .VIATIQUE LTEE.LES PRODUITS D'ARGILE DE ST-LAMBEHT LTEE.PRODUITS CHIMIQUES COBEL LTEE.PROFESSIONAL AUTOMOBILE SALESMEN'S ASSOCIATION-LES PROMOTIONS ALBANY INC.LES PROMOTIONS SUCCES INC. 1264 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February .9, 1971,, Vol.106.No.C Nom de la compagnie A'ame of the company Adresse Incorporation Address Date St-Félicien.22 11 1966 Montréal.30 11 1972 Mont-Laurier.19 10 1964 Kawdon.26 11 1968 Montréal.05 11 1069 Repentigny.25 03 1968 Montreal.22 07 1970 Lachine.23 04 1970 Montreal.07 11 19G9 Québec.06 10 I960 Montreal.17 08 1960 St.Lambert.22 01 1960 Jacques-Cartier.22 03 1966 Montreal.10 08 1967 Boucbsrville.02 02 1968 Montreal.21 11 1962 Laval.13 06 1968 Sillery.05 04 1972 St-Jean.13 01 1971 Montreal.09 12 1966 Saint-Sauveur.05 12 1967 Plessisville.10 05 1971 Montreal.06 06 1969 Montreal.02 10 1963 Montréal.12 11 1958 Montreal.13 08 1968 Québec.06 02 1968 Montreal.02 06 1965 Montréal.04 01 1966 St-Antoine-des-Luuren- 22 06 1960 tides Trois-Rivières.09 05 1961 Greenfield Park.05 08 1958 Montréal.03 04 1963 Montréal.12 10 1965 Dorion.29 01 1962 Montréal.05 04 1963 Longueuil.05 05 1967 PROPANE NORD INC.LES PROVISIONS MODERNES (MONTREAL) INC.PUBLICATIONS LABELLE INC.LES PUBLICATIONS LAMON INC.PUBLICITE JEN DRO INC.PUBLICONTACT INC.QUEBEC AUTOMOTIVE INDUSTRIES LIMITED.QUEBEC DRAGWAY INC.QUEBEC ELEC INC.QUEBEC STORE INC.QUICK O WASH INC.RAILROAD MEN'S BENEVOLENT FUND.RANCH J.N.INC.RAPID GRO CONSTRUCTION CO.LTD.RE HEC INC.REALTY GROUP INCORPORATED.RECUPERATION MONDA INC.LES REPRODUCTIONS ARTISANALES NOUVELLE-FRANCE INC.RESTAURANT ETOILE FILANTE INC.RESTAURANT LE GRAND PRIX INC.RESTAURANT LE POULET & MOI INC.RESTAURANT LES 4 SOEURS LTEE.RIVARD AUTO BODY INC.RONALD HOME PARTIES LTD.G.ROUX LIMITEE.S.H.C.HOLDING CORPORATION.S.I.V.A.LTEE.S & J ASSOCIATES INCORPORATED.J.B.ST-JACQUES LIMITEE.ST.JEROME AUTO SPORT INC.ST.JOSEPH JOBBING LTD.ST-LAMBERT TUILES & TERRAZZO LTEE.ST-ZOTIQUE RESTAURANT INC.SALON NATIONAL GRAND PRIX LTEE____ PAUL-E.SAUVE INC.J.SAVOY & CIE LTEE.SCULPT-O-MATIC INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 9 fierier 1974, 100- année, n° 0 1265 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Address Date \tMontréal.\t00\t11\t1959 \tMont-Tremblant.\t15\t08\t1966 LES SEMAINES INTERNATIONALES DU CINEMA.\tMontréal.\t27\t12\t19C7 \tHull.\t12\t12\t1967 LE SERVICE DES BOULANGERIES LABBE & ARMSTRONG INC.\tSte-Cécile-de-Milton .\t.12\t05\t1969 \tJonquière.\t23\t05\t1969 \t\t20\t06\t1964 \t\t20\t09\t1968 \t\t04\t03\t1963 SOCIETE BOGEST INC.\tSte-Foy.\t19\t06\t1969 LA SOCIETE DE CHASSE ET PECHE LAURENTIEN DE GATINEAU.\tGatineau.\t19\t05\t1905 SOCIETE DE CONSTRUCTION R M INC\tSt-Michel.\t08\t04\t1963 \t\t14\t08\t1961 \t\t02\t12\t1968 SOCIETE DES LOISIRS ET ECOLOGIE DE WATERLOO INC.\t\t\t12\t1971 LA SOCIETE PAPINEAU INC.\t\t.19\t02\t1964 LA SOCIETE SAINT-JEYN-BAPTISTE SA.INTE-MARIE\tMarieville.\t03\t10\t1951 SOMARO INC.\tCap-de-la-Madeleine.\t14\t08\t1967 SOUTHERN INDUSTRIAL BUSINESS SALES LTD.\tMontreal.\t19\t01\t1972 \t\t.26\t01\t1971 Sl'ORBEC INC.\tDrummondville.\t.10\t12\t1969 STAR OFFICE SUPPLIES INC.\t\t30\t08\t1967 \t\t01\t03\t1967 STATION ESTIVALE MASKINONGE LTEE.\tSt-Didace.\t16\t01\t1963 STEERING LTD.\tMontreal.\t19\t07\t1960 STRATHDEE'S FLOWER SHOP INC.\t\t15\t06\t1966 STUDIO J.P.M.INC.\tMontréal.\t13\t11\t1967 STUDIOLITH INC.\t\t14\tni\t1909 SUBSTANTIAL DEVELOPMENTS OF MONTREAL LTD.\t\t23\t06\t1970 \tQuébec.\t.12\tli)\t1965 \tMontréal.\t20\t02\t1958 \t\t23\t02\t1959 \t\t02\t05\t1968 SWANTON INVESTMENT CORP.\tMontreal.\t.15\t09\t1969 \t\t\t02\t1969 SYSTEMES DE BUREAUX ST-LAURENT LTEE\tSt-Laurent.\t21\t09\t1970 TAVERNE CHEZ JOS INC.\t\t01\t04\t1971 I2l)r, QCfiliFC OFFICIA/.GAZETTE, February 9.1974.Vol.100, So.G Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Incorporation Address Date Québec.22 01 1969 Montreal.20 08 ¦ 1963 Montréal.13 01 1960 St-Vallier.17 08 1967 Montreal.19 02 1963 Moot-Royal.12 12 1966 Montréal.19 02 1951 Ste-Koy.28 05 1964 Montréal.21 10 1971 Montréal.12 01 1966 Jonquière.14 03 1962 Montreal.15 12 1971 Montreal.23 04 1965 St-Séverin-de-1'rouxville.08 08 1961 Montreal.02 12 1944 Shawinigan.06 10 1967 St-Laurent.18 01 1072 Montreal.23 08 1971 Baie-Comeau 19 12 1969 Montreal ____ 26 05 1967 Montreal.04 01 1962 St-Don,inique.17 07 1962 St-Ueorges.22 12 1966 Granby .24 12 1963 Laval.21 09 1965 Beloeil.28 03 1958 Montréal.05 04 1971 Verdun.27 07 1967 Waterloo .22 03 1961 Montreal.19 07 1967 Lachine.27 11 1908 CôteSt-Luc.19 11 1969 TAVERNE PINET INC.TERREBONNE PARK ESTATES LTD.GERARD TETRAULT LTEE.GEORGES THEBERGE INC.THRU-WAY PARKING LTD.TIP TOP LEATHER GOODS MFG.LTD.TOMEO & COLAVECCHIO INC.TRANS ST-LAURENT EQUIPMENT INC.TRANSPORT E.L.LTEE.TREMBLAY & LAGARDE INC.LES TROUPIERS DE JONQUIERE INC.TRU-ACRES INC.JOHN TRUDEL INC.LES TUYAUX DE BETON MAURICIENS INC.20TH CENTURY LADIES WEAR INC.L'UNION DE PARENTS DU GRAND SHAWINIGAN.L'NITECH INC.UNIVERSITY INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION LTD.USINAGE ET SOUDURE BAIE COM EAU INC.V.L.AUTO BODY INC.VAL MORIN ENTERPRISES LTD.\\ AI.COURT & FILS AUTO PARTS INC.J.P.VEILLEUX INC.LES VICS DE GRANBY INCORPOREE.J dt 8 VINCENT INC.J.LOUIS VOGHEL LTEE.LES VOYAGES SOLMAR INC.WATER MATIC MONTREAL LTD.THE WATERLOO BASKETBALL CLUB .G.S.WATT 4 ASOCIATES LTD.WEST END HEALTH STUDIOS INC.YOUNG-1 INC.-,5)4:i4-o Ce directeur du service des compagnie*.PlKKKK Df.SJAIUHNS.05*34-., PiKHiii; Desjahpink.Ituiclor of the ' ¦\u201e,\u201e,,.,\u201e;,, Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9 fierier 1974.106' année, n' 6 1267 Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Lettres patentes (I\"' partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to l'art I de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ACT EH THICOLOHE LTEE.TRICOLOUR STEEL LTD.LES APPARTEMENTS SIR THOMAS CHAPAIS INC.REAL ARSENEAl- ET ASSOCIES INC.LES ATELIERS MECANIQUES DE TRACY INC.TRACY MECHANICAL SHOP INC.L'AUBERGE DE LA MARIE GALANTE INC.AUTO ALLARD INC.AUTOBUS CAMPAGNA INC.HAMBOO GARDENS RESTAURANT (AYLMER) LTD.RESTAURANT JARDINS BAMBOU (AYLMER) LTEE J.M.BECHARD INC.BETON PREMELANGE FORTIN INC.FORTIN READY-MIX IXC.LES BOIS A.R.C.INC.A.R.C.LUMBER IXC.BOUTIQUE AU COIN DES JEUNES AMOUREUX INC.HURY FISH HATCHERY INC.PISCICULTURE BURY INC.C.R.D.HOLDING INC.IMMEUBLES C.R.D.INC.CENTRE DE RADIOLOGIE WEST ISLAND INC.WEST ISLAND RADIOLOGY CEXTRE INC.CENTRE DU CAMION D'ASBESTOS INC.CHEZ NICOLE JEUNE MODE INC.CLINIQUE MEDICALE HUBERDEAU INC.HUBERDEAU MEDICAL CLINIC INC.COMMERCE STEIN INC.STEIN TRADING INC.LA COMPAGNIEGUY FLEURANT ET FRERE LIMITEE.CONSTRUCTION CLAUDE LAFOND INC.CONSTRUCTION DEUX MILLE TREIZE INC.CONSTRUCTION SYSTEMAX INC.405, Grand Boulevard, Ile-Perrot.16 11 73 3150, France-Prime, Québec.50.Place Crémazie ouest, Suite 1210, Montréal 351.4405, rue Lemay, Tracy.14X8.rue Ste-Catherine est, Montréal.2039, chemin Chambly.Longueuil.522, rue Wilson, Chibougamau.Aylmer.1035.Long-Sault, Sainte-Foy.145, Route 45ouest.Amos-ouest 21 11 73 20 07 73 11 12 73 23 11 73 03 12 73 18 12 73 22 10 73 14 12 73 28 12 73 108, rue Mariale, Sainte-Foy.10 12 73 La Grande Place, Rimouski.Bury.S140, 51e Avenue, Laval-ouest.Pointe-Claire.Asbestos, .Saint-Georges.Hulierdeau 350 Louvain Street West, 3rd Floor, Montreal.GS0O, rue l'apineau, app.2, Montréal .1285, avenue Vallée, Plessisville.IS, rue St-Romain, Saint-Emile.9293, 03e Avenue, Montréal.25 09 73 21 09 73 2S 11 73 20 U9 73 17 11 73 27 11 73 19 09 73 10 12 73 13 I1 73 19 11 73 28 12 73 07 12 73 12fiS QUEBEC DEE ICI,IL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, \\o.6 Nom / Katnt Siège social / Head Office Incorporation Date DECO K MEUBLES B.C.INC.JEAN-MARIE DELISLE LTEE.DISTRIBUTION AUTOMATIQUE D.A.M.LTEE.D.A.M.VENDING LTD.LES ENTREPRISES LA CHAUMIERE INC.LES ENTREPRISES MARSILLY INC.LES ENTREPRISES McCREADY INC.LES ENTREPRISES RENE TARDIF CHIBOUC.AMAU INC.EXCAVATION MARCEL CHABOT INC.LA FERME BOURGET INC.LA FERME DES TROIS CASTORS INC.FIBRE DE VERRE P.Q.INC.P.O.FIBERGLASS /AC.A.FORTIER & ASSOCIES INC.FURMAN (NORTH) LTD.FURMAN (NORD) LTEE PHILIPPE GENDRON & FILS INC.HAUTE COIFFURE ALAIN MICHEL INC.ALAIX MICHEL HAUTE COIFFURE IXC.HOTEL ALBANEL INC.REJEAN HOULE INC.LES IMMEUBLES ANDRE SEGUIN INC.LES IMMEUBLES COLETTE INC.COLETTE PROPERTIES IXC.LICS IMPORTATIONS G.& M.INC.G.cratives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act.he has authorized the correction of the letters paient issued to the following companies or corporations: Nom / Noms Siège social Incorporation Head office Date Modifications Corrections SERVICE PAR AIR DEI.IVRO INC.DEI.IVRO AIR SERVICE INC.179 Brittany, 20 11 73 Remplaçant le nom / Replacing the name: Mont-Royal.SERVICE PAR AIR DELIVRO INC.\u2014 DELIVRO PAR AIR SERVICE INC.par / 6y SERVICE PAR AIR DELIVRO INC.\u2014 DELIVRO AIR SERVICE INC.Le directeur du serriee des compagnies, 55834-0 1 'ik h uk.Dcsjardins.\tPierre Desjardins, 55834-o Director of the Companies Service.Changement de nom\tChange of Name Le ministre des institutions financières, compagnie** et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a approuvé les règlement n de changement de nom suivant:\tTlie Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act.he has approved the hy-lans changing the name of : Nouveau nom / Xew name\tAncien nom Incorporation Former name Date BLONDO INC.LACHAPELLE, ETHIER, RAINVILLE * ASSOCIES INC.RUBY FOO'S (MONTREAL) LTD.RUBY FOO'S (MONTREAL) LTEE INDIAN SLIPPER MFC.CO.LTD, 04 04 25 LACHAPELLE & ETHIER INC.II 08 71 1RLEO LTD.10 11 73 IRLEO LTEE 55834-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjmidins.56834-0 Pierre Desjahdins.Director of the Companies Scrricc. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 10G' année, n\" G 1273 Abandon de charte Surrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a accepté l'abandon de la charte de: Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Incorporation Dissolution Nom / Name Date Date ARNO REALTY LTD.1G 02 49 31 01 74 LES BARONETS INC.05 12 Of, 31 01 74 CENTRE CHIRURGICAL CREMAZIE INC.18 03 65 31 01 74 LA CIE DES MACHINES DE BUREAUX DE MONTREAL INC.05 09 57 31 01 74 MONTREAL OFFICE MACHINES CO.INC.CLUB SOCIAL DES POMPIERS DE COATICOOK.09 12 69 31 01 74 COMITE DU CENTENAIRE D'ALMA INC.23 06 60 31 01 74 DOMINION BANANA & POTATO CO.08 09 50 31 01 74 E.H.WOOLNOUGH INCORPORATED.24 03 30 31 01 74 ELLSWORTH INVESTMENT CORPORATION.10 04 62 31 01 74 LES ENTREPRISES ANVERS INC.09 07 63 31 01 74 LES ENTREPRISES MONVAL INC.09 08 66 31 01 74 MON VAL ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES POULIN INC.01 08 63 31 01 74 POULIN ENTERPRISES INC.E.T.TELECOMMUNICATIONS INC.15 05 64 31 01 74 FOUR SQUARE INVESTMENTS INC.11 06 65 31 01 74 HI-QUALITY CONSTRUCTION INC.25 05 60 31 01 74 LES IMMEUBLES BOUCHERVILLE INC.14 05 58 31 01 74 LAITERIE DOR VAL INCORPOREE.07 02 57 31 01 74 DORVAL DAIRY INCORPORATED MONTREAL WEST LIFT TRUCK SERVICE LTD.22 11 72 31 01 74 SERVICE DE CHARRIOTS-ELEVATEURS DE L'OUEST DE MONTREAL LTEE MORTON REALTIES INC.15 11 46 31 01 74 NORTH SHORE INDUSTRIES LTD.11 06 69 31 01 74 PALMER HAT MFG.CO.07 06 60 31 01 74 PANMAURIE INC.26 03 68 31 01 74 PUBLICATIONS PETIT JOURNAL LTEE.21 04 64 31 01 74 RACTCOT & FILS INC.19 10 01 31 01 74 ST.LEONARD CONSTRUCTION LTD.17 09 65 31 01 74 THE SCOTTISH TRUST COMPANY.14 04 08 11 02 74 SECURITIES ACCEPTANCE CORPORATION.25 02 37 31 01 74 TROIS-RIVIERES CHEVROLET (1969) LIMITEE.02 09 69 31 01 74 THREE RIVERS CHEVROLET (1969) LIMITED 1274 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 197/,.Vol.IPG, ,Vo.6_ UNION PEN & PENCIL LTD.09 12 66 14 12 73 VICTORIA STYLE SHOPPE INC.31 08 61 31 01 74 WEL INDUSTRIES LTD.26 05 69 31 01 74 Le directeur du service des compagnies, 55834-0 Pierre Desjardins.55834-0 Changement de nom \u2014 Loi du Change of name \u2014 Act Demandes Applications Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Dorina Brassard Avis est par les présentes donné que Dorina Brassard, résidant au 68 St-,Ioseph ouest, Chicoutimi, district de Chicoutimi, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret pour changer son nom à Lise Brassard.Ce changement n'affectera aucune autre personne que la requérante elle-même.Chicoutimi.le 28 décembre 1973.Les avocats de la requérante.55807-5-2-o Roy, Vaillancourt & Associés.Yousif Saleem Shukur Avis est donné que Yousif Saleem Shukur demeurant à 3333 rue Jean Talon ouest, app.309.Montréal, adresse une requête au ministre de la justice afin d'obtenir un décret pour changer son nom en celui de Joe Salim Shuker.Montréal, le 12 janvier 1974.Le requérant, 55808-5-2-o Yousif Saleem Shukur.Joseph Georges Claude Paul André Lipman Avis est donné par la présente que Joseph Georges Claude Paul André Lipman, artiste, 1191 rue Hope, Montréal, Québec, fera application au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom à Paul John Daniel André.Montréal, le 29 janvier 1974.Les procureurs du requérant, 55879-6-2-0 Blumer & Mass.Sam Solomon Lerer Avis est par les présentes donné que Sam Solomon Lerer présentera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour l'adoption d'un ordre de changement de son nom de famille à Larry pour le bénéfice aussi de sa femme Viola Rossy tous résidant à 306 Leacross Avenue, Town of Mount Royal, Québec.Montréal, le 25 janvier 1974.Les procureurs du requérant, 55880-6-2-o Roseniiek & Maciilovitch.Dorina Brassard Notice is hereby given that Dorina Brassard residing at 68 \\V.St-Joseph Street.Chicoutimi.District of Chicoutimi, will petition the Lieutenant-Governor in Council for permission to change his name to Lise Brassard.This change will not affect any person else than the applicant.Chicoutimi, December 28th, 1973.Roy, Vaillancourt & Associés, 55807-5-2-o Attorneys for Applicant.Yousif Saleem Shukur Notice is given that Yousif Saleem Shukur residing at 3333 Jean Talon St.West, Apt.309, Montreal, is applying to the Minister of Justice for an order changing his name to Joe Salim Shuker.Montreal, January 12.1974.Yousif Saleem Shukur, 55808-5-2-o The applicant, Joseph Georges Claude Paul André Lipman Notice is hereby given that Joseph Georges Claude Paul André Lipman, artist, 1191 Hope Street, Montreal, Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Paul John Daniel André.Montreal.January 29th, 1974.Blumer & Mass, 55879-6-2-0 Attorneys for Aplicant.Sam Solomon Lerer Notice is hereby given that Sam Solomon Lerer shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his surname to Larry, to benefit as well his wife Viola Rossy all residing at 306 Leacross Avenue, Town of Mount Royal, Québec.Montreal, January 25th, 1974.Roseniiek & Maciilovitch, 55880-6-2-o Attorneys for Applicant.Incorporation Dissolution Nom / Xame Date Date GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9 février 1974, 106' année, n° 6 1275 Jaroslav Chyzyj Avis est donné par les présentes que Jaroslaw Chyzyj, domicilié et résidant au 8082 avenue Stuart, en la ville de Montréal, district de Montréal, présentera au ministre de la justice du Québec conformément à la Loi du Changement de Nom (13-14 Eliz.II.c.77.tel qu'amendée) une requête afin que son nom soit changé en celui de Jerry Chase.Montréal, le 31 décembre, 1973.Les notaires du requérant.55791-5-2-0 WlCKHAM.WlCKHAM & LlssIER.Jaroslaw Chyzyj Notice is hereby given that Jaroslaw Chyzyj, domiciled and residing at 8082 Stuart Avenue in the City and District of Montreal will apply to the Minister of Justice of Québec under the Change of Name Act (13-14 Eliz.II, c.77, as amended) for an order changing his name to Jerry Chase.Montreal, December 31st.1973.WlCKHAM, WlCKHAM & lussier.55791 -5-2-0 Notaries for the Applicant, Omylian John Zadorozny Avis est par les présentes donné que Omylian John Zadorozny, surintendant, domicilié et résidant au 14 rue John White à Kirkland, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant ses nom et prénoms en ceux de John Drake.Ce changement de nom bénéficiera aussi à son épouse, née Virpi Salminen, ainsi qu'à ses enfants, Julie Stephanie Zadorozny et Jimmie Robert Zadorozny, tous domiciliés et résidant à la même adresse.Montréal, ce 22 janvier 1974.Le procureur du requérant, 55810-5-2-o Jean Piehhe Semeniuk.Omylian John Zadorozny Xotice is hereby given that Omylian John Zadorozny, supervisor, residing and domiciled at 14 John White Street, Kirkland, district of Montreal, will petition the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his names and surname to John Drake.This change of name shall benefit his wife, born Virpi Salminen, and his children.Julie Stephanie Zadorozny and Jimmie Robert Zadorozny, all domiciled and residing at the same address.Montreal, January 22nd 1974.Jean Pierre Semeniuk, 55810-5-2-o Attorney for the petitioner.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Change of name \u2014 Act Granted Edward Assh Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 125 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Israel Assh en celui de Edward Assh.Québec-le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, ch.Maurice Assh Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 126 du l6 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Moses Assh en celui de Maurice Assh.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, c.b.Heather Abrams Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 127 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Heather Abramovitch en celui de Heather Abrams.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normani>.Cit.Edward Assh It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Israel Assh to that of Edward Assh by order number 125, dated January 16, 1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c.55877 Deputy Minister of Justice.Maurice Assh It has pleased the Lieutenant Governor in Council to change the name of Moses Assh to that of Maurice Assh by order number 126, dated January 16.1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c.55877 Deputy Minister of Justice.Heather Abrams It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Heather Abramovitch to that of Heather Abrams by order number 127, dated January 16, 1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice. 1270 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.February 9.1974.Vol.106, No.6 Jean .Marie Berlinguette Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 128 du 16 janvier 1074 d'effectuer le changement de nom de Marie Anna Emma Berlinguette en celui de Jean Marie Berlinguette.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55S77-0 Robert Normand, ch.Jean Marie Berlinguette It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of -Marie Anna Emma Berlinguette to that of -lean Marie Berlinguette l>v order number 128.dated January 16.1974.Québec.January 28.1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of .1 uslice.Keith Clayton Bodaly Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 129 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Keith Clayton Platt en celui île Keith Clayton Bodaly.Québec, le 28 janvier 1974.Le ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, ch.Keith Clayton Bodaly It lias pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Keith Clayton Platt to that of Keith Clayton Bodaly by order number 129, dated January 16, ,974.Québec.January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy M inister of Justice.Andre Cantin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 130 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph Isidore Andréa Cantin on celui de André Cantin.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, ch.André Cantin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Isidore Andrea ( antin to that of Andre Cantin by order number 130.dated January 16, 1974.Québec, January 28.1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy M inister of Justice.-Marie Lucctte Emca Charest Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 131 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Marie I.ucctte Aiméa Cliarcltc en celui de Marie Lucette Eméa Charest.Québec, le 28 janvier 1974./.e sous-ministre de la justice.53877-0 Robert Normand, cit.Marie Lucette Emca Charest It has pleaseil the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Lucette Aiméa Cliarette to that of Marie Lucette Eméa Charest by order number 131, dated January 16, 1974.Québec.January 28.1974.Robert Normand, q.c, 558,7 Deputy Minister of Justice.Joseph Jules Marcel Conroy Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 132 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph Jules Marcel Dcslau-riers en celui de Joseph Jules Marcel Conroy.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-u Robert Normand, ch.Earl Scott Davidson Il a plu au lieutenant gouverneur en conseil, par le décret numéro 133 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Earlc \\\\ ilham Scott en celui de Earl Scott Davidson.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-o Robert Normand, ch.Joseph Jules .Marcel Conroy It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Jules Marcel Dcslau-riers to that of Joseph Jules Marcel Conroy by order number 132, dated January 16.1974.Québec.January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.Earl Scott Davidson It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Bade William Scott to that of Earl Scott Davidson by order number 133, dated January 16, 1974.Quebec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 février 1974.106* aimée, n° 6 1277 Michèle Monique De Cicco II a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 134 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Michèle Monique Jolly en celui de Michèle Monique De Cicco.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, c.r.Michèle Monique De Cicco It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Michèle Monique Jolly to that of Michèle Monique De Cicco by order number 134, dated January 16, 1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.James Perry Desmarais Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 135 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de James Perry Garayt en celui de James Perry Desmarais.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, c.r.James Perry Desmarais It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of James Perry Garayt to that of James Perry Desmarais by order number 135.dated January 16, 1974.Québec.January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy minister of Justice.Valerie Carole Devlin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 136 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Valerie Carol Spraggon en celui de Valerie Carole Devlin.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice.55877-0 Robert Normand, ch.Valerie Carole Devlin It has pleased the Lieutenant Governor in Council to change the name of Valerie Carol Spraggon to that of Valerie Carole Devlin by order number 136.dated January 16, 1974.Quebec, January 28.1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.Melvyn Abraham Dobriu Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 137 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Abraham Dobrinsky en celui de Melvyn Abraham Dobrin.Québec, le 28 janvier 1974.Ije sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, ch.Melvyn Abraham Dobrin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Abraham Dobrinsky to that of Melvyn Abraham Dobrin by order number 137, dated January 16, 1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c.55877 Deputy Minister of Justice.Mounir Martin Farah Il a plu au lieutenant gouverneur en conseil, par le décret numéro 138 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Mounir Farah en celui «le Mounir Martin Farah.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice.55877-0 Robert Normand, c.r.Mounir Martin Farah It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Mounir Farah to that of Mounir Martin Farah bv order number 138, dated January 16, 1974.Québec.January 28.1974.Robert Normand, q.c.55877 Deputy Minister of Justice.Anne Morrinc Garner Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 139 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Anne Morrine Smith en celui de Anne Morrine Garner.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de ta justice.55877-0 Robert Normand, ch.Anne Morrine Garner It has pleased the Lieutenant-Governor in Council lo change the name of Anne Morrine Smith to that of Anne Morrine Garner by order number 139, dated January 16, 1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice. 1278 QUÉBEC OFF ICI M, GAZETTE.February 9, 1974, Vol 106, No.6 Henri Alexander Gordon II a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 140 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Henry Gedziorowski en celui de Henry Alexander Gordon.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, c.r.Henri Alexander Gordoii It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Henry Gedziorowski to that of Henri Alexander Gordon by order number 140, dated .January 16, 1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.René Kallis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 141 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph Hector Antonio René Chakallis en celui île René Kallis.Québec.le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, c.r.René Kallis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Hector Antonio René Chakallis to that of René Kallis by order number 141, dated January 16, 1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Juslice.Constant Kallis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 142 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph Adrien Constant Y von Tshakallis en celui de Constant Kallis.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice.55877-0 Robert Normand, c.r.Constant Kallis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Adrien Constant Yvon Tshakallis to that of Constant Kallis by order number 142, dated January 16, 1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.Pierre Kallis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 143 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph-Pierre-René-Maurice Tshakallis en celui de Pierre Kallis.Québec.le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice.55877-0 Robert Normand, c.r.Pierre Kallis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph-Pierre-René-Maurice Tshakallis to that of Pierre Kallis by order number 143, dated January 16, 1974.Québec.January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.Ernie King Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 144 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph Gédéon Ernest Yerrot en celui de Ernie King.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice.55877-d Robert Normand, c.r.Ernie King It has pleased the Licutenant-Ciox'ernor in Council to change the name of Joseph Gédéon Ernest Verret to that of Ernie King by order number 144, dated January 16, 1974.Québec.January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.Gin Min Lee Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 145 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Gin Min Tom en celui de Gin Min bec.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, ch.Gin Min Lee It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Gin Min Tom to that of Gin Min l.ee by order number 145, dated January 16, 1974.Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c 55877 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 février 1974.106' année.;i° 6 1279 Thérèse Maher Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 146 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Marie Josephine Marguerite Dupuis en celui de Thérèse Maher.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice.55877-0 Robert Normand, c.k.-Monic Major Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 147 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Marie Monique Lise Gisèle Major en celui de Monic Major.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, c.r.Rachid Maurice Mawad Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 148 du l6 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Rachid (Maurice) Mouawad en celui de Rachid Maurice Mawad.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice.55877 o Roueiit Normand, ch.John Naumcnko Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 149 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Jan Stanislaw Stepicn en celui de John Naumcnko.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice.55877-0 Robert Normand, c.r.Nelsonc Rivard Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 150 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Marie-Francine-Nelson Lafond en celui de Nelsone Rivard.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, c.r.Joseph Jacques Vaillancourt Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 151 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph Jacques Forget en celui de Joseph Jacques Vaillancourt.Québec, le 28 janvier 1974.Le sous-ministre de la justice.55877-0 Robert Normand, cit.Frank Wareing Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 152 du 16 janvier 1974 d'effectuer le changement de nom de Frank Clegg en celui de Frank Wareing.Québec, le 28 janvier 1974.Ij\u20ac sous-ministre de la justice, 55877-0 Robert Normand, c.r.Thérèse Maher It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Josephine Marguerite Dupuis to that of Thérèse Maher by order number 146, dated January 16, 1974 Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.Monic Major It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Monique Lise Gisèle Major to that of Monic Major by order number 147, dated January 16.1974.Québec, January 28.1974.Robert Normand, q.c.55877 Deputy Minister of Justice.Rachid Maurice Mawad It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Rachid (Maurice) Mouawatl to that of Rachid Maurice Mawad by order number 148, ¦lated January 16.1974.Québec.January 28.1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.John Naumcnko It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Jan Stanislaw Stepien to that of John Naumcnko by order number 149, dated January 16.1974.Québec.January 28, 1974.Robert Normand, q.c.53877 Deputy Minister of Justice.Nelsone Rivard It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Maric-Francinc-Nelson Lafond to that of Nelsonc Rivan! by order number 150, dated January 16, 1974.Quebec.January 28, 1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.Joseph Jacques Vaillancourt It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Jacques Forget to that of Joseph Jacques Vaillancourt by order number 151.dated January 16, 1974.Québec, January 28.1974.Robert Normand, q.c, 55877 Deputy Minister of Justice.Frank Wareing It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Frank Clegg to that of Frank Wareing by order number 152.dated January 16, 1974, Québec, January 28, 1974.Robert Normand, q.c.55877 Deputy Minister of Justice. 1280 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9.197!,, Vol.106, Xo.6 Charte \u2014 Charter \u2014 demandes d'abandon de Applications for Surrender of ACME .MEAT PACKERS INC.Avis est donné que la compagnie « ACME MEAT PACKERS INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social et sa principale place d'affaires en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 10 janvier 1974.Les procureurs de la requérante.55862-0 Yanofsky Kahn Buull & Stkaubek.ASSOCIATION DE PROTECTION DES FORETS DU ST-MAURICE ST.MAURICE FOREST PROTECTIVE ASSOCIATION Prenez avis que la corporation « ASSOCIATION DE PROTECTION DES FORETS DU ST-MAURICE - ST.MAURICE FOREST PROTECTIVE ASSO-CIATION s constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Trois-Rivières.demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Trois-Rivières, le 24 janvier 1974.Les procureurs de la compagnie.55S63-o Lajoie, Gouin, Desailnieus & Lajoie.ACME MEAT PACKERS INC.Notice is hereby given that \"ACME MEAT PACKERS INC.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, January, 10, 1974.Yaxofsky, Kahn, Brull & Stkaubkr, 55862-o Attorneys for petitioner.ASSOCIATION DE PROTECTION DES FORETS DU ST-MAURICE ST.MAURICE FOREST PROTECTIVE ASSOCIATION Notice is hereby given that \"ASSOCIATION DE PROTECTION DES FORETS DU ST-MAURICE - ST.MAURICE FOREST PROTECTIVE ASSOCIATION\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Trois-Rivières, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Trois-Rivières, January 24.1974.Lajoie, GoUiN, Desaulniehs & I,ajoie.55863-0 Attorneys for the Company.CENTRE DE DISTRIBUTIONS SOLEIL (C.D.S.) INC.Prenez avis que la compagnie « CENTRE DE DISTRIBUTIONS SOLEIL (C.D.S.) INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et Coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Me Giixes Coulombë.Ill rue King, Sherbrooke.55865-o CORPORATION D'HYPOTHEQUES FONCIERES, INC.Avis est par les présentes donné que « CORPORATION D'HYPOTHEQUES FONCIERES, INC.», corporation incorporée sous la Loi des compagnies et ayant son siège social à Oiitremont.province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province île Québec-la permission d'abandonner sa charte en vertu des dis.positions de la Loi des compagnies.Outremont, le S janvier 1974.La secrétaire, 55866-ci Juliette Tkempe.CENTRE DE DISTRIBUTIONS SOLEIL (C.D.S.) INC.Notice is given that \"CENTRE DE DISTRIBUTIONS SOLEIL (C.D.S.) INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Me Gilles Coulombe, Attorney for the Company.111 King Street, Sherbrooke.55865 CORPORATION D'HYPOTHEQUES FONCIERES, INC.Notice is hereby given that \"CORPORATION D'HYPOTHEQUES FONCIERES, INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Outremont, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Outremont, January 8, 1974.Juliette Tiiempe, 55866-o Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février J97i, 106' année, n° 6 1281 BELLEVUE HOUSING CORP.Avis est donné par les présentes que la compagnie «BELLEVUE HOUSING CORP.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte et l'annulation d'icelle à compter de la date qui sera fixée par lui.Montréal, le 18 janvier 1974.Le secrétaire, 55864 Michael Greenblatt, ch.BELLEVUE HOUSING CORP.Notice is hereby given that \"BELLEVUE HOUSING CORP.\", a corporation constituted under the Companies Act, and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for the acceptance of the surrender of its charter and its cancellation on and from a date to be fixed by him.Montreal, 18th January, 1974.Michael Greenblatt, q.c, 55864-0 Secretary.KAYAR REALTY CORP.Avis est donné que la compagnie « KAYAR REALTY CORP.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social et sa principale place d'affaires en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 15 janvier 1974.Les procureurs de la requérante, 55867-0 Yanofsky, Kahn, Brull & Stauber.KAYAR REALTY CORP.Notice is hereby given that \"KAYAR REALTY CORP.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city and district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, January 15, 1974.Yanofsky, Kahn, Brull & Strauber, 55867-0 Attorneys for Petitioner.MONTREAL CUTTING CO.LIMITED Prenez avis que la compagnie « MONTREAL CUTTING CO.LIMITED » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, le 24 janvier 1974.Le secrétaire, 55868-0 Jean Delisle.MONTREAL CUTTING CO.LIMITED Notice is hereby given that \"MONTREAL CUTTING CO.LIMITED\" shall make application for leave to surrender its charter to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.Dated at Montreal, January 24, 1974.Jean Delisle, 55868-0 Secretary.LES SPECIALITES MONTROSE INC.MONTROSE SPECIALITIES INC.Prenez avis que la compagnie « LES SPECIALITES MONTROSE INC.\u2014 MONTROSE SPECIALITIES INC.' demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 24 janvier 1974.Les procureurs de la compagnie.Malo, Wilhelmy, Àquin, Croteau, Larue, Cyr, 55869-0 Boudreault & Latulippe.LES SPECIALITES MONTROSE INC.MONTROSE SPECIALITIES INC.Notice is given that \"LES SPECIALITES MONT-ROSE INC.\u2014MONTROSE SPECIALITIES INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, January 24, 1974.Malo, Wilhelmy, Aquin, Croteau, Larue, Cyr, Boudreault & Latulippe, 55869 Attorneys for the Company.SELIGMAN & LATZ BOULEVARD SALON, LTD.Prenez avis que la compagnie « SELIGMAN & LATZ BOULEVARD SALON, LTD.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 22 janvier 1974.Les procureurs de la requérante.55874-0 Lafleur & Brown.SELIGMAN & LATZ BOULEVARD SALON, LTD.Take notice that the company \"SELIGMAN & LATZ BOULEVARD SALON, LTD\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, January 22, 1974.Lafleur & Brown, 55874-0 Attorneys for Petitioner. 1282 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, No.6 VOYAGES OCEANAIR INC.OCEANAIR TRAVEL INC.Avis est par les présentes donné que « VOYAGES OCEANAIR INC.\u2014OCEANAIR TRAVEL INC.», ayant sa principale place d'affaires en la ville de Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner ses lettres patentes, à partir de la date qu'il lui plaira de déterminer.Montréal, le 22 janvier 1974.La secretaire.55870-o Mme J.T.Matthews.VOYAGES OCEANAIR INC.OCEANAIR TRAVEL INC.Notice is hereby given that \"VOYAGES OCEANAIR INC.\u2014OCEANAIR TRAVEL INC.\", having its head office in the City of Montreal, District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its letters patent, from and after the date which he will be pleased to determine.Montreal, January 24th, 1974.Mrs.J.T.Matthews, 55870-o Secretary.UNIVERSAL INVESTMENT LTD.LE PLACEMENT UNIVERSEL LTEE Prenez avis que la compagnie « UNIVERSAL INVESTMENT LTD.\u2014 LE PLACEMENT UNIVERSEL LTEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Québec, ce 4 décembre 1973.Le procureur de la compagnie.Andke Duval, notaire.(\"entre Bois-Fontaine, 880 chemin Ste-Foy.Que.G IS 2L1 55871 -o UNIVERSAL INVESTMENT LTD.LE PLACEMENT UNIVERSEL LTEE Notice is given that \"UNIVERSAL INVESTMENT LTD.\u2014LE PLACEMENT UNIVERSEL LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, December 4, 1973.André Duval, Notary, Attorney for the Company.Centre Bois-Fontaine, 880 chemin Ste-Foy, Que.G IS 2L1 55871 rado investments limited LES PLACEMENTS RADO LIMITEE Prenez avis que la compagnie « RADO INVESTMENTS LIMITED \u2014LES PLACEMENTS RADO LIMITEE » une compagnie dûment incorporée, ayant son siège social à Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, selon les dispositions de la Loi des compagnies Daté à Montréal, Québec, ce 23e jour de janvier 1974.Le président.55872-0 Peter M.McEntvhe.RADO INVESTMENTS LIMITED LES PLACEMENTS RADO LIMITEE Notice is herebv given that \"RADO INVESTMENTS LIMITED \u2014LES PLACEMENTS RADO LIMITEE\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives in the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, Québec, this 23rd day of January 1974.Peter M.McEntyre, 55872-0 President.SEDAP INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « SEDAP INC.», corporation légalement constituée, ayant une principale place d'affaires dans les cité et district de Montréal, province de Québec, et constituée en vertu de la Loi des compagnies s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Ix>i îles compagnies.Montréal, le 21 janvier 1974.Les procureurs de la compagnie.Gervais, Tannage, Bélanger, Gauthier, Bouchard 55873-u & Dksaulniers.SEDAP INC.Notice is hereby given that \"SEDAP INC.\", a corporation incorporated under Companies Act, and having its head office in the city and district of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter, according to provisions of the Companies Act.Montreal, January 21, 1974.Gervais, Tannage, Bélanger, Gauthier, Bouchard & Desaulniers, 55873-u Attorneys for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' aimée, n° 6 1283 Divers Compagnies Miscellaneous Companies ASSOCIATION DES ETUDIANTS MBA DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES INC.« L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS MBA DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 9.Le secrétaire.Robert Vinet.55843-0 1899-71 ASSOCIATION DES ETUDIANTS MBA DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES INC.Notice is given that \"L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS MBA DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 9.Robert Vinet, Secretary.55843 1899-71 GILLES BLONDEAU ET COMPAGNIE La compagnie « GILLES BLONDEAU ET COMPAGNIE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 7.Le secrétaire.Claudette H.Blondeau.55844 3392-69 GILLES BLONDEAU ET COMPAGNIE Notice is given that \"GILLES BLONDEAU ET COMPAGNIE\" has increased the numbre of its directors from 3 to 7.Claudette H.Blondeau, Secretary.55844 3392-69 LES ENTREPRISES GADUPLO INC.La compagnie « LES ENTREPRISES GADUPLO INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire.Marcel Gacxox.55845-0 733945 LES ENTREPRISES GADUPLO INC.Notice is given that \"LES ENTREPRISES GADUPLO INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.Marcel Gagnon, Secretary.55845 733945 MANNA LIMITEE La compagnie « MANNA LIMITEE ' donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire.Antoine Diceppe.55846-o 12811-60 M ANNA LIMITEE Notice is given that \"MANNA LIMITEE\" has reduced the number of its directors from 5 to 3.55846 Antoine Duceppe, Secretary.12811-60 THE MONTREAL JOCKEY CLUB La compagnie «THE MONTREAL JOCKEY CLUB » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 24 à 21.Le secrétaire.Jérôme E.Paradis.55847-0 4121-09 THE MONTREAL JOCKEY CLUB Notice is given that \"THE MONTREAL JOCKEY CLUB\" has changed the number of its directors from 24 to 21.Jérôme E.Paradis, Secretary.55847 4121-09 VICTORIAVILLE SPORTWEAR INC.La compagnie « VICTORIAVILLE SPORTSWEAR INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire-trésorier.Freda Gottlieb.55861-0 11067-57 VICTORIAVILLE SPORTWEAR INC.Notice is given that \"VICTORIAVILLE SPORTSWEAR INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Freda Gottlieb.Secretary-Treasu rer.5586 l-o 11067-57 1284 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, No.6 Sièges sociaux Head Offices B N SHOE TRIMMINGS & NOVELTIES LTD.B N SHOE TRIMMINGS & NOVELTIES LTD.La compagnie « B.N.SHOE TRIMMINGS & NOVELTIES LTD.\u2022 donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 550, rue du Havre, Montréal, au numéro 460, rue Sainte-Catherine ouest, suite 113.Montréal.Le secrétaire.55848 Nathan Baum.Notice is given that \"B.N.SHOE TRIMMINGS & NOVELTIES LTD.\" has moved its head office from 550 du Havre Street, Montreal, to 460, St.Catherine Street West, Suite 113, Montreal.55848-0 Nathan Baum, Secretary.CENTRE DE PRODUCTIVITE DES TRANSPORTS DU QUEBEC Avis est donné, par les présentes, que la corporation « CENTRE DE PRODUCTIVITE DES TRANSPORT DU QUÉBEC », constituée en corporation en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 27 mars 1973 et ayant son siège social en la ville de Montréal, district judiciaire de Montréal, a établi son bureau principal à 1259, rue Berri, suite 400.à Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 21e jour de janvier 1974.Les procureurs de la corporation.Desjardins, Duciiarme.Desjardins, Tei.lier, Zigbt & Michaud, 55849-u par: jacques Paqiin.CENTRE DE PRODUCTIVITE DES TRANSPORTS DU QUEBEC Notice is hereby given that the Corporation \"CENTRE DE PRODUCTIVITÉ DES TRANSPORT DU QUÉBEC\", incorporated under the provisions of Part III of the Companies Act by letters patent dated March 27, 1973 and having its head office in the city of Montreal, district of Montreal, has established its office at 1259, Berri Street, Room 400, Montreal.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the Corporation as being its head office.Given at Montreal, this 21st day of January 1974.Desjardins, Duciiarme, Desjardins, Tellier, Zigby & Michaud, Attorneys for the Corporation, 55S49-0 per: Jacques Paquin.OMER GINGRAS & FILS INC.La compagnie « OMER GRINGRAS & FILS INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2491, Chemin Gomin, Sainte-Foy, au numéro 2305.rue Masson.Sillery.Le secrétaire.Maurice Boulanger.55850-o 9963-51 LES ECURIES V.I.P.INC.Avis est donné par les présentes que la compagnie « LES ÉCURIES V.I.P.INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 octobre 1973 a son siège social au 506.Des Oblats, à Québec.Le président, 55851-0 Gaston Poulin.LA SOCIETE D'ENTRETIEN DU QUEBEC INC.« LA SOCIETE D'ENTRETIEN DU QUEBEC INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 15.rue Maple.Kénogami, au numéro 28-A.rue Upper Edison, Saint-Lambert.La secrétaire.Michelle Soucy Bilodeau.55860-o 5380-67 OMER GINGRAS & FILS INC.Notice is given that \"OMER GINGRAS & FILS INC.\" has transferred its head office from 2491 Gomin Road.Ste.Foy.to 2305 Masson Street, Sillery.Maurice Boulanger, Secretary.55850 9963-51 V.I.P.STABLES INC.Notice is given that \"V.I.P.STABLES INC.\", incorporated by letters patent dated October 11, 1973, has established its head office at 506 Des Oblats, Québec.President, 55851-0 Gaston Poulin.LA SOCIETE D'ENTRETIEN DU QUEBEC INC.Notice is given that \"LA SOCIETE D'ENTRETIEN DU QUEBEC INC.\" has transferred its head office from 15 Maple Street, Kénogami, to 28-A Upper Edison Street, St.Lambert.Michelle Soucy Bilodeau, Secretary.55860 5380-67 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 /écrier 1974, 106' année, n° G 1285 LOITEL ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES LOITEL INC.Avis est donné que la compagnie « LOITEL ENTERPRISES INC.\u2014 LES ENTREPRISES LOI-TEL INC.» constituée en corporation par lettres patentes datées du 22 mars 1973 a son siège social dans le district de Montréal, au 5830 Place Decclles, app.3, à Montréal.Le secrétaire, 55852-0 Claude Dufresne.LOITEL ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES LOITEL INC.Notice is given that \"LOITEL ENTERPRISES INC.\u2014 LES ENTREPRISES LOITEL INC.\" incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent issued on March 22nd, 1973, has its head office in the District of Montreal, at 5830 Place Decel-les, Apt.3, Montreal.Claude Dufresne, 55852-0 Secretary.M.A.T.VOYAGES INC.La compagnie « M.A.T.VOYAGES INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 85, rue Holton, Westmount, au numéro 3465, Côte-des-Neiges.Montréal.Le seciétaire.Marcel Piché.55853 M.A.T.VOYAGES INC.Notice is given that \"M.A.T.VOYAGES INC.\" has transferred its head office from 85 Holton Street, West-mount, to 3465 Côte-des-Neiges, Montreal.1503-69 55853-0 Marcel Piché, Secretary.1503-69 P.S.I.MANUFACTURING LIMITED Avis est donné que la compagnie « P.S.I.MANUFACTURING LIMITED » constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies en date du vingt-huitième jour de mai.1971, a trans- Krté son siège social de 780, rue Bancroft, Pointe-aire, Québec, à 91 boulevard Hymus, Pointe-Claire, Québec.Montréal, le 23 octobre.1973.(Sceau) 7-e secrétaire.55854-0 R.W.McKimm.P.S.I.MANUFACTURING LIMITED Notice is hereby given that \"P.S.I.MANUFACTURING LIMITED\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated the twenty-eighth day of May, 1971 has moved its head office from 780 Bancroft Street, Pointe-Claire, Québec, to 91 Hymus Boulevard, Pointe-Claire, Quebec.Montreal, October 23, 1973.(Seal) R.W.McKim.m 55854-0 Secretary.L.V PEPINIERE PARE INC.PARE NURSERY INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « LA PEPINIERE PARE INC.\u2014 PARE NURSERY INC.», constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres patentes en date du 10 décembre.1973 et ayant son siège social à Outremont, district judiciaire de Montréal, a établi son bureau principal au numéro 2090 ouest, Broadway, à Montreal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 16e jour de janvier.1974.Le président.55855-0 Charles Paré.LA PEPINIERE PARE INC.PARE NURSERY INC.Notice is hereby given that \"LA PEPINIERE PARE INC.\u2014 PARE NURSERY INC.\" is incorporated by letters patent dated December 10, 1973 issued pursuant to the provisions of Part I of the Companies Act of the Province of Québec, and having its head office in the City of Montreal, has established its head office at 2090 West Broadway, Outremont, Montreal, Québec.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Given at Montreal, this 16th day of January, 1974.Charles Pare, 55855-0 President.VICTORIAVILLE SPORTSWEAR INC.La compagnie « VICTORIAVILLE SPORTSWEAR INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2, rue Laurier, Victoriaville, au numéro 5776.avenue Mapleridge, Côte-Saint-Luc.Le secrétaire, Freda Gottlieb.55861-o 11067-57 VICTORIAVILLE SPORTSWEAR INC.Notice is given that \"VICTORIAVILLE SPORTS-WEAR INC.\" has transferred its head office from 2 Laurier Street, Victoriaville, to 5776 Mapleridge Avenue, Côte-Saint-Luc.Freda Gottlieb, Secretary.55861-o 11067-57 I2M'i QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 9.1974.Vol.106.So.6 PARELCO INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « PARELCO INC.» constituée en corporation dans la province de Québec, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes portant la date du 19 septembre 1973, et ayant son siège social en la ville de Montréal, a établi son bureau principal au 385, avenue Simcoe, à Montréal, dit district.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal, ce 22e jour de janvier 1974.(Sceau) Le président', 55856-0 Louis Paul Smith.PARELCO INC.Notice is hereby given that the company \"PARELCO INC.\" incorporated in the Province of Québec, under Part I of the Companies Act, by letters patent bearing the date of September 19, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 385 Simcoe Avenue, in Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Montreal, this 22nd day of January 1974.(Seal) Louis Paul Smith, .-,.-,s.\",fi-i> President.SMOOD PRODUCTIONS INC.LES PRODUCTIONS SMOOD INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « SMOOD PRODUCTIONS INC.\u2014 LES PRODUCTIONS SMOOD INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 1er octobre 1973, a établi son siège social au 4591, avenue Hingston à N.D.G., district de Montréal.Montréal, ce 22e jour de janvier 1974.Le secrétaire, 55857 Robert Vineberg.SMOOD PRODUCTIONS INC.LES PRODUCTIONS SMOOD INC.Notice is hereby given that \"SMOOD PRODUCTIONS INC.\u2014 LES PRODUCTIONS SMOOD INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated October 1st, 1973 has established its head office at 4591 Hingston Avenue in N.D.C., District of Montreal.Montreal, this 22nd day of January, 1974.Robert Vineberg, 55857-0 Secretary.QUEBEC OILS & FATS BROKERS LTD.La compagnie « QUEBEC OILS & FATS BRO-ERS LTD.» constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec, le 3 mars, 1971, et ayant son siège social au 360 ouest, rue St-Jacques, en la ville de Montréal, donne avis qu'elle l'a transporté son bureau à a/s M.David Haimovitch, c.a., 1253 Mc-Gill College, Chambre 404, en la ville de Montréal, district de Montréal.A compter de la date de cet avis ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 14e jour de novembre, 1973.La secrétaire, 55858-0 Cabrielle Schnabel.SHAWICON INC.Avis est donné que « SHAWICON INC.».compagnie constituée en corporation par lettres patentes, le 19 octobre 1973 et ayant son bureau principal à Shawinigan, a établi son bureau au numéro 3652, 34e Avenue.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Shawinigan, ce 22 janvier 1974.Les procureurs de la compagnie, 55859-0 Gihoiahu.Bkaumier & Associés.QUEBEC OILS & FATS BROKERS LTD.Notice is hereby given that \"QUEBEC OILS & FATS BROKERS LTD.\" incorporated by Part I of the Companies Act on the 3rd day of March, 1971, and having its head office in the City of Montreal, Québec, where its office was situated up to to-day at 360 St.James Street West.Montreal, Québec has moved it to c/o Mr.David Haimovitch, c.a., 1253 McGill College, Room 404, Montreal, Québec.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head ffice of the Company.Dated at Montreal, this 14th day of November, 1973.Uabrielle Schnabel, 55858-0 Secretary.SHAWICON INC.Notice is given that \"SHAWICON INC.\", Company incorporated by letters patent, on the October 19th, 1973 and having its head office in Shawinigan has established its office at 3652, 34e Avenue.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.(iiven at Shawinigan.this January 22, 1974.GlROUARD.beaumier & associates 55859-o Attorneys for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 197/,, 106' année, «° G 1287 Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission a proprio motn 5 (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion \" proprio motu ¦>.a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes, \u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées.i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014¦ Other proceedings.HI \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application, (a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).lb) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Commission des transports Québec Transport du Québec Commission 1288 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, No.6 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.* Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of applications : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Rôle M-992 M-D-6 TF BT-1 bureau des tarifs du quebec inc., Edifice Girardin, suite 400, 1259, rue Bern, Montréal 132, P.Q.Rôle M-993 M-d-l-tf OC-8 association provinciale des proprietaires de camions citernes, 4868 - 6ième Avenue, Rosemont, P.Que.Demande de fixation de taux : Modification: Augmentation des taux de classe et d'espèces et des frais minima publies au Tarif No 120, entre les localités situées dans la province de Québec et les localités situées dans les provinces du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile du Prince-Edouard et Terreneuve: a) taux de classe et d'espèces: vers l'est 4 % vers l'ouest 3 % b) frais minima S 0.50 le tout conformément à l'article 2.64 et suivants de la section 3 du Règlement No 2, concernant la concurrence tarifaire avec un transporteur ferroviaire.Application for fixiDg of rates: Modification: Increase of class and cash rates and of minimum charges published in Tariff No.120, between any point located in the Province of Québec and any point located in the Provinces of New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, and Newfoundland; (a) Class and cash rates: Eastbound 4 % Westbound 4 % (i>) Minimum charges $0.60 the whole pursuant to sections 2.64 and following of division 3 of Regulation No.2, respecting tariff competition with railway carriers.A.P.C.C.No 100 Milles Miles Tarif 100 Tariff 100 Produits légers Light Products Page 11 Amdt.No 5 Produits lourds Heavy Products \t\tMin.7000\t\t\tMin, 6000 21 \u2014\t25\tS\t0\t0081\tS 0.0091 26 \u2014\t30\tS\t0\t0084\tt 0.0095 31 \u2014\t36\t?\t0\t0088\tS 0.0102 36 \u2014\t40\t*\t0\t0094\t9 0.0107 41 \u2014\t45\t9\t0\t0099\t9 0.0116 46 \u2014\t50\t9\t0\t0111\t9 0.0126 51 \u2014.\t55\t%\t0\t.0119\tS 0.0136 56 \u2014\t60\t9\t0\t0126\tS 0.0145 61 \u2014\t65\tS\t0\t0131\t9 0.0149 66 \u2014\t711\t*\t0\t.0137\t$ 0.0155 71 \u2014\t76\tS\t0\t0145\tS 0.0162 76 \u2014\t80\t1\t0\t0154\tS 0.0175 81 \u2014\t85\t9\t0\t0161\t9 0.0186 86 \u2014\t90\t9\t0\t.0173\tS 0.0197 91 \u2014\t95\tt\t0\t0180\t9 0.0204 96 \u2014\t100\t?\tu\t0190\tS 0.0216 101 \u2014\t105\tI\to\t0198\tS 0.0225 106\t110\t*\t0\t0208\t$ 0.0235 111 \u2014\t115\t9\t0\t0218\t9 0.0247 116 \u2014\t120\t(\t0\t0226\tS 0.0258 121 \u2014\t125\t\t0\t0237\t9 0.0268 Zone 1 et 2: $0.0001 de plus le gallon que le tarif déposé le 15 novembre 1973.Region 1 and 2: tO.0001 increase per galion over the tariff filed on November 15, 1973. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, n\" 6 1289 Rôle M-994 1256-V D-l a & f baillarceon express inc., 5600, Ferrier, Montréal 307, Que.Rôle M-995 23368-V D-l jean menard, 2258, De Melbourne, Chomedey Est, Ville Laval, Que.Modification de permis (droit additionnel): La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis l'autorisation suivante: La détentrice est autorisée à louer, a long terme (2 ans) de A.F.Baillargeon Truck & Trailer Rental Inc., permis No 587-DYV, dix (10) remorques dont la description apparaît au contrat de location déposé à la Commission.Nouvelle demande: La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant : Transport restreint-longue distance-rayon.De Laval.Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme à toutes les localités situées dans la province de Québec, et retour, pour le transport de maisons mobiles et roulottes de voyages, pour le compte de : LAVIGUEUR AUTOMOBILES INC.JET CAMPING INC.CITE PARC DE MAISONS MOBILES LTEE LES ROULOTTES CHAMPION LTEE CITE LAVAL CARAVANE LTEE PAVILLON DU CAMPEUR INC.CM.SPORT INC.G.M.CARAVAN INC.DENIS ROBERT INC.FOYER DU CADEAU INC.PLACE LONGCHAMP Conditions: Le permis du détenteur, de remorquer des unités mobiles avec des tracteurs dont il est propriétaire et qui sont enregistrés en son nom est subordonné à l'obtention annuelle d'une autorisation spéciale selon les conditions suivantes qui devront être observées strictement dans leur moindre détail: a) Le détenteur doit obtenir de la Commission des transports du Québec l'émission d'une plaque C.T.amovible sur paiement de la somme de $75.00; ladite plaque devant être apposée uniquement sur les unités mobiles, remorquées.b) Chaque unité mobile doit porter ladite plaque C.T./ amovible de la Commission des transports du Québec, qui doit être fixée jusqu'à la livraison a destination.c) Cette autorisation n'exempte pas le détenteur de ses obligations de payer au Ministère des finances de la province tous droits qui peuvent être requis en vertu de la Loi des Véhicules Automobiles.d) Une liste de tous les véhicules transportés en vertu de ce certificat durant chaque semaine d'opération doit être déposée, en duplicata, à la Commission des transports du Québec, au plus tard le vendredi de la semaine qui suit lesdites semaines d'opération.e) Ce registre doit être signé par le détenteur et doit comporter les informations suivantes: (le mot « équipement » employé ci-après signifie: roulottes de tout genre, neuves ou usagées.) 1.a) Date de l'expédition; b) Endroit d'où provient l'équipement; c) Endroit de destination de l'équipement.2.Le numéro de la plaque C.T.amovible fixée à l'équipement.Modification of permit (additional right) : The applicant requests the Commission to add following authorization to its permit: The permit-holder is authorized to lease, on a long-term basis (2 years), from A.F.Baillargeon Truck & Trailer Rental Inc., permit No.587-DYV, ten (10) trailers described in the lease filed with the Commis- New application: The applicant requests the Commission to authorize it to provide the following transportation service, according to the prescribed conditions: Restricted trucking-long distance-radius-From Laval, Ste.Thérèse and St.Jérôme to any point located in the Province of Québec, and return for the transportation of mobile homes and travel trailers, on behalf of: LAVIGUEUR AUTOMOBILES INC.JET CAMPING INC.CITE PARC DE MAISONS MOBILES LTEE LES ROULOTTES CHAMPION LTEE CITE LAVAL CARAVANE LTEE PAVILLON DU CAMPEUR INC.CM.SPORT INC.Q.M.CARAVAN INC.DENIS ROBERT INC.FOYER DU CADEAU INC.PLACE LONGCHAMP Conditions: The permit which authorizes its holder to haul mobile units with the tractors which he owns and which are registered in his name, shall be subject to the annual obtain-ment of a special authorization according to the following conditions, which shall be rigorously observed.(a) The permit-holder must obtain from the Québec Transport Commission a removable C.T.plate at the cost of $75; said plate shall be affixed to the mobile units to be hauled.(6) Said removable C.T.plate issued by the Québec Transport Commission shall be affixed to each mobile unit until its final delivery.(c) The present authorization does not exempt the permit^holder from paying to the Department of Finance all the fees which may be required pursuant to the Highway Code.(d) A list of all the vehicles transported according to this certificate, during each week of operation, must be filed in duplicate with the Québec Transport Commission not later than on Friday of the week following said weeks'operation.(\u2022 / Decision \"proprio motu\" of the Commission ASSOCATION DES PROPRIETAIRES D'AUTOBUS, Pour: TRANSPORT FONTAINE LTEE, No 316-A TRANSPORT FONTAINE LIMITEE GOSSELIN TRANSPORT LIMITEE AUTOBUS COTE ENRG.MAGNY TRANSPORT INC.PERRON TRANSPORT LIMITEE Jusqu'à décision finale de la Commission sur la demande de permis régulier./ Until final decision of the Commission on the application for a regular permit.Jusqu'à décision finale de la Commission.Until final decision by the Commission.Jusqu'à la décision finale de la Commission.Until final decision by the Commission.6 mois ou jusqu'à décision finale.6\" months or until final decision.Jusqu'à décision finale de la Commission.Until final decision by the Commission.2 mois / °.months 6 mois ou jusqu'à décision finale.le compte de Verrault Navigation Inc./ Special permit-From Les Machins to Montreal and return; for the transportation of goods, on behalf of Verrault Navigation Inc.Permis spécial / Special permit.a) De Montréal, Québec et Portneuf à Havre Saint-Pierre, pour le transport de marchandises générales consignées à Benoit Vigneault Limitée.(a) From Montreal, Québec and Portneuf to Hâvre-Saint-Pierre, for the transportation of general goods consigned to Benoit Vigneault Limitée.b) De Havre Saint-Pierre à Sept-Iles et Blanc-Sablon, avec droit de desservir les ports intermédiaires entre eux.(b) From Havre Saint-Pierre to Sept-Iles and Blanc-Sablon, with the right to provide service between the intermediate ports.c) De Havre Saint-Pierre aux ports sur le fleuve Saint-Laurent, entre Sept-Iles et Blanc-Sablon, pour le transport de marchandises générales appartenant à Benoit yigneault Limitée.(c) From Havre Saint-Pierre to ports on the St.Lawrence River, between Sept-lles and Blanc-Sablon.for the transportation of general goods belonging to Benoit Vigneaxdt Limitée.Permis spécial - La requérante est autorisée à mettre en vigueur les taux mentionnés dans la requête relativement aux voyages spéciaux ou à charte-partie / Special permit - The applicant is authorized to enforce the rates mentioned in the application regarding special or charter trips.Permis spécial - Autorise la requérante à mettre en vigueur à compter de la date de la présente la nouvelle tarification pour ses services: Québec - Buckland, Québec - Armagh / Special permit - Authorizing the applicant to apply, from the date of these presents, the new tariffs for its services between: Québec - Buckland, Québec -Armagh.Permis spécial - La détentrice est autorisée à louer un camion-tracteur Freight Liner 1974, modèle WFT 6364T, No de série HV078895 de I.A.C.Limitée, détentrice du permis 508DYV de la Commission / Special permit - The holder is authorized In lease a 1974 Freight Liner truck-tractor, WFT6364 T model, serial No.HV07889 from I.A.C.Limitée, holder of permit 608DYV from the Commission.Permis spécial - La requérante est autorisée à mettre en vigueur à compter du 23 janvier 1974 les tarifs soumis avec la requête relativement au service de Chicoutimi-St-Siméon / Special permit - The applicant is authorized to apply, from January 23,1974, the tariffs submitted with the application concerning the Chicoutimi-St.Simeon service.Permis spécial - A Matagamiet au nord de Mata-gami sur la route desservant le territoire de la Baie James, de Montréal, pour le remorquage de 10 silos à ciment portatifs, en acier, sur roues / Special permit-To Matagami and to the north of Matagami on the road serving the James Bay Territory, from Montreal, for the haulaway of 10 mobile steel cement silos, on wheels.Permis spécial - En donnant les services prévus aux clauses y, k et o de son permis, la détentrice est autorisée à transporter sur des remorques 1304 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, No.6 No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de:.à:\tDétails du permis Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tValidity Period\tParticulars of permits QS-175 Q-3063-V-8-1 Q-22621-V QS-176 Q-23615-V-S-1\tLUCIEN GUERARD Voiturier-remorqueur / Haulaway operator JEAN-MARIE GOSSELIN A FILS LTEE Voiturier-roulier / Carrier ABATTOIR ST-ALEXANDRE LTEE\t6 months or until final decision.6 mois ou jusqu'à décision finale.G months or until final decision.6 mois ou jusqu'à décision finale.G months or until final decision.\tsurbaissées spécialement agencées, des maisons modulaires (maisons sectionnelles) préfabriquées aux usines de Les Constructions Latendresse Inc.lesdites remorques appartenant à et louées de Les Constructions Latendresse Inc.permis No 85-DYL / Special permit -When providing the services entitled under clauses j, k, and o of its permit, the holder is authorized to transport modular houses (sectional houses) prefabricated at the shops of Les Constructions Latendresse Inc.utilizing specially-equipped lowbed trailers belonging to and leased from Les Constructions Latendresse Inc.permit No.85-DYL.Permis spécial - Lucien Guérard est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Jean-Marie Gosselin & Fils Limitée (22621-V) selon les clauses a et b dudit permis No 22621-V / Special permit - Lucien Guérard is authorized to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to Jean-Marie Gosselin & Fils Limitée (22621-V), according to clauses a and b of said permit No.22621-V.Permis spécial / Special permit.1) St-Alexandre et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites dudit endroit, pour le transport d'animaux vivants.(1) St.Alexandre and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said locality, for the transportation of livestock.2) De St-Alexandre à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites dudit endroit, et retour, pour le transport d'animaux vivants.(2) From St.Alexandre to all points located within a radnisof 30 miles from the limits of said locality, and return, for the transportation of livestock.DECISION DE LA COMMISSION « PROPRIO MOTU » / DECISION \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t No\t\tRequérants\t\t\t\tCause\t \tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tA pplicants\t\t\t\tCose\t QCR-426\t24-01-74\tQ-23319-V-P-I\t\t\t\t\t \t\tGERARD ROY\t\t7423\t15-12-73\tQ-479\tLa Commission décrète le remboursement du dépôt de $25.fait par Gérard Roy au lieu du montant de $50.tel qu'indiqué dans la décision QCR-291 du 1S-10-73 / The Commission orders the reimbursement of the $25.deposit made by Gerard Roy.instead of the sum of $50.as indicated in decision QCR- QCR-426\t24-01-74\tQ-21839-V-P-1\t\t\t\t\t291 of 1S-10-7S.\t\tERIC J.BOURQUE\t\t7423\t15-12-73\tQ-480\tLa Commission décrète le remboursement du GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, n\" 6 1305 No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tG page\tO.Q.date\tCause Case\tDécisions ML-212\t28-01-74\t1180-DY c issued pursuant to bylaw number S2 \u2014 $73,000 \u2014 loan renewal.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, February 25, 1974.at 8:00 o'clock p.m.at the Town Hall.7 de la Mairie, L'Ange-Gardien, County of Montmorencv No.1, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.L'Ange-Gardien (County of Montmorency No.1), February 1, 1974.René Gariépy, Secretary-Treasu rer.Town Hall, 7 de la Mairie, L'Ange-Gardien.(Montmorency No.1), P.Q Telephone: 822-1555.code 418.550,98 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, n° 6 1347 La commission scolaire de Jacques-Cartier Siège social: 1500, Boulevard Curé-Poirier Est, Longueuil P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Doris Archambault, directeur-général.Bureau administratif.1500 Est, Boulevard Curé-Poirier, Ville de Longueuil, J4J-4T9, jusqu'à 8.00 heures du soir, mercredi, le 27 février 1974, pour l'achat de $1,907,000 d'obligations de la commission scolaire de Jacques-Cartier datées du 15 mars 1974 et remboursables en série du 15 mars 1975 au 15 mars 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 mars 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $1,907,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 03 1975.x $ 157,000 15 03 1976.x 168.000 15 03 1977.x 179,000 15 03 1978.x 192,000 15 03 1979.x 205,000 15 03 1980.143,000 15 03 1981.152,000 15 03 1982.161,000 15 03 1983.171.000 15 03 1984.182,000 La commission scolaire de Jacques-Cartier se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des bois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.Les x indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'une subvention de $380,000, accordée par le gouvernement provincial et payable en 5 versements de $76,000 de 1975 à 1979 inclusivement, seront appliqués au service de cet emprunt.Les versements effectués à même cette subvention seront «lé-posés durant les années précitées entre les mains du ministre des finances en vue de compléter les sommes nécessaires pour acquitter en totalité le setvice de la dette sur cette émission, conformément aux dispositions du Bill 64.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: The Jacques-Cartier School Board Head Office: 1500 Curé-Poirier Boulevard East.Longueuil.P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned.Doris Archambault, Director-General, at the Administration Office, 1500 Curé-Poirier Boulevard East.City of Longueuil.J4J 4T9.until 8:00 o'clock p.m., on Wednesday, February 27, 1974, for the purchase of a bond issue of $1,907,000 for the Jacques-Cartier School Board, dated March 15, 1974 and redeemable serially from March 15.1975 to March 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual recemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from March 15, 1974.Redemption table \u2014 SI,907,000 \u2014 20 years Date Capital 15 03 1985.$ 13,000 15 03 1986.14,000 15 03 1987.15,000 15 03 1988.17,000 15 03 1989.18,000 15 03 1990.20,000 15 03 1991.22,000 15 03 1992 .24,000 15 03 1993 .26,000 15 03 1994 .28,000 The Jacques-Cartier School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.The years marked with the letter \"x\" indicate those years during which the annual instalments of a grant of $380,000, awarded by the Provincial Government and payable in 5 instalments of $76,000 each from 1975 to 1979 inclusive, will be applied to the service of this loan.The instalments paid on such grant will be deposited during the aforesaid years with the Minister of Finance for the purpose of completing the sums required to pay off the aggregate amount of the debt service on this issue, in conformity with the provisions of Bill 64.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1348 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1971,, Vol.106, No.6 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $28,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéance apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéance excluant l'échéance du 15 mars 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetahles par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $28,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéance apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire de Jacques-Cartier s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 mars 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 31 juillet 1963 \u2014 $1,282,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 23 août 1972 \u2014 $575,000 \u2014 agrandissement de l'école Hubert Perron; 15 août 1973 \u2014 $50,000 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 27 février 1974, à 8 heures du soir.Bureau administratif, 1500 est, Boulevard Curé-Poirier, Ville de Longueuil, P.Q.J4J 4T9.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute in aucune des soumissions.Longueuil, ce 1er février 1974.Le directeur général, Doris Archambault.Bureau administratif, 1500 est.Boulevard Curé-Poirier, Ville de Longueuil, P.Q., J4J 4T9.Téléphone: 670-2410.code 514.55897-o 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year., 2.1 to 15-year serial bonds with the balance earned forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds., 4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for te one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-vear fixed-term bonds will not be for an amount less than $28,000, and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of March 15.1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to l-w.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $28,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on March 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Jacques-Cartier School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon from and after March 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: July 31, 1963 \u2014 $1,282,000 \u2014 loan renewal; August 23, 1972 \u2014 $575,000 \u2014extension of Hubert Perron School; August 15.1973 \u2014 $50,000 \u2014 refinancing costs.Tenders will be opened and considered at a meeting cf the School Commissioners to be held on Wednesday, February 27, 1974, at 8:00 o'clock p.m., at the Administration Office, 1500 Curé-Poirier Boulevard East, City of Longueuil, P.Q.J4J 4T9.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Longueuil, February 1, 1974.Doris Archambault, Director General.A111111111 -1 ra 11 ' mi Office, 1500 Curé-Poirier Boulevard East, City of Longueuil, P.Q.J4J 4T9 Telephone: 670-2410, code 514.55897 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, n° 6 1349 Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.GASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Gaspé l fiHEMINS DE FER NATIO-Percé, No 4701.\\ ^> NAUX DU CANADA, demanderesse, vs NORBERT TRA-CHY, de Cap d'Espoir, district de Gaspé, et MICHEL TRACHY, de Cap d'Espoir, district de Gaspé, défendeurs.A) « Un certain lopin de terre de figure irrégulière, sis et situé à Cap d'Espoir, comté de Gaspé, province de Québec, mieux connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Percé, comme partie du lot 147 du 1er rang est, Cap d'Espoir à l'Anse-à-Beaufils, canton de Percé, borné au nord-ouest par le lot 149, au nord et au nord-est par le golfe St-Laurent, au sud-est par une partie du lot 147 occupée par Gaston Pitre et au sud-ouest, 1153 au sud-est, 124.5 et 46.1 au sud-ouest, ayant une superficie de 205,115 pieds carrés.» B) * Un certain lopin de terre de figure irrégulière, sis et situé à Cap d'Espoir, comté de Gaspé, province de Québec, mieux connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Percé, comme partie du lot 145 du 1er rang est, Cap d'Espoir à l'Anse-à-Beaufils, canton de Percé, borné au nord-ouest par partie du lot 146 occupé par Roland Seymour, au nord-est par le golfe St-Laurent, à l'est par partie du lot 144, propriété de Gordon Trachy et au sud-ouest par le chemin public, mesurant 1125 pieds au nord-ouest, 1176 au sud-est, 1735 pieds au sud-ouest, borné au nord-ouest par partie du lot 146, propriété de Roland Seymour, au nord-est par le chemin public, au sud-est par partie du lot 145 occupée par Gordon Trachy et au sud-ouest par le lot 145 occupé par Gordon Trachy mesurant 926.6 pieds au nord-ouest, 172.8 au nord-est, 901.7 au sud-est, 901.7 au sud-est et 156.1 au sud-ouest, ayant une superficie de 149,914 pieds carrés.» O « Un certain lopin de terre de figure irrégulière, sis et situé à Cap d'Espoir, comté de Gaspé, province de Québec, mieux connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Percé, comme partie du lot 145 du 1er rang est, Cap d'Espoir à l'Ansc-à-Beaufils, canton de Percé, borné au nord-ouest par partie du lot 146, propriété de Roland Seymour, au Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.GASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Gaspé ( /CANADIAN NATIONAL RAIL-Percé, No.4701.< ^ WAY, plaintiff, vs NORBERT ' TRACHY.of Cap d'Espoir, District of Gaspé, and MICHEL TRACHY, of Cap d'Espoir, District of Gaspé, defendants.(A) \"A certain parcel of land of irregular configuration, lying and situate in Cap d'Espoir, County of Gaspé, Province of Québec, better known and described in the official plan and in the book of reference for the Township of Percé, as part of lot 147 in First Range East, Cap d'Espoir in Anse-à-Beaufils, Township of Percé, bounded on the northwest by lot 149, on the north and northeast by the Gulf of St.Lawrence, on the southeast by a part of lot 147 in the possession of Gaston Pitre and on the southwest, 1153 on the southeast, 124.5 and 46.1 on the southwest, covering a surface area of 205,115 square feet.(B) \"A certain parcel of land of irregular configuration, lying and situate in Cap d'Espoir, County of Gaspé, Province of Québec, better known and described on the official plan and in the book of reference for the Township of Percé, as part of lot 145 in the First Range East, Cap d'Espoir in Anse-à-Beaufils, Township of Percé, bounded on the northwest by part of lot 146 belonging to Roland Seymour, on the northeast by the Gulf of St.Lawrence, on the east by part of lot 144, property of Gordon Trachy and on the southwest by the public road, measuring 1125 feet on the northwest, 1176 on the southeast, 1735 feet on the southwest, bounded on the northwest by part of lot 146, property of Roland Seymour, on the northeast by the public road, on the southeast by part of lot 145 belonging to Gordon Trachy and on the southwest by lot 145 belonging to Gordon Trachy, measuring 926.6 feet on the northwest, 172.8 on the northeast, 901.7 on the southeast and 156.1 on the southwest, covering a surface area of 149,914 square feet.\" (C) \"A certain parcel of land of irregular configuration, lying and situate in Cap d'Espoir, County of Gaspé, Province of Québec, better known and described on the official plan and in the book of reference for the Township of Percé, as part of lot 145 in First Range East.Cap d'Espoir in Anse-à-Beaufils, Township of Percé, bounded on the northwest by part of lot 146, 1350 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9.1974, Vol.106, No.6 sud-est par partie du lot 145, au sud-ouest par le lot 133, propriété occupée par Joseph Ahern.» Avec bâtisses construites sur lesdites propriétés, circonstances et dépendances.Ces lots sont maintenant connus sous les numéros 147-1, 145-2, 145-1 et 145-4 du cadastre revisé du rang I est du Cap d'Espoir à l'Anse-à-Beaufils, canton de Percé.Pour être vendu au bureau de la division d'enregistrement de Percé, au Palais de Justice, LUNDI, le ONZIÈME jour de MARS, 1974, à DIX heures de l'avant-midi._Percé, le 22 janvier 1974.Le shérif, 55885-0 Jean Bourget.property of Roland Seymour, on the southeast by part of lot 145.on the southwest by lot 133, property of Joseph Ahern.\" With the buildings erected on said properties, appurtenances and dependencies., The aforasaid lots are now known under numbers 147-1, 145-2, 145-1 and 145-4 on the revised cadastre for Range I East of Cap d'Espoir in Anse-a-Beauhls, Township of Percé., _ .To be sold at the Office of the Perce Registration Division, in the Court House of Perce, on MONDAY the ELEVENTH day of MARCH, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Percé, January 22, 1974.Jean Bourget, 55885 Sheriff.KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Kamouraska l /COMMISSION SCOLAIRE DE RI-Xo 6204.-J O VIÈRE-DU-I.OUP, corporation léga- ' lement constituée ayant son siège d'affaiies à 464 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, demanderesse, rs AUCLINE DUMONT, domicilié et résidant à 76 rue Gilles, Rivière-du-Loup, défendeur.« Le numéro du lot 47-16-1, tel que décrit au cadastre officiel de la Ville de Fraserville; borné vers le nord-ouest par le lot 674 rue St-Georges, vers le nord-est par le lot 47-17-2, vers le sud-est par les lots 47-28-1 et 47-16-2, et vers le sud-ouest par les lots 47-16-2 et 47-15-2.Mesurant quatre-vingt-seize pieds et cinq dixièmes (.96.5') vers le nord-ouest, cent-douze pieds (112') vers le nord-est, cinquante et un pieds (51') et quarante-quatre pieds et six dixièmes (44.6') vers le sud-est, sept pieds (7') et cent cinq pieds (105') vers le sud-ouest.Contenant en superficie dix mille quatre cent trente-neuf pieds carrés et huit dixièmes (10,439.8'*) M.A.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement dix ision de Témiscouata, situé à 65A, rue Iberville, Rivière-du-Loup, le DIX-HUITIÈME jour de MARS 1974.à DIX heures de Pavant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Maurice Morin.Rivière-du-Loup, ce 4 février 1974.55905-o MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal l TNAME YOLANDE LAURIN, No 05-O15662-73.< J\u2014' demand eresse, es ASSOCIATION COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION LES AMIS DU QUE-BEC (A.C.O.P.A.Q.), défenderesse.KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Kamouraska ( -\"THE RIVIÈRE-DU-LOUP SCHOOL No.6204a BOARD, a corporation legally in- v corporated having its head office at 464 Lafontaine Street, Rivière-du-Loup, plaintiff, versus AUCLINE DUMONT, domiciled and residing at 76 Gilles Street, Rivière-du-Loup, defendant.\"The number of lot 47-16-1, as described on the official cadastre for the Town of Fraserville; bounded towards the northwest by lot 674 St.Georges Street, on the northeast by lot 47-17-2, towards the southeast by lots 47-28-1 and 47-16-2, and towards the southwest by lots 47-16-2 and 47-15-2.Measuring ninety-six and five tenths feet (96.5') towards the northwest, one hundred twelve feet (112') towards the northeast, fifty-one feet (51') and forty-four and six tenths feet (44.6') towards the southeast, seven feet (7') and one hundred five feet (105') towards the southwest.Covering a surface area of ten thousand four hundred thirtv-nine and eight tenths feet (10,439.8 sq.ft.) E.M.\" To be sold at the Registry Office in the Témiscouata Division, located at 65A, Iberville Street, Rivière-du-Loup.on the EIGHTEENTH day of MARCH, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Maurice Morin, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, February 4, 1974.55905 MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal C r\\/fRS YOLANDE LAURIN, No.05-015662-73.-J J-VJ.plaintif, vs ASSOCIATION v COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION LES AMIS DU QUEBEC (A.C.O.P.A.Q.), defendant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 février 197t, 106' année.u° 6 1351 1° « Un emplacement étant la partie sud-ouest du lot originaire numéro quarante-six (Ptie S.O.46) aux plan et livre de renvoi officiels du Quartier Centre de la Ville de Montréal, mesurant trente-trois pieds de front sur la rue St-Paul et cinquante-huit pieds et six pouces de profondeur, et de là mesurant soixante-quatre pieds de largeur sur une nouvelle profondeur, et de là mesurant soixante-quatre pieds de largeur sur une nouvelle profondeur de trente-quatre pieds, y compris le passage en arrière du lot numéro quarante-sept desdits plan et livre de renvoi officiels, le tout plus ou moins, mesure anglaise.Cet emplacement est borné comme suit: en front au sud-est par la rue St-Paul, en arrière au nord-ouest par le lot numéro cinquante desdits plan et livre de renvoi officiels; du côté nord-est par partie du lot numéro quarante-six sus-mentionné et par le lot numéro quarante-huit et du côté sud-ouest partie par ledit lot numéro quarante-sept desdits plan et livre de renvoi officiels et partie par la rue St-Jean-Baptiste.Avec bâtisses dessus érigées portant le numéro civique 25 est.rue St-Paul et 409, rue St-Jean-Baptiste et sujet à la servitude d'un droit de passage en arrière dudit lot numéro quarante-sept desdits plan et livre de renvoi officiels au bénéfice des propriétaires de l'autre partie du lot numéro quarante-six.Avec toutes circonstances, servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble.» 2° « Un emplacement situé à l'angle nord-est des rues St-Paul et St-Jean-Baptiste, dans la ville de Montréal, connu et désigné comme étant le lot numéro quarante-sept (47) aux plan et livre de renvoi officiels dudit Quartier Centre.Avec toutes les bâtisses dessus érigées portant le numéro 21 est, de ladite rue St-Paul et 405, rue St-Jean-Baptiste, en la ville de Montréal.Avec toutes circonstances et dépendances, servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.» Pour être vendu « séparément » au bureau du shérif, au Palais de Justice en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le QUINZIÈME jour de MARS 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 24 janvier 1974.55838-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Fédérale No T-827-72.C TNANS L'AFFAIRE DE LA LOI 18-001510-73.\\ DE L'IMPOT SUR LE REVE-l NU, demanderesse, vs BARUCH DIENSTAB, résidant de l'État de New-York, défendeur.« Un immeuble ou terre située dans la ville d'Anjou, autrefois la paroisse de St-Léonard-dc-Port-Maurice, connue et désignée, aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de la Longue-Pointe, sous le numéro quatre cent quatre-vingt-deux (482), mesurant trois 1.\"An emplacement being the southwest part of original lot number forty-six (S.W.Pt.46) on the official plan and in the book of reference for Centre Ward in the City of Montreal, measuring thirty-three feet in front on St.Paul Street and fifty-eight feet and six inches ia depth, and thence measuring sixty-four feet in width by a new depth, and thence measuring sixty-four feet in width by a new depth of thirty-four feet, including the passage way in the rear of lot number forty-seven on said official plan and book of reference, the whole more or less, English measure.Said emplacement is bounded as follows: in front on the southeast by St.Paul Street, in the rear on the northwest by lot number fifty on said official plan and book of reference; on the northeast side by a part of above-mentioned lot number forty-six and by lot number forty-eight and on the southwest side partly by said lot number forty-seven on said official plan and book of reference and partly by St.Jean-Baptiste Street.With the buildings erected thereon bearing civic numbers 25 St.Paul Street East and 409 St.Jean-Baptiste Street, and subject to a servitude of right of way for the benefit of the owners of the other part of lot number forty-six.With all appurtenances, and active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveable.\" 2.\"An emplacement located at the northeast corner of St.Paul and St.Jean-Baptiste Streets, in the City of Montreal, known and described as being lot number forty-seven (47) on the official plan and in the book of reference for said Centre Ward.With all the buildings erected thereon bearing civic numbers 21 of said St.Paul Street East and 405 St.Jean-Baptiste Street, in the City of Montreal.With all appurtenances and dependencies, and all active and passive, apparent of unapparent servitudes attaching to said immoveable.\" To be sold separately at the Sheriff's Office, at the City of Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the FIFTEENTH day of MARCH, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 24, 1974.55838 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Federal Court No.T-827-72.1 TN THE MATTER OF THE IN-18-001510-73.< -1 COME TAX ACT, plaintiff, vs v BARUCH DIENSTAB, residing in the State of New York, defendant.\"An immoveable or tract of land located in the Town of Anjou, formerly the Parish of St.Léonard-de-Port-Maurice, known and described on the official plan and in the book of reference for the Parish of Longue-Pointe as number four hundred eighty-two (482), measuring 1352 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 9, 1974.Vol.106.No.6 arpents de front sur quarante arpents de profondeur, plus ou moins, tenant: en front, au chemin de la base de ladite Ville d'Anjou: et arrière, aux terres de la paroisse de la Rivière-des-Prairies; d'un côté à la terre numéro quatre cent quatre-vingt-un (481) auxdits plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de la Longue Pointe, et de l'autre côté à la terre numéro quatre cent quatre-vingt-trois (483) auxdits plan et livre de renvoi officiels, sans bâtisse dessus édifiée.À distraire cependant de cette terre les parties d'icclle ci-après désignées, savoir: a) la lisière de terrain vendue par Gustave Pépin à The Shawinigan Water & Power Co., suivant vente reçue devant Mtrc.H.Baby.Notaire, le neuf mai mil neuf cent onze, dont une copie authentique a été enregistrée au bureau d'enregistrement des comtés d'Hoche-laga et de Jacques-Cartier, sous le numéro 196,395 le trente et un août mil neuf cent onze; b) un lopin de terrain mesurant quarante-cinq pieds de largeur sur cent cinquante-deux pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise, vendu par Gustave Pépin à Isaïe Valiquette, suivant vente reçue devant Mtrc.J.A.O'Cleman.notaire, le neuf avril mil neuf cent douze, et dont une copie authentique a été enregistrée au même bureau d'enregistrement des comtés d'Hochelaga et de Jacques-Cartier, sous le numéro 212,877, le vingt-quatre avril mil neuf cent douze; et c) une lisière de terrain mesurant trois cent vingt-huit pieds de largeur en front sur le chemin public, sur cent cinquante-deux pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise; laquelle dite lisière est bornée, en front, par le chemin public, d'un côté, dans sa ligne sud-ouest, par le lopin de terre mentionné au paragraphe b ci-dessus, et décrit à l'acte enregistré à Hochelaga et Jacques-Cartier, sous le numéro 212,877.et dans ses lignes nord-ouest et nord-est par le résidu dudit lot numéro 482, du susdit cadastre: Ainsi que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives apparentes, ou occultes, attachées audit immeuble ou terre.» Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le QUATORZIÈME jour de MARS 1974.à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure.Paul St-Martin.Montréal, ce 23 janvier 1974.55839-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T ES ARTISANS, SOCIÉTÉ No 05-009881-73.< J-' COOPÉRATIVE D'ASSU-V RANCE-VTE, corporation légalement constituée, ayant son siège social au numéro 333 est de la rue Craig, dans les ville et district de Montréal, demanderesse.Pi MARGUERITE MEIDF.RER three arpents in front by forty arpents in depth, more or less, and bounded as follows: in front by the base road in said Town of Anjou; in the rear by the lands of the Parish of Rivière-des-Prairies; on one side by lot number four hundred eighty-one (481) on said official plan and in said book of reference for the Parish of Longue-Pointe, and on the other side by lot number four hundred eighty-three (483) said official plan and in said book of reference, without building erected thereon.Nevertheless to withdraw from this piece of land the parts thereof described hereinafter, namely: (a) the strip of land sold by Gustave Pépin to The Shawinigan Water & Power Co., according to a deed of sale executed before Me H.Baby, notary, on the ninth of May one thousand nine hundred eleven, of which a certified copy was registered at the Registry Office for the Counties of Hochelaga and Jacques-Cartier under number 196,395 on the thirty-first of August, one thousand nine hundred eleven; (6) a plot of land measuring forty-five feet in width by one hundred fifty-two feet in depth, more or less, English measure, sold by Gustave Pépin to Isaïe Valiquette, according to a deed of sale executed before Me J.A.O'Cleman, notary, on the ninth of April, one thousand nine hundred twelve, of which a certified copy was registered at said Registry Office for the Counties of Hochelaga and Jacques-Cartier, under number 212,877 on the twenty-fourth of April, one thousand nine hundred twelve; and (c) a strip of land measuring three hundred twenty-eight feet in width in front on the public road, by one hundred fifty-two feet depth, more or less, English measure; said strip of land being bounded as follows: in front by the public road, on one side on its southwest line by the plot of land described hereinabove in paragraph b and in the deed registered in Hochelaga and Jacques-Cartier under number 212.877, and on its northwest and northeast lin.-s by* the remainder of said lot number 482 on the aforesaid cadastre.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveable or tract of land.\" To be sold at the Sheriff's Office in the City of Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor.Room 56.on the FOURTEENTH day of MARCH, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office.Paul St-Martin, Superior Court.Assistant Sheriff.Montreal, this 23rd of January, 1974.55839 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( T ES ARTISANS, SOCIÉTÉ No.05-009881-73.< COOPÉRATIVE D'ASSU-l RANCE-VIE, a corporation legally incorporated, having its head office at 333 Craig Street East, in the City and District of Montreal, plaintiff, rs MARGUERITE MEIDERER MON- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, n\" 6 1353 MONGRAIN et SONIA LUNDBIGAN, domiciliées et résidant au 1330, de la rue Robert, dans la ville de Brossard, district de Montréal, défenderesses.* Un emplacement sis et situé à la ville de Brossard, P.Q., connu et désigné comme étant composé des lots numéros six cent trois et six cent quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro trente-six (36-603 et 604) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairic de la Magdeleine; Avec une maison dessus érigée portant le numéro civique 1330 rue Robert; Ainsi que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laprairie.à 214 St-Ignace, à Laprairie, P.Q., le TREIZIÈME jour de MARS 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 23 janvier 1974.55840-o GRAIN AND SONIA LUNDRIGAN, domiciled and residing at 1330 Robert Street, in the Town of Brossard, District of Montreal, defendant.\"An emplacement lying and situated in the Town of Brossard, P.Q.known and described as consisting of lots numbers six hundred three and six hundred four of the official subdivision of original lot number thirty-six (36-603-604) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine; With a house erected thereon bearing civic number 1330 Robert Street; As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveable.\" To be sold at the Registry Office of the County of Laprairie, at 214 St.Ignace, in Laprairie, P.Q., on the THIRTEENTH day of MARCH.1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, this 23rd of January, 1974.55840 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal I T\\AME LILIAN BUTLER, deman-Sb 676 620X \u2022L-' deresse, vs HENRY JAMES HI-l SHON.défendeur.Un immeuble composé de: « Le lot originaire numéro trente-deux, subdivision quatre-vingt-quatorze (94-32) des plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Ste-Geneviève.division d'enregistrement de Montréal, avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances, portant le numéro civique 4890 de la rue Rachel, en la Cité de Pierrefonds, district de Montréal.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice, en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig.lOe étage, chambre 56, le TREIZIÈME jour de MARS 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 23 janvier 1974.55842-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal l T ONDON LIFE INSURANCE No 05-013845-73.< *-> COMPANY, demanderesse M ¦-RICHARD H.JAMES, défendeur.« Un emplacement ayant front sur la rue Élie dans la ville de Fabreville, connu comme étant la subdivision deux cent quatre-vingt-un du lot numéro deux cent vingt-huit (228-281) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sainte-Rose, de figure irrégulière et mesurant soixante pieds de largeur sur une profondeur de cent deux pieds et quatre dixièmes d'un côté au nord-ouest, et de cent deux pieds de l'autre côté au sud-est, mesure anglaise.Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal (\"X/fRS.LILIAN BUTLER, plaintiff.No.676 620.< JVJL M HENRY JAMES HISHON, ' defendant.An immoveable consisting of: \"Original lot number thirty-two, subdivision ninety-four (94-32) on the official plan and in the book of reference for the cadastre of the Parish of Ste.Geneviève, Montreal Registration Division, with the building erected thereon, appurtenances and dependencies, bearing civic number 4890 Rachel Street, in the City of Pierrefonds, District of Montreal.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the City of Montreal Court House.10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the THIRTEENTH day of MARCH, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal.January 23, 1974.55842 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal I T ONDON LIFE INSURANCE No.05-013845-73.{ COMPANY, plaintiff, versus \\ RICHARD H.JAMES, defendant.\"An emplacement fronting on Élie Street in the town of Fabreville known as subdivision two hundred and eighty-one of lot number two hundred and twenty-eight (228-281) on the official plan and book of reference for the Parish of Ste.Rose of irregular figure and measuring sixty feet in width by a depth of one hundred and two feet and four tenths of a foot on one side to the northwest and one hundred and two feet on the other side to the southeast, English measure. 1354 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, No.6 Avec le bâtiment dessus érigé portant le numéro civique 370 de la rue Élie en la ville de Fabreville.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155, boulevard Je-Me-Souviens, à Laval (Québec), le DOUZIÈME jour du mois de MARS 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif.Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 23 janvier 1974.55841 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Cour municipale de Québec Québec, à savoir: / T A VILLE DE QUEBEC, vs AL-Nos 335 de 1970 ) -L* FRED DIT FREDDY FLA-et56de 1973 ) M AND, 1910, de la Ronde, Qué-{ bec, P.Q.« Un emplacement sis à 1910, rue de la Ronde, à Québec, portant le numéro 584-69 du cadastre officiel de St-Roch Nord et décrit comme suit: La subdivision numéro soixante neuf du lot originaire numéro cinq cent quatre-vingt-quatre (584-69) du cadastre officiel de la paroisse de St-Roch Nord en la ville de Québec, bornée vers le nord-ouest par le lot numéro 584-71, vers le nord-est par le lot numéro 584-70, vers le sud-est par la rue numéro 584-157 et vers le sud-ouest par la rue numéro 584-161 mesurant cinquante pieds (50') de front sur quatre-vingts pieds (80') de profondeur, contenant en superficie quatre mille pieds (4,000').Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de justice, à Québec, le QUINZIÈME jour de MARS 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 5 février 1974.55899-o With the building thereon erected bearing civic number 370 Élie Street in the Town of Fabrevdie.To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je Me Souviens Boulevard, in Laval, P.Q., on the TWELFTH diy of MARCH 1974, at ELEVEN o clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, January 23, 1974.55841-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec Municipal Court Québec, to wit:, THE CITY OF QUEBEC, rs Nos.335 of 1970J J- ALFRED, known as FRED-and 56 of 1973.1 DY FLAMAND, 1910 de la Ronde, ( Québec, P.Q.\"An emplacement located at 1910 de la Ronde Street, in Québec, bearing number 584-69 on the official cadastre for St.Roch North and described as follows: Subdivision number sixty-nine of original lot number five hundred eighty-four (584-69) on the official cadastre for the Parish of St.Roch North in the City of Québec, bounded towards the northwest by lot number 584-71, towards the northeast by lot number 584-70, towards the southeast by street number 584-157 and towards the southwest by street number 584-161, measuring fifty feet (50') in front by eighty feet (80') in depth, covering a surface area of four thousand feet (4,000').With the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Québec Court House, on the FIFrEENTH day of MARCH.1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, February 5, 1974.55899 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février Mb.106- année, n' 6 1355 Errata Cité de Shawinigan Edition numéro 5 du 2 février 1974, page 1146, 6e paragraphe 2e ligne, radier: « 1363 \u2014 $160,000 \u2014 achat de terrains ».55834-A Municipalité du comté de Lévis Édition numéro 4 du 26 janvier 1974, page 728, 9e ligne, nous aurions dû lire: « Jean-Paul Dionne 401-16, P-8.9, 10» au lieu de: « Jean-Paul Dionne 301-16, P-8, 9, 10 ».55834-A Municipalité du comté de Papineau Dans l'avis de vente pour taxes publié dans la Gazelle officielle du Québec, du 19 janvier 1974 (page 384) et du 26 janvier 1974 (page 705), à l'item « D » de la description de « LA CORPORATION DU VILLAGE DE MONTEBELLO » nous aurions dû lire SUB.983, du lot 283, au lieu de SUB.985, du lot 283.Le secrétaire-trésorier, 55906-o Hugues Servant.Municipalité du comté de Rouville L'avis de vente |pour taxes donné par la municipalité du comté de Rouville dans la Ga-.ette officielle du Québec des 19 et 26 janvier 1974 concernant la propriété Brodeur, Lionel (No de cadastre 156-16) aurait dû se lire « Du cadastre de Ste-Marie-de-Monnoir » au lieu de « Du cadastre de Marievillc ».La secrétaire-trésorière, 55834-0 Mme Rita Buondeau.Errata City of Shawinigan Issue number 5, dated February 2, 1974, page 1146, 6th paragraph, 2nd line, delete: \"1363 \u2014 $160,000\u2014 purchase of land\".55834-A Municipality of the County of Levis Issue number 4, dated January 26, 1974, page 728, the 9th line should have read: \"Jean-Paul Dionne 401-16, P-8, 9, 10\" instead of: \"Jean-Paul Dionne 301-16, P-8, 9, 10\".55834-A Municipality of the County of Papineau In the notice of sale for taxes published in the Québec Official Gazette, issues dated January 19, 1974 (page 384) and January 26, 1974 (page 705), in item \"D\" of the description printed under \"THE CORPORATION OF THE VILLAGE OF MONTEBELLO\", for \"SUB.9S5 of lot 283\".please read : \"SUB.983 of lot 283\".Hugues Servant, 55906 Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Rouville The public notice given by the Municipality of the County of Rouville in the Québec Official Gazette of the 19th and 26th of January 1974 regarding the property belonging to Brodeur, Lionel (cadastre number 156-16) should have read \"On the cadastre for Ste.Marie-de-Monnoir\" instead of \"On the cadastre for Marieville.\" Mrs.Rita Blondeau, 55834-0 Secretary-Treasurer.The Val-Mauricie School Board Issue number 5, dated February 5, 1974.page 1152, the correct telephone number is: \"536-5606\" and not: '535-5606\".55834-A QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 7974.Vol.106.No.6 INDEX No 6 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIONS Coopérative de transport d'écoliers Abénakis (La) [Formation).1337 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Beauharnois.cité-citv (Requitc-l'elition).131\" Boulanger (J.H.).Limitée (L.P.S.) (Correction).1315 Club des Sentiers 4 Saisons (L.P.).1315 Eglise Anglaise de Christ de Lachine (L.P.).\u2022 \u2022 \u2022 1315 Estate of Gérard Ayotte (Benefit of inrenlory).1311 Estate of Pierre lemieux (Benefit af iurenlory).1316 Estate of Charles B.Plamondon (Benefit of inventory).1317 Lachine English Church of Christ (L.P.).1315 I'ointe-Calumet, village (Requt'te-Petition).1316 4 Seasons Trail Riders Club (L.P.).1315 St-Pierre, ville-town (Requcte-Petition).1316 Succession Gérard Ayotte (Bénéfice d'inventaire).1317 Succession Pierre Lemieux (Bénéfice d'inventaire).1316 Succession Charles B.Plamondon ^Bénéfice d'inventaire).1317 CHANGEMENT DE NOM Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordée: Granted: Assh, Edward.1275 Assh, Maurice.1275 Ahrams, Heather.1275 Berlinguette.Jean Marie.1276 Bodaly, Keith Clayton.1270 Cantin, André.1276 Charest, Marie Lucette Eméa.1276 Conroy, Joseph Jules Marcel.1276 Davidson.Earl Scott.1276 De Cicco, Michèle Monique.1277 Desmarais.James Perry.1277 I IcyIiii.Valerie t'arole.1277 Dobrin.Melvyn Abraham.1277 Karah.Mounir Martin.1277 (iarner.Anne Morrine .1277 (iordon.Henri Alexander.1278 Kallis, René.1278 Kallis, Constant.1278 Kallis, Pierre.1278 King, Ernie.1278 Lee, Gin Min.1278 Maher, Thérèse .127!» Major, Monic.1270 Mawad.Rachid Maurice.1279 Naumcnko.John.1279 Rivard.Nelsone.1279 Vaillancourt, Joseph Jacques.1279 Wareing.Frank.1279 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 100' année, n° G 1357 Demandes: Applications: Brassard, Dorina.1274 Chyzyj, Jaroslaw.1275 Lerer, Sam Solomon.1274 Lipman, Joseph Georges Claude Paul André.1274 Shukur, Yousif Saleem.1274 Zadoronozny, Omylian John.1275 COMMISSION COMMISSION Commission Québec Transport des transports du Québec Commission Avis de décisions rendues.1295 Avis de désistement.1311 Avis de la Commission « proprio motu » .1310 Avis d'introduction de requêtes.1288 Notice of decisions rendered.1295 Notice of submission of applications.1288 Notice of withdrawal.1311 Notice \"proprio motu\" by the Commission .1310 Places d'affaires Places of business dans la province: in the Province: Finch & Sons Transport Ltd.1311 Morgan Drive Away Inc.1312 Parent Transport Ltd.1312 Rca Bros.Limited.1311 Rumble Transport Limited.1312 Trudeau (J.P.) & Fils Limited.1311 Palmer Hat Mfg.Co.1273 Panmaurie inc.1273 Poulin Enterprises Inc.1273 Publications Petit Journal Ltée.1273 Racicot & Fils inc.1273 St.Leonard Construction Ltd.1273 Scottish Trust Company (The).1273 Security Acceptance Corporation.1273 Service de Charriots-Elévateurs de l'Ouest de Montréal Ltée.1273 Three Rivers Chevrolet (1969) Limited.1273 Trois-Rivières Chevrolet (1969) Limitée.1273 Union Pen & Pencil Ltd.1274 Victoria Style Shoppe inc.1274 W'el industries Ltd.1274 Notice of correction of Letters Patent Avis de correction de lettres patentes Delivro Air Service Inc.1272 Service par Air Delivro Inc.1272 COMPAGNIES \u2014 COMPANIES LOI DES ACT Abandon Surrender de charte of Charter Arno Realty Ltd.1273 Baronets inc.(Les).1273 Centre chirurgical Crémazie inc.1273 Cie des machines de bureaux de Montréal inc.(La).1273 Club social des pompiers de Coaticook.1273 Comité du centenaire d'Alma inc.1273 Dominion Banada & Potato Co.1273 Dorval Dairy Incorporated.1273 E.H.Woolnough Incorporated.1273 Ellsworth Investment Corporation.1273 Entreprises Anvers Inc.(Les).1273 Entreprises Monval inc.(Les).1273 Entreprises Poulin inc.(Les).1273 E.T.Telecommunications Inc.1273 Four Square Investments Inc.1273 Hi-Quality Construction Inc.1273 Immeubles Boucherville Inc.(Les).1273 Laiterie Dorval Incorporée.1273 Montreal Office Machines Co.Inc.1273 Montreal West Lift Truck Service Ltd.1273 Monval Enterprises Inc.1273 Morton Realties Inc.1273 North Shore Industries Ltd.1273 Changement de nom Change of name Blondo Inc.1272 Lachapelle.Ethier, Rainville & Associés Inc.1272 Rubv Foo's (Montreal) Ltd.1272 Ruby Foo's (Montreal) Ltée.1272 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter Acme Meat Packers Inc.1280 Association de protection des forêts du St-Maurice.1280 Bellcvuc Housing Corp.1281 Centre de distributions Soleil (C.D.S.) Inc.1280 Corporation d'hypothèques foncières, inc.1280 Kayar Realty Corp.1281 Montreal Cutting Co.Limited.1281 Montrose Specialities Inc.1281 Occanair Travel Inc.1282 Placement Universel ltée (Le).1282 Placements Rado limitée (Les).1282 Rado Investments Limited.1282 St.Maurice Forest Protective Association.1280 Sedap inc.1282 Seligman & Latz Boulevard Salon.Ltd.1281 Spécialités Montrose inc.(Les).1281 Universal Investment Ltd.1282 Voyages Oceanair inc.1282 1358 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974.Vol.106, Xo.6 Divers Misscellaneous Association des Etudiants MBA des Hautes Études Commerciales inc.(Dir.).1283 Blondeau (Gilles) et compagnie (Dir.).1283 Entreprises Gaduplo inc.(Les) (Dir.).1283 Manna limitée (Dir.).1283 Montreal Jockey Club (The) (Dir.).1283 Victoriaville Sportswear Inc.(Dir.).1283 Lettres patentes Letters Patent (1™ partie) (Part /) Acier tricolore ltée.1267 Aluminium Versailles inc.1269 A.R.C.Lumber Inc.1267 Appartements Sir Thomas Chapais inc.(Les).1267 Art et Photo R.B.inc.1269 Arseneau (Réal) et Associés inc.1267 Ateliers de Carrosserie Lavoic Sept-îles inc.1268 Ateliers mécaniques de Tracy inc.(Les).1267 Auberge de la Marie Galante inc.(L').1267 Auto Allard inc.1267 Autobus Campagna inc.1267 Automobile Théo inc.1269 Bamboo Gardens Restaurant (Avlmer) Ltd.1267 Béchard (J.M.) inc.1267 Belgo-Canadian Import Corporation Inc.1269 Béton prémélange Fortin inc.1267 Bois A.R.C.inc.(Les).1267 Boutique Au coin des Jeunes Amoureux inc.1267 Burv Fish Hatcherv Inc.1267 C.R.D.Holding Inc.1267 Centre de radiologie West Island inc.1267 Centre du camion d'Asbestos inc.1267 Christin Auto Leasing Inc.1268 Chez Nicole Jeune mode inc.1267 Clinique médicale Huberdeau inc.1267 Colette Properties Inc.1268 Commerce Stein inc.1267 Compagnie Guy Fleurant & Frère limitée (La) 1267 Construction Claude Lafond inc.1267 Construction Deux Mille Treize inc.1267 Construction Systémax inc.1267 D.A.M.Vending Ltd.126S Décor meubles B.C.inc.1268 Delisle (Jean-Marie) ltée.1268 Distribution automatique D.A.M.ltée.1268 Dupéré Transport inc.1269 Entreprises La Chaumière inc.(Les).1268 Entreprises Marsilly inc.(Les).126S Entreprises McCready inc.(Les).1268 Entreprises René Tardif Chibougamau inc.(Les).1268 Excavation Marcel Chabot inc.1268 Ferme Bourget inc.(La).1268 Ferme des Trois Castors inc.(La).1268 Fibre de verre P.Q.inc.126S Portier (A.) & Associés inc.126S Fortin Ready-mix inc.126?Furman (Nord) ltée.1268 Furim-n (North) Ltd.126K G.& M.Importing Inc.12j>f Gendron (Philippe) & Fils inc.1268 Haute coiffure Alain Michel inc.Ç Hôtel Albanel inc.1268 Houle (Réjean) inc.1268 Huberdeau Medical Clinic Inc.1267 Immeubles André Séguin inc.(Les).'268 Immeubles C.R.D.inc.1267 Immeubles Colette inc.(I partie) (Part III) Association des étudiants adultes de la régionale Carignan.1270 Association des propriétaires du Lac Millet inc.1270 Association des propriétaires forestiers Mata- ne-Matapédia (L\").1270 Association du hockey mineur de l'Epiphanie inc.(L').1270 Centre d'accueil de Luceville inc.1270 Club de hockey mineur de Val d'Or inc.1270 Club de moto-neige Beauharnois inc.1270 Club de moto-neige Vikings de Howick.1270 Club des Sentiers 4 Saisons.1315 Comité touristique village des Temps inc.1270 Corporation de base-bail amateur de Beaupré, inc._.1270 Fondation des diplômés de l'université de Montréal (La).1270 Fondation pour la recherche sur le cancer et les maladies du sang de Montréal.1270 Loisirs promo de Giffard inc.(Les).1270 Montreal Foundation for Research on Cancer and Blood Diseases.1270 4 Seasons Trail Riders Club.1315 Société d'aménagement du Mont Sir Wilfrid Laurier inc.1270 Société d'expansion de Baie-Trinité.1270 Lettres patentes Letters Patent supplémentaires supplementary Association des Recycleurs de Pièces d'Auto et de Camion A.R.P.A.C.Inc.1271 Boulanger (J.H.), Limitée (Correction).1315 Breuvages Lucky One (1973) Inc.1271 Bourque (LE.) & Fils, Limitée.1271 Candiac Development Corporation.1271 Charbois Inc.1271 Cogena Inc.1271 Compagnie Internationale de Voiliers Performance Limitée.1271 Construction L.S.M.Inc.1271 Corporation «l'Administration Inco Ltée.1271 Dufresne Forest Products Inc.1271 Entreprises Toujac Inc.1271 Equipements Industriels (Cap-Chat) Inc.(Les).1271 Fibracan Inc.1271 Forget, Entrepreneur Général Ltée.1271 Inco Administration Corporation Ltd.1271 L.S.M.Construction Inc.1271 Lefal Inc.1271 Lucky One Beverages (1973) Inc.1271 Mass Holdings Corporation.1271 Performance Sailcraft International Company Limited.1271 Produits Forestiers Dufresne Inc.1271 Rive-Sud Plomberie & Chauffage Inc.1271 Sports Experts Inc.1272 Supradur du Canada Inc.1272 Supradur of Canada Inc.1272 Sièges sociaux Head Offices B N Shoe Trimmings & Xovelties Ltd.1284 Centre de productivité des transports du Québec.1284 Ecuries V.I.P.inc.(Les).1284 Entreprises Loitel inc.(Les).1285 Gingras (Orner) & Fils inc.1284 Loitel Enterprises Inc.1285 M.A.T.Voyages inc.1285 P.S.I.Manufacturing Limited.1285 Paré Xursery Inc.1285 Parclco Inc.1286 Pépinière Paré inc.(La).1285 Productions Smood inc.(Les).1286 Québec Oils & Fats Brokers Ltd.1286 Shawicon Inc.1286 Smood Productions Inc.1286 Société d'entretien du Québec inc.(La).1284 V.I.P.Stables Inc.1284 Victoriaville Sportswear Inc.1285 LIQUIDATION DES WINDING-VP COMPAGNIES - - Loi de la ACT Association coopérative des citoyens de la localité de Clarke City.\u2022 \u2022 ¦ 1334 Coopérative de consommation des policiers provinciaux du Québec (La).1334 Hamel (Réal) Construction.1335 Syndicat forestier de St-Yvon.1335 MIN ISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Amos, ville-town (Fusion-A mulgamation).1338 Amos-Ouest-West, munie.(Fusion-Amalgamation).1338 Board of revision for the district of Montreal 1341 Board of revision for the district of Québec.1341 Board of revision for the district of Québec.1341 Bureau de révision du district de Montréal.1341 Bureau de révision du district de Québec.1341 Bureau de révision du district de Québec.1341 1300 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 9, 1974, Vol.106, No.6 Terre» et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Ange-Gardien, par.1312 Beauport, par.1312 Charlesbourg.par.1313 Chicoutimi, par.1313 Lachenaie.par.1313 Letellier, canton-township.1313 Orford, canton-township.1313 Saint-Antoine-de-Longueuil.par.1314 Sainte-Geneviève, par.1314 Saint-Mathieu-de-Belocil, par.1314 Saint-Télesphore, par.1314 Tremblay, canton-township.1314 RENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATIONS ACT Aeis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: A.J.P.Electronique inc.1235 A & R Mobile Transport Inc.1235 Agences d'assurance LaSalle inc.(Les).1235 Agra Investment Co.Ltd.1235 Amicale Muriste Beloeil inc.1235 Association des écoles de coiffure pour dames de la province de Québec (L\").1235 Beauchamp (René) Electrique inc.1235 Beaulieu (J.B.) ltée.1235 Beaumanoir incorporée.1235 Bede Auto Inc.1235 Belco Knitting Company Inc.1235 Bellauto ltée.1235 Bigras & Vaillancourt inc.1235 Boissy (A.) compagnie limitée.1235 Botany Hall Clothes Inc.1235 Boulevard Development Co.Inc.1235 Boutique Les Impeccables inc.1235 Burdct (M.) Inc.1235 Burners (I.C.) Ltd.1235 C.& N.Fish & Game Club Inc.1235 Campbell & MacDonald Motor Sales Ltd.1235 Casino Dress Inc.1235 Centre civique de Saint-Paul de Lavaltrie (Le) 1230 Cercle musical d'Acton Vale inc.1230 Charlemagne Construction Inc.1230 ( 'ie de Mica de Mistassibi I tée ( La).1230 Cic de navigation Gauthier inc.(La).1236 Cinq-O-ltée.1236 Club des ambassadeurs de Gatineau-Bucking- ham inc.1236 Club Colombien (Le).1236 Club des employés de la compagnie électrique du Sagucnay inc.1236 Club Picardie.1236 Club Rob-Ra inc.1236 Club Tracadièche.1236 Commercial Administration Inc.1236 Compagnie «le déblaiement îles chemins d hiver de Kamouraska inc.(I.a).1286 Compagnie Edouanl Jutras limitée (La).1236 Compagnie d'imprimerie et de publication de la rive-sud limitée (La).j^og Compagnie Jean & Charles (La)., \u2022 \u2022 ¦ \u2022 ¦\u2022¦ ¦ J ' Compagnie de réfrigération nationale limitée, l£JO Compagnie Roger Poitras transport (1-a) i£>o Connaught Country Club.ii- ' ' tVj io-jc Consolidated Québec Vellowknife Mines Ltd.UHO Construction préfabriquée Tnbic inc.«g Cooper (Hy) Inc.23b Côte Vertu Riding School Inc.}*JJ Crane (Shirley) Inc.l-\"° D.S.& B.Enterprises Ltd.}236 Daigle & Ross limitée.123b Daigneault (R.) ltée.1236 Daily Pick-Up & Delivery Limited.1236 Dainty Dot Shoes Inc.1236 Da-Kerr-Ad Consolidated Mines Limited 1236 Daltner's Ltd.1237 Dan-D-Lax Corporation.1237 Dandy Pants & Sportswear Inc.1237 Daneau (G.) limitée.1237 Danel Sportswear Inc.1237 Danforth Import Export Inc.1237 Danis (J.) limitée.1237 D'Anjou (P.E.) & Fils limitée.1237 D'Argencourt inc.1237 Darling Investments Limited.1237 Daruth Manufacturing Co.Ltd.1237 Daverna Mills Limited.1237 De Luxe Silks & Lingerie Ltd.1237 Debbage & Hewitson Inc.1237 Dcchaux Brothers Limited.1237 Defor Chibougamau 'Mines Limited.1237 Delisle (J.E.) inc.1237 Delorimicr Construction Ltd.1237 Delta Machine and Motor Company.1237 Demers (L.) & cie limitée.1237 Deniers Transport ltée.1237 Denis Machine Shop Limited.1237 Depclteau (J.-H.) inc.1237 Dependable Watchstraps Co.Ltd.1237 Deschenes Ratepayers Association (The).1237 Désilets (A.D.) & Cie linitée.1237 Desjardins Express inc.1237 Desroches limitée.1237 Desrosiers (Fernand) inc.1237 Diamond Fur Blending Corp.(Canada).1237 Diamond (H.) & Sons Inc.1237 Distributeurs & manufacturiers de l'Est cic ltée.1237 Distributeurs de produits industriels de Sept-îles ltée (I.es).1237 Ducharme (Edmond) Insurance Agencies Ltd 1237 Ducharme (.I.A.) & Fils limitée.1238 Duvernay Équipement limitée.1238 E.S.P.Electronics Ltd.1238 Emmaus-Granby.1238 Engora Enterprises Ltd.1238 Entreprises Calco ltée (Les).1238 Entreprises Crystal Clair de Laval inc.(Les).1238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, h° 6 1361 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Faucher immeubles et prêts inc.1238 Fédération d'escrime du Québec (La).1238 Fédération québécoise de la compétition-moto-neige.1238 Foisy (Stanley) limitée.1238 Freecan Industries Inc.1238 Gestion S.A.P.inc.123S Giroux (Emile) limitée.1238 Guay (Adélard) inc.1238 Guil inc.1238 Hébert (Ovila) inc.1238 Hodge & I.loyd Limited.1238 Horizon Holdings Inc.1238 Houde Laroche & Cie ltée.12.38 Hut Barbecue Inc.(The).1238 Hyco Fur Company Incorporated.1238 Iannuzzi (D.A.) & Sons Inc.1238 Ideal Textiles Inc.1238 Ideal Trading Corporation.1238 Ile Perrot Yacht Club Inc.(The).1238 Imperial Auto Sales Corporation.1238 Imprimerie formules légales provinciales liée.1238 Imprimerie Pigeon limitée.1238 Indépendant Merchants Association of Québec (The).1238 Industries Agricola inc.1238 Industries Laurentiennes limitée (Les).1238 Industries Patapédia limitée (Les).1238 Industries Thermo ltée (Les).1238 Institut canadien des affaires publiques (I C A P) (L').1239 Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal (L').1239 Inter-British Trading Co.Inc.1239 Interknit Limited.1239 International Asbestos Company Ltd.1239 .lacoby Studios Incorporated.1239 Jacoby's House of Antiques Inc.1239 Jagra Import and Underwear Company Limited.1239 Jardiniers unis de Québec inc.1239 Jayccear Realty Corporation.1239 Jeannotte (Bruno) limitée.1239 Jerri Inc.1239 Jeune barreau de Québec inc.(Le).1239 Jeune commerce de Gaspé inc.(Le).1239 Jeunesse-Ville inc.1239 Jewellers Plating Ltd.1239 Jewish Citizen's League of Montreal Inc.1239 Jewish School Publishing Association Inc.1239 Jo Ann Lingerie Corporation.1239 Joe's Sandwich Shop Inc.1239 Johnson Fruit Company Limited.1239 Joliette Demolition Inc.1239 Joliette Foundry & Tool Works Limited.1239 Joliette Machine Works Limited.1239 Joliette Textile Corporation.1239 Joliette Worsted Co.Ltd.1239 Jonquière Quilles limitée.1239 Josef Inc.1239 Joseph (H.) & Co.Inc.1239 Joy Footwear Ltd.1239 JoyelCorp.1239 Jubilee Médecines Co.1239 Juddmarlnc.1239 Julep Realties Inc.1240 Julien Electrique Company limitée.1240 Julien (J.C.) limitée.1240 Junior Knitting Mills Limited.1240 K&GCloakCo.1240 Kaiser (CH.) & Son Inc.1240 Kanbec Gold Mines Limited.1240 Kane Products Inc.1240 Kapp Agencies Ltd.1240 Karo incorporée.1240 Kastner limitée.1240 Kennar Textiles Limited.1240 Kent Trading Corporation.1240 Kertchiff Dress Inc.1240 Keystone Overall & Pants Mfg.Co.Inc.1240 Knight of the Round Table Alumni Association Inc.1240 Kotler (B.) Inc.1240 L.K.Pastry & Delicatessen Shop Ltd.1240 Laboratoire Cunard limitée.1240 Laboratoire métropolitain d'électroencéphalo- graphie ltée.1240 Labrador Construction Company Limited.1240 Lac St-Jean automobile limitée.1240 Ladouceur Auto Repairs Limited.1240 Laflamme & Laflamme Limited.1240 Lafond & Coderre, ltée.1240 Lafontaine ltée.1240 Lahaie automobile ltée.1240 Lahaye inc.1240 Laing's Inn Inc.1240 Laiterie La Suète limitée (La).1240 Laiterie moderne de St-Eustache limitée.1240 Laiterie Pinard limitée.1240 Laiterie St-Jean-Baptiste limitée (La).1240 Lajoie Grocers Incorporated.1241 Lakeland Sportswear Incorporated.1241 Lakeshore Football Club Inc.(The).1241 Lamy & Fils limitée.1241 Landa Frocks Inc.1241 Landry (A.C.) limitée.1241 Landry & McNeil Inc.1241 Landry & Perry limitée.1241 Langeiier (J.Robert) Shoe Manufacturing Co.Ltd.1241 Langlois Motor Sales Limited.1241 Lanoix (Bernard) limitée.1241 Lanquetôt (M.) & Fils limitée.1241 Lenco Fibre Canada Corporation.1241 Lessard Police Equipment & Sports Inc.1241 Ligue de crosse des Cantons de l'Est.1241 Lortie & Roussin incorporée.1241 Love-Lee Lady Lingerie Stores Inc.1241 1362 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, No.6 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Lumber & Supply Ine.1241 Lustralite Corporation.1241 Lynns Ladies Wear Inc.1241 M.A.Knitting Mills Limited.1241 M.& A.Sheet Metal Works Ltd.1241 M.& J.Novelty Co.Ltd.1241 M.& R.Traders Inc.1241 Mab limitée (Limited).1241 Macamic Inc.1241 Macdonald Smelting & Refining Company Limited.1241 MacLeod (D.E.) Granite Inc.1241 Macy Fur Co.(The).1241 Mademoiselle Modes inc.1241 Madison D ress Inc.1241 Mafco Corporation Ltd.1241 Magasin Belle-rivière limitée.1241 Magasin Gareau limitée.1241 Magma Mines Limited.1241 Maher (.las.H.) & Son Ltd.1242 Mailman Corporation Limited.1242 Main Motor Sales Inc.1242 Main Street Club of Montreal Inc.(The)____ 1242 Maison Adélard LaSalle limitée.1242 Maison Bourdon inc.1242 Maison Chambord ltée.1242 Maison Charmaine ltée.1242 Maison Colombienne de Roberval incorporée (La).1242 Maison Diana inc.(La).1242 Maison Joseph Boumansour limitée (La).1242 Maison Notre-Dame-de-l'Enfance.1242 Maître Voilier inc.(I.e).1242 Maîtrise d'arts limitée.1242 Majestic Industries Limited.1242 Malartic Club.1242 Manhattan Company Limited.1242 Manoir Investments Limited.1242 Manoir Rocher Panet inc.1242 Manufacture de meubles Matane ltée.1242 Mansfield Realty Corporation Limited.1242 Mansions Motors Limited.1242 Mansonville Utilities Limited.1242 Manufacture de robes et costumes de Repentigny inc.1242 Maple Leaf Clenears & Overs Co.1242 Maple Leaf Peat Limited.1242 Maple Leaf Textiles Ltd.1242 Maple Leaf Transport Limited.1242 Maple Orchards Limited.1242 Mapron Realty Inc.1242 Marathon Construction Company Limited.1242 Marbo Plastics Co.Ltd.1242 Marcelle's Ladies Wear Inc.1242 Marchand & Hamel automobile ltée.1242 Marché-Davis-Market limitée.1243 Marché de fruits Jacques-Cartier ltée.1243 Marché St-Vallier limitée.J243, Marcotte (A.E.) ltée.}243 Margie Don Incorpored.:rT^ Margolis (Samuel) Dress Corp.J-Jo Margot Coats Inc.Mariette Gold Mines Limited.J*™ Maritime & Gulf Lumber Limited.LS*> Maritzer Dress Inc.f Marlev Agencies Limited.Marshall Ross & Co.Ltd.'243 Marsoul Mines Limited.Jg| Martel Garage cie ltée.Jg*J Martin limitée.J**J Mary's Food Market Inc.J243 Maskoutaine limitée (La).'243 Massicotte (L.) ltée.«43 Master Footwear Incorporated.\u2022 \u2022 \u2022 ¦ 1243 Master Ladies-Hairdressers and Wigmakers Guild (The).1243 Matane Beach Country Club incorporé.1243 Matane Works Inc.1243 Matériel d'imprimerie limitée.1243 Maxwell Holdings Inc.1243 Maxwell Spreads Inc.1243 May (Deanna) Inc.1243 Mayhery Hat Incorporated.1243 Mayfair Food Corporation.1243 Mayou-Pencer Clothes Inc.1243 McCulloch Equipment Co.Ltd.1243 McGill Fur Limited.1243 McGill Printing Limited.1243 Mcharg & Wade Ltd.1243 Mclean (D.V.) Incorporated.1244 Medical Acoustic Instruments Limited.1244 Megantic Aero Service Limited.1244 Megantic Mills Ltd.1244 Meilleur (Georges) & Fils inc.1244 Mel Glass & Léon Pascal Importers Limited.1244 Mel-Ber Manufacturing Company.1244 Memphremagog Water Power Association Incorporated.1244 Mendelsohn (S.) Inc.1244 Men's Apparel Inc.1244 Menuiserie canadienne limitée (La).1244 Merchants Clothing Co.Ltd.1244 Mercury Shoe Co.Ltd.1244 Merry Maid Fashions Inc.1244 Metal Heat Treating Co.1244 Metal Industries Incorporated.1244 Metallic Crystal Gauge Co.Ltd.1244 Metalore Mining Corp.Limited.1244 Metayer, Simoneau et Panneton limitée.1244 Metro Textiles Ltd.1244 Métropole Club Incorporated.1244 Métropole construction ltée.1244 Métropolitain Braids Ltd.1244 Metropolitan Goulet Company Limited.1244 Metropolitan Jewellery Mfg.Co.Ltd.1244 Metropolitan Manufacturing & Supply Co.Ltd.1244 Metropolitan Service Incorporated.1244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, n' 6 1363 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Metwood Products Inc.1244 Meubeau inc.1244 Meuble Somerset limitée (Le).1244 Miami Lingerie Inc.1244 Michael Manufacturing Company Limited.1244 Mictaw Mines Limited.1244 Midland Industries Ltd.1244 Mid-Town Dress Inc.1245 Miklos Incorporated.1245 Milady Hat Mfg.Co.Ltd.1245 Mile End Fruit Exchange Incorporated.1245 Milicent's Incorporated.1245 Milk for Health Incorporated.1245 Miller (A.I.) & Sons Ltd.1245 Miller (D.A.) Co.Ltd.(The).1245 Miller Trading & Manufacturing Ltd.1245 Miller's Economy Store Limited.1245 Milmar Cleaners & Dyers Inc.1245 Mil-War Ltd.1245 Mimeo-Sencil Manufacturers Limited.1245 Mines Holdings Limited.1245 Mines d'or Bellehumeur ltée (Les).1245 Minesco inc.1245 Mineshafts Limited.1245 Mireille incorporée.1245 Miss America Maid Incorporated.1245 Mistassini Lead Corporation Limited.1245 Modern Age Manufacturing Company Limited .1245 Modern Frocks Limited.1245 Modern Home Furnishers Ltd.1245 Modern Novelties & Specialties Limited.1245 Modern Spinners Inc.1245 Modem Traders Ltd.1245 Modern Wood Products Ltd.1245 Modernaire Incorporated.1245 Modernité Industries Limited.1245 Modes du jour limitée.1245 Moliver Sisterhood and Brotherhood Society (The).1245 Molyca Mines Limited.1245 Monarch Realty & Administration Company.1245 Monette Furs Inc.1245 Montcalm Lumber Company Inc.(The) .1245 Mont-Cassin Lodge Ltd.1246 Montex Limited.1246 Montfort Country Club Inc.(The).1246 Mont-Louis Mines Limited.1246 Montreal Blanket Company (The).1246 Montreal Blouse & Sports Wear Inc.1246 Montreal Civic Centre Incorporated.1246 Montreal Clothing Co.Inc.1246 Montreal Dental Supply and Manufacturing Company Limited (The).1246 Montreal Die Casting Co.Ltd.1246 Montreal Elgar Choir (The).1246 Montreal Figure Skating Club Incorporated (The).1246 Montreal Football Club Incorporated.1246 Montreal Fruit Receivers Association Inc.1246 Montreal Fuel Cell Form Supplyers Ltd.1246 Montreal Hardwood Flooring Co.Ltd.1246 Montreal Hat & Cap Manufacturers Association Inc.1246 Montreal Hearing Aids Bureau Inc.1246 Montreal Hebrew Old Peoples' and Sheltering Home (The).1246 Montreal Horse Show, Ltd.(The).1246 Montreal Industries & Enterprises Limited.1246 Montreal Iron and Metal Smelters, Limited .1246 Montreal Island Power Company.1246 Montreal Kennel Association, Inc.1246 Montreal Knitting Mills Inc.1246 Montreal Merchants' Association.1246 Montreal Model Railroad Club Inc.1246 Montreal-New York Express Ltd.1246 Montreal Orchestra.Inc.1246 Montreal-Ottawa Express Line Limited.1246 Montreal Plaster Works Incorporated.1246 Montreal & Provincial Shoe Repairers Association Inc.1246 Montreal Quarry Limited.1246 Montreal Tinning &- Retinning Co.Ltd.1246 Montreal Veneer Panel Inc.1247 Montreal Wartime Fuel Committee Inc.1247 Montreal Wax Paper Manufacturing Company Limited.1247 Mor-Ann Fashions Inc.1247 Mordave Realty Inc.1247 Mordipal Construction Company Inc.1247 Morency Motor Sales Ltd.1246 Morgan Silver Cross Mines Limited.1247 Morin (J.B.) & Cie limitée.1247 Morin (J.B.) inc.1247 Morin Lumber Limited.1247 Mor-Lite Realty Corporation.1247 Morton Clothes Ltd.1247 Mount Roval Mines Limited.1247 Mountain Castle Inc.(The).1247 Mountain Crest Mines Limited.1247 Mountain Limited.1247 Mountain View Bungalows Limited.1247 Mouvement pour le respect de la vie humaine inc.1247 Multi-Products Limited.1247 Mundy Grain Trimmers Patents Limited- 1247 Murray Cold Storage & Warehousing Co.Ltd.1247 Mutual Enterprises Ltd.1247 Mutual Industries Limited.1247 Mutual Sportswear Incorporated.1247 Myron Glass Frame Inc.1247 Natalie inc.\u2022.1247 National Accessories Company Limited.1247 National Construction Co.Limited.1247 National Frames Limited.1247 National Fruit Exchange Incorporated.1247 National Hardware Inc.1247 National Health Association.1248 1364 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, No.6 Avû dc dissolution éventuelle de corporations: (suite) Notice of Eventual Dissolution of Corporations: (continued) .1248 National Realty & Building Company.National Shoe Repairers Protective Association Incorporated.1248 Needleworks Limited (The) ,.1248 Nelson Plumbing & Heating Company Limited .1248 Nemo Construction Co.Ltd.1248 Neo-Bcauty Line Company Limited.1248 Nets Incorporated.1248 New Chiriotto Farm Inc.(The).1248 New Palace Hotel Limited.1248 News-Ad Incorporated.1248 Panorama Distribution Inc.1248 Pelon Inc.1248 Pcrald Inc.1248 Placements Meilleur inc.1248 Planchers Dominion inc.1248 Prahova Mines Limited.1248 Princeville Woodcraft Limited.124S Prominent Garment Inc.1248 Provincial Laboratories Limited.1248 Publicographes inc.1248 Pyramid Metals Incorporated.1248 Québec Explorers Ltd.1248 Québec Motor Sales Company Limited.1248 Québec Musical ( 'ompctith n festival Incorporated (The).]24H Québec Precambrian Corporation Limited.1248 Québec Rokorol Limited.1248 Québec Textiles Inc.1248 R.& G.Machine Rebuilders Ltd.1248 Radio Groupe Trans-Quebec inc.1248 Rainville & Company Limited.1248 Ranchouse Foods Ltd.1248 Rangers Club Inc.1248 Ratello Social Club Limited.1248 Red Comet of Canada Ltd.1249 Refrigeration « Glaciale » limitée.1249 Renardière P.A.Alain limitée (la).1249 Renaud and Sons Ltd.1249 Renco Limited.1249 Rcvanna Sportswear Inc.1249 Rhodt Metal Works Ltd.1249 Rimoin's 5é to $1.00 Stores Inc.1249 Roberge & Fils ltée.1249 Roy (Marcel) & Associés inc.1249 St.Hubert Departmental Store Ltd.1249 St.Lawrence Hardware Inc.1249 Sanatorium Hruchési de Montréal (Le).1249 Sanatorium dc Gaspé inc.(Le).1249 Sanders Garment Inc.1249 Savannah Confectionery Limited.1249 Savard (P.A.) limitée.1249 Scott Jewellery Co.Ltd.1249 Seaforth Mines Limited.1249 Seagrcen La!>oratoires inc.1249 Seaward Limited.1249 Secrétariat des syndicats catholiques de Mont- réal incorporée.,¦¦\u2022.9,q Seguin Consolidated Mines Limited.Jf*» Seligman (Jack) Incorporated.{5 j?Selinger (H.) & Sons Ltd.[fjfl Sénat de la jeunesse (Le).Sendel (Louis A.) Co.J**\" Sendel Machinery Corporation.J\"g Serrure de capot général inc.\\osa Service d'améliorations limitée.: Y ' ' ,0,0 Service d'aviation Charlevoix Saguenay ltee.UW Service de lavage de 10 minutes ltée.1*4» Service des loisirs de Ste-Scholastique.UWI Service Pleating Incorporated.j**» Service Populaire inc.Joen Service Sportswear Mfg.Co.«50 Service Tooling Co.Ltd.«50 Services publicitaires incorporés.«\u2022*> Seven Eighteen Corporation.«50 Seven Islands Lions Club Inc.«50 Shachter (Jack) Incorporated.1250 Shakespeare Club.J250 Shawinigan Mica Limited.\u2022 \u2022 \u2022.«50 Shawinigan Plywood Products Limited.«50 Shawinigan Golf Mines Ltd.1250 Shavne (A.) Inc 1250 Sheffield Steel Blade Ltd.1250 Shefler (H.C.) Inc.1250 Sherbrooke Feeds Limited.1250 Sherbrooke News Company Incorporated.1250 Shermont Inc.1250 Shiller's Fabrics Inc.1250 Shoccraft Company Limited.1250 Shulman Cap Company Limited.1250 Sidney Textile Corporation.1250 Sigma Phi Delta Fraternity Montreal Inc.1250 Sil-Blu Garment Inc.1250 Silmont Import Inc.1250 Silver Granite Company Limited.1250 Silver (H.J.) Fur Mfg.Co.Limited.1250 Simard (Jacques) inc.1250 Sim-Art Inc.1250 Simis Inc.(Service d'information de Montréal) 1250 Simis Realties Inc.1250 Simmons Mining Company Limited.1250 Simon (J.) & Company Limited.1250 Simon Shoe Company Limited (The).1250 Simoncau (J.P.) ltée.1250 Singer-Jackson Fashions Inc.1250 Sinotte (Donat) inc.1251 Skall Inc.1251 Skoda & Son Limited.1251 Sky Cruises Incorporated.1251 Skyline Clothes Inc.1251 Slater Bros.Inc.1251 Small General 5é Store Ltd.1251 Smart Children's Wear Incorporated.1251 Smart Made Dress Company Ltd.1251 Smart Miss Inc.1251 Smartwear Limited.1251_ Smeaton Bros.Limited.1251 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, n° 6 1365 -Iris de dissolution éventuelle de corporations: Notice of Eventual Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Smiling Juniors Inc.1251 Smith (Arthur) Furs Inc.1251 Smith Building Services Ltd.1251 Smith (J.) ltée.1251 Smith (WAV.) & Company Limited.1251 Smith's Sanitary Supply Co.Ltd.1251 Snowdon Dry Cleaners Inc.1251 Société canadienne d'assistance médicale incorporée.1251 Société classique (La).1251 Société d'entraide Québec-Haïti.1251 Société générale de Sainte-Luce-sur-Mer limitée (La).1251 Society Hat Mfg.Co.Ltd.(The).1251 Société d'histoire régionale de Lachine.1251 Société immobilière Maisonneuve limitée.Société de placements St-Georges ltée (La).1251 1251 Société des produits Délecta limitée.1251 Société St-Jean Baptiste de Sayabec (La).1251 Société des secouristes de Québec inc.(La).1251 Soieries Boell limitée.1251 Somerled Realties Company Ltd.1252 Soucisse (Victor C.) & Compagnie incorporée.1252 South Shore Echo Ltd.1252 Southern Slippers (1966) Ltd.1252 Spécialités LaSalle Specialties Inc.1252 Sport Guild Inc.1252 Standard Steel Products Limited.1252 Stanley Club Inc.(The).1252 Stanray Company Limited.1252 Stella Dress Inc.1252 Sterling Embroidery Ltd.1252 Sterling Fur Company.1252 Sterling Slipper Inc.1252 Stoker limitée.1252 Structures universelles inc.1252 Stuar t Enterprises Ltd.1252 Studio Albert Dumas limitée.1252 Sutdio Hébert ltée.1252 Style Signs Ltd.1252 Trasn-Kébec Vacuum (Que.) Inc.1252 Tremblay Lumber Co.Ltd.1252 Trumor Securities Ltd.1252 Vanguard System Inc.1252 Vera Pizza Inc.1252 Verville (Maurice) limitée.1252 W.B.Realty Company.1252 Youth Employment Service Corporation.1252 lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: A.E.C.Corporation Inc.1253 A.X.Electronics Corp.1253 Agences Léo Gauthier inc.(Les).1253 Agences M.(iuay inc.1253 Agences musicales Saguenay-Lac-St-Jean ltée (Les)-.1253 Agences touristiques Cartier inc.1253 Ahuntsic Plumbing & Heating Co.Ltd.1253 Aide au Foyer inc.(L\").1253 Aménagements Baie Plaisance inc.1253 Arche des Jeunes (L').1253 Archers laurentiens (Les).1253 Arena de la rive sud incorporée.1253 Aresville Gardens Inc.1253 Argenteuil Equipment Limited.1253 Argus Press Corp.1253 Armoires de luxe inc.1253 Arnel Commercial Enterprises Ltd.1253 Arts féminins de la Mauricie inc.(Les).1253 Arvida Tennis Club Inc.1253 Association de baseball de St-Hyacinthe inc .1253 Association de camping de Chandler inc.(L') 1253 Association de chasse et pêche du serpent Xo- tre-Dame-du-Laus, Que.1253 Association des cités des jeunes du Québec .1253 Association des clubs de service du Québec métropolitain inc.(L').1253 Association des consommateurs avertis (L').1253 Association de danse A.D.R.Q.1253 Association diocésaine des commissions scolaires de Trois-Rivières inc.(L\").1253 Association des étudiants du Cégep de Thetford inc.(L').1253 Association générale des étudrants du collège de Jonquière.1253 Association des groupements en alimentation inc.1253 Association Jeunesse et Culture du Québec .1254 Association des loisirs du lac Rond inc.1254 Association nautique du lac Bleu inc.(L'); .1254 Association des numismates de Montréal inc.(L').1254 Association parents-maîtres St-Georges inc.1254 Association professionnelle des cinéastes.1254 Association des propriétaires des chalets des éboulis inc.(L').12&t Association des propriétaires du lac Bisbey (L')., 1254 Association des propriétaires du lac Matambin 1254 Association des propriétaires du lac Vert inc.(!.').1254 Association régionale de natation amateur Rive Sud métropolitaine.1254 Association Trois Cap.1254 Assurances Pierre Alix inc.1254 Auberges de jeunesse du Québec (Les).1254 Auto C.O.V.inc.1254 Auvicom Inc.125) Avian Development Corporation.1254 Ayotte & Lambert inc.1254 B.G.L.inc.1254 B.H.construction inc.1254 B.L.M.construction inc.1254 B.L.R.Language Schools Ltd.1254 II.T.H.construction ltée.1254 Baie du nord Fourrures inc.(La).1254 Baillargeon (Yves) ltée.1254 Barons de Rouyn Xoranda (l.es).1254 1366 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol.106, No.6 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) BarrifLtd.1254 Baycolnc.1254 Beaconsfield Club Shares Limited.1254 Beaudin (Charles A.) inc.1254 Beaulé tuile et tapis inc.1254 Béton Minville inc.1254 Bibliothèque centrale de prêt du Saguenay- Lac-St-Jean.1254 Biencoltée.1254 Big Vallev Levestock Exporters inc.1254 Bilrallnc.1255 Black and Gold Athletic Association inc.(The) 1255 Blackstone Building Corporation.1255 Blanchard (FAV.) inc.1255 Blanchet (Gérard) inc.1255 Blé d'Inde Paysan inc.(Le).1255 Blondin Leasing Inc.1255 Boeuf sur le Toit inc.1255 Bohème Haute Coiffure inc.(La).1255 Bonneville Realty Inc.1255 Boutin (Gérard) ltée.1255 Boutique Au Vieux Grenier inc.1255 Boutique Maxime inc.1255 Boutique Taj Mahal ltée.1255 Brault (Maurice) joaillier inc.1255 C.A.T.A.(L'Age d'Or).1255 C.L.P.S.Inc.1255 Cadet Cleaners Limited.1255 Café Tabouret ltée (Le).1255 Cantalia Construction Inc.1255 ('entre astronomique de Montmorency inc.1255 Centre civique de Joliette incorporée.1255 Centre colombien Sainte-Foy inc.(Le).1255 Centre Jour inc.1255 Centre loisirs Danse Baie des Chaleurs.1255 Cercle d'études en conduite automobile (C.E.C.A.).1255 Champoux (Armand) inc.1255 Chaussures Massy inc.1255 Cidrerie de la vallée du Richelieu inc.1255 Ciné-Parc Val Loisir inc.1255 Cinédôme Theatres Ltd.1255 Circuit Mt Tremblant St-Jovite inc.1255 Citadel Salvage Corporation.1255 Citadel Steak House Inc.(The).1255 Cité des Jeunes de Hull.1255 City Edible Refining Ltd.1255 Club au Rendez-vous des Sportifs (bac Caché) inc._.1255 Club auto neige Em Bo de Rouyn Noranda inc.1255 Club auto neige de Ste-Marie inc.1256 Club automobile Bombardier.1256 Clul> d'aviation de Trois-Rivières inc.1256 Club d'aviron de l'équipe du Québec inc .1256 Club de baseball Les Saints de Sainte-Thérèse inc.(Le).1256 Club Bi-Clou-Fil.1256 Club de chasse & pêche Lachaine.1256 Club de chasse et de pêche St-Germain-des- Monts.I256 Club de hockey les Barons de Granby inc- 1256 Club du lac du Repos.'oin Club du lac Vernon inc.1256 Club de moto-neige les Étoiles des Pins inc.1256 Club optimiste Lorette.1256 Club Parc Duchesneau.1256 Club des plaines inc.1256 Club Le Raccourci inc.1256 Club des Raquetteurs (Tikouape) inc.1256 Club récréatif Joko inc.1256 Club Richelieu de Gatineau.1256 Club la Rose des Vents du Québec métropolitain inc.1256 Club de ski de Gaspé inc.(Le).1256 Club sportif Blanc-Rouge-Vert inc.1256 Club sportif Pocomoco inc.1256 Club sportif de Victoriaville inc.(Le).1256 Club de tennis de Matane.1256 Club de tennis (St-Isidore inc.).1256 Club Trois-Rivières Archers.1256 Club Vien inc.1256 Comeau (Louis) inc.1256 Comité des citoyens de Trois-Rivières.1256 Comité des loisirs des Trois-Ruisseaux incorporée.I256 Compagnie des matériaux de construction inc.(La).1256 Comptoir agricole St-Louis inc.1256 Concile des jeunes de Saint-Hyacinthe (Le).1256 Conseil régional de Bien-Etre de Sherbrooke.1256 Construction générale Sphex ltée.1256 Convenco of Canada Limited.1256 Corko ltée.1257 Cornucupia Investments Ltd.1257 Corporation immobilière B.& J.inc.1257 Cyclones de Warwick (Les).1257 Cyr (Y.) Tire & Auto Service Ltd.1257 D.R.Rolling Metal Inc.1257 D'Avray Properties Limited.1257 Delta Investments Inc.1257 Delta Techniques Ltd.1257 Diguer (Bernard) 5-10-15 inc.1257 Discount Ista-Prints (D.I.P.) Inc.1257 Distribution Elite ltée.1257 Domaine du Perchoir inc.1257 Downcaster Development Inc.1257 Dromil Investment Inc.1257 Dunn Enterprises Incorporated.1257 Dwelling Location Service Ltd.1257 E.T.Specialties Inc.1257 Ecolog-Motivation Inc.1257 Edifice Trever inc.1257 Elgar Mining Corp.Limited.1257 Entreprises Arc inc.1257 Entreprises Armand Vadeboncoeur ltée (Les).1257 Entreprises BLB inc.(Les).1257 Entreprises Bocar inc.1257 Entreprises G.& C.inc.(Les).1257 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 fierier 1974, 106' aimée, n° C 1367 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Entreprises G.M.M.inc.(Les).1257 Entreprises H.O.M.ltée.1257 Entreprises J.J.S.inc.(Les).1257 Entreprises Hospitalité limitée.1257 Entreprises Labranche inc.(Les).1257 Entreprises Lafleur (1961 ) ltée (Les).1257 Entreprises Lallouz inc.(Les).1257 Entreprises Lanry inc.(Les).1257 Entreprises Maupier inc.(Les).1257 Entreprises Maurog inc.(Les).1257 Entreprises de meubles Luc Genest inc.(Les).1257 Entreprises Mont Plansant inc.(Les).1257 Equipement B.G.inc.1258 Euro-Studio limitée.1258 Favre & Fils limitée.1258 Fiederer (Ernest) Sales Inc.1258 Fondation artistique de Saint-Jean.1258 Fonds Masks limitée.1258 4 Seasons Drive In (Masson) Ltd.1258 Forcier (Edgar) & fils inc.1258 Frontier Beagle Club.1258 G.A.Inc.1258 G.G.Graphics Inc.1258 G.H.i .afné Agencies Inc.1258 Gang du Barbillon inc.(La).1258 Garage A & B ltée.1258 Garthby transport limitée.1258 Gatineau Petroleum Inc.1258 Gaz Ouellet (1962) ltée.1258 Gélinas (Paul) inc.1258 (iélineau Auto Parts Inc.1258 Gendron (Michaud) inc.1258 Généreux construction inc.1258 Geneva Investment Limited.1258 (ienoa Painting Inc.1258 Gertoltée.1258 Gestnan limitée.1258 (iiguère & Frères inc.1258 Golden Arms Club Inc.(The).1258 Granby Holding Ltd.1258 Granby Spinning Mills Ltd.1258 Grand Construction Ltd.1258 Grand Pavillon (Hull) inc.1258 Grand Temple Pvthian Sister (P.S.) of Québec Inc.1258 Grange 32 Inc.1258 Greek Progressive Association of Canada Inc.1258 Greek Radio Wire Programs Inc.1258 (îrondin (Jean) inc.1258 Guay (Jacques G.) et Associés inc.1258 Hamel (Lucien) Construction Inc.1259 Harvev (Bert) corporation.1259 Hellenic Food Industries Co.Ltd.1259 Henri-Ette Dress Inc.1259 Hickory Industries International Sales Corporation.1259 Hilltop Nursery and Greenhouses Ltd.1259 Hôtel Paquet ltée.1259 Hôtel Rocher Blanc ltée.1259 Hôtel St-Louis (La Sarre) inc.1259 Hôtel Taillcfer et Fils inc.1259 Huiles Laflamme inc.(Les).1259 I & C Construction Inc.1259 Immeubles Impérial cie ltée.1259 Immeubles Labrosse inc.(Les).1259 Immeubles Outremont Realties Inc.1259 Immeubles et Prêts J.P.L.inc.1259 Industries Grondin & Doucet inc.1259 International Ciné-Club inc.1259 International Premier Pizza King corporation 1259 Inventions Catien & Major liée (Les).1259 J & J Promotion Inc.1259 J & M Leather Goods Ltd.1259 J.M.J.Holdings Inc.1259 J.P.B.Automate Inc.1259 Jacques (J.L.) transport inc.1259 Jctronics Corporation.1259 Jeunac inc.1259 Jeune chambre de Mont-Laurier (La).1259 Jeune commerce de Lyster.1259 Jeune commerce de Québec-Ouest inc.(Le).1259 Joa Management Ltd.1259 Jobson (Ray) inc.1259 Jolin construction ltée.1259 Joseph Le Tailleur inc.1259 Junior B de Thetford inc.1259 Junior Holdings Inc.1259 K & M Meat Market Inc.1259 Kalo Realties Ltd.1260 Kanawid Inc.1260 Kaprisse inc.1260 Katz (M.) inc.1260 Kcmpson Inc.1260 Kernor Corporation.1260 Kessler Industries Inc.1260 Kimpton Dupuit Agencies Limited.1260 Kiron Investment Corporation Ltd.1260 King Kong café de Thetford inc.1260 L.B.Service inc.1260 L & M Transport Inc.1260 L.T.L.inc.1260 Lahbé autos ( 1964) inc.1260 Labelle électrique inc.1260 Labrador Oil Inc.1260 Labrosse Expansion Bit Corporation.1260 Lachapelle (R.) ltée.1260 Lachine Maroons inc.1260 Lachmas Investments Inc.1260 Lacombe Investments Inc.1260 Lacoste (J.) inc.1260 Laduqucsne inc.1260 Lafond & Valdais inc.1260 Lakeshore Structural Steel Co.Ltd.1260 Laliberté & Fils inc.1260 Lambert (J.M.) automobile inc.1260 Lambert Co.Ltd.1260 Lambert Management Corporation.1260 Laminco inc.1260 Lan bar Construction Corp.1260 136S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9, 1974, Vol- 106, No.6 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Landscape Sales Co.Ltd.1260 Landsman (Sam) Inc.1260 Langco Inc.1260 Laurentian Ski-Doo Centre Inc.1260 Laverdière (J.P.) inc.1260 Léger (O.U.) inc.1260 Lemaire auto inc.1261 Librairie Edibec inc.1261 Ligue de balle molle St-Georges.1261 Ligue de hockey intermédiaire « A » de l'est du Québec inc.1261 Ligue de hockey Laval Senior inc.1261 Ligue des propriétaire de Blainville (La) .1261 Ligue des propriétaires de la ville de Charlesbourg (La).1261 Lingerie Lado inc.1261 Loisirs du lac Massie inc.1261 Loisirs de North Hatley inc.(Les).1261 Loisirs de Venise en Québec inc.1261 Longueuil Plastering Inc.1261 Lou Black's Living Room \" 67 \" Inc.1261 Lubbers (Theodore J.) Co.Inc.1261 M & M Investments lac.1261 Maison Roméo inc.1261 Maisonex ltée.1261 Maisonneuve Metals & Smelting Inc.1261 Maisons économiques B.G.inc.1261 Manoir Ste-Agathe inc.(Le).1261 Maple Grove Island Corp.1261 Maple Leaf Truck Lines Inc.1261 Marine Computer Center Ltd.1261 Mar-Lanlnc.1261 Martin's Drive In Restaurant Inc.1261 Maskinongé Stock Car Inc.1261 Massicotte Transport Inc.1261 Masson (Rodolphe) inc.1261 Master Realties Inc.1261 Master Tilers Corporation.1261 Matol Research Limited.1261 Matte & St-Arnaud automobiles inc.1261 Mi- \\ m Ltd.1261 McDonald-Carticr Ltd.1261 McKay Transport Inc.1261 Mei Lan Inc.1261 Milair Aviation Inc.1261 Mining Company of the North Ltd.1262 Miroir du Québec inc.(Le).1262 Mizener Elevator Company.1262 Mobel construction limitée.1262 Mobilab inc.1262 Mobile Motel Inc.1262 Mobitap ltée.1262 Modal Inc.1262 Molise Paving Co.Ltd.1262 Monacco Development Corp.1262 Monik Realtv Corp.1262 Montreal J.M.Electric Inc.1262 Montreal Switchgcar Inc.1262 Motel Le Bocage Sightseeing inc.1262 Mouvement laïque de langue française.1262 Multiplan Inc.1262 Musée de Lanaudière.1262 Nettoyeur, Magique de l'Outaouais inc.1262 Nettoyeur « Maison Blanche » inc.(Le).1262 Niagara Maintenance Inc.1262 Nielsen (C.B.) & Co.Ltd.1262 Norman (Bruce G.) Limited.1262 O.T.J.De Waterville inc.1262 Oeil 1969 inc.(L').J262 Oucllette & Laforest inc.1262 P.J.B.& Associates Investment Corp.1262 P.N.L.Construction Inc.1262 P.V.C.Isolation inc.1262 Page & Page ameublements inc.1262 Palmer Junior Wear Mfg.Co.Inc.1262 Pamorc Investment Corporation.1262 Pan-Am Equipment and Machinery Ltd.1262 Paname Bistro inc.1262 Parachute St-Jean inc.1262 Paradis (Guy) auto Body Inc.1262 Parant (Pierre) Automobile ltée.1262 Par-Bizinc.I262 Parc Saint-Jovite inc.(Le).1263 Park Construction Ltd.1263 Park Une Gifts Ltd.1263 Park Productions Ltd.1263 Parklaflnc.1263 Parthimos Electric Lampshades Co.Ltd.1263 Pasteur St-Urbain Realty Corp.1263 Pat Realties Ltd.1263 Pâtisserie Rosemont ltée.1263 Patry-Joanis ltée.1263 Peintures libelle inc.1263 Pcllerin (J.L.) inc.1263 Perle du lac inc.(I-a).1263 Pétrole Gazet inc.1263 Pheasant Land Inc.1263 Pino Landscaping Co.Ltd.1263 Place d'Armes St-James Street Victoria Square Businessmen's Association (The).1263 Placements D.L.R.inc.(Les).1263 Placements Gratien Gélinas inc.1263 Placements Karol inc.1263 Placements Lajeunesse ltée.1263 Placements Lamarre ltée (Les).1263 Placements Michel Drolet inc.(Les).1263 Placements de la Montagne inc.1263 Placements Nuckle inc.(Les).1263 Placements Ragilles de Québec ltée (Les)- 1263 Plantation Eden inc.(Les).1263 Plomlwrie Papineau ltée.1263 Plomlierie Paris inc.1263 Plomberie Ste-Madclcine ltée.1263 Poligraphic Label & Tag (Québec) Inc.1263 Port-O-Matique ltée.1263 Produits d'argile de St-Laml>ert ltée (Les).1263 Produits chimiques Cobel ltée.1263 Professional Automobile Salesmen's Association.1263 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 1974, 106' année, n° 6 1369 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Promotions Albany inc.(Les).1263 Promotions succès inc.(Les).1263 Propane Nord inc.1264 Provisions Modernes (Montréal) inc.(Les).1264 Publications Labelle inc.1264 Publications Lamon inc.(Les).1264 Publicité Jen Dro inc.1264 Publicontact Inc.1264 Québec Automotive Industries Limited.1264 Québec Dragway Inc.1264 Québec Elec Inc.1264 Québec Store Inc:.1264 Quick-O-Wash Inc.1264 Railroad Men's Benevolent Fund.1264 Ranch J.N.Inc.1264 Rapid Gro Construction Co.Ltd.1264 ReHecInc.1264 Realty Group Incorporated.1264 Récupération Monda inc.1264 Reproductions artisanales Nouvelle France inc.(Les).1264 Restaurant Etoile Filante inc.1264 Restaurant Le Grand Prix inc.1264 Restaurant Le Poulet & Moi inc.1264 Restaurant les 4 Soeurs ltée.1264 Rivard Auto Body Inc.1264 Ronald Home Parties Ltd.1264 Roux (G.) limitée.1264 S.H.C.Holding Corporation.1264 S.I.V.A.ltée.1264 S & J Associates Incorporated.1264 St-Jacques (J.B.) limitée.1264 St-Jérôme Auto Sport Inc.1264 St-Joseph Jobbing Ltd.1264 St-Lambert tuiles & terrazzo ltée.1264 St-Zotique Restaurant Inc.1264 Salon national Grand Prix ltée.1264 Sauvé (Paul-E.) inc.1264 Savoy (J.) & Cie ltée.1264 Sculpt-O-Matic Inc.1264 Secret de Lorette inc.1265 Séguinel (Jean) inc.1165 Semaines internationales du cinéma (Les).1265 7 jours du cinéma de Hull (Les).1265 Service des boulangeries Labbé & Armstrong inc.(Le).1265 Service Super Sports ltée.1265 Services Kan-Kaf inc.1265 Shirley's Downtown Restaurant Inc.1265 Société d'astronomie de la Mauricie.1265 Société Bogest inc.1265 Société de chasse et pêche Laurentien de Gatineau (La).1265 Société de construction R.M.inc.1265 Société Jennis inc.1265 Société de la jeunesse de Ste-Ursule (La).1265 Société des loisirs et écologie de Waterloo inc.1265 Société Papineau inc.(La).1265 Société Saint-Jean-Baptiste Sainte-Marie (La) 1265 Somaro inc.1265 Southern Industrial Business Sales Ltd.1265 Spic incorporée.1265 Sporbecinc.1265 Sport club de Québec inc.(Le).1265 Star Office Supplies Inc.1265 Starlet Manufacturing Co.Ltd.1265 Station estivale Maskinongé ltée.1265 Steering Ltd.1265 Strathdee's Flower Shop Inc.1265 Studio J.P.M.inc.1265 Studiolith Inc.1265 Substantial Developments of Montreal Ltd.1265 Sullivan (J.W.) Inc.1265 Sully (George) (1958) Inc.1265 Sumac Land Corporation.1265 Sumar Construction Ltd.1265 Swanton Investment Corp.1265 Sydli Inc.,.1265 Systèmes de bureaux St-Laurent ltée.1265 Taverne chez Jos inc.1265 Taverne Pinet inc.1266 Terrebonne Park Estates Ltd.1266 Tétrault (Gérard) ltée.1266 Théberge (Georges) inc.1266 Thru-Way Parking Ltd.1266 Tip Top Leather Goods Mfg.Ltd.1266 Tomeo & Colavecchio Inc.1266 Trans St-Laurent équipement inc.1266 Transport E.L.ltée.1266 Tremblay & Legarde inc.1266 Troupiers de Jonquière inc.(Les).1266 Tru-Acres Inc.1266 Trudel (John) Inc.1266 Tuvaux de béton Mauriciens inc.(Les).1266 20th Century Ladies Wear Inc.1266 Union de parents du Grand Shawinigan (L').1266 Unitech inc.1266 University International Holdings Corporation Ltd.1266 Usinage et soudure Baie Comeau inc.1266 V.L.Auto Body Inc.1266 Val Morin Enterprises Ltd.1266 Valcourt & fils Auto Parts Inc.1266 Veilleux (J.P.) inc.1266 Vies de Granby incorporée (Les).1266 Vincent (J & S) inc.1266 Voghel (J.Louis) ltée.1266 Voyages Solmar inc.(Les).1266 Walter Matic Montreal Ltd.1266 Waterloo Basketball Club.1266 Watt (G.S.) & Associates Ltd.1266 West End Health Studios Inc.1266 Young-1 Inc.1266 1370 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 9.1974, Vol.100, No.G Société d'habitation Québec Housing du Québec Corporation Kénogami, cité-city (Programmede rênovation- Reneical program) (Mod./Amend.).1336 Municipal Housing Bureau of Pointe-Claire (L.P.) .1335 Municipal Housing Bureau of Saint-Anselme (L.P.).1337 Municipal Housing Bureau of Saint-Nicéphore (L.P.).1336 Office municipal d'habitation de Pointe-Claire (L.P.).1335 Office municipal d'habitation de Saint-Anselme (L.P.) .1337 Office municipal d'habitation de Saint-Nicéphore (L.P.).1336 SOUMISSIONS \u2014 demandes de TENDERS \u2014 Requests for Ange-Gardien, par.1345 Beloeil.ville-town.1343 Jacques-Cartier, c.s.-s.b.1347 Rivière-du-Gouffre.munie.1341 Shawinigan.cité-city (Erratum).1355 Val-Mouricie, s.b.(Erratum).1355 VENTES SALES Par Shérifs By Sheriffs Gaspé Gaspé Canadian National Railway N Trachy.1349 Chemins de Fer nationaux du Canada m Trachy.1349 Kamouraska Kamouraska Rivière-du-Loup.c.s.-s.b.es Dumont.1350 Montréal Montreal Artisans, société coopérative d'assuranec-vie (Les) vs Mongrain et al.1352 Butler vs Hishon.1353 Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu r* Dienstab.1351 In the matter of the income Tax Act M Dienstab.1351 I.au: in vs Association coopérative ouvrière de production Les Amis du Québec.1350 London Life Insurance Company vs James 1353 Quebec Québec Québec, ville-city vs Flamand.1354 Taxes Taxes Lac St-Jean-Est, comté.1318 Lake St.John East, county.1318 Levis, comtc-county (Erratum).1355 Maniwaki.ville-town .1325 Papineau.comté-county (Correction).1355 Pointe-aux-Trembles, cité-city.1319 Rouville, comté-county (Erratum).1355 Terrebonne, ville-town.1328 SOMMAIRE Associations coopératives, loi des.1337 Avis divers.1315 Changement de nom, loi du: Accordés.1275 Demandes.1274 Commission des transports du Québec.1287 Compagnies, loi des: Abandon de charte.1273 Changement de nom.1272 Demandes d'abandon de charte.1280 Divers.1283 Lettres patentes (1\" partie).1267 Lettres patentes (3° partie).1270-1315 Lettres patentes {avis de correction).1272 Lettres patentes supplémentaires.1271-1315 Sièges sociaux.1284 Liquidation.1334 Ministères: Affaires municipales.1338 Terres et forêts.1312 Renseignements sur les compagnies: Avis de dissolution éventuelle de corporations.1235 lettres patentes annulées.1253 Société d'habitation du Québec.1335 Soumissions.1341-1355 Ventes: Par shérifs: Gaspé.1349 Kamouraska.1350 Montréal.1350 Québec.1354 Pour taxes.1318-1355 SUMMARY Change of Name Act: Applications.1274 Granted.1275 Companies Act: Applications for surrender of charter.1280 Change of name.1272 Head offices.1284 Letters patent (Part 1).1267 Utters patent (Part III).1270-1315 Utters patent supplementary.1271-1315 Utters patent (notice of correction).1272 Miscellaneous.1283 Surrender of charter.1273 Companies Information Act: Utters Patent Annulled.1253 Notice of Eventual Dissolution of corporations 1235 Cooperative Associations Act.1337 Departments: Lands and Forests.1312 Municipal Affairs.1338 Miscellaneous Notices.1315 Québec Housing Corporation.1335 Québec Transport Commission.1287 Sales: By Sheriffs: Gaspé.1349 Kamouraska.1350 Montreal.1350 Québec.1354 Fou taxes.1318-1355 Tenders.1341-1355 Winding-Up Act.1334 avis de paruHon recueil des ordonnances de la régie des services publics La Régie des Services publics vient de publier toutes les ordonnances qu'elle a émises en matière de services publics entre le 1er juillet 1972 et le 30 juin 1973.320 pages \u2014 prix unitaire : S S Les ordonnances émises entre le 1er juillet 1971 et le 30 juin 1972 sont toujours disponibles : elles ont été publiées sous le titre
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.