Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 15 septembre 1973, Partie 1 samedi 15 (no 37)
[" f* GAZETTF ^ rnr^ SEPTEMBRE ?- N° 37 Off- (2,3/ frit / OFFICIELLE OFFICIAL DU QUEBEC GAZETTE 5319 PARTIE 1 PART 1 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 septembre 1073, 105' année, n' 37 .5321 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.C.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Editeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.!).Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Quebec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.S.The Quebec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Afore-over, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties arc requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHAULES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 5322 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: S5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, S20; du 1er avril au 31 décembre, S15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Editeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, el c.) at double rate.Translation: S5 per 100 words.Single copies: SI each.Slips: S3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, S20; from 1 April to 31 December, S15 and from 1 July to 31 December, 810.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.Eor information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rales to the Québec Official Gazelle, please call: Georges I.apierrc Québec Official Gazelle Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1973, 105' année, n° 37 5 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.Notice of Eventual Dissolution of Corporal ions The Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act.for one year or more; the companies arc consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie .Xame of the company Adresse .1(1(1 re sx Rapports non produits Bel urns not filed A & D.Trans|h)rt Itée.A.L.D.L.Distributeurs ltée.A.P.G.Enterprises l.td.A.S.S.F.Inc.Adanac Briar l'ipe Inc.Administradiin Inc.Agences Baly Assurances inc.Ahuntsic Construction ltée.Alarme de Sûreté (Montréal) inc.Albert Audct limitée.Algol Realty Limited.Ameublement Branchaud Furniture inc.Ameublements Col-Can ltée.Anoki Fish and Came Club.Antoine Lake Fish and Game Club Inc.Les Appartements Igloo inc.Atlantic Oil Products Limited.-Montréal.1971,1972,1973 Saint-Michel.1909,1973 Sherbrooke.1902 à/to 1908, 1972, 1973 Montreal.1972, 1973 Montreal.1909,1972,1973 Quebec.1972, 1973 Montreal.1902, 1903, 1908 A/to 1973 incl.Montréal.1951.1907, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971, 1972, 1973 Val d'Or.1970,1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Maniwaki.1970, 1971, 1973 Québec.1972, 1973 Hull.1932 à/to 1064 inch, 1973 Fort Coulonge.1940 à/to 1905 inch, 1973 Schcflei ville.1972, 1973 Montreal.1907 à/to 1973 incl.Auberge des Grèves inc.Sept-llcs.1901 à/to 1900 inch, 1971 à/to 1973 incl.Audeman Inc.Anglo-French Investments (1900) Corporation.Levis.1972, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl. 5324 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Auto Port Inc.Automation de Qualité de Montréal inc.Aquamex Inc.Aquarius Cleaners Ltd.Artemis Sportswear Ltd.L'Association des Citoyens de la Muuricic.Association des Enseignants Professionnels de la Danse du Québec.Association des Entrepreneurs Pétroliers du Québec inc.Association des Ptopriétaires de St-Louis-dc-Tcrre-bonne inc.L'Association des Propriétaires de la ville de Lebel-sur-Quévillon.Association Québec-France des Jeunes Juristes (AQFJ) Assurance licauHcu inc.Les Assurances Pesant inc.Astra Services Techniques inc.Atelier de formation d'animateur culturel.Atlantic Land Holdings Ltd.Atlantide Realties Ltd.Auberge du Cheval Blanc inc.Norbert Aubin incorporée.Audet Plastics Specialties Inc.Aunis Inc.Aylmer Rod & Gun Club Inc.Bantam Investment & Realty Co.Ltd.Bcauchesnes Club.P.& N\".Beaudoin Construction inc.Beaver Mining Corporation.Beaver Oil Co.Limited.Jean-Marie Bédard inc.Bega Lobster House Inc.Trois-Rivicres.1971 a/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1909 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreul.1972, 1973 Trois-Rivièrcs.1972, 1973 Pointe-Claire.1971, 1973 Montiéal.1972, 1973 St-Louis-de-Tcrrebonne.1970 à/to 1973 incl.Leb?l-sur-QuéviIlon.1971, 1972, 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Sopl-llcs.1972, 1973 Montréal.1972,1973 Montréal.1963, 1964, 1965, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1961, 1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1962,1973 Sherbrooke.1971, 1972, 1973 Bedford.1972, 1973 Aylmer.1961 à/to 1970, 1973 Montreal.1959 à/to 1902 incl., 1964 à/to 1973 incl.Louiseville.1906 à/to 1909 incl., 1972, 1973 St-Rédemptcur.1972, 1973 Montreal.1972, 1973 Montreal.1907, 1970 à/to 1973 Charlesbourg.1970 à/to 1973 incl.-Montreal.1972,1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1073, W5' année, n° 37 5325 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Belvicar ltée.Beleo Realty Co.Bell-Kay Investments Inc.Belmont Coffee Shop Inc.Armand Bibeau Construction inc.Biskcl Investments Inc.Les Boiseries du Manoir inc.Marcel Boisvert Construction inc.Bokor Holdings Ltd.E.Bonelli et F.Tenaglia Monuments inc.Boulevard Homes Improvements Ltd.Gabriel Bourassa inc.Boutique du Cadeau Norske, incorporée.Brake Clutch Service Inc.Brasserie du Capitaine inc.Edouard Brault inc.Geo.Brien inc.Brisson (Fourrures) Itéé.Brookside Furs Ltd.Brunei & Paqucttc inc.Buffalo Converters Company.R.Q.Builders Inc.Bus.Stop Boutique inc.Butterfly International Inc.CP.P.Distributors & Services Inc.Cadeaux - Le Carillon inc.Camp Iroquois inc.Camping des Sportifs inc.Canadian Corps (1914-19) Association in Québec.Canadian Gear-Box Manufacturing Inc.Canadian Weight Losers Club C W L C Inc.Cantex Chemicals & Equipment Corp.Montréal.1972, 1973 Montreal.1968 A/to 1973 incl.Montreal.1972,1973 Montreal.1972, 1973 Montréal.1971,1972,1973 Montreal.1963, 1969 A/to 1973 incl.Ste-Foy.1969, 1970, 1973 Montréal.1965, 1966, 1969 A/to 1973 incl.Montreal.1960 A/to 1973 incl.St-Léonard.1965, 1967, 1971 A/to 1973 incl.Ville Brossard.1903, 1900, 1973 Val d'Or.1972 cl/and 1973 Montréal.1972 et/and 1973 Saint-Léopard.1970 A/to 1973 incl.Sainte-Thérèse.1970 A/to 1973 incl.Montréal.1960 A'to 1965 incl.et/and 1971-1972, 1973 Montréal.1903 à/to 1973 Montréal.1907 et/and 1909 A/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montréal.1960 à/to 1907 incl.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.LaSalle.1907 A/to 1973 Montréal.1970-1972 A/to 1973 incl.Montreal.1971.A/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1907 A/to 1973 incl.Laval.1908 A/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Montreal.1970 A/to 1973 Longucuil.1971 à/to 1973 incl.Montreal.19GG ct/and 1973 incl.Monlieal.1909 à/to 1973 incl. 5326 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Gilles Cantin ltée.Cardinal Air Services Limited.Case Exporters Inc.Catrala Québec Inc.Centennial Enterprises Ltd.Centre de Beauté Naturiste Lafortune inc.Centre International du Cinéma inc.Le Centre de Loisirs de La Pocatière inc.Centre Sl-Jacqucs inc.Cephallonian Brotherhood Society.Cercle combatif contre l'incendie de la province de Québec inc.Jos Chamberland inc.Jean-Marie Champagne inc.Alain Charbonneau inc.Le Château Blanc de Stc-Scholastique inc.Le Château des Monts inc.Chaussures Bellemare ltée.Chaussures Gaétan inc.Chaussures Georgio ltée.Citadel Wholesalers Limited.Edgar Clément limitée.Club automobile P.C.A.inc.Club automobile Waki.Club automobiles de Beaucc inc.Club auto-ncige, lac St-Picrrc inc.Club de baseball junior Sl-lérôme inc.Club de C.et P.frontière.Club de C.& P.gaspésien inc.Club de C.& P.du lac Elgin de Stratford été de Wolfe inc.Club cabane Ernest inc.Club de chasse de la dune inc.Club de chasse et de pèche Bonne Fortune.St-Rcmuald d'Etchemin.\t1969 à/to 1973 incl.Québec.\t1963 à/to 1973 incl.Lorraine.\t1971-1972-1973 St-Laurcnt.\t1971-1972-1973 Montreal.\t1967 à/to 1973 incl.\t1972 ct/and 1973 Montréal.\t1971-1972-1973 La Pocatière.\t1965-1972-1973 \t1960 à/to 1969 incl.et/ai d \t1973 Montreal.\t1900-1908-1973 Montréal.\t19GS à/to 1973 incl.Jersey Mills.\t1906.1969 et/an.1 1971 St-Georges Bec\tà/to 1973 incl.Montréal.\t1972 et, and 1973 Montréal.\t1968 à/to 1973 incl.Ste-Scholastiquc.\t1971 à/to 1973 incl.Sl-Paul-dc-Montminy.\t1972 et/and 1973 \t1972 ct/and 1973 Montréal.\t1972 et/and 1973 Montréal.\t1970 à/to 1973 incl.Montreal.\t1971 à/to 1973 incl.Québec.\t1971.1972, 1973 Montréal.\t1971 et/and 1973 Wceilon.\t1972 et/and 3973 St-Joseph.\t1961 à/to 1973 incl.Stc-Annc-dc-la-\t1967.1972 et/and 1973 Pocatière\t St-.f érôme.\t1972 cl/and 1973 \t1966 à to 1970 incl Ste-Annc-des-Monls.\t1971 à/to 1973 incl.Stratford.\t1909, 1970 ct/and 1973 St-Paul-du-Nord.\t1971 à/to 1973 incl.Ile aux grues.\t1971 et/and 1973 Montebcllo.\t1972 et/and 1973 Nom de la compagnie Adresse Rapports non produits Name of Ike company Address Returns not filed GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1073, 105' année, n° 37 5327 Xom «le la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Club de chasse & pèche ('lenient inc.Club Clatro inc.Club Clerion inc.Club Concorde.Chili du Cran inc.Chili du Crick.Club Croissant d'Or inc.Club Danscrcau inc.Club Dequen.Club des Deux Lacs Outardes inc.Club Diamant inc.Club Doc inc.Club Dollard.Club Drummond Arthabaska inc.Club Elbow.Club Encr inc.Club Epinettc Rouge.Club Esso inc.Club Earlay.Club du Faucon d'Or inc.Club Gagnon.Club La Galette.Club Gar-Lac.Club des Gaspards inc.Club Geldcrt.Club Goéland.Club (ionzague.Club Gustave inc.Club de la Hache inc.St-Ainié-dcs-laes.1955 à/to 1973 incl.Dolbeau.1900 à/to 1970 incl.Rouyn.1959 à/to 1971 incl.et 1973 Montréal.1900 à/to 1973 incl.Aima.1900-1973 incl.Aima.1900 à/to 1973 incl.Escoumins.1900 à/to 1909 incl., et/and 1973 St-llruno.1907 à/to 1909 incl., ct/and 1973 Chicoutimi.1971 àl973 incl.Chicoutimi.1900 à/to 1909 incl.ct/and 1973 St-Narcisse.1900 à/to 1970 incl.Notre-Daine-dcs-l'rairies 1971 àto 1973 incl.Rimouski.1900 à/to 1973 incl.Kingscy Falls.1900 à/to 1970 incl., ct/and 1973 I\u201eaval-des-Rapidcs.1972 ct/and 1973 Cap-de-la-Madeleine____ 1971 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1966 à/to 1973 incl.Rouyn.1966 à/to 1970 incl., ct/and 1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.Windsor.1971 ct/and 1973 Chicoutimi.1966 à/to 1970 incl.1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.Hull.1966 à/to 1973 incl.St-Zénon.1966 à/to 1970 incl.et/and 1973 St-Jérôme.1966 à/to 1971 incl., ct/and 1973 Shawinigan.1960 à/to 1973 incl.Rimouski.1900 à/lo 1973 incl.Jonquière.1971, 1972 et/and 1973 Baic-Sl-Paul.1900 à/to 1971 incl., ct/and 1973 5328 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Club Hélène inc.Club Hilfrcd.Club Hosanna inc.Club de la John.Club Kido inc.Club Kue-Kuc inc.Club du lac Coco.Club du lac Emmuraille inc.Club du lac Fccteau.Club du lac François.Club lac Gerard.Club du lac Isidore.Club du lac Pierre Aubin inc.Club Lasource inc.Club Maskoutain inc.Club nautique des Mille-Îles ltée.Le club optimiste de St-Hyacinthe inc.Club de pêche et chasse du lac Laurel inc.Club de pêche et de chasse Linièrc.Club de pêche Gourgannc.Club de pêche du lac Famine inc.Club de protection de la faune du lac Masson inc.Club des quilleurs du Québec (19G2) inc.Le club de sécurité du transport écolier inc.Club Vautri.Les clubs de Francs, incorporée.Samuel E.Cohen Ltd.Coliseum Diversified Holdings Inc.Commercial Lipho Plate Graining Ltd.Commercial Plastics & Supply Corp.(Québec) Ltd.Concept 2S87139 ltée.Cosec Construction Inc.Ste-Foy.19GG à/to 1973 incl.Forestville.1966 à/to 1973 incl.La Tuque.1966 à/to 1973 incl.Matane.1966 à/to 1973 incl.Dolbeau.1966 à/to 1970 incl., et/and 1973 St-Maurice.1971 ct/and 1972, 1973 Les Escoumins.1906 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1966 à 1973 incl.Mont-Joli.1966 à/to 1973 incl.St-Félicicn.1966 à/to 1970 incl.et/and 1973 Forestville.1971 à/to 1973 incl.Québec.1906 à/to 1970 incl., et/and 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Québec.1967 à/to 1973 incl.Longucuil.1971 ct/and 1973 Stc-Rose.1960 ct/and 1973 St-Hyacinthe.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.St-Côme-de-Kennebcc.1971 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Stc-Rosc-dc Watford.1966 à/to 1973 incl.Lac Masson.1966 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1973 incl.Jonquière.1972 ct/and 1973 Beloeil.1971 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 et/and 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972 cl/ and 1973 Montreal.1967 à/to 1969 incl., ct/and 1973 Montréal.1970-72-1973 Montreal.1969-71 à/to 73 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 197,3, 105' année, u° 37 5329 J.P.Côté assurances ltée.Patrick Côté inc.Côte St-Luc Car Wash Inc.Consolidated Dolsan Mines Ltd.Construction Befor ltée.Construction Norvcx ltée.Conseil économique rural de la région 3.Consumer's Printing Supplies Ltd.Corporation de financement industriel de Portncuf inc.Cosmctrix inc.Counsellor Investment Corporation.Courtemanchc équipement inc.Création de mode écusson inc.Crédit Beaumont inc.Dairy Bam' Stores of Canada Limited.Daroil Construction Ltd.Dasec Inc.Debmark Investments Ltd.Decin Investments Inc.Delco Realty Incorporated.La Délicieuse ltée.Dento Inc.Gilles Deshaies inc.R.Desjardins S.O.S.Manitenance Ltd.Les développements des beaux quartiers ltée.Distributeurs Montmorency limitée.Distribution Capitale ltée.Les distributions mini-maxi (Joliette) inc.District Finance Corporation Limited.Domaine Chambery ltée.Le domaine du Lac Louise inc.Domaine Mon Plaisir inc.Les domaines Fontainebleus ltée.Repentigr.y.\t19G9 et/and 1973 Charlcsbourg.\t1972 ct/and 73.Montreal.\t1966-1970 à/to 73 incl.\t1958 ct/and 1973 Ixmgueuil.\t1972 et/and 1973 Carleton.\t1971 ct/and 73.Québec.\t1971 à/to 1973 incl.Montreal.\t1970 à/to 1973 incl.Donnacona.\t1971 à/to 1973 incl.Montreal.\t1971 A/to 1973 incl.Québec.\t19G7, 19G9 à/to 1973 incl.Mont-Laurier.\t1961 à/to 1969 inch.\t1970 à/to 1973 incl.Montréal.\t1972 et/and 1973 Victoria ville.\t1972 et and 1973 Montreal.\t1971 à/lo 1973 incl.Hampstcad.\t1971 à/to 1973 incl.Montreal.\t1970 à/to 1973 incl.Montreal.\t1969 à'to 1973 incl.Montreal.\t1963, 1970 à/to 1973 Montreal.\t1966, 1967, 1969 à to 197 \tincl.Montréal.\t1970 à/to 1973 incl.A font real.\t1972 ct/and 1973 Victoriaville.\t1972 ct/and 1973 Montreal.\t1972 et/and 1973 incl.Montréal.\t1967, 1969 à/to 1973 incl.Afontreal .\t1970 à/to 1973 incl.Montréal.\t1968-69-70-71-72-73.Joliette.\t1971 à/to 73 incl.Sherbrooke.\t1969-70-71-72-73.Lucerne.\t1972-1973.Saint-Louis-de-Bland-\t1972-1973.ford\t Stc-Sophie.\t1971-72-73.Montréal.\t1971 à/to 73 incl.Nom de la compagnie Adresse Rapports non produits Name of the company Address Returns not filed 5330 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits * Returns not filed Dorchester Mini-Market Limited F.Drapeau Transport Inc.Dumoulin Automobile inc.Dunn's Men's Wear Inc.Dunton Investments Ltd.André Durivage Lamarre Productions Inc.Dutex Co.Ltd.E.& M.Promotion Sales Ltd.Kbénislcric Ami inc.Économie sociale ltée.Edifico Inc.Les Éditions L'Action inc.Les Éditions musicales Parma inc.Éditions situation inc.Les Éditions solutions ltée.E.& G.Car Wash Service Ltd.Eflol Inc.Egeco ltée.Electro SQL Inc.Entrepôts Bona venture liée.Entreprises Beaubien inc.Montreal.1972-73.Saint-Julie.1972-1973.Dorion.1958 à/to 63, 67, 71 à/to 73 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1972, 1973.Montreal.1972, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1915 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.St-Eustache.1903, 1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973.Montréal.1972 et /and 1973 La Salle.1972 ct/and 1973 Montreal.1972 ct/and 1973 Montréal.1972 et/and 1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 ct/and 1973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Les entreprises Huard inc.Pcaucevillc.1972 ct/and 1973 incl.Les entreprises de Foy inc.Québec.195S, 1969 à/to 1973 incl.Les entreprises Dimco liée.Donnacona.1972,1973 Les entreprises J.M.inc.Québec.1963 à/to 1973 incl.Les entreprises Pointe Valaine ltée.Ottcrburn Park.1971, 1972, 1973 Les entreprises Roland Daiglc inc.Orsainville.1971 à/to 1973 incl.St-Adolphc d'Howard .1967 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 .Montreal.1967, 1968, 1973.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.xMontrcal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Entreprises St-Adolphe inc.Esker Québec Mines Limited.Esman Investment Corporation.Esquire Really Corp.Europe Plastic Moulds, Tools & Dies Ltd.Exeter Investments Ltd.Falcon Construction Corp. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 septembre 1073, 105' aimée, u° 37 5331 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Farnham Woodwork and Supplies Ltd.Federal Plastics Ltd.Federation des archers du Quebec.Fédération haltérophile du Québec.Ferco Paints & Machinery Rentals Ltd.P.R.Finance Inc.Findec Investments Inc.Flash Screen Process Inc.Focal International Inc.J.M.F.Fortin inc.Fournitures chirurgicales du Québec ltée G.M.C.Excavation Inc.Marcel A.Gagnon & associés inc.Gai Logis inc.Garage Aimé Bourassa inc.Fernand Gaudrcau.A.Gauthier & fils ltée.General Builders Association.Roch Giard ltée.Gif Bec ltée.Gita International Inc.Gold Medal Developments Inc.A.Goodis inc.1.A.Gosselin liée.(ïranow Incorporated.Hampstead Golf Club lue.Haro Industries Limited.Ilartland Acceptance Corp.Guy Hébert inc.1'.N.Hickey Limited.Hope Realties Inc.Hotel Motel Tapance Inc.Farnham.1958-59 - 1963 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 T rois-Rivières.1971 ct/and 1973 Québec.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 66-6S 73 incl.Ste-Foy.1972 ct/and 1973.Montreal.1963, 70 à/to 73 incl.Montreal.196S-1973 Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1962-64-65-67 à/to 71 cl,/ and 73 Montréal.1966 à/to 1970 incl.et/and 1973 La Salle.1972-1973 Montréal.1906-67-72-73 incl.Québec.1966 à/to 73 incl.Grand'Mèrc.1969-71-73 incl.Rouyn.1971 à/lo 73 incl.Yamachiche.1972-73 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Granby.196S-69-73 incl.Québec.1972 ct/and 1973.Montreal.1970 à/lo 73 incl.Montreal.1959, 63 à/to 66 incl.68, 70 à/lo 73 incl.Montreal.1967 à/to 73 incl.St-Romuald d'Etchemin.1972-73 incl.Montreal.1966 à/to 71-73 Granby.1910-41-42-64-66-67-70 à/to 73 incl.Laval.1970-72-73.Montreal.1961, 73 incl.Saint-Samuel.1972 et/and 1973 Montreal.1972-73 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Stc-Anne-du-Lac.1971 à/to 1973 incl. 5332 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Howark Corp.Ltd.Westmount.1970 à/to 1973 incl.Hy Fashion Millinery Inc.Ideal Development Co.Ltd.Les immeubles Beauharnois inc.Immeubles de la Grand Route inc.Immeubles Imperial ltée.Importations Narbonne inc.Les importations Taron inc.Les industries Péloquin ltée.Inter-City Commercial Inc.R.S.Investment Co.Ltd.Isacclla Investments Ltd.Issbro Investments Inc.Jafra Inc.Jaymar Construction Ltd.La Jeune Chambre de La Sarre inc.Joliette Plomberie & Chauffage inc.Kabigx Ltd.Kar-Din Sales Inc.Mack Kaufman Inc.Kiba Inc.Alex Kindler Inc.Knopp's Coiffure Co.Aldex Krishna Inc.L.D.Sport Wear Inc.Labclle Associates Inc.Lac Echo Development Inc.Laine Longucuil Inc.LapCO Construction Inc.François Lapointe inc.Latvian Camp Eglaine Inc.Laurcntian Garden Development Ltd.Laurentide Mobile Homes Inc.Montreal.1965-66-73 Montreal.1972 ct/and 73 Beauharnois.1972 ct/and 73 Montréal.1964 à/to 1968 incl.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Saintc-Foy.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montreal.1959, 60, 70 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 73 incl.Montreal.1902-73 Montreal.1903-70 à/to 73 incl.St- Jérôme.1909-72-73 Montreal.1972 et/and 1973 La Sarre.1908-71 à/to 73 incl.Joliette.1970 à/to 73 incl.Montreal.1971 à/to 73 incl.Montreal.1909 à/to 73 incl.Montreal.1905-72 et/and 73 Montreal.1970 à/to 73 incl.Mont-Royal.1907-09-70 a/to 73 incl.Montreal.1900 à/to 73 incl.Montreal.1908 à/to 73 incl.Princeville.1970 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1963-1966 à/to 70 incl., ct/and 73 Montreal.1967, 1972 et/and 1973 Arvida.1970 à/to 1973 incl.Tadoussac.1972 cl/and 1973 Laval.1969 et/and 1973 Montreal.1972 ct/and 1973 Yaudreuil.1959 et/and 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1973, 105' année, u° 37 5333 Nom do la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Belarus not filed G.L.Optica! Industry Inc.P.A.R.Transport Inc.P.M.Packers Limited.P.S.I.Manufacturing Limited.Papeterie St-Laurent inc.O.Paradis inc.L.Patcnaudc Auto Centre inc.Léonard Patry ltée.Periodica Inc.Penna-Roc Inc.Laval Embellissement ltée.I.awbar Company Ltd.Ledair Holdings Inc.Ledan Investments Inc.Ligue de ballon sur glace de Victoriaville inc.La Ligue des Propriétaires de St-Eustachc ouest inc.La Ligue Vieux Poêle d'Arvida inc.Linen Distributors Ltd.Lingerie Idéale de Saint-Victor.Lithographie Versailles inc.Little Sue Creations Inc.Livra Transport Inc.Location de Mini Auto Chicoutimi inc.Logis (Québec) inc.Lotissement Québec ltée.Luinic limitée.Luso Sporting of Montreal Inc.Luxor Construction inc.M.13.Monuments Ltd.M.X.L.F.Inc.Machinerie St-Mauricc inc.Machinerie Tousignant inc.Montreal.1972 ct/and 1973 Montreal.1972 et/and 1973 Mingan.1972 ct/and 1973 Pointe-Claire.1971 à/to 1973 incl.Tracy.1972 et/and 1973 Montmagny.1971 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Hull.1968, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/lo 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montréal.1966, 1967, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/lo 1973 incl.Montreal.1971, 1973 Montreal.1965, 1973 Victoriaville.1971, 1973 St-Eustache.1955, 1956, 1971 à/to 1973 incl.Arvida.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971,1973 St-Victor.1961 à/to 1963, 1966 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1971 incl., ct/and 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Chicoutimi.1971 et/and 1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 ct/and 1973 Montréal.1972 ct/and 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Laval-des-Rapides.1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970-1973 Montreal.1966 à/to 1968 incl., et/and 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 ct/and 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl. 5334 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Les Machineries Lcma ltée.Maclar Corp.La Maison Mademoiselle de Paris liée.Maisons Modulaires inc.Jean K.Malouf inc.Manseau Milling Ltd.Mansville Uranium Ltd.Maple Cleaning Center Inc.Marché-Escompte de Québec inc.Marotte Transport inc.Mazelle inc.Mccanodrome St-Gcorgos inc.Mcc-Paco inc.Mercerie Paul-Aimé liée.Merit Furs Inc.Les Meubles B.D.(09) inc.Meubles Bellehumeur ltée.Les Meuniers Suprêmes limitée.Milan in Investments Inc.Mirad Inc.Model Manufacturing Corp.Les Modes Donali inc.Montage Productions inc.Mont Ste-Adèlc Lodge Inc.Montreal Air Leasing Inc.Montreal Chinese Development.Montreal Commercial Foreign Trade Company Ltd.Multi Development Co.Ltd.Municipal Mortgage Corporation Ltd.Mustang Mines Limited (No Personal Liability).Nadmor Realties Co.Nesger Investments Inc.Nilo Investment Corp.Bedford.1972 ct/and 1973 Montieal.1972 et/and 1973 Montréal.1971 à/lo 1973 incl.Sic-Adèle.1909 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/lo 1973 incl.Manseau.1068, 1909, 1970 et/and 1973 Mont-Laurier.1909 à/to 1973 incl.Châtcauguay.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Montréal.1909 à/to 1973 incl.Saint-Georges.1909 à/to 1973 incl.St-Antoinc des Lauren- 1972, 1973 tides.Maricville.1905 à/to 1973 incl.Montreal.1909 à/to 1973 incl.Montréal.1909, 1972, 1973 Val d'Or.1971 à, to 1973 incl.Jonquière.1971 à; to 73 Montreal.1903-70 à/to 73 incl.Québec.1970 à, to 73 incl.Montreal.1909 à/to 73 incl.Montréal.1972 et/and 73 Montréal-Nord.1972 ct/and 1973 Sainte-Adèle.1909-70-71-72-73 incl.Dorval.1900 et/and 1973 Montreal.1900-07-1909 à/to 73 incl.Mont-Royal.1909-70-71-72-73 incl.Québec.1972 ct/and 73 Montreal.1901-04-05-71-72-73 Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1959-04-00-72-73 Montreal.1903-70 à/to 73 incl.Ahuntsic.1900-03-05-00-70 à/to 73 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 197.% 105' année, u° 37 5335 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed 980 St.Antoine Ltd.Noark Holdings Ltd.Norcanda Québec Limited.Nordex Development Ltd.Norgrev Construction Ltd.Noithview Restaurant Ltd.Norval Investment Corporation.O'Malley Brewery Ltd.O'Neil Paints Inc.L'Oeuvre des Terrains de Jeux de l'Assomption.Olive Electro Dynamics Inc.Olympia Aluminum Mfg.Ltd.Personal Credit Assistance Ltd.Pestico ltée.Phillips Square Properties Limited.Plioebus Imports Inc.La pierre de taille Archambault ltée.Roger Pilon construction inc.The Place for Steak Inc.Les placements industriels du Québec limitée.Les placements Lyon ltée.Les placements Tracy inc.Placeroy inc.La plomberie Sicotte ltée.Point Realties Inc.J.A.Poirier limitée.Les ponçages industriels inc.Pont Viau Land & Housing Corp.Posteritex inc.Pratte & Company Limited.Precision Steel Rule Dies Ltd.Montreal.19(19 à/lo 1973 incl.Montreal.1972-73 incl.Montreal.1958, 1972, 1973 Montreal.1959 à/to 1973 incl.Montreal.1955, 1956, 1970 a/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1960, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Georges.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971, 1972, 1973 Montreal.196S à/to 1973 incl.II ' Montreal.197,1 à/to 1973 incl.St-Eustachc.1972 ct/and 1973 Montreal.196S, 1972 ct/and 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 ct/and 1973 Dollard des Ormeaux .1972 ct/and 1973 Montreal.1965 ct/and 1973 Thctford Mines.1965, 1966 et/and 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Sorcl.1971 à/to 1973 incl.Québec.1968, 1970.1972 et/and 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1956, 1964 à/to 1968 incl., 1972 et/and 1973 Granby.1969 à/to 1973 incl.Mont-Saint-Hilaire.1972 et/and 1973 Montreal.1958,1961,1965, 1967 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Quebec.1968 ct/and 1973 Montreal.1965, 1967, 1969 à/to 1973 incl. 5336 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Préville Associates Inc.Les productions Da Sylva inc.Les productions Hyd inc.Les productions Mojack inc.Les produits laitiers intcr-provinciaux ltée.Les produits 'Pino inc.Progressives Books et Periodicals Ltd.Promotions de travail de Montréal ltée.Prompt Taxi Association Ltd.Les propriétés métropolitaines ltée.Québec Forged Products Ltd.Québec Tea Ltd.Queen's Hotel (Montreal) Limited.R.P.M.Garage Inc.Radairco inc.Raspberry Mahogany Shops Inc.Regent Construction Management Inc.Rcislcr & Weisbord Inc.Rela Construction Co.Ltd.Le réseau électrique Potvin ltée.Restaurant Le Campeur inc.Restaurant Le Florence inc.Restaurant Mambo inc.Restaurant Le Nocturne inc.Restaurant Le Vieux Amsterdam inc.Restaurant Lchoux inc.Richelieu Woodworking Ltd.Rigaud fonderie ltée.Riva Realty Inc.Robitaille Electric Corporation.Rofdub Investments Inc.Roland Shell Service Inc.Montreal.' 1956, 1957 1963 à/to 1973 incl.Montréal.1972 ct/and 1973 Montréal.1965 à/to 1968 incl., ct/and 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Granby.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montreal.1964, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1961,1962,1964.1966, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Québec.'.1972 et/and 1973 Laval.1972 ct/and 1973 V.St-Laurent.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1967,1968, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1967 ct/and 1973 Montréal.1968 à/l.o 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/tb 1973 incl.Thctford Mines.1972 ct/and 1973 St-Jean.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1963, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.i 1966 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1970 à/to 1973 incl Lebel-sur-QuévilIon.1970 à/to 73 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1973, 105' année, n° 37 5337 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Rol-Art Sales Col.P.Roy & fils ltée.S.A.U.S.inc.S.& C.Shirt Corporation.S.O.S.taxi ltée.St-Louis Rancho Inc.St.Thérèse Investment Corp.Salem Exploration Limited.Salon Pierre Daoust inc.Screen Process Sales Co.Seagull Prk Co.Ltd.Seawood Investment Corp.Securibcc inc.Service Esco ltée.Servoparc inc.Snowdon Sauvé Ltd.La société Paul Dubord limitée.St.Martin Development Corp.Sherbrooke Steak House Inc.Sibcr Construction Inc.Sijan Construction Inc.Silcan Mines Ltd.Société de criminologie du Québec.La société G.B.R.inc.Société immobilière L.L.G.inc.Société Nuclctron inc.Sociex inc.Socrates School Bus Service Ltd.Solibec Inc.Southern Holdings Corporation.Le Sorelois ltée.Spécialités Macla inc.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1901, 1965, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1956, 1967, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1969 à 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1967 à/to 1973 incl.Mont-Laurier.1971 à/to 1973 Incl.Montreal.1963-65-71-72-73 incl.Montreal.1969 à/to 73 incl.Montreal.1959 à/to 62 incl., 64-65-66-72-73.Québec.1971 à/to 73 incl.Montréal.1969-73.Montréal.1960-68 à/to 73 incl.Montreal.1968 et/and 73.Montréal.1972 ct/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1971 à/to 1973 incl.St-Léonard.1971 à/to 1973 incl.St-Eustachc.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972 ct/and 1973 Magog.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 73 incl.Montreal.1972 et/and 73 Rcpentigny.1971 à/to 73 incl.Montreal.1959 à/to 73 incl.Sorcl.1960-67-70-73 Stc-Foy.1972 ct/and 73 533S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Nona de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed The Stamp Mart Inc.Stanwood Precision Corp.Steinberg Agencies Limited.Stelat Investments Inc.Studio d'amaigrissement forme miracle de Trois-Ri-vières inc.Studio 437 inc.Sunnyside Properties Inc.Sunset Sportswear Inc.Super marches Unmet inc.Suscon Corporation.Southgate Graphics Ltd.Robert T.Swinton Inc.Syndicat des consommateurs du guide italien inc.T.& T.Cleaners Inc.Tapis Longueuil inc.Jean-Marc Tardif inc.David Tarlo Corp.Télé-couleur atlantique ltée.Templeton Development Corporation.Tcrko Investment Corp.Terrace Lacordairc Inc.Terre noire transport inc.Théâtre des' prairies.Le tlieatrix.Thermo-Pan Inc.Thruway Auto Centre Inc.Titanic Development Limited.Trapper Québec Inc.Troy Investments Ltd.Twin Pinnacle Towers Corp.Unity Land & Housing Ltd.Universal Concrete Services Ltd.¦Montreal.196S à/to 70 incl.et/and 73 Montreal.1972 et/and 73 Montreal.1972 ct/and 73 Montreal.1963-70 à/to 73 incl.Trois-Rivières.1972 et/and 73.Québec.1967 à/to 73 incl.Montreal.1963-70-72-73 Montreal.1972 el/and 73.Relocil.196S-70 à/to 73 inc!.Montreal.1971-72-73 Rrossard.1971 à/lo 73 incl.Montreal.1964-65-70 à/to 73 incl.Montréal.1966 à/to 73 incl.Montreal.1969 à/lo 73 incl.Longucuil.1967 à/lo 1973 incl.SteFoy.1972,1973 Montreal.196S, 1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.Montreal.195S à/lo 1973 incl.Montreal.1959 à/lo 1962, 196S, 1969, 1972, 1973 Montreal.1967,1973 Greenfield Park.1967 à/lo 1973 incl.Juliette.1967, 1970 à/lo 1973 incl.Longueuil.1966 à/to 1973 incl.Scpt-Iles.1972, 1973 Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Sherbrooke.1966, 1967, I960 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/lo 1973 incl.Montreal.1972,1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Wcstmount.1967, 1969, 1972, 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1973, 105' année, n° 37 5339 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Valetaille inc.Montreal.1970,1972,1973 Raymond Vcndctlc ltée.Laval.190S A/to 1973 incl.Ville Émard Packaging Company Ltd.Montreal.1971, 1972, 1973 Ville St-Pierre Taxi Ltd.Westmount Business Services Inc.Wilrich Realty Co.Ltd.Window Cleaning Service Ltd.Winikoff Inc.World Wide Map Inc.Worldwide Holiday Club Inc.X-L Screw Mfg.Co.Ltd.York Investment Co.Ltd.Young I Inc.Antoine Zacharie limitée.Zego Ltd.Zenon Ilellcro.se inc.Zikron Enterprises Ltd.A & G Zillmann Inc.Zlala Praha Club Inc.St-Pierre.1970 A/to 1973 incl.Montreal.1972,1973 Dorval.1960, 1968, 1970, 1973 Montreal.1941, 1971 A/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1967 A/to 1973 incl.Dorval.1969, 1973 Montreal.1971 A/to 1973 incl.Montreal.1967, 1973 Côte St.Luc.1971 A/to 1973 incl.Sacré Coeur de Jésus____ 1972, 1973 Montreal.1972,1973 Joliette.1969 A/lo 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.St.Michel.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Le directeur du service des compagnies, 53477-0 Pierre Desjardin's.Lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.Pierre Desjaruins, 53477-0 Director of the Companies Service.Letters Paient Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4.5a and following of the Compamea Information Act, the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazette of this second notice.Xom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date L'aide à l'éducation borroméenne inc.Ambassador Clothes Ltd.La compagnie Ludger Leblanc inc.Les habitations Duchesnes inc.Ludger Leblanc Limitée.Sherbrooke.16 04 42 Montreal.09 11 66 Amqui.11 09 58 Val d'Or.11 07 67 Amqui.10 08 50 53-10 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Nom do la compagnie Name of the company Adresse Add reus Incorporation Date Marie-Marthe Morin inc.Modern Fabrics Inc.J.Scrrcntino Construction Corporation Space Research Corporation.Montréal.19 11 08 Montreal.12 05 09 Montreal.24 05 03 Chicoutimi.;.24 OS 53 Le directeur du service des compagnies, 53477-0 PlKKKK Dksjahdins.43477-0 ; Piberé Desjardins, Director of the Companies Service.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Lettres patentes (!\"\" partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies The Minister of Financial Institutions, Companies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres to Part I of the Companies Act, he has granted letters patentes constituant en corporation: patent incorporating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date Aluminium Tremblay (1973) limitée.Café Paris Chan ltée.Chan Paris Cafe Ud.Centre de Motoneiges Laval inc.Centre du Camion Mercier inc.Mercier Truck Center Inc.Confection Royale liée.Royal Confection Ltd.Décor Jacques ltée.Editions Elysée inc.Électro-Meubles Soucy ltée.Soucy Electro-Furnitures Ltd.Les Encans d'Animaux de Levis inc.Les Entreprises Normand Choinièrc inc.Les Excavations Chénard inc.Chénard Excavation Inc.Fer et Métal Sic-Agathe inc.Sic-Agathe Iron and Metal Inc.205, Dorchester Sud, Québec.20 07 73 Rouyn.10 07 73 Montréal.00 08 73 222, rue St-Jean-llaptiste, Mercier.17 08 73 1401 Legcndre West, Montreal 354.OS 05 73 1591, l.ottinvillc, Saint-Paulin.00 00 73 7925, rue Kingsley, Montréal.23 08 73 Port-Cartier.13 OS 73 Lévis.10 08 73 Promont.23 07 73 4000 Orchard, Saint-Hubert.00 OS 73 1045, Route 11, Val-David.12 07 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1973, 105' année, n\" 37 5341 Nom / Name Incorporation Siège social / Head Office Date Douville.11 07 73 Beauport.14 08 73 Montreal.13 06 73 Hangar numéro 2 de l'Aéroport municipal 17 07 73 de Saint-Jean, Saint-Jean.Montreal.09 01 73 1737, rue Boudrias, Saint-Laurent.07 08 73 Québec.20 07 73 Saint-Joscph-dc-la-Rivièrc-Bleuc.20 07 73 Shawinigan.09 08 73 415, rue Collard ouest, Aima.00 07 73 Laval.-.01 08 73 109, 2e Avenue est, La Sarre.18 07 73 3194, rue Beaubien est, Montréal.30 07 73 Saint-Jean.02 08 73 105, rue St-Louis, Rimouski.08 08 73 Sainte-Edwidge.03 07 73 Montreal.03 08 73 Saint-Jean-Chrysostomc.22 08 73 Hartley Canada ltée.Monique Hébert inc.Junex inc.Lignes Aériennes Astro inc.Astro Airline Inc.Locations Protrail ltée.Prolrail Rentals Ltd.Les Modes Bulle inc.Multigest inc.Gérard L.Oucllet inc.l'arc Louis IX inc.Place de l'Entraide d'Alma inc.Place St-Martin inc.Les Placements Fernand Doyon inc.Fernand Doyon Investments Inc.Quincaillerie Beaubien inc.Jean-Luc Roy inc.CE.St-Pierre inc.Scalabrini & Fils inc.Textiles Trans-Contincntal ltée.Trans-Continenlal Textiles Ltd.Les Transports de Pétroles, Québec liée.Petroleum Transport, Québec Ltd.Le directeur du service des compagnies, 53477-0 Piekhk Desjaruins.53477-0 Pi euh e Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes (.l\" partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies The Minister of Financial Institutions, Companies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres to Part III of the Companies Act, he has granted patentes constituant en corporation: letters patent incorporating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date Association B.C.S.B.C.S.Association.Association de Ski Nautique de la Région de Québec inc.Lennoxvillc.23 05 73 Québec.10 08 72 5342 QUÉBEC OIE ICI AL GAZETTE, September J.r>, 1975, Vol.105, No.37 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date L'Association des Parents de Langue Française de Mont-Royal inc.Centre de Référence et d'Information de la Côtc-du-Sud, inc.Le Centre La Bonté inc.Club de l'Âge d'Or St-.Iean-Baptiste inc.Le Club Social Les Termites inc.Comité des Citoyens du Lac René inc.Les Dames Philanthropiques de Fort-Coulonge.Kcolc Jésus-Marie de Bcauccville.École St-Clémcnt, 15G0, boulevard Laird, 11 07 73 Montréal 304.Montmagny.10 08 73 470, Place du Collège, app.2, Longueuil.05 02 73 Montréal.30 03 73 Wccdon.05 07 73 Lac René, Lesage.15 08 73 Fort-Coulonge.30 07 73 Bcauccville.28 00 73 Le directeur du service des compagnies, 53477-0 Pierre Desjaudins.\tPierre Desjahdins, 53477-0 Director of the Companies Service.(Lettres patentes supplémentaires)\t(Supplementary letters patent) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a accordé des lettres patentes supplémentaires à:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Incorporation Nom / Name Date\tL.P.S./ S.L.I'.Modifications Date Changes Auto Latulippe & Dumas inc.27 00 08 Lalulippc & Dumas Auto Inc.\t19 07 73 Ancien nom / Former name: Garage Thébergc & Dumas inc.Boutique Mi-Lainc inc.13 05 08 Charbonneau, Guérin & Associés inc.24 01 73 30 07 73 La Compagnie de Transport Général 23 01 09 Labergc ltée Jerbin Investments Ltd.Placement Jerbin ltée Lave Auto Asbestos inc.20 07 72 27 05 08 10 07 73 1) Ancien nom / Former name: Raphael '07 (Quebec ) inc.2) Etendant les pouvoirs/Extending Ike powers.Ancien nom / Former name: Conseillers en Administration Charbonneau, Guérin & Associés inc.21 07 71 1) Modifiant le capital \\ Altering the capital 2) Modifiant, certaines dispositions des lettres patentes/Amending certain provisions of the letters patent 02 OS 73 Modifiant le capital / Altering the capital 00 07 73 Ancien nom / Former name: Garage Paquette & Bergeron inc. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1073, 105' année, ti° 37 5343 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes Mackay Smith Cleaners Ltd.14 07 67 12 07 73 La Plume Rouge-Région Adminis- 09 02 45 24 08 73 trative de Québec United Wurchousc Ltd.02 11 50 25 07 73 Modifiant le capital/Altering the capital 1) Ancien nom / Former name: Conseil îles Oeuvres et du Bicn-Etrc de (Québec.2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes/Amending certain provisions of the letters patent Modifiant le capital/Altering the capital Le directeur du service des compagnies, 53477-0 Pierre Desjardiks.53477-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.(Lettres patentes) Avis de correction (Letters patent) Notice of correction Le ministre «les institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a autorisé la correction de lettres patentes suivantes: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has authorized the correction of the letters patent, issued to the following companies or corporations: Nom / Name Siège social Incorporation Head office Date Modifications Corrections Jim Russell International Racing Drivers' School (Canada) Ltd.Montreal Hustam Holdings Limited.Côte-Saint-Luc Les Gestions Rustam limitée 26 11 69 Corrigeant le nom - ancien nom / Correcting the name - former name Jim Russe 1 International Racing Drivers' School (Canada) Ltd.28 06 73 Remplaçant le nom de la compagnie-ancien nom / Replacing the name of the company - former name Rustam Holdings Limited / Les Placements Hustam limitée \tLe directeur du service des compagnies,\t\tPierre Desjardins, 53477-0\tPierre Desjardins.\t53477-0\tDirector of the companies service.\tSièges sociaux\t\tHead Offices \t3 R inc.\t\t3 R Inc.La compagnie « 3 R inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2261, chemin Rockland, bureau 104, Mont-Royal 304, au numéro 3030, boulevard Laurier, Sainte-Foy.Le secrétaire, Pierre Buousseau.53502-o 6197-68 Notice is given that \"3 R inc.\" has transferred its head office from 2261 Rockland Road, Room 104, Mount Royal 304, to 3030 Laurier Boulevard, Ste.Foy.53502 Pierre Buousseau, Secretary.0197-6S 5344 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Les Boisés Mirabel Limitée Avis est donné que la compagnie « Les Boisés Mirabel Limitée », constituée par lettres patentes datées du 22 août 1973 et ayant son siège social à Montréal a établi son bureau principal à 6410, 44ième Avenue, Rosemont.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, P.Q., ce 22e jour d'août 1973.Le président, 53490-o F.A.Chefteciii.Car-I.an Inc.Avis est donné que la compagnie « Car-Lan Inc.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, S.R.Q 1964, ch.271, en date du 16 avril 1973 et ayant son siège social dans la ville de Sherbrooke, province de Québec, district de St-François, a établi son bureau au numéro 6 de la rue Wellington sud.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Sherbrooke, ce 23e jour d'août 1973.Le président, 53492-0 Andh'é Langi-ois.Les Boisés Mirabel Limitée Notice is hereby given that \"Les Boisés Mirabel Limitée\", incorporated by letters patent dated August 22, 1973 and having its head ollice in Montreal has established its head office at 6410 - 44th Avenue, Rosemont.From and after the date of the present notice, the said ollice is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, P.Q., this 22nd day of August, 1973.F.A.ClIEFTECW, 53490-o President.Car-Lan Inc.Notice is hereby given that \"Car-Lan Inc.\", incorporated under the Companies Act, H.S.Q 1961, ch.271, dated the 16th of April 1973 and having its head office in the City of Sherbrooke, province of Québec, district of St.François has established its office at 6 Wellington Street South.From and after (he date of this notice the said office will be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Sherbrooke, this 23rd day of August 1973.An due Lanci.ois, 53402-o President.Centre d'Achat Lachcnaic ltée Lachenaic Shopping Centre Ltd.Avis est donné que la compagnie « Centre d'Achat Lachenaie ltée \u2014 Lachenaic Shopping Centre Ltd.», constituée en corporation selon la première partie de la Loi des compagnies en date du 23 juillet 1973 et ayant son siège social dans Montréal, a établi son bureau au no 5950 de la rue Côte des Neiges, Suite 203, Montréal, où clic avait son bureau situé jusqu'à aujourd'hui, l'a transporté à 5858 de la rue Côte des Neiges, Suite 210.Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Québec, ce 13c jour d'août 1973.53493-0 Man S.Kaufman, c.h.Compagnie Provinciale d'Antirouille (Québec) ltée Provincial Rustproofing Company (Québec) Ltd.I>a * Compagnie Provinciale d'Antirouille (Québec) ltée \u2014 Provincial Rustproofing Company (Québec) Ltd.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Québec, au numéro 374 rue Notre-Dame nord, Thetford Mines.Le secrétaire, PlEHHE Dozoïs.53494-0 720760 Centre d'Achat Lachenaie ltée Lachenaic Shopping Centre Ltd.Notice is given that \"Centre d'Achat Lachenaie ltée\u2014 Lachenaie Shopping Centre Ltd.\", incorporated under Part I of the Companies Act on July 23, 1973, and having its head office in Montreal, has established its office at 5950 Côte des Neiges Street, Suite 203, Montreal, where its office was located until the present day, has transferred said ollice to 5S5S Côte des Neiges Street, Suite 210, Montreal.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Dated at Québec, this 13th day of August.1973.53493 Man S.Kaufman, u.c.Compagnie Provinciale d'Antirouille (Quebec) ltée Provincial Rustproofing Company (Québec) Ltd.Notice is given that \"Compagnie Provinciale d'Antirouille (Québec) ltée \u2014 Provincial Rustproofing Company (Québec) Ltd.\" has transferred its head ollice in Québec, to 374 Notre-Dame Street North, Thetford Mines.Pierre Dozoïs.Secretary.53494 720700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 septembre 1973, 105' année, »i° 37 5345 François Brault incorporée La compagnie « François Brault incorporée » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2207, rue Marcil, Montréal, au numéro 81, 1ère Avenue nord, Roxboro.Le secrétaire, Roger Lenoih.5349 l-o 3352-71 Dominion Dry Milk Limited La compagnie « Dominion Dry Milk Limited » donne avis qu'elle a transféré son siège social du 4941, rue Coronet, Montréal, au 2300, chemin Lucerne, Pièce 8, Mont-Royal.Le secrétaire, Kathleen M.Connolly.53495 11051-01 Roland Dumas lice Avis est donné par la compagnie « Roland Dumas ltée», constituée en corporation par lettres patentes CD date du onze juin mil neuf cent soixante-treize et ayant son siège social dans la Ville de Matane, qu'elle a établi son siège social au i\\o 178 de la rue St-Raymoinl à Matane.A compter de la date du présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Matane, ce 28 août 1973.Le président, 53490-o Roland Dumas.François Brault incorporée Notice is given that \"François Brault incorporée\" has transferred its head office from 2207 Marcil Street, Montreal, to 81 - 1st Avenue North, Roxboro.53491 Roger Lenoir, Secrctari/.3352-71 Dominion Dry Milk Limited Notice is given that \"Dominion Dry Milk Limited\" has transferred its head ollice from 4941 Coronet Street, Montreal, to 2300 Lucerne Road, Room 8, Mount-Royal.Kathleen M.Connolly, Secretary.53495-0 11051-01 Roland Dumas lice Notice is given that \"Roland Dumas ltée\", incorporated by letters patent on the eleventh day of June one thousand nine hundred seventy-three and having its head ollice in the Town of Matanc has established its head ollice at 178 St.Raymond Street, Matanc.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Dated at Matane, this 2S of August, 1973.Roland Dumas, 53490 President.Les Entreprises Erdee inc.Erdec Enterprises Inc.Avis est donné que la compagnie « Les Entreprises Erdee inc.\u2014 Erdee Enterprises Inc.», constituée par lettres patentes datées du 10 août 1973 et ayant son siège social à Laval-des-Rapides, Laval, Québec, a établi son bureau principal à 30 Dor.ck.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, l'.Q., ce 10e jour d'août 1973.Le président, 53497-c) F.A.Chefteciii.Fcrro Products Co.Ltd.La compagnie « Fcrro Products Co.Ltd.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes émises le 20e jour de niais 1963, donne avis qu'elle a déménage son siège social du 6540 rue Magloire.dans la Cité de Si-Léonard, au 9405 boulevard Pascal-Gagnon dans la cité de St-Léonard.Le 25 avril 1973.Le secrétaire, 53498-0 Rudolph Fritsch.Les Entreprises Erdee inc.Erdec Enterprises Inc.Notice is hereby given thai \"Les Entreprises Erdee inc.\u2014 Erdee Enterprises Inc.\".incorporated by letters patent dated August 16, 1973 and having its head ollice in Laval-dos-Rapidcs, Laval, Québec, has established its head ollice at 30 Donck.From and after the date of the present notice, the said ollice is considered by the company as being its head office.Given at Montreal.P.Q., this Kith day of August, 1973.F.A.Chefteciii, 53497-0 President.Fcrro Products Co.Ltd.Notice is hereby given that \"Fcrro Products Co.Ltd.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated March 20, 1903, has moved its head office from 0510 Magloire Street, in the City of St.Léonard to 9105 Pascal Gagnon Boulevard in ll.c City of St.Léonard.April 25, 1973.Rudolph Fritsch, 53498-0 Secretary. 5346 QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Librairie Select Inc.Avis est donné que la compagnie « Librairie Select Inc.» a établi son siège social au numéro 225 boul.d'Anjou, Châteauguay.Les procureurs de la compagnie, Viau, hébert, 53499-0 Dblisle & Major.Select Library Inc.Notice is given that the company \"Select Library Inc.\" has established ils head ollice on 255 Blvd.d'Anjou, Châteauguay.Viau, Hébert, Delisle & Major, 53499-0 Attorneys for the Company.Société d'Action Mutuelle Québec-Tiers-Monde Inc.Avis est, par les présentes, donné (pic « Société d'Action Mutuelle Québoc-Tiors-Monde Inc.», constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies, et ayant son siège social à Longucui!, a établi son principal bureau au numéro 2540 rue Oxford, district de Montréal, province de Québec.A compter de la dale du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Longueuil, ce 17e jour d'août 1973.Le président, 53500-o Peux Brillant.Société d'Action Mutuelle Québoc-Ticrs-Mondc Inc.Notice is hereby given that \"Société d'Action Mutuelle Québec-Tiers-Monde Inc.\", incorporated by letters patent issued under the provisions of l'art III of the Companies Act, and having its head ollice in Longueuil, has established its head ollice at 2510 Oxford, district of Montreal, Province of Québec.Prom and after the date of this notice, the said ollice shall be considered by the company as being its head office.Ciiven at Longueuil, this 17th day of August, 1973.félix Brillant, 53500-o /'resident.Star Shipping Supplies Ltd.Avis est donné par les présentes que la compagnie « Star Shipping Supplies Ltd.>\\ constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de la province de Québec, par lettres patentes en date du 15e jour de décembre 1961, a transféré son siège social du 6650, rue Saint-Urbain en la ville de Montréal, au 8525, Marco Polo en la ville de Montréal.Fait ce 28e jour d'août 1973.Le président, 53501 Barry H.Shapiro.Star Shipping Supplies Ltd.Notice is hereby given that \"Star Shipping Supplies Ltd.\", incorporated under Part 1 of the Companies Act of the Province of Québec by letters patent dated the 15th day of December, 1961 has moved its head office from 6650 St.Urbain Street in the City of Montreal to 8525 Marco Polo in the City of Montreal.Dated this 28lh day of August, 1973.Barry II.Shapiro, 53501-o President.Upaco Corporation Avis est par les présentes donné que la compagnie « Upaco Corporation », constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, a transféré son siège social du 4880, rue Courval, à Ville Saint-Laurent, district de Montréal, province de Québec, au 896, chemin Montée-dc-Liesse.à Ville St-Laurent, district de Montreal, province de Québec.Fait à Montréal, ce 8c jour de juin 1973.Le secrétaire, 53503 Hahveï Uline.Les Entreprises J.M.P.inc.La compagnie « Les Entreprises J.M.P.inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1522, Place des Bouleaux, appartement numéro 1, Charny, au numéro 5, rue Fontaine, Saint-Jcan-Chrysostome.Le secrétaire, M.Pouliot.53520-o 3337-71 Upaeo Corporation Notice is hereby given that \"Upaco Corporation\", incorporated under Part 1 of the Companies Act.has moved its head ollice from 4880 Courval Street in the City of St.Laurent, District ol Montreal.Province of Québec, to 89G Montée de Liesse Boad in the City of St.Laurent.District of Montreal, Province of Québec.Dated at Montreal, this Sth day of June.1973.Harvey Ui.ine, 53503-o Secretary.Les Entreprises J.M.P.inc.Notice is given that \"Les Entreprises J.M.P.inc.\" has transferred its head office from 1522 Place des Bouleaux.Apartment 1, Charny, to 5 Fontaine Street, St.Jcan-Chrysostoinc.M.Pouijot, Secretary.53520 3337-71 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 .septembre 1073, 105' année.«\" 37 5347 Fabricants d'Acier (Grand'Mèrc) inc.Avis est donné que la compagnie « Fabricants d'Acier (Grand'Mèrc) inc.» constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies en date du 25e jour de février 1972, et ayant son siège social dans Grand'Mèrc, a établi son bureau au numéro 1281, 7e Avenue, CP.609.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Grand'Mèrc, ce 5c jour de juillet 1972.La secrétaire.Claudette St-Aknaud.53517-0 721120 \\xs Charpentes Métalliques Thomas inc.Thomas Structural Steel Inc.La compagnie « Les Charpentes Métalliques Thomas inc.\u2014 Thomas Structural Steel Inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 11324, rue Edger, Montréal-Nord, au numéro 1500, Maric-Victorin, Saint-Bruno-dc-MontarvilIc.Le secrétaire, Georges Deshosiehs.53519-o 1094-04 Le Mois Franc Itoyal Ltée Royal Hardwood Ltd.Avis est donné que la compagnie « Le Bois Franc Royal Ltée \u2014 Royal Hardwood Ltd.», constitué en corporation selon la première partie de la Loi des compagnies en date du 4 janvier 1973 et ayant son siège social dans la ville de Beloeil où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 275 boulevard Laurier, l'a transporte au 2095, de la rue de l'Industrie, Beloeil, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Beloeil, ce 31e jour du mois d'août 1973.(Sceau) Le président, 53544-0 Pierre Legault.Fabricants d'Acier (Grand'Mèrc) inc.Notice is given that \"Fabricants d'Acier (Grand' Mère) inc.\" incorporated under l'art I cf the Companies Act, on February 25th, 1972, and having its head ollice in Grand'Mèrc, has established its ollice at 12S1 - 7th Avenue.P.O.Box 009.From the dale of this notice, the said ollice shall be considered by the Company as being its head oflicc.Grand'Mèrc, this 5th day of July, 1972.claudette St-AhNAUD.Sccrctari/.53517 721120 Les Charpentes Métalliques Thomas inc.Thomas Structural Steel Inc.Notice is given that \"Les Charpentes Métalliques Thomas inc.\u2014 Thomas Structural Steel Inc.\" has transferred its head oflicc from 11324 Edger Street, Monireal-North, to 1500 Marie-Victorin, St.Bruno-dc-Montarville.( !eokues Desuosiers, Sccrctari/.53519 1094-04 Le Bois Franc Royal Liée Royal Hardwood Ltd.Notice is given that \"Le Bois Franc Royal Ltée \u2014 Royal Hardwood Ltd.\", incorporated under Part I of the Companies Act on the 4th day of January 1973 and having its head ollice in the Town of Beloeil where its oflicc was located until the present day at 275 Laurier Blvd., has transferred said office to 2095 rue de l'Industrie, Beloeil, Québec.From and after the date of the present notice, the said ollice shall be considered by the Company as being its head ollice.Dated at Beloeil, this 31st day of August 1973.(Seal) Pierre Legault, 53544-0 /'resident.I li.iIi.ini 1 Fashions Inc.Avis est donné que la compagnie « ChabancI Fashions Inc.», constituée en vertu de la Loi des Compagnies par lettres patentes en date du 30 octobre, 1909, et ayant son siège social et sa principale place d'affaires en les ville et district de Montréal, l'a transporté à 9500, rue Meilleur, en les ville et district de Montréal, province de .Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 1er jour de mai 1973.Le secrétaire, Lionel Gauthier.53545-q 5094-09 Cliabauel Fashions Inc.Notice is hereby given that \"ChabancI Fashions Inc.\", incorporated under the Companies Act by letters patent dated October 30, 1909, and having its head ollice and principal place of business in the city and district of Montreal, has moved it to 9500 Meilleur Street, in the city and district of Montreal, Province of Québec.From anil after the dale of this notice the said ollice shall be considered by the Company as being the head oflicc of the company.Dated at Montreal, this 1st day of May, 1973.Lionel Gauthier.Secretari/.53545-0 5094-09 5348 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Auteuil Auto inc.La compagnie « Auteuil Auto inc.» donne avis qu'elle a change son siège social de Montreal, au numéro 807, boulevard des Mille-Îles, Laval.Le président, Gilbert Barbas.53518-0 482-09 Clarus Heal tics Ltd.Immeubles Clarus liée Avis est par les présentes donné (pie « Clarus Realties Ltd \u2014 Immeubles Clarus ltée», constituée en corporation par lettres patentes en date du lie jour de janvier 1973, et ayant son siège social dans la ville de Montréal, où elle avait son bureau situé au numéro 1, Place Ville Marie, suite 3035, a transféré ledit bureau au numéro 1, Edison, Place Bonaventure, Montréal 114, district de Montréal, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Fait à Montréal, ce 10c jour d'août 1973.Le secrétaire-trésorier.Pearl Mitchell.53510 730052 Habitat 2000 Inc.Avis est donné que la compagnie « Habitai 2000 Inc.», constituée en corporation par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives en date du 10e jour de novembre 1971 et ayant son siège social dans le district de Québec où elle avait son bureau situé jusqu'à aujourd'hui à 1415, 24e Rue, l'a transporté à 1000, 24e Rue, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Québec, ce 25c jour de juillet 1973.Le secrétaire, Jacques Moms.53547-0 716214 Ladoru inc.Avis est donné que la compagnie « Ladora inc.», constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, le 10e jour de juillet 1973 et ayant son siège social en les ville et district de Montréal a établi son bureau au 3945 rue Ontario Est, à Montréal dans la province de Québec.Signé à Montréal, ce 20e jour d'août, 1973.Le secrétaire, 53548-o Y von St-Amouu.Revalcx inc.La compagnie « Revalcx inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 501, du Chenal, Repentiguy, au numéro 1, Place Ville Marie, Montréal.Le secrétaire, John H.Leiinert.53551-q 1897-07 Auteuil Auto inc.Notice is given that \"Auteuil Auto inc.\" has transferred its head office from Montreal to S07 Mille-Îles Boulevard, Laval.Gilbert Barbas, President.53518 4S2-G9 Clarus Realties Ltd.Immeubles Clarus lice Notice is hereby given that \"Clarus Realties Ltd.\u2014 Immeubles Claras ltée\", incorporated by letters patent on the 11th day of January, 1973, and having its head office in the City of Montreal, where its office was situated at 1 Place Ville Marie, Suite 3035, has moved it to No.1 Edison, Place Bonaventure, Montreal 114, district of .Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said ollice shall be considered by the Company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 10th day of August, 1973.Pearl Mitchell, Secret ary-Trcasurer.53540-o 730052 Habitat 2000 Inc.Notice is given that \"Habitat 2000 Inc.\", incorporated by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives on November 16, 1971, and having its head office in the District of Québec where its ollice was located until the present day at 1415\u2014 24th Street, has transferred said ollice to 1000-24th Street, Québec.From the date of this notice, the said ollice shall be considered by the Company as its head office.Dated at Quebec, this 25th day of July, 1973.Jacques Morin, Sccrclari/.53547 710214 Ladora inc.Notice is hereby given that \"Ladora inc.\", incorporated by letters patent under the provisions of Part I of the Companies Act, on the 10th day of July 1973 and having its head ollice in the City and District of Montreal, has established its oflicc at 3915 Ontario Street East, District of Montreal, Province of Québec.Dated at Montreal, this 20th day of August, 1973.Yvon St-Amour, 53548-0 Secretary.Revalcx Inc.Notice is given that \"Revalex inc.\" has transferred its head office from 501 du Chenal, Repentiguy, to 1 Place Ville Marie, Montreal.John II.Leiinert, Secretary.5355l-o 1897-07 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1973, 105' année, n° 37 5349 Satellite Import Corp.La compagnie « Satellite Import Corp.», constituée en corporation par lettres patentes cr Investment Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act, and having its head ollice in the Town of Cowansville, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Cowansvillc, this 20th day of July, 1973.Me C.Peter Turner, 53483-0 Attorney for the Company.Greenfield Park Donuts Ltd.Avis est ici donné que « Greenfield Park Donuts Ltd.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville dc Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives dc la province dc Québec, l'autorisation d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 1er jour du mois d'août 1973.(Sceau) Le secrétaire, 53484-0 Jack Peck eu.Greenfield Park Donuts Lid.Notice is hereby given that \"Greenfield Park Donuts Ltd.\", a cor|k>ration incorporated under the Companies Act and having its head ollice in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 1st day of August 1973.(Seal) Jack Becker, 53484-0 Secretary.Lamontagnc limitée Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « Lamontagnc limitée » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 29e jour d'août 1973.Les procureurs dc la compagnie, Viau, Bélanger.IIéhekt, Maii.i.oux, 53485-0 Beauregard, Paquet & Pinard.l'ocarl Inc.Prenez avis que la compagnie « Pocart Inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 30c jour d'août 1973.Le procureur de la compagnie, 53487-0 Maurice Martel, ch., avocat.South End Development Corp.Avis est donné que \" South End Development Corp.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social à Montréal, district dc Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 30e jour d'août 1973.Le procureur de la requérante, 1440 rue Ste-Calhcrine ouest, Judaii L.Wolofsky.Montréal 107, Que.534S8-o Lamontagnc limitée Notice is hereby given that the company \"Lamontagnc limitée» shall apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Montreal, this 29th day of August 1973.Viau, Bélanger.IIéhekt.Maii.i.oux.Beauregard, Paquet & Pinard, 534S5-0 .1ttorneys for the Company.Pocart Inc.Notice is hereby given that \"l'ocarl Inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, this 30lh day of August 1973.Maurice Martel, q.c, Advocate.534S7-o Attorney for the Company.South End Development Corp.Notice is hereby given that \"South End Development Corp.\", a corporation incorporated under Part I of the Companies Act, and having its head oflicc in the City of Montreal, District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 30th day of August, 1973.judaii L.W'oLOKSKY, 1410 Ste.Catherine St.West, Attorney for petitioner.Montreal 107, Que.53488-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1073.105' aimée, n° 37 5355 Morin Équipement inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies « Morin Équipement inc.» s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, (pie son annulation soit dirigée et qu'une date soit fixée à compter de laquelle la compagnie sera dissoute.Ce 9e jour d'août, 1973.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, 53486-0 RoBBOT M autel.Morin Equipement inc._ Under the provisions of the Companies Act, \"Morin Équipement inc.\" hereby gives notice that it will make application to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for acceptance of the surrender of its charter and to direct its cancellation and fix a dale upon and from which it shall be dissolved.This 9th day of August, 1973.(Seal) Robert Martel, 53486-0 Secretary-Treasurer.ftudcr Bros.(Quebec) Inc.Avis est donné que la compagnie « Bailer Bros.(Quebec) Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la \\ ille dc Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 12e jour dc juillet 1973.7,c secrétaire, 53552-o Jekalo Bader.Cie Bélanger (1962) Inc.Avis est donné conformément à la Loi des compagnies que la « Cie Bélanger (1962) Inc.», qui a son siège social à Montréal, province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 6c jour de septembre 1973.La secrétaire, 53553-0 Mme Olga Weineh.Bader Bros.(Québec) Inc.Notice is hereby given that \"Bader Bros.(Québec) Inc.\".a corporation incorporated under the Companies Act and having its head ollice in the City of Mont rial, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 12th day of July, 1973.Jerai.i) Bader, 53552-0 Secretary.Cic Bélanger (1962) Inc.Notice is hereby given that \"Cic Bélanger (1962) Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act, and having its head ollice in the City and District of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated al Montreal, this 6th day of September, 1973.Mrs.Olga Weiner, 53553-0 Secretary.Huntingdon Industrial Development Corporation Prenez avis que la compagnie « Huntingdon Industrial Development Corporation » demandera au minis-Ire des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa chai te.Huntingdon, Que.Le procureur de la compagnie, 53554-0 Me.Claude Mé.nard, notaire.Huntingdon Industrial Development Corporation Notice is given that \"Huntingdon Industrial Development Corporation\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Huntingdon, Que.Me.Claude Menard, notary.53554 Attorney for the company.Ilytncr Agencies Inc.Avis est ici donne que « Ilytncr Agencies Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, l'autorisation d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 20e jour d'août 1973.(Sceau) La secrétaire, 53555-0 Adèle Hvtner.Ilytncr Agencies Inc.Notice is hereby given that \"Hytner Agencies Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head ollice in the City of Montreal, will apply to the Minister of financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 20th day of August, 1973.(Seal) Adèle Hytner, 53555-0 Secretary. 5350 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Trans-Vil Inc.Prenez avis que la compagnie « Trans-Vil Inc.» demandera au ministre .des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 53489-0 Mk François Rain villi:, notaire.Roscmont Hosiery Inc.Prenez avis que « Roscmont Hosiery Inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province dc Québec, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 4 septembre 1973.Les procureurs de la compagnie, LBTOURNEAU, FoKKST.raymond, 53550-o IjEtouhkkau & Roy.S tans lead Investments Inc.Avis est donné (pic la compagnie ' Stanstcad Investments Inc.», une corporation constituée en vertu dc la Loi des compagnies et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour obtenir la permission d'abandonner sa chai te conformément aux dispositionsde la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 0 septembre 1973.Les avocats, 53557-0 LiciiiTsToNE & Riback.Unity .Manufacturing Co.Ltd.Avis est donné que la compagnie « Unity Manufacturing Co.Ltd.», une corporation constituée en vertu dc la Loi des compagnies et ayant son siège social en la Ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 15 août 1973.La secrétaire, 5355S-0 Hilda Gold.Divers Compagnies Programmes d'Investissements Capitalisés, ltée Planned Investments Corporation La compagnie « Programmes d'Investissements Capitalisés, ltée-\u2014Planned Investments Corporation» donne avis qu'ell a changé dc 8 à 7 le nombre dc ses administrateurs.Le secrétaire, W.Kohman.53512 11912-00 Trans-Vil Inc.Take notice that \"Trans-Vil Inc.\" will apply to Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province for leave to surrender ils charter.Mk François Rain villi;, Notary, 534S9-o ¦ Attorney for the company.Roscmont Hosiery Inc.Notice is hereby given that \"Roscmont Hosiery Inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec to surrender its charter.Montreal, September 4, 1973.LÊTOUIINKAU, FoitKST, RAYMOND, LÊTomtNKAU & Roy, 53550-o Attorneys for Petitioner.Stanstcad Investments Inc.Notice is hereby given that \"Stanstcad Investments Inc.\", a corporation constituted under the Companies Act.and having its head ollice in the city and district, of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, September 0, 1973.LicirrsToNK & Riback, 53557-0 .1 dvacates.Unity Manufacturing Co.Ltd.Notice is hereby given that \"Unity Manufacturing Co.Ltd.\", a corporation incoi-porated under the Companies Act and having its head ollice in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charlci under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 15th day of August, 1973.Hilda Gold, 53558-0 Secretary.Miscellaneous Companies Programmes d'Investissements Capitalises, I tec Planned Investments Corporation Notice is given that \"Programmes d'Investissements Capitalisés, ltée \u2014 Planned Investments Corporation\" has changed the number of its directors from S to 7.W.KORMAN, Secretary.53512-0 11912-00 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1073, 105' année, n' 37 5357 Les Auvents Acme & Cic ltée Acme Awning & Co.Ltd.La compagnie « Les Auvents Acme & Cic ltée \u2014 Acme Awning & Co.Ltd.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Jacob Scopp.53504 3025-67 Alpha Meat Packers Ltd.La compagnie « Alpha Meat Packers Ltd.» donne avis qu'elle a diminué de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.Peter Goudis.53505 3878-71 J.F.Hearings Inc.La compagnie « J.F.Bearings Inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.IjC secrétaire, Laurent Lebeau.53506-o 725589 D D G G M inc.La compagnie « D D G G M inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire, Jean-Paul Dagenais.53508-o 2471-68 J.T.Gcndron inc.La compagnie « J.T.Gcndron inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 8 à 5.Le secrétaire, R.Desormbaux.53509-o 3230-17 Mbies Patino (Québec) limitée Patino Mines (Québec) Limited La compagnie « Mines Patino (Québec) limitée \u2014 Patino Mines (Québec) Limited » donne avis qu'elle a diminué de 5 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, A.D.Stilling.53510 714018 Les Auvents Acme & Cie ltée Acme Awning & Co.Ltd.Notice is given that \"Les Auvents Acme & Cic ltée \u2014 Acme Awning & Co.Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Jacob Scopp, Secretary.53504-o 3025-67 Alpha Meat Packers Ltd.Notice is given that \"Alpha Meat Packers Ltd.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.53505-o Peter Goudis, Secretary.3878-71 J.F.Hearings Inc.Notice is given that \"J.F.Bearings Inc.\" has changed the number of its directors from 5 to 3.53506 Laurent Lebeau.Secretary.725589 1) 1) G G M inc.Notice is given that \"D I) G G M inc.\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Jean-Paul Dagenais, Secretary.2471-68 5350S J.T.Gcndron inc.Notice is given that \"J.T.Gcndron inc.\" has changed the number of its directors from 8 to 5.53509 It.Desormeaux, Secretary.3230-47 Mines Patino Québec) limitée Patino Mines (Québec) Limited Notice is given that \"Mines Patino (Québec) limitée \u2014 Patino Alines (Québec) Limited\" has changed the number of its directors from 5 to 4.A.I).Stilling, Secretary-Treasurer.53510-o 714618 Service de Loisirs pour Personnes Retraitées de Montréal La corporation \"Service dc Loisirs pour Personnes Retraitées de Montréal » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 9.La secrétaire, Imelda Beaudoin.53514-0 730447 Service dc Loisirs pour Personnes Retraitées dc Montréal Notice is given that \"Service de Loisirs pour Personnes Retraitées de Montréal\" has increased the number of its directors from 4 to 9.Imelda Beaudoin, Secretary.53514 730447 5358 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Corporation de Planification de Transport Stcmoral Stcmoral Transportation Planning Corp.La compagnie « Corporation de Planification de Transport Stcmoral \u2014 Stcmoral Transportation Planning Corp.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre dc ses administrateurs.Le secrétaire, Stephen Maislin.53507 732159 Les Placements Monkland inc.La compagnie « Les Placements Monkland inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, Serge Deshociieus.5351l-o 4500-09 St.Lawrence Plastics Ltd.St-Laurent Plastiques ltée La compagnie « St.Lawrence Plastics Ltd.\u2014 St-Laurent Plastiques liée » donne avis qu'elle a diminué de 4 à 3 le nombre dc ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, C.W.Hazell.53513 11823-54 Corporation de Planification de Transport Stcmoral Stcmoral Transportation Planning Corp.Notice is given that \"Corporation de Planification de Transport Stcmoral \u2014 Stcmoral Transportation Planning Corp.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Stephen Maislin, Secretary.53507-o 732159 Les Placements Monkland inc.Notice is given that \"Les Placements Monkland inc.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Seuge Desrochers, Secretary.53511 4500-09 St.Lawrence Plastics Ltd.St-Laurent Plastiques lice Notice is given that \"St.Lawrence Plastics Ltd.\u2014 St-Laurent Plastiques ltée\" has changed the number of its directors from 4 to 3.C.W.Hazei.i., Secretary-Treasurer.53513-o 11823-54 La Société de Gestion Progressive liée « La Société de Gestion Progressive ltée » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs dc 5 à 3.La secrétaire.Georgette Rancourt.53515-0 2482-03 3 R inc.La compagnie « 3 R inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire, Pierre Buousseau.53516-0 0197-68 La Société dc Gestion Progressive ltée Notice is given that \"La Société dc Gestion Progressive ltée\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Georgette Rancourt, Secretary.53515 2482-63 3 R inc.Notice is given that \"3 R inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 5.Pierre Buousseau, Secretary.53516 6197-68 Fabricants d'Acier (Grand'Mèrc) inc.La compagnie « Fabricants d'Acier (Grand'Mèrc) inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre dc ses administrateurs de 3 à 5.La secrétaire, Claudette St-Arnaud.53517-0 721120 Revalcx inc.La compagnie « Revalcx inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre dc ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire.John H.Leunert.5355l-o 1897-07 Fabricants d'Acier (Grand'Mèrc) inc.Notice is given that \"Fabricants d'Acier (Grand' Merc) inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 5.Claudette St-Ahnaud, Secretary.53517 721120 Revalcx inc.Notice is given that \"Revalcx inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.John H.Lehnert, Secretary.53551-0 1897-07 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 107.3, 105' année, n° 37 5359 Carrier Distribution Credit Corporation Avis est donné qu'en vertu d'une nouvelle procuration en date du 20 juillet 1973, dont copie a été remise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, monsieur Pierre Legrand, de la suite 700, édifice de la Banque Royale, 1, place Aille Marie, Montréal, a été nommé remplaçant de monsieur P.André (Servais en tant qu'agent principal dans la province de « Carrier Distribution Credit Corporation ».une compagnie étrangère dûment autorisée à faire des affaires dans la province de Québec, conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies étrangères.Avis est aussi donné qu'en vertu dc la nouvelle procuration ci-dessus mentionnée, le siège social de ladite compagnie est établi à la suite 750, dans l'édifice dc la Banque Royale, situé au 1.place Ville Marie.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Fernand Lalonde.53559 PA: 35-72 Carrier Distribution Credit Corporation Notice is given that, by new power of attorney dated July 20th.1973, a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.Mr.Pierre Legrand of Suite 700, The Royal Bank Building.1 Place Ville Marie.Montreal, was appointed to replace Mr.P.-Andrc (Servais as chief agent in the Province of \"('airier Distribution Credit Corporation\", an Extra-Provincial Company duly authorized to carry on business in the Province of Québec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act.Notice is also given that pursuant to the above-mentioned new power of attorney, the head ollice of the said company is established at Suite 750, The Royal Bank Building.1 Place Ville Marie, Montreal, Judicial District of Montreal.Fernand Laloxde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.53559-0 PA: 35-72 Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Assurances Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Insurance Herald Insurance Company La Compagnie d'Assurances Herald Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que « Herald Insurance Company \u2014 La Compagnie d'Assurances Herald », enregistrée sous le numéro 755 a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1749 qui l'autorise à compter du 26 juillet 1973, à effectuer dans la Province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Accidents et Maladie; Aviation; Automobile; Abus de confiance; Responsabilité; Biens et Caution.Le siège social de la compagnie est situé au Royal Trust Tower, Suite 1102, Toronto, Ontario.La compagnie a nommé monsieur M.-F.-L.Jaques, 800, Place Victoria, Suite 2802, Montréal, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 29 août 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, Le surintendant des assurances, 53457-36-2-0 Rogeb-A.Çamakaire.Herald Insurance Company La Compagnie d'Assurances Herald Notice of Issue of Licence and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"Herald Insurance Company\u2014 La Compagnie d'Assurances Herald\", registered under number 755, has obtained the licence and certificate of registry number 1749, authorizing it, as from the 26th of July 1973, to undertake in the Province contracts of insurance in the following classes: Accident and Sickness; Aircraft; Authomobile; Fidelity; Liability; Property and Surety.The head ollice of the company is situated at Royal Trust Tower, Suite 1102, Toronto, Ontario.The company has appointed Mr.M.F.L.Jaques, 800, Place Victoria, Suite 2802, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Depart Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 29 th of August 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Superintendent of Insurance, 53457-36-2-0 Roger-A.Camaraire.Compagnies étrangères Extra-Provincial Companies Agent Agent 53G0 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1073, Vol.105, No.37 Commission des transports Québec Transport du Québec Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis dc la Commission « proprio motn » (Règlement 2, a.2.21) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction dc requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes dc vérification dc permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : / 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées.i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en viae.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulations 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (().(\u2022.2619-73 and its amendments).These headings arc identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\\ erification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.- Other proceedings.HI \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1973.105' année, n° 37 5361 ii.au moins trois membres.\u2014 transport générai de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis.d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications |>euvcnt avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.In certain cases of application for special jiermits, publications may be made in local newspapers.V \u2014 Avis des decisions rendues : La Commission donne avis de la nature des decisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement No 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs dc la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered : The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.5S of Regulation 2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be recpiestcd within a period of 15 clear days following this publication.SÉANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAM HERS \t\t\t\tc;\t.()..31\t2291\t14-4-73\tAccordée / Granted \t\t1005-TF\t\t\t\t \t\tFrancis Gosine Moving & Storage\tl-6-i>.35\t2291\t14-4-73\tAccordée / Granted \t\t100G-TF\t\t\t\t \t\tTymos Cartage & Storage Ltd.\t1-6-p.35\t2291\t14-4-73\tAccordée / Granted \t\t1040-TF\t\t\t\t \t\tJourne:iu Transfer & Storage Ltd.\t1-G-p.\t2291\t14-4-73\tAccordée / Granted QL-49\t4-9-73\t15-V\t\t\t\t \t\tTransport d'Anjou Inc.\t1-17-6\t4137\t14-7-73\tAccordée / Granted QL-50\t4-9-73\t163-D Y - 153-DYV - 7-DYA - 5-DYE\t\t\t\t \t\tRouvn Drive Yourself Ltd.\t1-9-43\t3026\t19-5-73\tAccordée / Granted QL-51\t4-9-73\tQ-1Ô22-DYV\t\t\t\t \t\tChez Nous Camping Enrg.\t1-19-94\t4435\t28-7-73\tAccordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1973, 105' année, n° 37 5305 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t \t\tRequérants\t\t\t\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\t QL-52\t4-9-73\t007-D Y - 257-DYV\t\t\t\t \t\tShawinigan Auto Location Inc.788-DY-319-DYV\t1-10-113\t3245\t20-5-73\tAccordée / Granted QL-53\t4-9-73\t\t\t\t\t \t\tAlbert Fortier requérant-vendeur / applicanl-xendor Clément Thibcault\t\t\t\t \t\trequérant-acquéreur / applicant-\t1-8-191\t2978\t12-5-73\tAccordée / Granted \t\tpurchaser\t\t\t\t ML-84\t4-9-73\t141-DYL\t\t\t\t \t\tCanadian Pittsburg Industries Ltd.\tl-S-184\t2976\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-85\t4-9-73\t1007-DY Auto Location Varennes limitée\t\t\t\t \t\tVarennes Auto Leasing Limited\t1-7-82\t2872\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-80\t4-9-73\t1190-DY\t\t\t\t \t\tRoger Davidson Leasing Limited\t1-8-178\t2975\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-87\t4-9-73\t1169 DY Yelùclc Lease and Management .Services\t\t\t\t \t\tInc.\t1-15-23\t3977\t7-7-73\tAccordée / Granted ML-88\t4-9-73\t1204-DY-907-DYV\t\t\t\t \t\tCinvest limitée / Cinrest Limited\t1-15-29\t3980\t7-7-73\tAccordée / Granted R1L-89\t4-9-73\t1266-DY-981-DYV\t\t\t\t \t\tDon Mann Motor Sales Limited\t1-8-170\t2973\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-90\t4-9-73\t1237-DY\t\t\t\t \t\tCaravane Vaudreuil inc.\t1-17-18\t4140\t14-7-73\tAccordée / Granted ML-91\t4-9-73\t1247-DY \u2014 1010-DYV\t\t\t\t \t\tMont-Bruno Ford Sales Inc.\t1-16-59\t4134\t14-7-73\tAccordée / Granted ML-92\t4-9-73\t046-DYV Looation Champion inc.\t\t\t\t \t\tChampion Leasing Inc.\t1-15-28\t39S0\t7-7-73\tAccordée / Granted ML-93\t4-9-73\tM-696-DYV\t\t\t\t \t\tVersailles Ford Sales limitée\t1-8-186\t2977\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-94\t4-9-73\t882-DYV John A.Buckland ltée\t\t\t\t \t\tJohn A.Huckland Ltd.\t1-8-177\t2974\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-95\t4-9-73\t984-DYV\t\t\t\t \t\tKim-Tam Truck Leasing Limited\t1-8-175\t2974\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-96\t4-9-73\t985-DYV licaudin Leasing Heg'd\t\t\t\t \t\tLocation Beaudin Enrg.\t1-8-173\t2973\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-97\t4-9-73\t552-DY - 154-DYV\t\t\t\t \t\tDuval Rental Corporation 1084-DY-74G-DYV\t1-15-25\t3978\t7-7-73\tAccordée / Granted ML-98\t4-9-73\t\t\t\t\t \t\tThe Imperial Leasing Company\t1-8-182\t2976\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-99\t4-9-73\t1159-DY\t\t\t\t \t\tCarousel Leasing Reg'd\t1-12-59\t3G18\t10-0-73\tAccordée / Granted ML-100\t4-9-73\tM-1158-DY \u2014841-DYV\t\t\t\t \t\tSt-Eustache Drive Yourself Inc.\t1-8-185\t2976\t12-5-73\tAccordée / Granted ML-101\t4-9-73\t1246-DY La Compagnie des Ciments du St-Laurent\t\t\t\t \t\tSt-Lawrcnce Cements Co.\t1-1G-58\t4134\t14-7-73\tAccordée / Granted ML-102\t4-9-73\t714-DYV\t\t\t\t \t\tFêter O'Day\t1-8-1 (19\t2973\t12-5-73\tPermis cancellé / \t\t\t\t\t\tPermit cancelled ML-103\t4-9-73\t982-DY Ville Emard Rent a Car\t\t\t\t \t\t(Dominico Di Carlo)\t1-14-114\t3890\t30-0-73\tAccordée / Granted QSM-13\t4-9-73\tQ-10-N\t\t\t\t \t\tSociété des Traversiers Quélxsc-Lévis\t1-19-103\t4437\t28-7-73\tAccordée / Granted 53GG QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1073, Vol.105, No.37 AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS \t\t\tG.O.Q.\t\t No\tDate\tpage\t\tdate\tDécisions MPE-1 QPE-1\t30-8-73\t4142\t\t14-7-73\t Décision de la Commission des transports du Québec concernant l'approbation et l'entrée en vigueur de la prolongation des contrats de transport d'écoliers pour l'année 1973-74 / Decision of Ihc Québec Transport Commission concerning the approval and the coming into force of the extension of contracts for the transport of pupils for the year 1973-74.La Commission décide, à l'exception du contrat entre la Commission dc transport de la Communauté Régionale de l'Outaouais et la Commission Scolaire Régionale de l'Outaouais avec les Commissions Scolaires d'Aylmer et d'Outaouais-llull qui n'est pas prolongé, de donner son approbation, conformément à l'article 171 dc la Loi des Transports, à la prolongation de tousles contrats pour le transport d'écoliers dont telle prolongation a été décrétée le 20 juin 1973 par arrêté en conseil No 2229-73; la prolongation de tous ces contrats entre en vigueur le 1er septembre 1973 / The Commission decides to grant its approval, in conformity with section 171 of the Transport Act, to the extension of all contracts for the transport of pupils, ichich extension was ordered on June 20, 1973, by Order in Council No.2229-73; the extension of all these contracts shall become effective on September 1, 1973.The foregoing shall not apply to the contract between the Oulaouais Regional Community Transit Commission and the Oulaouais Regional School Hoard with the Aylmer and Oulaouais-Hull School Hoards, which is discontinued.\t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicatns\t\t\t\tCase.\t QPV-88\t4-9-73\t3483-A\t\t\t\t\t \t\tJoseph Lacroix\t1-8-141\t2904\t12-5-73\t2370\tDésistement / Withdrawal QPV-89\t4-9-73\t3475-A Elorian & Jean-Paul\t\t\t\t\t \t\tlinlicault\t1-5-55\t2702\t5-5-73\t2349\tRcjetéc / Rejected MPV-53\t4-9-73\t1475-AT Service Voyageurs\t\t\t\t\t \t\tVaudreuil Inc.\t3-21-01\t2084\t7-4-73\t4005\tAccordée , Granted MPV-54\t4-9-73\t1475-AT Service Voyageurs\t\t\t\t\t \t\tVaudreuil Inc.\t\t2082\t7-1-73\t3995\tAccordée / Granted QCR-226\t4-9-73\t22317-V\t\t\t\t\t \t\tBiais & Langloislnc.\t3-20-14\t2070\t7-4-73\t4021\tAccordée / Granted QCR-227\t4-9-73\t32-V\t\t\t\t\t \t\tTransport Dallaire Ltée\t1-1-19\t2530\t28-4-73\t2330\tDésistement / Withdrawal QCR-228\t4-9-73\t4545-V\t\t\t\t\t \t\tTransport Lavoie Ltée\t3-22-52\t1938\t31-3-73\t2300\tRejetée / Rejected QCR-229\t4-9-73\t22787-V\t\t\t\t\t \t\tRoger I'ouliot\t1-7-5\t2848\t12-5-73\t2300\tDésistement / Withdrawal QCR-230\t4-9-73\t22942-V\t\t\t\t\t \t\tRobert Morisscttc\t1-7-11\t2849\t12-5-73\t2301\tRcjetéc / Rejected QCR-231\t4-9-73\t23230rV\t\t\t\t\t \t\tCormier & Renaud Inc.\t1-11-70\t3371\t2-G-73\t2404\tRejetée / Rejected QCR-232\t4-9-73\t22317-V\t\t\t\t\t \t\tBiais & Langlois Inc.\t3-20-2\t2077\t7-4-73\t4022\tDésistement / Withdrawal QCR-233\t4-9-73\t10483-V\t\t\t\t\tCause remise pour être appelée à nouveau lors d'un prochain appel de rôle seulement sur requête :\\ cet effet / Case deferred to be called again at a future roll case, upon request to \t\tNorway Transport Inc.\t2-23-23\t2232\t14-4-73\t3375\t \t\t\t\t\t\t\tthis purpose only.QCR-234\t4-9-73\t9827-V\t\t\t\t\t \t\tPierre Aubin\t3-22-28\t2210\t14-4-73\t40S8\tDésistement / Withdrawal Sommation / Summons QCR-235\t4-9-73\t7952-V Gabriclle L.Latcrreur\t\t\t\tS-172\t \t\tintimée / defendant\t\t\t\t\t11 n'y a pas lieu de procéder \t\t\t\t\t\t\tplus avant - affaire classée /No grounds for proceeding further - matter dismissed. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1073, 105' année, n° 37 5307 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tA pplicants\t\t\t\tCase\t QCR-236\t4-9-73\tM-9570-V\t\t\t\t\t \t\tCoutu Transport Express\t3-G-52\t2238\t14-4-73\tM-3638\tCause remise pour être \t\tLimitée\t\t\t\t\tAppelée a nouveau lors d'un prochain appel de \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\trôle seulement sur re- \t\t\t\t\t\t\tquête h cet effet / Case \t\t\t\t\t\t\tdeferred to be called again \t\t\t\t\t\t\tai a future roll call upon \t\t\t\t\t\t\trequest to this purpose QCR-237\t4-9-73\tM-9570-V\t\t\t\t\tonly.\t\tCoutu Transport Express\t2-23-21\t2232\t14-4-73\tM-3373\tCause remise pour être \t\tLimitée\t\t\t\t\tappelée à nouveau lors d'un prochain appel de rôle, seulement sur requête a cet effet / Case deferred to he called again at a future roll call, upon \t\t\t\t\t\t\trequest to this purpose only.MCR-268\t4-9-73\t23003-V Erie Produce Company\t\t\t\t\t \t\tLimited\t3-19-32\t1792\t24-3-73\tM-4025\tAccordée eu partie / \t\t\t\t\t\t\tPartly granted QCS-133\t4-9-73\t2873-V\t\t\t\t\t \t\tLamotlie Quebec Inc.\t3-1-17\t2236\t14-4-73\t3548\tAccordée en partie / \t\t\t\t\t\t\tPartly granted QCS-134\t4-9-73\tC793-V\t\t\t\t\t QCS-13S\t\tBrazeau Transport Inc.\t3-21-41\t2260\t14-1-73\t4000\tDésistement / Withdrawal \t4-9-73\tM-22478-V\t\t\t\t\t MCS-178\t\tJ.André Bergeron 22933-V\t3-20-29\t2075\t7-4-73\t400G\tRejetée / Rejected \t4-9-73\t\t\t\t\t\t QL-54\t4-9-73\t-Morgan Drive-Away Inc.991-DVV\t3-16-6\t1770\t24-3-73\tM-3938\tliejetée / Rejected QL-55\t\tRoland Poulin\t1-10-117\t3247\t26-5-73\t2390\tAccordée / Granted Remontrance à l'intimée à être notée au dossier / Remontrance to the defendant to be entered on the file- \t4-9-73\t2594-V Gérard Gagnon Ltée\t\t\t\tS-185\t 53575-0 Sièges sociaux ( C.T.Q.) Head Offices (Q.T.C.) Queensway Tank Lines Limited Avis est donné que la place d'affaires au Québec de « Queensway Tank Lines Limited » sera au 714 boulevard St-Joseph, Hull, téléphone 771-3223.53534-0 Les procureurs de la requérante, Geofkrion & Prud'homme.Jack B.Kelly Inc.Avis est donné que l'adresse, pour la province «le Québec, de la compagnie « Jack B.Kelly Inc.», est: 212, rue Bloomfield, Outremont, province de Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 53539-0 Perreaui.t & Rivet.Queensway Tank Lines Limited Notice is given that the place of business in the Province of Québec of \"Queensway Tank Lines Limited\" shall be at 714 St.Joseph Boulevard.Hull, telephone number: 771-3223.cîeoffrion & Prud'homme.53534 Attorneys for petitioner.Jack B.Kelly Inc.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"Jack B.Kelly Inc.\", is 212 Bloomfield St., Outrcmont, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 53539-0 Attorneys for the company. 5368 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Hume's Transport Ltd.Avis est donné (pic l'adresse, pour la province dc Québec, de la compagnie « Hume's Transport Ltd.», est: 212, rue Bloomfield, Outremont, province de Québec.Les procureurs de la requérante, Paquette, Paquette, 53530-o Perheault & Rivet.Hume's Transport Ltd.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"Hume's Transport Ltd.\", is 212, rue Bloomfield, Outremont, Province of Québec.Paquette, Paquette, Pekheault & Rivet, 53530-o Attorneys for the Company.McBurney Transport Ltd.Avis est donné que l'adresse, pour la province dc Québec, de la compagnie « McBurncv Transport Ltd.», permis No: 21179-V est: a/s K.J.Ryan 229 Gilford Ave, Beaconsfield, 880, province de Québec.Les procureurs de la requérante, Paquette, Paquette, 53531-0 Perreault & Rivet.Mercury Tanklincs Ltd.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « Mercury Tanklincs Ltd.», permis No 19007-V est: 212, rue Bloomfield, Outremont, province of Québec.Les procureurs de la requérante, Paquette, Paquette, 53532-o Pehkeault & Rivet.Oil & Industry Suppliers Ltd.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, dc la compagnie « Oil & Industry Suppliers Ltd.», permis No 18363-V est: 212, rue Bloomfield, Outremont, province de Québec.Les procureurs de la requérante, Paquette, Paquette, 53533-0 Pehkeault & Rivet.McBumcy Transport Ltd.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"McBurney Transport Ltd.\", permit No.21179-V is c/o K.J.Ryan 229 Gilford Ave., Beaconsfield, 880, Province of Québec.Paquette, Paquette, Pekheault & Rivet, 53531-0 Attorneys for the Company.Mercury Tanklincs Ltd.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"Mercury Tanklincs Ltd.\", permit No.19007-V is 212, rue Bloomfield, Outremont, Province of Québec.Paquette, Paquette, Pehkeault & Rivet, 53532-0 Attorneys for the Company.Oil & Industry Suppliers Ltd.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"Oil & Industry Suppliers Ltd.\", permit No.18363-V is 212, rue Bloomfield, Outremont, Province of Québec.Paquette, Paquette, Pehkeault & Rivet, 53533-0 Attorneys for the Company.Rea Bros.Ltd.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « Ilea Bros.Ltd.», permis No 19626-V est: 4999 ouest, rue Sle-Catherinc, Montréal 215, province de Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 53535-0 Pekreault & Rivet.Sept-îles Transport Inc.Avis est donné que la compagnie « Sept-îles Transport Inc.», incorporée dans la province de l'île du Prince-Edouard par lettres patentes datées du 4 août 1971 et ayant son siège social dans la ville de Souris, île du Prince-Edouard, a établi une place d'affaires à 608 rue Cartier, Sept-îles, province dc Québec.Souris, I.P.E., ce 17e jour d'août 1973.(Sceau) 53536-0 Albert McCormick.Rea Bros.Ltd.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"Rea Bros.Ltd.\", ]>crmit No.19626-V is 4999 Stc-Catherine St.W., Montreal 215, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 53535-0 Attorneys for the company.Sept-îles Transport Inc.Notice is hereby given that the company \"Sept-îles Transport Inc.\", incorporated in the Province of Prince Edward Island by letters patent bearing the date of August 4, 1971 and having its head oflicc in the city of Souris, Prince Edward Island, has established a place of business at 608 Cartier, Sept-îles, Province of Québec.Souris, P.E.I., this 17th day of August 1973.(Seal) 53536-0 Albert McCormick. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1973, 105' année, n° 37 Arnold Bros.Transport Ltd.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « Arnold Bros.Transport Ltd.», permis No 21992-V est: 212, rue Bloomfield, Outremont, province de Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 53537-0 Perreault & Rivet.Can-Am Dis t.& Whse Inc.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, dc la compagnie « Can-Am Dist.& YVlise Inc.» est: 3250 Place Hélène Boullé, Montréal 356, province dc Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 53538-0 Pehkeault & Rivet.Faslgalc Ford Sales & Services Ltd & Co.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « Eastgate Ford Sales & Services Ltd.», est: 7242 rue Vannes, St-Léonard, province dc Québec, téléphone: 259-0713.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 53541-o Perreault & Rivet.Laircrly-Smilli Kxprcss Lines Ltd.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « Lafl'crty-Smith Express Lines Ltd.», permis No 17431-V est:\"l 1,242 est, boul.Gouin, Montréal 477, Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 53542-0 Perreault & Rivet.T.J.Lewis Cartage, .Moving & Parcel Delivery Avis est donné que l'adresse, pour la province dc Québec, dc la compagnie « T.I.Lewis Cartage, Moving & Parcel Delivery », est: 527 rue Dollard, Ville Lasallc, province dc Québec.Les procureurs dc la compagnie, Paquette, Paquette, 53543-0 Perreault & Rivet.5369 Arnold Bros.Transport Ltd.Notice is given that the address, for the Province of Quebec, of \"Arnold Bros.Transport Ltd.\", permit No.21992-V is 212 Bloomfield St., Outremont, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 53537-0 Attorneys for the company.Can-Am Dist.& Whsc Inc.Notice is given that the address, for the Province of Quebec, of \"Can-Am Dist.& Whse Inc.\" is 3250 Place Hélène Boullé, Montreal 356, Province of Québec.Paquette, Raquette, Perreault & Rivet, 53538-0 Attorneys for the company.Kastgale Ford Sales & Services Ltd & Co.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"Eastgatc Ford Sales & Services Ltd.\", is 7242 Vannes Street, St-Léonard, Province of Québec, telephone: 259-0713.Paquette, Paqubite, Perreault & Rivet, 53541-0 Attorneys for the company.Lallcrtv-Smilh Express Lines Lid.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"Lalfei'tv-Smith Express Lines Ltd.\", permit No.17431-V is 11,242 Gouin Blvd.East, Montreal 477, Quebec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 53542-0 Attorneys for the company.T.J.Lewis Cartage, Moving & Parcel Delivery Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"T.I.Lewis Cartage.Moving & Parcel Delivery\", is 527 Dollard St., Ville Lasallc, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 53543-0 Attorneys for the company.Nomination Avis est donné qu'il a plu au liculenant-gou vcrncur en conseil de faire, par commission sous le grand sceau de la province, la nomination suivante: Québec, le 8 août 1973.'Me Maurice Lanicl, cit., domicilié à Montréal: coroner pour le district judiciaire de Montical, et ce, à compter du 8 août 1973.Québec, le 11 septembre 1973.Le sous-procureur général adjoint, 53529-0 Jean Alarie.Appointment Notice is given that il has pleased the Lieutenant-Governor ill Council to make the following appointment by commission under the Great Seal of the Province: Quebec, August 8, 1973.Me Maurice Laniel, q.c, domiciled in Montreal: Coroner for the Judicial District of Montreal, effective from August.8, 1973.Québec, September 11, 1973.Jean Ai.arie, 53529 Assistant Deputy Attorney General. 5370 QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Centre roi/ram anicr-DclixIc\" (Modifications) Notice is given that pursuant to section 40 of the Québec Housing Corporation Act (1960-1967, Chapter 55), the Lieutenant-Governor in Council has, by Order number 3103-73 dated August 22, 1973, ratified the modifications adopted by by-law number 1603 of May 22, 1973 of the City of Montreal in its renewal program for the part of its territory known \"Ilots Vauicr-Dclislc\", declared a \"renewal zone\" by Order number 408S dated November 4, 1970.The Québec Housing Corporation has, by its resolution number 6S32 dated August 13, 1973.approved these modifications.Mb Jean-Luc Lesace, notary, 53525-0 Secretary.Proclamations Canada, Province de HUGHES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur dc la Foi.A tous ceux (pie les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Sai.lt.Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320,1, il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du canton de Letellier, comprenant le bloc 26, située dans la division d'enregistrement dc Sept-lles, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie dc ce plan correct, accompagné d'une copie dc ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau dc la division d'enregistrement de Sept-îles, à Sept-îles; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions dc l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt de ces plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement de Sept-îles et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton de Letellier.Proclamations Canada, Provinceof III Cl l'.S I.AI'I II NTL Québec.|L.S.) ELIZABETH THF SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories.Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these presentJcttcrs shall conic, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1904, Chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Letellier, comprising block 20, located in the Scpl-llcs Registration Division, wilh a book of reference relating to this correct plan; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together will; a Copy of this book of reference has been deposited in the Sept-îles Registration Division Ollice, in Scpt-iles by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now- expedient, pursuant to the provisions of article 2109 of I he ( 'ivil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor In Council, t he deposit of t he original plan and book of reference in the Scpt-llcs Registration Division, and, at the same time, the day on which the provisions of article 21 OS will, become effective, the whole in relation to the said pari of the Township of Letellier. 5374 qrf.llF.C OFFICIAL GAZETTE, September 10, 1073, Vol.l:,, Xo.37 À ces causes, du consentement et dc l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2997-73, du 15 août 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre dc renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent », qu'il y a lieu: à) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement de Sept-îles, à Sept-îles, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton de Letellier, comprenant le bloc.26, située das la division d'enregistrement dc Sept-îles; b) de fixer à la date dc la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie du canton de Letellier; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot dc terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement, par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui dc droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icellcs apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., ch., lieutenant-gouverneur dc Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province dc Québec, ce quinzième jour d'août en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Jean Alahie.Libro: 501 Folio: 147 53529-0 Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 2997-73, dated August 15, 1973, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), ami articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Hooks of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Sept-îles Registration Division Office, in Sept-îles, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Letellier, comprising block 26, located in the Sept-îles Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (b) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the Township of Letellier; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable alfectcd, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; («/) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof, We have caused these Our present, letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c., Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this fifteenth day of August in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Jean Alarie, Assistant Deputy Attorney General.Libro: 501 Folio: 147 53529 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1973, 105' année, ?i° 37 5375 Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, défenseur dc la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie «lu canton de Shehyn.comprenant le bloc F, située dans la division d'enregistrement de Témiscaminguc, avec un livre dc renvoi relatif à ce plan; Attendu\" que le plan dc cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagné d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau dc la division d'enregistrement de Témiscaminguc, à Ville-Marie; Attendu\" que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2109 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt de ces plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement de Témiscaminguc.cl, en même temps, le jour auquel les dispositions dc l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton dc Shehyn.A ces causes, du consentement et dc l'avis dc Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2998-73, du 15 août 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, déciétons et ordonnons, sur la proposition du ministre «les terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec.1964, chapitre 329), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan cl du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent », qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau dc la division d'enregistrement de témiscaminguc, à Ville-Marie, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton de Shehyn, comprenant le bloc F, située dans la division d'enregistrement de Témiscamingue; b) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie du canton dc Shehyn; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, ï'enregislreemnt de tout droit réel, sur un Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of Gotl, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Shehyn.comprising Block P, located in the Témiscaminguc Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his ollice; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Témiscaminguc Registration Division Office, in Ville-Marie by the Minister of Lands and Forests; V\\hekkas it is now expedient, pursuant lo the provisions of article 2109 of I he Civil Code, Lo announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Témiscaminguc Registration Division, and, at the same time, the day on which the provisions of article 216S will become effective, the whole irr relatiorr to the said part of the Township of Shehyn.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 2998-73, dated August: 15, 1973, Wc have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests aird pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Quebec.1964, Chapter 320), and articles 2106 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this ('ode, the title of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and of Matters Connected 'Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit irr the Témiscaminguc Registration-Division Ollice in Ville-Maric, of the original plan and book of reference of a part, of the 'Township of Shehyn, comprising Block F located in the Témiscaminguc Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (b) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the 'Township of Shehyn; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this dale, the registration of any real right QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 5376 lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement, par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 216S et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autics que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et dc se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur i celles apposer le grand sceau dc Notre province dc Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lafointe, c.P.,ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville dc Québec, dc Notre province dc Québec, ce quinzième jour d'août en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre, Le .sous-procureur general adjoint, Libro: 501 Jean Alauie.Folio: 148 5352'J-o Ministère des Terres et Forêts Cadastre Canton de Hull Cadastre officiel du canton dc Hull, municipalité de la ville de Touraine, division d'enregistrement de Ga-tineau Avis est par la présente donné que les lots 5B-47et 5B-48 du rang VII sont annulés en vertu dc l'article 2174a du Code civil.Québec, le 15 août 1973.Pour le sous-ministre, 53479-o Benoît Ghimahd, a.-g.Canton de Jonquièrc Cadastre officiel du canton de Jonquièrc, municipalité de la cité de Jonquièrc, division d'enregistrement dc Chicoutimi Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 23-b-l-A du rang IV est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 16 août 1973.Pour le sous-ministre, 53479-0 Benoît Grimaro, a.-g.upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 216S and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; ((/) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern arc hereby required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony wheheof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great seal of Our Province of Quebec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lai'ointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this fifteenth day of August in the year of Our Boni one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Jean Ai.akie, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 148 53529 Department of Lands and Forests Cadastre Township of Hull Official cadastre of township of Hull, niunicipalily of the town of Touraine, registration division of Gali-neau Notice is hereby given that lots 5B-47 and 5B-48 of range VII are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, August 15, 1973.Benoît Ghimahd, a.-g., 53479-0 For the Deputy Minister.Township of Jonquièrc Official cadastre of township of Jonquièrc, municipality of the city of Jonquièrc, registration division of Chicoutimi.Notice is hereby given that a part of lot 23-b-l-A of range IV is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, August 16, 1973.Benoît Ghimahd, a.-g., 53479-0 For the Deputy Minister. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 107-3, 10-ï' année, n° 37 5377 Canton d'Olis Cadastre officiel du canton d'Otis, municipalité du canton d'Otis, division d'enregistrement de Chicoutimi.Avis est par la présente donné que les lots 44-11-2, 45-13-2.45-B-3.40-B-2, 47-B-2, 4S-B-2, 48-B-10 du rang VIII sont annulés en vertu dc l'article 21/4a du Code civil.Québec, le 7 août 1973.Pour le sous-minislre, 53479-0 Benoît Grimahd, a.-c.Paroisse de l'Angc-Gardicn Cadastre officiel de la paroisse de l'Angc-Gardicn, municipalité du village dc Saint-Jean-dc-Boischatcl, division d'enregistrement de Montmorency.Avis est par la présente donné que les lots 170-13, 176-14 sont annulés en vertu dc l'article 2174a du Code civil.Québec, le 15 août 1973.Pour le sous-minislre, 53479-o Benoît Grimahd, a.-c Village dc Bagolville Cadastre officiel du village de Bagotville, municipalité de la ville de Bagotville, division d'enregistrement dc Chicoutimi.Avis est par la présente donné cpie le lot 315-35 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 13 août 1973./'oie used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from November 1, 1973. 5386 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 15, 1973, Vol.105, No.37 Tableau d'amortissement \u2014 $746,000 \u2014 20 ans Date Capital 01 11 1974.816,000 01 11 1975.17,000 01 11 1976.18,000 01 11 1977.19,000 01 11 1978.22,000 01 11 1979.23,000 01 11 1980.25,000 01 11 1981.28,000 01 11 1982.30,000 01 11 1983.32,000 La commission scolaire des Mille-Îles, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre dc l'Éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à ternie fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à S72.000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er novembre 1993.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 872,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 1er novembre de chaque année pour le montant annuel Redemption table \u2014 $746,000 \u2014 20 years Date Capital 01 11 1984.$35,000 01 11 1985.37,000 01 11 1986.41,000 01 11 1987.45,000 01 11 1988.48,000 01 11 1989.53,000 01 11 1990.56,000 01 11 1991.61,000 01 11 1992.68,000 01 11 1993.72,000 The Mille-Îles School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board G rants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school eori>ora-tion, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the follow-ing terms ami conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than S72.000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of November 1, 1993.However, tenders should be sent for one of the alxivc methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 872,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on November 1st of each year for the annual amount GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1973, 105' année, n\" 37 5387 requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal j'i 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire des Mille-Iles s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er novembre 1973 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 4 avril 1973 \u2014 $126,000 \u2014 agrandissement de l'école St-Patrick; 7 mars 1973 \u2014 $620,000 \u2014 construction d'une école élémentaire à Lorraine.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à 8 heures du soir, mercredi, le 3 octobre 1973.École Curé Antoine Labellc, Ste-Rose, Ville de Laval, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Laval, ce 6 septembre 1973.Le directeur-général, Marcel Bolduc.Centre administratif, 2275, Honoré Mercier, Ste-Rose, Ville de Laval, P.Q.Téléphone: 625-6951, code 514.53540-o Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis set seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.GASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District of Gaspé \u2014 Division Iles-de-la-Madeleinc ( T A CAISSE POPULAIRE DE IIA- No 255.< ^ VRE-AUX-MAISONS, îles-de-la ' Madeleine, demanderesse, vs Dr.MARCEL PARATTE, résidant à Cap-aux-Meules, îles-de-la-Madeleindc, défendeur.Un certain lopin de terre au cadastre revisé officiel de l'île dc Cap-aux-Meules, municipalité de Cap-aux-Meulcs, division d'enregistrement des îlcs-dc-la-Madc-leine, connu comme cuint le lot mille sept cent dix-sept (1717) tel que cadastré contenant en superficie 13,950 pieds carrés, avec maison dessus construite, circonstances et dépendances.Pour être vendus au bureau du registratcur de la division d'enregistrement des îles-de-la-Madcleine.au Palais de justice à Havre-Aubert, I.M.VENDREDI le DIX-NEUVIÈME jour d'OCTOBRE 1973 à ONZE heures de Pavant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Palais de Jusice, Napoléon BriAMD.Havrc-Aubert, I.M.53567-0 required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Mille-Îles School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after November 1, 1973, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: April 4, 1973 \u2014 $126,000 \u2014 extension of St.Patrick School: March 7, 1973 \u2014 $620,000 \u2014 construction of an elementary school in Lorraine.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Wednesday, Octol>er 3, 1973, at 8:00 o'clock p.m.Curé Antoine Labellc School.Ste.Rose, City of Laval.P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Laval, September 6, 1973.Maiickl Bolduc, Director-General.Administration Centre, 2275 Honoré-Mercier Street, Ste.Rose, City of Laval, P.Q.Telephone: 625-6951, code 514.53540 Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the under mentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.GASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec-District of Gaspé \u2014 Division of Magdalen Islands (\"T A CAISSE POPULAIRE DE HA-No.255.< L VRE-AUX-MAISONS, Magdalen 'islands, plaintiff.M Dr.MARCEL PARATTE.domiciled in Cap-aux-Mcules, Magdalen Islands, defendant.A certain parcel of land on the updated official cadastre for Grindstone Island, Municipality of Cap-aux-Mcules, Magdalen Islands Registration Division, known as lot one thousand seven hundred seventeen (1717) as shown on the cadastre, covering an area of 13,950 square feet, with a house erected thereon, appurtenances and dependencies.To be sold at the Ollice of the Registrar of the Magdalen Islands Registration Division, in the Havrc-Aubert Court House.M.I.on FRIDAY, the NINETEENTH day of OCTOBER, 1973, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Napoléon Bhiand, Court House, Assistant Sheriff.Havre-Aubert, M.I.53567 5388 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, September 1», 1073, Vol.105, No.37 Fieri Facias dc Terris Canada \u2014 Province dc Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal C O .VISSE POPULAIRE SAINT-No 05-004475-73A ^ JOSEPH DE BORDEAUX, l demanderesse, r* CHARLES-EDOUARD TREMBLAY, défendeur.« Un certain emplacement ayant front sur le Boulevard Taylor, en la Cité de Montréal, connu et désigné comme étant le lot quatre-vingt-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent vingt-sept (327-89) aux plan et livre de renvoi officiels dc la paroisse du Sault-au-Récollet.Avec la maison dessus érigée portant le numéro civique 11,932 du boulevard Taylor.Sujet à une servitude en faveur de la Compagnie de Téléphone Bell du Canada, enregistrée à Montréal, sous le numéro: 1041288.Tel que le tout se trouve présentement, avec tous ses droits, circonstances et dépendances sans exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice, en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le SEIZIÈME jour d'OCTOBRE 1973, à DEUX heures et TRENTE dc l'après-midi.Bureau du Shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 7 septembre 1973.53561-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court\u2014 District of Montreal C CAISSE POPULAIRE SAf.NT-Xo.05-004475-73.-) v-1 JOSEPH DE BORDEAUX, I plaintiff,CHARLES-EDOUARD TREMBLAY, defendant \"A certain emplacement fronting orr Taylor Boulevard, in the City of Montreal, known and described as lot eighty-nine of the official subdivision of original lot number three hundred twenty-seven (327-89) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Sault-au-Récollet.With the house erected thereon bearing civic number 11,932 Taylor Boulevard.Subject to a servitude in favour of the Bell Telephone Company of Canada, registered in Montreal, under number:\" 1041288.As the whole now subsists, with all its rights, appurtenances and dependencies, without exception or reservation.\" To be sold at the Sheriff's Ollice, in the City of Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Eloor, Room 56.on the SIXTEENTH day of OCTOBER, 1973, at TWO-THIRTY o'clock in the afternoon.Sheriff's Ollice, Pail St-Martix, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, September 7, 1973.53561 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Quebec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal { O T -LOUIS IX V EST M E N T No 05-000 902-73.< O CORP., demanderesse, is EOR-'TUXATO SAYA, défendeur, et ROSARIAIMBESI, mis en cause.« Un emplacement situé en la Cité dc Chomedey ayant front à la soixante-sixième Avenue, connu et désigné comme étant le lot numéro dix-sept subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-sept (197-17) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin; Avec toutes les bâtisses dessus construites, notamment une maison portant les numéros civiques 39 et 41 de ladite 66e Avenue, Chomedey.Avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval.155 boni.Je-Me-Souviens.à Laval, P.Q., le DIX-HUITIÈME jour d'OCTOBRE 1973, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 7 septembre 1973.53563-0 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal C CT-LO UIS IN V EST M EN T No 05-000 902-73.< 0 CORP., plaintiff, es FORTU-l NATO SAYA, defendant, and ROSARIA IMBESI, mis en cause.\"An emplacement located in the City of Chomedey, fronting on Sixty-sixth Avenue, known and described as lot number seventeen of the official subdivision of original lot number one hundred ninety-seven (197-17) otr the official plan and in the book of reference for the Parish of St.Martin; With all the buildings erected thereon, namely a house bearing civic numbers 39 and 41 of said 66th Avenue, Chomedey.With all active and passive, apparent or unapparcnt servitudes attaching to said immoveable.\" To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je-Me-Souviens Blvd., in Laval, (Que.), on the EIGHTEENTH day of OCTOBER, 1973, atELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin.Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, September 7, 1973.53563 MONTRÉAL MONTREAL GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, ir, septembre 1973, 105' année, n° 37 5389 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE D'ÉPARGNE No 05-005 822-73.< ^ DE LA CITÉ ET DU DIS- -' RANGE PRUDENTIELLE v D'AMÉRIQUE, (CANADA) LTD.a corporation duly ' incorporated, having a place of business at 400 Montée-dc-I.icssc.District of Montreal, Province of Québec, plaintiff, r* PHILIPPE MIGNAULT, businessman, residing and domiciled in Fort Coulongc, Province of Québec.District of Pontiac, defendant.Two (2) parts of lot 13-40, Range I, Township of Mansfield.Pontiac Registration Division, said parts being more fully described as follow: 1.All of that emplacement of rectangular configura; tion being part of subdivision 40 of lot 13 of the First Range on the official plan and iir the book of reference for the Township of Mansfield, measuring 102 feet 6 inches in width by 19S feet, more or less, in depth, the width being measured from the northwest to the southeast; the depth, from the southwest to the northeast.The northwest limit of said emplacement is parallel to and at a distance of 102 feet 6 inches to the southeast of Lévesque Street or Lauzon Boulevard (after widening which lakes a strip of about 5 feet in a northwest portion of said lot 13-40).The northeast boundary of said emplacement merges with the dividing line of said lot 13-10 and of the adjoining lot 13-24 of said Range ami said Township.This emplacement being bounded in front along its width towards the southwest bordering on Legucrrier Street made rrp of another part of said lot 13-40; in rear, on the cast along its width towards the northeast by the aforesaid dividing line between lots 13-40 arrd 13-24; lengthwise towards the northwest by another part of said lot 13-40 belonging to Jean-Baptiste Mignault or representatives, and lastly on the other side, lengthwise towards the southeast adjoining to the remainder of said lot 13-40, said emplacement with all buildings erected thereon and all active or passive servitudes.2.All of that guadrilateral part of lot 13-40, Range I, on the official plan and in the book of refcrerrce for the Township of Mansfield, measuring 165 feet in width from the northwest to the southeast by a depth of 130 feet, more or less, comprised within the following boundaries'; in front, on the southwest, adjoining to the new Provincial Highway Xo.8, in depth, on the northwest, to Poirier Street, irr depth, on the southeast to lot 12-1, Range I, Mansfield and lastly in rear, on the northeast, bordering on the other parts of said lot 13-40 occupied by Fcrrarier Marion or représentants, with all buildings erected thereon and all active or passive servitudes.To be sold at the Pontiac Division Rcgistrv Office, at Campbell's Bay, on the TWENTY-FOURTH day of OCTOBER, 1973, at TEN-THIRTY o'clock in the forenoon André Laçasse, Sheriff's Office, Sheriff: September 4, 1973.53523 5392 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 16, 1973, Vol.105, No.37 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Quebec, à savoir:/JOSEPH LESSARD, homme de Cour Provinciale, 1 J service, 130, St-Jcan-Baptiste, JN'o 59-054.S Villeneuve, P.Q., contre SIMONE (.FILTEAU LAG AC É, 139, St-Joscph, Beauport, P.Q., et RAYMOND GAGNÉ, ès qualité de registrateur dc la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.« Les lots huit cent quatorze - soixante, huit cent quatorze - soixante-six, huit cent quatorze - soixante et onze, huit cent quatorze - soixante-douze, huit cent quatorze - soixante-treize, huit cent quatorze - soixante-seize, huit cent quinze - vingt-cinq, huit cent quinze - vingt-huit, huit cent, quinze - vingt-neuf, huit cent quinze - trente, huit cent seize - vingt-neuf - un, huit cent seize - vingt-neuf - trois, huit cent seize - trente-deux, huit cent seize - trente-quatre, huit cent seize -trente-huit, huit cent seize - trente-neuf - un, huit cent seize - trente-neuf - trois, huit cent seize - quarante, huit cent seize - dix-huit, huit cent seize - sept -deux, huit cent seize - vingt-sept (814-60, 814-66, 814-71, 814-72, 814-73, 814-76.815-25, 815-28, 815-29, 815-30, 816-29-1.816-29-3, 816-32, 816-34, 816-38, 816-39-1, 816-39-3, 816-40, 816-18, 816-7-2, 816-27) du cadastre officiel pour la paroisse de Beauport, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendus au bureau d'enregistrement de Québec, 10, Avenue Chauveau.Québec, le DIX-HUITIÈME jour du mois d'OCTOBRE 1973, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 12 septembre 1973.53578-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( JOSEPH LESSARD, serviceman, Provincial Court, j J 130 St.Jean-Baptiste, Ville-No.59-054.) neuve.P.Q., versus SIMONE FIL-[ TEAU LAC»AC É, 139 St.Joseph, Beauport, P.Q., and RAYMOND GAGNÉ, in his capacity as registrar for the Québec Registration Division, mis en cause.\"Lots eight hundred fourteen - sixty, eight hundred fourteen - sixty-six, eight hundred fourteen - seventy-one, eight hundred fourteen - seventy-two, eight hundred fourteen - seventy-three, eight hundred fourteen - seventy-six, eight hundred fifteen - twenty-five, eight hundred fifteen - twenty-eight, eight hundred fifteen - twenty-nine, eight hundred fifteen - thirty, eight hundred sixteen - twenty-nine - one, eight hundred sixteen - twenty-nine - three, eight hundred sixteen - thirty-two, eight hundred sixteen - thirty-four, eight hundred sixteen - thirty-eight, eight hundred sixteen - thirty-nine - one, eight hundred sixteen -thirty-nine - three, eight hundred sixteen - forty, eight hundred sixteen - eighteen, eight hundred sixteen -seven - two, eight hundred sixteen - twenty-seven (814-60, 814-66, 814-71, 814-72, 814-73, 814-76, 815-25, 815-28, 815-29, 815-30.816-29-1, 816-29-3, 816-32, 816-34, 816-38, 816-39-1.816-39-3, 816-40, 810-18, 816-7-2, 810-27) on the officiai cadastre for the Parish of Beauport, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Quebec Registry Office.10 Chauveau Avenue, Québec, on the EIGHTEENTH day of OCTOBER, 1973, at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, September 12, 1973.53578 SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de St-François / DANQUE CANADIENNE NATIO-No 38,783a *-f NALE, corporation légalement cons-l tituée, ayant son siège social dans les cité et district de Montréal, demanderesse, vs GUY LA-BRECQUE, d'Asbestos, district de St-François, défendeur.« Le lot numéro quatre-vingt-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro huit cent-soixante-cinq (865-87) et le lot numéro un de la resubdivision du lot numéro quatre-vingt-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro huit cent soixante-cinq (865-88-1) au cadastre officiel du Village de Windsor-Mills, maintenant Ville de Windsor.SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court\u2014 District of Saint-François / \"DANK CANADIAN NATIONAL, a No.38,783.^ corporation legally incorporated, hav-v hig its head office in the City and District of Montreal, plaintiff, vs GUY LABRECQUE, of Asbestos, District of Saint-François, defendant.\"Lot number eighty-seven of the official subdivision of original lot number eight hundred sixty-five (865-87) and lot number one of the resubdivision of lot number eighty-eight of the official subdivision of original lot number eight hundred sixty-five (865-88-1) on the official cadastre for the Village of Windsor Mills, now the Town of Windsor. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 1973, 105' année, n° 37 5393 Avec maison dessus construite, circonstances et dé-I>cndanccs.» Pour être vendus « en bloc» au bureau d'enregistrement, à Richmond, P.Q., MARDI, le SEIZIÈME jour d'OCTOBRE 1973, à DIX heures de la matinée.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Palais de Justice, Jean-Guy Bisson.Sherbrooke, P.Q., ce G septembre 1973.535G6-o SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Saint-Hyacinthe l T) AOUL MALOUIX, demandeur vs Numéro: 7107.S iV RENÉ DUSSAULT, défendeur
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.