Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 mars 1971, samedi 6 (no 10)
[" 103» ANNÉE VOL.103 QUEBEC Gazette officie/le à Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE N° lO 2105 Québec, samedi 6 mars 1971 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer complunt et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazelle officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.Québec, Saturday, March 6, 1971 Rules 1, Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements arc payable in advance at rates set forth below, except when they arc to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like arc payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazelle is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline fsTuesdajuioon.Material not delivered in time \"will appear1 in-a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.\\ _^_z_ L'Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE.Québec Official Publisher 2106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: S4 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre S20; du 1er avril au 31 décembre, SI5 et du 1er juillet au 31 décembre, S10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nomhrc d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocii Lefebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1969 37883 \u2014 l-52-o 8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.Advertising, Rales, Subscriptions, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: S4 per 100 words.Single copies: SI each.Slips: S3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, S20; April 1st to December 31st, S15 and July 1st to December 31st, S10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazelle carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Rocii Lefebvre, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, April 30, 1969 37883 \u2014 l-52-o Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec 4, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Quebec Official Gazelle, please call : Georges Lapierre Quebec Official Gazelle Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec 4, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2107 Lettres patentes Action machineries inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Jean Frappier, Pierre Sal va il, tous deux avocats, et Cécile Péloquin, secrétaire, épouse de Gérald Péloquin, tous trois de 70, rue Roi, Sorel, pour les objets suivants: Exploiter une quincaillerie, sous le nom de « Action machineries inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 150 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Tracy.district judiciaire de Richelieu.Le soiis-ininislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PuiuppE Bouchard.38940-o 111-1971 Acroclub du Lac St-Jcan inc.Luke St.John Flying Club Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé tics lettres patentes, en d.itc du Se jour de janvier 1971, constituant en corporation: Benoît Lévesquc, 541, boulevard St-Joscph, Lucien Roy, 268, Côté, tous deux négociants, et Jean-Claude Boudrcault, pilote, rang St-Dominique, tous trois de Robcrval, pour les objets suivants: Faire le commerce de vaisseaux aériens de toutes sortes, de moteurs, bateaux, instruments de navigation aérienne et tic leurs necessoires, sous le nom de « Aéroclub du Lac St-Jean inc.\u2014 Lake St.John Flying Club Inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 500 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Roberval, district judiciaire de Roberval.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Puilippe Bouchard.38940-o 5110-1970 Agences Dcsirella inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Guy Bergeron, industriel, 320, St-Picrre, Jonquiôrc, Bernard Fortin, vendeur, 249, Stc-Famille, Kénogami, et Pierre Bergeron, avocat, 1175, Mclançon, Chicoutimi, pour les objets suivants: Exploiter des magasins de bonneterie, sous le nom de « Agences Désirclla inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 8,000 actions ordinaires de $5 chacune.Letters Patent Action machineries inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters _ patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean Frappier, Pierre Sal vail, both advocates, and Cécile Péloquin, secretary, wife of Gerald Péloquin, all three of 70 Roi Street, Sorel, for the following purposes: To operate an hardware business, under the name of \"Action machineries inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 2,500 common shares of a nominal value of S10 each and 150 preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at Tracy, judicial district of Richelieu.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial histitutions, Companies and Cooperatives.38940 111-1971 Aérorlub du Lac St-Jcan inc.Lake St.John Flying Club Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th dav of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bcnoft Lévesquc, 541 St-Joseph Boulevard, Lucien Roy, 268 Côté, both traders, and Jean-Claude Boudrcault, pilot, St-Dominique Range, all three of Roberval, for the following purposes: To deal in aircrafts of all kinds, motors, ships, aerial navigation instruments and their accessories, under the name of \"Aéroclub du Lac St-Jcan inc.\u2014 Lake St.John Flying Club Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 5,000 common shares of 810 each and 500 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Roberval, judicial district of Roberval.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5110-1970 Agences Désirclla inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by he Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Bergeron, industrialist, 320 St-Pierre Street, Jonquièrc, Bernard Fortin, salesman, 249 Ste-Famille, Kénogami, and Pierre Bergeron, advocate, 1175 Mclançon, Chicoutimi, for the following purposes: To operate knitted goods stores, under the name of \"Agences Désirella inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 8,000 common shares of 85 each. 2108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103- année, n° 10 Le siège social de la compagnie est 271, rue St-Hubert, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-ministre îles institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5563-1970 Artisanat Gaspésicn inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour de décembre 1970, constituant en corporation : Hélène Cimichclla, épouse de Michael Walker, 1307, Patrice, Lasalle, Jocelyne Cyr, épouse de Antonio Soarcs, 304, Montée Sanche, Roscmère, et André De Rome, épouse de Pierre Lacel-les, 0302, P.E.Lamarchc, Saint-Léonard, toutes trois secrétaires, pour les objets suivants: Faire le commerce de l'artisanat dans tous les domaines, sous le nom de ' Artisanat Gaspésicn inc.», avec un capital divisé en 30,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 100 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Mont-Saint-Picrrc, district judiciaire tic Gaspé.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5682-1970 lii'-iIaiil.Forticr et associés inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de janvier 1971, constituant en corporation: Pierre L.Lapointe, 155, Marcotte, Alexander S.Konigsberg, 2378, Frenctte, tous deux de Saint-Laurent, Mark Rosenstein, 5003, Lacombe, Montréal, Thomas A.Lavin, Knowlton, tous quatre avocats, et Dean Jodoin, secrétaire, fille majeure, 11000, Laurcntides, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom de « Bédard, Forticr et associés inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de SI chacune et en 35,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est 8, rue Bennett, Chambly, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 132-1971 Brasserie Québécoise inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Eugène Mercure, gérant, 605, Fontainebleau, Jean-Claude Mercure, 697, Au-teuil, et Claude Ouellette, 956, Frechette, ces deux The head office of the company is at 271 St-Hubert Street, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Ls-Piiiljppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5563-1970 Artisanat Gaspésicn inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Hélène Cimichclla, wife of Michael Walker, 1307 Patrice, Lasalle, Jocelync Cyr, wife of Antonio Soarcs, 304 Montée Sanche, Roscmère, and André De Rome, wife of Pierre Lacelles, 6302 P.E.Lamarche, Saint-Léonard, all three secretaries, for the following purposes: To deal in handicraft productions of all kind, under the name of \"Artisanat Gaspésicn inc.\", with a capital stock divided into 30,000 common shares without nominal value and 100 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Mont-Saint-Pierre, judicial district of Gaspé.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial hislilulions.Companies and Cooperatives.38940 5682-1970 Bédard, Fortier et associés inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre L.Lapointc, 155 Marcotte, Alexander S.Konigsberg, 2378 Frenette, both of Saint-Laurent, Mark Rosenstein, 5003 Lacombe, Montreal, Thomas A.Lavin, Knowlton, all four advocates, and Dean Jodoin, secretary, spinster of the full age of majority, 11000 Laurentidcs, Montreal-North, for the following purposes: To do business as insurance agents and brokers, under the name of \"Bédard, Fortier et associés inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 5,000 common shares of $1 each and 35,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 8, Bennett Street, Chambly, judicial district of Montreal.Ls-Philippe BoucnARD, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 132-1971 Brasserie Québécoise inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Eugène Mercure, manager, 605 Fontainebleau, Jean-Claude Mercure, 697 Auteuil, and Claude Ouellette, 956 Frechette, the latter two advo- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 derniers avocats, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Brasserie Québécoise inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 3839-1970 Centre Équestre La Cavalcade inc.La Cavalcade Equestrian Centre Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Marcel Robert, instructeur d'équitation, route rurale numéro 3, Mont-Saint-Hilairc, Roger Robert, entrepreneur en excavation, et Cécile Colin, ménagère, épouse dudit Roger Robert, ces deux derniers de 345, Grand boulevard, Saint-Bruno-dc-Montarvillc, pour les objets suivants: Administrer un centre d'équitation, sous le nom de * Centre Équestre La Cavalcade inc.\u2014 La Cavalcade Equestrian Centre Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Mont-Saint-11 il,lire, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5338-1970 F.Chapdelaine assurances inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Ferdinand Chapdelaine, courtier d'assurance, Gertrude Chapdelaine, ménagère, épouse dudit Ferdinand Chapdelaine, et Jean-Pierre Chapdelaine, assistant-comptable, tous trois de 1217, Beauregard, Longucuil, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom de « F.Chapdelaine assurances inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 105, boulevard de Gentilly ouest, Longueuil, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5445-1970 2109 cates, all three of Laval, for the following purposes: To operate holtels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Brasserie Québécoise inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940.3839-1970 Centre Équestre La Cavalcade inc.La Cavalcade Equestrian Centre Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marcel Robert, equestrian instructor.Rural Route number 3, Mcnt-Saint-Hilairc, Roger Robert, excavation contractor, and Cécile Colin, housewife, wife of said Roger Robert, the latter two of 345 Grand Boulevard, Saint-Bruno-dc-Montarville, for the following purposes: To administer an equestrian centre, under the name of \"Centre Équestre La Cavalcade inc.\u2014 La Cavalcade Equestrian Centre Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of S100 each.The head office of the company is at Mont-Saint-Hilaire, judicial district of Saint-Hyacinthe.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5338-1970 F.Chapdelaine assurances inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ferdinand Chapdelaine, insurance broker, Gertrude Chapdelaine, housewife, wife of said Ferdinand Chapdelaine, and Jean-Pierre Chapdelaine, assistant-accountant, all three of 1217 Beauregard, Longueuil, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, under the name of \"F.Chapdelaine assurances inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at 105 Gentilly Boulevard West, Longucuil, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 6445-1970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103- année, n\" 10 2110 Clinique Naturiste Brunct inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de janvier 1971, constituant en corporation : Jean-Marc Brunct, naturopaths, 219, Rive Elgar, llc-aux-Socurs, Jean-Luc Lauzon, stagiaire-natiiropathe, SG51, de Gaspé, Montréal, et Lise Dauphin, secrétaire, épouse de Gilles Proulx, Verdun, |>our les objets suivants: Exploiter et développer des centres de santé et bien-être par les méthodes naturistes, sous le nom de « Clinique Naturiste Brunct inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 7103, rue St-Denis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-miiiislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5939-1969 Club de Fer Royal de Sorel inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coo|>érativcs donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Fernand Beaulieu, noyauteur, 219, Prince, Gérard Lavalléc, rentier, 31, du Roi, et Jean Chevalier, constable, 29, du Prince, tous trois de Sorel, pour les objets suivants: Exploiter un club de fer, sous le nom de « Club de Fer Royal de Sorel inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 500 actions ordinaires de 850 chacune et en 300 actions privilégiées de S50 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sorel, district judiciaire de Richelieu.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5768-1970 Club optimiste St-Michel, Montréal Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Pierre Tremblay, avocat, 10450, rue Bélair, Pierrefonds, Henri Murray, restaurateur, 654, Val d'Anjou, Anjou, et Laurent Pellcgrino, gérant de banque, 675, Marguerite Bourgcoys, Laval, pour les objets suivants: Développer l'optimisme comme une philosophie de vie, sous le nom de « Club optimiste St-Michel, Montréal ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.Clinique Naturiste Bru ne t inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Marc Brunct, naturopath, 219 Elgar Rive, Ile-aux-Soeurs, Jean-Luc Lauzon, naturopath articled-student, 8651 de Gaspé, Montreal, and Lise Dauphin, secretary, wife of Gilles Proubr, Verdun, for the following purposes: To operate and develop health and well-being centres by the naturist methods, under the name of \"Clinique Naturiste Brunet inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 7103 St-Denis Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe BoucnARD, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5939-1969 , Club de Fer Royal de Sorel inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Fernand Beaulieu, core-maker, 219 Prince, Gérard Lavallée, annuitant, 31 du Roi, and Jean Chevalier, constable, 29 du Prince, all three of Sorel, for the following purposes: To operate a horsc-shoc club, under the name of \"Club de Fer Royal de Sorel inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $50 each and 300 preferred shares of $50 each.The head office of the company is at Sorel, judicial district of Richelieu.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5768-1970 Club optimiste St-Michel, Montréal Notice is given that under Part HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Pierre Tremblay, advocate, 10450 Bélair Street, Pierrefonds, Henri Murray, restaurant-owner, 654 Val d'Anjou, Anjou, and Laurent Pellcgrino, bank manager, 675 Marguerite Bourgcoys, Laval, for the following purposes: To develop optimism as a philosophy, under the name of \"Club optimiste St-Michel, Montreal\".The amount to which the value of immovable property which the corporation may acquire or possess is limited is $100,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5383-1970 Comité d'aide aux éprouvés de Deux-Montagnes inc.Two Mountains Community Emergency Association Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Ross McCarty, contremaître, 39, 13c Avenue, René Prud'homme, optométriste, 1825, Lakebreeze, et Francis Larivière, surveillant, 706, Rockland, tous trois de Deux-Montagnes, pour les objets suivants: Aider de toute manière les personnes dans le besoin pour toute cause, sous le nom de « Comité d'aide aux éprouvés de Deux-Montagnes inc.\u2014 Two Mountains Community Emergency Association Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 840,000.¦ Le siège social de la corporation est 258, 5e Avenue, Deux-Montagnes, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 3809-1970 Le comité des loisirs du boulevard St-Jean inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Pierre Marcoux, camionneur, 10655, boulevard St-Jean, René Poirier, papetier, boulevard St-Jean, Jeannot Bourassa, industriel, et Lise Dufresne, ménagère, épouse-dudit Jeannot Bourassa, ces deux derniers de 10795, boulevard St-Jean, tous quatre de Trois-Rivières, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Le comité des loisirs du boulevard St-Jean inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $10,000.Le siège social de la corporation est à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 110-1971 2111 The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5383-1970 Comité d'aide aux éprouvés de Deux-Montagnes inc.Two Mountains Community Emergency Association Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Ross McCarty, foreman, 39, 13th Avenue, René Prud'homme, optometrist, 1825 Lakebreeze, and Francis Larivière, supervisor, 706 Rockland, all three of Dcux-Montagnes, for the following purposes: To help in every way people who find themselves in need for one reason or the other, under the name of \"Comité d'aide aux éprouvés de Deux-Montagnes inc.\u2014 Two Mountains Community Emergency Association Inc.\".The amount to which the value of immovable property which the corporation may acquire or possess is limited is 840,000.The head office of the corporation is at 258, 5th Avenue, Dcux-Montagnes, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 3809-1970 Le comité des loisirs du boulevard St-Jcan inc.Notice is given that under Part DTI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Pierre Marcoux, trucker, 10655 St-Jcan Boulevard, René Poirier, stationer, St-Jean Boulevard, Jeannot Bourassa, industrialist, and Lise Dufresne, housewife, wife of said Jeannot Bourassa, the latter two of 10795 St-Jean Boulevard, all four of Trois-Rivières, for the following purposes: Organization of recreational activities, under the name of \"Le comité des loisirs du boulevard St-Jean inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable properties that the corporation may acquire and hold is $10,000.The head office of the corporation is at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 110-1971 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 2112 Compagnie de gestion J.N.Tessier inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jocelyne Baribeau, secrétaire, fille majeure, 425, rue Arcand, apt.3, Cap-de-la-Made-lcinc, Marccl-J.G.Beaumier, 3600, Place d'Auteuil, Trois-Rivières-Ouest, et Robert Huard, 2497, boulevard Normand, Trois-Rivières, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille (holding), sous le nom de « Compagnie de gestion J.N.Tessier inc.», avec un capital total de $2,000,300, divisé en 100 actions ordinaires de SI chacune, 5,000 actions privilégiées classe « A » de S100 chacune, 200 actions privilégiées classe « B» de SI chacune ct.cn 15,000 actions privilégiées classe « C » de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 21 rue Mance, Baie-Comeau, district judiciaire de Hauterive.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 71-1971 Construction Émcry Paquette inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Richard Paquette, Émery Paquette, tous deux entrepreneurs, et Louisellc Isabelle, diététicienne, épouse dudit Émcry Paquette, tous trois de 2, rue Marcel, Saint-Timothée, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de* Construction Émcry Paquette inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 2, rue Marcel, Saint-Timothée, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 4268-1970 Construction & Pavage Moderne ltée Modem Construction & Paving Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1971, autorisant la fusion de « Pavage & Construction Moderne inc.\u2014 Modern Paving & Construction Inc.», constituée par lettres patentes en date du 2 janvier 1970, « Sera Inc.», constituée par lettres patentes en date du 14 juin 1966, et « Sorel Asphalte ltée », constituée par lettres patentes en date du 17 juin 1954, toutes les lettres patentes précitées ayant été émises en vertu de Compagnie de gestion J.N.Tessier inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day ot December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jocelyne Baribcau, secretary, spinster of the full age of majority, 425 Arcand Street, Apartment 3, Cap-de-la-Madeleine, Marccl-J.G.Beaumier, 3600 d'Auteuil Place, Trois-Rivières-West, and Robert Huard, 2497 Normand Boulevard, Trois-Rivières, the latter two advocates, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Compagnie de gestion J.N.Tessier inc.\", with a total capital stock of S2,000,300, divided into 100 common shares of $1 each, 5,000 class \"A\" preferred shares of $100 each, 200 class \"B\" preferred shares of $1 each and 15,000 class \"C\" preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 21 Mance Street, Baie-Comcau, judicial district of Hautcrive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 71-1971 Construction Émcry Paquette inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Richard Paquette, Emery Paquette, both contractors, and Louisclle Isabelle, dietician, wife of the said Emery Paquette, all three of 2 Marcel Street, Saint-Timothée, for the following purposes: To do business as builders and general contractors in construction and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Construction Émery Paquette inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 2 Marcel Street, Saint-Timothée, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 4268-1970 Construction & Pavage Moderne ltce Modern Construction & Paving Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Pavage & Construction Moderne inc.\u2014 Modern Paving & Construction Inc.\", incorporated by letters patent dated January 2, 1970, \"Sera Inc.\", incorporated by letters patent dated June 14, 1966, and \"Sorel Asphalte ltée\", incorporated by letters patent dated June 17, 1954, all the aforesaid letters patent having been issued under QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 ladite première partie de la Loi des compagnies, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Construction & Pavage Moderne ltée \u2014 Modem Construction & Paving Ltd.», avec un capital total de §1,000,000, divisé en 60,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et en 400,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions, financières, compagnies et coopératives, ' Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5676-70 Créations Claude Hurtubisc ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Claude Hurtubisc, gérant, 8820, Girard in, Saint-Léonard, Maurice Martel, avocat, 1301, St-Viateur ouest, Outremont, et Lucille Roy, secrétaire, épouse de Jean-Claude Biais, 24, rue Gilles, Sainte-Thérèse-Ouest, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, graveurs, relieurs, éditeurs, photographes et tous autres commerces semblables, sous le nom de « Créations Claude Hurtu-bise ltée », avec un capital total de 540,000, divisé en 30 actions ordinaires de S10 chacune, 3,960 actions privilégiées classe « A » de S10 chacune et en 100 actions privilégiées classe « B » de SI chacune._ Le siège social de la compagnie est 8820, rue Girar-din, Saint-Léonard, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutioiis financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5604-1970 Marcel Dcaudelin inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Aimé Béllerose, gérant, 10677, Tanguay, Montréal, Marcel Deaudclin, industriel, et Thérèse Bélanger, ménagère, épouse dudit Marcel Deaudclin, ces deux derniers de 177, 7e Avenue, Laval, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce du savon et de ses produits, des détergents, de l'eau de javel, des cires, huiles, parfums, cosmétiques, lotions et autres produits semblables, sous le nom de « Marcel Deaudelin inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10' chacune et en 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 177, 7e Avenue, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, , compagnies et coopérative, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5698-1970 2113 said Part I of the Companies Act, for the following purposes : To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Construction & Pavage Moderne ltée \u2014 Modern Construction & Paving Ltd.\", with a total capital stock of S1,000,000, divided into 60,000 preferred shares of a par value of S10 each and 400,000 common shares of a par value of SI each.The head office of the company is at Notre-Dame-du-Bon-Conscil, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5676-70 Créations Claude Hurtubisc ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude Hurtubisc, manager, 8820 Girardin, Saint-Léonard, Maurice Martel, advocate, 1301 St-Viatcur West, Outremont, and Lucille Roy, secretary, wife of Jean-Claude Biais, 24 Gilles Street, Sainte-Tliérèsc-Oucst, for the following purposes: To do business as printers, engravers, bookbinders, publishers, photographers and all other related businesses, under the name of \"Créations Claude Hurtubisc ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 30 common shares of S10 each, 3,960 preferred shares class \"A\" of S10 each and 100 preferred shares class \"B\" of SI each.The head office of the company is at 8820 Girardin Street, Saint-Leonard, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5604-1970 Marcel Deaudclin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Aimé Bcllcrosc, manager, 10677 Tanguay, Montreal, Marcel Dcaudelin, industrialist, and Thérèse Bélanger, housewife, wife of the said Marcel Deaudelin, the latter two of 177, 7th Avenue, Laval, for the following purposes: To manufacture and to deal in soaps and its products, detergents, javel water, waxes, oils, perfumes, cosmetics, lotions and similar products, under the name of \"Marcel Deaudelin inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of S10 each and 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 177,7th Avenue, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial hislitutions, Companies and Cooperatives.38940 5698-1970 2114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 Les défrichements Warwick inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Bertrand Allard, cultivateur, Diane A.Allard, épouse dudit Bertrand Allard, tous deux de Saintc-Sérapliine, et Liliane Perreault, veuve de Albert Carrière, 00, Campagna, Victoriaville, ces deux dernières ménagères, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'entrepreneurs en excavation de toutes sortes, déplacement de terre de tous genres, sous le nom de « Les défrichements Warwick inc.», avec un capital total de S40,000, divisé en 200 actions ordinaires de S10 chacune et en 880 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Warwick, district judiciaire d'Arthabaska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38940-o 5686-1970 Delson Auto Parts Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jean Monette, inspecteur, 503, St-Georges, Drummondville, Jean-Claude Monette, 1, boulevard 9C, et Edmond Cassivi, 155, St-François-Xavier, ces deux derniers mécaniciens, de Delson, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de pièces d'automobiles et véhicules de toutes sortes, sous le nom de « Delson Auto Parts Inc.», avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 155, St-François-Xavier, Delson, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5504-1970 Déry automobile ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de janvier 1971, constituant en corporation: François Déry, marchand, Louise Trahan, ménagère, épouse dudit François Déry, tous deux de 424, Champlain, et Wilfrid Déry, bourgeois, 10, St-Hubert, tous trois de Saint-Jean, pour les objets suivants: Faire le commerce d'automobiles, camions, motocyclettes, vélocipèdes, tracteurs, aéroplanes ou tout autre genre de véhicules ou engins, sous le nom de « Déry automobile ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Les défrichements Warwick inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bertrand Allard, farmer, Diane A.Allard, wife of the said Bertrand Allard, both of Sainte-Séraphine, and Liliane Perreault, widow of Albert Carrière, 60 Campagna, Victoriaville, the latter two housewives, for the following purposes: To carry on a business as digging contractors, in excavations of all kinds and in earth removal, under the name of \"Les défrichements Warwick inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $10 each and 380 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Warwick, judicial district of Arthabaska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 ' 5686-1970 Delson Auto Parts Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean Monctte, inspector, 503 St-Gcorgcs, Drummondville, Jean-Claude Monette, 1, 9C Boulevard, and Edmond Cassivi, 155 St-François-Xavier, the latter two mechanics, of Delson, for the following purposes: To manufacture and deal in automobile and vehicle parts of all kinds, under the name of \"Delson Auto Parts Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without nominal value and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 155 St-François-Xavier, Delson, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5504-1970 Déry automobile ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: François Déry, merchant, Louise Trahan, housewife, wife of said François Déry, both of 424 Champlain, and Wilfrid Déry, gentleman, 10 St-Hubert, all three of Saint-John's, for the following purposes: To deal in automobiles, trucks, motocycles, velocipedes, tractors, airplanes or any other kinds of vehicles or motors, under the name of \"Déry automobile ltée », with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.108, No.10 Le siège social de la compagnie est à Saint-Jean, district judiciaire d'Ibcrville.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 385-1971 Les disques Jacob inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de décembre 1970, constituant en corporation: F.-Michel Gagnon, 5195, Coolbrock, Robcrl-P.Godin, 4222, Beaconsfield, tous deux de Montréal, et Claude Lachance, 30, Place Côte Vertu, app.509, Saint-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce île disquaire en général, sous le nom de « Les disques Jacob inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 30,000 actions privilégiées d'une valeur nominale «le SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5585-1970 Distribution Yvon Ellyson inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compognics, il n accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Denis Protcau, huissier, 1493, Lalemcnt, Yvon Ellyson, homme d'affaires, et Janine St-Picrrc, ménagère, épouse dudit Yvon Ellyson, ces deux derniers de 83, Brooks sud, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de distribution et de vente connu et désigné comme distributions de billets de loterie pour le compte de la « Société d'exploitation des loteries et courses du Québec», et toutes autres distributions, sous le nom de « Distributions Yvon Ellyson inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5657-1970 Les éditions Contemporaines inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Rolland Forget, Richard Martel et Jacques Gilbert, tous trois avocats, de 500, Place d'Armes, suite 1063, Montréal, pour les objets suivants: 2115 The head office of the company is at Saint-John's, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 385-1971 Les disques Jacob inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: F.-Michcl Gagnon, 5195 Coolbrook, Robert-P.Godin, 4222 Beaconsfield, both of Montreal, and Claude Lachance, 30 Côte Vertu Place, Apt.509, Saint-Laurent, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as record dealer is general, under the name of \"Les disques Jacob inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of a nominal value of 81 each and 30,000 preferred shares of a nominal value of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5585-1970 Distribution Yvon Ellyson inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Denis Proteau, bailiff, 1493 Lalemcnt, Yvon Ellyson, businessman, and Janine St-Picrre, housewife, wife of the said Yvon Ellyson, the latter two of 83 Brooks South, all three of Sherbrooke, for the fcllov.ing purposes: To run a business for the distribution and sale of lottery tickets on behalf of the \"Société d'exploitation des loteries et courses du Québec\", and for other kinds of distribution, under the name of \"Distributions Yvon Ellyson inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 .5657-1970 Les éditions Contemporaines inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Rolland Forget, Richard Martel and Jacques Gilbert, all three advocates, of 500 Place d'Armes, suite 1063, Montreal, for the following purposes: 2116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Agir comme producteur, réalisateur, imprésario, agent et conseiller de récitals, spectacles de variétés et de music-hall, sous le nom de « Les éditions Contemporaines inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune et en 7S0 actions privilégiées d'une valeur nominale de S50 chacune.Le siège social de la compagnie est 112, rue St-Paul, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5695-1970 Entreprises Roisclair & Dubois inc.Le ministre d'es institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Renald Boiscluir, hôtelier, 1007, Boulay, Acton Vale, Madeleine Lafond, caissière, fille majeure, 295, Notre-Dame, Nieolct, et Jean-Marie Dubois, fonctionnaire, 60, Gossclin, Drununondville, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Entreprises Boisclair & Dubois inc.», avec un capital total de S75.000, divise en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 650 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Acton Vale, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-q 167-1971 Les entreprises Domil inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Jean-Charles Latour, 239, Deguire, Saint-Laurent, Marc Valois, 4390, Old Orchard, tous deux avocats, et Jocelyne Dancause, secrétaire, fille majeure, 1646, Galt, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Les entreprises Domil inc.», avec un capital divisé en 20,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 105-1971 Les entreprises M.Léger inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et.coopératives donne avis, qu'en vertu de la première To carry on business as producer, director, impresario, agent and adviser for recitals, variety and music-hall shows, under the name of \"Les éditions Contemporaines inc.\", with a total capital slock of 840,000, divided into 100 common shares of a nominal value of S10 each and 780 preferred shares of a nominal value of S50 each.The head office of the company is at 112 St.Paul Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5695-1970 Entreprises Boisclair & Dubois inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Renald Boisclair, hotclkccper, 1007 Boulay, Acton Vale, Madeleine Lafond, cashier, spinster of the full age of majority, 295 Notre-Dame, Nieolct, and Jean-Marie Dubois, civil employee, 60 Gosselin, Drummondville, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Entreprises Boisclair & Dubois inc.\", with a total capital stock of S75.000, divided into 1,000 common shares of S10 each and 650 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Acton Vale, judicial district of Saint-Hyacinthe.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 167-1971 Les entreprises Domil inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Charles Latour, 239 Dcguirc, Saint-Laurent, Marc Valois, 4390 Old Orchard, both advocates, and Jocelyne Dancausc, secretary, spinster of the full age of majority, 1646 Gait, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Les entreprises Domil inc.\", with a capital ctock divided into 20,000 common shares without nominal value and 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 105-1971 Les entreprises M.Léger inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Marcel Léger, homme d'affaires, Jeanne d'Arc Lamontagnc, ménagère, épouse dudit Marcel Léger, tous deux de 6025, Mcrriam, Anjou, et Gérard Bourbonnière, notaire, 9101, Airlie, Lasalle, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de placement, sous le nom de « Les entreprises M.Léger inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 3,000 actions ordinaires de S10 chacune, et en 1,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 3337, avenue Desmartcau, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-7iiinistre des institutions financières, compagnies et- coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S940-o 5526-1970 Fédération du Canotage Long Parcours du Québec inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Nadcau, tailleur, 516, du Pont, Raymond St-Gcrmain, chef de bureau, 89, Chapleau, tous deux de Mont-Laurier, Luc Robillard, professeur d'éducation physique, 239, Central, Québec, Gérald Desfossés, culturiste, 6, Augusta, Sorel, et Gilles Labranche, registrateur, Ville-Marie, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif pour promouvoir le sport en général et le canotage de compétition en particulier, sous le nom de « Fédération du Canotage Long Parcours du Québec inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $40,000.Le siège social de la corporation est à Mont-Laurier, district judiciaire de Labelle.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5453-1970 Benoit Fcrland & fils ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de décembre 1970, constituant en corporation: Herman Ferland, étudiant, 8540, boulevard Ste-Anne, Château-Richer, Simon Ferland, vendeur, 26, Brome, Sainte-Foy, et Claire Maheux, secrétaire, épouse de Gilles Morin, 386, 14c Rue, Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de « Benoit Ferland & fils ltée », avec un capital total de $100,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 5,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.2117 December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marcel Léger, businessman, Jeanne d'Arc Lamontagne, housewife, wife of the said Marcel Léger, both of 6025 Mcrriam, Anjou, and Gérard Bourbonnière, notary, 9101 Airlie, Lasalle, for the following purposes: To carry on business as a real estate and investment company, under the name of \"Les entreprises M.Léger inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 3337 Dcsmar-teau Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Finaiicial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5526-1970 Fédération du Canotage Long Parcours du Québec inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Marcel Nadcau, tailor, 516 du Pont, Raymond St-Gcrmain, office chief, 89 Chaplcau, both of Mont-Laurier, Luc Robillard, physical culture professor, 239 Central, Québec, Gérald Desfossés, culturist, 6 Augusta, Sorel, and Gilles Labranche, registrar, Ville-Maric, for the following purposes: To form and operate a sport club for promoting sport in general and competition rowing in particular, under the name of \"Fédération du Canotage Long Parcours du Québec inc.\".The amount to which is limited the annual revenue from the immovable property that the corporation may acquire and hold is S40.000.The head office of the corporation is at Mont-Laurier, judicial district of Labcllc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5453-1970 Benoit Fcrland & fils ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Herman Ferland, student, 8540 Ste-Anne Boulevard, Chateau-Richer, Simon Fcrland, salesman, 26 Brume, Saint-Foy, and Claire Maheux, secretary, wife of Gilles Morin, 386, 14th Street, Québec, for the following purposes: To deal in building materials, under the name of \"Benoit Ferland & fils ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 5,000 common shares of a nominal value of $10 each and 5,000 preferred shares of a nominal value of $10 each. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 2118 Le siège social de la compagnie est 8540, boulevard Ste-Anne, Chateau-Richer, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Lb-Philippe Bouchard.38940-o 2131-1970 André Fortin Auto inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Gérard Rolland, mécanicien, rue St-Pierrc, Saint-Luc, André Fortin, 332, rue St-Jacqucs, et René Fournier, 495, rue Lalemant, ces deux derniers commerçants, de Saint-Jean, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « André Fortin Auto inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 320, rue St-Jac-ques, Saint-Jean, district judiciaire d'Rjcrvillc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5500-1970 Franconet inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de janvier 1971, constituant en corporation: Gérard Tardif, notaire, 20, Bord-du-Lae, Beaconsfield, Horst Wessel, entrepreneur, et Ausilia Maria Franzoni, ménagère, épouse dudit Horst Wessel, ces deux derniers de 256, Strasbourg, Dollàrd-des-Ormeaux, pour les objets suivants: Importer, exporter et faire ie commerce «le produits alimentaires et leurs accessoires, sous le nom de « Franconet inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 256, Strasbourg Drive, Dollard-des-Ormeaux, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 94-1971 G.S.T.Tire Casings Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a occordé des lettres patentes, en date du 21e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Guy Spénard, gérant, Clémence Tessier, administratrice, épouse de Gérard Spénard, tous deux de 7321, 12e Avenue, Montréal, Léo-Paul Tessier, menuisier, 11993, Henrietta, Mont- The head office of the company is at 8540 Ste-Anne Boulevard, Chateau-Richer, judicial district of Québec.Ls-PniLippE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 2131-1970 André Fortin Auto inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérard Rolland, mechanic, St-Pierrc Street, Saint-Luc, André Fortin, 332 St-Jacqucs Street, and René Fournier, 495 Lalemant Street, the latter two merchants, of Saint-Jean, for the following purposes: To do business as garage-owners and to deal in cars, motors, machinery and their accessories and parts, under the name of \"An«lré Fortin Auto inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 320 St-Jacques Street, Saint-Jean, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5500-1970 Franconct inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of January, 1971, have been issuctl by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérard Tardif, notary, 20 Bord-du-Lac, Beaconsfield, Horst Wessel, contractor, and Ausilia Maria Franzoni, housewife, wife of said Horst Wessel, the latter two of 256 Strasbourg, Dollard-des-Ormeaux, for the following purposes: To import, export and deal in food products and their accessories, under the name of \"Franconet inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 256 Strasbourg Drive, Dollar«l-des-Ormeaux, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 94-1971 G.S.T.Tire Casings Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act; letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy .Spénard, manager, Clémence Tessier, administrator, wife of Gérard Spénard, both of 7321, 12th Avenue, Montreal, Léo-Paul Tessier, carpenter, 11993 Henrietta, Montreal-North, and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 .2119 réal-Nord, et Lucien Bourgct, commis, 661, Patenaude, Laval, pour les objets suivants: Exercer le commerce de rechapage et de pneus neufs et usagés, sous le nom de « G.S.T.Tire Casings Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 7321, 12e Avenue, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5617-1970 Guy Gagnon inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Guy Gagnon, courtier d'assurances, Mariette Brisson, ménagère, épouse dudit Guy Gagnon, tous deux de 1148, Desrochers, et Normand Larouche, médecin, 708, Bon Désir, tous trois de Hauterivc, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'assurances générales sous toutes ses formes, sous le nom de « Guy Gagnon inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le_ siège social tic la compagnie est à Hauterive, district judiciaire de Hauterive.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5501-1970 Gestion V.P.D.inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Lambert Toupin, 194, avenue Melbourne,, Mont-Royal, Maurice-A.Forget, 269, avenue les Erables, Laval, Claude Lachance, 30, Place Côte Vertu, app.509, Saint-Laurent, Robert-P.Godin, 4222, avenue Beaconsfield, et Jean-L.-C.Aubcrt, 3105, rue Fcndall, ces deux derniers de Montréal, tous cinq avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de gestion mobilière et immobilière, de portefeuille et de placement, sous le nom de « Gestion V.P.D.inc.», avec un capital divisé en 5,000 actions ordinaires sans valeur nominale.Le siège social de la compagnie'est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Iœ sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5584-1970 Habitations de la Côte Nord inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première Lucien Bourget, clerk, 661 Patenaude, Laval, for the following purposes: To carry on business in retreading and to deal in new and second-hand tires, under the name of \"G.S.T.Tire Casings Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 7321, 12th Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5617-1970 Guy Gagnon inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Gagnon, insurance broker, Mariette Brisson, housewife, wife of the said Guy Gagnon, both of 1148 Desrochcrs, and Normand Larouche, physician, 708 Bon Désir, all three of Hauterive, for the following purposes: To carry on a general insurance business specializing in insurance of all kinds, under the name of \"Guy Gagnon inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Hauterive, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5501-1970 Gestion V.P.D.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Lambert Toupin 194 Melbourne Avenue, Mont-Royal, Maurice-A.Forget, 269 les Erables Avenue, Laval, Claude Lachance 30 Côte Vertu Place, Apt.509, Saint-Laurent, Robert-P.Godin, 4222 Beaconsfield Avenue, and Jean-L.-C.Aubert, 3105 Fendall Street, the latter two of Montreal, all five advocates, for the following purposes: To carry on business as a moveable and immoveable management, holding and investment company, under the name of \"Gestion V.P.D.inc.\", with a capital stock divided into 5,000 common shares without nominal value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5584-1970 Habitations de la Côte Nord inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 2120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 108\" année, n° 10 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Claude B.Thomas, 12210, Jasmin, Montréal, Normand Bourbonnais, 290, Blci-gnier, Saint-Laurent, et André B.Thomas, 823, Pratt, Outremont, tous trois industriels, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes s de matériaux, sous le nom de « Habitations de la Côte Nord inc.s, avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 123, Côte Vertu, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5747-1970 Les immeubles de l'Amiante inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Laval Turcotte, rentier, 243, rue Turcotte, Maurice Faucher, préposé aux achats, 1183, rue Jeanne Mancc, et Jean-R.Gardner, notaire, 179, rue Notre-Dame sud, tous trois de Thetford Mines, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les immeubles de l'Amiante inc.», avec un capital total de 8200,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de 8100 chacune et en 500 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 179, rue Notre-Dame sud, Thetford Mines, district judiciaire de Mégantic.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 131-1971 Les immeubles Dupernay ine.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Maurice-D.Godbout, 16, Place Cambrai, Outremont, Pierre Sauvé, 229, des Landes, Saint-Lambert, Claude Nadeau, 1615, Jules-Poitras, app.101, et Pierre Dozois, 4840, Édouard-Montpetit, app.2, ces deux derniers de Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Faires affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom de « Les immeubles Dupernay inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 30,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 81 chacune.1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude B.Thomas, 12210 Jasmin, Montreal, Normand Bourbonnais, 290 Bleignicr, Saint-Laurent, and André B.Thomas, 823 Pratt, Outremont, all three industrialists, for the following purposes: To carry on business as constructors and general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Habitations de la Côte Nord inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of S10 each and 200 preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at 123 Côte Vertu, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5747-1970 Les immeubles de l'Amiante inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 8th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Coo)>erativcs, incorporating: Laval Turcotte, annuitant, 243 Turcotte Street, Maurice Faucher, purchasing agent, 1183 Jeanne Mancc Street, and Jcan-R.Gardner, notary, 179 Notre-Dame Street South, all three of Thetford Mines, for the following purposes: To do business as a real estate and construction company, under the name of \"Les immeubles de l'Amiante inc.\", with a total capital stock of S200.000, divided into 1,500 common shares of S100 each and 500 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 179 Notre-Dame Street South, Thetford Mines, judicial district of Mégantic.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 131-1971 Les immeubles Dupernay inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Maurice-D.Godbout, 16 Cambrai Place, Outremont, Pierre Sauvé 229 des Landes, Saint-Lambert, Claude Nadeau, 1615 Julcs-Poitras, Apt.101, and Pierre Dozois, 4840 Édouard-Montpetit, Apt.2, the latter two of Montreal, all four advocates, for the following purposes: To carry on business as a real estate, building and investment company, under the name of \"Les immeubles Dupernay inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of a nominal value of 81 each and 30,000 preferred shares of a nominal value of 81 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March G, 1971, Vol.103, No.10 Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-u 190-1971 Les immeubles Sabrcvois inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Maurice-D.Godbout, 16, Place Cambrai, Outremont, Pierre Sauvé, 229, des Landes.Saint-Lambert, Claude Nadcaù, 1615, Jules-Poitras, app.101, et Pierre Dozois, 4840, Édouard-Montpetit, app.2, ces deux derniers de Montréal, tous quatre avocats, |k>ur les objets suivants: Fuire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom de « Les immeubles Sabrcvois inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 30,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Ac sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, \u2022 Ls-Philippe Bouciiaud.38940-o 189-1971 Roger Laehambrc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2Se jour de décembre 1970, constituant en corporation: Roger Laehambrc, marchand, Françoise Meunier, épouse dudit Roger Lachambre, et Lucille Lachambre, épouse de Marcel Beaulieu, ces deux dernières ménagères, tous trois de Saint-Ours, pour les objets suivants: Faire le commerce, l'entretien et la réparation des appareils de radio, de télévision, accessoires électriques, instruments de musique, leurs parties et accessoires, et autres marchandises semblables, sous le nom de « Roger Lachambre inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Ours, district judiciaire de Richelieu.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5490-1970 Gaétan Lavoie, ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Dcnysc Labrèchc, ouvrière, fille majeure, 71, rue Dufort, Gaétan Lavoie, vendeur, et 2121 The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 190-1971 Les immeubles Sabrcvois inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Mauricc-D.Godbout, 16 Cambrai Place, Ontremont, Pierre Sauvé, 229 des Landes, Saint-Lambert, Claude Nadeau, 1615 Jules-Poitras, Apt.101, and Pierre Dozois, 4840 Édouard-Montpetit, Apt.2, the latter two of Montreal, all four advocates, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Les immeubles Sabrcvois inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of a nominal value of 81 each and 30,000 preferred shares of a nominal value of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 189-1971 Roger Lachambre inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Lachambre, merchant, Françoise Meunier, wife of said Roger Lachambre, and Lucille Lachambre, wife of Marcel Beaulieu, the latter two housewives, all three of Saint-Ours, for the following purposes: To deal, entertain and repair radio and television sets, electrical accessories and musical instruments, their parts and supplies and other similar goods, under the name of \"Roger Lachambre inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of S100 each.The head office of the company is at Saint-Ours, judicial district of Richelieu.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5490-1970 Gaétan Lavoie, ltée Notice is given that under Part I of the Companies' Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Denyse Labrèchc, workwoman, spinster, 71 Dufort Street, Gaétan Lavoie salesman, and Jean- 2122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103- année, n\" 10 Jeannette Labrèchc, ménagère, épouse dudit Gaétan Lavoie, ces deux derniers de 986, rue Ste-Maric, tous trois de Chambly, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de produits, articles et marchandises de toutes sortes, sous le nom de « Gaétan Lavoie, ltée », avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 3,900 actions privilégiées «l'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 9S6, rue Ste-Marie, Chambly, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre tics institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 125-1971 Lemairc & I.emairc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jean-Maurice Lcmaire, 673a, boulevard Mercure, Gilles Lcmaire, 677, boulevard Mercure, tous deux arpenteurs-géomètres, et Ronald Aubé, commis de bureau, 416, Dumoulin, tous trois de Drummondville, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille (holding), sous le nom de < Lcmaire & Lcmaire inc.», avec un capital total de S 100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de SI chacune et en 9,500 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Drummondville, district judiciaire de Drummond.Le sous-mi?iistrc des inslitutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 149-1971 Normand Leroux Stables Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour de décembre 1970, constituant en corporation : Normand Leroux, vendeur, 1945, Arvida, Saint-Bruno-de-Montarville, Claude Godmairc, 3425, Papineau, #507, et Claude Gauvin, 3460, Place Decelles, #49, ces deux derniers gérants, de Montréal, pour les objets suivants: Faire l'achat, la vente, la location, le transport et l'entretien de chevaux, sous le nom de « Normand Leroux Stables Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1945, rue Arvida, Saint-Bruno-de-Montarville, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5622-1970 nette Labrèchc, housewife, wife of said Gaétan Lavoie, the latter two of 986 Ste-Marie Street, all three of Chambly, for the following purposes: To manufacture and deal in products, articles and goods of all kinds, under the name of \"Gaétan Lavoie, ltée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of a'nominal value of SI each and 3,900 preferred shares of a nominal value of S10 each.The head office of the company is at 9S6 Stc-Maric Street, Chambly, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 125-1971 Lcmaire & Lemairc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Maurice Lemairc, 673a Mercure Boulevard, Gilles Lemairc, 677 Mercure Boulevard, both land-surveyors, and Ronald Aubé, office clerk, 416 Dumoulin, all three of Drummondville, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Lemairc & Lemairc inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 5,000 common shares of SI each and 9,500 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Drummondville, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 149-1971 Normand Leroux Stables Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Normand Leroux, salesman, 1945 Arvida, Saint-Bruno-dc-Montarvillc, Claude Godmairc, 3425 Papincau, #507, and Claude Gauvin, 3460 Decelles Place, #49, the latter two managers, of Montreal, for the following purposes: To purchase, sell, hire, transport and maintain horsesi under the name of \"Normand Leroux Stables Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company is at 1945 Arvida Street, Saint-Bruno-dc-Montarville, judicial district of Montarville.Ls-PniLippE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5622-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 Levis T.V.service inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Jean-Guy Duinont, soudeur, 3411, Botrcl, René Dumont, professeur, 14, Orléans, et Gisèle Dumont, ménagère, épouse de Gilles Dumont, 14, St-IIonoré, tous trois de Lauzon, pour les objets suivants: Fabriquer, acheter, vendre, faire l'entretien et la réparation des appareils de radio, de télévision, accessoires électriques, instruments de musique, leurs parties et accessoires, et autres marchandises semblables, sous le nom de « Levis T.V.service inc.», avec un capital total de SIO.OOO, divisé en SOO actions ordinaires de SôO chacune.Le siège social de la compagnie est à Lévis, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 6-1971 Les liqueurs du Bas St-Laurent ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Armand Trotticr, commerçant, Pauline Gcndron, ménagère, épouse dudit Armand Trotticr, Ghislaine Trottier, et Micheline Trotticr, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous quatre de 55, Blanchctte, Mont-Joli, pour les objets suivants: Faire la préparation, l'embouteillage, la mise en marché et la distribution de toutes liqueurs, sous le nom de \" Les liqueurs du Bas St-Laurent ltée », avec un capital total tic $200,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 15,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 55, rue Blanchctte, Mont-Joli, district judiciaire de Rimouski.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38940-o 5647-1970 Les loisirs Parc Orléans incorporée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie île la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Paul Lefeb-vre, publicitaire, 6S5, 79e Rue est, Jacques Lachance, représentant, 7205, Place de Verncuil, et Mariclle Pinard, infirmière, épouse de Jules Pinard, 700, de Nogcnt, tous trois de Charlcsbourg, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Les loisirs Parc Orléans incorporée ».2123 Lévis T.V.service inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Guy Dumont, welder, 34B Botrcl, René Dumont, professor, 14 Orléans, and Gisèle Dumont, housewife, wife of Gilles Dumont, 14 St-Honoré, all three of Lauzon, for the following purposes: To manufacture, buy, sell, keep in good working order and repair radios, television sets, electric appliances, musical instruments, their parts and accessories and similar merchandise, under the name of \"Levis T.V.service inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 800 common shares of $50 each.The head office of the company is at Levis, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 6-1971 Les liqueurs du Bas St-Laurent ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives, incorporating: Armand Trottier, merchant, Pauline Gcndron, housewife, wife of the said Armand Trottier, Ghislaine Trottier, and Micheline Trottier, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, all four of 55 Blanchctte, Mont-Joli, for the following purposes: To proceed with the preparation, bottling, marketing and distribution of all kinds of soft drinks, under the name of \"Les liqueurs du Bas St-Laurent ltée\", with a total capital stock of $200,000, divided into 5,000 common shares of S10 each and 15,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 55 Blanchctte Street, Mont-Joli, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5647-1970 Les loisirs Parc Orléans incorporée Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Paul Lcfcbvre, publicist, 685, 79th Street east, Jacques Lachance, representative, 7205 Place de Verneuil, and Marielle Pinard, nurse, wife of Jules Pinard, 700 de Nogent, all three of Charlesbourg, for the following purposes: The organization of leisure-time activities, under the name of \"Les loisirs Parc Orléans incorporée\". GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 108' année, n\" 10 2124 Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corpora^ tion, est de 810,000.Le siège social de la corporation est à Charlesbourg, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S940-o 238-1971 Léo Mailhot inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Clément Trudel, 118, 1ère Avenue, André Fontaine, 5, des Sapins, tous deux de Notre-Dame-des-Prairies, et André Roy, 1077, Godin, Joliette, tous treis avocats, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de « Léo Mailhot inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 300 actions ordinaires de S10 chacune, 2,000 actions privilégiées classe « A » de SI chacune et en 3,500 actions privilégiées classe « B » de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 11, rue Landry, Saint-Alexis, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 114-1971 Marché Price inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Roger La pointe, gérant, 356, avenue Maltais, Rosaire Girard, commerçant, et Nora St-Pierre, ménagère, épouse dudit Rosaire Girard, ces deux derniers de 254, rue Price est, tous trois de Chicoutimi, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers, sous le nom de « Marché Price inc.», avec un capital total de 820,000, divisé en 400 actions ordinaires de 350 chacune.Le siège social de la .compagnie est à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5722-1970 Mercerie Lafleur inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et.coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Pierre-C.Fournier, 1880, de Rouville, André Rodrigue, 206, Kennedy sud, et Ronald Dudemaine, 630, Jacques-Cartier nord, tous trois avocats, de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités le commerce de mercerie, sous le nom de « Mercerie Lafleur inc.», avec The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire or possess is limited is 810,000.The head office of the corporation is at Charlesbourg, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 238-1971 Léo Mailhot inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Clément Trudel, 118, 1st Avenue, André Fontaine, 5 des Sapins, both of Notrc-Damc-des-Prairics, and André Roy, 1077 Godiri, Joliette, all three advocates, for the following purposes: To deal in the lumber trade under the name of \"Léo Mailhot inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 300 common shares of 810 each, 2,000 preferred shares class \"A\" of 81 each and 3,500 preferred shares class \"B\" of S10 each.The head office of the company is at 11 Landry Street, Saint-Alexis, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 114-1971 Marché Price inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Lapointe, manager, 356 Maltais Avenue, Rosaire Girard, trader, and Nora St-Pierre, housewife, wife of said Rosaire Girard, the latter two of 254 Price Street east, all three of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on business as grocers, under the name of \"Marché Price inc.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 400 common shares of $50 each.The head office of the company is at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial l7istitutio7is, Compa7iies a7id Cooperatives.38940 5722-1970 Mercerie Lafleur inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre-C.Fournier, 1880 de Rouville, André Rodrigue, 206 Kennedy South, and Ronald Dudemaine 630 Jacques-Cartier North, all three advocates, of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on, in all its specialties, an haberdashery business, under the name of \"Mercerie Lafleur inc.\", QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2125 un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 3,800 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlllUPPE bouchard.38940-o 5557-1970 with a total capital stock of S40.000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of $1 each and 3,800 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minuter of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5557-1970 Meubles Guy Nadcau inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de janvier 1971, constituant en corporation : Lionel Picard, comptable, 145, Gravel, Guy_ Nadeau, 110, Viau, et Gaston Bergeron, 173, Saint-Ephrcm, ces deux derniers vendeurs, tous trois de Chicoutimi-Nord, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles neufs et usagés, ameublements de maison et appareils électriques d'usage domestique, sous le nom de « Meubles Guy Nadeau inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 354, Ste-Anne, Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-ministre des i7istitutions financières, compagnies et,coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 133-1971 Mouflons des montagnes inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Renaud Couture, agent d'assurances, 156, Principale, J.-Hermas Poirier, épicier, Guy Biais, garagiste, Bertrand Frechette, hôtelier, Richard Gagnon, tous cinq de Lamb-ton, et Ghislain Giroux, Saint-Sébastien, ces deux derniers menuisiers, pour les objets suivants: Etablir, former et exploiter un club de moto-neige, sous le nom de « Mouflons des montagnes inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.Le siège social de la corporation est à Lambton, district judiciaire de Beauce.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 100-1971 Meubles Guy Nadeau inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Lionel Picard, accountant, 145 Gravel, Guy Nadeau, 110 Viau, and Gaston Bergeron, 173 Saint-Éphrem, the latter two salesmen, all three of Chicoutimi-North, for the following purposes: To deal in new and second-hand furniture, house furnishings and home electric appliances, under the name of \"Meubles Guy Nadeau inc.\", with a total capital stock of S40.0J0, divided into 400 common shares of S100 each.The head office of the company is at 354 Sainte-Anne, Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 133-1971 Mouflons des montagnes inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Renaud Couture, insurance agent, 156 Principale, J.-Hermas Poirier, grocer, Guy Biais, garage-owner, Bertrand Frechette, hotel-keeper, Richard Gagnon, all five of Lambton, and Ghislain Giroux, Saint-Sébastien, the latter two carpenters, for the following purposes: To organize, form and operate a snowmobile club, under the name of \"Mouflons des montagnes inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which may be acquired and owned by the corporation is $100,000.The head office of the corporation is at Lambton, judicial district of Beauce.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 100-1971 Murdock Lumber inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et cooopératives donne avis qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de décembre 1970, Murdock Lumber inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, 2126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 autorisant la fusion\" de « Murdock Lumber Co.», constituée par lettres patentes en date du 7 juin 1949, «Murdock & Fils ltée \u2014 Murdock & Son Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 26 novembre 1968, et \" Komduroc Construction Limited », constituée par lettres patentes en date du 20 octobre 1948, toutes les lettres patentes précitées ayant été émises en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de « Murdock Lumber inc.», avec un capital divisé en 60,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 2,000 actii.ns privilégiées de S100; et la considération totale pour laquelle les 60,000 actions ordinaires sans valeur nominale pourront être émises ne devra pas excéder 8300,000.Le siège social de la compagnie est 23 est, rue Racine, Chicoutimi, dans le district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-miitiilre des institutions financières, compagnies et coopératives.Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5551-70 Murray Bay Resort Hotels Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accerdé des lettres patentes, en date du 19c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Bernard Léveillé, secrétaire administratif, 14, Parc Marchand, Lorettevillc, Gilles Giroux, 1057, avenue Royale, Villeneuve, Jacques Taschcrcau, 315, avenue Laurier, tous deux notaires, et Huguette Fournel, secrétaire, fille majeure, 554, Latou-relîe, ces ceux derniers de Québec, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, motels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Murray Bay Resort Hotels Inc.», avec un capital divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur nominale.Le siège social de la compagnie est à Pointe-au-Pic, district judiciaire de Sagucnay.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 259-1971 Nadeau Êlectrix inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Gérald Nadeau, maître-électricien, 9S4, Riel, Laval, Ronald Clément, électricien, 6559, 21c Avenue, Montréal, et Ninon Joly, ménagère, épouse de Jules Aubin, 6315, Paul-Émile Lamarche, Saint-Léonard, pour les objets suivants: Faire affaires comme maîtres-électriciens; fabriquer et faire le commerce de toutes sortes de matériaux et appareils électriques, sous le nom de « Nadeau Élcctrix inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.authorizing the amalgamation of \"Murdock Lumber Co.\", incorporated by letters patent dated June 7, 1949, \"Murdock & Fils ltée \u2014 Murdock & Son Ltd.\", incorporated by letters patent dated November 26, 1968, and \"Komduroc Construction Limited\", incorporated by letters patent dated October 20, 1948, all the aforesaid letters patent having been issued under said Part I of the Companies Act, for the following purposes: Industry and trade of wood, under the name of \"Murdock Lumber inc.\", with a capital stock divided into 60,000 common shares without nominal value and 2,000 preferred shares of S100 each; and the aggregate consideration for which the 60,000 common shares without nominal value may be issued shall not exceed 8300,000.The head office of the company is at 23 Racine Street East, Chicoutimi, in the judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5551-70 Murray Bay Resort Hotels Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bernard Léveillé, administrative secretary, 14 Marchand Park, Lorettevillc, Gilles Giroux, 1057 Royale Avenue, Villeneuve, Jacques Taschcrcau, 315 Laurier Avenue, both notaries, and Huguette Fournel, secretary, spinster of the full age of majority, 554 Latourelie, the latter two of Québec, for the following purposes: To operate hotels, motels, taverns, inns, and restaurants, under the name of \"Murray Bay Resort Hotels Inc.\", with a capital stock divided into 10,000 common shares without nominal value.The head office of the company is at Pointc-au-Pic, judicial district of Saguenay.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies atid Cooperatives.38940 259-1971 Nadeau Élcctrix inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérald Nadeau, master electrician, 984 Riel, Laval, Ronald Clément, electrician 6559, 21st Avenue, Montreal, and Ninon Joly, housewife, wife of Jules Aubin, 6315 Paul-Emile Lamarche, Saint-Léonard, for the following purposes: To carry on business as masters electricians; to manufacture and deal in all kinds of electrical materials and apparatus, under the name of \"Nadeau Élcctrix inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 300 preferred shares of 8100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March G, 1971, Vol.103, No.10 Le siège social de la compagnie est 8757, 14e Avenue, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 85-1971 Omicron Holding Company Ltd.La Cic de gestion Omicron ltée Le ministre des instituions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Jacques Morand, notaire, 4S94, Valéry, Saint-Léonard, Mariette Henry, épouse de Réjcan Jobin, 6180, Roi René, Anjou, et Gisèle Desroches, épouse de Jean-Marie Langlois, 624, Taillon, Montréal, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de « Omicron Holding Company Ltd.\u2014 La Cie de gestion Omicron ltée », avec un capital total de 840,000, divisé en 2,400 actions ordinaires de SI chacune, 35,000 actions privilégiées classe « A » de SI chacune et en 2,600 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 4001, boulevard Métropolitain est, suite 200, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o \u2022 12-1971 Organisation des sports et loisirs de Stc-Agncs de Bclcombc Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Luc Roy, Joseph Prévost, tous deux électriciens, Claire Gaignard, ménagère, épouse dudit Joseph Prévost, Marcel Mercier, journalier, Juliette Paquin, ménagère, épouse dudit Marcel Mercier, et Roger Levesque, cultivateur, tous six de Sainte-Agnès de Belcombc, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Organisation des sports et loisirs de Ste-Agnès de Belcombc ».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 815,000.Le siège social de la corporation est à Sainte-Agnès de Belcombe, district judiciaire de Rouyn-Noranda.IjC sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5426-1970 2127 The head office of the company is at 8757, 14th Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 85-1971 Omicron Holding Company Ltd.La Cic de gestion Omicron ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Morand, notary, 4894 Valéry, Saint-Léonard, Mariette Henry, wife of Réjean Jobin, 6180 Roi René, Anjou, and Gisèle Desroches, wife of Jean-Marie Langlois, 624 Taillon, Montreal, the latter two secretaries, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Omicron Holding Company Ltd.\u2014 La Cie de gestion Omicron ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,400 common shares of 81 each, 35,000 class \"A\" preferred shares of SI each and 2,600 class \"B\" preferred shares of SI each.The head office of the company is at 4001 Metropolitan Boulevard East, suite 200, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 12-1971 Organisation des sports et loisirs de Ste-Agnès de Belcombe Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to incorporate a corporation without share capital: Jean-Luc Roy, Joseph Prévost, both electricians, Claire Gaignard, housewife, wife of the said Joseph Prévost, Marcel Mercier, labourer, Juliette Paquin, housewife, wife of the said Marcel Mercier, and Roger Levesque, farmer, all six of Sainte-Agnès de Belcombe, for the following purposes: To organize leisure-time activities, under the name of \"Organisation des sports et loisirs de Ste-Agnès de Belcombe\".The amount to which the annual revenue of the immovable property which the corporation may acquire or possess is limited is S15.000.The head office of the company is at Sainte-Agnès de Belcombe, judicial district of Rouyh-Noranda.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5426-1970 2128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 P.V.Plus, manufacturiers ltée P.V.Plus Manufacturers Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de janvier 1971, constituant en corporation: G.Harold Picket, 47, Arlington, West-mount, Claude Boisvcrt, 1505, Moore, Laval, Guy-E.Boisvert, 4976, Glcncairn, tous trois avocats, Dcnyse Marcoux, secrétaire, 1488, Gait, et Yolande Poliseno, réceptionniste, 7928, Durccher, ces deux dernières filles majeures, ces trois derniers de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de moteurs, d'appareils et objets de toutes sortes, machines, leurs parties et accessoires et autres instruments, sous le nom de \" P.V.Plus, manufacturiers ltée \u2014 P.V.Plus Manufacturers Ltd.», avec un capital divisé en 3,000,000 d'actions ordinaires sans valeur nominale.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.38940-o 36-1971 P.V.station service me.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Michel Pineault, mécanicien, Manon Brunclle, secrétaire, épouse dudit Michel Pineault, tous deux de 3256, Firmin, Jacques Viau, vendeur, et Christiane Raymond, secrétaire, épouse dudit Jacques Viau, ces deux derniers de 33, 5e Rue, app.3, tous quatre de Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce de toutes sortes de véhicules et moyens de transport, sous le nom de « P.V.station service inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 3480, boulevard Dagenais, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5723-1970 Les placements Gilles Neveu inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jean-Yves Neveu, 517, 10e Avenue, Gilles Neveu, tous deux plombiers, et Madeleine Guillemette, ménagère, épouse dudit Gilles Neveu, ces deux derniers de 521, 10e Avenue, tous trois de Laval, pour les objets suivants: P.V.Plus, manufacturiers ltée P.V.Plus Manufacturers Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: G.Harold Pickel, 47 Arlington, Wcstmount, Claude Boisvcrt, 1505 Moore, Laval, Guy-E.Boisvert, 4976 Glcncairn, all three advocates, Dcnyse Marcoux, secretary, 1488 Gait, and Yolande Poliseno, receptionist, 7928 Durochcr, the latter two spinsters of the full age of majority, the latter three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and to deal in motors, appliances and objects of all kinds, machinery, parts, accessories and other instruments, under the name of \"P.V.Plus, manufacturiers ltée \u2014 P.V.Plus Manufacturers Ltd.\", with a capital stock divided into 3,000,000 common shares of no nominal value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 36-1971 P.V.station service inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of Japuary, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel Pineault, mechanic, Manon Brunelle, secretary, wife of the said Michel Pineault, both of 3256 Firmin, Jacques Viau, salesman, and Christiane Raymond, secretary, wife of the said Jacques Viau, the latter two of 33, 5th Street, Apt.3, all four of Laval, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers and to deal in all kinds of vehicles and to provide means of transportation, under the name of \"P.V.station service inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of SI each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 3480 Dagenais Boulevard, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5723-1970 Les placements Gilles Neveu inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Yves Neveu, 517, 10th Avenue, Gilles Neveu, both plumbers, and Madeleine Guillemette, housewife, wife of said Gilles Neveu, the latter two of 521, 10th Avenue, all three of Laval, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 Faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de * Les placements Gilles Neveu inc.», avec un capital total de 340,000, divisé en 30 actions ordinaires de S10 chacune, 3,961 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 9 actions privilégiées classe « B » de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 521, 10e Avenue, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5786-1970 Placements Gil-Po inc.Le ministro des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de décembre 1970, constituant en corporation: Pauline St-Maurice, ménagère, veuve de Gilles Labonté, 1180, d'Auteuil, Jean-Paul Bertrand, gérant de ventes, 3542, Lagardc, tous deux de Laval, Yves Labonté, président de Radio-Québec, 2225, Nicolas Pcrrot, André Labonté,.notaire, 4850, Côte des Mcigcs, app.1001, tous deux de Montréal, et Philippe St-Maurice, assistant inspecteur, 12024, Laurier, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de « Placements Gil-Po inc.», avec un capital divisé en 400 actions ordinaires sans valeur nominale, 2,452 actions privilégiées classe « A » de $100 chacune et en 1,080 actions privilégiées classe « B » de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1050, Côte du Beaver Hall, chambre 1600, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-7iii7iistre des i7islitutions financières, compag7iies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5357-1970 Les placements Jean^Yves Neveu inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Gilles Neveu, 521, 10e Avenue, Jean-Yves Neveu, tous deux plombiers, et Simonne Vaillancourt, ménagère, épouse dudit Jean-Yves Neveu, ces deux derniers de 517, 10e Avenue, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de < Les placements Jean-Yves Neveu inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 30 actions ordinaires de $10 chacune, 3,961 actions privilégiées classe « A » de S10 chacune et en 9 actions privilégiées classe « B » de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 517, 10e Avenue, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-7iiinistre des institutions fi7iancières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5787-1970 2129 To carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"Les placements Gilles Neveu inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 30 common shares of $10 each, 3,961 class \"A\" preferred shares of $10 each and 9 class \"B\" preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 521, 10th Avenue, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutio7is, Companies and Cooperatives.38940 5786-1970 Placements Gil-Po inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pauline St-Maurice, housewife, widow of Gilles Labonté, 1180 d'Auteuil, Jean-Paul Bertrand, sales manager, 3542 Lagarde, both of Laval, Yves Labonté, president of Radio-Québec, 2225 Nicolas Pcrrot, André Labonté, notary, 4850 Côte des Neiges, Apt.1001, both of Montreal, and Philippe St-Maurice, assistant inspector, 12024 Laurier, Montreal-North, for the following purposes: To do business as an investment company, under the name of \"Placements Gil-Po inc.\", with a capital stock divided into 400 common shares of no nominal value, 2,452 preferred shares class \"A\" of $100 each and 1,080 preferred shares class \"B\" of 810 each.The head office of the company is at 1050 Beaver Hall Hill, room 1600, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Mi7iisler of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5357-1970 Les placements Jean-Yves Neveu inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles Neveu, 521, 10th Avenue, Jean-Yves Neveu, both plumbers, and Simonne Vaillancourt, housewife, wife of the said Jean-Yves Neveu, the latter two of 517, 10th Avenue, all three of Laval, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"Les placements Jean-Yves Neveu inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 30 common shares of $10 each, 3,961 class \"A\" preferred shares of $10 each and 9 class \"B\" preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 517, 10th Avenue, Laval, Judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5787-1970 2130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Plomberie L.Chalifoux ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Guy Raderniakcr, Sainte-Véronique, Leopold Chalifoux, tous deux plombiers, et Hugucttc Hébert, secrétaire, épouse dudit Leopold Chalifoux, ces deux derniers de Nomininguc, pour les objets suivants: Paire affaires comme entrepreneurs en plomberie et chauffage et faire le commerce de toutes sortes d'appareils ou systèmes de chauffage, sous le nom de « Plomberie L.Chalifoux ltée », avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie st à L'Annonciation, district judiciaire de Labellc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 112-1971 Plomberie Ray St-Jcan inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Raymond St-Jean, plombier, Lucienne Gagnon, ménagère, épouse dudit Raymond St-Jean, tous deux de 23, Sarto, et Réal Racctte, voyageur, 29, Sarto, tous trois de Repentigny, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en pomberie, chauffage et réfrigération et faire le commerce de toutes sortes d'appareils ou systèmes de chauffage, sous le nom de « Plomberie Ray St-Jean inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S5 chacune, 20,000 actions privilégiées classe « A » de SI chacune et en 10,000 actions privilégiées classe « B » de SI chacune.Le siège social de la compagnie est 23, rue Sarto, Repentigny, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 136-1971 Prima Maintenance Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de janvier 1971, constituant en corporation : Maurice St-Jcan, entrepreneur, Thérèse Lacourse, ménagère, épouse dudit Maurice St-Jcan, tous deux de 11760, Dorchester est, Montréal, et Pierre Despatis, avocat, 85, Auguste Lacaillc, Boucherville, pour les objets suivants: Entretenir, nettoyer, laver, décorer, peinturer et généralement contracter pour les travaux se rapportant Plomberie L.Chalifoux ltcc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12lh day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and .Coopératives, incorporating: Guy Raderniakcr, Sainte-Véronique, Leopold Chalifoux, both plumbers, and Hugucttc Hébert, secretary, wife of said Leopold Chalifoux, the latter two of Nomininguc, for the following purposes: To carry on business as plumbing and heating contractors and to deal in all kinds of heating apparatus and systems, under the name of \"Plomberie L.Chalifoux liée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of S10 each and 200 preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at L'Annonciation, judicial district of Labcllc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 112-1971 Plomberie Ray St-Jcan inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29lh da' jf December, 1970, have been issue by the Minist of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Raymond St-Jean, plumber, Lucienne Gagnon, housewife, wife of said Raymond St-Jean, both of 23 Sarto, and Real Racette, traveller, 29 Sarto, all three of Repentigny, for the following purposes: To carry on business as plumbing, heating and refrigeration contractors and to deal in all kinds of heating apparatus and systems, under the name of \"Plomberie Ray St-Jean inc.\", with a total capital slock of S40.000, divided into 2,000 common shares of S5 each, 20,000 class \"A\" preferred shares of SI each and 10,000 class \"B\" preferred shares of SI each.The head office of the company is at 23 Sarto Street, Repentigny, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 136-1971 Prima Maintenance Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Maurice St-Jean, contractor, Thérèse Lacourse,\"\" housewife, wife of said Maurice St-Jean, both of 11760 Dorchester East, Montreal, and Pierre Despatis, advocate, 85 Auguste Lacaille, Boucherville, for the following purposes: To entertain, clean, wash, decorate, paint and generally act as contractors for the works pertaining to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.108, No.10 à la conciergerie et autres travaux semblables, sous le nom de « Prima Maintenance Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 18-1971 Produits Sévis inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Demetrius Sevapstidis, Bellefeuille, Gratien Descoteaux, tous deux industriels, et Madeleine Landry, ménagère, épouse dudit Gratien Descoteaux, ces deux derniers de Saintc-Scholastique, pour les objets suivants: Exploiter une laiterie dans toute ses spécialités, sous le nom de « Produits Sévis inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est rang St-Camille, Bellefeuille, 'district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 48-1971 Proulx & Gcnessc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Francis Proulx, marchand, Raymond Gencssc, gérant, et Jean-Marc Gcnessc, camionneur, tous trois de Authier, pour les objets suivants:\" Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Proulx & Gencssc inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Authier, district judiciaire d'Abitibi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.' 38940-o 5186-1970 M.Quintal inc.Le ministre des institutions financières, \"compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Joseph Rivard, vendeur, 8110, du Cap, Saint-Léonard, Marcel Quintal, 6375, Lan-gelier, et Jean-Jacques Gauthier, 8596, Choquctte, ces deux derniers administrateurs, de Montréal, pour les objets suivants: 2131 caretaking and other similar works, under the name of \"Prima Maintenance Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 18-1971 Produits Scvis inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Demetrius Sevapstidis, Bellefeuille, Gratien Descoteaux, both industrialists, and Madeleine Landry, housewife, wife of the said Gratien Descotcaux, the latter two of Saintc-Scholastique, for the following purposes : To operate a dairy with all its specialties, under the name of \"Produits Scvis inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 3,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Range St-Camille, Bellefeuille, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 48-1971 Proulx & Gencssc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Francis Proulx, merchant, Raymond Gcncsse, manager, and Jean-Marc Gcncsse, truck-driver, all three of Authier, for the following purposes: To carry on business as a transportation company, under the name of \"Proulx & Gcnessc inc.\", with a total capital stock of 540,000, divided into 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company is at Authier, judicial district of Abilibi.Ls-Philippe Bouchard, , Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5186-1970 M.Quintal inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Joseph Rivard, salesman, 8110 du Cap, Saint-Léonard, Marcel Quintal, 6375 Langelier, and Jean-Jacques Gauthier, 8596 Choquctte, the latter two administrators, of Montreal, for the following purposes: I GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 108' année, n\" 10 2132 Faire affaires comme buandicrs et faire la location et l'entretien de tabliers, serviettes, nappes et lingerie de toutes sortes, sous le nom de « M.Quintal inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 2860, boulevard de la Concorde, Laval, district judiciaire de Montréal.Le.sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 160-1971 Rapid Gaz Bar inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Edward .1.Druker, 5763, Mc-Murray, Côte Saint-Luc, Robert G.Wolfe, 2050 De Maisonncuve, app.115, Montréal, tous deux avocats, et Rachel R.Sands, secrétaire, veuve de Samuel Sands, 8659, Des Rapides Terrace, Lasalle, pour les objets suivants: Agir comme importateurs, expéditeurs, entrepreneurs, transporteurs, trafiqueurs, fournisseurs, et distributeurs ou/et négociants dans l'essence, pétrole, petroleum, produits pétroliers, et produits secondaires de toute nature, sous le nom de « Rapid Gaz Bar inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 3889-1970 Restaurant Jardin Hochelaga inc.Iiochelaga Garden Restaurant Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Jean-Paul Ménard, commerçant, Lise Malouin, gérante, épouse dudit Jean-Paul Ménard, tous deux de 8794, Hochelaga, Montréal, et Denise Legault, ménagère, épouse de Richard Hébert, 1450, 12e Avenue, app.204, Pointe-aux-Trembles, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Restaurant Jardin Hochelaga inc.\u2014 Hochelaga Garden Restaurant Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 8792, rue Hochelaga, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 4907-1970 To carry on business as launderers and to rent and maintain aprons, napkins, table-cloths and lingerie of all kinds, under the name of \"M.Quintal inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 2860 de la Concorde Boulevard, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 160-1971 Rapid Gaz Bar inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Edward J.Drukcr, 5763 McMurray, Côte Saint-Luc, Robert G.Wolfe, 2050 Dc Maisonncuve, Apt.115, Montreal, both advocates, and Rachel R.Sands, secretary, widow of Samuel Sands, 8659 Des Rapides Terrace, Lasalle, for the following purposes: To act as importers, shippers, contractors, forwarders, traders, suppliers and distributors or/and merchants in essence, petroleum, petroleum products and byproducts of all nature, under the name of \"Rapid Gaz Bar inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 20,000 common shares of a nominal value of SI each and 2,000 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial histitutions.Companies and Cooperatives.38940 3889-1970 Restaurant Jardin Hochelaga inc.Hochelaga Garden Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Paul Ménard, merchant, Lise Malouin, manager, wife of the said Jean-Paul Ménard, both of 8794 Hochelaga, Montreal, and Denise Legault, housewife, wife of Richard Hébert, 1450, 12th Avenue, Apt.204, Pointe-aux-Trembles, for the following purposes: To do business as restaurant-owners, under the name of \"Restaurant Jardin Hochelaga inc.\u2014 Hochelaga Garden Restaurant Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at 8792 Hochelaga Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 4907-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March G, 1971, Vol.103, No.10 Restaurant Rosaire Deshaies ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Rosaire Deshaies, Marie-Rose Chartier, épouse dudit Rosaire Deshaies, tous deux restaurateurs, de 160, Brassard, et Roland Chartier, gérant, 576, Monseigneur Courchesne, tous trois de Ni-colet, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Restaurant Rosaire Deshaies ltée », avec un capital total de 840,000, divisé en 10 actions ordinaires de 810 chacune, 90 actions privilégiées classe « A » de 810 chacune et en 390 actions privilégiées classe « B » de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Nicolet, district judiciaire de Nicolet.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 4765-1970 Rioux, Ouellct & Labrie inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de décembre 1970, autorisant la fusion de « Cypricn Rioux & Associés inc.», constituée par lettres patentes en date du 28 juin 1968, et « Rosaire Labrie inc.», constituée par lettres patentes en date du 15 octobre 1968, toutes les lettres patentes précitées ayant été émises en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies, pour les objets suivants: Agir comme courtiers en assurance, sous le nom de « Rioux, Ouellct & Labrie inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Trois-Pistoles, dans le district judiciaire de Kamouraska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5301-1970 Hector Robert inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Hector Robert, comptable, Pauline Chrétien, ménagère, épouse dudit Hector Robert, tous deux de 6, Lionel Groulx, et Fernand Larose, notaire, 31, Jean XXIII, tous trois de Pointe-Gatincau, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous-le nom de « Hector Robert inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.2133 Restaurant Rosaire Deshaies ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Rosaire Deshaies, Marie-Rose Chartier, wife of the said Rosaire Deshaies, both restaurant-owners, of 160 Brassard, and Roland Chartier, manager, 576 Monseigneur Courchesne, all three of Nicolet, for the following purposes: To do business as restaurant-owners, under the name of \"Restaurant Rosaire Deshaies ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10 common shares of 810 each, 90 preferred shares class \"A\" of 810 each and 390 preferred shares class \"B\" of 8100 each.The head office of the company is at Nicolet, judicial district of Nicolet.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 4765-1970 Rioux, Ouellct & Labrie inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Cyprien RiouX & Associés inc.\", incorporated by letters patent dated June 28, 1968, and \"Rosaire Labrie inc.\", incorporated by letters patent dated October 15, 1968, all the aforesaid letters patent having been issued under said Part I of the Companies Act, for the following purposes: To act as insurance brokers, under the name of \"Rioux, Ouellet & Labrie inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Trois-Pistoles, in the judicial district of Kamouraska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5301-1970 Hector Robert inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Hector Robert, accountant, Pauline Chrétien, housewife, wife of said Hector Robert, both of 6 Lionel Groulx, and Fernand Larose, notary, 31 Jean XXIII, all three of Pointe-Gatineau, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Hector Robert inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each. 2134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Le siège social de la compagnie est à Amos, district judiciaire d'Abitibi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5509-1970 Jean-Paul Ross inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Jean-Paul Ross, entrepreneur, Eliane I.epnge, ménagère, épouse dudit Jean-Paul Ross, et Gaélane Ross, secrétaire, fille majeure, tous trois de 140, Smith, Sepf-Ilcs, pour les objets suivants: Faire alfaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Jean-Paul Ross inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur nominale de S100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 146, avenue Smith, Sept-Iles, district judiciaire de Hauterive.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5508-1970 St-Bruno Chrysler inc.Le ministre des instistions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Denis Durochcr, 389, boulevard Seigneurial est, Saint-Bruno-dc-Montarvillc, Jean Le-gault, 8151, boulevard Yves Prévost, Anjou, et Gilles St-Pierrc, 230, Guillerm, Longueuil, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, autos-neige, machines agricoles et autres instruments aratoires, camions, tracteurs, tondeuses à gazon, bateaux, appareils de vol et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « St-Bruno Chrysler inc.», avec un capital total de S100.000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune, 1,000 actions privilégiées classe « A » d'une valeur nominale de S10 chacune et en 8,500 actions privilégiées classe « B » d'une valeur nominale de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 635, boulevard Clairevue ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 124-1971 Ste Thérèse Roofing Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première The head office of the company is at Amos, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5509-1970 Jean-Paul Ross inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Paul Ross, contractor, Élianc Lepage, housewife, wife of the said Jean-Paul Ross, and Gaétane Ross, secretary, spinster of the full age of majority, all three of 146 Smith, Scpt-Ilcs, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Jean-Paid Ross inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 100 common shares of a nominal value of S100 each and 300 preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at 146 Smith Avenue, Sept-Iles, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Fina?icial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5503-1970 St-Bruno Chrysler inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Denis Durochcr, 389 Seigneurial boulevard east, Saint-Bruno-de-Montarvillc, Jean Legault, 8151 Yves Prévost boulevard, Anjou, and Gilles St-Picrre, 230 Guillerm, Longucuil, all three advocates, for the following purposes: To do business as garage-owners and to deal in cars, motors, snowmobiles, farm machinery and agricultural implements, trucks, tractors, lawn-mowers, boats, flying apparatus and all related parts and accessories, under the name of \"St-Bruno Chrysler inc.\", with a total capital stock of 5100,000, divided into 500 common shares of a nominal value of S10 each, 1,000 preferred shares class \"A\" of a nominal value of S10 each and 8,500 preferred shares class \"B\" of a nominal value of S10 each.The head office of the company is at 635 Clairevue boulevard west, Saint-Bruno-de-Montarville, judicial district of Montreal.Ls-Pi 11 li ppe Bou ch ar p, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 124-1971 Ste Thérèse Roofing Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of De- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2135 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jean-Pierre Durcchcr, notaire, 35, rue Montscc, Lorraine, Céline Duquette, 30, Leclair, Sainte-Thérèse, et Yvette Fortin, 120, Équerre, Laval, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Ste Thérèse Hoofing Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et en 390 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 533, rue Chamberlain, Sainte-Thérèse-Ouest, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5429-1970 La scierie Manicouagan inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres [latentes, en date du 23e jour de décembre 1970, constituant en corporation: YVilbrod Jacques, entrepreneur, Germaine Jacques, institutrice, épouse dudit Wilbrod Jacques, tous deux de Ragucncau, Léo Lessard, entrepreneur, et Gemma Larouche, maîtresse de maison, épouse dudit Léo Lessard, ces deux derniers de 534, rue Benoît, Hauterive, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de « La scierie Manicouagan inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Ragueneau, district judiciaire de Hauterive.Le sous-ministre des institutions fina/icières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.38940-o 4S34-1970 Service de chaussures de sûreté de Montréal inc.Montreal Safety Shoes Service Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de janvier 1971, constituant en corporation: Bertrand Joyal, marchand, Lise Lcmaire, ménagère, épouse dudit Bertrand Joyal, tous deux de S941, de Louresse, Anjou, et Claude Joyal, notaire, 340, Frontenac, Bcrthierville, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de toutes sortes de chaussures et articles en cuir et leurs accessoires, sous le nom de « Service de chaussures de sûreté de Montréal inc.\u2014 Montreal Safety Shoes Service Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires de 810 chacune et en 390 actions privilégiées de 8100 chacune.cember, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Pierre Durocher, notary, 35 Montscc Street, Lorraine, Céline Duquette, 36 Leclair, Sainte-Thérèse, and Yvette Fortin, 120 Équerre, Lava), the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To carry on business as general building contractors and to ileal in all kinds of building materials, under the name of \"Ste Thérèse Roofing Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of 81 each and 390 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 533 Chamberlain Street, Sainte-Thérèsc-Wcst, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 ' 5429-1970 La scierie Manicouagan inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Wilbrod Jacques, contractor, Germaine Jacques, teacher, wife of said Wilbrod Jacques, both of Ragueneau,- Léo Lessard, contractor, and Gemma Larouche, housewife, wife of said Léo Lessard, the latter two of 534 Benoit Street, Hauterive, for the following purposes: Industry and trade of wood, under the name of \"La scierie Manicouagan inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company is at Ragueneau, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 4834-1970 Service de chaussures de sûreté de Montréal inc.Montreal Safety Shoes Service Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bertrand Joyal, merchant, Lise Lemairc, housewife, wife of the said Bertrand Joyal, both of 8941 dc Louresse, Anjou, and Claude Joyal, notary, 340 Frontenac, Bcrthierville, for the following purposes: To manufacture and to deal in all kinds of shoes, leather articles and their accessories under the name of \"Service de chaussures de sûreté de Montréal inc.\u2014 Montreal Safety Shoes Service Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of 810 each and 390 preferred shares of 8100 each. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 2236 Le siège social de la compagnie est 10827, Place Moisan, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Pnn.iPPE Bouchard.38940-o 79-1971 Service des loisirs Notre-Damc-de-la-Salette Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Joseph Paquette, Raymond Dulac, tous deux de 3535, Park Avenue, Jeanne Prévost, religieuse, 5340, McKcnna, tous trois éducateurs, de Montréal, et Yvon Ropers, travailleur en loisirs, 11500, boulevard Pierrefonds, #102, Pierrefonds, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Service des loisirs Notre-Dame-dc-la-Salettc ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est de 575,000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5506-1970 Les Traductions 530 inc.Translations 530 Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Michel Coupai, traducteur, 3570, Ridgcwood, app.301, Montréal, Maurice Martel, avocat, 1301, St-Viatcur ouest, Outremont, et Lucille Roy, secrétaire, épouse de Jean-Claude Biais, 24, rue Gilles, Ste-Thérèse-Oucst, pour les objets suivants: Faire affaires comme traducteurs et conseillers en publicité, sous le non de « Les Traductions 530 inc.\u2014 Translations 530 Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 3,900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1681, rue Parc Lafontaine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 59-1971 Transport Charron ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Lucienne Joly, ménagère, veuve non remariée de Rolland Charron, Lucie Charron, coiffeuse, toutes deux de 146, boulevard Labelle, Sainte- The head office of the company is at 10827 Place Moisan, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 79-1971 Service des loisirs Notrc-Damc-dc-la-Salctte Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Joseph Paquette, Raymond Dulac, both of 3535 Park Avenue, Jeanne Prévost, nun, 5340 McKcnna, all three educators, of Montreal, and Yvon Ropers, organizer of leisure-time activities, 11500 Pierrefonds Boulevard, Apt.102, Pierrefonds, for the following purposes: The organization of recreational activities, under the name of \"Service des loisirs Notre-Damc-dc-la-Salette\".The amount to which is limited the value of the immovables which may be acquired and owned- by the corporation is $75,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5506-1970 Les Traductions 530 inc.Translations 530 Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel Coupai, translator, 3570 Ridge-wood, Apt.301, Montreal, Maurice Martel, advocate, 1301 St-Viatcur West, Outrcmont, and Lucille Roy, secretary, wife of Jean-Claude Biais, 24 Gilles Street, Ste-Thérèse West, for the following purposes: To carry on business as publicity translators and advisers, under the name of \"Les Traductions 530 inc.\u2014 Translations 530 Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1681 Park Lafontaine Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 59-1971 Transport Charron ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Lucienne Joly, housewife, unremarried widow of Rolland Charron, Lucie Charron, hairdresser, both of 146 Labelle Boulevard, Sainte-Thérèse, and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 Thérèse, et Françoise Payette, secrétaire, 624, La-chaine, Saint-Jérôme, ces deux dernières filles majeures, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Transport Charron ltée », avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 146, boulevard Labelle, Sainte-Thérèse, district judiciaire de Terre-bonne.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5442-1970 Video Sonic Motivation Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour d'octobre 1970, constituant en corporation: Léonce-E.Roy, avocat, 3335, de la Monncrie, Claude Sauvageau, étudiant en droit, 3303, l'Heureux, app.8, tous deux de Saintc-Foy, et Céline Guilbcault, secrétaire, épouse de Raymond Guilbcault, 330, Père Marquette, app.B, Québec, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de matériel audiovisuel et de programmes éducatifs, sous le nom de « Video Sonic Motivation Inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,500 actions ordinaires d'une valeur nominale de S50 chacune et en 5,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 85 chacune.Le siège social de la compagnie est 198, rue Arago est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 4479-1970 Vigncault & frères inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Réal Vigncault, Jean-Luc Vigncault et Henri-Paul Vigncault, tous trois camionneurs, de route rurale numéro 1, Plessisville, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Vigneault & frères inc.», avec un capital total de 880,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur nominale de 8100 chacune et en 600 actions privilégiées d'une valeur nominale de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est route rurale numéro 1, Plessisville, district judiciaire de Mégantic.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o .78-1971 2137 Françoise Payette, secretary, 624 Lachaine, Saint-Jérôme, the latter two spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Transport Charron ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 146 Labelle Boulevard, Sainte-Thérèse, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5442-1970 Video Sonic Motivation Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies.and Cooperatives, incorporating: Léonce-E.Roy, advocate, 3335 de la Monnerie, Claude Sauvageau, law student, 3303 l'Heureux, Apt.8, both of St.Foy, and Céline Guilbcault, secretary, wife of Raymond Guilbcault, 330 Père Marquette, Apt.B, Québec, for the following purposes: To manufacture and to deal in audio-visual material and educational programmes, under the name of \"Video Sonic Motivation Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,500 common shares of a nominal value of 850 each and 5,000 preferred shares of a nominal value of $5 each.The head office of the company is at 198 Arago Street East, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 4479-1970 Vigncault & frferes inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Real Vigneault, Jean-Luc Vigneault and Henri-Paul Vigncault, all three truck drivers, Rural Route No.1, Plessisville, for the following purposes: To carry on business as a transportation company, under the name of \"Vigneault & frères inc.\", with a total capital stock of $80,000, divided into 200 common shares of a nominal value of $100 each and 600 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Rural Route No.1, Plessisville, judicial district of Mégantic.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 ' 78-1971 2138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Walter Gagnon inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Pierre Gagnon, comptable agréé, 11, Providence, Montréal-Est, André Gagnon, pharmacien, 75, Labclle, L'Assomption, et Jérôme Gagnon, comptable, 09, Lemoyne, Repentigny, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, clubs, cabarets, tavernes, commerces, restaurants, cafés, salles à manger, comptoirs-lunch, salles, chalets et kiosques, sous le nom de « Walter Gagnon inc.», avec un capital total de SI50,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 1,250 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal-Est, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 4878-1970 Zcnirama inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du Se jour de janvier 1971, constituant en corporation: Gilles Chevalier, industriel, 91S5, Vincent Quiblicr, Ruth De Kinder, secrétaire, épouse de Louis De Kinder, 101S4, Marquette, tous deux de Montréal, et Jean-Marc Poulin, avocat, 3345, Savard, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Faire le commerce du ciment, stuc, asphalte, pierre, pierre concassée, sable, schiste, roche, beis, brique, tuile, matériaux de pavage, argile, gravier, plâtre, peinture et autres matériaux, sous le nom de « Zcnirama inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et en 20,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est 1884, rue Darling, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 140-1971 Walter Gagnon inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Gagnon, chartered accountant, 11 Providence, Montreal-East, André Gagnon, pharmacist, 75 Labclle, L'Assomption, and Jérôme Gagnon, accountant, 09 Lemoyne, Repentigny, for the following purposes: To operate hotels, clubs, night-clubs, taverns, businesses, restaurants, cafés, dining-rooms, lunch-counters, halls, cottages and stalls, under the name of \"Waller Gagnon inc.\", with a total capital stock of 8150,000 divided into 2,500 common shares of u nominal value of $10 each and 1,250 preferred shares of a nominal value ol S100 each.The head office of the company is at Montreal-East, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 4878-1970 Zcnirama inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8lh day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles Chevalier, industrialist, 9185 Vincent Quiblier, Ruth De Kinder, secretary, wife of Louis De Kinder, 101S4 Marquette, both of Montreal, and Jean-Marc Poulin, advocate, 3345 Savard, Saint-Laurent, for the following purposes: To deal in cement, stucco, asphalt, stone, crushed stone, sand, schist, rock, wood, brick, tile, paving materials, clay, gravel, plaster, paints and other materials, under the name of \"Zcnirama inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 20,000 common shares of SI each and 20,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at 1884 Darling Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 140-1971 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Atome Kitchen Supply Co.Ltd.Atonic Kitchen Supply Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour de novembre 1970, à la compagnie « Atome Kitchen Supply Co.Ltd.», augmentant son capital de 840,000 Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Atome Kitchen Supply Co.Ltd.\", increasing its capital from 840,000 à 8100,000 by the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March G, 1971, Vol.103, No.10 2139 à 3100,000 par la création de 6,000 actions privilégiées de 310 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 1028-67 CJMS Radio Montréal limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 31e jour d'août 1970, à la compagnie « CJMS Radio Montréal limitée », 1° réduisant son capital de S25q,000 à $50,000 par l'annulation de 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune; 2° augmentant son capital de 350,000 à 3550,000 par la création de 5,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le sous-mitiistrc des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 1718-53 J.B.A.Lachance inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 21e jour de décembre 1970, à la compagnie « J.B.A.Lachance inc.», 1° réduisant son capital de 860,000 à 825,000 par l'annulation de 3,500 actions privilégiées de $10 chacune; 2?augmentant son capital de S25,000 à 8125,000 par la création de 1,000 actions privilégiées de 3100 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 11770-59 creation of 6,000 preferred shares of 310 each.Ls-PniLippE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 1028-67 CJMS Radio Montréal limitée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day.of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"CJMS Radio Montréal limitée\" 1.reducing its capital from 3250,000 to 850,000 by the cancellation of 2,000 preferred shares of a par value of 3100 each; 2.increasing its capital from 850,000 to 3550,000 by the creation of 5,000 preferred shares of a par value of 8100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 1718-53 J.B.A.Lachance inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"J.B.A.Lachance inc.\", 1.reducing its capital from 860,000 to 325,000 by the cancellation of 3,500 preferred shares of $l0 each; 2.increasing its capital from 325,000 to 8125,000 by the creation of 1,000 preferred shares of 8100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 11770-59 Compagnies dissoutes Armitage Tire Ltd.Armitage Tire ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de < Armitage Tire Ltd.\u2014 Armitage Tire ltée», constituée en corporation le 5 novembre 1943, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.38940-o 5853-43 Association St-François inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Association St-François inc.», constituée en corporation le 21 avril 1948, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38940-o \u2022 .3366-48 Companies Dissolved Armitage Tire Ltd.Armitage Tire ltée Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the 26th day of February, 1971, of the charter of \"Armitage Tire Ltd.\u2014 Armitage Tire ltée\", incorporated on November 5, 1943.Rocu Rioux, Director of the Companies Branch.38940 5853-43 Association Si -François inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the 26th day of February, 1971, of the charter of \"Association St-François inc.\", incorporated on April 21, 1948.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 3366-48 2140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 Audet & Bergeron ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Audet & Bergeron ltée », constituée en corporation le 7 décembre 1961, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux, 3S940-o 15931-61 BMMS Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « BMMS Inc.», constituée en corporation le 4 avril 1967, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.3S940-o 1236-67 B.T.R.Cosmétiques inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « B.T.R.Cosmétiques inc.», constituée en corporation le 29 janvier 1969, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.3S940-o 434-69 Baruch Building Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Baruch Building Corp.», constituée en corporation le 19 décembre 1955, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38940-o 13549-55 Beacon Hill Mall Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Beacon Hill Mall Ltd.», constituée en corporation le 28 mars 1967, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38940-o 1359-67 Belvedere Investment Company Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Belvedere Investment Company », constituée en corporation le 9 novembre 1929, à compter du 15 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.2181-29 38940-o Audet & Bergeron ltée Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from February 26th, 1971, of the charter of \"Audct & Bergeron ltée\", incorporated on December 7, 1961.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 * 15931-61 BMMS Inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from February 26, 1971, of the charter of \"BMMS Inc.\", incorporated on April 4, 1967.Rocn Rioux, Director of the Companies Branch.38940 1236-67 B.T.R.Cosmétiques inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from February 26th, 1971, of the charter of \"B.T.R.Cosmétiques inc.\", incorporated on January 29, 1969.Rocn Rioux, Director of the Companies Branch.38940 434-69 Baruch Building Corp.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the 26th day of February, 1971, of the charter of \"Baruch Building Corp.\", incorporated on December 19, 1955.Rocn Rioux, Director of the Companies Branch.38940 13549-55 Beacon Hill Mall Ltd.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the 26th day of February, 1971, of the charter of \"Beacon Hill Mall Ltd.\", incorporated on March 28, 1967.Rocn Rioux, Director of the Companies Branch.38940 1359-67 Belvedere Investment Company Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 15,1971, of the charter of \"Belvedere Investment Company\", incorporated on November 9, 1929.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 .2181-29 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, iVo.10 2141 Butchy Boy Bakery Ltd.Boulangerie Butchy Boy ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Butchy Boy Bakery Ltd.\u2014 Boulangerie Butchy Boy ltée », constituée en corporation le 9 juillet 1963, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Ko en Rioux.38940-o 2861-63 Candiac Construction Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de «Candiac Construction Ltd.», constituée en corporation le 28 février 1958, à compter du 26 février 1971.38940-o Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.10506-58 Butchy Boy Bakery Ltd.Boulangerie Butchy Boy ltée Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"Butchy Boy Bakery Ltd.\u2014 Boulangerie Butchy Boy ltée\", incorporated on July 9, 1963.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 2861-63 Candiac Construction Ltd.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the 26th day of February, 1971, of the charter of \"Candiac Construction Ltd.\", incorporated on February 28, 1958.Rocn Rioux, Director of the Companies Branch.38940 ' 10506-58 Centre Médico-Chirurgical de Saint-Jean inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Centre Médico-Chirurgical de Saint-Jean inc.», constituée en corporation le 17 janvier 1964, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.3S940-o 224-64 Chuck's Snack Bar Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Chuck's Snack Bar Inc.», constituée en corporation le 12 avril 1966, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.38940-o 1519-66 Club autos-Neige St-Gcrmain inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Club Autos-Neige St-Gcrmain inc.», constituée en corporation le 6 décembre 1967, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.38940-o 4948-67 Coat Front Contractors Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Coat Centre Médico-Chirurgical de Saint-Jean inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from February 26, 1971, of the charter of \"Centre Médico-Chirurgical de Saint-Jean inc.\", incorporated on January 17, 1964.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 224-64 Chuck's Snack Bar Inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"Chuck's Snack Bar Inc.\", incorporated on April 12, 1966.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 1519-66 Club autos-Ncigc St-Gcrmain inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept tlic surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"Club Autos-Neige St-Germain inc.\", incorporated on December 6, 1967.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 4948-67 Coat Front Contractors Ltd.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, 2142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, G mars 197J, 103' année, n° 10 Front Contractors Ltd.», constituée en corporation le 5 septembre 1961, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.38940-o 14199-61 Davro Industries Ltd.Les Industries Davro ltée Le ministre «les institutions financières, compagnies et- coopératives lionne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de cliartc de « Davro Industries Ltd.\u2014 Les Industries Davro liée », constituée en corporation le 6 décembre 1966, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roca Rioux.38940-o 5031-66 Distributeurs Métropolitains inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Distributeurs Métropolitains inc.», constituée en corporation le 8 novembre 1968, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.38940-o 3408-68 A.R.Duchninc & Cic ltée Le ministre elcs institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'ubundon de charte de « A.R.Duchainc & Cie ltée », constituée en corporation le 29 août 1956, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.38940-o 12623-56 Faille Automobile inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de lu Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Faille Automobile inc.», constituée en corporation le 6 juin 1967, à compter du 26 février 1971.Le directeur dît service des compagnies, Rocn Rioux.38940-o 2530-67 Lake Ml m- Realty (Québec) Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Lake Blue Realty (Québec) Ltd.», constituée en corporation le 19 décembre 1961, à compter du 26 février 1971.38940-o Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.16114-61 from the February 26, 1971, of the charter of \"Coat Front Contractors Ltd.\", incorporated on September 5, 1961.Rocn Rioux, Director of the Companies Branch.38940 14199-61 Davro Industries Ltd.Les Industries Davro liée Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"Davro Industries Ltd.\u2014 I-es Industries Davro ltée\", incor-poratcil on December 6, 1966.Rocn Rioux, Director of the Companies Branch.38940 5031-66 Distributeurs Métropolitains inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from February 26th, 1971, of the charter of \"Distributeurs Métropolitains inc.\", incorporated on November 8, 1968.Rocn Rioux, Director of the Companies Branch.38940 3408-68 A.R.Duchainc & Cic ltée Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Coop\"ratives has been pleased to accept the surrender, from February 26, 1971, of the charter of \"A.R.Duchainc & Cie ltée\", incorporated on August 29, 1956.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 12623-56 Faille Automobile inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from February 26, 1971, of the charter of \"Faille Automobile inc.\", incorporatcil on June 6, 1967.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 \u2022 2530-67 Luke Blue Realty (Québec) Ltd.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from February 26, 1971, of the charter of \"Lake Blue Realty (Québec) Ltd.\", incorporated on December 19, 1961.Rocu Rioux, Director of the Companies Branch.38940 16114-61 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March G, 1971, Vol.103, No.10 2143 Berthe Lavoie Productions inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Berthe Lavoie Productions inc.», constituée en corporation le 23 juin 1954, à compter du 26 février 1971.38940-o Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.11576-54 Marl Incorporated Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Mari Incorporated », constituée en corporation le 12 mai 1956, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.38940-O 11534-56 Raymond Matte limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Raymond Slatte limitée », constituée en corporation le 30 janvier 1950, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.38940-o 2014-50 S.T.W.Developments (Québec) Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « S.T.W.Developments (Québec) Limited », constituée en corporation le 14 mars 1962, à compter du 26 février 1971.3S940-o Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.11125-62 St.Martin Shopping Centre Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte_ de « St.Martin Shopping Centre Limited », constituée en corporation le 24 mai 1956, à compter dû 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38940-o 11675-56 Styval Really Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Styval Realty Corp.», constituée en corporation le 27 juin 1958, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38940-o 12086-58 Berthe Lavoie Productions inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from February 26, 1971, of the charter of \"Berthe Lavoie Productions inc.\", incorporated on June 23, 1954.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 11576-54 Marl Incorporated Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"Marl Incorporated\" incorporated on May 12, 1956.Rocn Rioux, Director of the Companies Branch.38940 * 11534-56 Raymond Matte limitée Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26,1971, of the charter of \"Raymond Matte limitée\", incorporated on January 30, 1950.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 2014-50 S.T.W.Developments (Québec) Limited Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"S.T.W.Developments (Québec) Limited\", incorporated on March 14, 1962.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 11125-62 St.Martin Shopping Centre Limited Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"St.Martin Shopping Centre Limited\", incorporated on May 24, 1956.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 11675-56 Styval Realty Corp.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"Styval Realty Corp.\", incorporated on June 27, 1958.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 12086-58 2144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Guy Towers Building Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Guy Towers Building Ltd.», constituée en corporation le 6 juin 1969, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38940-o 2784-69 Trans-Nation Realties Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Trans-Nation Realties Inc.», constituée en corporation le 9 mai 1962, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.38940-o 12012-62 J.P.Vézina incorporée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « J.P.Vézina incorporée », constituée en corporation le 21 avril 1948, à compter du 26 février 1971.Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.38940-o 3299-48 Guy Towers Building Ltd.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"Guy Towers Building Ltd.\", incorporated on June 6, 1969.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 2784-69 Trans-Nation Realties Inc.Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"Trans-Nation Realties Inc.\", incorporated on May 9, 1962.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38940 12012-62 J.P.Vézina incorporée Notice is given that under the Companies Act the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, from the February 26, 1971, of the charter of \"J.P.Vézina incorporée\", incorporated on April 21, 1948.Roch Rioux, Director of the' Companies Branch.38940 3299-48 Ministère des institutions Department of Financial financières, compagnies et Institutions, Companies and coopératives Cooperatives Assurance Insurance United Shoe Machinery Company Mutual Relief Association of Canada Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « United Shoe Machinery Company Mutual Relief Association of Canada » a cessé de faire affaires dans la province de Québec; Attendu que « United Shoe Machinery Company Mutual Relief Association of Canada » a produit au Service des assurances une déclaration à l'effet que le 16 février 1971, elle ne possédait plus aucun actif, ni aucun passif, ayant distribué son surplus à ses membres, après avoir acquitté toutes ses dettes; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « United Shoe Machinery Company Mutual Relief Association of Canada » sont annulés à compter du 16 février 1971.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 16 février 1971.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le surintendant des assurances, 38921-9-2-o Rogee-A.Càmabairb.United Shoe Machinery Company Mutual Relief Association of Canada Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"United Shoe Machinery Company Mutual Relief Association of Canada\" has ceased to do business in the Province of Québec; Whereas \"United Shoe Machinery Company Mutual Relief Association of Canada\" has filed with the Insurance Branch a declaration to the effect that on the 16th of February 1971, it had no assets and no liabilities, having distributed its surplus to its members after having discharged all its debts; Therefore, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"United Shoe Machinery Company Mutual Relief Association of Canada\" arc cancelled as from the 16th of February 1971.Given at the Office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 16th of February, 1971.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Rooer-A.Camaraire, 38921-9-2-0 Superintendent of Insurance. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2145 Ventes pour taxes Ville de Rigaud Avis est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, Que.les immeubles ci-dessous décrits, situés dans la ville de Rigaud, seront vendus à l'enchère publique à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville 102 St-Pierre à Rigaud, JEUDI, le QUINZIÈME jour d'AVRIL, 1971, à ONZE heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêt, plus les frais encourus ou qui pourront être encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.Succession Paul-Émile Lefebvre, lot P.-114 (Fonder-Succession Paul-Emile Lefebvre, lot 125 (maison fonderie).Taxes municipales ducs plus intérêts: $1,470.14; taxes scolaires plus intérêts: $770.54.Donné à Rigaud, ce 15c jour de février, 1971.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, greffier, 38859-9-2-0 Bernard Lalonde.Municipalité du comté de Saguenay Avis est par la présente donné que le soussigné, secrétaire trésorier de la municipalité du comté de Saguenay, que les propriétés ci-après désignées seront vendues à l'enchère publique à l'Hôtel de Ville de Tadoussac, comté de Saguenav, chef lieu de la corporation du comté de Saguenay, JEUDI, le ONZIÈME jour de MARS 1971 à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêt plus les frais encourus subséquemment à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant cette date.Sales for Taxes Town of Rigaud Notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the aforesaid municipality, that the immovables described hereunder, situated in the town of Rigaud, will be sold by public auction, in the Council Hall of the Town, 102 St-Pierre in Rigaud, on THURSDAY, the FIFTEENTH day of APRIL 1971, at ELEVEN o'clock in the forenoon, to satisfy with the payment of the municipal and school taxes, with interest, plus cost which have been or may be incurred, unless the said taxes, interests and cost be paid before sale.Estate Paul-Émile Lefebvre, lot P.-114 (Foundry).Estate Paul-Émile Lefebvre, lot 125 (House Foun- Municipal taxes plus interest: $1,470.14; school taxes plus interest: $770.54.Given at Rigaud, this 15th day of February, 1971.Seal) Bernard Lalonde, 38859-9-2-o Town clerk, Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Saguenay Notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the Municipality of the County of Saguenay, that the immovables hereinafter designated shall be sold by public auction at the Tadoussac Town Hall, county of Saguenay, county seat of the Corporation of the county of Saguenay, THURSDAY, the ELEVENTH day of MARCH, 1971, at TEN o'clock in the forenoon, for the non-payment of municipal and school taxes with interest and the costs incurred subsequently, unless he said taxes, interest and costs be paid before the date of the sale.Sacré-Coeur Taxes Taxes munie.scolaires Total Munie.School taxes taxes Henri Tremblay.Lot 19, Rg Nord, B.R.est.Lucion A.Tremblay.Lot 20, Rg.Nord, B.R.est.15.30 $ 40.24 S 65 54 20.01 20.61 Escoumnins Arthur Dubé.11-A-U, cadastre 168.Rg 1.Edouard Girard Fils.15-C-3, 231, Rg 1.Jeannine Lavoie Bouliano.10-A-16, P.-10, (254T253, Rg 1).G.Albert Létourneau, P.-A-2-4, 273, Rg A.Ovila Martel.P.-20, cadastre 303, Rg 1.Rémi Tremblay (Théo).P.-17-A, cadastre 425, Rg 1.Renold Tremblay.A-27-(7), 435 A.Jos Aimé Tremblay.13-C-1-5, 460, Rg 1.Georges Henri Tliibeault.P.-35, 424, Rg 1., Vincent Brisson.P.-16-A-18, cadastre 41, Rg 1.Conrad Therrien.75 x 100.P.-10, cadastre 407, Rg A_____ Leopold Bergeron.P.-11-A-13, cadastre P.-21, Rg 1.Adelard Caron.P.-16-B-3, cadastre 122, R« 1.$ 182.98\t\tS 182.98 162.27\t\t152.27 432.40\t\t432.40 120.89\t\t120.89 20.83\tS 118.89\t139.72 32.39\t\t32.39 62.21\t104.67\t160.78 33.64\t138.63\t172.17 16.56\t166.24\t171.80 160.00\t178.07\t338.67 203.52\t460.34\t663.86 26.18\t91.10\t117.28 70.61\t221.07\t291.68 2146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, G mars 1971, 108- année, n° 10 Escoumains (auUc-continued) Taxes Taxes munie.scolaire Total Munie.School taxes taxes Honoré Caron.17-9.cadastre 128, Rg 1.S Orner Brisson.31-A, cadastre 40, Rg 1.Napold Deschesnes.11-4, cadastre 156, Rg A.Marcel Dufour Alphonse.10-A-2, cadastre 172, Rg 1.Gérard Quay, Clovis.14-A-l, cadastre 222, Rg 1.Gérard Gagnon.A-2-5, cadastre 214, Rg A.Victor Lapointe.P.-10-A, Rg A.Raymond Harvey.14-J-57, cadastre 239, Rg 1.Raymond Marie Bouchard (Léon).P.-34, Rg 1.Georges Roussell.ll-A-12, cadastre 353, Rg 1.J.Charles Gagnon, 13-12, cadastre 203, Rg 1.91.97\tS 120.30\tS 212.27 13.72\t343.26\t350.98 30.00\t180.82\t211.48 14.44\t61.56\t76.00 118,30\t907.03\t1,025.03 75.08\t237.87\t312.95 \t104.57\t104.67 55.55\t414.54\t470.09 11.18\t94.25\t105.43 120.18\t152.03\t273.11 00.75\t132.29\t199.04 Saint-Paul-du-Nord Georges Couture a/s-c/o Jacques Ostiguy N., 3290, l'Heureux 1, Ste Foy, Québec.Lots 21-22-2/3 du 23 Iberville, Rg 2 & 3.S Gabriel Bouchard.33 A Partie-Part & 31 Partie-Part.Rg 4.Mme-Mrs.Léon Poitras.P.33-B, 34-A, 14 & 15, Rg 4 & 2.Ls-Philippe Tremblay (Emile).P.32-B, Rg 4.Réal Tremblay (Joseph).P.34-A, Rg 4.Mme-Mrs.Patrick Bouchard.P.34-B, Rg 4.Jacques Hovington.P.51-A, Rg 4.Fernand Gagné.Lot 60-C, Rg 4.Mme-Mrs V.-W.Edgard Gagné.Lot 56-C.Rg 4.Jacques Mercier, 515 Conseil, Sherbrooke.Lot 67-C, Rg 4.Jean-Paul Pilotte.Lot 1.Rg A.Fernand Tremblay (B).Lot 6, Rg A (rés.Forestville).Henri Tremblay (Berthe).Lot 8, Rg A.Josaphnt Tremblay (rés.Forestville).P.59, Rg A.Chs-Albert Tremblay.P.61, Rg A.Louison Jean.P.61, Rg A.Armand Tremblay (F).Lot 93, Rg A.Henri Tremblay (F).P.95-94-96, Rg A.\u2022Mme-Mrs.Vve-Wid.Henri-Paul Laurencellc.Lot 128, Rg A.Romuald Barctte.Lot 133-134, Rg A.47.12\tS 174.44\tS 221.50 89.93\t204.51\t354.44 95.39\t574.50\t009.95 72.40\t339.50\t411.90 53.87\t47.02\t101.40 111.52\t378.12\t489.64 74.30\t171.07\t246.97 73.90\t402.05\t535.95 84.90\t488.70\t573.66 79.12\t261.79\t340.91 65.62\t121.98\t187.60 41.40\t347.80\t389.32 306.38\t\t300.38 121.10\t20.00\t141.10 73.23\t193.14\t200.37 102.50\t200.88\t303.44 110.15\tmo n.\t250.31 433.00\t1,449.38\t1,882.9.8 23.14\t22.09\t45.83 73.98\t109.71\t243.09 Sainte-Anne-de-Portneuf Jennnot Bélanger.Lot 217, Rg B.S 184.60 1 8 184.60 Rodolphe Blouin.Lot 147, Rg B.139.62 139.52 Mme-Mrs.Gabriel Desbiens.Lot 34, Rg B.147.40 147.40 Pierre Desmeulcs.Lot 214.Rg B, (2610, Boul.de la Baie, Port-Alfred Clé Chic.)____ 169.95 169.95 Raymond Foster.Lot 274.Rg B.124.54 124.64 Henri Jean.Lot 143-146.Rg B.57.67 67.07 Marcel Lafontaine.Lot 224-225-226, Rg B (B.Comeau).1,469.87 1,469.87 Florian Lavoie.Lot 9, Rg B.258.00 258.00 Loraine Leblanc.Lot 02, Rg B (Petit Rocher N.Bruns).99.18 99.18 Emélien Morissette.Lot 19, Rg B.10.12 10.12 Mme-Mrs.Pierre Paul Morneau.Lot 53, Rg B.264.00 204.00 Jean-Noël Poulin.Lot 39, Rg B.46.13 40.13 Mme-Mrs.Rock St-Gelais.Lot 17, Rg B.139.50 139.50 Mme-Mrs.Jos Thomas Savard (décédé-decoased).Lot 78, Rg B.231.19 231.19 Gérard Savard.Lot 108, Rg B.409.42 409.42 Léonard Simonneau.Lot 41, Rg B.83.70 83.70 Jean-Benoit Tremblay.Lot 2-1 A 2-2, Rg B.37.35 37.35 Rodrigue Tremblay.Lot 267-2, Rg B.372.38 372.38 Leopold Jolicoeur.Lot 288.Rg B.164.29 154.29 Adolphe Halle.Lot 6, Rg B (33, Valmond, Repentigny, Mont.).60.64 60.04 René Tremblay.Lot 29, Rg B (188, avenue Lamontagno, Québec).210.74 210.74 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March G, 1971, Vol.103, No.10 2147 Bergeronnes Taxes\tTaxes\t munie.\tscolaire\tTotal Munie.\tSchool\t taxes\ttaxes\t Edouard Brisson.Lot 45-A, Rg 1, Canton Bergeronncs-Township, dimension-Area 00x 150-.S 30.00 S 00.00 S 90.00 Donné à Bcrgeronncs, ce 10e jour de février 1971.Enregistrée.Le secrétaire-trésorier, 3SS84-9-2-0 Paul Bouchard.Given at Bergcronnes, this 10th day of February, 1971.Registered.Paul Bouchard, 38884-9-2-6 Secretary-Treasurer.Demandes à la Législature Applications to Legislature La cité de Giffard Avis est par les présentes donné que la cité de Gilfard, corporation municipale légalement constituée, ayant son siège social en la cité de Giffard, district de Québec, s'adressera à la Législature de la Province de Québec, au cours de la prochaine session, pour obtenir l'adoption d'une loi modifiant ses limites territoriales.Québec, ce 18c jour de février 1971.Le procureur de la requérante, 38949-10-4-o Me Roger Tiiibaudeau.c.h.Ville de Montréal Avis est par les présentes donné que la ville de Montréal s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, au cours de la deuxième session de la vingt-neuvième législature, pour lui demander l'autorisation de présenter un bill ayant pour objet de modifier les dispositions de sa charte relativement aux matières suivantes: 1° les modifications ou additions au plan général de la ville; 2° la preuve photographique des documents des archives de la ville; 3° l'augmentation de la juridiction du comité exécutif de $5,000 à $10,000 pour l'octroi des contrats et la limitation aux dépenses de plus de $10,000 des appels de soumissions; 4° la mise à la retraite des cadres administratifs et lesbénéfices de rentes qui peuvent leur être accordés à l'engagement; 5° le pouvoir du conseil d'autoriser certaines institutions à occuper ou construire en dérogation de la réglementation de zonage dans des secteurs résidentiels; 6° le transfert de certaines responsabilités «le l'estimateur au Directeur des Finances dans des cas de changements affectant la perception mais ne nécessitant pas de nouvelles évaluations; 7° l'approbation des plans d'ensemble; 8° les rccouvrenicnUs de la Communauté Urbaine île Montréal et les estimés budgétaires; 9° le paiement des taxes; 10° la date de production des contestations d'évaluations pour taxes; City of Giffard Notice is hereby given that the city of Giffard, municipal corporation legally incorporated and having its head office in the city of Giffard, district of Québec, will apply to the Legislature of the Province of Québec, at its next session, for a law to be adopted amending its territory.Québec, this 18th day of February, 1971.Me Roger Thibaudeau, q.c, 38949-10-4 Attorney for Ike A pplicant.City of Montreal Notice is hereby given that the City of Montreal will petition the Québec National Assembly, during the course of the Second Session of the 29th Legislature, to be authorized to present a bill to modify the dispositions of its charter in relation to the following subjects: 1.the modifications or additions to the general plan of the City; 2.the photographic proof of documents in the archives of the City; 3.Increase of the jurisdiction of the Executive Committee from $5,000 to $10,000 for the granting of contracts and the limitation of the calling of tenders to expenditures of more than $10,000; 4.The )>ensioning of administrative cadres and the pension benefit that may be granted to them when they join the service of the City; 5.the power of council to authorize certain institutions to occupy or build in residential zones, notwithstanding zoning restrictions; 6.The transfer of certain responsibilities of the assessor to the Director of Finance concerning certain changes affecting the collection of taxes but not requiring any new evaluation; 7.the approbation of master plans; 8.the recoveries from the Montreal Urban Community and the budgetary estimates; 9.the payment of taxes; 10.the date of production of complaints against tax assessments; 2148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103- année, n° 10 11° le bureau de revision; 12° les délais pour le dépôt des indemnités d'expropriation; 13° l'octroi d'indemnités aux locataires lors d'acquisition d'immeubles par la ville; 14° l'administration de la cour municipale et les signatures sur les documents qui en émanent; 15° le pouvoir des juges municipaux d'édicter des règles de pratique; 16° les avis, le paiement libératoire et les assignations en cour municipale; et toutes autres matières utiles à la bonne administration des affaires de la ville.Hôtel de Ville, le 19 février 1971.Agents et procureurs de la Ville, Côté, Péloquin, Mercier, Normandin, 38950-10-4-o Duciiarme & Bouchard.La Corporation municipale de St-Donat « La Corporation municipale de St-Donat», comté de Montcalm, s'adressera à la législature pour obtenir une Loi lui accordant le pouvoir d'ériger, posséder et opérer des barrages, écluses et canaux pour régler le niveau des lacs situés sur son territoire.Le procureur de la municipalité, 38632-7-4-0 Jacques Duoas, c.r.Congregation Avath Scholom Nusoch IInori Avis est donné que Joe Gorelik, manufacturier; Israël Kositsky, marchand; Morris Sacharen, marchand; Barney Yanofsky, agent d'assurance; Abraham Goodman, peintre; Nathan Nachfolger, gérant de bureau; Harry Nachfolger, marchand; A.Chizy, opérateur; Joe Freeder, marchand; Nathan Cohen, constructeur; Aaron Cohen, constructeur; Aaron Vogel, marchand; Oscar Singer, entrepreneur plombier; tous des cité et district de Montréal, et Isidore Grecnbaum, avocat, de Côte Saint-Luc, dans le district de Montréal, s'adresseront à l'Assemblée nationale de la province de Québec, à sa prochaine session ou prochaine session subséquente afin de demander la passation d'un projet de Loi constituant en corporation « Congregation Avath Scholom Nusoch Haori ».Daté à Montréal, 15 janvier 1971.Le procureur des requérants, 38681-7-4 Isidore Greenbaum.Commissaires d'écoles pour la municipalité de Ville d'Anjou Avis est par les présentes donné que les Commissaires d'écoles pour la municipalité scolaire de Ville d'Anjou, dans le comté de Lafontainc, s'adresseront à l'Assemblée Nationale de la province de Québec, à sa présente ou à une prochaine Session, dans le but de demander l'abrogation de la loi 6-7 Elizabeth 2, 1957-1958, chapitre 114, ainsi que la loi 7-8 Elizabeth 2, 1958-1959, chapitre 133, afin de revenir aux dispositions générales de la Loi de l'Instruction Publique fixant la date de la prochaine élection générale au deuxième lundi du mois de juin 1971, et abrogeant toute division en quartiers pour fins scolaires et pour toutes autres fins.Montréal, le 25 janvier 1971.Le secrétaire-trésorier, 38700-7-4-o Pierre Racine, c.a.11.the Board of Revision; 12.the date for the deposit of expropriation indemnities; 13.the granting of indemnities to tenants when the City acquires immoveables; 14.the administration of the Municipal Court and the signatures of documents from said Court; 15.the power of municipal judges to adopt practice rules; 16.the notices, the discharge payments and the summons in the Municipal Court; and all other matters relevant to the good administration of the affairs of the City.City Hall, February 19, 1971.Côté, Péloquin, Mkrcier, Normandin, Duciiarme & Bouchard, 38950-10-4-o Agents and attorneys for the City.The Municipal Corporation of St-Donat \"The Municipal Corporation of St-Donat\", Montcalm county, will petition the National Assembly to have enacted a law granting power to erect, possess and operate dams, locks and canals to regulate water level on the lakes in its territory.Jacques Ducas, q.c, 38632-7-4-0 Sollicitor for the Municipality.Congregation Avalh Scholom Nusoch Haori Notice is hereby given that Joe Gorelik, manufacturer; Israël Kositsky, merchant; Morris Sacharen, merchant; Barney Yanofsky, insurance agent; Abraham Goodman, painter; Nathan Nachfolger, office manager; Harry Nachfolger, merchant; A.Chizy, operator; Joe Freeder, merchant; Nathan Cohen, builder; Aaron Cohen, builder; Aaron Vogel, merchant; Oscar Singer, plumbing contractor, all of the city and district of Montreal, and Isidore Grecnbaum, advocate, of Côte St.Luc, in the district of Montreal, will apply to the National Assembly of the Province of Québec at its next or next succeeding session to request the passing of a bill incorporating \"Congregation Avath Scholom Nusoch Haori\".Dated at Montreal, January 15, 1971.Isidore Greenbaum, 38681-7-4-o Attorney for the petitioners.School Commissioners for the municipality of Ville d'Anjou Notice is hereby given that the School commissioners for the municipality of Ville d'Anjou, in the county of Lafontainc, will petition the National Assembly of the Province of Québec, at its present or next Session, in order to obtain the abrogation of the Act: 6-7 Elizabeth 2, 1957-1958, chapter 114, and 7-8 Elizabeth 2, 1958-1959, chapter 133, and replacing these special laws by the General Regulations of the Education Act, and fixing the date of the next general election to the second Monday of June 1971, and abrogating any division in wards for school purposes.Montreal, January 25, 1971.Pierre Racine, c.a., 38700-7-4-o Secretary-Treasurer. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March G, 1971, Vol.103, No.10 2149 Avis divers Miscellaneous Notices Cite ilc LaSallc Comté de Margucrite-Bourgeoys (anciennement Comté Jacques-Cartier) Avis de rachat partiel pour obligations à fonds d'amortissement Émission de SI,450,000 à 514%, datée du 15 avril 1957.Avis est, par les présentes, donné aux détenteurs d'obligations à fonds d'amortissement 534% année, n\" 10 2.Honorer toute convention et tout contrat faits par l'Office ou son délégué dans l'exercice de ses pouvoirs et attributions; 3.Si l'OlIice adopte un règlement à cette fin, se procurer un quota de production et de vente auprès de l'Office et le respecter; 4.Se conformer aux normes de qualité établies par l'autorité compétente et l'Office, et se soumettre à toute inspection visant à vérifier la qualité du produit visé; 5.Payer les frais d'administration du plan conjoint et ceux relatifs à la mise en marché du produit visé, ainsi que toute autre contribution spéciale édictée en vertu du plan ou d'une loi, selon le montant et les modalités déterminées par l'Office; 6.Payer sa quote-part de toute somme due à un voituricr; 7.Contribuer, selon les modalités établies par l'Office, au coût de l'écoulement des surplus de lait et de produits laitiers attribuables aux producteurs visés; 8.Fournir à l'Office tout renseignement jugé utile à l'exécution du plan.IX.Devoirs de l'Office Les devoirs de l'Office sont: 1.Accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi des marchés agricoles du Québec impose à un Office de producteurs; 2.Viser à assurer la mise en marché d'un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes d'inspection décrétés par l'autorité compétente, et 3.Maintenir une comptabilité scion les standards minima que peut exiger la Régie.X.Pouvoirs et attributions de l'Office L'Office peut: 1.Coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors de la province du produit visé et exercer à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d'une autre juridiction prévoyant une telle coopération; 2.Exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d'une délégation de l'un quelconque des pouvoirs remis par la Régie; 3.Émettre un quota de production et de vente aux producteurs assujettis au plan conjoint, et réglementer le transfert de ce quota; 4.Arrêter la participation financière de chaque producteur à l'administration du plan conjoint; 5.Affecter une partie de la contribution des producteurs pour l'administration du plan conjoint, à des fins de publicité du produit visé; 6.Pour réaliser l'un quelconque des aspects de la mise en marché du produit visé, dont la disposition des surplus de lait et de produits laitiers, décréter, avec l'approbation de la Régie, une contribution spéciale de tous les producteurs ou d'un groupe déterminé de producteurs; 7.Déterminer les montants, ainsi que les modalités de paiements et de perception des diverses contributions que les producteurs doivent payer; 2.Honour any agreement and any contract made by the Board or its delegate, in the exercise of its powers and attributions; 3.If the Board has adopted a regulation to that effect, obtain from the same a production and marketing quota and abide by it; 4.Conform with the standards of quality established by the competent authority and the Board, and submit to any inspection intended to verify the quality of the contemplated product; 5.Defray the administration cost of the plan and those relative to the marketing of the designated product, as well as any other special contribution ordered in accordance with the plan or an Act, to the amount and conditions that the Board shall establish; 6.Pay its share of any sum due to a carrier; 7.Share the cost of the disposal of milk and milk products surpluses due to the producers bound by the plan, according to the modalities established by the Board's regulations; 8.Provide the Board with any information deemed useful to the carrying out of the Plan.LX.Duties of the Board The duties of the Board are: 1.To perform all duties and obligations imposed on a Producers' Board under the Québec Agricultural Marketing Act; 2.To assure the marketing of a quality product in conformity with regulations and inspection standards decreed by the competent authority, and 3.To keep its books in conformity with the Regie's requirements.X.Powers and attributions of the Board The Board may: 1.Co-operate with similar bodies in Canada for the marketing outside the Province of Québec of the contemplated product and, for this purpose, exercise the powers and perform the duties resulting from any law from another jurisdiction providing for such a co-operation; 2.Exercise any power and perform duties resulting from the delegation of any one of the Regie's powers; 3.Issue a production and sale quota to producers bound by the Joint Plan, and regulate the transfer of such quota; 4.Determine the financial contribution of each producer for the administration of the Joint Plan; 5.Utilize a part of the producers' contribution to the administration of the Joint Plan for advertising purposes of the contemplated product; 6.For the carrying out of any aspect of the marketing of the contemplated product and, among other things, for the disposal of milk and milk products surpluses, order with the approval of the Régie, a special contribution for all producers or for a specified group of producers; 7.Determine the amounts and the methods of payment and \"mode of collection of the various contributions that the producers must pay; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.10S, No.10 2161 8.Rationaliser lc transport du produit visé; 9.Statuer sur les conditions de production, de manutention ou de déplacement du produit visé, ainsi que sur sa qualité; 10.Contingenter la production et la vente du produit visé, fixer le temps et le lieu de sa mise en marché, prohiber la mise en marché hors du temps ou du lieu fixé ou en violation des quotas établis ou d'une norme imposée; 11.Signer tout contrat relatif à la mise en marché du produit visé et, par là, lier chaque producteur assujetti au plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement; 12.Établir un Comité de bonne entente pour étudier et solutionner les griefs des producteurs relativement à l'exécution du plan, en déterminer les règlements et la portée de ses décisions; 13.Obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l'exécution du plan; 14.Faire toute enquête requise par les objectifs du plan ; 15.Négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi des marchés agricoles, toute condition de mise en marché, et spécialement: a) le prix de vente du produit visé; b) les conditions et modalités de paiement du prix du produit visé; c) la rationalisation des circuits, les conditions, modalités et prix du transport, ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé; d) les conditions de livraison; c) la qualité et la quantité du produit visé; /) la surveillance par un représentant de l'office du paiement, du poids, de la qualité et de la teneur en gras ou autre constituant du produit visé; g) le mode de retenue par le marchand de lait et la remise à l'office, de la contribution nécessaire au financement du plan, à la mise en marché ou à la disposition des surplus des produits visés; h) la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations; i) tant à l'occasion de la signature d'une convention qu'au cours de son exécution, une procédure de règlement des griefs.XI.Administration du plan conjoint 1.Le plan conjoint est administré par l'office des producteurs de lait fournisseurs à la Crémerie Révélation Inc., qui est composé de sept (7) administrateurs.Les administrateurs de l'office sont présentement: M.Maurice Caza, St-Anicet, comté de Huntingdon, M.Robert Castagnier, Dundee, comté de Huntingdon, M.André Billette, R.R.3, Huntingdon, comté de Huntingdon, M.Fernand Leduc, R.R.2, Beauharnois, comté de Beauharnois, 8.Rationalize the transportation of the contemplated product ; 9.Determine the conditions of production, handling or transportation of the contemplated product, and of its quality; 10.Establish a quota for the production and sale of the contemplated product, fix the time and place of its marketing, prohibit marketing outside the fixed time or place or in violation of the established quota or of a prescribed rule; 11.Sign any contract relative to the marketing conditions of the contemplated product and, thereby, bind each producer subjected to the Joint Plan, and determine the duration and conditions for its renewal; 12.' Establish a Good Will Committee to study and find solution to the producers' grievances with respect to the carrying out of the Joint Plan, determine the regulation of the Committee and the full implication of its decisions; 13.Obtain from the producers all information judged useful to carry out the Joint Plan effectively; 14.Make all inquiries of such a nature as to attain the ends set down in the Joint Plan; 15.Ncgociate with any person bound to do so by the Québec Agricultural Marketing Act all the marketing conditions, and more specifically: (a) The selling price of the contemplated product; (b) The conditions and the methods of payment of the price of the contemplated product; (c) The rationalization of the routes, the conditions, means and cost of transportation or of any service related to the marketing of the contemplated product; (d) The delivery conditions; (e) The quality and the quantity of the contemplated product; (/) The supervision by a representative of the Board of the payment, the weight, the quality, the percentage of butterfat or any other constituent of the contemplated product; (g) The method of withholding by the purchaser and its remittance to the Board, of the necessary contribution to finance the Joint plan, of a special contribution for the marketing or for the disposal of surpluses of the contemplated product; (/j) The duration of agreements as well as the conditions for their renewal and those permitting the reopening of negotiations; (i) The settlement procedure relating to grievances both at the time of signing and during the course of an agreement.XI.Administration of the Joint Plan 1.The Joint Plan shall be administered by the Board composed of seven (7) administrators.The administrators of the Board are presently: Mr.Maurice Caza, St-Anicet, county of Huntingdon; Mr.Robert Castagnier, Dundee, county of Huntingdon; Mr.André Billette, R.R.3, Huntingdon, county of Huntingdon; Mr.Fernand Leduc, R.R.2, Beauharnois, county of Beauharnois ; 2162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 M.Fernand Théoret, Rang 2, St-Timothée, comté de Beauharnois, M.Rocli Deschamps, Si-Stanislas de Kostka, comté de Beauharnois, M.Marcel Martineau, St-Clet, comté de Soulanges.2.Les administrateurs de l'Office doivent être des producteurs intéressés, au sens du présent plan conjoint.3.L'Office doit convoquer et tenir, au moins une fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs assujettis au plan conjoint pour rendre compte de ses activités, procéder à la nomination d'un vérificateur et à l'élection des administrateurs.4.Tout administrateur dudit Office de producteurs, qui cesse d'être un producteur intéressé ou qui devient autrement inapte à remplir ses fonctions, doit être remplacé par les autres administrateurs en fonction.5.Sauf les cas où la Loi des marchés agricoles assujettit l'application d'un règlement à sa publication dans la Gazelle officielle du Québec, la publication des règlements ayant rapport aux modalités d'exécution du plan conjoint et à l'exercice des pouvoirs de l'Office sera faite dans les langues française et anglaise, par parution dans le journal « La Terre de Chez-Nous ».Tout règlement ainsi publié entre en vigueur le quinzième jour suivant sa publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.XII.Mode de financement L'administration et la mise en oeuvre du plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le plan, selon le mode déterminé par l'Office.Le montant de cette contribution est déterminé par l'Office au moyen d'un règlement qui doit être approuvé par l'assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d'entrer en vigueur.Jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par un tel règlement, la contribution est de un cent (0.01) le cent (100) livres de lait livré au marchand de lait.Les contributions versées à l'Office en vertu de la Loi des marchés agricoles du Québec, doivent servir à défrayer les dépenses de l'administration et de la mise en oeuvre du plan.39001-o Modification au plan conjoint des producteurs de lait du Québec à la Cie Carnation Avis Prenez avis que les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec à la Cie Carnation ont accepté des modifications à leur plan et que, suite à l'ordonnance de publication rendue par la Régie des marchés agricoles, le texte de ce plan conjoint modifié doit se lire comme suit: I.Définitions Dans le présent plan conjoint, l'expression « mise en marché » signifie l'offre de vente, la vente, l'expédition Mr.Fernand Théoret, Rang 2, St-Timothée, county of Beauharnois; Mr.Roch Deschamps, St-Stanislas de Kostka, county of Beauharnois; Mr.Marcel Martineau, St-Clct, county of Soulanges.2.The administrators of the Board must be interested producers within the meaning of the present Joint Plan.3.The Board must convene and hold, at least once a year, a general meeting of all producers bound by the Joint Plan to render an account of its activities, submit financial reports for approval and proceed to the nomination of an auditor and the election of the administrators.4.Any administrator of the Board, who ceases to be an interested producer or who is otherwise unable to hold its function, must be replaced by the other administrators of the Board.5.Save the cases where the application of a Board's regulation is subjected to its publication in the Quebec Official Gazelle, the regulations related to the modalities of the carrying out of the Joint Plan and the exercise of the Board's powers shall be published in French and English in \"La Terre de Chez-Nous\".Every regulation thus published in \"La Terre de Chez'Nous\" shall come into force on the fifteenth day after publication or on such later date as may be fixed therein.XII.Financing The administration and carrying out of the Joint Plan shall be financed through a contribution which must be paid by all producers bound by the Joint Plan, according to the method selected by the Board.The amount of this contribution shall be determined by the Board by means of a regulation which must be approved by the general meeting of the producers and by the Régie before coming into force.Until it is amended by such a regulation, the contribution is of one cent (0.01) per one hundred (100) pounds of milk delivered to the milk dealer.Contributions paid to the Board under the Québec Agricultural Marketing Act must serve to defray the expenses incurred in the administration and implementation of the Joint Plan.39001-o Amendments to the Québec Carnation Company Milk Producers' Plan Notice Take notice that the producers bound by the Québec Carnation Company Milk Producers' Plan have accepted modifications to the marketing plan and that, following the publication order rendered by the Québec Agricultural Marketing Board, the text of the modified joint plan reads as follows: I.Definitions In the present joint plan, the word \"marketing\" means the offer to sell, the sale, the transportation and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2163 pour fin de vente, le transport et l'achat, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement du produit visé; l'expression « fabrique » a la même signification que dans la loi des produits laitiers et de leurs succédanés; l'expression « office » signifie l'office des producteurs de lait du Québec à la Cie Carnation, et l'expression * Régie » signifie la Régie des marchés agricoles du Québec.II.Dêsignalion Le plan conjoint est désigné sous le nom de « Plan conjoint des producteurs de lait du Québec à la Cie Carnation ».IDT.Produit visé Le produit visé est le lait provenant du troupeau d'un producteur intéressé, livré à une fabrique de la Compagnie Carnation située au Québec.IV.Conditions à remplir pour être un producteur intéressé Le producteur intéressé au sens du présent plan est toute personne qui met en marché le produit visé.V.Extension juridique À compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, le plan est exécutoire.Tous les producteurs intéressés et, postérieurement au vote, tous les producteurs, qui, au cours de la durée de l'application du plan continuent à remplir ou répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur intéressé, sont assujettis au plan.VI.Réalisation du plan L'exécution et l'administration du plan sont confiées a l'Office des producteurs de lait du Québec à la Cie Carnation.VII.Agent de négociation et de vente L'Office est l'agent de négociation et l'agent de vente pour l'exécution du plan.VIII.Devoirs, obligations et engagements du producteur Le producteur doit: 1.Se conformer aux décisions et règlements adoptés par l'Office dans l'exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi des marchés agricoles du Québec; 2.Honorer toute convention et tout contrat faits par l'Office ou son délégué dans l'exercice de ses pouvoirs et attributions; 3.Si l'Office adopte un règlement à cette fin, se procurer un quota de production et de vente auprès de l'Office et le*respecter; 4.Se conformer aux normes de qualité établies par l'autorité compétente et l'Office, et se soumettre à toute inspection visant à vérifier ia qualité du produit visé; 6.Payer les frais d'administration du plan conjoint et ceux relatifs à la mise en marché du produit visé, ainsi que toute autre contribution spéciale édictée en vertu du plan ou d'une loi, selon le montant et les modalités déterminées par l'Office; the purchase, together with the advertising and the financing of the operations related to the disposal of the contemplated product; the word \"factory\" has the same meaning as the one indicated in the Dairy Products and Dairy Products Substitutes Act; the word \"Board\" means the Québec Carnation Company Milk Producers' Board; the word \"Régie\" means the Québec Agricultural Marketing Board.H.Designation The joint shall be designated as the \"Québec Carnation Company Milk Producers' Joint Plan\".III.Contemplated product The contemplated product is the milk issuing from the herd of an interested producer, delivered to a Carnation Company's factory situated in the Province of Québec.IV.Conditions required to be an interested producer For the purpose of the present joint plan, the interested producer is any person who markets the contemplated product.V.Legal extension From the date of its publication in the Québec Official Gazette, the joint plan is executory.It binds all interested producers and, subsequent to the votation, all producers who, during the course of its carrying out, continue to fulfill or meet the conditions required to be qualified as interested producers., VI.Carrying out of the plan \"The Québec Carnation Company Milk Producers' Board\" is entrusted with the carrying out and administration of the joint plan.VII.Negotiating and sales agent The negotiating and sales agent designated for the carrying out of the plan shall be the Board.Vlil.Duties, obligations and commitments of producers The producer must: 1.Conform with all decisions and regulations adopted by the Board, using the powers granted to the latter under the Québec Agricultural Marketing Act; 2.Honour any agreement and any contract made by the Board or its delegate, in the exercise of its powers and attributions; 3.It the Board has adopted a regulation to that effect, obtain from the same a production and marketing quota and abide by it; 4.Conform with the standards of quality established by the competent authority and the Board, and submit to any inspection intended to verify the quality of the contemplated product; 5.Defray the administration cost of the plan and those relative to the marketing of the designated product, as well as any other special contribution ordered in accordance with the plan or an Act, to the amount and conditions that the Board shall establish; 2164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 6.Payer sa quote-part de toute somme due à un voituricr; 7.Contribuer, selon les modalités établies par l'Office, au coût de l'écoulement des surplus de lait et de produits laitiers attribunbles aux producteurs visés; 8.Fournir à l'Office tout renseignement jugé utile à l'exécution du plan.IX.Devoirs de l'Office Les devoirs de l'Office sont: 1.Accomplir tout devoir et remplir toute obligation (pie la Loi des marchés agricoles du Québec impose à un Office de producteurs; 2.Viser à assurer la mise en marché d'un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes d'inspection décrétés par l'autorité compétente, et 3.Maintenir une comptabilité selon les standards minima que peut exiger la Régie.X.Pouvoirs cl attributions de l'Office L'Office peut: 1.Coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors de la province du produit visé et exercer à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d'une autre juridiction prévoyant une telle coopération; 2.Excreer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d'une délégation de l'un quelconque des pouvoirs remis par la Régie; 3.Émettre un quota de production et de vente aux producteurs assujettis au plan conjoint, et réglementer le transfert de ce quota; 4.Arrêter la participation financière^ de chaque producteur à l'administrât ion du plan conjoint; 5.Affecter une partie de la contribution des producteurs pour l'administration du plan conjoint, à des fins de publicité du produit visé; 6.Pour réaliser l'un quelconque des aspects de la mise en marché du produit visé, dont la disposition des surplus de lait et de produits laitiers, décréter, avec l'approbation de la Régie, une contribution spéciale de tous les producteurs ou d'un groupe déterminé de producteurs; 7.Déterminer les montants, ainsi que les modalités de paiements et de perception des diverses contributions (pie les producteurs doivent payer; 8.Rationaliser le transport du produit visé; 9.Statuer sur les conditions de production, de manutention ou de déplacement du produit visé, ainsi que sur sa qualité; 10.Contingenter la production et la vente du produit visé, fixer le temps et le lieu de sa mise en marché, prohiber la mise en marché hors du temps ou du lieu fixé ou en violation des quotas établis ou d'une norme imposée; 11.Signer tout contrat relatif à la mise en marché du produit visé et, par là, lier cliaquc producteur assujetti au plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement; 6.Pay its share of any sum due to a carrier; 7.Share the cost of the disposal of milk and milk products surpluses due to the producers bound by the plan, according to the modalities cstbalishcd by the Board's regulations; 8.Provide the Board with any information deemed useful to the carrying out of the Plan.IX.Duties of the Board The duties of the Board arc: 1.To perform all duties and obligations imposed on a Producers' Board under the Québec Agricultural Marketing Act ; 2.To assure the marketing of a quality product in conformity with regulations and inspection standards decreed by the competent authority, and 3.To keep its books in conformity with the Regie's requirements.X.Powers and attributions of the Board The Board may: 1.Co-operate with similar bodies in Canada for the marketing outside the Province of Québec of the contemplated product and, for this purpose, exercise the powers and perform the duties resulting from any law Iroin another jurisdiction providing for such a co-operation; 2.Exercise any power and perform duties resulting from the delegation of any one ol the Regie's powers; 3.Issue a production and sale quota to producers bound by the Joint Plan, and regulate the transfer of such quota; 4.Determine the financial contribution of each producer for the administration of the Joint Flan; 5.Utilize a part of the producers' contribution to the administration of the Joint Plan for advertising purposes of the contemplated product; 6.For the carrying out of any aspect of the marketing of the contemplated product and, among other things, for the disposal of milk and milk products surpluses, order with the approval of the Régie, a special contribution for all producers or for a specified group of producers; 7.Determine the amounts and the methods of payment and mode of collection of t\\\\c various contributions that the producers must pay; 8.Rationalize the transportation of the contemplated product; 9.Determine the conditions of production, handling or transportation of the contemplated product, and-of its quality; 10.Establish a quota for the production and sale of the contemplated product, fix the time and place of its marketing, prohibit marketing outside the fixed time or place or in violation of the established quota or of of prescribed rule; 11.Sign any contract relative to the marketing conditions of the contemplated product and, thereby, bind each producer subjected to the Joint Plan, and determine the duration and conditions for its renewal; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2165 12.Établir un Comité de bonne entente pour étudier et solutionner les griefs des producteurs relativement à l'exécution du plan, en déterminer les règlements et la portée de ses décisions; 13.Obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l'exécution du plan; 14.Faire toute enquête requise par les objectifs du plan ; 15.Négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi des marchés agricoles, toute condition de mise en marché, et spécialement: a) le prix de vente du produit visé; b) les conditions et modalités de paiement du prix du produit visé; c) la rationalisation des circuits, les conditions, modalités et prix du transport, OU de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé; cl) les conditions livraison; c) la qualité et la quantité du produit visé; /) la surveillance par un représentant de l'oflice du paiement, du poids, de la qualité et de la teneur en gras ou autre constituant du produit visé; g) le mode de retenue pur le marchand de lait et la remise à l'office, de la contribution nécessaire au financement du plan, à la mise en marché ou à la disposition des surplus des produits visés; h) la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations; i) tant à l'occasion de la signature d'une convention qu'au cours de son exécution, une procédure de règlement des griefs.XI.Administration du plan conjoint 1.Le plan conjoint est administré par l'Office des producteurs de lait .du Québec à la Cie Carnation, qui est composé de sept administrateurs.Les producteurs de langue anglaise sont représentés par deux membres et les producteurs de langue française, par cinq membres.À l'avenir, la représentation pour chaque groupement de producteurs à l'Office sera proportionnelle au pourcentage de la production totale livrée à l'acheteur par les membres de chacun des deux groupements de producteurs.Les administrateurs de l'Office sont présentement: M.Danias Messier, R.R.2, Bromptonville, comté de Richmond.Tél.: 846-4597.M.Dennis Kcenan, R.R.1, Grcenlay, comté de Richmond.Tél.: 845-2934.M.Denis Tétreault, R.R.2, Stanstead, comté de Stanstead.Tél.: 838-4853 ; M.Gaston Pouliot, R.R.2, Tingwick, comté d'Ar-thabaska.Tél.: 82S.4; M.Gilles Giroux, Côté est de la Rivière, Ste-Brigide.Tél.: 293-6267; M.Yvan Gaudreau, La Patrie, comté de Compton.Tél.: 888-2480; M.Murray Powell, Watcrville, comté de Compton.Tél.: 837-2675.12.Establish a Good Will Committee to study and find solution to the producers' grievances with respect to the carrying out of the Joint Plan, determine the regulation of the Committee and the full implication of its decisions; 13.Obtain from the producers all information judged useful to carry out the Joint Plan effectively; 14.Make all inquiries of such a nature as to attain the ends set down in the Joint Plan; 15.Negociatc with any person bound to do so by the Québec Agricultural Marketing Act all the marketing conditions, and more specifically: (a) The selling price of the contemplated product; (b) The conditions and the methods of payment of the price of the contemplated product; (c) The rationalization of the routes, the conditions, means and cost of transportation or of any service related to the marketing of the contemplated product; (imius Mcdica inc.Domus Mcdica Institute Inc.La compagnie « L'Institut Domus Medica inc.\u2014 Domus Medica Institute Inc.», donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 7 à 5.Le secrétaire, Jean-Paul Zigby.39018-o \u2022 228-67 L'Institut Domus Medica inc.Domus Mcdica Institute Inc.Notice is given that \"L'Institut Domus Medica inc.\u2014 Domus Medica Institute Inc.\", has changed the number of its directors from 7 to 5.Jean-Paul Zigby, Secretary.39018 228-67 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March G, 1971, Vol.103, No.10 2217 Dobois Realties Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 2, de la compagnie * Domaine du Bois de Montréal (1970) ltée \u2014 Domaine du Bois of Montreal (1970) Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 23e jour dc décembre 1970, changeant son nom en celui dc « Dobois Realties Ltd.».Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.39019-o 5782-70 Mercury Electric and Mcclianicai , Contractors Ltd.Avis est donné que la compagnie « Mercury Electric and Mechanical Contractors Ltd.» n changé le nombre de ses administrateurs dc 3 à 4.Le secrétaire, Leo Fisher.39020 707-05 Wilwakcn lue La compagnie « Wilvakcn Inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs dc 5 à 3.Le secrétaire, Mme Val Willis.39021-o 6309-69 Bibliothèque Centrale dc Fret du Sagticnay-Lac-St-Jcan Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 11 février 1971, il a approuvé les règlements généraux de la corporation « Bibliothèque Centrale de Prêt du Sagucnay-Lac-St-Jcan », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38983-0 4433-70 Dobois Realties Ltd.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.2, of the company \"Domaine du Bois de Montréal (1970) ltée \u2014 Domaine du Bois of Montreal (1970) Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 23rd day of December 1970, changing its name into that of \"Dobois Realties Ltd.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.39019-o 5782-70 Mercury Electric and Mechanical Contractors Ltd.Notice is given that \"Mercury Electric and Mechanical Contractors Ltd.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Leo Fisher, Secretary.39020-o 707-65 Wilwukcn Inc.Notice is given that \"Wilvaken Inc.\", has changed the number of its directors from 5 to 3.Mrs.Val Willis, Secretary.39021 6309-69 Bibliothèque Centrale dc Prêt du Saguenay-Lac-Sl-Jean Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, on February 11, 1971, has approved the general by-laws of \"Bibliothèque Centrale de Prêt du Saguenay-Lac-St-Jean\", pursuant to section 225 of the Companies Act.389S3 Roch Rioux, Director of the Companies Branch.4433-70 L'Association des Directeurs dc Théâtre inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 11 février 1971, il a approuvé les règlements généraux de « L'Association des Directeurs de Théâtre inc.», et ce, en vertu dc l'article 225 dc la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.38907-o 3953-64 L'Association des Directeurs de Théâtre inc.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on February 11, 1971, pursuant to section 225 of the Companies Act, he approved the general by-laws of \"L'Association des Directeurs de Théâtre inc.\".Roch Rioux, Director of the Companies Branch.3S967 3953-64 L'Association des Zouaves dc Québec inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 17 février 1971, il a approuvé les amendements aux règlements généraux numéro 10 de « L'Association des Zouaves dc Québec inc.», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38968-0 2027-65 L'Association des Zouaves de Québec inc.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on February 17, 1971, pursuant to section 225 of the Companies Act, he approved the amendments to general by-laws number 10 of \"L'Association des Zouaves de Québec inc.\".38968 Roch Rioux, Director of the Companies Branch.2027-65 2218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 L'Association Québécoise des Fabricants dc Tuyau de Béton inc.Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.Le ministre «les institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 22 janvier 1971, il a approuvé les règlements numéro 1, 2 et 3 de « L'Association Québécoise des Fabricants de Tuyau de Béton inc.\u2014 Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.», et ce, en vertu dc l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38969-o 5643-70 Boutique Phase inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 6, dc la compagnie « Créations de l'Heure (Saguenay) inc.», constituée par lettres patentes en date du 4c jour dc septembre 1969, changeant son nom en celui de « Boutique Phase inc.».Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38970-o 4191-69 Cincpix Inc.La compagnie « Cinepix Inc.», donne avis qu'elle a changé le nombre dc ses administrateurs dc 3 à 5.Le secrétaire, Leo Gregory.38971 12777-62 Comité des Loisirs dc Frontenac (St-Jcan Vianncy) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 29 janvier 1971, il a approuvé les règlements généraux de la corporation « Comité des Loisirs de Frontenac (St-Jean Vianncy) », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38972-o 3901-70 Custom Craft Furniture Inc.La compagnie « Custom Craft Furniture Inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Saul Tolmasky.38973 15563-59 Solo Products Limited La compagnie « Solo Products Limited » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses directeurs de 4 à 6.Le secrétaire, Nat.L.Solomon.38978 1150-37 L'Association Québécoise des Fabricants de Tuyau dc Béton inc.Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on January 22, 1971, approved by-laws numbers 1, 2 and 3 of \"L'Association Québécoise des Fabricants de Tuyau dc Béton inc.\u2014 Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38969 5643-70 Boutique Phase inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.6, of the company \"Créations de l'Heure (Saguenay) inc.\", incorporated by letters patent dated the 4th day of September 1969, changing its name into that of \"Boutique Phase inc.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.3S970-o 4191-69 \u2022 Cincpix Inc.Notice is given that \"Cincpix Inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 5.Leo Gregory, Secretary.38971-0 12777-62 Comité des Loisirs dc Frontenac (St-Jcan Vianncy) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on January 29, 1971-, pursuant to Section 225 of the Companies Act, he approved the general by-laws of \"Comité des Loisirs de Frontenac (St-Jean Vianncy) ».Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3S972 3901-70 Custom Craft Furniture Inc.Notice is given that \"Custom Craft Furniture Inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.38973-o Saul Tolmasky.Secretary.15563-59 Solo Products Limited Notice is given that \"Solo Products Limited\" has changed the number of its directors from 4 to 6.Nat.L.Solomon, Secretary.38978-0 1150-37 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 \u2022 2219 Les Dames Auxiliaires du Centre Francois-Michelle pour Déficients Mentaux Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 18 février 1971, il a approuvé les règlements numéro 1, 2 et 3 dc la corporation « Les Dames Auxiliaires du Centre François-Michelle pour Déficients Mentaux », et ce, en vertu de l'article 225 dc la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38974-o 1775-70 Les Dames Auxiliaires du Centre Francois-Michelle pour Déficients Mentaux The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on February 18, 1971, pursuant to section 225 of the Companies Act, he approved by-laws Nos.1, 2 and 3 of \"Les Dames Auxiliaires du Centre François-Michelle pour Déficients Mentaux ».Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38974 1775-70 Pan Arkadian Brotherhood of Canada Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 18 février 1971, il a approuvé les règlements généraux dc la corporation «Pan Arkadian Brotherhood of Canada», et ce, en vertu de l'article 225 dc la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38975-o 10381-61 l'a ! -an Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il y approuvé le règlement numéro 1S, de la compagnie « Progressive Publications Inc.\u2014 Publications Progressives inc.», constituée par lettres patentes en date du 29e jour dc juillet 1968, changeant son nom en celui dc « Patsan Inc.».Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.38976-0 3423-68 Pan Arkadian Brotherhood of Canada The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on February 18, 1971, pursuant to section 226 of the Companies Act, he approved the general by-laws of the \"Fan Arkadian Brotherhood of Canada\".Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38975 10381-61 Patsan Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number 18, of the company \"Progressive Publications Inc.\u2014 Publications Progressives inc.\", incorporated by letters patent dated the 29th day of July 1968, changing its name into that of \"Patsan Inc.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.3S976-o .3423-68 Service des Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens de Montréal Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 11 janvier 1971, il a approuvé les règlements généraux numéro 1 à 41 de la corporation « Service des Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens de Montréal », et ce, en vertu de l'article 225 dc la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.38977-0 14009-59 Service des Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens dc Montréal The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on January 11,1971, he approved general by-laws number 1 to 41 of \"Service des Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens de Montreal\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Roch Rioux, Director of the Companies Branch.38977 14009-59 Sièges sociaux Lafargc Concrete Ltd.Lafarge Béton ltée La compagnie «Lafarge Concrete Ltd.\u2014 Lafarge Béton ltée » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 750, boulevard Laurenticn, ville Saint-Laurent au numéro 620 ouest, boulevard Dorchester, Montréal.L'assistant-secrétaire, Jacques Gourdon.38989-0 .6158-46 Head Offices Lafarge Concrete Ltd.Lafarge Béton ltée \"Lafarge Concrete Ltd.\u2014 Lafarge Béton ltée\" gives notice that it changed its head office from 750 Lauren-tian Boulevard, City of St.Laurent to 620 Dorchester Boulevard West, Montreal.Jacques Gourdon, Assistant Secretary.38989 6158-46 2220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103- année, n° 10 Fleuriste Place Bonavcnturc inc.Place Bonavcnturc Florist Inc.La compagnie « Fleuriste Place Bonavcnture inc.\u2014 Place Bonavcnture Florist Inc.» constituée en corporation par lettres patentes, le 1er août 1966, et ayant son siège social en la ville de Montréal, donne avis qu'elle a établi son bureau à 1.place Bonavcnturc.À compter de la date dc cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 23e jour dc septembre 1970.Le président, Alastir Smith.38984 3030-66 Les Imprimeries Amyot inc.La compagnie «.Les Imprimeries Amyot inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social dc Montréal au numéro 637, Place Publique, Ste-Dorothée, Laval.Le secrétaire, Claudette Sciotti.38985-q 132-68 Fleuriste Place Bonavcnture inc.Place Bonavcnturc Florist Inc.Notice is hereby given that \"Fleuriste Place Bonavcnturc inc.\u2014 Place Bonaventure Florist Inc.\" incorporated by letters patent on the 1st day of August 1966, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 1 Place Bonaventure.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office at the company.Dated at Montreal, this 23rd day of September, 1970.Alastir Smith, President.38984-0 3030-66 Les Imprimeries Amyot inc.Notice is given that \"Les Imprimeries Amyot inc.\" has changed its head office from Montreal to number 637 Place Publique, Ste-Dorothée, Laval.Claudette Sciotti, Secretary.38985 132-68 Inter-Provincial Mortgage Corporation Avis est donné que la compagnie « Inter-Provincial Mortgage Corporation », constituée en corporation en vertu des dispositions de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 21c jour de février 1963, et ayant son' siège social à Montréal, a transporté son bureau dc 1255, carré Phillips, local 303, ville et district de Montréal à 2085, rue Guy, « Penthouse Floor », ville et district de Montréal.Daté à Montréal, ce 13e jour dc janvier 1971.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, Gerard L.Schneider.38986 822-63 Jontec inc.La compagnie « Jontec inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3899, rue de la Peltrie, Montréal au numéro 304C, rue Saint-Hubert, Jonquière.Le secrétaire, André Tremblay.38987-o 2276-70 In ter-Provincial Mortgage Corporation Notice is hereby given that \"Intcr-Provincial Mortgage Corporation\", incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act by letters patent dated from the 21st day of February, 1963, and having its head office in Montreal, has moved its office and principal place of business from 1255 Phillips Square, Suite 303, city and district of Montreal, to 2085 Guy Street, Penthouse Floor, city and district of Montreal.Dated at Montreal, this 13th day of January, 1971.(Seal) Gerard L.Schneider, Secretary-Treasurer.38986-0 822-63 Jontec inc.Notice is given that \"Jontec inc.\" has changed its head office from number 3899 de la Peltrie Street to number 304C, Saint-Hubert Street, Jonquière.38987 André Tremblay, Secretary.2276-70 L'Association des Directeurs de Théâtre inc.Avis est donné que la corporation « L'Association des Directeurs de Théâtre inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 septembre 1964 et ayant son siège social dans la cité de Montréal, a établi son bureau au numéro 1400, rue St-Urbain.À compter de la date du présent avis, le bureau est considéré par la corporation comme étant son siège social., Donné â Montréal, ce 16 décembre 1970.(Sceau) Le président, Gilles Pelletier.38979-0 3953-64 L'Association des Directeurs de Théâtre inc.Notice is given that \"L'Association des Directeurs de Théâtre inc.\", incorporated by letters patent dated September 28, 1964, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at number 1400, St-Urbain St.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the corporation as being its head office.Given at Montreal, December 16, 1970.(Seal) Gilles Pelletier, President.38979-o 3953-64 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2221 Kcbccon Construction Inc.Avis est donné que la compagnie « Kebecon Construction Inc.» a transféré son siège social de 240, rue Le Baron, Boucherville à 190, Ile dc France, Longucuil.Le secrétaire, Moyra Caron.389S8 1688-70 Kebecon Construction Inc.Notice is given that \"Kebecon Construction Inc.\" has transferred its head office from 240 Lc Baron Street, Boucherville to 190 Ile de France, Longueuil.Moyba Caron, Secretary.38988-0 1688-70 Lasalle Industrial Development Corporation Développement industriel Lasalle Avis est donné que la compagnie « Lasalle Industrial Development Corporation \u2014 Développement industriel Lasalle», constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie dc Loi des compagnies du Québec en date du 26e jour de novembre, 1970, et ayant son siège social dans la ville de Lasalle, a établi son bureau à 7401, boulevard Newman.A compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 1.9e jour de janvier 1971.(Sceau) Le secrétaire, Clément Beauregard.38980-o 5225-70 Lasalle Industrial Development Corporation Développement industriel Lasalle Notice is hereby given that \"Lasalle Industrial Development Corporation \u2014 Développement industriel Lasalle\", incorporated under the provisions of Part I of the Québec Companies Act on the 26th day of November, 1970, and having its bead effice in the city of Lasalle, has established its effice at 7401 Newman Boulevard.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 19th day of January 1971.(Seal) Clément Beauregard, Secretary.38980-O 5225-70 LaSalle Caskets Manufacturers Inc.Les fabricants de cercueils LaSalle inc.Avis est donné que la compagnie « LaSalle Caskets Manufacturers Inc.\u2014 Les fabricants de cercueils LaSalle inc.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 23 mars 1970 et ayant son siège social à Verdun, a établi son bureau au numéro 1425, de la rue Leclair.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.i Donné à Cité LaSalle, ce 1er jour de février 1971.38981-0 Gérald Lépine.1159-70 G.R.Legault & Associés inc.G.R.Legault & Associates Inc.La compagnie « G.R.Legault & Associés inc.\u2014 G.R.Legault & Associates Inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Montréal au numéro 1400, rue Des Alouettes, St-Bruno-de-Montarville.Le secrétaire, Jacques Robidoux.38990-o 4489-70 Les Services M.E.O.(Montréal) inc.Im compagnie « Los Services M.E.O.(Montréal) inc.», donne avis qu'elle a chagé son siège social de Montréal au numéro 472, 15c Avenue, (Laval des Rapides) Laval.Le secrétaire, Dominique Fiorito.39026-o 4360-70 LaSalle Caskets Manufacturers Inc.Les fabricants dc cercueils LaSalle inc.Notice is given that \"LaSalle Caskets Manufacturers Inc.\u2014 Les fabricants de cercueils LaSalle inc.\", incorporated by letters patent dated March 23, 1970, and having its head office in Verdun, established its office at 1425 Leclair Street, From and after the date of this notice, the said effice is considered by the company as being its head effice.Given at the City of LaSalle, this 1st day of February, 1971.Gérald Lépine.38981 1159-70 G.R.Legault & Associés inc.G.R.Legault & Associates Inc.Notice is given that \"G.R.Legault & Associés inc.\u2014 G.R.Legault & Associates Inc.\" has changed its head office from Montreal to number 1400 Des Alouettes Street, St-Bruno-de-Montarvillc.Jacques Robidoux, Secretary.38990 4489-70 Les Services M.E.O.(Montréal) inc.Notice is given that \"Les Services M.E.O.(Montréal) inc.\", has changed its head office from Montreal to 472, 15th Avenue, (Laval des Rapides), Laval.39026 Dominique Fiorito, Secretary.4360-70 2222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103- année, n' 10 Pierre Morcault limitée Avis est donné que la compagnie « Pierre Morcault limitée » constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 janvier 1971 et ayant son siège social à Hull, a établi son bureau principal au numéro civique 193, rue Montcalm.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, en date du 12e jour de janvier 1971.Le président, Raymond Crevier.38991-o 91-71 A.H.Nadon,Inc.Avis est donné que la compagnie « A.H.Nadon, Inc.», constituée en corporation par lettres patentes émises par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives en date du deuxième jour de janvier 1970, et ayant son siège social à Buckingham, dans le district de Hull, a établi son bureau au No 104, de la rue MacLarcn Est.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Buckingham, ce huitième jour de février 1971.André H.Nadon.38992-0 6225-69 Shaggy Dog Hotel Inc.La compagnie « Shaggy Dog Hotel Inc.» donne avis qu'elle a transporté son siège social de Cowansville à Bolton-East.Le secrétaire, Alfred Pilgrim.38993 214-64 A.I.M.S.Inc.Avis est donné que la compagnie « A.I.M.S.Inc.», a transporté son siège social de 4, rue Grecnview, Dollard-des-Ormcaux à 1130, rue Peel, Montréal.Le secrétaire.Lois M.White.39022 4914-70 H.Nathanson Inc.Avis est donné que la compagnie « H.Nathanson Inc.», a transféré son siège social de Montréal au 1, Aldred descent, Hunipstcad.Le secrétaire, Marlene Nathanson.39023 11387-56 Restaurants Renaissance inc.La compagnie « Restaurants Renaissance inc.», donne avis qu'elle a changé son siège social de Montréal à Aéroport International de Montréal, Doryal.Le secrétaire, Bernard Durante.39025-o 5054-70 Pierre Morcault limitée Notice is hereby given that \"Pierre Morcault limitée\" incorporated by letters patent dated January 11, 1971 and having its head office in Hull, has established its office at civic number 193 Montcalm Street.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given in Montreal, this 12th day of January, 1971.Raymond Crevier, President.38991-o 91-71 All.Nadon, Inc.Notice is hereby given that \"A.H.Nadon, Inc.\", company incorporated by letters patent issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, on the second day of January, 1970, and having its head office in Buckingham, district of Hull, has established its office at No.104 MacLarcn Street East.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Buckingham, this eighth day of February, 1971.André H.Nadon.38992-o 6225-69 Shaggy Dog Hotel Inc.Notice is given that \"Shaggy Dog Hotel Inc.\" has transferred its head office from Cowansville to Bolton-Est.Alfred Pilgrim, Secretary.38993-o 214-64 A.I.M.S.Inc.Notice is given that \"A.I.M.S.Inc.\", has transferred its head office from 4 Grecnview Street, Dollard-des-Ormeaux to 1130 Peel Street, Montreal.Lois M.White, Secretary.39022-o 4914-70 H.Nathanson Inc.Notice is given that \"H.Nathanson Inc.\", has transferred its head office from Montreal to 1 Aldred Crescent, Hampstead.Marlene Nathanson, Secretary.39023-o 11387-56 Restaurants Renaissance inc.Notice is given that \"Restaurants Renaissance inc.\", has changed its head office from Montreal to the Montreal International Airport, at Dorval.Bernard Durante, Secretary.39025 5054-70 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 Stalwart Holdings Inc.Avis est donné que la compagnie « Stalwart Holdings Inc.», constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies en date du 8e jour de janvier 1971, et ayant son siège social dans la ville dc Montréal, a établi son bureau à 355, rue St-Jacques Ouest. compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, Kathryn Morrow.38994-o 108-71 Trans-Provincial Mortgage Corp.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Trans-Provincial Mortgage Corp.», constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie dc la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 4 octobre 1968, et ayant son siège social à Montréal, Ji transporté son bureau et sa principale place d'affaires de 1255, carré Phillips, local 303 à 2085, rue Guy, « Penthouse Floor ».Daté à Montréal, ce 13c jour de janvier 1971.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, Morton J.Litwack.38995 4579-68 Plomberie P.V.G.Inc.Avis est donné que la compagnie « Plomberie P.V.G.Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 26 novembre 1970, et ayant son siège social à Terrebonne a établi son bureau au numéro 674, de la rue Saint-Michel.A compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 15 février 1971.Les procureurs de la compagnie, Brière, Boivin, Paquette & Beaulac.39024-o 5221-70 La Société d'Entretien du Québec inc.« La Société d'Entretien du Québec inc.», donne avis qu'elle a changé son siège social de Jonquière au numéro 15, rue Maple, Kénogami.Le secrétaire, Michelle Soucy.39027-o 5380-67 2223 Stalwart Holdings Inc.Notice is hereby given that \"Stalwart Holdings Inc.\", incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act on the 8th day of January, 1971, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 355 St.James Street West.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.(Seal) Kathryn Morrow, Secretary-Treasurer.38994-o 108-71 Trans-Provincial Mortgage Corp.Notice is hereby given that \"Trans-Provincial Mortgage Corp.\", incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act by letters patent dated October 4, 1968, and having its head office in Montreal has moved its office and principal place of business from 1255 Phillips Square, Suite 303, to 2085 Guy Street, Penthouse Floor.Dated at Montreal, this 13th day of January, 1971.(Seal) Morton J.Litwack, Secretary-Treasurer.38995-o 4579-68 Plomberie P.V.G.Inc.Notice is hereby given that \"Plomberie P.V.G.Inc.\", duly incorporated by letters patent dated November 26, 1970, and having its head office in Terrebonne has established its office at 674 St.Michel Street.As from the date of the piescnt notice, the said office is considered by the company as its head office.Given at Montreal, February 15, 1971.Brière, Boivin, Paquette & Beaulac, Attorneys for the Company.39024-o 5221-70 La Société d'Entretien du Québec inc.Notice is given that \"La Société d'Entretien du Québec inc.\", has changed its head office from Jonquière to number 15 Maple Street, Kénogami.Michelle Soucy, Secretary.39027 5380-67 Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Tomi Moskovits Avis est donné que M.Tomi Moskovits, résidant à 564, 68e Avenue, cité de Laval, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur afin d'obtenir le changement de son nom en celui de M.Tom Masco.Montréal, 4 janvier 1971.Les procureurs du requérant, 38947-10-2 Mtres Lechter & Segal.Change of name \u2014 Act Applications Tomi Moskovits Notice is hereby given that Mr.Tomi Moskovits, residing at 564, 68th Avenue, city of Laval, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor to change his name to Mr.Tom Masco.Montreal, January 4, 1971.Mtres.Lechter & Segal, 3S947-10-2-o Attorneys Jor petitioner. 2224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Johann Thomschitz Avis est donné que Johann Thomschitz, résidant à 5007, avenue Van Horne, Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur afin d'obtenir le changement de son nom en celui de M.John Thomas et que Mme Paule Thomschitz puisse changer son nom en celui de Mme Paule Thomas.Montréal, 16 février 1971.Les ¦procureurs du requérant, 38948-10-2 Leciiter & Segal.Apostolos (Paul) Papathanasoponlos Avis est donné que Apostolos (Paul) Papathanaso-poulos, du 7525 de la rue Jean-Bourdon, de la ville et district dc Montréal, Province dc Québec, s'adressera au ministre dc la justice pour changer son nom de Apostolos (Paul) Papathanasopoulos à Paul Pappas; ledit changement de nom devant profiter à son épouse.Dame Helen Gavaris, et à ses deux enfants mineurs, Frank (Paul) Papathanasopoulos cl Gcorgc-Constan-tinc Papathanasopoulos.Daté à Montréal, Québec, ce 26e jour de février 1971.Le procureur du réqcérant, 39044-10-2-o Alexander Biega, c.r.Joseph René Louis Emile Edgard Cognard Avis est par les présentes donné, que Joseph René Louis Emile Edgard Cognard, professeur, domicilié à 6510 avenue Wilderton, app.204, Montréal 251, P.Q., présente une requête au ministre dc la Justice de la province de Québec afin de changer son nom à Ronald Lawrence Cunard, suivant les dispositions de la Loi du changement de nom, Statuts du Québec, chapitre 77, 1965.Montréal, le 17 février 1971.Le procureur du requérant, 38883-9-2-0 Stanley Haltrecut.Florence Soucissc dit Soucis Avis est par les présentes donné que Mademoiselle Florence Soucissc, dit Soucis, commis de bureau résidant au 5074 rue Fabre, Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Florence Soucis.Montréal, le 12 février 1971.38902-9-2-o Florence Soucisse.Jean-Pierre Noury Avis est par la présente donné que Jean-Pierre Noury fib de René Noury et de Georgette Pcneault, demeurant et domicilié au 12, 42e Avenue à Bois des Filions, district de Terrebonne, a présenté au ministre de la Justice une requête suivant la Loi du changement de nom (chapitre 77 des Statuts de la province de Québec de 1965) aux fins de changer son nom en celui de Jean-Pierre Deslauriers et d'y exercer tous ses droits sous ce nouveau nom.Les procureurs du requérant, 38903-9-2-o Bêland, Trudeau & Bastien.Johann Thomschitz Notice is hereby given by these presents that Mr.Johann Thomschitz, residing at 5007 Van Horne Avenue, Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor to change his name to Mr.John Thomas and Mrs.Paule Thomschitz will change her name to Mrs.Paule Thomas.Montreal, February 16, 1971.Lechter & Segal, 38948-10-2-o Attorneys for petitioner.Apostolos f I'.mI) Papathanasopoulos Notice is given that Apostolos (Paul) Papathanasopoulos, of 7525 Jean-Bourdon Street, of the city and district of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Justice to change his name from Apostolos (Paul) Papathanasopoulos to Paul Pappas; said change of name is to benefit his wife, Dame Helen Gavaris, and his two minor children, Frank (Paul) Papathanasopoulos and Gcorgc-.Constantine Papathanasopoulos.Dated at Montreal, Québec, this 26th day of February, 1971.Alexander Biega, q.c, 39044-10-2-o Attorney for the Petitioner.Joseph Rend Louis Emile Edgard Cognard Notice is hereby given that Joseph René Louis Emile Edgard Cognard, teacher, residing at 6510 Wilderton Avenue, Apt.204, Montreal 251, P.Q., is applying to the Minister of Justice of the Province of Québec to change his name to Ronald Lawrence Cunard, in accordance with the Change of Name Act, Québec Statutes chapter 77, 1965.Montreal, February 17, 1971.Stanley Haltrecht, 38883-9-2-0 Attorney for the applicant.Florence Soucisse dit Soucis Notice is hereby given that Miss Florence Soucisse, dit Soucis, office clerk, residing at 5074 Fabre Street, Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain a decree changing her name to Florence Soucis.Montreal, February 12, 1971.38902-9-2-o Florence Soucisse.Jean-Pierre Noury Take notice that Jean-Pierre Noury son of René Noury and Georgette Peneault, living at 12, 42e Avenue, Bois des Filions, district of Terrebonne, made an application to the Minister of Justice under the Change of Name Act (chapter 77, Statutes of the Province of Québec 1965) to have his name changed to Jean-Pierre Deslauriers and claim and possess all his legal rights under this new name.Béland, Trudeau & Bastien, 38903-9-2-o Attorneys for the petitioner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.10S, No.10 2225 Sidney Thomas Kitaika Avis est par la présente donné que Sidney Thomas Kitaika, marchand, résidant et domicilié au 4151 avenue Cunard, ville St-Laurent, district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province dc Québec un décret changeant son nom en celui dc Sydney Thomas Ticker, duquel changement bénéficieront aussi son épouse, née Roslyn Seltzer et leurs enfants mineurs, Charles Brian et Ghita Feigie, résidant et étant tous domiciliés à l'adresse ci-haut mentionnée.Montréal, le 24 février 1971.Les procureurs du requérant, Greenblatt, Godinsky 39010-10-2-o & Resin.Sidney Thomas Kitaika Notice is hereby given that Sidney Thomas Kitaika, merchant, residing and domiciled at 4151 Cunard Avenue, Ville St.Laurent, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to Sydney Thomas Ticker, which change will also benefit his wife, born Roslyn Seltzer and their minor children Charles Brian and Ghita Feigie, all residing and domiciled at the address mentioned above.Montreal, February 24, 1971.Greenblatt, Godinsky & Resin, 39010-10-2-o Attorneys for the applicant.Demandes à la Législature Applications to Legislature Cité de Verdun Avis public est par les présentes donné que la cité de Verdun s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.pour abroger l'article 6 du chapitre 55 des lois de 1943; 2.pour abroger les articles 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 .du chapitre 53 des lois de 1944; 3.pour abroger les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du chapitre 73 des lois de 1945; 4.pour abroger l'article 2 du chapitre 53 des lois de 1954-55; 5.pour abroger l'article 6 du chapitre 70 des lois de 1955-56; 6.pour amender pour la cité l'article 473 de la Loi des cités et villes pour autoriser la cité à accorder une subvention de $200 à tout propriétaire qui démolit son hangar ou autre bâtiment accessoire; 7.pour amender pour la cité l'article 426-1 de la Loi des cités et villes pour autoriser la cité à adopter un règlement de zonage remplaçant le règlement No 128 concernant les bâtiments et les règlements qui l'ont modifié, ledit règlement devant fitre approuvé par le ministre des Affaires municipales, après une enquête publique tenue par la Commission municipale de Québec; 8.pour amender pour la cité l'article 473 de la Loi des cités et villes pour autoriser le conseil de la cité à accorder par règlement, sujet à l'approbation dc la Régie des Rentes du Québec, une pension annuelle n'excédant pas S600 à tout officier ou employé permanent ayant complété 25 années de service, qui n'est pas eligible au fonds de pension ou qui ne reçoit pas une pension suffisante de la cité; 9.pour remplacer pour la cité l'article 593 de la Loi des cités et villes.et pour toutes autres fins.Montréal, ce 24 février 1971.Les procureurs de la cité de Verdun, Lacroix, Viau, Bélanger, Hébert, 39012-10-4-o Mailloux et Beauregard.City of Verdun Public notice is hereby given that the city of Verdun will apply to the National Assembly of Québec at its present session, for the adoption of an Act amending its charter, for the following purposes: 1.to abrogate article 6 of chapter 55 of the laws of 1943; 2.to abrogate articles 7, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 of chapter 53 of the laws of 1944; 3.to abrogate articles 4, 5, 6, 7, 8 and 9 of chapter 73 of the laws of 1945; 4.to agrogate article 2 of chapter 53 of the laws of 1954-55; 5.to abrogate article 6 of chapter 70 of the laws of 1955-56; 6.to amend for the city, article 473 of the Cities and Towns Act to authorize the city to grant a subsidy of $200 to every owner .who is pulling down his shed; 7.to amend for the city, article 426-1 of the Cities and Towns Act to authorize the city to adopt a zoning by-law replacing by-law No.128 concerning buildings and the by-laws modifying said by-law No.128, said by-law to be approved by the Minister of Municipal Affairs, after a public enquiry held by the Municipal Commission of Québec; 8.to amend for the city, article 473 of the Cities and Towns Act to authorize the city to grant by by-law to be approved by the Québec Pension Plan, an annual pension not exceeding $600 to every permanent officer or employee having completed 25 years of services, who is not eligible to the pension fund or does not receive a sufficiant pension from the city; 9.to replace for the city, article 593 of the Cities and Towns Act.and for all other purposes.Montreal, February 24, 1971.Lacroix, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux & Beauregard, 39012-10-4-o Attorneys for the city of Verdun. 2226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Club dc Golf de New Glasgow (1966) Inc.Avis est donné par les présentes que « Club dc Golf de New Glasgow (1966) Inc.» s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, à sa prochaine session, afin d'obtenir une loi pourvoyant entr'autres: A) Modifier le capital actions de la corporation; B) Pourvoir que la nouvelle charte sera régie par les dispositions de la deuxième partie de la Loi des compagnies du Québec; C) Telles autres fins qui sont énumérées dans la loi ; Montréal, le 23 février 1971.39011-10-4-o André Forget et Jacques Guérin.New Glasgow Golf Club (1966) Inc.Notice is hereby given that: \"New Glasgow Golf Club (1966) Inc.\" will apply to the National Assembly of Québec, at its next session, to get the adoption of act for the following purposes: A) To amend the shareholding stock of the corporation; B) To provide for that the provisions of the second part of the Québec Companies Act will apply to the new charter; C) For all other purposes provided for in the law.Montreal, February 23, 1971.39011-10-4-o André Forget and Jacques Guérin.Ministère des Terres et Forêts Cadastre Village dc Beaulac Cadastre officiel du village dc Beaulac, municipalité du village de Beaulac, division d'enregistrement de Wolfe.Avis est par la présente donné que le bloc 11 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 12 février 1971.Le sous-ministre, 39003-o Fernand Boutin.Canton de Carignan du Rang 11 Cadastre officiel du canton dc Carignan du Rang 11, division d'enregistrement de La Tuque.Avis est par la présente donné que les lots 12A, 12B et 12C sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 octobre 1970.Le sous-ministre, 39003-o Fernand Boutin.Paroisse de Notre-Dame de Québec (BanUeue) Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame de Québec (Banlieue), municipalité de la ville de Québec, division d'enregistrement de Québec.Avis est par les présente donné qu'une partie du lot 35-99 est annulée et que le lot 35-92 est corrigé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 3 février 1971.Le sous-ministre, 39003-o Fernand Boutin.Canton Orford Cadastre officiel du canton Orford, municipalité de la paroisse de St-Denis de B romp ton, division d'enregistrement de Sherbrooke.Department of Lands and Forests Cadastre Village of Beaulac Official cadastre of village of Beaulac, municipality of village of Beaulac, registration division of Wolfe.Notice is hereby given that block 11 is added in virtue of Article 2174A of the Ci\\il Code.Québec, February 12, 1971.Fernand Boutin, 39003-o Deputy Minister.Township of Carignan of Rang 11 Official cadastre of township of Carignan of Range 11, registration division of La Tuque.Notice is hereby given that lots 12A, 12B and 12C are added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, October 7,1970.Fernand Boutin, 39003-o Deputy Minister.Parish of Notre-Dame de Québec (Suburbs) Official cadastre of the parish of Notre-Dame de Québec (Suburbs), municipality of the town of Québec, registration division of Québec.Notice is hereby given that a part of lot 35-99 is cancelled and that lot 35-92 is corrected in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 3, 1971.Fernand Boutin, 39003-o Deputy Minister.Township of Orford Official cadastre of township of Orford, municipality of the parish of St-Denis de Brompton, registration division of Sherbrooke. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2227 Avis est par la présente donné que les lots 725-6, 725-7 and 725-8 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 15 février 1971.Le sous-minislre, 39003-o Fernand Boutin.Paroisse dc St-Mathicu de Belocil Cadastre officiel de la paroisse de St-Mathieu dc Belocil, municipalité de la ville de Beloeil, division d'enregistrement de Verchères.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 41-250 et 41-250-2 et des lots 41-251, 41-252, 41-254 et 41-255 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 2 février 1971.Le sous-ministre, 39003-o Fernand Boutin.Canton dc Stratford Cadastre officiel du canton de Stratford, municipalité du canton de Stratford, division d'enregistrement de Wolfe Avis est par la présente donné que le bloc 1 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 12 février 1971.Le sous-ministre, 39003-o Fernand Boutin.Notice is hereby given that lots 725-6, 725-7 and 725-8 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 15, 1971.Fernand Boutin, 39003-o Deputy Minister.Parish of St-Mathieu de Beloeil Official cadastre of the parish of St-Mathicu de Beloeil, municipality of the town of Beloeil, registration division of Verchères.Notice is hereby given that a part of lots 41-250 and 41-250-2 and that lots 41-251,41-252, 41-254 and 41-255 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 2, 1971.Fernand Boutin, 39003-o Deputy Minister.Township of Stratford Official cadastre of township of Stratford, municipality of township of Stratford, registration division of Wolfe.Notice is hereby given that block 1 is added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 12, 1971.Fernand Boutin, 39003-o Deputy Minister.Ministère de l'Éducation Department of Education Lorettevillc, diss, et Saint-Sauveur, Prot.Demande est faite de fusionner le territoire actuel dc la municipalité scolaire de Saint-Sauveur (prot.) dans le comté de Saint-Sauveur, et celui actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles pour la municipalité de Lorettevillc, dans le comté de Chauveau, et de les ériger en une municipalité scolaire distincte pour les protestants seulement, sous le nom de Lorettevillc-Saint-Sauveur, dans les comtés de Chauveau et Saint-Sauveur.Québec, le 2 mars 1971.Le ministre de l'Éducation, i Guy Saint-Pierre.39054-10-2-o 990-03 Montcbello, diss.Demande est faite d'annexer le territoire actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles pour la municipalité scolaire de Montebello, dans le comté de Papincau, à la municipalité scolaire de Buckingham (prot), dans le comté de Papineau.Québec, le 1er mars 1971._ Le ministre de l'Éducation, Guy Saint-Pierre.39055-10-2-o 970-01 Lorettevillc, diss, et Saint-Sauveur, Prot.Application is made to amalgamate the present territory of the school municipality of Saint-Sauveur (Prot), in the county of Saint-Sauveur, with that now under the jurisdiction of the school trustees for the municipality of Loretteville, in the county of Chauveau, and to erect them into a distinct school municipality, for Protestants only, under the name of Loretteville-Saint-Sauveur, in the counties of Chauveau and Saint-Sauveur.Québec, March 2, 1971.Guy Saint-Pierre, Minister of Education.39054-10-2 \u2022 x 990-03 Montcbello, diss.Application is made to annex the territory now under the jurisdiction of the school trustees for the school municipality of Montebello, in the county of Papineau, to the school municipality of Buckingham (Prot.), in the county of Papineau.Québec, March 1, 1971.Guy Saint-Pierre, Minister of Education.39055-10-2 970-01 2228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 108' année, n° 10 Murdochvillc, diss.Demande est faite d'ériger en une municipalité scolaire distincte, pour les protestants seulement, le territoire actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles pour la municipalité scolaire de Murdochville, dans le comté de Gaspé-Ouest.Québec, le 1er mars 1971.Le minisire de l'Éducation, Guy Saint-Pierre.39056-10-2-o 930-01 Portneuf, diss.Demande est faite d'ériger en une municipalité scolaire distincte pour les protestants seulement, le territoire actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles pour la municipalité scolaire de Portneuf, dans le comté dc Portneuf.Québec, le 1er mars 1971.Le ministre de l'Éducation, Guy Saint-Pierre.39057-10-2-o 990-03-G Sle-Adble, diss.Demande est faite d'ériger en une municipalité scolaire distincte, pour les protestants seulement, le territoire actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles pour la municipalité scolaire de Ste-Adèle, dans le comté de Terrebonne.Québec, le 1er mars 1971.Le ministre dé l'Éducation, Guy Saint-Pierre.39058-10-2-o 940-01 Murdochville, diss.Application is made to erect into a distinct school municipality, for Protestants only, the territory now under the jurisdiction of the school trustees for the school municipality of Murdochville, in the county of Gaspé West.Québec, March 1, 1971.Guy Saint-Pierre, Minister of Education.39056-10-2 930-01 Portneuf, diss.Application is made to erect into a distinct school municipality, for Protestants only, the territory now under the jurisdiction of the school trustees for the school municipality of Portneuf, in the county of Portneuf.Québec, March 1, 1971.Guy Saint-Pierre, Minister of Education.39057-10-2 990-03-G S te-Adèle, diss.Application is made to erect into a distinct school municipality, for Protestants only, the territory now under the jurisdiction of the school trustees for the school municipality of Ste-Adèle, in the county of Terrebonne.Québec, March 1, 1971.Guy Saint-Pierre, Minister of Education.39058-10-2 940-01 Société d'habitation Québec Housing du Québec Corporation Office municipal d'habitation de, Victoriaville Municipal Housing Bureau of Victoriaville Errata Dans l'avis d'émission de lettres patentes constituant en corporation l'« Office municipale d'habitation de Victoriaville \u2014 Municipal Housing Bureau of Victoriaville », paru à la page 1754 de la Gazette officielle du Québec le 13 février 1971 (N° 7, Volume 103), il aurait fallu lire à la 6e ligne à la suite des mots « sans but lucratif » les noms suivants: Paul Bégin, opérateur, Victoriaville; Adrien Lessard, commerçant, Victoria-ville; Albert Audet, ingénieur, Victoriaville; J.G.Tou-rigny, inspecteur en bâtiments, Victoriaville; Lévis Lupien, administrateur, Victoriaville; Robert Proven-cher, entrepreneur général, Victoriaville; Gaston Dunn, contremaître, Victoriaville; Claude Pinard, avocat, Victoriaville; Rock Gardner, professeur, Victoriaville.Le secrétaire, 39042-o Richard Valois.Office municipal d'habitation dc Victoriaville Municipal Housing Bureau of Victoriaville Errata In the notice of issue of letters patent incorporating 1' \"Office municipal d'habitation de Victoriaville \u2014 Municipal Housing Bureau of Victoriaville\", published on page 1754 of the Québec Official Gazette, February 31 1971, (No.7, Vol.103), the following names: Paul Begin, operator, Victoriaville; Adrien Lessard, merchant, Victoriaville; Albert Audet, engineer, Victoriaville; J.G.Tourigny, building inspector, Victoriaville; Levis Lupien, director, Victoriaville; Robert Proven-cher, general contractor, Victoriaville; Gaston Dunn, foreman, Victoriaville; Claude Pinard, lawyer, Victoriaville; Rock Gardner, teacher, Victoriaville; should have appeared in the 6th line after the word \"corporation\".Richard Valois, 39042-o Secretary. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2229 Lettres patentes Letters Patent Association Provinciale des Chevaux Miniatures Provincial Association of Miniature Horses Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger les lettres patentes de Vf Association Provinciale des Chevaux Miniatures \u2014 Provincial Association of Miniature Horses », en date du 5 janvier 1971, en y remplaçant, dans l'adresse du siège social dc la compagnie, le nom « Saint-Grégoire », par le nom.dc « Ville de Bécancour », dc manière que telle adresse se lise: Ville dc Bécancour, district judiciaire de Nicolet.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 38-71 Association Provinciale des Chevaux Miniatures Provincial Association of Miniature Horses Notice is given that under Part ni of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the letters patent of \"Association Provinciale des Chevaux Miniatures \u2014 Provincial Association of Miniature Horses\", bearing date January 5, 1971, by replacing in the head office address of the company the name \"Saint-Grégoire\", by the name of \"Ville de Bécancour\", in order that such address may be read: Town of Bécancour, judicial district of Nicolet.38940 Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38-71 Propane Gas Utilities (1970) Limited Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger les lettres patentes de fusion, en date du 31 décembre 1970, de la compagnie \" Propane Gas Utilities (1970) Limited », dc manière que le capital de ladite compagnie soit divisé en 150,000 actions ordinaires sans valeur au pair au lieu de 100,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38940-o 5598-70 Propane Gas Utilities (1970) Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives to correct the letters patent of amalgamation, bearing date December 31, 1970, of the company \"Propane Gas Utilities (1970) Limited\", in order that the capital of the said company be divided in 150,000 common shares without par value instead of 100,000 common shares without par value.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38940 5598-70 Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Municipalité de La Martre (Errata) Avis est donné par les soussignés que le lieutenant-gouverneur en conseil à adopté, en date du 27 janvier 1971, un arrêté en conseil ayant pour objet de changer le nom de la municipalité de Christie, comté de Gaspé-Oucst, en celui dc: « Municipalité de La Martre».Conformément à l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Sainte-Marthe, le 4 février 1971.\u2022 ' Le maire, Grégoire Tassé.Le secrétaire-trésorier, 38943-0 Louis-Marie Vallée.Municipality of La Martre (Errata) Notice is given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council adopted, on January 27, 1971, an Order in Council in order to change the name of the municipality of Christie, county of Gaspé-West, to that of : \"Municipality of La Martre\".In conformity with section 48 of the Municipal Code, this change of name comes into effect from and after the publication of this notice in the Québec Official Gazette.Ste-Marthe, February 4, 1971.Grégoire Tassé, Mayor.Louis-Marie Vallée, 38943-o Secretary-Treasurer. 2230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, ?i° 10 Ville de Saintc-Anne-dc-BellcMie Avis est donné que, par l'arrêté en conseil No 725 du 24 février 1971 et conformément à l'article 43 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193), il a plu au lieutenant-gouverneur C7i conseil d'approuver le règlement No 270 du conseil municipal de la ville de Sainte-Annc-de-Bellcvue et de décréter que, à compter de la date dc la publication du présent avis, le territoire mentionné audit règlement et décrit ci-dessous est détaché de la municipalité de la ville de Baie d'Urfé et annexé à la ville Sainte-Anne-de-Bellevue.Ce territoire est le suivant: Certains territoires faisant actuellement partie de la ville de Baie d'Urfé et comprenant en référence au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Anne, dans la division d'enregistrement de Montréal, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins ou parties d'iceux, le tout défini comme suit, à savoir: Premier lerriloire: Tout le territoire composé de la partie des lots 305, 310 et 311 située au nord dc la ligne médiane de la route Transcanadienne (i.e.ligne passant à mi-distance entre les deux chaussées principales) et limité au sud par ladite ligne médiane; Deuxième territoire: Tout le territoire composé de la partie des lots 318 à 326 inclusivement située au nord-ouest de la ligne médiane de la route Trans canadienne (i.e.ligne passant à mi-distance entre les deux chaussées principales) et limité au sud-est par ladite ligne médiane; Troisième territoire: Tout le territoire composé de la partie du lot 329 située au nord de la ligne médiane dc la route Transcanadienne (i.e.ligne passant à mi-distance entre les deux chaussées principales) et limité au sud par ladite ligne médiane; lesquels territoires sont détachés de la ville de Baie d'Urfé et annexés à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.Le sous-ministre des Affaires municipales, 3S943-o Richard Beaulieu.Ville dc Baie d'Urfé Avis est donné que, par l'arrêté en conseil No 726 du 24 février 1971 et conformément à l'article 43 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193), il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver le règlement No 445 du conseil municipal de la ville de Baie d'Urfé et de décréter que, à compter de la date de la publication du présent avis, le territoire mentionné audit règlement et décrit ci-dessous est détaché de la municipalité de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et annexé à la ville de Baie d'Urfé.Ce territoire est le suivant: Deux territoires faisant actuellement partie de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et comprenant en Town of Sainte-Anne-de-Bellevue Notice is given that, by Order in Council No.725 of February 24, 1971 and in accordance with section 43 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 1964, chapter 193), the Lieutenant-Governor in Council was pleased to approve by-law No.270 of the municipal council of the town of Sainte-Anne-dc-Bcllcvue and to decree that, from and after the date of publication of tlie present notice, the territory mentioned in the said by-law and described hereunder is detached from the municipality of the town of Baie d'Urfé and annexed to the town of Sainte-Anne-de-Bellevue.The territory is as follows: Certain territories which are now part of the town of Baie d'Urfé and comprising, with reference to the official cadastre of the parish of Sainte-Anne, in the Montreal Registration Division, the lots or parts of lots and their subdivisions present and future, as well as the roads or parts thereof, the whole defined as follows, to wit: First territory: The whole territory consisting of that part of lots 305, 310 and 311 situated north of the median line of the Trans-Canada Highway (i.e., the line which is midway between the two main lanes) and bounded on the south by the said median line; Second territory: The whole territory consisting of that part of lots 318 to 326 inclusive situated north-west of the median line of the Trans-Canada Highway (i.e., the line which is mid-way between the two main lanes) and bounded on the southeast by the said median line; Third territory: The whole territory consisting of that part of lot 329 situated north of the median line of the Trans-Canada Highway (i.e., the line winch is mid-way between the two main lanes) and bounded on the south by the said median line; the said territories are detached from the town of Baie d'Urfé and annexed to the town of Sainte-Annc-de-Bellevue.Richard Beaulieu, 38943 Deputy Minister of Municipal Affairs.Town of Baie d'Urfé Notice is given that on February 24, 1971, by Order in Council No.726 and in conformity with Section 43 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1964, Chapter 193), the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to approve by-law No.445 of the Municipal Council of the town of Baie d'Urfé and to decree that, from and after the date of the publictaion of this notice, the territory mentioned in the said by-law and hereunder described is detached from the municipality of the town of Sainte-Anne-de-Bellcvue and annexed to the town of Baie d'Urfé.This territory is the following: Two territories now forming part of the town of Sainte-Anne-de-Bellevue and.including in reference to QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2231 référence au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Anne, dans la division d'enregistrement de Montréal, les lots ou parties dc lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins ou parties d'iccux, le tout défini comme suit, à savoir: Premier territoire: Tout le territoire composé dc la partie du lot 63 située au sud-est dc la ligne médiane de la route Transcanadienne (i.e.ligne passant à mi-distance entre les deux chaussées principales) et limité au nord-ouest par ladite ligne médiane; Deuxième territoire: Tout le territoire composé du lot 343, d'une partie des lots 56, 57, 58-1, 5S et 62 et d'une partie de l'ancienne montée Sainte-Marie, situé au sud-est dc la ligne médiane de la route Transcanadienne (i.e.ligne passant à mi-distance entre les deux chaussées principales) et limité au nord-ouest par la ligne médiane de ladite route; lesquels territoires sont détachés de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et annexés à la ville de Baie d'Urfé.Le sous-minislre des Affaires municipales, 38943-0 Richard Beaulieu.the official cadastre of the parish of Sainte-Anne, in the registration division of Montreal, the lots or parts of lots and their subdivisions, present and future, as well as the roads or parts of these, the whole defined as follows, to wit: First territory: All the territory composed of the part of lot 63 situated southeast of the median line of the Trans Canadian Route (the line passing at mid-distance between both main lanes) and limited on the northwest by the said median line; Second territory: All the territory composed of lot 343, a part of lots 56, 57, 58-1, 58 and 62 and a part of former Montée Sainte-Marie, situated southeast of the median line of the Trans Canadian Route (the line passing at mid-distance between both main lanes) and limited on the northwest by the median line of the said route; such territories are detached from the town of Sainte-Anne-de-Bellevue and annexed to the town of Baie d'Urfé.Richard Beaulieu, 38943 Deputy Minister of Municipal Affairs.Proclamations Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.Proclamation Attendu que le conseil municipal de Stukely-Sud, comté de Shcfford, a soumis, pour approbation, son numéro 214, à l'effet de soumettre le.territoire de cette municipalité à la juridiction de la Cour municipale de la ville de Waterloo; Attendu que le conseil municipal de la ville de Waterloo, par son règlement numéro 330, a concouru dans la teneur dudit règlement adopté par le conseil municipal de Stukely-Sud; Attendu que, sous l'autorité de l'article 7 de la Loi des Cours municipales, (Statuts refondus, 1964, chapitre 24), le lieutenant-gouverneur en conseil a donné son approbation à ces règlements.À ces causes, de l'avis et du consentement de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 409, en date du 27 janvier 1971, et vu les dispositions des articles 693 à 697 de la Loi des cités et villes, (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), et des Proclamation s Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting:.Proclamation Whereas the municipal council of South Stukely, county of Shefford, submitted for approval its by-law No.214, for the purpose of submitting the territory of this municipality to the jurisdiction of the Municipal Court of the town of Waterloo; Whereas the municipal council of the town of Waterloo, by its by-law No.330, agreed to the terms of the said by-law adopted by the municipal council of South Stukely; Whereas, under section 7 of the Municipal Courts Act (Revised Statutes, 1964, chapter 24), the Lieutenant-Governor in Council gave his approval to these by-laws.Therefore, upon the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree bearing No.409, dated January 27, 1971, and in view of the provisions of sections 693 to 697 of the Cities and Towns Act (Revised Statutes, 1964, chapter 193), and of sections 2232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103- année, 7i° 10 articles 3 à 7 «le la Loi des Cours municipales, (Statuts refondus, 1964, chapitre 24), Nous avons décrété et décrétons qu'à compter de trente et un jours après la publication dc la présente proclamation dans la Gazelle officielle du Québec, le territoire de la municipalité de Stukely-Sud sera soumis à la juridiction dc la Cour municipale de la ville de Waterloo.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icclles apposer le grand sceau de Notre province dc Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., C.B., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-septième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante et onze dc l'ère chrétienne et de Notre Règne la dix-neuvième année.Par ordre.Lucien Darveau, 39041-o Sous-procureur général.Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut.Proclamation Attendu qu'en vertu de l'article 10 de la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts refondus, 1964, chapitre 319), il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, quand il le juge à propos, d'appliquer, par proclamation, les dispositions dc la section I dc cette loi à toute autre division d'enregistrement dc la province; Attendu Qu'il y a lieu d'appliquer lesdites dispositions législatives à la division d'enregistrement de Yamaska, à Saint-François du Lac, et de décréter l'émission d'une proclamation à cette fin.A ces causes, du consentement et dc l'avis dc Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 250, en date du 20 janvier 1971, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que les dispositions de la section I de la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts refondus, 1964, chapitre 319), s'appliquent à la division d'enregistrement de Yamaska, à Saint-François du Lac, à compter de la date de la publication de la proclamation dans la Gazette officielle du Québec.3 to 7 of the Municipal Courts Act(Revised Statutes, 1964, chapter 24), We have decreed and do hereby decree that from and after thirty-one days following the publication of this proclamation in the Québec Official Gazelle, the territory of the municipality of the South Stukely will be submitted to the jurisdiction of the Municipal Court of the town of Waterloo.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern arc hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of ' Québec, in Our Province of Québec, this twenty-seventh day of January in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-one and in the nineteenth year of Our Reign.By command.Lucien Darveau, 39041 Deputy Attorney General.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God.of the United Kingdom, Cannda and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas under Section 10 of the Registry Office Act (Revised Statutes, 1964, chapter 319), the Lieutenant-Governor in Council may, whenever he deems it expedient, extend, by proclamation, the provisions of Division 1 of this Act to any of the other registration divisions of the Province; Whereas it is deemed expedient to apply the said legislative provisions to the registration division of Yamaska, at St-Frunçois du Lac, and to decree that a proclamai ion be issued for such purpose.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 250, dated January 20, 1971, We have decreed and ordered and, hereby, decree and order that the provisions of section 1 of the Registry Office Act (Revised Statutes, 1964, chapter 319), apply to the registration division of Yamaska, at Saint-François du Lac, from and after the date of the publication of the proclamation in the Québec Official Gazette. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.108, No.10 2233 De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icellcs apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., en., lieutenant-gouverneur de Notre province dc Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingtième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante et onze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la dix-neuvième année.Par ordre.Lucien Darveau, 39041-o Sous-procureur général.Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur dc la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut.Proclamation Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts refondus, 1964, chapitre 319), il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, quand il le juge à propos, d'appliquer, par proclamation, les dispositions dc la section I dc cette loi à toute autre division d'enregistrement de la province; Attendu Qu'il y a lieu d'appliquer, lesdites dispositions législatives à la division d'enregistrement de Napiervillc, à Napierville, et de décréter l'émission d'une proclamation à cette fin.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 245, en date du 20 janvier 1971, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que les dispositions de la section I dc la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts refondus, 1964, chapitre 319), s'appliquent à la division d'enregistrement de Napierville, à Napierville, à compter de la date de la publication de la proclamation dans la Gazette officielle du Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take note and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twentieth day of January in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-one and in the nineteenth year of Our Reign.By command.Lucien Darveau, 39041 Deputy Attorney General.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, \u2022 Greeting.Proclamation Whereas pursuant to Section 10 of the Registry Office Act (Revised Statutes, 1964, chapter 319), the Lieutenant-Governor in Council may extend by proclamation, whenever he deems it expedient, the provisions of Division I of that Act to any other registration divisions of the Province; Whereas it is deemed expedient to apply the said legislative provisions to the registration division of Napierville, in Napierville, and to order that a proclamation be issued for such purpose.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 245 dated January 20, 1971, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order that the provisions of Division I of the Registry Office Act (Revised Statutes, 1964, chapter 319) apply to the registration division of Napierville, in Napierville, as of the date of publication of the proclamation in the Québec Official ' Gazette.Of all of which all Our loving subjects and all other.- whom these presents may concern are hereby required to take note and to govern themselves accordingly. 2234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville dc Québec, dc Notre province de Québec, ce vingtième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante et onze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la dix-neuvième année.i'ar ordre.Lucien Dahveau, 39041-o Sous-procureur général.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given in Our Parliament Building*,, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twentieth day of January in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-one and in the nineteenth year of Our Reign.By command.Lucien Darveau, 39041 Deputy Attorney General.Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.Proclamation Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts refondus, 1964, chapitre 319), il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, quand il le juge à propos, d'appliquer, par proclamation, les dispositions de la section I de cette loi à toute autre division d'enregistrement de la province; Attendu Qu'il y a lieu d'appliquer lesdites dispositions législatives à la division d'enregistrement de Maskinongé, à Louiseville, et de décréter l'émission d'une proclamation à cette fin.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 243, en date du 20 janvier 1971, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que les dispositions de la section I de la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts refondus, 1964, chapitre 319) s'appliquent à la division d'enregistrement dc Maskinongé, à Louiseville, à compter de la date de la publication de la proclamation dans la Gazette officielle dit Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas under Section 10 of the Registry Office Act (Revised Statutes, 1964, chapter 319), the Lieutenant-Governor in Council may, whenever he deems it expedient, extend, by proclamation, the provisions of Division I of this Act to any of the other registration divisions of the Province; Whereas it is deemed expedient to apply the said legislative provisions to the registration division of Maskinongé, at Louiseville, and to order that a proclamation be issued for such purpose; Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council expressed in a decree bearing number 243 dated January 20, 1971, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order that the provisions of Division I of the Registry Office Act (Revised Statutes, 1964, chapter 319) apply to the registration division of Maskinongé, at Louiseville, as of the date, of publication of the proclamation in the Québec Official Gazette.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take note and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2235 Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingtième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante et onze de l'ère chrétienne et dc Notre Règne la dix-neuvième année.Par ordre.Lucien Darveau, 39041-o Sovs-procureur général.Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur dc la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.Proclamation Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts refondus, 1964, chapitre 319), il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, quand il le juge à propos, d'appliquer, par proclamation, les dispositions de la section I de cette loi à toute autre division d'enregistrement de la province; Attendu Qu'il y a lieu d'appliquer lesdites dispositions législatives à la division d'enregistrement de Huntingdon, à Huntingdon, et de décréter l'émission d'une proclamation à cette fin.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 241, en date du 20 janvier 1971, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que les dispositions de la section I de la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts refondus, 1964, chapitre 319), s'appliquent à la division d'enregistrement de Huntingdon, à Huntingdon, à compter de la date de publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle du Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et dc se conduire en conséquence.En foi dè quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentés et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, 4e Notre province de Québec, ce Witness: Our Right-Trusty and WelhBeloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twentieth day of January in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-one and in the nineteenth year of Our Reign.By command.Lucien Darveau, 39041 Deputy Attorney General.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas pursuant to Section 10 of the Registry Office Act (Revised Statutes, 1964, chapter 319), the Lieutenant-Governor in Council may, whenever he deems it expedient, extend, by proclamation, the provisions of Division I of this Act to any of the other registration divisions of the Province; Whereas it is deemed expedient to apply the said legislative provisions to the registration division of Huntingdon, at Huntingdon, and to decree that a proclamation be issued for such purpose.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 241, dated January 20, 1971, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order that the provisions of Division I of the Registry Office Act (Revised Statutes, 1964, chapter 319), apply to the registration division of Huntingdon, at Huntingdon, from and after the date of the publication of this proclamation in the Québec Official Gazette.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take note and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twentieth 2236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 vingtième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante et onze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la dix-neuvième année.Par ordre.Lucien Darveau, 39041-o Sous-procureur général.Canada, Province de HUGUES LAPOINÏE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.Proclamation Attendu que la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (chapitre 51 des lois de 1969) sanctionnée le 13 juin 1969 doit, sous l'autorité de son article 102, entrer en vigueur à la date ou aux dates qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par une ou plusieurs proclamations; Attendu que les articles 45 et 47, l'article 48, à l'exception des paragraphes a), b), c), d) et/), ainsi que les articles 51, 52 et 57 de ladite loi ont été décrétés en vigueur par l'arrêté en conseil numéro 2160 du 23 juillet 1969, à compter du 2 août 1969, date de la publication dc la proclamation dans la Gazelle officielle du Québec; Attendu que les chapitres I, II et III, sauf l'alinéa /) de l'article 30, et les chapitres IV, V, VI et VII ainsi que les articles 58, 97, 98, 100 et 101 du chapitre VIII ont été décrétés en vigueur par l'arrêté en conseil numéro 123 du 14 janvier 1970, à compter du 3 février 1970, date dc la publication de la proclamation dans la Gazelle officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de rendre applicables certaines autres dispositions de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 770, en date du 24 février 1971, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes décrétons et ordonnons que les articles 59, 60 et 61 de ladite loi entrent en vigueur à compter de la date de la publiation de la présente proclamation dans la Gazelle officielle du Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., en., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.day of January in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-one and in the nineteenth year of Our Reign.By command.Lucien Darveau, 39041 Deputy Attorney General.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas the Manpower Vocational Training and Qualification Act (chapter 51 of the Statutes of 1969) assented to on June 13, 1969 shall, under section 102 thereof, come into force on the date or dates which the Lieutenant-Governor in Council shall be pleased to fix by one or more proclamations; Whereas sections 45 and 47, section 48 with the exception of paragraphs (a), (b), (c), ( nor more than 8J4%> payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1971.Table of redemption \u2014 SI,444,000 \u2014 20 years Year Capital April 1, 1972.$ 36,000 April 1,1973.37,000 April 1,1974 .39,000 April 1, 1975.41,000 April 1, 1976.42,000 April 1, 1977 .44,000 April 1, 1978.46,000 April 1,1979.49,000 April 1,1980 .53,000 April 1, 1981.58,000 April 1,1982 .39,000 April 1,1983.41,000 April 1,1984.45,000 April 1,1985.48,000 April 1, 1986 .52,000 April 1, 1987 .56,000 April 1,1988.59,000 April 1,1989.63,000 April 1,1990.68,000 April 1, 1991.528,000 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: 1.One- to 10-year serial bontls with the balance carried forward to the tenth year.2.One- to 15-ycar serial bonds with the balance «airried forward to the fifteenth year.3.One- to 10-year serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.4.One- to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten year for one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the latter terms and conditions, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $65,000, and if greater than the latter amount, said surplus must only comprise one or several complete annual amortizations, taking into account the tables of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the April 1*.2001 maturity of the renewable part hereinafter mentioned. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2243 Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril 1991 au montant dc S52S.000 comprend un solde de $454,000 renouvelable pour une période additionnelle dc 10 ans, et échéant comme suit: Année Capital 1er avril 1992.S 31,000 1er avril 1993.33,000 1er avril 1994 .36,000 1er avril 1995.39,000 1er avril 1996.42,000 1er avril 1997.45,000 1er avril 1998.50,000 1er avril 1999.54,000 1er avril 2000 .59,000 1er avril 2001.65,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé payable au pair à Dollard-des-Ormeaux.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont.le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à tcimc fixe 20 ans pour un montant supérieur à $528,000 et seul cet excédent sera rachctable par anticipation au pair le 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 33 \u2014 $113,500 \u2014 renouvellement «l'emprunt; 38 \u2014 $216,000 \u2014 renouvellement «l'emprunt; 39 \u2014 $53,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 190 \u2014 $16,500 \u2014 aqueduc et égouts; 216 (284) \u2014 $17,500 \u2014 aqueduc et égouts; 326 \u2014 $28,000 \u2014 aque-«luc, égouts et voirie; 337 \u2014 $10,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 340 \u2014 $12,000 \u2014 aqueduc, égouts, etc.; 349 (414) \u2014 $10,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 367 \u2014 $107,000 \u2014 services récréatifs et communautaires; 374 \u2014 $140,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 381 \u2014 $50,000 \u2014 électricité; 384 \u2014 $14,000 \u2014 voirie; 385 \u2014 $37,400 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 3S6 \u2014 $15,000 \u2014 aqueduc et égouts; 392 \u2014 $160,000 \u2014 aqueduc et égouts; 393 (411) \u2014 $82,000 \u2014 voirie; 394 \u2014 $21,000 \u2014 voirie et électricité; 395 \u2014 $4,500 \u2014 acquisition de lots; 396 \u2014 $180,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 400 \u2014 $36,000 \u2014 voirie; 406 \u2014 $100,100 \u2014 électricité; 433 \u2014 $20,000 \u2014 frais de refinancement.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The April 1,1991 maturity in the amount of $528,000 includes a balance of $454,000 renewable for an additional 10-year period and maturing as follows: Year Capital April 1, 1992.:.$ 31,000 April 1,1993.33,000 April 1,1994.36,000 April 1,1995.39,000 April 1,1996.42,000 April 1,1997.:.45,000 April 1, 1998.50,000 April 1, 1999 .54,000 April 1,2000.59,000 April 1,2001.65,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any by certified cheque payable at par at Dollard-des-Ormeaux.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued in part as 20-year fixed-term bonds for an amount higher than $528,000, and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, April 1st of each year, for the annual amount required to amortize the issue pursuant to the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certifieil cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 33 \u2014 $113,500 \u2014 loan renewal; 38 \u2014 $216,000 \u2014 loan renewal; 39 \u2014 $53,500 \u2014 loan renewal; 190 \u2014 aqueduct and sewers; 216 (284) \u2014 $17,500 \u2014 aqueduct and sewers; 326 \u2014 $28,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 337 \u2014 $10,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 340 \u2014 $12,000 \u2014 aqueduct, sewers, etc.; 349 (414) \u2014 $10,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 367 \u2014 $107,000 \u2014 recreational and communal services; 374 \u2014 $140,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 381 \u2014 $50,000 \u2014 electricity; 384 \u2014 $14,000 \u2014 roads; 385 \u2014 $37,400 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 386 \u2014 $15,000 \u2014 aqueduct and sewers; 392 \u2014 $160,000 \u2014 aqueduct and sewers; 393 (411) \u2014 $82,000 \u2014 roads; 394 \u2014 $21,000 \u2014 roads and electricity; 395 \u2014 $4,500 \u2014 purchase of lots of land \u2014 396 \u2014 $180,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 400 \u2014 $36,000 \u2014 roads; 406 \u2014 $100,100 \u2014 electricity, 433 \u2014 $20,000 \u2014 refinancing costs. 2244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, G mars 1971, 103\" année, n\" 10 Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 22 mars 1971, à S heures du soir, Poste de Police, 10, rue Sunnydalc, Dollard-des-Ormeaux, comté dc Robert Baldwin, P.Q.' Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Dollard-des-Ormeaux (Comté de Robert Baldwin), ce 25 février 1971.Le greffier, Mme Lillian L.Lamarciie.Hôtel de Ville, 4139, Boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux, (Robert Baldwin), P.Q.Téléphone: 6S4-1010, code 514.39004-o Lac Saint-Charles Comté de Québec Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription \" Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Normand Beaulieu, secrétaire-trésorier, jusqu'à 7 heures 30 du soir.Bureau dc la corporation, 17, Delage Est, Lac St-Charles, comté de Québec, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir, Centre des Loisirs, rue Delage Ouest, Lac St-Charles, comté de Québec, P.Q., jeudi, le 25 mars 1971, pour l'achat de 8500,000 d'obligations du Lac St-Charles, comté de Québec, datées du 1er avril 1971 et remboursables par série du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 734%.ni supérieur à 834%.payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1971.Tableau d'amortissement \u2014 8500,000 \u2014 S0 ans Année Capital 1er avril 1972.8 1,000 1er avril 1973.1,000 1er avril 1974.1,000 1er avril 1975 .2,000 1er avril 1976.2,000 1er avril 1977.2,000 1er avril 1978 .2,000 1er avril 1979.2,000 1er avril 1980.3,000 1er avril 1981.3,000 1er avril 1982.;.3,000 1er avril 1983.4,000 1er avril 1984.4,000 1er avril 1985.4,000 1er avril 1986.5,000 1er avril 1987.5,000 1er avril 1988.6,000 1er avril 1989.6,000 1er avril 1990.7,000 1er avril 1991.437,000 Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, March 22, 1971, at 8:00 o'clock p.m., at the Police Station, 10 Sunnydalc Street, Dollard-des-Ormeaux, county of Robert Baldwin, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Dollard-des-Ormeaux (County of Robert Baldwin), February 25, 1971.Mrs.Lillian L.Lamahciie, Town Clerk.Town Hall, 4139 des Sources Boulevard, Dollard-dcs-Ormeaux, (Robert Baldwin), P.Q.Telephone: 684-1010, code 514.39004 Lake St.Charles County of Québec Public notice is hereby given that scaled tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received up to 7:30 p.m., Thursday, March 25, 1971 by the undersigned Normand Beaulieu, Secretary-Treasurer, at the Office of the corporation, 17 Dclagc cast, Lake St-Charlcs, county of Québec, P.Q., and up to 8:00 p.m., Centre des Loisirs, Delage street west, Lake St-Charlcs, county of Québec, P.Q., on the same day for the purchase of S500,000 of bonds for Lake St-Charlcs, county of Québec, dated April 1, 1971 and redeemable serially from April 1, 1972 to April 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 734%.nor more than 834%.payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The interest rate may be the same for the whole issue; but if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from April 1, 1971.Table of redemption \u2014 $500,000 \u2014 20 years Year Capital April 1, 1972.$ 1,000 April 1, 1973.1,000 April 1, 1974.1,000 April 1, 1975.2,000 April 1, 1976.2,000 April 1, 1977.2,000 April 1, 1978.2,000 April 1,1979.2,000 April 1, 1980.3,000 April 1,1981.3,000 April 1, 1982.3,000 April 1, 1983.4,000 April 1, 1984.4,000 April 1,1985.'.x.4,000 April 1, 1986.,.5,000 April 1,1987 .5,000 April 1, 1988.6,000 April 1,1989 .6,000 April 1, 1990____.7,000 April 1, 1991.437,000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2245 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 ii 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, .pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à §45,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2011 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril 1991 au montant de $437,000 comprend un solde de $430,000 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans, et échéant comme suit: Année ¦ Capital 1er avril 1992.$ 8,000 1er avril 1993 .9,000 1er avril 1994.10,000 1er avril 1995.10,000 1er avril 1996.11,000 1er avril 1997.12,000 1er avril 1998.14,000 1er avril 1999.15,000 1er avril 2000.:.16,000 1er avril 2001.18,000 1er avril 2002.20,000 1er avril 2003 .21,000 1er avril 2004.24,000 1er avril 2005.:.26,000 1er avril 2006.28,000 1er avril 2007 .31,000 1er avril 2008.34,000 1er avril 2009.37,000 1er avril 2010.41,000 1er avril 2011.45,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Charlcsbourg.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $437,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er avril de chaque année pour le montant Moreover, only the following terms and conditions shall be considered: 1.One- to 10-year serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.Onc-to 15-year serial bonds with the balance carried over to the fifteenth year.3.One- to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One- to 10-year serial bonds with the balance carried over to the tenth year for one part and as 20-year fixed-term bonds for the other part.However, for the latter terms and conditions, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $45,000 and, if greater than the latter amount, the said part must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of April 1, 2011 of the renewable part hereafter mentioned.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The maturity date of April 1, 1991 in the amount of $437,000 includes a balance of $430,000 renewable for an additional period of 20 years, and.maturing as follows : Year Capital April 1, 1992.$ 8,000 April 1,1993____ .9,000 April 1,1994.10,000 April 1, 1995.10,000 April 1, 1996.11,000 April 1,1997.12,000 April 1, 1998.14,000 April 1,1999.15,000 April 1,2000.16,000 April 1,2001.18,000 April 1, 2002.20,000 April 1,2003.21,000 April 1,2004.24,000 April 1,2005.26,000 April 1,2006.28,000 April 1,2007 .31,000 April 1, 2008 .34,000 April 1,2009 .37,000 April 1,2010.41,000 April 1,2011.45,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Charlesbourg.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $437,000 and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par on April 1 of each year for the amount required to amortize the 2246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement no 56 \u2014 8500,000 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue jeudi, le 25 mars 1971, à 8 heures du soir, Centre des Loisirs, rue Delage Ouest, Lac St-Charles, comté de Québec, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Lac St-Charlcs (Comté de Québec), ce 24 février 1971.Le secrétaire-trésorier.Normand Beaulieu.Bureau de la corporation, 17, Delage Est, Lac St-Charles (Québec), P.Q.Téléphone! 849-3483, code 418.39005-o Ville dc L'Ancienne-Lorette Comté dc Chauveau Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Roland Bernard, greffier.Hôtel de ville, 1575, rue Tunnel, Ancienne-Lorelte, comté de Chauveau, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 23 mars 1971, pour l'achat de $77S,500 d'obligations de la ville de L'Ancienne-Lorette, comté de Chauveau, datées du 1er avril 1971 et remboursables par série du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 734%.ni supérieur à 834%, payable semi-annuellcmcnt les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1971.Tableau d'amortissement \u2014 8778,600 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1972.$ 7,500 1er avril 1973.7,000 1er avril 1974.8,000 1er avril 1975.8,000 1er avril 1976 .9,000 1er avril 1977 .9,000 1er avril 1978.10,000 1er avril 1979.11,000 1er avril 1980.12,000 1er avril 1981.14,000 1er avril 1982 .8,000 1er avril 1983.1.8,000 issue in accordance with the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amoimt of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: No.56 \u2014 8500,000 \u2014 aqueduct and sewers.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council which will be held on Thursday, March 25,1971, at 8:00 p.m.Centre des Loisirs, Delage Street West, Lake St-Charles, county of Québec, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Lake St-Charles (County of Québec), February 24, 1971.Normand Beaulieu, Secretary-Treasurer.Office of the corporation, 17 Delage east, Lake St-Charles (Québec), P.Q.Telephone: 849-3483, code 418.39005 Town of L'Ancicnne-Lorctte County of Chauveau Public notice is hereby given that sealed tenders Iwaring the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Roland Bernard, clerk, Town Hall, 1575 Tunnel Street, Ancienne-Ix>rette, county of Chauveau, P.Q., until 8:00 p.m., on Tuesday, March 23,1971, for the purchase of an issue of S778.5Ô0 of bonds for the town of L'Ancienne-Lorette, county of Chauveau, dated April 1, 1971 and redeemable serially from April 1, 1972 to April 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 734%, \"or more than 8J4%» payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from April 1, 1971.Table of redemption \u2014 8778,600 \u2014 20 years Year Capital April 1, 1972.8 7,500 April 1, 1973 .7,000 April 1, 1974.8,000 April 1,1975.8,000 April 1,1976.9,000 April 1, 1977.9,000 April 1,1978.10,000 April 1,1979.11,000 April 1,1980.12,000 April 1, 1981.14,000 April 1,1982 .8,000 April 1,1983.8,000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2247 1er avril 1984.$ 10,000 1er avril 1985.10,000 1er avril 1986.11,000 1er avril 1987.10,000 1er avril 1988.11,000 1er avril 1989.12,000 1er avril 1990.13,000 1er avril 1991.590,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2.Obligations échéant en série 1 à 15 uns avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $60,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2011 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril 1991 au montant de $590,000 comprend un solde de $576,000 renouvelable pour une période additionnelle dc 20 ans, et échéant comme suit: Année Capital 1er avril 1992.$10,000 1er avril 1993.12,000 1er avril 1994.13,000 1er avril 1995.14,000 1er avril 1996.15,000 1er avril 1997.17,000 1er avril 1998.18,000 1er avril 1999.20,000 1er avril 2000 .21,000 1er avril 2001.24,000 1er avril 2002 .26,000 1er avril 2003 .29,000 1er avril 2004 .32,000 1er avril 2005.\u2022.35,000 1er avril 2006.38,000 1er avril 2007.42,000 1er avril 2008 .46,000 1er avril 2009.50,000 1er avril 2010.54,000 1er avril 2011.60,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Québec.April 1, 1984.$ 10,000 April 1, 1985.10,000 April 1, 1986.11,000 April 1,1987.10,000 April 1,1988.11,000 April 1,1989.12,000 April 1,1990.13,000 April 1,1991.590,000 Moreover, on the following terms and conditions shall be considered: 1.One- to 10-year serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.One- to 15-ycar serial bonds with the balance carried over to the fifteenth year.3.One- to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One- to 10-year serial bonds with the balance carried over 10-year for one part and 20-ycar fixed-term bonds for the other part.However, for the latter terms and conditions, the 20-ycar fixed-term bonds shall not be for an amount less than $60,000, and if greater than the latter amount, the surplus must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the tables of maturities in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of April 1, 2011 of the renewable part hereafter indicated.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The April 1,1991 maturity in the amount of $590,000 includes a balance of $576,000 renewable for an additional period of 20 years, and maturing as follows: Year Capital April 1, 1992.$10,000 April 1, 1993.12,000 April 1,1994r.13,000 April 1, 1995.14,000 April 1,1996.15,000 April 1, 1997.17,000 April 1,1998.18,000 April 1,1999.20,000 April 1,2000 .21,000 April 1, 2001.24,000 April 1,2002.26,000 April 1,2003 .29,000 April 1,2004 .32,000 April 1,2005.35,000 April 1,2006.38,000 April 1, 2007 .42,000 April 1,2008.46,000 April 1,2009 .50,000 April 1,2010.54,000 April 1,2011.60,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Québec. 2248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $590,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: V-56 \u2014 $25,000 \u2014 fonds de roulement; V-68 \u2014 $28,000 \u2014 aqueduc, égouts; V-69 \u2014 $33,900 \u2014 voirie; V-70 \u2014 $6,300 \u2014 voirie; V-75 \u2014 $1,400 \u2014 voirie; V-76 \u2014 $144,400 \u2014 aqueduc, égouts; V-77 \u2014 $97,500 \u2014 aqueduc, égouts; V-79 \u2014 $20,700 \u2014 aqueduc, égouts; V-80 \u2014 $4,000 \u2014 aqueduc, égouts; V-85 \u2014 $15,000 \u2014 aqueduc, égouts; V-86 \u2014 $80,000 \u2014 aqueduc, égouts; V-8S \u2014 $297,300 \u2014 aqueduc, égouts; V-103 \u2014 $25,000 \u2014 achat d'un camion avec équipement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le 23 mars 1971, à 8 heures du soir, Hôtel de ville, 1575, rue Turmel, Ancienne-Lorettc, comté de Chauveau, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ancienne-Lorettc (Comté de Chauveau), ce 25 février 1971.Le greffier, Roland Bernard.Hôtel de ville, 1575, rue Turmel, Ancienne-Lorette (Comté de Chauveau), P.Q.Téléphone: 872-9811, code 418.39006-o ViUe de Saint-Bruno-de-Montarvillc Comté de Verchères Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Roland Coulombe, greffier, Hôtel de ville, 1585, rue Montarville, St-Bruno-de-Montarville, comté de Verchères, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 23 mars 1971, pour l'achat de $660,000 d'obligations de la ville de St-Bruno-de-Montarville, comté de Verchères, datées du 1er avril 1971 et remboursables en séries du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 734%, ni supérieur à 834%.payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $590,000, and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the amount required to amortize the issue in accordance with the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: V-56 \u2014 $25,000 \u2014 working capital; V-68 \u2014 $28,000 \u2014 aqueduct, sewers; V-69 \u2014 $33,900 \u2014 roads; V-70 \u2014 $6,300 \u2014 roads; V-75 \u2014 $1,400 \u2014 roads; V-76 \u2014 $144,400 \u2014 aqueduct, sewers; V-77 \u2014 $97,500 \u2014 aqueduct, sewers; V-79 \u2014 $20,700 \u2014 aqueduct, sewers; V-80 \u2014 $4,000 \u2014 aqueduct, sewers; V-85 \u2014 $15,000 \u2014 aqueduct, sewers; V-86 \u2014 $80,000 \u2014 aqueduct, sewers; V-88 \u2014 $297,300 \u2014 aqueduct, sewers; V-103 \u2014 $25,000 \u2014 purchase of a truck with equipment.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, March 23, 1971, at 8:00 p.m., at the Town Hall, 1575 Turmel Street, Ancienne-Lorette, county of Chauveau, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Ancienne-Lorettc (County of Chauveau), February 25, 1971.Roland Bernard, Clerk.Town Hall, 1575 Turmel Street, Ancienne-Lorette (County of Chauveau), P.Q.Telephone: 872-9811, code 418.39006 Town of Saint-Bruno-de-MontarvUle County of Verchères Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the unsersigned Roland Coulombe, Town Clerk, at the Town Hall, 1585 Montarville Street, St-Bruno-de-Montarville, county of Verchères, P.Q., up to 8:00 o'clock p.m., Tuesday, March 23, 1971, for the purchase of an issue of $660,000 of bonds for the town of Saint-Bruno-de-Montarville, county of Verchères, such bonds will be dated April 1, 1971 and redeemable serially from April 1, 1972 to April 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 734%> nor more than 834%, payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice. 1 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 Pour adjudication seulement l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1971.Tableau d'amortissement \u2014 $660,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1972.$13,000 1er avril 1973.13,000 1er avril 1974.15,000 1er avril 1975.17,000 1er avril 1976.18,000 1er avril 1977.19,000 1er avril 1978.22,000 1er avril 1979.23,000 1er avril 1980.26,000 1er avril 1981.28,000 1er avril 1982.30,000 1er avril 1983.33,000 1er avril 1984.36,000 1er avril 1985.¦ 40,000 1er avril 1986.43,000 1er avril 1987.48,000 1er avril 1988.52,000 1er avril 1989.56,000 1er avril 1990.61,000 1er avril 1991.67,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: ¦ 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $67,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Bruno.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $67,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis 2249 For adjudication only, interest will be calculated as from April 1, 1971.Table of rédemption \u2014 $660,000 \u2014 20 years Year Capital April 1, 1972.'.$13,000 April 1,1973.13,000 April 1, 1974.15,000 April 1,1975.17,000 April 1, 1976.18,000 April 1,1977.19,000 April 1, 1978.22,000 April 1, 1979.23,000 April 1, 1980.26,000 April 1, 1981.28,000 April 1,1982 .30,000 April 1,1983 .33,000 April 1,1984.36,000 April 1, 1985 .40,000 April 1,1986.43,000 April 1, 1987 .48,000 April 1,1988 .52,000 April 1,1989.56,000 April 1,1990.61,000 April 1, 1991.67,000 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: 1.One- to 10-year serial bonds with the.balance carried forward to the tenth year.2.One- to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.One- to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One- to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten year for one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the latter terms and conditions, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $67,000, and if greater than the latter amount, said surplus must only comprise one or several complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, exclusing the April 1, 1991 maturity.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay.for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Saint-Bruno.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount, greater than $67,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the annual amount required 2250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 600 \u2014 8130,000 \u2014 voirie, aqueduc, égouts, électricité; 629 \u2014 8152,200 \u2014 voirie, aqueduc, égouts, électricité; 631 \u2014 844,600 \u2014 voirie, aqueduc, égouts, électricité; 633 \u2014 847,000 \u2014 voirie, aqueduc, égouts, électricité; \u2014 641 \u2014 891,300 \u2014 voirie, égouts, aqueduc, électricité; 642 \u2014 S95.900 \u2014 voirie, aqueduc, égouts, électricité; 645 \u2014 $8,400 \u2014 électricité; 660 \u2014 $74,800 \u2014 voirie, aqueduc, égouts, électricité; 673 \u2014 $15,800 \u2014 voirie, aqueduc, égouts, électricité.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 23 mars 1971, à 8 heures du soir.Hôtel de ville, 1585, rue Montarville, St-Bruno-de-Montarville, comté de Verchères, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Bruno-de-Montarville, (Comté de Verchères), ce 24 février 1971.Le greffier, Roland Coulombe.Hôtel de ville, 1585, rue Montarville, St-Bruno-de-Montarville, (Comté de Verchères), P.Q.Téléphone: 653-2443, code 514.39007-o to amortize the issue, in accordance with the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 600 \u2014 $130,000 \u2014 roads, aqueduct, sewers electricity; 629 \u2014 $152,200 \u2014 roads, aqueduct, sewers, electricity; 631 \u2014 $44,600 \u2014 roads, aqueduct, sewers, electricity; 633 \u2014 $47,000 \u2014 roads, aqueduct, sewers, electricity; 641 \u2014 $91,300 \u2014 roads, sewers, aqueduct, electricity; 642 \u2014 $95,900 \u2014 roads, aqueduct, sewers, electricity; 645 \u2014 $8,400 \u2014 electricity; 660 \u2014 $74,800 \u2014 roads, aqueduct, sewers, electricity; 673 \u2014 $15,800 \u2014 roads, aqueduct, sewers, electricity.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, March 23, 1971, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 1585 Montarville Street, Saint-Bruno-de-Montarville, county of Verchères, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St-Bruno-de-Montarville (County of Verchères), February 24,1971.Roland Coulombe, Town Clerk.Town Hall, 1585 Montarville Street, St-Bruno-de-Montarville, (County of Verchères), P.Q.Telephone: 653-2443, code 514.39007 ViUe de La Providence Comté de Saint-Hyacinthe Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Dominique Dupont, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 370, rue St-Charles, La Providence, comté de St-Hyacinthe, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 22 mars 1971, pour l'achat de $161,000 d'obligations dc la ville de La Providence, comté de St-Hyacinthe, datées du 1er avril 1971 et remboursables en série du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 734%.ni supérieur à 834%.payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1971.Tableau d'amortissement \u2014 $161,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1972.$ 4,500 1er avril 1973.4,500 Town of La Providence County of Saint-Hyacinthe Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Dominique Dupont, Secretary-Treasurer, Town Hall, at 370 St-Charles Street, La Providence, county of St-Hyacinthe, P.Q., until 8:00 p.m., on Monday, March 22, 1971, for the purchase of an issue of $161,000 of bonds for the town of La Providence, county of St-Hyacinthe, dated April 1, 1971 and redeemable serially from April 1, 1972 to April 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 734%.nor more than 834%.payable semiannually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; but, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from April 1, 1971.Table of redemption \u2014 $161,000 \u2014 20 Years Year Capital Aprill, 1972.$ 4,500 Aprill, 1973.\u2022.4,500 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.108, No.10 2251 1er avril 1974.5,500 1er avril 1975.5,500 1er avril 1976.'.6,500 1er avril 1977.6,500 1er avril 1978.7,500 1er avril 1979.8,500 1er avril 1980.9,000 1er avril 19S1.10,000 1er avril 19S2.6,000 1er avril 1983.6,500 1er avril 1984.7,000 1er avril 1985.8,000 1er avril 1936.8,500 1er avril 1987.9,500 1er avril 1988.10,500 1er avril 19S9.11,000 1er avril 1990.12,500 1er avril 1991.13,500 Aprill, 1974.5,500 April 1, 1975.5,500 April 1, 1976.6,500 April 1, 1977.6,500 April 1, 1978.7,500 Aprill, 1979.8,500 April 1, 19S0.9,000 April 1, 1981.10,000 April 1, 1932.6,000 April 1, 1983.6,500 April 1, 1934.7,000 April 1, 19S5.8,000 April 1, 1936.8,500 April 1, 1987 .9,500 April 1, 19S8.10,500 April 1, 1939.11,000 April 1, 1990.12,500 April 1, 1991.13,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à S13.500, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Hyacinthe.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à S13.500, et seul cet excédent sera rachetablc par anticipation au pair le 1er avril dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Moreover, only the following terms and conditions shall be considered: 1.One- to 10-year serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.One- to 15-year serial bonds with the balance carried over to the fifteenth year.3.One- to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One- to 10-year serial bonds with the balance carried over 10-ycar for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, for the latter terms and conditions, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than S13.500, and if greater than the latter amount, the surplus must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the table of maturities appearing in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of April 1, 1991.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at St-Hyacinthe.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said, bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than S13,500, and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue in accordance with the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender. 2252 GAZETTE OFFICIELLE DV QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 505 \u2014 8130,000 \u2014 aqueduc, égouts, etc.; 503 \u2014 831,000 \u2014 achat d'équipement de voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 22 mars 1971, à 8 heures du soir, Hôtel de ville, 370, rue St-Charles, La Providence, comté de St-Hyacinthe, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.La Providence (Comté de St-Hyacinthe), ce 2 mars 1971.Le secrétaire-trésorier, Dominique Dupont.Hôtel de ville, 370, rue St-Charles, La Providence (St-Hyacinthe), P.Q.Téléphone: 773-0341, code 514.39053-o The said bonds will be issued pursuant to the 'following by-laws: 505 \u2014 8130,000 \u2014 aqueduct, sewers, etc.; 503 \u2014 $31,000 \u2014 purchase of road equipment.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, March 22, 1971, at 8:00 p.m., at the Town Hall, 370 St-Charles Street, La Providence, county of St-Hyacinthe, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.La Providence (County of St-Hyacinthe), March 2, 1971.Dominique Dupont, Secretary-Treasurer.Town Hall, 370 St-Charles Street, La Providence (St-Hyacinthe), P.Q.Telephone : 773-0341, code 514.39053 Paroisse dc Saint-Annc-dc-Sorcl Comté de Richelieu Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Peter S.White, secrétaire-trésorier, jusqu'à 4.30 heures de l'après-midi, bureau du secrétaire-trésorier, 748, Chenal-du-Moine, Ste-Anne-de-Sorel, cemté dc Richelieu, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir, salle du conseil, Stc-Ânne-de-Sorel, comté de Richelieu, P.Q., mercredi, le 24 mars 1971, pour l'achat de $98,000 d'obligations de la paroisse dc Ste-Anne-de-Sorel, comté de Richelieu, datées du 1er avril 1971 et remboursables par série du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 734%, ni supérieur à 834%.payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que mentré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1971.Tableau d'amortissement \u2014 S98.000 \u2014 SO ans Année Capital 1er avril 1972.$ 1,000 1er avril 1973.1,000 1er avril 1974.,.1,000 1er avril 1975.1,000 1er avril 1976.1,000 1er avril 1977.1,000 1er avril 1978.1,000 1er avril 1979.1,000 1er avril 1980.1,000 1er avril 1981.1,000 1er avril 1982.1,500 1er avril 1983.1,500 1er avril 1984.1,500 1er avril 1985.1,500 1er avril 1986.1,500 1er avril 1987.1,500 1er avril 1988.2,000 Parish of Sainte-Aniic-de-Sorel County of Richelieu Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Peter S.White, Secretary-Treasurer, up to 4:30 o'clock p.m., at the Office of the Secretary-Treasurer, 748 Chcnal-du-Moinc, Stc-Anne-de-Sorel, county of Richelieu, P.Q., and afterwards up to 8:00 p.m., àt the Council Hall, Ste-Anne-de-Sorel, county of Richelieu, P.Q., Wednesday, March 24, 1971, for the purchase of an issue of $98,000 of bonds for the parish of Stc-Annc-dc-Sorel, county of Richelieu, P.Q., such bonds will be date April 1, 1971 and redeemable serially from April 1, 1972 to April 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 734%.nor more than 834%.payable semi-annually on April 1st, and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tables of redemption in the present notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from Aprill, 1971.Table of redemption \u2014 $98,000 \u2014 SO years Year Capital April 1, 1972.$ 1,000 April 1, 1973.1,000 April 1, 1974.1,000 April 1, 1975.1,000 April 1, 1976.1,000 Aprill, 1977.1,000 April 1, 1978.1,000 April 1, 1979. having its head office in the city and district of Montreal, plaintiff, vs ABACA INC., a corporation legally constituted, having its head office 2264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 social à Chambly, district de Montréal, et PLACE CHAMBLY LTEE, une corporation légalement constituée, ayant son siège social à Montréal, district de Montréal, défenderesses.« Ce certain emplacement situé en ladite cité de Chambly composé du lot de resubdivision numéro un du lot de subdivision numéro cent trente-quatre du lot originaire numéro cent quinze (115-134-1) aux plan et livre de renvoi officiels du village de Chambly Bassin, et le lot de subdivision numéro cent trente-six dudit lot originaire (115-136) audit plan officiel, avec la bâtisse dessus érigée et portant le numéro civique 1221 Grand Boulevard, en la cité de Chambly.Ensemble avec le droit de passage à pied et en voitures, en commun avec tous les autres y ayant droit dans, sur et par-dessus une lisière de terrain adjacente au côté nord-ouest dudit emplacement, ladite lisière de terrain mesurant sept pieds et soixante-douze centièmes (7.72') de largeur sur sa ligne de côté nord-est, sept pieds et quatre-vingt-cinq centièmes (7.85') sur sa ligne de côté sud-ouest, sur une profondeur de soixante-deux pieds et un dixième (62.1') et étant bornée d'un côté au sud-est par l'emplacement ci-dessus décrit à une extrémité au nord-est par une partie du lot de subdivision numéro cent trente-quatre dudit lot originaire (115-134), d'un côté au nord-ouest partiellement par une autre partie dudit numéro 115-134 et partiellement par une partie non-subdiviséc dudit lot originaire numéro cent quinze (Plie 115) et à l'autre extrémité au sud-ouest par une autre partie non-subdivisée dudit lot numéro cent quinze (Ptic 115) (formant partie du droit de passage ci-après décrit au paragraphe suivant).Et ensemble avec le droit de passage ou chemin en commun avec tous les autres y ayant droit, à pied et en voitures, dans, sur et par-dessus une lisière de terrain sur la façade dudit emplacement et comprenant deux parties dudit lot originaire numéro cent quinze (Pties 115) et ayant la forme de la lettre L, et ayant pour but de permettre d'accéder au Grand Boulevard et d'en sortir.Une partie dudit lot numéro cent quinze (115) formant partie dudit droit de passage mesure cent cinquante pieds (150') sur chacune de ses lignes nord-est et sud-ouest sur vingt-six pieds et neuf dixièmes sur chacune de ses lignes nord-ouest et sud-est, et elle est bornée d'un côté au nord-est par la ligne limite sud-ouest dudit lot numéro 115-136 et la projection d'icelle en ligne droite dans une direction sud-est et nord-ouest; à une extrémité au sud-est par une partie de la ligne de côté nord-ouest du lot 117-66 audit cadastre, de l'autre côté au sud-ouest par la ligne de côté nord-est du lot numéro 115-133 audit cadastre et la projection d'icelle en ligne droite, dans une direction nord-ouest, et à l'autre extrémité au nord-ouest par une autre partie dudit lot numéro 115.L'autre partie dudit lot numéro 115 formant partie dudit droit de passage mesure deux cent six pieds (206') sur chacune de ses lignes des côtés nord-ouest et sud-est et vingt pieds (20') sur chacune de ses lignes des côtés nord-est et sud-ouest et elle est bornée à une at Chambly, district of Montreal, and PLACE CHAMBLY LTÉE, a corporation legally constituted, having its head office at Montreal, district of Montreal, defendants.\"That certain emplacement situated in the said city of Chambly, composed of resubdivision lot number one of subdivision lot number one hundred and thirty-four of original lot number one hundred and fifteen (115-134-1) on the official plan and book of reference of the village of Chambly Bassin, and subdivision lot number one hundred and thirty-six of said original lot (115-136) on said official plan, with the building thereon erected and bearing civic number 1221 Grand Boule-bard, in the city of Chambly.Together with the right of passage on foot and with vehicles in common with all others having rights therein, in, over an upon a strip of land adjacent to the northwest side of said emplacement measuring said strip of land seven feet, and seventy-two hundredths of a foot (7.72') in width in its northeast side line, seven feet and eighty-five hundredths of a foot (7.85') in its southwest side line, by a depth of sixty-two feet and one tenth of a foot (62.1') and being bounded on one side to the southeast by the emplacement hereinabove described at one end to the northeast by part of subdivision lot number one hundred and thirty-four of said original lot (115-134) on one side to the northwest partly by another part of said lot number 115-134 and partly by an unsubdivided part of said original lot number one hundred and fifteen (Pt.115) and at the other end to the southwest by another unsubdivided part of said lot number one hundred and fifteen (Pt.115) (being part of the right-of-way hereinafter described in the following paragraph).And together with the right of way or passage in common with all others having rights therein on foot and with vehicles, in, over and upon a strip of land fronting said emplacement and comprising two parts of said original lot number one hundred and fifteen (Pt.115) and being L-shaped, and intented to permit access to and from Grand Boulevard.One part of said lot number one hundred and fifteen (115) forming part of said right-of-way measures one hundred and fifty feet (150') in each of its northeast and southwest lines by twenty-six feet and ninetenths of a foot in each of its northwest and southeast lines, and is bounded on one side to the northeast by the southwest boundary line of said lot number 115-136 and the projection thereof in a straight line in a southeasterly and north westerly direction; at one end to the southeast by part of the northwest side line of lot 117-66 of said cadastre, on the other side to the southwest by the northeast side line of lot number 115-133 of the said cadastre and the projection thereof in a straight line in a northwesterly direction, and at the other end to the northwest by another part of said lot number 115.The other part of said lot number 115 forming part of said right-of-way measures two hundred and six feet (206') in each of its northwest and southeast side line, and twenty feet (20') in each of its northeast and southwest side lines and it is bounded at one end to the north- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.108, No.10 2265 extrémité au nord-est par cette portion dudit droit de passage décrite au paragraphe immédiatement précédent, d'un côté au sud-est par autre partie dudit lot numéro 115 appartenant au gouvernement du Canada (bureau des postes) à l'autre extrémité au sud-ouest par le Grand Boulevard et de l'autre côté au nord-ouest, partiellement par le lot numéro 115-135 dudit cadastre et partiellement par une autre partie dudit lot numéro cent quinze (Ptie 115).Et également ensemble avec un droit de chemin ou de passage, en commun avec tous les autres y ayant droit, à pied et en voitures dans, par-dessus et sur une pièce triangulaire dc terrain formant le coin est du lot de subdivision numéro cent trente-trois dudit lot originaire numéro cent quinze (115-E.coin 133) audit plan officiel, ladite pièce de terrain mesurant vingt-cinq pieds (25') sur sa ligne sud-est, soixante pieds (60') sur sa ligne nord-est et soixante-cinq pieds (65') sur sa ligne sud-ouest; et étant bornée au nord-est par la portion dudit droit de passage décrite au paragraphe qui précède le paragraphe immédiatement précédent, d'un côté au sud-est par ledit lot numéro 117-66 et de l'autre côté au sud-ouest par le résidu dudit lot numéro 115-133 (bureau des postes).Toutes les dimensions ci-dessus sont de mesure anglaise et plus ou moins.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Longueuil, 201 Place Charles Lemoyne, Longueuil, le HUITIÈME jour d'AVRIL 1971, a ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 25 février 1971.39051 east by that portion of said right-of-way described in the immediately preceeding paragraph, on one side to the southeast by another part of said lot number 115 belonging to the Government of Canada (Post Office) at the other end to the southwest by Grand Boulevard, and on the other side to the northwest partly by lot number 115-135 of said cadastre and partly by another part of said lot number one hundred and fifteen (P.115).And also together with a right-of-way or passage in common with all others having rights therein on foot and with vehicles in, over and upon a triangular piece of land forming the easterly corner of subdivision lot number one hundred and thirty-three of said original lot number one hundred .and fifteen (115-E.cor.133) on said official plan, measuring said piece of land twenty-five feet (25') in its southeast line, sixty-feet (60') in its northeast line, and sixty-five feet (65') in its southwest line, and being bounded to the northeast by the portion of said right-of-way described in the paragraph preceeding the immediately preceeding paragraph, on one side to the southeast by said lot number 117-66 and the other side to the southwest by the remainder of said lot number 115-133 (Post Office).All the above measurements are english measure and more or less\".To be sold at the registry office of Longueuil, 201 Charles Lemoyne Place, Longueuil, the EIGHTH day of APRIL, 1971, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, February 25, 1971.39051-o Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( /\"GORDON W.LIGHTSTONE, admi-No 793 852.< *J nistrateur, de la ville de Laval, t district de Montréal, y résidant et domicilié à Bellèrive Acres, édifice 3, appartemant 1107, demandeur, contre JOHN PERT, agent immobilier, résidant et domicilié au 582, rue Vachon, dans la ville de LaSalle, district de Montréal, défendeur.« Un certain emplacement donnant sur l'avenue Vachon, dans la ville de LaSalle, connu et désigné comme étant le lot numéro trois cent vingt-deux de la subdivision du lot original numéro neuf cent quatre-vingt-treize (993-322) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Lachine, mesurant 55 pieds de largeur sur 79.45 pieds de profondeur, mesures anglaises et plus ou moins, avec la bâtisse y érigée portant le numéro 582, avenue Vachon.Sous réserve d'une servitude en faveur de la compagnie de Téléphone Bell du Canada, telle qu'établie en vertu des clauses d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement de Montréal, sous le numéro 1301964.Telle que ladite propriété existe présentement, avec tous ses droits, membres et appartenances, sans exception ou réserve d'aucune sorte.»\u2022 Pour être vendu au bureau du protonotaire, chambre #129, au Vieux Palais de Justice, dans la ville de Mont- Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal C CORDON W.LIGHTSTONE, execu-No.793 852.< tive, of the city of Laval, district v of Montreal, residing and domiciled therein at Bellerive Acres, Building 3, Apartment 1107, plaintiff, versus JOHN FERT, realtor, residing and domiciled at 582 Vachon Street, in the city of LaSalle, district of Montreal, defendant.\"That certain emplacement fronting on Vachon Avenue, in the city of LaSalle, known and deisgnated as lot number three hundred and twenty-two of the subdivision of original lot number nine hundred and ninety-three (993-322) on the official plan and book of reference of the parish of Lachine, measuring 55 feet in width by 79.45 feet in depth, English measure and more or less, with the building thereon erected bearing civic number 582 Vachon Avenue.Subject to a servitude in favour of the Bell Telephone Company of Canada as established under the terms of a deed registered at the Montreal Registry Office under number 1301964.As the said property now subsists, together with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind.To be sold at the the Prothonotary's Office, Room #129, in the Old Court House, in the city of Montreal, 2266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 réal, le HUITIÈME jour d'AVRIL 1971, à ONZE heures du matin.Bureau du Shérif, Le shérif ajdoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 25 février 1971.39048 the EIGHTH day of APRIL 1971, at ELEVEN o'clock in the morning.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, February 25, 1971.39048-o Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District dc Montréal ( T> ENAUD GAUDET, professeur, ré-No 800-436.< iV sidant au no 5345, rue Marquis, t Saint-Léonard, district de Montréal, demandeur, contre ABRAHAM STERNTHAL, gentilhomme, résidant au no 56S5, rue Edgcmorc, à Montréal, district de Montréal, défendeur.Premièrement > « Un emplacement donnant sur la rue Poupart, dans la ville de Montréal, mesurant soixante-cinq pieds et cinq dixièmes de pied de largeur sur une profondeur de quatre-vingt-deux pieds, mesures anglaises, plus ou moins, et comprenant: (a) les lots de terre connus et désignés sous les numéros quarante et un et quarante-deux de la subdivision officielle du lot original numéro mille trois cent soixante-trois (1363-41 et 42), aux plan et livre de renvoi officiels du quartier Sainte-Marie, mesurant chacun trente pieds de largeur sur une profondeur de quatre-vingt-deux pieds; (b) la partie sud-est du lot dc terre connu désigné sous le numéro quarante de la subdivision officielle dudit lot original numéro mille trois cent soixante-trois (1363-p.s.-e.-40), mesurant, ladite partie, cinq pieds et cinq dixièmes de pied dc largeur sur une profondeur de quatre-vingt-deux pieds, et bornée comme suit: en avant, au sud-ouest, par ladite rue Poupart; à l'arrière, au nord-est, par une ruelle connue et désignée sous le numéro 1363-58; d'un côté, au sud-est, par ledit lot numéro 1363-41; et dc l'autre côté, au nord-ouest, par le résidu ou la partie nord-ouest dudit lot numéro 1363-40, le tout du même cadastre.Avec les bâtisses dessus construites et portant les numéros 1667 au 1683 inclusivement de ladite rue Poupart, et dont le mur nord-ouest est mitoyen sur une longueur dc trente-deux pieds et six pouces.Deuxièmement Un emplacement donnant sur la rue Poupart, dans la ville de Montréal, mesurant quatre-vingt-quatre pieds et cinq dixièmes dc pied de largeur, sur une profondeur de quatre-vingt-deux pieds, mesures anglaises, plus ou moins, et comprenant: (a) les lots de terre connus et désignés sous les numéros trente-huit et trente-neuf de la subdivision officielle du lot original numéro mille trois cent soixante-trois (1363-38 et 39), aux plan et livre de renvoi officiels du quartier Sainte-Marie, mesurant, chacun desdits lots, trente pieds de largeur sur une profondeur de quatre-vingt-deux pieds; (b) la partie nord-ouest du lot de terre connu et désigné sous le numéro quarante de la subdivision officielle du lot original numéro mille trois cent soixante-trois (1363-p.n.-o.-40), mesurant, ladite partie, vingt- Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal C \"D ENAUD GAUDET, teacher, res-No.800-436X iding at No.5345 Marquis St., V St-Léonard, district of Montreal, plaintiff, vs ABRAHAM STERNTHAL, gentleman, residing at No.5685 Edgemore St., at Montreal, district of Montreal, defendant.Firstly \"An emplacement fronting on Poupart Street, in the city of Montreal, measuring sixty-five feet and five-tenths of a foot in width by a depth of eighty-two feet, English measure, more or less, and composed : (a) Of the lots of land known and designated under the numbers forty-one and forty-two of the official subdivision of the original lot number one thousand three hundred and sixty-three (1363-41 and 42), on the official plan and in the book of reference of St.Mary's Ward, measuring each of said lots thirty feet in width by a depth of eighty-two feet; (b) Of the southeast part of the lot of land known and designated under the number forty of the official subdivision of said original lot number one thousand three hundred and sixty-three (1363-pt.s-e.-40), measuring said part five feet and five-tenths of a foot in width by a depth of eighty-two feet, and bounded as follows; in front, to the southwest, by said Poupart Street; in rear, to the northeast, by a lane known and designated under number 1363-58; on one side, to the southeast, by the said lot number 1363-41; and on the other side, to the northwest, by the residue or northwest part of the said lot number 1363-40, all of the same cadastre.With the buildings thereon erected and bearing the civic numbers 1667 to 1683 inclusive of the said Poupart Street, where of the northwest wall is mitoyen by a length of thirty-two feet and six inches.Secondly An emplacement fronting on Poupart Street, in the city of Montreal, measuring eighty-four feet and five-tenths of a foot in width by a depth of eighty-two feet, English measure, more or less, and composed: (a) Of the lots of lend known and designated under the numbers thirty-eight and thirty-nine of the official subdivision of the original lot number one thousand three hundred and sixty-three (1363-38 and 39), on the official plan and the book of reference of St.Mary's Ward, measuring, each of said lots thirty feet in width by a depth of eighty-two feet; (6) Of the northwest part of the lot of land known and designated under the number forty of the official subdivision of the original lot number one thousand three hundred and sixty-three (1363-pt.n.w.-40), QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2267 quatre pieds et cinq dixièmes de pied de largeur sur une profondeur de quatre-vingt-deux pieds, et _ borné comme suit: en avant, au sud-ouest, par ladite rue Poupart; à l'arrière, au nord-est, par une ruelle portant le numéro 1363-58; d'un côté, au sud-est, par le résidu ou la partie sud-est dudit lot numéro 1363-40; et de l'autre côté, au nord-ouest, par ledit lot numéro 1363-39, le tout du même cadastre.Avec les bâtisses y érigées, portant les numéros 1685 à 1707 inclusivement de ladite rue Poupart, et dont les niurs latéraux sont mitoyens sur une longueur de trente-deux pieds et six pouces.Troisièmement Un emplacement donnant sur la rue Poupart, dans la ville dc Montréal, mesurant soixante-deux pieds et cinq dixièmes de pied de largeur sur une profondeur de quatre-vingt-deux pieds, mesures anglaises, plus ou moins, et comprenant: (o) les lots de terre connus et désignés sous les numéros trente-six et trente-sept de la subdivision officielle du lot original mille trois cent soixante-trois (1363-36 et 37) aux plan et livre de renvoi officiels du quartier Sainte-Marie, mesurant, ledit lot no 1363-36, trente et un pieds de largeur en front, trente et un pieds et cinq dixièmes de pied de largeur à l'arrière, sur une profondeur de quatre-vingt-deux pieds, et ledit lot no 1363-37, trente pieds de largeur sur une profondeur de quatre-vingt-deux pieds; (6) le lot de terre connu et désigné sous le numéro un de la redivisiou de lot numéro quarante-quatre du lot original numéro mille trois cent soixante-deux (1362-44-1), aux plan et livre de renvoi officiels du quartier Sainte-Marie, mesurant un pied et cinq dixièmes de pied de largeur sur une profondeur de soixante-douze pieds et cinq dixièmes de pied.Avec les bâtisses y érigées et portant les numéros 1709 à 1725 inclusivement de ladite rue Poupart, et dont le mur sud-est est mitoyen sur une longueur de trente-deux pieds et six pouces.Telles que lesdites propriétés existent présentement, avec tous leurs droits, membres et appartenances, sans exception ou réserve et avec et sous réserve de toutes les servitudes, actives et passives, apparentes ou non apparentes, qui s'y rattachent.» Pour être vendus séparément au bureau du protonotaire, chambre #129, au Vieux Palais de Justice, dans la ville de Montréal, le SEPTIÈME jour d'AVRIL 1971, à ONZE heures du matin.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 25 février 1971.39046 measuring said part twenty-four feet and five-tenths of a foot in width by a depth of eighty-two feet, and bounded as follows; in front, to the southwest, by said Poupart Street; in rear, to the northeast, by a lane bearing number 1363-58; on one side, to the southeast, by the residue or southeast part of said lot number 1363-40; and on the other side, to the northwest, by said lot number 1363-39, all of the same cadastre.With the buildings thereon erected and bearing the civic number 1685 to 1707 inclusive of said Poupart Street, whereof the lateral walls arc mitoyen by a length of thirty-two feet and six inches.Thirdly An emplacement fronting on Poupart Street, in the city of Mpntreal, measuring sixty-two feet and five-tenths of a foot in width by a depth of eighty-two feet, English measure, more or less, and composed : (o) Of the lots of land known and designated under the numbers thirty-six and thirty-seven of the official subdivision of the original lot number one thousand three hundred and sixty-three (1363-36 and 37), on the official plan and in the book of reference of St.Mary's Ward, measuring said lot number 1363-36 thirty-one feet in width in front, thirty-one feet and five-tenths of a foot in width in rear, by a depth of eighty-two feet, and said lot number 1363-37, thirty feet in width by a depth of eighty-two feet; (6) Of the lot of land known and designated under the number one of the resubdivision of the lot number forty-four of the original lot number one thousand three hundred and sixty-two (1362-44-1), on the official plan and in the book of reference of St.Mary's Ward, measuring one foot and five-tenths of a foot in width by a depth of seventy-two feet and five-tenths of a foot.With the buildings thereon erected and bearing the civic number 1709 to 1725 inclusive of said Poupart Street, whereof the southeast wall is mitoyen by a lenght of thirty-two feet and six-inches.As the said properties now subsist, with all their rigths, members and appurtenances, without exception or reserve, and with and subject to all servitudes, active and passive, apparent or unapparent, attached thereto.' To be sold separately at the Prothonotary's Office, Room #129, at the Old Court House, in the city jf Montreal, the SEVENTH day of APRIL 1971, at ELEVEN o'clock in the morning.Sheriff \"s Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant-Sheriff.Montreal, February 25th, 1971.39046-0 PONTIAC Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Pontiac ( TîELMONT ELECTRICAL SUP-No 7216.s -D PLIES LTD., compagnie ayant v son siège social et sa principale place PONTIAC Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Pontiac C TJELMONT ELECTRICAL SUP-No.7216.< y PLIES LTD., a corporation having V its head office and principal place of 2268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 d'affaires dans la ville de Pembrooke, province d'Ontario, demanderesse, «s ARTHUR MARCOTTE, du village de Chapeau, district de Pontiac, défendeur.< Village de Chapeau, lot 154-C, aux plan et livre de renvoi officiels dudit village de Chapeau, membres et appartenances s'y rattachant; Village de Chapeau, lot 155, moins cette partie décrite comme étant la partie est vendue par Arthur Marcotte à Bella Ranger-Fitzpatrick par acte passé le 23e jour de mars 1968 et enregistré le même jour sous le numéro 81829.» Pour être vendu au bureau du régistraire du comté de Pontiac, à Campbell's Bay, Québec, MARDI, le SIXIÈME jour d'AVRIL 1971, à DIX heures du matin.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Mme Georgette Spence.Campbell's Bay, Québec, le 25 février 1971.39092 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( T> TANGUAY AUTOMOBI-Cour Supérieure, ) LES LTÉE, corporation No 3364.) légalement constituée ayant un ' bureau d'affaires au 89, route Kennedy, Lévis, district de Québec, vs JEAN-PAUL ROBERGE, résidant à 252, Royale, St-Pierre, Ile d'Orléans, district de Québec.« Un emplacement situé en la paroisse de St-Pierre, Ile d'Orléans, connu et désigné comme étant une partie du lot vingt-cinq (25 Ptie) du cadastre officiel pour la paroisse St-Pierre, Ile d'Orléans, comté de Montmorency, borné au nord par le chemin public, à l'est par la propriété de monsieur Joseph Pichette ou représentants, au sud à l'ouest par d'autres parties du même lot 25, propriété de monsieur Alexandre Roberge; cet emplacement mesurant cent vingt-cinq pieds (125') en front le long du chemin public par une profondeur de deux cents pieds du cûté est, c'est-à-dire jusqu'au fossé se trouvant au bout de cette profondeur, le long de la propriété de monsieur Joseph Pichette et deux cent cinquante pieds (250') du côté ouest c'est-à-dire le long de la partie de ce même lot restant la propriété du vendeur, moins une partie vendue par la suite par M.Jean-Paul Roberge au ministère de la Voirie en date du 6 février 1970, et enregistré le 16 février 1970, sous le numéro 19,304, mesurant mille cent vingt-cinq pieds carrés plus ou moins en superficie, mesure anglaise, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dép-pendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de l'Ile d'Orléans, à 1286, avenue Royale, St-Laurent, Ile d'Orléans, comté de Montmorency, le SEPTIÈME jour d'AVRIL 1971, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 2 mars 1971.39037-o business in the town of Pembrooke, Province of Ontario, plaintiff, vs ARTHUR MARCOTTE, of the village of Chapeau, district of Pontiac, defendant.\"Village of Chapeau, lot 154-C, according to the official plan and book of reference for the said village of Chapeau, together with members and appurtenances thereto belonging; Village of Chapeau, lot 155, less that part being described as the east part sold by Arthur Marcotte to Bella Ranger-Fitzpatrick by deed executed on the 23rd of March 1968 and registered on the same date under number 81829.\" To be sold at the registrar's office for the county of Pontiac, in Campbell's Bay, P.Q., on TUESDAY, the SIXTH day of APRIL, 1971, at TEN o'clock in the the forenoon.Mrs.Georgette Spence, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Campbell's Bay, P.Q., February 25, 1971.39092-o QUÉBEC Fieri Facias De Terris Québec, to wit: ( T3 TANGUAY AUTOMOBILES Superior Court, ) LTÉE, a corporation legal- No.3364.j ly incorporated having a place of (.business at 89 Kennedy Route, Levis, district of Québec, vs JEAN-PAUL ROBERGE, residing at 252 Royale, St-Pierre, Island of Orléans, district of Québec.\"An emplacement situated in the parish of St-Pierre, Island of Orléans, known and designated as forming a part of lot twenty-five (P.25) of the official cadastre for the parish of St-Pierre, Island of Orléans, county of Montmorency, bounded on the north by the public road, on the east by the property of Mr.Joseph Pichette or representatives, on the south and west by other parts of the same lot 25, property of Mr.Alexandre Roberge; this emplacement measuring one hundred and twenty-five feet (125') in front along the public road by a depth of two hundred feet on the east side, that is to say, to the ditch existing at the end of this depth, along the property of Mr .Joseph Pichette and two hundred and fifty feet (250') on the west side, that is to say, along the part of this same lot remaining the property of the vendor, less a part later sold by Mr.Jean-Paul Roberge to the Department of Roads on February 6, 1970, and registered on February 16, 1970, under number 19,304, measuring one thousand one hundred and twenty-five square feet, more or less in area, English measure, with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold at the Registry Office of the Island of Orléans, at 1286 Royale Avenue, St-Laurent, Island of Orléans, county of Montmorency, on the SEVENTH day of APRIL, 1971, at TEN o'clock in the morning.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, March 2, 1971.39037 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March G, 1971, Vol.108, No.10 2269 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: / T ES HUILES DE QUÉBEC Cour Provinciale, ) *-> LTÉE., corporation légale-No 62-125.J ment constituée, ayant sa place \\ d'affaires à 252 de Villiers, Québec, district de Québec, vs ROGER CHOUINARD, résidant à 125 rue Verret, Lorettevillc, district de Québec.« Le lot numéro 612-3-1 de la paroisse de St-Ambroise de la Jeune-Lorette, district de Québec.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 10 avenue Chauveau, Québec, le SIXIÈME jour d'AVRIL 1971, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 2 mars 1971.39034-o Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( T ES HUILES DE QUÉBEC Provincial Court, ) LTÉE, corporation legally No.62-125.1 incorporated having its place of V business at 252 de Villiers, Québec, district of Québec, vs ROGER CHOUINARD, residing at 125 Verret Street, Lorettcville, district of Québec.\"Lot number 612-3-1 in the parish of Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, district of Québec.\" To be sold at the Québec Registry Office, 10 Chauveau Avenue, Québec, on the SIXTH day of APRIL, 1971, at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, March 2, 1971.39034 ROUYN-NORANDA De Terris District de Rouyn-Noranda Cour Supérieure, C T)ETER E.FIRLOTTE, rentier No 10,000.\\ * de Noranda, district de Rouyn-t Noranda, vs DELPHINO PICCO, photographe de Rouyn, district de Rouyn-Noranda, et CLEMENTE RIZZO, mineur de Elliot Lake, province \u2022d'Ontario.« Lots numéros trois cent quarante-six et trois cent quarante-sept (346-347) du plan officiel et livre de renvoi pour la cité de Noranda, avec bâtisses ci-dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendus au bureau du Shérif, Palais de Justice, à Rouyn, P.Q.le VINGTIÈME jour d'AVRIL 1971, à TROIS heures de l'après-midi.' Le shérif.Bureau du Shérif, J.-J.-R.Desmeules.Rouyn, Que., le 25 février 1971.39030-o SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris Sherbrooke \u2014 District de St-François Cour Supérieure, C \\ 7TNCENT BARRÉ, comptable, No 35,281.< Y des cité et district de Mont-v réal, demandeur, vs ALFRED DION, domicilié à Compton, district de St-François, défendeur.« Une propriété de ferme, située partie au canton de Compton et partie au village de Compton, connue et désignée comme suit: L- Toute la partie du lot onze-B (11-B) dans le cinquième rang, du cadastre du canton de Compton, se trouvant situé à l'ouest de la rivière Coaticook, laquelle partie est bornée comme suit: au nord par le cadastre du village de Compton, à l'est par la rivière Coaticook, et le lot onze-C (11-C) du même rang, au sud par le lot onze-C et le lot onze-A (11-C et 11-A) du même ROUYN-NORANDA De Terris District of Rouyn-Noranda Superior Court, ( \"DETER E.FIRLOTTE, retired of No.10,000.< -t Noranda, district of Rouyn-l Noranda, vs DELPHINO PICCO, photographer of Rouyn, district of Rouyn-Noranda and CLEMENTE RIZZO, miner of Elliot Lake, Province of Ontario.\"Lots number three hundred and forty-six and three hundred and forty-seven (346-347) on the official plan and book of reference for the town of Noranda, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, Rouyn, Que., on the TWENTIETH day of APRIL 1971, at THREE o'clock in the afternoon.J.-J.-R.Desmeules, Sheriff's Office, Sheriff.Rouyn, Que., February 25, 1971.39030-o SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris Sherbrooke \u2014 District of St-François Superior Court, ( \\7TNCENT BARRÉ, accountant No.35,281.\\ V 0f the City and district of I Montreal, plaintiff; vs ALFRED DION, domiciled at Compton, district of St-François, defendant.\"A farm situated in part in the township of Compton and in part in the Village of Compton, known and designated as follows: 1.The entire part of lot eleven-B (11-B) in the fifth range of the cadastre of the township of the township of Compton, situated west of Coaticook River, this part of which is bounded as follows: on the north by the cadastre of the Village of Compton, on the east by Coaticook River, and lot- eleven-C (11-C) of the same range, on the south by lot eleven-C 2270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 cinquième rang et à l'ouest par le lot onze-H (11-H) rang quatre, cette dite partie contenant environ cent quarante-deux acres en superficie; 2.Le lot numéro douzc-D (12-D) dans le quatrième rang, dc la contenance de dix acres en superficie du cadastre du canton dc Compton; 3.Le lot numéro douze-G (12-G) dans le même quatrième rang, dc la contenance de deux rods en superficie du cadastre du canton dc Compton; 4.Le lot numéro treizc-C (13-C) dans le quatrième rang dc la contenance de sept acres en superficie du cadastre du canton dc Compton.Sauf et excepté de ce dernier lot, la partie vendue par Alfred Dion et Paul Dion à Edmond Roy, par acte devant M i: G.A.Normandin, notaire le 14 novembre sous le numéro 67798 du bureau d'enregistrement dc Sherbrooke et décrit comme suit: Etant la partie située à la pointe ouest dudit lot treizc-C (ptic 13-C) du quatrième rang, bornée au sud par la partie nord-ouest du lot douzc-C du rang quatre, à l'est par une ligne qui serait la prolongation vers le nord de la ligne ouest du lot douze-D (12-D) du quatrième rang et sur son troisième côté par le chemin public; 5.Le lot numéro cent trente-sept (137) du cadastre du village de Compton, de la contenance dc dix-sept acres en superficie; 6.Toute la partie ouest du lot cent trente-neuf (ptie O.139) du cadastre du village de Compton, laquelle partie se trouve à l'ouest de la rivière Coaticook et est bornée comme suit: à l'est par lu rivière Coaticook, au sud par la ligne sud dudit lot cent trente-neuf (139), à l'ouest et au nord par la ligne ouest et nord dudit lot cent trente-neuf (139); de la contenance de cent quarante-huit acres en superficie; Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu en bloc au bureau d'enregistrement, à Sherbrooke, MARDI, le SIXIÈME jour d'AVRIL 1971, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif, Palais de Justice, Donat Jacques.Sherbrooke, le 24 février 1971.39031-O and lot eleven-A (11-C and 11-A) of the same fifth range and on the west by lot eleven-H (11-H) range four, this said part containing about one hundred and forty-two acres in area; 2.Lot number twelve-D (12-D) in the fourth range containing ten acres in area on the cadastre of the township of Compton; 3.Lot number twelve-G (12-G) in the same fourth range, containing two rods in area on the cadastre of the township of Compton ; 4.Lot number thirteen-C (13-C) in the fourth range, containing seven acres in area on the cadastre of the township of Compton.Save and except from this latter lot, the part sold by Alfred Dion and Paul Dion to Edmond Roy, by a deed before Me G.A.Normandin, notary, on November 14, under number 67798 of the Sherbrooke Registry Office and described as follows: The part situated at the west point of said lot thirteen-C.(P.13-C) of the fourth range, bounded on the south by the northwest part of lot twelve-C of range four, on the cast by a line which is said to be the prolongation to the north of the west line of lot twelve-D (12-D) of the fourth range and on its third side by the public road ; 5.Lot number one hundred and thirty-seven (137) of the cadastre of the Village of Compton, containing seventeen acres in area; 6.The entire west part of lot one hundred and thirty-nine (P.W.139) of the cadastre of the Village of Compton, the part of which is west of Coaticook River and is bounded as follows: on the east by Coaticook River, on the south by the south line of said lot one hundred and thirty-nine (139) on the west and north by the west and north line of said lot one hundred and thirty-nine (139); containing one hundred and forty-eight acres in area; The whole with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies\".To be sold \"en bloc\" at the Sherbrooke Registry Office, on TUESDAY, the SIXTH day of APRIL, 1971, at TEN o'clock in the morning.Sheriff's Office, Donat Jacques, Court House, Sheriff.Sherbrooke, February 24, 1971.39031 TROIS-RIVIÈRES Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Trois-Rivières (TA BANQUE DE MONTRÉAL, cor-No 32,528.\\ \u2022Lj poration légalement constituée, l ayant son siège social en les cité et district de Montréal, et une place d'affaires en les cité et district de Trois-Rivières, demanderesse, M FRANÇOIS BOISVERT, financier, résidant autrefois au No_ 1266, rue Mont-Royal, Outremont, résidant maintenant au 45 Kelvin, Outremont, district de Montréal, LOUIS FOTEAS, gérant, résidant au 2095, boul.des Forges, cité et district de Trois-Rivières, TROIS-RIVIÈRES Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Trois-Rivières ( »-pHE BANK OF MONTREAL, a cor-No.32,528a poration legally incorporated, hav-v ing its head office in the city and district of Montreal, and a place of business in the city and district of Trois-Rivières, plaintiff, vs FRANÇOIS BOISVERT, financier, formerly residing at No.1266 Mont-Royal Street, Outrcmont, now residing at 45 Kelvin Outremont, district of Montreal, LOUIS FOTEAS, manager, residing at 2095 des Forges Boulevard, city and district of Trois-Rivières, CLAUDE QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2271 CLAUDE SIMARD, industriel, résidant au 1760, des Chenaux, cité et district de Trois-Rivières, défendeurs conjoints et solidaires, Claude Simard, subrogé aux droits de la Banque de Montréal, a fait saisir les immeubles suivants, appartenant au défendeur, François Boisvert.Un emplacement situé en la cité des Trois-Rivières, au coin des rues Sle-Julie, Père Frédéric et Nérée Duplessis, composé: A) des lots 1473 et 1474 des plans et livre de renvoi officiels de la cité de Trois-Rivières; B) d'une partie du lot 1475 (p.1475) desdits plan et livre de renvoi officiels, mesurant en front au sud-ouest, 50.6 pieds, en arrière au nord-est 50.08 pieds par une profondeur de 97.6 pieds, mesure anglaise et plus ou moins, bornée en front au sud-ouest par la rue Nérée Duplessis, en arrière au nord-est par une partie du lot 1575, du côté nord-ouest par le lot No 1476 te de l'autre côté au sud-est par le lot 1474 ci-dessus décrit: C) d'une partie du lot 1492 desdits plan et livre de renvoi officiels, mesurant 50.08 pieds de largeur par une profondeur de 90.7 pieds, mesure anglaise et plus ou moins, bornée en front au nord-est par la rue Ste-Julie (P.1492), en arrière au sud-ouest par le lot 1473, d'un côté au nord-ouest par la partie du lot 1491 ci-après décrite et de l'autre côté au sud-est par la rue Père Frédéric; .D) d'une partie du lot 1491 desdits plan et livre dc renvoi officiels mesurant 50.08 pieds de largeur par une profondeur de 90.7 pieds mesure anglaise et plus ou moins, bornée en frnot au nord-est par la rue Ste-Julie (P.1491), en arrière au sud-ouest par le lot 1474, d'un côté au nord-ouest par une partie du lot 1490 et partie par le lot 1491 ci-après décrite et au sud-est par la partie du lot 1492 ci-dessus décrite.À distraire toutefois de cet emplacement un morceau de terrain faisant partie du lot No 1491 desdits plan et livre de renvoi officiel, contenant 2.35 pieds du côté nord-ouest, 2 pieds dans une ligne sud-ouest, par une profondeur de 14 pieds, mesure anglaise et plus ou moins, étant situé à 28 pieds du coin nord-ouest de la partie du lot 1491 ci-dessus décrite, bornée au nord-est, sud-est et sud-ouest par une partie du lot 1491 et au nord-ouest par une partie du lot 1490.Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice, 250, rue Laviolette, en la cité de Trois-Rivières, MERCREDI, le QUATORZIÈME jour du mois d'AVRIL, 1971, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Fernande Turgeon.Trois-Rivières, le 24 février 1971.39032-o SIMARD, industrialist, residing at 1760 des Chenaux, city and district of Trois-Rivières, defendants, jointly and severally.Claude Simard, subrogated in the rights of the Bank of Montreal, has caused to be seized the following immoveables, belonging to the defendant François Boisvert.An emplacement situated in the city of Trois-Rivières, at the corner of Ste-Julie, Père Frédéric and Nérée Duplessis Streets, and composed: A) of lots 1473 and 1474 on official plan and book of reference for the city of Trois-Rivières; B) of a part of lot 1475 (P.1475) on said official plan and book of reference, measuring in front on the southwest, 50.6 feet, in rear on the northeast 50.08 feet by a depth of 97.6 feet, English measure and more or less; bounded in front on the southwest by Nérée Duplessis Street, in rear on the northeast by part of lot 1575, on the northwest side by lot No.1476 and on the other side on the southeast by lot 1474 hereinabove described : C) of a part of the lot 1492 on said official plan and book of reference, measuring 50.08 feet in width by a depth of 90.7 feet, English measure and more or less; bounded in front on the northeast by Ste-Julie Street, (P.1492), in rear on the southwest by lot 1473, on one side on the northwest by the part of lot 1491 hereinafter described and on the other side on the southeast by Père Frédéric Street; D) of a part of lot 1491 of said official plan and book of reference, measuring 50.08 feet in width by a depth of 90.7 feet, English measure and more or less; bounded in front on the northeast by Ste-Julie Street, (P.1491), in rear on the southwest by lot 1474, on one side on the northwest partly by a part of lot 1490 and partly by lot 1491 hereinafter described and on the southeast by part of lot 1492 hereinabove described.Nevertheless to withdraw from this emplacement a piece of land forming part of lot 1491 of said official plan and book of reference, containing 2.35 feet on the northwest side, 2 feet in a southwest line, by a depth of 14 feet, English measure and more or less, being situated at 28 feet from the northwest corner of the part of lot 1491 hereinabove described; bounded on the northeast, southeast and southwest by a part of lot 1491 and on the northwest by a part of lot 1490.With the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the Sheriff's Office, in the Court House, 250 Laviolette Street, in the city of Trois-Rivières, WEDNESDAY, the FOURTEENTH day of the month of APRIL, 1971, at THREE o'clock in the afternoon.Fernande Turgeon, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Troîs-Rivères, February 24, 1971.39032 2272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 Ventes pour taxes Sales for taxes Municipalité du comté d'Abitibi Errata (Vente des lots pour taxes) Commission scolaire dc Clericy Dufresnoy 54 8 Ruben Bourgeois $290.17 et non tel que décrit antérieurement.Le secrétaire-trésorier, 39033-10-2-o J.-P.Gariépt.Municipality of the county of Abilibi Errata (Sale of lots for taxes) School Commission of Clericy Dufresnoy 54 8 Ruben Bourgeois $290.17 and not as formerly described.J.-P.Gariêpy, 39033-10-2 Secretary-Treasurer.Corporation municipale du comté de Dorchester Avis public est pour les présentes donné par Henri-Paul Bouffard, secrétaire-trésorier de la corporation municipale du comté de Dorchester, que les immeubles ci-dessous décrits seront vendus à l'enchère publique, pour taxes municipales ou scolaires ducs et les frais encourus, JEUDI, le TREIZIÈME jour de MAI 1971, en la salle du conseil de comté, à Ste-Hénédine, à DIX heures de l'avant-midi, à moins que lesdites taxes et les frais aient été payés avant le jour ci-dessus indiqué.La corporation du comté de Dorchester est autorisée & faire une enumeration abrégée des numéros cadastraux d'immeubles à être vendus par ladite corporation pour non-paiement de taxes d'ici le 31 mai 1971, à condition que ladite enumeration abrégée ne s'applique qu'aux numéros cadastraux d'immeubles qui sont consécutifs et qui appartiennent au même propriétaire, le tout conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 730 du Code municipal.Municipal Corporation of the County of Dorchester Public notice is hereby given by Henri-Paul Bouffard, Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the county of Dorchester, that the immovables hereunder described will be sold by public auction, for municipal or school taxes due and the costs incurred, on THURSDAY, the THIRTEENTH day of MAY, 1971, at the county seat, at Ste-Hénédine, at TEN o'clock in the forenoon, unless the said taxes and costs are paid before the date hereabove indicated.The Corporation of the county of Dorchester is authorized to make an abbreviated enumeration of the cadastral numbers of the immovables to be sold by the said corporation for non-payment of taxes before May 31, 1971, on the condition that the said abbreviated enumeration apply only to the same owner, the whole in conformity with the provisions of the last paragraph of Section 730 of the Municipal Code.Municipolit6 de Sainte-Aurélie \u2014 Municipality of Sainte-Aurélie Nom Proprietor\tLot\tRang Range\tCanton Township\tSuperficie Area\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes bcoi.School taxes\tFrais Costa\tTotal \tP.72-73.\tIX.\tMetgermette-Nord\t3.18 mes.irr.\tS 6.00\tS 30.71\tf 3.50\t$ 40.21 Municipalité de Saint-Anselme \u2014 Municipality of Saint-Anselme\t\t\t\t\t\t\t\t Raphael Côté.\tP.480.P.203.\tSt-Paul.\t\t7.83\tS 1.60 449.54\tS 8.30 141.37\tS 1.09 84.35\tS 10.99 675.26 Municipalité de Saint-Odilon de Cranbourno \u2014 Municipality of Soint-Odilon de Cranbourne\t\t\t\t\t\t\t\t \t250.P.225.P.268.392.431.432.433\tV.v.v vi viii.,\tCranbourne.Cranbourne.\t\t$140.46 137.27\t$488.80\t$ 6.50 6.75\t$ 146.96 144.02 488.80 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2273 Municipalité de Saint-Nazaire\u2014 Municipality of Saint-Nazaire Nom Proprieror\tLot\tRang Range\tCanton Township\tSuperficie Area\tTaxes muni.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal \tP.200.201, 202, 203, 204, 217, 218, 219.\tIII.\tBuckland.\t\t$195.23\t$742.18\t$ 70.30\t$1,007.77 \t\tIll III IV IV\t\t\t\t\t\t Municipalité de Saint-Prosper \u2014 Municipality of Saint-Prosper\t\t\t\t\t\t\t\t Oliva Paquet, bâtisses seulement, terrain a la municipalité - building only, land to the municipality.\t23-A.\t\tWatford.\t\t$ 63.50\t$ 35.20\t$ 4.00\t$ 92.70 \t23-B.\t\t\t\t\t\t\t Municipalité do Sainte-Rose \u2014 Municipality of Sainte-Rose Raoul Gagnon.Raoul Gagnon.P.61-62.60.Watford.Watford.74 66.$ 29.40\t$ 89.25\tS\t7.49 9.80\t29.75\t\t0.28 $ 126.14 39.83 Donné à Ste-Hénédine, ce 25e jour de février 1971.Le secrétaire-trésorier, 38951-10-2-o Henri-Paul Bouffard.Ville de Sainte-Thérese-Oucst Avis public est par le présent donné par le soussigné, M.Rosaire G.Brisson, secrétaire-trésorier de la ville dc Sainte-Thérèse-Ouest, que les immeubles ci-dessous désignés seront vendus à l'enchère à l'Édifice Municipal de la ville de Saint-Thérèse-Ouest situé au 901 boulevard Ste-Thérèse-Ouest, le MERCREDI, TRENTE ET UNIÈME jour du mois de MARS 1971 à DIX heures- de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts plus les frais subséquemment encourus à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant la vente.La Commission municipale de Québec, par décision en date du 7 décembre 1970, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles sous l'autorité de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193, article 550).Fiches Roll Given at Ste-Hénédine, this 25th day of February, 1971.Henri-Paul Bouffard, 38951-10-2 Secretary-Treasurer.Town of Sainte-Thexese-Ouest Public notice is hereby given by the undersigned, Mr.Rosaire G.Brisson, Secretary-Treasurer of the town of Saintc-Thérèse-Oucst, that the immovable properties hereunder described will be sold by public auction in the Municipal Building situed at 901 Boulevard Ste Thérèse Ouest, on WEDNESDAY, the THIRTY-FIRST day of MARCH 1971, at TEN o'clock in the morning to satisfy the payment of the municipal and school taxes with interest, plus the cost which have been or may be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before sale.The Québec Municipal Commission by a decision dated December 7 1970, has authorized an abridged enumeration of the cadastral lots numbers under the authority of the Cities and Towns Act (SRQ 1964, chapter 193, article 550).Lota et cadastre Lots and cadastre Noms des propriétairee Name of owners 1-63 André Massy.1-167 Saxony Holding Corporation 79-30-20.79-36P. 2274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Un certain emplacement ayant 365 pieds de largeur par 150 pieds de profondeur; do h\\, s'élargissant h 4G5 pieds par une profondeur do 476 pieds avoc une superficie totale de 252,840 pieds carrés; barné au nord-est par la Montée Sanche; au sud-est par les lots 79-301' et 79-30-104; au sud-ouest par une partie du lot 82 ot au nord-ouest, par les lots 79-30-87 a 79-36-96, plus une partie du lot 79-30.Fiches Roll A certnin emplacement measuring 365 feet width by 150 feet of depth; thereon, widening to 465 feet by a depth of 476 feet with a total urea of 252,840 square feet; bounded to the northeast by the Montée Sanche; to the southeast by the lots 79-301' and 79-30-104; to the southwest, by a part of lot 82 and to the northwest, by lots 79-36-87 to 79-36-96, plus a part of lot 79-36.Lots et cadastre Lots and cadastre Noms des propriétaires Name of owners 1-307 MarcBlain.82P.Un certain emplacement ayant 50 pieds de largeur par 160 A certain emplacement measuring 50 feet width by 160 pieds do profondeur avec une superficie de 8,000 pieds carrés; feet of depth with a total area of 8,000 square feet; bounded to borné au nord-est par la 4e Avenue; au sud-est par une partie the northeast by 4th Avenue; to the southeast, by n part of du lot 82 :\\ Jules d'Aoust; au sud-ouest par le lot 84 el au nord- lot 82 belonging to Jules d'Aoust; to the southwest, by lot 84 ouest, par une partie du lot 82 a L.A.Legault avec bâtisse y and to the northwest by a part of lot 82 belonging to L.A.érigée portant le numéro 10, 4o Avenue.Legault with building thereon erected and bearing civic number 10, 4th Avenue.1-317 Mme-Mrs.Mariotto Tremblay.82P.Un certain emplacement ayant 50 pieds de largeur par 100 A certain emplacement measuring 50 feet width by 100 feet pieds de profondeur avec une superficie totale de 5,000 pieds of depth with a total urea of 5,000 square feet; bounded to the carrés; borné au nord par une partie du lot 82 appartenant à north by n part of lot 82 belonging to Mrs.Thérèse Tremblay Dame Thérèse Tremblay Gratton; au sud par une partie du Gratton; to the south by n part of lot 82 belonging by Mrs.lot 82 appartenant à Damo Fernande Valiquct Bankley; 5, Fernande Valiquet Bankloy; to the east by a part of'lot 82 l'est, par une partie du lot 82 appartenant à Emilien Biais et al.belonging to Mr.Emilien Biais et ni.and to the west by the et à l'ouest, par la 4e Avcnuo uvou bâtisse y érigée portant le 4th Avenue.With building thereon erected and bearing numéro 16, 4o Avenue.civic number 15, 4th Avenue.1-323 Guy Devoault.82P.Un certain emplacement ayant 85 pieds de largeur par 100 A certain emplacement measuring 85 feet width by 100 pieds de profondeur avec une superficie totale de 8.600 pieds feet of depth with a total area of 8,500 square feet and bounded carrés et borné comme suit: nu nord-est, par les lots 82-70 et to the northeast by lots 82-70 and P.82; to the southeast by P.82; au sud-est, par le lot 82-8G; au sud-ouest, par la 5o Ave- lot 82-80; to the southwest by the 5th Avenue and to the nue et au nord-ouest, par le lot 82-34 avec bâtisses y érigée northwest by lot 82-34.With building thereon erected and portant les numéros 75 et 85, Se Avenue.bearing civic numbers 76 and 85, 6th Avenue.1-335 Roger Langlois.82P.Un cortain emplacement ayant 47 pieds de largeur par 85 A certain emplacement measuring 47 feet width by 85 feet pieds de profondeur avec une superficie totale de 3,995 pieds of depth with a total area of 3,995 square feet and bounded carrés ot borné comme suit: au nord-est, par la 3e Avenue; au to the northeast by the 3th Avenue; to the southeast by the sud-est, par la 3o Avenue; nu nord-ouest, par la rue Marie 3th Avenue; to the northwest by Marie Rose Street and to the Rose et sud-ouest, par une partie du lot 82 appartenant à southwest by a part of lot 82 belonging to Mr.Emilien Biais Emilien Biais et al.et al.2-A-164 Gaston Poirier.943-P.344, 943-345, 943- P.346, 943-347.3-64 Ernest Sirois.101-34.3-65 Ernest Sirois.101-35.3-209 Sport Togs Ltd.'.102P.Un certnin emplacement a figure trapèze ayant une superfi- A certain emplacement with a trapezoidal figure with a cie totale do 1.22 arpents (ou 44,923 pieds carrés),'mesurant total area of 1.22 arpents (or 44,923 square feet), measuring au nord-ouest, 98-04 pieds; nu sud-est, 95 pieds; au nord-est, to the northwest, 98.04 feet; to the southeast, 95 feet; to the 487 pieds et au sud-ouest, 458.75 pieds et borné comme suit: northeast, 487 feet and to the southwest, 458.75 feet and boun-au sud-est, par le lot 102-227-2; au nord-est.par le lot 102-8; ded to the southeast by lot 102-227-2; to the northeast by lot au nord-ouest, par le lot 102-299 et au sud-ouest, par les lots 102-8; to the northwest, by lot 102-299 and to the southwest 108-89 a 108-94 et 108-133.by lots 108-89 to 108-94 and 108-133.Un certain emplacement ii figure irrégulière ayant une A cortain emplacement with an irregular figure with a total superficie totale de 6.484 arpents et mesurant au sud-est, area of 6.484 arpents and measuring to the southeast, 443 443 pieds et au sud-ouest, 125 pieds et 382 pieds et borné feet and to the southwest, 125 feet and 382 feet and bounded comme suit: au sud-ouest, par les lots 102-8, 102-208, 102-271; to the southwest by lots 102-8, 102-208, 102-271; to the au nord-est, pnr une partie du lot 101; au sud-est, par une northeast by a part of lot 101; to the southeast by lot 102-partie du lot 102 et par le lot 102-227-2 et au nord-ouest, par 227-2 nnd to the northwest, by lots 102-266, 102-284 to 102-286 les lota 102-200, 102-284 a 102-286 inclusivement.inclusively.3-396 Entreprises Dubord Inc.102-276.3-397 Entreprises Dubord Inc.102-270.3-403 Entreprises Dubord Ino.-.¦.102-282.3-404 Entreprises Dubord Ino.102-283.3-406 Entreprises Dubord Inc.102-285.3-407 Sport Togs Ltée.102-286.3-409 Entreprises Dubord Ino.102-288.3-410 Entreprises Dubord Ino.102-289.3-411 Entreprises Dubord Inc.'.102-290.3-412 Entreprises Dubord Ino.102-291. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2275 Fiches Roll Noms des propriétaires Name of owners Lots et cadastre Lots and cadastre 3-413 Entreprises Dubord Ino.102-292.3-414 Entreprises Dubord Ino.102-293.3-415 Entreprises Dubord Inc.102-294.3-410 Entreprises Dubord Inc.102-295.3-417 Entreprises Dubord Inc.102-296.3-418 Entreprises Dubord Ine.102-297.3-419 Entreprises Dubord Inc.102-298.3-420 Sport Togs Ltée.102-299 3-407-2 Sport Togs Ltée.102-349.3-407-3 Sport Togs Ltée.102-350.3-467-4 Sport Togs Ltée.102-361.3-167-5 Sport Togs Ltée.103-362.3-467-6 Sport Togs Ltée.103-363.3-467-7 Sport Togs Ltée.102-354.3-467-8 Sport Togs Ltée.102-365.3-407-9 Sport Togs Ltée.102-356.3-467-10 Sport Togs Ltée.102-367.3-467-11 Sport Togs Ltée.102-358.3-467-12 Sport Togs Ltée.102-359.5-182 Henry Scholten.167-192.5-183 Henry Scholten.167-193.5-220 Mme-Mrs.Pearl Levy.157-230.5-221 Mme-Mrs.Pearl Levy.167-231.5-222 Mme-Mrs.Pearl Levy.157-232.5-223 Mme-Mrs.Pearl Levy.167-233.5-326 Investment R.B.Ltée.P.168.Un certain emplacement ayant 282 pieds de largeur en front; A certain emplacement mensuring 282 feet width in front; 324-02 pieds en arriére; 584 pieds de profondeur dans une 324.02 feet in back; 584 feet of depth on one side and 461.99 ligne et 451.99 pieds de profondeur dans une autre ligne avec feet on the other side with a total area of 154,196 square feet une superficie totale de 154,196 pieds carrés (ou 4.19 arpents) (or 4.19 arpents) and bounded to the northeast by lot 184; et borné comme suit: au nord-est par le lot 184; au sud-ouest, to the southwest by lot 157; to the southeast by lot 158-127 par le lot 157; au sud-est, par le lot 158-127 et au nord-ouest, and to the northwest by lot 158-126.par le lot 158-126.5-570 Ste Thérèso West Land.158-260.5-571 Ste Thérèse West Land.168-261.5-868 Mme-Mrs.Madeleine Thérien.162-106.5-869 Mme-Mrs.Madeleine Thérien.162-107 et-and 188-6.5-952 Entreprises Bella Inc.187P.et-and 189P.Lot P187: un certain emplacement ayant une superficie Lot P187; a certain emplacement with a total area of 27.57 totale de 27.57 arpents et borné comme suit: au nord, par le arpents and bounded to the north by the Côte Sud Road; to chemin de la Côte Sud; à l'est, par une partie du lot 189; the east, by a part of lot 189; to the south, by the Canadian au sud, par le Canadien Pacifique Railway et à l'ouest, par le Pacific Railway and to the west, by lot 186.lot 186.Lot P189: un certain emplacement ayant une superficie Lot P189: a certain emplacement with a total area of 18.167 totale de 18,167 arpents et borné comme suit: au nord, par le arpents and bounded to the north by the Côte Sud Road; to chemin de la Côte Sud; à.l'est, par le boul.Ste Thérèse Ouest; the east, by the Blvd.Ste Thérèse Ouest; to the south, by the au sud, par le Canadien Pacifique Railway et à l'ouest, par une Canadian Pacific Rail way and to the west, by a part of lot 187.partie du lot 187.5-990 Entreprises Montjoie Ltée.187-38.5-991 Crédit Immobilier Inc.187-39.5-992 Entreprises Montjoie Ltée.187-40.5-993 Crédit Immobilier Inc.187-41.6-994 Entreprises Montjoie Ltée.187-42.5-995 Crédit Immobilier Inc.187-43.5-997 Entreprises Montjoie Ltée.!™\"jf' 5-1000 Entreprises Montjoie Ltée.187-48.5-1002 Entreprises Montjoie Ltée.1f'\"f°- 6-1003 Entreprises Montjoie Ltée.187-61.5-1010 Entreprises Montjoie Ltée.187-58.5-1015 Crédit Immobilier Inc.187-63.6-1016 Crédit Immobilier Ino.187-64.5-1017 Crédit Immobilier Ino.187-66.6-1080 Entreprises Bella Ino.189P.Un certnin emplacement ayant une superficie totale de A certain emplacement with a total area of 8.999 arpents 8.999 arpents et borné comme suit: au nord-ouest, par le lot and bounded to the northwest, by lot 189-28 (street); to the 189-28 (rue); au sud-ouest, par une partie du lot 188 et le southwest, by a part of lot 188 and the lot 189-32; to the south-lot 189-32; au sud-est, par une partie du lot 99 et le lot 98-64 east, by a part of lot 99 and lot 98-64 and to the northeast, et au nord-est, par le lot 189-29 (Boul.Ste Thérèse Ouest).by lot 189-29 (Blvd.Ste Thérèse Ouest). 2276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103- année, n\" 10 Fiches Noms des propriétaires Lots et cadastre Roll Name of owners Lots and cadastre 5-1081 Entreprises Bella Inc.189P.Un certain emplacement ayant une superficie totale de 8.0 A certain emplacement with a total area of 8.0 arpents and arpents et borné comme suit: au sud-est, par le lot 189-3 et la bounded to the southeast, by lot 189-3 and the Côte Sud Côte Sud (front); au nord-est, par le lot 189-31 (Boul.Ste Thé- (front); to the northeast, by lot 189-31 (Blvd.Ste Thérèse rèse Ouest) ; au nord-ouest, par une partie du lot 582 près de la Ouest) ; to the northwest, by a part of lot 582 near the Rivière Rivière aux Chiens et au sud-ouest, par une partie du lot 187, aux Chiens und to the southwest by a part of lot 187 and lots et les lots 189-4 et 189-3.189-4 and 189-3.6-7 Real Jacob.108P.Un certain emplacement ayant 60 pieds de largeur par 00 A certain emplacement measuring 50 feet width by 60feet pieds de profondeur avec une superficie totale de 3,000 pieds of depth with a total urea of 3,000 square feet and bounded carrés et borné comme suit: au nord-ouest, par une partie du to the northwest, by a part of lot 108 belong to C.E.Turcotte lot 108 appartenant it C.E.Turcotte ou représentant; au sud- or representative; to the southeast, by a part of lot 108 est, par une partie du lot 108 appartenant à Mme Flore belonging to Mrs.Flore Brisson Bolduc or representative; Brisson Bolduc ou représentant; au nord-est, par une partie to the northeast, by a part of lot 108 belonging to Mrs.Flore du lot 108 appartenant à, Mme Flore Brisson Bolduc ou repré- Brisson Bolduc or representative and to the southwest, by the sentant et nu sud-ouest, par la rue Principale.Principale Street.6-206 Donald Walker.117-28.6-207 Donald Walker.117-29.6-230 Donald Walker.117-62.0-341 Armand D3 Grandprô.123-26.6-342 Armand De Grandpré.123-27.6-451 Nova Misse.124-28 et-and 123-133.6-452 Nova Masse.124-29 et-and 123-134.6-502 Juliette Gagnon Lessard.123-73.6-513 Jean-Paul Imbaault.124-84.9-04 Charles Einser.166-52.9-65 Charles Einser.166-53.9-66 Charles Einser.166-54.9-71 Paul E.Vander Borchs.166-59.9-72 Paul E.Vander Borchs.106-60.9-73 Paul E.Vander Borchs.166-61.9-74 Paul E.Vander Borchs.166-62.9-361 Michael Samuel.175-128.9-365 Michael Samuel.175-129.9-366 Michael Samuel.175-130.9-367 Michael Samuel.175-131.9-368 Michael Simuel.175-132.9-369 Michael Simuel.175-133.9-370 Michael Samuel.175-134.9-376 Shapiro Isadore.175-140.9-377 Shapiro Isadore.175-141.9-555 Donald Missad.175-322.9-556 Danald Missad.175-323.9-557 Donald Missad.175-324.9-558 Donald Missad.175-326.9-559 Donald Massad.175-326.9-560 Donald Massad.176-327.9-561 Donald Missad.175-328.9-562 Donald Massad.175-329.9-597 Michael Simuel.175-364.9-598 Michael Simuel.175-365.9-599 Michael Simuel.176-366.9-600 Michael Samuel.175-367 9-601 Michael Simuel.175-368.9-602 Michael Simuel.175-369.9-603 Michael Samuel.175-370.9-604 Michael Samuel.176-371.9-611 Donald Massad.175-378.9-612 Donald Massad.175-379.Les immeubles ci-haut mentionnés font partie du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Thérèse de BJain-ville, division d'enregistrement de Terrebonne et situés dans la ville de Sainte-Thérèse-Ouest.Ladite vente sera en outre faite avec tous les droits de subrogation, toutes les servitudes actives ou passives apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Donné en la ville de Sainte-Thérèse-Ouest, ce vingt-deuxième jour du mois de février 197L Le secrétaire-trésorier, 38952-10-2-o Rosaiee G.Bbisbon.The above mentioned immovables are from the official cadastre of the parish of Ste-Thérèse de Blain-ville, Terrebonne registration division, and situated in the town of Sainte-Thérèse Ouest.The said sale will be made with all subrogation rights, and all active and passive servitudes, apparent or occult, attached to the said immovables.Given at the town of Sainte-Thérèse Ouest, this twenty-second day of February 1971.Rosaire Brisson, 38952-10-2-o Secretary-Treasurer. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2277 Ville de La Prairie Avis public est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la ville de La Prairie, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l'enchère publique, à l'Hôtel de Ville de la ville de La Prairie, 600, boulevard Ste-Élisabeth, dans la ville de La Prairie, MARDI, le TRENTIEME jour du mois de MARS 1971, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec les intérêts et les frais, plus les frais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant la vente.La Commission municipale de Québec, par décision en date du 19 novembre 1970, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles, sous l'autorité de la Loi des cités et villes, article 550 (S.R.Q.1964, chapitre 193).Town of La Prairie Public notice is hereby given by the undersigned, Town Clerk of the town of La Prairie, that the immoveables hereinafter described will be sold by public auction, in the Town Hall of the town of La Prairie, 600, St.Elizabeth Boulevard, in the town of La Prairies, on TUESDAY, the THIRTIETH day of the month of MARCH 1971, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of the municipal and school taxes, with interests and.costs, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale.The Québec Municipal Commission, by a decision dated November 19, 1970, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of article 550 of the Cities and Towns Act (S.R.Q.1964, chapter 193).Paroisse de Lnprairie-de-la-Madeleine \u2014 Parish of Laprairie-of-the-Magdeleine Rôle Noms des propriétaires Cadastre Subdivision Roll Names of proprietors 64-177 18-558 64-80 64-81 64-64 64-77 23-5 24-12 10-501 64-65 64-76 64-70 64-75 23-511 64-63 64-46 64-73 44-31-1 44-31-1 67-2 21-501 21-501 66-37 66-36 66-39 66-38 66-35 32-600 23-10 58-605 64-78 41-15 41-16 41-17 4-26 4-523 64-169 64-170 64-184 64-29 64-30 66-42 66-45 66-51 Gianfranco Bnruzzo A.Piccoli.492 .213.Brosseau, Louis.459.Busits Francisco Opits.492 .85.Busits Francisco Opits.492 .86.Paolo Carlo Capra.492 .69.Antonio Francese Cattarino.492 .82.Coopérative d'Habitation du comté de-of county of Laprairie.673.1019.Coopérative d'Habitation du comté de-of county of Laprairie.673.1195.Coopérative d'Habitation du comté de-of county of Laprairie.673.1143.DaFonseca Torres Antonio.492.DaFonseca Torres Antonio.492.Manuel De Abren Pereira.'.\u2022.492.De Freitas Antonio.492.Desmarais Jules.673.De Sousa Agosthino Nunez.492.DiPalmaGuido.639.Gastaldo Mlle-Miss Guilia.492.Georges Gibeault.673.Georges Gibeault.673.Gérald Girard.640.Marcel Guérin etrand Lionel Tremblay.673.Marcel Guérin et-and Lionel Tremblay.673.Ramiro Vieiravalente Vieira.539.Valente Manuel Vieira.639.Diaz Jose Joad.539.Diaz Jose Joad.539.Peto Matusiva.539.St-Louis Products Limited.673.Longtin, Gérard.673.Hamelin, Jean-Yves.673.Ibarmia Santiago.492.Lamarche, Victor.673.Lamarche, Victor.673.Lamarche, Victor.673.Lefebvre, Maurice.655.Lefebvre, Maurice.655.Lesage, Henri.492.Lesage, Henri.492.Maccan, Andretta Antonio.492.Masse, Antoine.492.Masse, Antoine.492.Milheiro Oliveira Casimiro.¦.539.Montoni Renato.639.Nunez Juan Del Castillo.;.539.70.81.75.80.622.68.61.78.794.793.11.254.255.P-52.P-51.64.P-53.P-50.184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198.737.449.83.1032.1031.1030.142.203.205.206.220.34.33.67.\u2022 60.66. 2278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 Paroisse de Laprairie-de-la-Madeleino (traie) \u2014 Parish of Laprairie-of-the-Magdeleine (continued) Rôle Noms des propriétaires Cadastre Subdivision Roll Names of proprietors 46-16 Perron, Gilles.64-178 Piccoli Aurelio.64-155 Salomon, Alfred.64-156 Salomon, Alfred.64-157 Salomon, Alfred.19-4 Senôcal, Lucien.19-4 Senécal, Lucien.19-4 Senécal, Lucien.19-4 Senécal, Lucien.60-13 Senécal, Lucien.5-500 Senécal, Lucien.64-79 Trucillo Emilio & Sofia de Trucillo.44-541 Guérin.Marcel.Un immeuble connu et désigné comme étnnt le lot entier numéro 673-264 et une partie du lot 673 tous du cadastre de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot P-073.Borné au nord-ouest parle boul.Ste-Elisabeth, au nord-est par lu rue Lanctôt, nu sud-ouest pur une uutre partie du lot 673, au sud-est par le lot 673-204, mesurant dans sa ligne nord-ouest environ quntre-vingt-quutre pieds (84'), dans sa ligne nord-est environ dix-neuf pieds (19'), dans sa ligue sud-ouest environ neuf pieds (9'), dans sa ligne sud-est quatre-vingt-trois pieds (83').23-12 Longtin, Gérard.23-12 Longtin, Gérard.\u2022.Un immeuble connu et désigné comme étnnt le lot entier numéro 673-734 et une partie du lot 673-767 tous du cadastre de lu paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot 673-767.Borné au nord par le lot 673-734, au sud par le résidu dudit lot 673-767, a l'ouest par le lot 673-799, étant la rue Rouillier, a l'est par une autre partie dudit lot 673-767, mesurant dans ses lignes est et ouest, trente-deux pieds (32') dans ses lignes sud et nord, soixante-quinze pieds (76').673.492.492.492.492.304.304.304.304.549.549.492.136.214.191.192.193.264.265.266.267.8.2-12.84.33-504 Longtin, Alcide.____ 33-504 Longtin, Alcide.,.Un immeuble connu et désigné comme étant le lot entier numéro 673-393 et une partie du lot 673-395 tous du cadastre de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot 673-395.Borné au nord-est par une partie du lot 673-396, au sud-ouest par la rue Longtin, au sud-est par le lot 673-393, au nord-ouest par une autre partie dudit lot 673-393, mesurant dans ses lignes sud, ouest et nord-est, vingt et un pieds (21'), dans ses lignes nord-ouest et sud-est, quarante-sept pieds et trois dixièmes (47.3').27-12 Marion, Laurier.Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 469 du cadastre de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot 469.Borné au nord-ouest par une partie du lot 469, au sud-est par le chemin public (La Bataille Nord), au nord-est par une partie du lot 469, au sud-ouest par une partie du lot 470, mesurant dans sa ligne nord-ouest, soixante-cinq pieds et huit dixièmes (65.8') dans sa ligne nord-est soixante dix-neuf pieds et cinquante-huit centièmes, (79.58') dans sa ligne sud-est cent un pieds et un dixième (101.1') dans sa ligne sud-ouest quatre-vingt-dix-neuf pieds et un dixième (99.1').19-1 Senécal, Lucien.19-1 Senécal, Lucien.Un emplacement vague connu et désigné comme étant le lot entier numéro 304-248-7 et une partie du lot 304-248-8 tous du cadastre de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot 304-248-8.Borné au sud-est par la Fournier, au nord-ouest par une partie du lot 304, au nord-est par le résidu dudit lot 304-248-8, au sud-ouest par le lot 304-248-7, mesurant dans ses lignes sud-est et nord-ouest, quarante pieds (40'), dans ses lignes nord-est et sud-ouest, cent un P.073 ol-nnd 073.264.An immoveable known and designated us being the whole lot number 673-264 and a part of lot 673, both of the cadastre of the parish of Laprnirie-de-la-Magdeleine.Part of lot P-673.Bounded towards the northwest by St.Elizabeth Boulevard, towards the northeast by Lunctôt Street, towards the southwest by another part of lot 673, towards the southeast by lot 673-264, measuring on its northwest line eighty-four feet (84') more or less, on its northeast line nineteen (19') feet more or less, on its southwest line nine (9') feet more or less, on its southeast line eighty-three (83') feet.673 .784.P.673 .767.An immoveable known and designated us being the wholo lot number 673-734 and a part of lot 673-767, both of the cadustre of the parish of Lapruirie-de-la-Magdeleine.Part of lot 673-767.Bounded towards the north by lot 673-734, towards the south by the remainder of said lot 673-707, towards the west by lot 073-799, being Rouillier Street, towards the east by another part of said lot 673-767, measuring on its east and west lines thirty-two (32') feet, on its south and north lines seventy-five (75') feet.673.393.P.673 .395.An immoveable known and designated us being the whole lot number 673-393 and a part of lot 673-395, both on the cadastre of the parish of Laprairie-de-la-Magdelcine.Part of lot 673-395.Bounded towards the northeast by a part of lot 673-396, towards the southwest by Longtin Street, towards the southeast by lot 673-393, towards the northwest by another part of said lot 673-393, measuring on its southwest and northeast lines twenty-one (21') feet, on its northwest and southeast lines forty-seven feet and three tenths (47.3').P.469.An immoveable known and designated ns being part of lot 469 on the cadastre of the parish of Laprairie-de-la-Magdeleine.Part of lot 469.Bounded towards the northwest by part of lot 469, towards the southeast by the public road (La Bataille Nord), towards the northeast by a part of lot 469, towards the southwest by a part of lot 470, measuring on its northeast line seventy-nine feet and fifty-eight hundredths (79.58'), on its southeast line one hundred and one feet and one tenth (101.1') on its southwest line ninety-nine feet and one tenth (99.1').304 .248-7.P.304 .248-8.A vague emplacement known and designated as being the whole lot number 304-248-7 and a part of lot 304-248-8, both on the cadastre of the parish of Laprairie-de-la-Magdeleine.Part of lot 304-248-8.Bounded towards the southeast by Fournier Street, towards the northwest by a part of lot 304, towards the northeast by the remainder of said lot 304-248-8, towards the southwest by lot 304-248-7, measuring on ita southeast and northwest lines forty feet (40'), on its northeast QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2279 Paroisse de Laprairie-de-la-Madeleine (suite) \u2014 Parish of Laprairie-fo-the-Magdeleine (continued) Rôle Roll Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivision pieds et neuf dixièmes (101.0').19-504 Scnécul, Lucien.19-504 Senécnl, Lucien.19-504 Senécal, Lucien.Un emplacement vague connu et désigné comme étant les lots entiers numéros 304-259 et 304-200 et une partie du lot 304-258 tous du cadastre de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdclcine.Partie du lot 304-268.Borné au nord-ouest pur la ruo Founder, au sud-est par le lot 304-255, au sud-ouest par le résidu dudit lot 301-258, au nord-est pnr le lot 304-259, mesurant dans ses lignes nord-ouest et sud-est, quinze pieds et trois dixièmes (15.3') duns ses lignes sud-ouest et nord-est cent pieds (100').59-2 Senécal, Lucien.59-2 Senécal, Lucien.Un emplacement vague connu et désigné comme étant une partie du lot 549-2-10 et 549-2-11, tous du cadastre de la Èaroisse de Luprairie-de-la-Mugdelcine.Pnrtie du lot 549-2-10.orné nu nord par la route provinciale, à l'ouest par la rue Cloutier, au sud par une partie du lot 549-2-12, h l'est par une partie du lot 549-2-11, mesurant dans sa ligne nord cinquante et un pieds et huit dixièmes (61.8') dans sa ligne ouest, trente-cinq pieds et trois dixièmes (36.3') dans sa ligne Bud, cinquante pieds (50.0'), dans su ligne est, qunrante-quatro pieds et huit dixièmes (44.8').Pnrtie du lot 549-2-11.Borné nu nord par la route provinciale, h l'ouest par une pnrtie du lot 549-2-10, au sud par une partie du lot 549-2-12, à, l'est par une partie du lot 549-3, mesurant dans sa ligne nord, cinquante pieds et sept dixièmes (50.7'), dans sa ligne ouest, cinquante-cinq pieds et deux dixièmes (55.2'), dans sa ligne sud, cinquante pieds (50.0') dans sn ligne est, soixante-dix pieds et cinq dixièmes (70.5').44-547 Senopo Corporation Limited.44-647 Senopo Corporation Limited.44-547 Senopo Corporation Limited.44-547 Senopo Corporation Limited.44-547 Senopo Corporation Limited.Un immeuble connu et désigné comme étant les lots entiers numéros 073-823 à 073-820 inclusivement et une partie du lot 073-822 tous du cadastre de lu paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot 073-822.Borné au nord-ouest par le boul.Ste-Elisabeth, au sud-est par le droit de pnssago du C.N., au nord-est par les lots 073-823, 673-824, 673-825, 673-826, au sud-ouest par le résidu dudit lot 673-822, mesurant dans sa ligna nord-ouest, vingt pieds (20.0') dans sa ligne nord-est.trois cent huit pieds et quatre dixièmes (308.4'), dans sa ligne sud-ouest, trois cent deux pieds et deux dixièmes (302.2').17-507 The Snlessa Corporation Limited.Un lopin de terre connu et désigné comme étant une partie du lot 377 tous du cadnstre de lu paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot 377.Borné à l'ouest par le chemin public (rung Fontarubic), a l'est par une pnrtie du lot 419, par les lots 420, 421, 422, 423, 424 et une purtie du lot 425, au nord par les lots 378 et 379, au sud par le lot 376, mesurant dans sa ligne ouest, quatre cent soixante et onze pieds (471') dans sa ligne ouest, quatre cent soixante-quinze pieds (475') dans sa ligne sud, cinq mille six cent quatorze pieds (5,614') dans sa ligne nord, cinq mille six cent huit pieds (5,008') formant une superficie de soixante et onze arpents carrés et quatre-vingt-seize centièmes (71.90').' 19-505 Fernand Brosseau.and southwest lines one hundred and one feet and nine tenthB (101.9').P.304 .268.304.259.304.260.A vague emplacement known and designated as being the whole lots numbers 304-259 and 304-260 and a part of lot 304-268, all on the cadastre of the parish of Laprairie-de-la-Mngdcleine.Part of lot 304-268.Bounded towards the northwest by Fournier Street, towards the southeast by lot 304-266, towards the southwest by the remainder of said lot 304-258, towurds the northeast by lot 304-259, measuring on its northwest nnd southeast lines fifteen feet and three tenths (15.3'), on its southwest and northeast lines one hundred feet (100').P.649 .2-10.P.649.2-11.A vague emplacement known and designated as being part of lot 649-2-10 and 549-2-11, both on the cadastre of the parish of Laprairie-de-la-Magdeleine.Part of lot 549-2-10.Bounded towards the north by the provincial highway, towards the west by Cloutier Street, towards the south by a part of lot Deux parcelles de terrain vague et désigné comme étant des parties du lot 304 du cadastre de la paroisse de Laprairie-de-la- line fifty feet (60.0'), in its east line forty-four feet and eight tenths (44.8').Part of lot 549-2-11, Bounded towards the north by the provincial highway, towards the west by part of lot 549-2-10, towards the south by part of lot 549-2-12, towards the east by part of lot 549-3, measuring in its north line fifty feet and seven tenths (50.7'), in its west line fifty-five feet and two tenths (55.2'), in its south lino fifty feet (50.0'), in its east line seventy feet and five tenths (70.6').P.673 .822.673.823.673.824.673 .825.673 .826.An immoveable known and designated as being the whole lots numbers 073-823 to 673-826 inclusively and n part of lot 673-822, all on the cadastre of the parish of Laprnirie-dc-ln-Magdeleine.Part of lot 673-822.Bounded towards the northwest by St.Elizabeth Boulevard, towards the southeast by the right of way of the C.N., towards the northeast by lots 673-823, 673-824, 673-826, 673-826, towards the southwest by the remainder of said lot 673-822, measuring in its northwest line twenty feet (20'), in its northeast line three hundred and eight feet and four tenths (308.4'), in its southwest line three hundred and two feet and two tenths (302.2').P.877.A parcel of land known and designated as being part of lot 377 on the cadastre of the parish of Laprairie-de-la-Mugdo-leine.Part of lot 377.Bounded towards the west by the publio road (Range Fontnrabie), towards the east by part of lot 419, by lots 420, 421, 422, 423, 424 and part of lot 426, towards the north by lots 378 and 379, towards the south by lot 370, mensuring in its west line four hundred and seventy-one feet (471'), in its west line four hundred nnd seventy-five feet (476'), in its south line, five thousand six hundred and fourteen feet (6614'), in its north line five thousand and eight feet (5008'), forming a superficy of seventy-one square arpents and ninety-six hundredths (71.96).P.304.Two vague parcels of land known and designated as being ports of lot 304 on the cadastre of the parish of Laprairie-de-la- 2280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Magdeleine.Première parcelle de forme triangulaire, partie du lot 304.Borné à l'oueet par la rue Fournier, au sud-ouest par le lot 304-260, au nord-ouest par une partie du lot 304, mesurant dans sa ligne sud-ouest soixante-trois pieds et quatre dixièmes (63.4'), dans sa ligne ouest vingt-cinq pieds et deux dixièmes (25.2'), formant une superficie de sept cent quntre-vingtrdix-huit pieds carrés et quatre-vingt-quatre centièmes (798.84 pi.car.).Deuxième parcelle de forme triangulaire.Borné à l'ouest par la rue Notre-Dame, au sud-ouest par le lot 304-252, au nord-est par une partie du lot 304, mesurant dans sa ligne sud-ouest, vingt-neuf pieds et sept dixièmes (29.7'), dans sa ligne ouest, onze pieds et huit dixièmes (11.8'), formant une superficie de trois cent cinquante pieds carrés et six centièmes (350.46 pi.car.).Magdeleine.First parcel of triangular shape.Part of lot 304 Bounded towards the west by Fournier Street, towards the southwest by lot 304-260, towards the northeast by part of lot 304, measuring in its southwest line sixty-three feet and four tenths (63.4'), in its west line twenty-five feet and two tenths (25.2'), forming a superficy of seven hundred and ninety-eight square feet and eighty-four hundredths (798.84 sq.ft.).Second parcel of triangular shape.Bounded towards the west by Notre-Dame Street, towards the southwest by lot 304-252, towards the northeast by part of lot 304, measuring in its southwest line twenty-nine feet and seven tenths (29.7'), in its west line eleven feet and eight tenths (11.8'), forming a superficy of three hundred and fifty square feet and forty-six hundredths (350.46 sq.ft.).Paroisse de Laprairie-de-la-Madeleine (.suite) \u2014 Parish of Laprairie-of-the-Magdeleine (continued) Râle- ' Noms des propriétaires Cadastre Subdivision Roll Names of proprietors 60-18 Miron, Adrien.Un terrain vague connu et désigné comme étant une partie du lot 555 tous du cadastre de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot 555.Borné au nord-ouest par le fleuve St-Laurent, au sud-est par l'ancienne route No 3, au nord-est par le lot 554-2, au sud-ouest par le lot 555-320, mesurant dans sa ligne sud-est, cent pieds (100'), dans sa ligne nord-est, quarante-trois pieds et trois dixièmes (43.3'), dans sa ligne sud-ouest, quarante-quatre pieds et six dixièmes (44.6').60-518 Miron, Adrien.¦.00-618 Miron, Adrien.Un terrain vague connu et désigné comme étant une partie du lot 555 et une partie de la rue non ouverte portant le numéro 555-243, du cadastre de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot 555 et 655-243 rue.Décrit comme suit: Partant d'un point A, de la ligne A-B en direction sud, mesure quatre cent quatre-vingt-douze piedset quatre dixièmes (492.4'), delà la ligne B-C, en direction nord-ouest, mesure neuf cent cinquante-trois pieds et sept dixièmes (953.7'), delà la ligne C-D-N, formant un angle de soixnnte-dix-neuf degrés et cinquante-sept minutes (79°57') en direction sud-est, mesure deux cent soixante-cinq pieds et cinq dixièmes (205.5'), delà la ligne N-O,\" en direction nord-ouest, mesure cent neuf pieds et huit dixièmes (109.8'), delà la ligne O-F, en direction est, mesure quarante-six pieds et quatre-vingt-sept centièmes (46.87') pour la première section et quatre-vingt-dix-neuf pieds et trois dixièmes pour l'autre partie, delà la ligne F-G, en direction sud-est, mesure trente-quatre pieds et neuf dixièmes (34.9') delà la ligne G-H, en direction nord-est, mesure quarante-neuf pieds.(49'), delà la ligne H-K, en direction est, mesure dix-neuf pieds et sept dixièmes (19.7'), delà la ligne K-L, en direction sud-est, mesure cent deux pieds et quatre-vingt-treize centièmes (102.93'), delà la ligne L-M, formant un angle de cent soixnhte-dix-huit degrés et quarante-sept minutes (178°47'), mesure cent dix-neuf pieds et quarante et un centième (119.41'), delà la ligne M-A, en direction sud-est, mesure quatre cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et six dixièmes (499.6'), la description ci-haut inclus la partie de la rue 555-243 le tout ayant une superficie totale de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt et un pieds carrés et doux dixièmes (399.181.2 pi.car.).La partie de rue portant le numéro 555-243 est située à l'est de la partie du iot 555 plus haut décrite et mesure dans sa ligne est quatre cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et six dixièmes (499.6'), dans sa ligne ouest cinq cent onze pieds et cinq dixièmes (511.5'), dans sa ligne nord-ouest, vingt-cinq pieds et vingt-huit centièmes, formant une superficie de douze mille six cent soixante-neuf pieds carrés et sept dixièmes (12,669.7 pi.car.) .P.555.A vague parcel of land knwon and designated as being part of lot 665 on the endnstre of the parish of Laprairie-de-la-Magdeleine.Purt of lot 555.Bounded towards the northwest by the St.Lawrence River, towards the southeast by former road No.3, towards the northeast by lot 554-2, towards the southwest by the lot 556-320, measuring in its southeast line one hundred feet (100'), in its northeast line forty-three feet and three tenths (43.3'), in its southwest line forty-four feet and six tenths (44.6').P.656.P.555.243.A vague parcel of land known and designated as being part of lot 555 and a part of the non-opened street bearing the number 555-243 on the cadastre of the Parish of Laprairie-de-la-Mngdeleine.Part of lot 555 and street 555-243.Described as follows: Starting from point A of line A-B, line A-B going south measures four hundred and ninety-two feet and four tenths (492.4'), thence line B-C going northwest measures nine hundred and fifty-three feet nnd seven tenths (953.7'), thence line C-D-N forming an angle of seventy-nine degrees and fifty-seven minutes (79°57') going southeast measures two hundred and sixty-five feet and five tenths (265.5') thence line N-0 going northwest measures one hundred and nine feet and eight tenths (109.8'), thence line O-F going east measures forty-six feet and eighty-seven hundredths (46.87') for the first section and ninety-nine feet nnd three tenths (99.3') for the other section, thence line G-F going northeast measures forty-nine feet (49'), thence line H-K going east measures nineteen feet and seven tenths (19.7'), thence line K-L going southeast measures one hundred and two feet and ninety-three hundredths (102.93'), thence line L-M, forming an angle of one hundred and seventy-eight degrees and forty-seven minutes (178°47') measures one hundred nnd nineteen feet and forty-one hundredths (119.41') thence line M-A going southeast measures four hundred and ninety-nine feet and six tenths (499.6').The above description includes the part of street 555-243, the whole forming a superficy of three hundred and ninety-nine thousand one hundred and eighty-one square feet and two tenths (399,181.2 sq.ft.) The part of the street bearing the number 555-243 is situated towards the east of part of lot 655 above described and measures in its east line four hundred and ninety-nine feet nnd six tenths (499.6'), in its west line five hundred and eleven feet and five tenths (611.5'), in its northwest line twenty-five feet and twenty-eight hundredths (25.28'), forming a superfioy of twelve thousand six hundred and sixty-nine square feet and seven tenths (12,669.7 sq.ft.). QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.103, No.10 2281 Paroisse de Laprairie-de-la-Mndelcinc (tuile) \u2014 Parish of Laprairie-of-the-Magdeleine (continued) Rôle Roll Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivision 17-4 Ellisbert Rosenthal Irving.Un lopin de terre connu et désigné comme étnnt une partie du lot 340 tous du cadastre de la paroisse de Lnpruirie-de-Ia-Magdeleine.Partie du lot 340.Borné à l'est par une partie du lot 344, à l'ouest par une partie du lot 347, au sud par le lot 670, formnnt une superficie de huit arpents carrés et vingt-quatre centièmes (8.24 arp.car.).P.346.A parcel of land known and designated as being part of lot 346 on the cadastre of the purish of Laprairie-de-la-Magdeleine.Part of lot 346.Bounded towards the east by part of lot 344, towards the west by part of lot 347, towards the south by lot 670, forming a superficy of eight square arpents and twenty-four hundredths (8.24 sq.orp.).46-2 46-2 St-Louis Products Limited.St-Louis Products Limited.Un terrain vague connu et désigné commo étant les lots entiers numéros 673-184 à 673-197 inclusivement et une partie du lot 673-183 tous du cadastre de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Partie du lot 673-183.Borné au sud-est par le lot 673-182 rue Notre-Dame et le résidu dudit lot 673-183, au sud-ouest par le lot 673-184, au nord-ouest par le lot 673-186, au nord-est par la rue St-Hcnri, mesurant dans sa ligne nord-est trente et un piedB et cinq dixièmes (31.5').et trente-cinq pieds (35'), dans sa ligne nord-ouest cent trente-cinq pieds (136'), dans sa ligne sud-est cent dix pieds (110') et vingt-cinq pieds (25'), dans sa ligne sud-ouest soixante-six pieds et cinq dixièmes (66.5').P.673.183.673.184 à-to 197-incl.A vague piece of land known and designated as being the whole lots numbers 673-184 to 673-197 inclusively and a part of lot 673-183, all on the cadastre of the parish of Laprairie-de-la-Magdeleine.Part of lot 673-183.Bounded towards the southeast by lot 673-182 Notre-Dame Street and the remainder of said lot 673-183, towards the southwest by lot 673-184, towards the northwest by lot 673-185, towards the northeast by St-Henri Street, measuring in its northeast line thirty-one feet and five tenths (31.5') and thirty-five feet (35') and in its northwest line one hundred and thirty-five feet (135'), in its southeast line one hundred and ten feet (110'), and twenty-five feet (25'), in its southwest line sixty-six feet and five tenths (66.5').Village incorporé de La Prairie \u2014 Village incorporated of La Prairie 43-504 Brisson, Sébastien.46-612 H & R Construction.46-513 H & R Construction.46-514 H & R Construction.40-616 H & R Construction.40-610 H & R Construction.36-503 H & R Construction.65-7 H & R Construction.65-8 H & R Construction.46-611 H & R Construction.55\u201415 Lefebvre, Maurice.42-613 Lefebvre, Maur ce.56-606 Si-Louis Products Limited.Un bâtiment connu et désigné comme portant le numéro civique 455 rue St-Philippe, à La Prairie, érigé sur une partie du lot 179.64-10 Lamarche, Victor.Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 80 du cudastre officiel du Village Incorporé de La Prairie.Purtie du lot 8G.Borné au Bud-est par la rue Ste-Murie, au nord par le résidu du lot 86, au sud par le lot 87, ayant une superficie de deux mille quatre cent trente et un pieds carrés (2,431 pi.car.), mesures anglaises.256.302.302.302.302.302.1.3.4.6.0.7.296 et-and 302.1.296.2.296.3.302 .2.293 .2.293.3.178.An immoveable known and designated bearing civic number 455 St.Philippe Street at La Prairie erected on lot part 179.46-14 Brisson, Sébastien.Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 247-5 du cadastre officiel du Village Incorporé de La Prairie.Partie du lot 247-5.Borné au nord-est par la rue St-Georges, au sud-ouest par le lot 250-3, au sud-est par la rue Notre-Dame, au nord-ouest par le résidu dudit lot 247-5, mesurant dans sa ligne nord-est, quarante-six pieds et soixante-sept centièmes (46.67'), dans sa ligne sud-ouest, quarante-dix pieds et huit centièmes (46.08'), dans ses lignes sud-est et nord-ouest, quatre-vingt-dix-sept pieds (97').P.86.An immoveable known and designated as being part of lot 86 on the official cadastre of the Village Incorporé de La Prairie.Part of lot 86.Bounded towards the southeast by Ste-Marie Street, towards the north by the remainder of lot 86, towards the south by lot 87, forming a superficy of two thousand four hundred and thirty-one square feot (2,431 sq.ft.), English measure.P.247.5.An immoveable known nnd designated as being part of lot 247-5 on the official cadastre of the Village Incorporé de La Prairie.Part of lot 247-5.Bounded towards the northeast by St-Georges Street, towards the southwest by lot 266-3, towards the southeast by Notre-Dame Street towards the northwest by the remainder of said lot 247-5, measuring in its northeast line forty-six feet and sixty-seven hundredths (46.67'), in its southwest line forty-six feet and eight hundredths (46.08'), in its southeast and northwest lines ninety-seven feet (97'). ci-haut mentionnés contiennent des bâtisses ou dé- mentioned in the hereinabove statement have buildings pmilances dessus construites, la vente de ces immeu- thereon erected, the sale of these immoveables for non bles pour taxes aura lieu avec l'ensemble des bâtisses payment of taxes shall include the buildings thereon et dépendances dessus construites.erected.Donné à La Prairie, ce vingt-sixième jour de février Given at La Prairie, this twenty-sixth day of Fc- 2282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n' 10 INDEX NolO ARRÊTÉS EN CONSEIL ORDERS IN COUNCIL 315 \u2014 Sécurité dans les édifices publics, concernant la modification des règlements généraux.2167 315 \u2014 Safety in Public Buildings, concerning the amendment of the general regulations.2167 548 \u2014 Pare national Forillon, concernant la constitution en réserve de chasse du territoire impliqué dans le projet.2197 548 \u2014 Forillon National Park, concerning the establishment of the territory implicated in the clan for the game reserve._.2197 549 \u2014 Oiseaux, concernant l'interdiction de chasser certaines espèces.2208 549 \u2014 Birds, concerning the prohibition to hunt certains species.2208 549 \u2014 Interdiction de chasser certains oiseaux.2208 549 \u2014 Prohibition to hunt certain birds.2208 601 \u2014 Parent, l'honorable Oswald, (Ministre d'État aux Affaires intergouvernementales).2207 601 \u2014 Parent, the Honourable Oswald, (Minister without Portfolio in the Department of Intergovern- mental Affairs).2207 602 \u2014 Véhicules-automobiles, (Réglementation relative aux poids maxima des véhicules-automobiles circulant sur les chemins publics du Québec).2207 602 \u2014 Motor vehicles, (Regulations respecting the maximum weight of motor vehicles operating on the Québec public highways).2207 606 \u2014 Serments et affirmations solennelles.2206 606 \u2014 Oaths and solcm affirmations._._.2206 657 \u2014 Immatriculation à prix réduit d'autobus, propriété de Colonial Coach Lines Limited et de ' Eastern Greyhound Lines Limited.;.2203 657 \u2014 Registration at reduced rates of the buses of the Colonial Coach Lines Limited and Eastern Greyhound Lines Limited._.2203 658 \u2014 Tarif des droits payables à la Régie des Transports pour certaines compagnies dc transport.2209 658 \u2014 Tariff of fees payables to the Transportation Board by certain transport companies.2209 682 \u2014 Hôtellerie, (Modifications aux règlements).2202 682 \u2014 Hotel Trade, (Amendments to the regulations).2202 683 \u2014 Hôtellerie, (Droits payables lors de la délivrance d'un permis).2206 683 \u2014 Hotel Trade, (Duties payable on the issue of a permit).2206 772 \u2014 Commission des accidents du travail de Québec, concernant l'adoption du règlement No 44, relatif aux industries de la cédule II qui, sur requête, peuvent être transférées à la cédule .2204 772 \u2014 Québec Workmen's Compensation Commission, concerning the adoption of Regulation No.44, respecting those industries of schedule II which, upon request, may be transferred to schedule I.2204 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Corporation des officiels municipaux agréés du Québec (Règl.No 17).2212 Corporation of chartered Municipal Officers of Québec (By-law No.17).\u2022.2212 Holy Name of Jesus, par.(Ch.limites).2149 Notre-Dame-de-Beaupré, par.(Annexion).2151 LaSalle, cité-city (Rachat partiel d'obligalions-Partial Redemption of Bonds).2149 Québec, ville-city (Rachat d'obligations-Redemption of bonds).2210 St-Aloysius, par.(Ch.limites)____.2151 Ste-Anne-de-Beaupré, par.(Annexion).2151 St-Féréol, par.(Annexion).2151 St-François-Xavier-de-Verchères, par.(Requête-Pétition).2211 Verchères, village (Requête-Pétition).2211 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.10S, No.10 2283 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du Demandes: Cognard, Joseph René Louis Emile Edgard.Kitaika, Sidney Thomas.Moskovits, Tomi.Noury Jean-Pierre.Papathanasopoulos, Apostolos (Paul).Soucisse dit Soucis, Florence.Thomschitz, Johann.CHANGE OF NAME ACT Applications: CAISSES D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT SAVINGS AND CREDIT UNIONS Caisse d'économie des enseignants d'Yamaska (Formation).2153 Caisse d'entraide économique de Granby (Nom-Name ch.).2153 Caisse d'entraide économique de Richelieu (Nom-Name ch.).2153 Caisse populaire de Notre-Dame du Foyer (L') (Nom-Name ch.).2154 Caisse populaire Marie Reine des Coeurs de Montréal (La) (Mod.terr.).2154 COMPAGNIES ÉTRANGÈRES EXTRA-PRO VINCI AL COMPANIES Licenses: Permis: Great Ski Manufacturing, Inc.2212 King Resources Company.2213 L.H.Shingle Company.2213 Piccolo Pizza of Alberta Ltd.2213 Powers (Elaine) Figure Salons (Canada), Limited.2214 Triple-E Motor Homes Ltd.2213 COMPAGNIES \u2014 LOI DES Demandes d'abandon de charte Affincrie québécoise de métaux inc.Aubé & Giroux ltée.Bélanger (Lise) inc.Canapower Limited.Ciné-Télévision ltée.De Beaumont (A.) & Cie ltée.Lacroix (H.) ltée.,.Lucad Corporation.Pâtisserie Nourry inc.Québec Metal Refining Inc.Schwartz (Eugenio) & Co.Ltd.Société de documentation politique ABC ltée Transatlantic Agencies Limited.Vannelli Super Market Inc.COMPANIES ACT Applications for Surrender of Charter 2214 2214 2216 2215 2215 2215 2216 2215 2216 2214 2214 2215 2216 2216 Dissoutes Dissolved Armitage Tire Ltd.2139 Armitage Tire ltée.2139 Association St-François inc.2139 Audet & Bergeron ltée.2140 BMMS Inc.2140 B.T.R.Cosmétiques inc.Baruch Building Corp.Beacon Hill Mall Ltd.Belvedere Investment Company.Boulangerie Butchy Boy ltée.Butchy Boy Bakery Ltd.Candiac Construction Ltd.Centre Médico-Chirurgical de Saint-Jean inc.Chuck's Snack Bar Inc.Club Autos-Neige St-Germain inc.Coat Front Contractors Ltd.Davro Industries Ltd.Distributeurs Métropolitains inc.Duchaine (A.R.) & Cie ltée.Faille Automobile inc.Industries Davro ltée (Les).Lake Blue Realty (Québec) Ltd.'.Lavoie (Berthe) Productions inc.Marl Incorporated.Matte (Raymond) limitée.S.T.W.Developments (Québec) Limited- St.Martin Shopping Centre Limited.Styval Realty Corp.Towers (Guy) Buildings Ltd.Trans-Nation Realties Inc.Vézina (J.P.) incorporée.^.2224 2225 2223 2224 2224 2224 2224 2140 2140 2140 2140 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2144 2144 2144 Divers Miscellaneous Association des directeurs de théâtre inc.(L') (Règl.-By-laws).2217 Association des zouaves de Québec inc.(L') (Règl.-By-laws).;.2217 Association québécoise des fabricants de toyau de béton inc.(L') (Règl.).2218 Bibliothèque centrale de prêt du Saguenay- Lac-St-Jean (Règl.-By-laws).2217 Boutique Phase inc.(Non-Name ch.).2218 Cinepix Inc.(Dir.).2218 Comité des loisirs de Frontenac (St-Jean-Vian- ney) (Règl.-By-laws).:.2218 Custom Craft Furniture Inc.(Dir.).2218 Dames auxiliaires du centre François-Michelle pour déficients mentaux (Les) (Règl.-By-laws) .2219 Dobois Realties Ltd.(Non-Names ch.).2217 Domus Medica Institute Inc.(Dir.).2216 Institut Domus Medica inc.(L') (Dir.).2216 Mercury Electric and Mechanical Contractors Ltd.(Dir.).2217 Pan Arkadian Brotherhood of Canada (Règl.-By-laws).2219 2284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n° 10 Divers Miscellaneous (suite) (continued) Patsan Inc.(Nom-Name ch.).2219 Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.(By-laws).2218 Service des loisirs Sts-Martyrs-Canadiens dc Montréal (Règl.-By-laws).2219 Solo Products Limited.2218 Wilwaken Inc.(Dir.).2217 Lettres patentes Letters Patent Action machineries inc:.2107 Aéroclub du Lac St-Jean inc.2107 Agences Désirella inc.2107 Artisanat Gaspésicn inc.2108 Association Provinciale «le Chevaux Miniatures (Correction).2229 Bédard, Fortier et associés inc.2108 Brasserie Québécoise inc.2108 Cavalcade Equestrian Centre Inc.(La).2109 Centre Équestre La Cavalcade inc.2109 Chapdelaine (F.) assurances inc.2109 Cie dc gestion Omicron ltée (La).2127 Clinique Naturiste Brunct inc.2110 Club de Fer Royal de Sorel inc.2110 Club optimiste St-Michel, Montréal.2110 Comité d'aide aux éprouvés dc Deux-Montagnes inc.\u2022 2111 Comité des loisirs du boulevard St-Jcan inc.(Le).2111 Compagnie dc.gcstion J.N.Tessier inc.2112 Construction Émery Paquette inc.2112 Construction & Pavage Moderne ltée.2112 Créations Claude Hurtubisc ltée.2113 Deaudelin (Marcel) inc.2113 Défrichements Warwick inc.(Les).2114 Delson Auto Parts Inc.2114 Déry automobile ltée.¦ 2114 Disques Jacob inc.(Les).2115 Distribution Yvon Ellyson inc.2115 Éditions Contemporaines inc.(Les).2115 Entreprises Boisclair & Dubois inc.2116 Entreprises Domil inc.(Les).2116 Entreprises M.Léger inc.(Les).2116 Fédération du Canotage Long Parcours du Québec inc.2117 Ferland (Benoit) & Fils ltée.2117 Fortin (André) Auto inc.2118 Franconet inc.2118 G.S.T.Tire Casings Ltd.2118 Gagnon (Guy) inc.2119 Gagnon (Walter) inc.2138 Gestion V.P.D.inc.2119 Habitations de la Côte Nord inc.2119 Hochelaga Garden Restaurant Inc.2132 Immeubles de l'Amiante inc.(Les).2120 Immeubles Dupernay inc.(Les).2120 Immeubles Sabrevois inc.(Les).2121 Lachambre (Roger) inc.2121 Lake St.John Flying Club Inc.2107 Lavoie, (Gaétan) ltée.2121 Lcmaire & Lemaire inc.2122 Leroux (Normand) Stables Inc.2122 Lévis T.V.service inc.2123 Liqueurs du Bas St-Laurent ltée (Les).2123 Loisirs Parc Orléans incorporée (Les).2123 Mailhot (Léo) inc.2124 Marché Price inc.2124 Mercerie Lafleur inc.2124 Meubles Guy Nadeau inc.2125 Modem Construction & Paving Ltd.2112 Montreal Safety Shoes Service Inc.2135 Mouflons des montagnes inc.2125 Murdock Lumber inc.2125 Murray Bay Resort Hotels Inc.2126 Nadeau Electrix inc.2126 Omicron Holding Company Ltd.2127 Organisation des sports et loisirs de Ste-Agnès de Belcombe.2127 P.V.Plus Manufacturers Ltd.2128 P.V.Plus, manufacturiers ltée.2128 P.V.station service inc.2128 Placements Gilles Neveu inc.(Les).2128 Placements Gil-Po inc.2129 Placements Jean-Yves Neveu inc.(Les).2129 Plomberie L.Chalifoux ltée.2130 Plomberie Ray St-Jcan inc.2130 Prima Maintenance Inc.2130 Produits Sévis inc.2131 Propane Gas Utilities (1970) Limited (Correc- rion).2229 Proulx & Genesse inc.2131 Provincial Association of Miniature Horses (Correction).2229 Quintal (M.) inc.2131 Rapid Gaz Bar inc.2132 Restaurant Jardin Hochelaga inc.2132 Restaurant Rosaire Deshaies ltée.2133 Rioux, Ouellet & Labrie inc.2133 Robert (Hector) inc.2133 Ross (Jean-Paul) inc.2134 St-Bruno Chrysler inc.2134 Ste-Thérèse Roofing Inc.2134 Scierie Manicouagan inc.(La).2135 Service de chaussures dc sûreté de Montréal inc.2135 Service des loisirs Notrc-Dame-de-la-Salette.213e Traductions 530 inc.(Les).2136 Translations 530 Inc.2136 Transport Cliarron ltée.2136 Two Mountains Community Emergency Association Inc.2111 Video Sonic Motivation Inc.2137 Vigneault & frères inc.2137 Zcnirama inc.2138 Lettres patentes Letters Patent supplémentaires supplementary Atome Kitchen Supply Co.Ltd.2138 CJMS Radio Montréal limitée.2139 Lachance (J.B.A.) inc.2139 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 6, 1971, Vol.10S, No.10 2285 Siëges sociaux Head Offices A.I.M.S.Inc.2222 Association des directeurs de théâtre inc.(L') 2220 Développement industriel Lasalle.2221 Fabricants de cercueils LaSalle inc.(Les).2221 Fleuriste place Bonaventure inc.2220 Imprimeries Amyot inc.(Les).2220 Inter-Provincial Mortgage Corporation.2220 Jontec inc.2220 Kebecon Construction Inc.2221 Lafarge Concrete Ltd.2219 Lafarge béton ltée.2219 LaSalle Caskets Manufacturers Inc.2221 Lasalle Industriel Development Corporation.2221 Legault (G.R.) & Associates Inc.2221 Legault (G.R.) & associés inc.2221 Moreault (Pierre) limitée.2222 Nadon (A.H.) inc.2222 Nathanson (H.) Inc.2222 Place Bonaventure Florist Inc.2220 Plomberie P.V.G.Inc.2223 Restaurants Renaissance inc.2222 Services M.E.O.(Montréal) inc.(Les).2221 Shaggy Dog Motel Inc.2222 Société d'entretien du Québec inc.(La).2223 Stalwart Holdings Inc.2223 Trans-Provincial Mortgage Corp.2223 DEMANDES A LA LÉGISLATURE APPLICATIONS TO LEGISLATURE Club de golf Glasgow (1966) inc.- 2226 Commission d'écoles pour la municipalité scolaire de Ville d'Anjou.2148 Congregation Avath Scholom Nusoch Haori.2148 Corporation municipale de St-Donal (La) .2148 Giffard, cité-city.2147 Montréal, ville-city.2147 Municipal Corporation of St-Donat (The)____ 2148 New Glasgow Golf Club (1966) Inc.2226 School Commissioners for the municipality of Ville d'Anjou.2148 Verdun, cité-city.2225 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Baie d'Urfé, ville-town (Annex.).2230 La Martre (Errata).2229 Ste-Anne-de-Bellevue, ville-town (Annex.).2230 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Barachois (Dem.-Appl.).2152 Les-Deux-Rives (Dem.-Appl.).2152 Loretteville, diss.(Prot) (Dem.-Appl.).2227 Montevello, diss.(Dem.-Appl.).2227 Murdochville, diss.(Dem.-Appl.).2228 Portneuf, diss.(Dem.-Appl.).2228 Roberval (Dem.-Appl.).2151 Ste-Adèle, diss.(Dem.-Appl.).2228 St-Émile (Dem.-Appl.).2152 St-Gabriel-de-Gaspé (Dem.-Appl.).2153 St-Sauveur (Prot.) (Dem.-Appl.).2227 Val-Monts (Dem.-Appl.).2152 Institutions Financial financières Institutions compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurance Insurance United Shoe Machinery Company Mutual Relief Association of Canada (Annul.).2144 Terres et forets Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Beaulac, village.2226 Carignan (Rang-Range 11), canton-township.2226 Notre-Dame de Québec (Banlieue-Suburbs), par.2226 Orford, canton-township.2226 St-Mathieu de Beloeil, par.2227 Stratford, canton-township.2227 Travail Labour Industrie ou métiers de: Industry or Trades of: Formation et qualification professionnelle de la main d'oeuvre (Mod.règlements).2237 Vocational training and qualification of manpower (Amend.Regulations).2237 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS Bureau de la division d'enregistrement de Huntingdon, à Huntingdon.2235 Bureau de la division d'enregistrement de Maskinongé, à Louiseville.2234 Bureau de la division d'enregistrement de Napierville, à Napierville-.2233 Bureau de la division d'enregistrement de Yamaska, à St-François du Lac.2232 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Waterloo à la municipalité de Stukely-Sud, comté de Shefford.2231 Extension of the jurisdiction of the Municipal Court of the town of Waterloo to the municipality of South Stukely, county of Shefford.2231 Formation et qualification professionnelle de la main d'oeuvre (Chapitre 51,1969), entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi 2236 Manpower Vocational Training and Qualification Act (Chapter 51, 1969) coming into force of certain provisions of the Act.2236 Office of the registration division of Huntingdon, at Huntingdon.2235 Office of the registration division of Maski-\u2022 nongé, at Louiseville.2234 Office of the registration division of Napierville, at Napierville.2233 Office of the registration division of Yamaska, at St-François du Lac.2232 2286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1971, 103' année, n\" 10 Régie de l'assurance-maladic du Québec Professionnels désangagés ou non-participants Withdrawn or non-participating professionals Québec Health Board Insurance 2238 2238 Régie Québec des marchés Agricultural agricoles du Québec Marketing Board Milk Producers-Suppliers to the Crémerie Révélation Inc.(Amend, to the Joint Plan) 2159 Milk Producers-Suppliers to the Québec Carnation Company (Amend, to the Joint Plan).2162 Milk Producers-Suppliers to the J.J.Joubert Ltd.(Nicolet) (Amend, to the Joint Plan) .2155 Office des producteurs de lait nature, Montréal (Liquidation).2166 Producteurs-fournisseurs de lait à la Crémerie Révélation inc.(Mod.Plan conjoint) .2159 Producteurs-fournisseurs de lait du Québec à la cie Carnation (Mod.Plan conjoint).2162 Producteurs-fournisseurs de lait J.J.Joubert ltée (Nicolet) (Mod.Plan conjoint).2155 Raw Milk Producers-Suppliers Board, Montreal (Liquidation).2166 Société d'habitation Québec Housing du Québec Corporation Municipal Housing Bureau of Victoriaville (Errata).2228 Office municipal d'habitation de Victoriaville (Errata).'.2228 SOUMISSIONS\u2014 TENDERS \u2014 demandes de Requests for Dollard-des-Ormeaux, ville-town.2241 Lac St-Charles, munie.2244 L'Ancienne-Lorette, ville-town.2246 Mercier, ville-town (correction).2256 La Providence, ville-town.2250 Ste-Anne-de-Sorel, par-.2252 St-Bruno-de-Montarville, ville-town.2248 Vaudreuil, c.s.-s.c.2254 SYNDICATS PROFESSIONAL PROFESSIONNELS SYNDICATES Association des employés de salaison fleur dc Lys ltée (L') (Const.-Inc.).2154 Syndicat professionnel des producteurs d'oeufs des Cantons de l'Est (Const.-Inc.).2154 VENTES SALES Effets non réclamés Unclaimed Baggage Canadian National Railway Company.2257 Canadian Pacific Railway Company.2257 Compagnie du chemin de fer canadien Pacifique.2257 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.'.2257 Licitation Licitation Diekmeyer vs Ashby.2259 Hamelin vs Cloutier.2257 Par Shérifs By Sheriffs Montmagny Montmagny Simoneau-Couillard va Théberge.2260 Montréal Montreal Aubin vs Clermont et al.2260 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Michel Construction Inc.2261 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Savignac (Gaston) ltée.2263 Gaudet vs Stern thai.2266 Laval, ville-city vs Luc Construction Inc.2261 Lightstone vs Pert.2261 Montreal city and district savings bank (The) vs Michel Construction Inc.2261 Montreal city and district savings bank (The) vs Savignac (Gaston) ltée.2263 Société des artisans vs Abaca Inc.et al.2263 Pontiac Pontiac Belmont Electrical Supplies Ltd.vs Marcotte 2267 Québec Québec Huiles de Québec ltée (Les) vs Ciiouinard.2269 Tanguay (R.) automobiles ltée vs Roberge____ 2268 Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda Firlotte vs Picco.2269 Saint-François Saint-François Barrées Dion.2269 Trois-Rivieres Three Rivers Banque de Montréal vs Boisvert et al.2270 Bank of Montreal vs Boisvert et al.2270 Taxes Taxes Abitibi, comté-county (correction).2272 Dorchester, comté-county.2272 La Prairie, ville-town.2277 Rigaud, ville-town.2144 Saguenay, comté-county.2144 Ste-Thérèse^Ouest, ville-town.2273 1 gouvernement du québec annuaire téléphonique $1.00 4, œmmunicationsquébec le réseau gouvernemental les postes téléphoniques les postes de téléscripteurs MAINTENANT NOW EN VENTE ON SALE Toute commande est payable d'avance.Les versements se font par mandat-poste ou chèque à l'ordre du ministre des Finances du Québec, adressés à : Prepayment is required with each order.Money orders or cheques should be made payable to the Minister of Finance, Québec, and sent to : L'Editeur officiel du Québec, Hôtel du gouvernement, Québec.The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec."]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.