Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 13 (no 7)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1971-02-13, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" 103» ANNÉE VOL.103 QUEBEC Gazette officielle du Québec QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE N° 7 1601 Québec, samedi 13 février 1971 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazette officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.Québec, Saturday, February 13, 1971 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they arc to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noo^rMalena\"i~~*~^,^_ not delivered in time will appear in abater edition1.'- / t/ Moreover, The Québec Official Publish right to defer publication of certain do of their length or for administrative ro er, reserve's the Lumen I s because [isons.; .PUB.* O L'Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE, Québec Officiai Publither 1602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n\" 7 8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur ofliciel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: §4 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, S10._N.B._\u2014Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocii Lefebvhe.Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1969 37883\u20141-52-0 8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation : S4 per 100 words.Single copies: SI each.Slips: S3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, S20; April 1st to December 31st, $15 and July 1st to December 31st, S10.N.B.\u2014Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once arc followed by our invoice number.Rocu Lefebvke, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, April 30, 1969 378S3\u2014l-52-o Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur ofliciel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec 4, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call : Georges Lapierre Quebec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec 4, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1603 Lettres patentes A.I.M.S.Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Richard Smeaton White, fils, directeur des ventes, 4, rue Greenview, Dollard-des-Ormeaux, Hart Margolian, avocat, 5022, avenue Isabella, et Abraham Arbel, conseiller en administration, 4901, avenue Kent, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de toutes sortes de disques, rubans, bandes sur cassette, rubans en cartouches, films, livres et autre matériel d'enregistrement, de photographie ou d'impression se rattachant à la motivation et au développement personnels, sous le nom de « A.I.M.S.Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $-10 chacune.Le siège social de la compagnie est au 4, rue Greenview, Dollard-des-Ormeaux, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.\u2022 38030 4914-1970 Allen Feeders Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Arthur Laplantc, cultivateur, Bernadette Leblanc, ménagère, épouse dudit Arthur Laplante, tous deux de Ormstown, et William J.Neverett, marchand de bestiaux, Huntingdon, pour les objets suivants: Exploiter une entreprise d'alimentation des bestiaux, sous le nom de « Allen Feeders Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Ormstown, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 4316-1970 Alliance Israélite culturelle (Am Israël Chai) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour d'août 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Harry Rothman, constructeur, 11, chemin Holtham, Milton Winston, notaire, 57l6, Whitehornc, Morris Pekelis, gérant du crédit, 7485, chemin Guelph, Wolf Bialik, manufactu- Letters Patent A.I.M.S.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Richard Smeaton White junior, sales executive, 4 Greenview Street, Dollard-des-Ormeaux, Hart Margolian, advocate, 5022 Isabella Avenue, and Abraham Arbcl, management consultant, 4901 Kent Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes : To manufacture and deal in all kinds of records, tapes, cassette tapes, cartridge tapes, films, books, and other recorded, photographed and printed material relating to personal motivation and development, under the name of \"A.I.M.S.Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,500 common shares of the par value of $10 each and 1,500 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at 4 Greenview Street, Dollard-des-Ormeaux, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4914-1970 Allen Feeders Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Arthur Laplante, farmer, Bernadette Leblanc, housewife, wife of the said Arthur Laplante, both of Ormstown, and William J.Ncverctt, cattle dealer, Huntingdon, for the following purposes: Cattle feeding operations, under the name of \"Allen Feeders Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Ormstown, judicial district of Beauharnois.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-0 4316-1970 Alliance Israélite culturelle (Am Israël Chai) Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Harry Rothman, builder, 11 Holtham Road, Milton Winston, notary, 5716 Whitehorne, Morris Pekelis, credit manager, 7485 Gnclph Road, Wolf Bialik, 1604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1971, 108- année, n° 7 rier, 2035, rue Clark, tous les quatre de Montréal, et Samuel Levine, marchand de crédit, 2315, Paton, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Établir, maintenir et diriger un organisme d'assistance fraternelle dans le but d'unir tous ceux qui croient au rayonnement du peuple juif, sous le nom de « Alliance Israélite culturelle (Am Israël Chai) ».Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le snus-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 3560-1970 American Industrial Research Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de novembre 1970, constituant en corporation : Madeleine Lamothe, secrétaire, épouse de Nelson Jackson, 155, Dcguire, Saint-Laurent, Seymour Machlovitch, 3495, Mountain, Montréal, et Marvin Rosenhck, 335, Grenfell, Mont-Royal, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « American Industrial Research Corporation », avec un capital total de 340,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est h Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.3S630 5111-1970 Anthony Shine Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Claude-Armand Sheppard, avocat, 5030, Glencairn, Huguette Fournier, 8179, 10e avenue, tous deux de Montréal, et Claudine Proutat, 200, Corot, Ile-dcs-Socurs, ces deux dernières secrétaires filles majeures, pour les objets suivants: S'établir conseillers en administration, conseillers industriels et experts dans l'exploitation d'entreprises de toutes sortes, sous le nom de « Anthony Shine Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est au 1935 ouest, boulevard de Maisonneuve, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phii.ippe Bouchard.38630 5160-1970 manufacturer, 2035 Clark Street, all four of Montreal, and Samuel Levine, credit merchant, 2315 Paton, Saint-Laurent, for the following purposes: To establish, maintain and conduct a fraternal service organization uniting all those who believe in the centrality of the Jewish People, under the name of \"Alliance Israélite culturelle (Am Israël Chai)\".The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Inslilutons, Companies and Cooperatives.38630-o 3560-1970 American Industrial Research Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Madeleine Lamothe, secretary, wife of Nelson Jackson, 155 Dcguire, Saint-Laurent, Seymour Alachlovitch, 3495- Mountain, Montreal,\" and Marvin Rosenhek, 335 Grcnfcll, Mount Royal, the latter two advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"American Industrial Research Corporation\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of SI each and 30,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3S630-o 5111-1970 Anthony Shine Inc.Notice is given that under Part I of the Compunies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude-Armand Sheppard, lawyer, 5030 Glencairn, Huguctte Fournier, 8179, 10th Avenue, both of Montreal, and Claudine Proutat, 200 Corot, Ile-des-Soeurs, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on business as management consultants, industrial consultants and advisers and consultants in the operation of all kinds of businesses, under the name of \"Anthony Shine Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1935 de Maison-neuve Boulevard West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-PniLippE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5160-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1071, Vol.103, No.7 Arena Charlevoix incorporée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Camille Brassard, avocat, Clermont, Lina Brisson, secrétaire, lillc majeure, Cap-à-l'Aigle, et René Guay, commis de bureau, Pointe-au-Pic, pour les objets suivants: Administrer un aréna, sous le nom de * Arena Charlevoix incorporée ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $500,000.Le siège social de la corporation est à Clermont, district judiciaire de Sagucnay.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5248-1970 Ash Transportation Service Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Samuel H.Shriar, 2445, Valade, Saint-Laurent, Maximilien Polak, 7897, chemin Wavcll, Côte Saint-Luc, et Harvey M.Coopcr-stone, 1448, Beverley Crescent, Laval, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une entreprise consistant à fournir aux étudiants et autres groupes, du transport par véhicules motorisés, ou un service général d'autobus, sous le nom de « Ash Transportation Service Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5269-1970 L'Association des commerçants du Centre-Ville de Val d'Or inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Leopold Lavoic, 616, 3e Avenue, Roger Landry, 864, 3e Avenue, et Florence Jette, épouse de Adélard Labelle, 799, 3e Avenue, tous trois marchands, de Val d'Or, pour les objets suivants: Étudier, promouvoir, protéger et développer de toutes manières, les intérêts économiques, sociaux et professionnels des membres, sous le nom de* L'Association des commerçants du Centre-Ville de Val d'Or inc.».1605 Arénu Charlevoix incorporée Notice is given that under Part DT of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Camille Brassard, advocate, Clermont, Lina Brisson, secretary, spinster of the full age of majority, Cap-à-1'Aigle, and René Guay, office clerk, Pointe-au-Pic, for the following purposes: To manage an arena, under the name of \"Arena Charlevoix incorporée\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire ami possess, is $500,000.The head office of the corporation is at Clermont, judicial district of Sagucnay.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5248-1970 Ash Transportation Service Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Samuel H.Shriar, 2445 Valade, Saint-Laurent, Maximilien Polak, 7897 Wavcll Road, Côte Saint-Luc, and Harvey M.Coopcrstone, 1448 Beverley Crescent, Laval, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of providing motor-vehicle transportation for students and other groups, and bus services generally, under the name of \"Ash Transportation Service Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-O 5269-1970 L'Association des commerçants du Centre-Ville de Val d'Or inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Leopold Lavoic, 616, 3rd Avenue, Roger Landry, 864, 3rd Avenue, and Florence Jette, wife of Adélard La-belle, 799, 3rd Avenue, all three merchants, of Val d'Or, for the following purposes: To study, promote, protect and develop in every way the economic social and professional interests, under the name of \"L'Association des commerçants du Centre-Ville de Val d'Or inc.\". 1606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 108- année, n° 7 Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $30,000.Le siège social de la corporaton est à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniuppE Bouchard.38630-o 3848-1969 The amount to which is to be limited the value of the real estate which the corporation may acquire or possess is $30,000.The head office of the corporation is at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 3848-1969 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Van Home Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Viin Home School Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de novembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Niko-laos Katerclos, peintre, 4301, avenue Linton, app.3, Michael Mourclatos, directeur de restaurant, 4030, avenue Linton, app.5, et George Dimopoulos, chauffeur de taxi, 4400, avenue Linton, app.5, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir la coopération entre parents, élèves et professeurs de l'école Van Home, sous le nom de « Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Van Home \u2014 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Van Home School ».Le montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que peut posséder ou détenir la corporation est de $40,000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.IjC sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Aldert Gagnon.38630 5070-1970 Association de villégiature du Lac Fer à Cheval Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Guy Massicotte, gérant, 34, rue de Vaudreuil, Yvon Délisle, entrepreneur, 28, me Ramczay, Maurice Carpentier, secrétaire-trésorier, 10, Père Gamier, Isidore D'Astous, sergent de police, 70, avenue Père-Arnaud, tous quatre de Baie-Comeau, et Claude Perreault, évaluateur, 197, Rouleau, Hauterive, pour les objets suivants: Grouper les personnes intéressées a la cause de la villégiature aux Lac Fer à Cheval, Lac St-Joseph et Lac Cinq Cents, sous le nom de « Association de villégiature du Lac Fer à Cheval ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est de $100,000.Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Van Home Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Van Home School Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Nikolaos Katerelos, painter, 4301 Linton Avenue, Apt.3, Michael Mourelatos, restaurant manager, 4030 Linton Avenue, Apt.5, and George Dimopoulos, taxi driver, 4400 Linton Avenue, Apt.5, all three of Montreal, for the following purposes: To promote co-operation between the parents, the pupils and teachers, under the name of \"Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Van Home \u2014 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Van Home School\".The amount to which the value of the immoveable property which may be owned or held by the corporation, is to be limited, is $40,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Aldert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5070-1970 Association de viUégiaturc du Lac Fer à Cheval Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Guy Massicotte, manager, 34 Vaudreuil Street, Yvon Déhslc, contractor, 28 Ramczay Street, Maurice Carpentier, secretary-treasurer, 10 Père Gamier, Isidore D'Astous, police sergent, 70 Père-Arnaud avenue, all four of Baie-Comeau, and Claude Perreault, evaluator, 197 Rouleau, Hauterive, for the foUowing purposes: To group together persons interested in the problems of organizing resorts at Lac Fer à Cheval, Lake St-Joseph and Lac Cinq Cents, under the name of \"Association de villégiature du Lac Fer à Cheval\".The amount to which is to be limited the value of the immovable property which the corporation may acquire or possess is $100,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 Le siège social de la corporation est à Baic-Comeau, district judiciaire de Hauterive.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5423-1970 L*Association Québécoise des Fabricants de tuyau de béton inc.Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Fcrnand Biais, 53, rue Blanchctte, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, René Lapointc, 1319, rue Preston, Sillery, tous deux avocats, et Mireille Bclzilc, secrétaire, fille majeure, 941, rue Pouliot, Saintc-Foy, pour les objets suivants: Organiser et tenir des conférences, réunions, assemblées, expositions sur la promotion, le développement et la vulgarisation de la science et de la technique du produit du tuyau de béton, dans ou en dehors de la province de Québec, sous le nom de « L'Association Québécoise des Fabricants de tuyau de béton inc.\u2014 Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 550,000.Le siège social de la corporation est à Ch&tcauguay, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniLiPPE Bouchard.38630-o 5643-1970 \"Auto American Shop L.S.Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de décembre 1970, constituant en corporation: Theodore H.Polisuk, avocat, 71, chemin Hampstcad, Joyce Larivière, 10731, Renault, et Elaine Engclberg, 5774, avenue Léger, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce d'automobiles, moteurs d'automobiles, moteurs, pièces et accessoires d'automobiles, sous le nom de « Auto American Shop L.S.Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.lie sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5305-1970 1607 The head office of the corporation is at Baie-Comeau, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5423-1970 L'Association Québécoise des Fabricants de tuyau de béton inc.Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Fernand Biais, 53 Blanchctte Street, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, René Lapointc, 1319 Preston Street, Sillery, both advocates, and Mireille Belzilc, secretary, spinster of the full age of majority, 941 Pouliot Street, Sainte-Foy, for the following purposes: To organize and hold lectures, assemblies, meetings, exhibitions, on the promotion, development and vulgarisation of science and the technic of concrete pipe product, in or outside the province of Québec, under the name of \"L'Association Québécoise des Fabricants de tuyau de béton inc.\u2014 Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $50,000.The head office of the corporation is at Châteauguay, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5643-1970 Auto American Shop L.S.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Theodore H.Polisuk, advocate, 71 Hampstead Road, Joyce Larivière, 10731 Henault, and Elaine Engelberg, 5774 Léger Avenue, the latter two secretaries, spinsters, all three of Montreal, for the following purposes : To manufacture and deal in automobiles, automobile engines, motors and automotive parts and accessories of all kinds, under the name of \"Auto American Shop L.S.Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5305-1970 1608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n\" 7 Les automates Purent liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Bernard Parent, directeur de relations extérieures, Muxinc Bossé, ménagère, épouse dudit Bernard Parent, tous deux de 410, Grande-Allée, Saint-Jérôme, et Roland Côté, gérant, 1245, 10e Rue, Saint-Antoine, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Les automates Parent ltéc », avec un capital total de §40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 390 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppk Bouchard.38630-o 5586-1970 B & G Sales Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en, vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Julian Kotler, 5S00, Hudson, Côte Saint-Luc, Harold W.Ashcnmil, 453, Mitchell, Mont-Royal, tous deux avocats, et Rima Randolph, secrétaire, épouse «le Malcolm Singer, 1540, Summerhill, Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises, fabriqués en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, substances plastiques, fourrure, textile, verre et de leurs sous-produits, sous le nom de « B & G Sales Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5097-1970 B.M.Woodwork Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Ernst Burmcister, entrepreneur en menuiserie, 12418, boulevard Richer, Pierrefonds, Fritz Mayer, entrepreneur, et Thérèse Mayer, ménagère, épouse dudit Fritz Mayer, ces deux derniers du 604, Jardin Sainte-Dorothée, Laval, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « B.M.Woodwork Inc.», Les automates Parent ltéc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and.Cooperatives, incorporating: Bernard Parent, exterior relations director, Maxinc Bossé, housewife, wife of said Bernard Parent, both of 416 Grande-Allée Saint-Jérôme, and Roland Côté, manager, 1245, 10th Street, Saint-Antoinc, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Les Automates Parent ltéc\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of SI each and 390 preferred .shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5586-1970 B & G Sales Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Julian Kotler, 5806 Hudson, Côte Saint-Luc, Harold W.Ashcnmil, 453 Mitchell, Mount Royal, both advocates, and Rima Randolph, secretary, wife of Malcolm Singer, 1540 Summerhill, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise, made in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products thereof, under the name of \"B & G Sales Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of a par value of S10 each and 3,000 preferred shares of a par value of S10 each.The head office of the company is at Saint-Luurent, judicial district of Montreal.Ls-Piiimppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5097-1970 B.M.Woodwork Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of December, 1970, have been issued by the Miniter of Financiul Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ernst Burmeistcr, carpenter contractor, 12418 Richer Boulevard, Pierrefonds, Fritz Mayer, contractor, and Thérèse Mayer, housewife, wife of the said Fritz Mayer, the latter two of 604 Jardin Ste-Dorothée, Laval, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"B.M.Wood- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.10S, No.7 avec un capital total de S40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et 20,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est au 604, Jardin Sainte-Dorothée, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-vrinistre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630 5245-1970 Baysidc Investments Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation : David Katznclson, 5526, avenue Ashdale.Côte Saint-Luc, Sandor Jack Klein, 6300, avenue Lennox, et Ralph Lipper, 1550, avenue McGregor, ces deux derniers de Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de iwrtefeuillc et de placement, sous le nom tie « Baysidc Investments Ltd.», avec un capital total de 540,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 36,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 81 chacune.Le siège social de la compagnie est à 1, place Ville-Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Phiuppe .Bouchard.38630 5367-1970 Jean-Guy Bcaucliemin inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Gilles Coulombe, avocat, route rurale #1, Lennoxville, Françoise Fouquet, 1011, McManamy, et Solangcs Manseau, 488, London, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de «Jean-Guy Beauchcmin inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et en 3,900 actions-privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 44, rue Lomas, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le soits-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5180-1970 La belle reliure de Montréal inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de novembre 1970, consti- 1609 work Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 20,000 common shares of SI each and 20,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at 604 Jardin Ste-Dorothée, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5245-1970 Bayside Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: David Katznclson, 5526 Ashdale Avenue, Côte Saint-Luc, Sandor Jack Klein, 6300, Lennox Avenue, and Ralph Lipper, 1550 McGregor.Avenue, the latter two of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment company, under the name of \"Bayside Investments Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of the par value of $1 each and 36,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 1 Place Ville Marie, Suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5367-1970 Jean-Guy Beauchcmin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles Coulombe, advocate, Rural Route No 1, Lennoxville, Françoise Fouquet, 1011 McManamy, and Solanges Manseau, 488 London.the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Jean-Guy Beauchcmin inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of SI each and 3,900 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 44 Lomas Street, Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5180-1970 La belle reliure de Montréal inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporât- 1610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n' 7 tuant en corporation: Jacques Morand, notaire, 4894, Valéry, Saint-Léonard, Mariette Henry, épouse de Réjean Jobin, 6180, Roi René, Anjou, et Gisèle Dcs-i roches, épouse de Jean-Marie Langlois, 624, Taillon, Montréal, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Faire affaires Comme éditeurs, imprimeurs, graveurs, relieurs et publicistes, sous le nom de « La belle reliure de Montréal inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 20,000 actions privilégiées d'une valeur nominulc de SI chacune.Le siège social de la compagnie est 8120, rue Viau, Montréal, district judiciaire de Montréal.N.B.Le présent avis annule et remplace celui publié dans le numéro 3 de la Gazelle officielle du Québec, du 16 janvier 1971, à la page 324, sous le titre « Les relieurs R & P inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.38630-o 4777-1970 C.K.Blair Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation: C.Kyle Blair, William Blair et Robert Blair, tous trois propriétaires de camions de transport, de Franklin, pour les objets suivants: Exploiter une entreprise de service de transport par camions, sous le nom de « C.K.Blair Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Franklin, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5051-1970 Blanchctte & Blanchctte inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Aurore Blanchette, gérant, Claude Blanchette, secrétaire, et Gilles Houde, comptable, tous trois de Saint-Gérard, pour les objets suivants : Industrie et commerce de bois, sous le nom de « Blanchette & Blanchette inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Gérard, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4780-1970 ing: Jacques Morand, notary, 4894 Valéry, Saint-Léonard, Mariette Henry, wife of Réjean Jobin, 6180 Roi René, Anjou, and Gisèle Desroches, wife of Jean-Marie Langlois, 624 Taillon, Montreal, the latter two secretaries, for the following purposes: To carry on business as editors, printers, engravers, bookbinders and publicists, under the name of \"La belle reliure «le Montréal inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of a nominal value of SI each and 20,000 preferred share of a nominal value of $1 each.The head office of the company is at 8120 Viau ' Street, Montreal, judicial district of Montreal.N.B.The present notice cancels and replaces the one published in issue number 3 of the Québec Official Gazette of January 16, 1971, on page 324, under title \"Les relieurs R & P inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4777-970 C.K.Blair Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: C.Kyle Blair, William Blair and Robert Blair, all three truck transportation owners, of Franklin, for the following purposes: To operate a trucking and transportation service, under the name of \"C.K.Blair Inc.\", with a total capital stock of S40,000, divided into 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company is at Franklin, judicial district of Beauharnois.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5051-1970 Blanchette & Blanchctte inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Aurore Blanchette, manager, Claude Blanchette, secretary, and Gilles Houde, accountant, all three of Saint-Gérard, for the following purposes: Industry and trade of wood, under the name of \"Blanchette & Blanchette inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of S100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Saint-Gérard, judicial district of Saint-François.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4780-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 John Bland Incorporated Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Claude-Armand Sheppard, avocat, 5030, Glencairn, Huguettc Fournier, 8179, 10c avenue, tous deux de Montréal, et Claudine Proutat, 200, Corot, Ile-des-Soeurs, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants : S'établir conseillers en administration, conseillers industriels, experts et conseillers dans l'exploitation ration pur lettres patentes dutées du 8e jour de murs 1939; « Cluirol Inc.of Canada», constituée en corporation par lettres patentes datées du 19e jour de février 1940; et « Perfcx Company Limited», constituée en corporation pur lettres patentes datées du 12e jour de juillet 1956, toutes ces lettres patentes ayunt été émises en vertu de ludite première partie de la Loi des compagnies, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de marchandises, articles et produits, sous le nom de « Bristumalg Limited», avec un capital de 100,000 actions sans valeur au pair et la valeur globale de l'émission desdites actions ne devra pas excéder en montant ou en valeur la somme de 85,622,900.Le siège social de la nouvelle compagnie est au local 1203, 5, place Ville Marie, Montréal, district judiciaire de Montréal.IjC sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030 5744-70 Bristumalg Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, dated the 30th day of December 1970, have l>cen issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Bristol Laboratories of Canada, Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 4th day of August, 1947, \"Chanteclerc (Limitée)\", incorporated by letters patent dated the 8th day of March, 1939, \"Clairol Inc.of Canada\", incorporated by letters patent dated the 19th day of February, 1940, and \"Perfex Company Limited\", incorporated by letters patent dated the 12th day of July, 1956, all such letters putcnt huving been issued under the said Part I of the Companies Act, for the following purposes: To manufacture and deul in ull kinds of goods, wares and merchandise, under the name of \"Bristamalg Limited\", with a capital stock of 100,000 shares without par value and the aggregate consideration for the issue of the said shares shall not exceed in amount or value the sum of 85,622,900.The head office of the new company is at Suite 1203, 5 Place Ville Marie, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5744-70 C.L.Distribution inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Gérard Fortier, agent, 2055, avenue du l'arc, J.-Charles Laganièrc, homme d'affaires, et Thérèse Bouchard, ménagère, épouse dudit J.-Charles Laganièrc, ces deux derniers de 3760, Nérée Beauchcmin, tous trois de Trois-Rivières, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents distributeurs de billets de loteries de Loto-Québec, sous le nom de « C.L.Distribution inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 1435, Place de l'Hôtel de Ville, Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5039-1970 C.L.Distribution inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérard Fortier, agent, 2055 Park Avenue, J.-Charles Laganière, businessman, and Thérèse Bouchard, housewife, wife of the said J.-Charlcs Laganière, the latter two of 3760 Nérée Beauchcmin, all three of Trois-Rivièrès, for the following purposes: To do business as distributing agents of lottery tickets for Loto-Québec, under the name of \"C.L.Distribution inc.\", with a total capital stock of 840,000 divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 1435 Place de l'Hôtel de Ville, Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, .Companies and Cooperatives.38630 5039-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 Carrefour d'entr'aide et bénévolat il\"- Richelieu inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-action - : Bernadette (julien, ménagère, épouse de Emile Bernard, 3325, rue des Érables, Tracy, Gilles Simard, agent d'immeubles, 153, chemin de Ste-Annc, et Rodrigue Lussier, courtier d'assurances, 281, rue du Roi, ces deux derniers de So-rel, pour les objets suivants : Établir et exploiter un centre de bénévolat pour dispenser, donner et diffuser tout genre de service bénévole d'entr'aide et de charité, sous le nom de « Carrefour d'entr'aide et bénévolat de Richelieu inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de §100,000.I-e siège social de la corporation est 124, rue Georges, Sorel, district judiciaire de Richelieu.Le sous-m inistre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5543-1970 Le carrefour Papineau ltéc l.c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Isidore Greenbauin, 615, West-lukc, Cote Saint-Luc, Baruch Pollack, 6085, de Vimy, et Aaron Pollack, 900, Rockland, ces deux derniers d'Ou-tremont, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Le carrefour Papineau Itée », avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5178-1970 Cayne Insurance Agencies Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Abel Selick, 1605; chemin Norway, Mont-Royal, Martin Gross, 190, Nethcrwood, Hampstead, et Gordon Zclman, 447 Nord, Wolseley, Montréal-Ouest, tous trois avocats, pour les objets suivants: S'établir agents et courtiers en assurances, sous le nom de « Cayne Insurance Agencies Inc.», avec un 1615 Carrefour d'entr'aide et bénévolat de Richelieu inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Bernadette Cullcn, housewife, wife of Emile Bernard, 3325 Érables Street, Tracy, Gilles Simard, real estate agent, 153 Ste-Annc Road, and Rodrigue Lussier, insurance broker, 281 Roi Street, the latter two of Sorel, for the following purposes: To establish and operate a bcnevolant center for the distributing, granting and diffusing of all kinds of mutual aid and charity bencvolant services, under the name of \"Carrefour d'entr'aide et bénévolat de Richelieu inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $100,000.The head office of the corporation is at 124 Georges Street, Sorel, judicial district of Richelieu.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5543-1970 Le carrefour Papineau ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Isidore Greenbaum, 615 Westluke, Côte Saint-Luc, Baruch Pollack, 6085 dc Vimy, and Aaron Pollack, 900 Rockland, the latter two of Outremont, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Le carrefour Papineau ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5178-1970 Cayne Insurance Agencies Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Abel Selick, 1605 Norway Road, Mount Royal, Martin Gross, 190 Netherwood, Hampstead, and Gordon Zelman, 447 Wolsclcy North, Montreal West, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as agents and insurance brokers, under the name of \"Cayne Insurance Agencies Inc.\", 161G GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1S février 1971, 103' année, n° 7 capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie est au 1,' Carré Westmount, Westniount, district judiciaire de Montréal.Le sont-ministre des institutions financières, compagnies ci coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030 4913-1970 with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of a par value of SI each and 390 preferred shares of n par value of 8100 each.The head office of the company is at 1 Westmount Square, Westmount, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38G30-o 4913-1970 Centre Audio de Chicoulimi inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, il a accordé fies lettres patentes, en date du 3c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Léo Marcil, gérant, 625, des Hospitalières, Roger Hudon, 1018, Pierrc-Bédard, et Yves Champagne, 79, Francocur, ces deux derniers techniciens, tous trois de Chicoulimi, pour les objets suivants: Faire le commerce d'appareils et pièces électroniques ou électriques et autres accessoires, sous le nom de « Centre Audio de Chicoulimi inc.», avec un capital total de 875,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5348-1970 Centre Audio de Chicoulimi inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Léo Marcil, manager, 625 des Hospitalières, Roger Hudon, 1018 Pierrc-Bédard, and Yves Champagne 79, Francocur, the latter two technicians, all three of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in electrical or electronic apparatus and parts and all other accessories, tinder the name of \"Centre Audio tic Chicoulimi inc.\", with a total capital stock of S75.000, divided into 5,000 common shares of a nominal value of S10 each and 250 preferred shares of a nominal value of SI 00 each.The head office of the company is at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5348-1970 Centre d'études des réformes sociales tic Québec inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu tie la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé tics lettres patentes, en date tlu 7c jour tic décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: André Sasscvillc, professeur, 1194, Colbert, app.309, Sainte-Foy, Bertrand Laroche, comptable, 2646, Pierre Boucher, Québec, et Yves Roy, étudiant, 974, Casot, Sillery, pour les objets suivants: Établir un service d'études et de recherches sur les problèmes sociaux, économiques et humains, sous le nom de « Centre d'études des réformes sociales de Québec inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est de S200.000.Le siège social de la corporation est ù Québec, district judiciaire de Québec.Ix sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5395-1970 Centre d'études tics réformes sociales de Québec inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing tlate the 7th day of October.1970, have been issuctl by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation: without share capital: André Sasscvillc, professor, 1194 Colbert, Apt.309, Sainte-Foy, Bertrand Laroche, accountant, 2646 Pierre Boucher, Québec, and Yves Roy, student, 974 Casot, Sillcry, for the following purposes: To establish a study antl research service for social economical and human problems, under the name of \"Centre d'études des réformes sociales de Québec inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable properly that the corporation may acquire and hold is 8200,000.The head office of the corporation is al Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5395-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February IS, 1971, Vol.103, No.7 1617 Centre Équestre Olympique inc.Olympic Equestrian Centre Inc.Le ministre eles institutions financières, compagnies et cooperatives donne avis, qu'en vertu de la première purtie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Bernard Desjarlais, 1600, Stephens, Verdun, Louis Vaillancourt, 4519, Oxford, et Roui a Cousineau, 5652, Drake, ces deux derniers de Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Dispenser des cours pour l'étude et l'avancement de l'art de l'équitation, sous le nom de « Centre Équestre Olympique inc.\u2014 Olympic Equestrian Centre Inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chucunc.Le siège social de la compagnie est à Verdun, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phii.ippe Bouchard.38630-o 5119-1970 Centre Gullcgo de Montréal Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19c jour de novembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Manuel Rodriguez, projectionniste, 2440, rue Gold, #401, Saint-Laurent, .luan Martinez, 431, St-Urbain, Montréal, et Francisco Lopez, 5360, Joseph, Saint-Hubert, ces deux derniers mécaniciens, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Centre Gallcgo de Montréal ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de SI,000,000.\\a: siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, La-Phimppk Bouchard.38630-o \u2022 5077-1970 Cercle d'études en conduite automobile (C.E.C.A.) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour de novembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Hervé Lan-gevin, 6755, 21e Avenue, app.3, Michel Labbô, 9167, Foucher, Paul LeBlanc, 1264, Laurier est, J.-Paul Spedding, 5808, boulevard St-Michel, Marcel Miron, 6745, de Lanaudièrc, René Valiquette, 5857, Iberville, Jean-Luc Bonneville, 2570, Granby, app.101, tous sept tie Montréal, Leopold Boudreault, 2350, Park Row ouest, Joseph Juneau, 8534, Chantcnay, Éliane Lan-thier, fille majeure, 9042A, Jamay, et Ginette Desmarais, épouse de Michel Desmarais, 8707, Barbeau, ces tjuatre derniers de Saint-Léonard, tous monitetirs, pour les objets suivants: Centre Équestre Olympique inc.Olympic Equestrian Centre Inc.Notice is given that untler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing tlatc the 24th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bernard Desjarlais, 1600 Stephens, Verdun, Louis Vaillancourt, 4519 Oxford, antl Roma Cousineau, 5652 Drake, the latter two of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To give courses for the study and promotion of equestrian art, untler the name of \"Centre Équestre Olympique inc.\u2014 Olympic Equestrian Centre Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company is at Verdun, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5119-1970 Centre Gallcgo de Montréal Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Manuel Rodriguez, projectionist, 2440 Gold Street, #401, Saint-Laurent, Juan Martinez, 431 St-Urbain, Montreal, antl Francisco Lopez, 5360 Joseph, Saint-Hubert, the Intter two mechanics, for the following purposes: Organization of recreational activities, under the name of \"Centre Gallego de Montréal ».The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is SI ,000,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 \u2022 5077-1970 Cercle d'études en conduite automobile (C.E.C.A.) Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Hervé Langevin, 6755, 21st Avenue, Apt.3, Michel Labbé, 9167 Foucher, Paul LeBlanc, 1264 Laurier East, J.-Paul Spedding 5808 St-Michel Boulevard, Marcel Miron, 6745 de Lanaudièrc, René Valiquette, 5857 Iberville, Jean-Luc Bonneville, 2570 Granby, Apt.101, all seven of Montreal, Leopold Boudreault, 2350.Park Row, West, Joseph Juneau, 8534 Chantenay, Éliane Lanthier, spinster of the full age of majority, 9042A Jamay, and Ginette Desmarais, wife of Michel Desma-rais, 8707 Barbeau, the latter four of Saint-Léonard, all monitors, for the following purposes: 1618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Étudier , promouvoir, protéger et développer de toutes manières les intérêts économiques, sociaux et professionnels des membres, sous le nom de « Cercle d'études en conduite automobile (C.E.C.A.) ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $100,000.Le siège social de la corporation est 1600, rue Berri, chambre 3149, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Ls-PlIILIPPE bouchard.38630-o 5131-1970 Chûtcaiiguay Convenience Food Store Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Arthur Yanofsky, avocat, 5872, Ferncroft, Hampstcad, Sheila Raymond, 89, Roxton Crescent, et Grace Ulackett, 5622 ouest, rue Sherbrooke, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles, produits et marchandises de toutes sortes et de toutes descriptions se rattachant à l'épicerie, y compris la bière, sous le nom de « Châtcauguay Convenience Food Store Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Châtcauguay, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5459-1970 Cie de produits Rodico liée Rodico Products Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Diane Ballabey, épouse d'Ernest Desjardins, 355, 15c rue, Laval, Karen Frances Ditkof-sky, épouse de Robert Nathan, 1295, Jules Poitras, Montréal, et Myrna Rosalind Center, épouse de Morton Sachs, 5507, Jellicoc, Côte Saint-Luc, toutes trois ménagères, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce d'articles brevetés, produits industriels et la réparation de montres et horloges, sous le nom de « Cie de produits Rodico ltée \u2014 Rodico Products Co.Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.To study, promote, protect and develop in all manners the economical social and professional interest of its members, under the name of \"Cercle d'études en conduite automobile (C.E.C.A.)\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $100,000.The head office of the corporation is at 1600 Bcrri Street, suite 3149, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5131-1970 Châtcauguay Convenience Food Store Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Arthur Yanofsky, advocate, 5872 Fern-croft, Hampstcad, Sheila Raymond, 89 Roxton Crescent, and Grace Blackctt, 5622 Sherbrooke Street West, the latter two secretaries, filles majeures, of Montreal, for the following purposes: To deal in goods, wares and merchandise of all kinds and descriptions connected with groceries, including beer and ale, under the name of \"Châtcauguay Convenience Food Store Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of SI each and 3,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Châtcauguay, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, CompaJiies and Cooperatives.38630-o 5459-1970 Cie de produits Rodico ltée Rodico Products Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Diane Ballabey, wife of Ernest Desjardins, 355, 15th Street, Laval, Karen Frances Ditkofsky, wife of Robert Nathan, 1295 Jules Poitras, Montreal, and Myrna Rosalind Center, wife of Morton Sachs, 5507 Jellicoc, Côté Saint-Luc, all three housewives, for the following purposes: To manufacture and deal in patent items, industrial products and to repair watches and clocks, under the name of \"Cie de produits Rodico ltéc \u2014 Rodico Products Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 20,000 common shares of a par value of $1 each and 2,000 preferred shares of a par value of $10 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 1619 Le siege social de la compagnie est au 455 ouest, rue Craig, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-min islre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030 4895-1970 The head office of the company is at 455 Craig Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4895-1970 Club autos sports de Laviil Ouest Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour de novembre 1970, constituant en cor|>oration sans capital-actions: Jacques Charette, professeur, Michel Charettc, journalier, tous deux de 2510, 21e Avenue, Laval, et Michel St-Vincent, notaire, 287, O'Shéa, Saint-Jérôme, pour les objets suivants: Exploiter un club d'automobiles, dont les activités principales sont de promouvoir le sport de l'automobile, les rallyes automobiles, les écoles de conduite, ainsi que tout ce qui louche de près ou de loin les sports de l'automobile, sous le nom de « Club nutos sports de Laval Ouest».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que ]>cut acquérir et posséder la corporation, est de $20,000.Le siège social de la corporation est 2510, 21e Avenue, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 5104-1970 Club autos sports de Laval Ouest Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters paient, bearing date the 20th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies antl Cooperatives, incorporating: Jacques Charclte, professor, Michel Charette, labourer, both of 2510, 21st Avenue, Laval, and Michel St-Vincent, notary, 287 O'Shéa, Suint-Jérôme, for the following purposes: To operate an automobile club, of which the principal activities arc to promote sporting activities respecting cars, automobile rallies, driving schools, ns well as everything which concerns automobile sporting events, under the name of \"Club nutos sports de Laval Ouest\".The umount to which is to be limited the value of the real estate which the corporation may acquire or possess is to be S20.000.The head office of the company is at 2510, 21st Avenue, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3S630 5104-1970 Club dc golf St-Laurcnl incl St.Lawrence Golf Club Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Louis Baillargeon, notaire, 615, Chouinnrd, Raymond Gagnon, 1178, 1ère Avenue, tous deux dc Québec, Jacques Blanchard, 1430, Godefroy, Sillery, tous deux avocats, Michel Mainville, arpenteur, 872, Plucc Beloeil, Sainte-Foy, et André Gingras, golfeur professionnel, 12S, chemin du Bout de l'Ile, Beaulieu, pour les objets suivants: Former et administrer un club sportif cl promouvoir en particulier le sport du golf, du tennis, de lu pétanque, du « curling » cl dc la natation, sous le nom dc « Club de golf St-Laurent inc.\u2014 St.Lawrence Golf Club Inc.», avec un capital total dc $500,000, divisé en 500 actions ordinaires dc S400 chacune et en 1,500 actions privilégiées de $200 chacune.Le siège social dc la compagnie est ù Suint-Laurent, Ile d'Orléans, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 5375-1970 Club de golf St-Laurent inc.St.Làwrcnco Golf Club Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Louis Bnillurgeon, notary, 615 Cliouinard, Raymond Gagnon, 1178, 1st Avenue, both of Québec, Jacques Blanchard, 1430 Godefroy, Sillery, both advocates, Michel Mainville, land-surveyor, 872 Place Beloeil, St.Foy, und André Gingras, professional golfer, 128 Bout dc l'llc road, Beaulieu, for the following purposes: To found and administer a sports club and to promote in particular golf, tennis, pétanque, curling and swimming, under the name of \"Club de golf St-Laurcnt inc.\u2014 St.Lawrence Golf Club Inc.\", with a total capital stock of S500.000, divided into 500 common shares of $400 each and 1,500 preferred shares of $200 each.The head office of the company is at St.Lawrence, Island of Orleans, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3SG30 5375-1970 1620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n\" 7 Club dc moto-neige les Montagnards de Saint-Alban inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Yves Rivard, hôtelier, 254, Principale, Jean-Pierre Sauva-geau, boucher, 7, St-Philippe, et Loreltc Pctitclcrc, ménagère, épouse de Rosario Laquerre, 11, St-Philippe, tous trois de Saint-Alban, pour les objets suivants: Administrer un club dc moto-ncigistes, sous le nom de « Club dc moto-ncige les Montagnards dc Saint-Alban inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corpora-' tion, est de 820,000.Le siège sociul de la corporation est à Saint-Alban, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5360-1970 Club dc natation Laval Laval Swimming Club Le ministre des institutions financières, compagnies, et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Adélard Goyette, assistant-technicien, 104, 10c Avenue est, Marcel Dupras, laitier, 181, Meunier, André Gougcon, voyageur, 155, 7c Avenue, Monique Bénard, ménagère, épouse de Denis Laroche, 60, 8e Rue, et Edmond Gratton, relieur, 550, d'Auteuil, tous cinq dc Laval, pour les objets suivants: Donner aux nageurs qui le désirent des possibilités d'entraînement et de compétition, sous le nom de « Club dc natation Laval \u2014 Laval Swimming Club ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8100,000.Le siège social de la corporation est 104, 10c Avenue est, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5336-1970 Club d'dquitation de Rivifcre-du-Loup inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Pierre Richard, médecin, 110, rue Laval, Bastien Méthot, industriel, 4, Hôtel de Ville, et Guy Sirois, vendeur, 13, des Vétérans, tous trois dc Rivièrc-du-Loup, pour les objets suivants: Club dc moto-ncige les Montagnards dc Saint-Alban inc.Notice is given that under Part ni of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Yves Rivard, hotel keeper, 254 Main, Jean-Pierre Sauvageau, butcher, 7 St-Philippe, and Lorcttc Petil-clerc, housewife, wife of Rosario Laqucrrc, 11 St-Philippc, all three of Saint-Alban, for the following purposes: To manage a snowmobile club, under the name of « Club de moto-neige les Montagnards dc Saint-Alban inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is 820,000.The head office of the corporation is at Saint-Alban, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5360-1970 Club dc natation Laval.I .aval Swimming Club Notice is given that under Part ni of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Adélard Goyctte, assistant technician, 104, 10th Avenue East, Marcel Dupras, milkman, 181 Meunier, André Gougcon, traveller, 155, 7th Avenue, Monique Bénard, housewife, wife of Denis Laroche, 60, 8th Street, and Edmond Gratton, bookbinder, 550 d'Auteuil, all five of Laval, for the following purposes: To grant training and competing possibilities to the swimmers wishing the latter, under the name of \"Club de natation Laval \u2014 Laval Swimming Club\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is S100.000.The head office of the corporation is at 104, 10th Avenue East, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5336-1970 Club d'équitation de Rivière-du-Loup inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Jean-Pierre Richard, physician, 110 Laval Street, Bastien Méthot, industrialist, 4, Hôtel de Ville, and Guy Sirois, salesman, 13 des Vétérans, all three of Rivière-du-ïx>up, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Exploiter un club sportif et promouvoir en particulier le sport de l'équitation, sous le nom de « Club d'équi-tation dc Rivière-du-Loup inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $50,000.Le siège social dc la corporation est à Rivière-du-Loup, district judiciaire de Kamouraska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, LS-PlIILIPPE Bouchard.38630-o 5366-1970 Club de Moto-neige les Campagnards inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il n accordé des lettres patentes, en date du 24c jour dc novembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Robert Fcrlaud, commerçant, 105S, Notre-Dame nord, Laurent Vaelion, 75S, Marcoux, et Jean-Paul Leroux, 371, Marcoux, ces deux derniers mineurs, tous trois dc Thctford Mines, pour les objets suivants: Former et administrer un club sportif et promouvoir en particulier le sport de la inoto-neige, sous le nom de « Club dc Moto-neige les Campagnards inc.».Le montant auquel sont limités les revenus provenant des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de S100.000.Le siège social de la corporation est à Saintc-Anne-ilu-l.ae.district judiciaire de Mégantic.Ixsous-miiiislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 4807-1970 Club des Castors dc Buckingham Buckingham Beavers Club Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie delà Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Robert Pearson, Denis Tremblay, tous deux électriciens, John C.Campbell, Hilary Lawliss, Chcsley Ladouceur, Raymond Delcourt, tous quatre commis, Don Ncilson, marchand, Jean-Marc Chicoine, assistant-comptable, Aimé Racine, journalier, Alan Whytc, machiniste, Lionel Clément, peintre, Denis Montreuil, avocat, et Léonard Tremblay, entrepreneur, tous de Buckingham, pour les objets suivants: Exploiter un club sportif et promouvoir en parti-I ier le sport de hockey, sous le nom de « Club des Castors de Buckingham \u2014 Buckingham Beavers Club ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc 8100,000.Le siège social dc la corporation est à Buckingham, district judiciaire de Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5275-1970 1621 To operate a sport club and to promote in particular riding sport, under the name of \"Club d'équitation de Rivière-du-Loup inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $50,000.The head office of the corporation is at Rivière-du-Loup, judicial district of Kamouraska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5366-1970 Club de Moto-ncige les Campagnards inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Robert Ferland, trader, 1058 Notre-Dame North, Laurent Vachon, 75S Marcoux, and Jean-Paul Leroux, 371 Marcoux, the latter two miners, all three of Thctford-Mines, for the following purposes: To form and administer a sport club and to promote in particular snow-mobile sport, under the name of \"Club de Moto-Ncigc les Campagnards inc.\".The amount to which is limited the revenue issuing from the immovable property that the corporation may acquire and hold is $100,000.The head office of the corporation is at Saintc-Anne-du-Lac, judicial district of Mégantic.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4807-1970 Club des Castors dc Buckingham Buckingham Beavers Club Notice is given that under Part ni of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Robert Pearson, Denis Tremblay, both electricians, John C.Campbell, Hilary Lawliss, Chesley Ladouceur, Raymond Delcourt, all four clerks, Don Neilson, merchant, Jean-Marc Chicoine, assistant-accountant, Aimé Racine, labourer, Alan Whyte, machinist, Lionel Clément, painter, Denis Montreuil, advocate, and Léonard Tremblay, contractor, all of Buckingham, for the following purposes: To operate a sport club and to promote in particular hockey sport, under the name of \"Club des Castors de Buckingham \u2014 Buckingham Beavers Club\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is S100,000.The head office of the corporation is at Buckingham, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5275-1970 1622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Club de ski Val d'Irène inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Louis-Philippe Gcndron, entrepreneur, Saint-Léon-le-Grand, Camille Simard, secrétaire, et André-Albert Gagné, cultivateur, ces deux derniers dc Sainte-Irène, pour les objets suivants: Former et administrer un club sportif et promouvoir en particulier le sport du ski, sous le nom de « Club dc ski Val d'Irène inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de S300.000.Le siège social de la corporation est à Sainte-Irène, district judiciaire de Rimouski.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5340-1970 Club Équestre d'Arvida inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Yvan Tremblay, secrétaire, 56S, rue Neilson, André Fay, journalier, 168, rue Régina, et Claude Tremblay, contremaître, 574, rue Fickc, tous trois d'Arvida, pour les objets suivants: Exploiter un club sportif et promouvoir en particulier le sport de l'équitation, sous le nom de « Club Équestre d'Arvida inc.».Le montant auquel est limitée In valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de S10.000.Le siège social dc la corporation est à Arvida, district judiciaire de Chicoulimi.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies cl coopératives, J.-Albert Gagnon.38630-o 5388-1970 Club Le Sanglier inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc Ta troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour dc novembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Arthur Loiselle, entrepreneur, Georgiana Dcbonvillc, ménagère, épouse dudit Arthur Loiselle, tous deux de 55, Jeamie-Mancc, et Claude Loiselle, décorateur, 215, Marie-Rose, tons trois dc Salaberry-de-Vallcyficld, pour les objets suivants: Exploiter un local pour fins sociales, sous le nom de « Club Le Sanglier inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $25,000.Club de ski Val d'Irène inc.Notice is given that under Part HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Louis-Philippe Gcndron, contractor, Saint-Léon-le-Grand, Camille Simard, secretary, and André-Albert Gagné, farmer, the latter two of Saint-Irène, for the following purposes: To form and direct a sport club and to promote in particular ski sport, under the name of \"Club dc ski Val d'Irène inc.\".The amount to wliich is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $300,000.The head office of the corporation is at Sainte-Irène, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5340-1970 Club Équestre d'Arvida inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation: without share capital: Yvan Tremblay, secretary, 568 Neilson Street, André Fay, labourer, 168 Régina Street, and Claude Tremblay, foreman, 574 Ficke Street, all three of Arvida, for the following purposes: To operate a sport club and to promote in particular riding sport, under the name of \"Club Équestre d'Arvida inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $10,000.The head office of the corporation is at Arvida, judicial district of Chicoutimi.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3S630 5388-1970 Club Le Sanglier inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Arthur Loiselle, contractor, Gcorgiana Dcbonvillc, housewife, wife of said Arthur Loiselle, both of 55 Jeanne-Munce, and Claude Loiselle decorator, 215 Marie-Rose, all three of Salaberry-de-Vnlleyfield, for the following purposes: To operate premises for social purposes, under the name of \"Club Le Sanglier inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $25,000. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Le siège social de la corporation est 17;ï, rue Sala-berry, Sulaberry-de-Vallcyficld, district judiciaire de Beauharnois.Le .ioim-7iiini.stre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.¦ :i8630-o 5286-1970 Le Club moto-ncige Abénaquis de St-Prosper Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres, patentes, en date du 3c jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Fabien Dulac, entrepreneur général, Benoît Poulin, entrepreneur électricien, Jean-Claude Grenier, boulanger, et Camille Côté, opérateur, tous quatre de Saint-Prosper, pour les objets suivants: Structurer des activités pour le sport d'auto-ncige, sous le nom dc « Le Club moto-neige Abénaquis dc St-Pros|>cr ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc S50.000.Le siège social dc la corporation est à Saint-Prosper, district judilairc dc Bcaucc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippb Bouchard.38630-o 5133-1970 Le Club Optimiste d'Hochclaga Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1970, constituant en corporation suns capital-actions: Michel Laroche, banquier, 7732, Viltel, Saint-Léonard, Gilles Masse, gérant, 6505, Louis Dupirc, Jean-Paul Ravary, industriel, 5300, des Tilleuls, Denis Payette, comptable, 12331, avenue Salk, Marcel Couture, tavernier, 5494, Bélanger, Jacques de Laplante, journalier, 4007, Ste-Cathcrine, Reginald Bcaulieu, 4589, Ste-Catherine, et Laurier Robert, 3234, boulevard Lévcsquc, ces deux derniers marchands, ces sept derniers de Montréal, pour les objets suivants: Développer l'optimisme comme une philosophie dc la vie, sous le nom de « Le Club Optimiste d'Ho-chelaga ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de SI,000,000.Le siège social de lu corporation est 3767, Stc-Catherine est, La Porte Ste-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4569-1970 Coffrage Idéal de Montréal inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première 1623 The head office of the corporation is at 175 Salaberry Street, Salabcrry-dc-Vallcyfield, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5286-1970 Le (lull moto-neige Abénaquis de St-Prosper Notice is given that under Part ni of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Fabien Dulac, general contractor, Benoît Poulin, electrician contractor, Jean-Claude Grenier, baker, and Camille Côté, operator, all four of Saint-Prosper, for the following purposes: To structure activities for snow-mobile sports purposes, under the name of \"Lc Club moto-neige Abénaquis de St-Prosper\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is S50.000.The head office of the corporation is at Saint-Prosper, judicial district of Bcauce.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5133-1970 Le Club Optimiste d'Hochclaga Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Michel Laroche, banker, 7732 Vittel, Saint-Léonard, Gilles Masse, manager, 6505 Louis Dupiré, Jean-Paul Ravary, industrialist, 5300 des Tilleuls, Denis Payette, accountant, 12331 Salk Avenue, Marcel Couture, tavern keeper, 5494 Bélanger, Jacques de Laplante, labourer, 4007 Ste-Catherine, Reginald Bcaulieu, 4589 Stc-Catherinc, and Laurier Robert, 3234 Lévesque Boulevard, the latter two merchants, the last seven of Montreal, for the following purposes: .To develop optimism as a philosophy of life, under the name of \"Le Club Optimiste d'Hochelaga\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is 81,000,000.The head office of the corporation is at 3767 Ste-Catherine Street East, La Porte Ste-Catherine, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4569-1970 Coffrage Idéal de Montréal inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of Novem- 1624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1071, 108' année, n° 7 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Noëlla Gencst, ménagère, épouse dc Marcel Laforest, 11223, Ubald-Paquin, Philippe Gencst, entrepreneur, et Gisèle Brassard, secrélaiie, épouse dudit Philippe Gencst, ces deux derniers dc 11225, Ubald Paqum, tous trois dc Montréal-Nord, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en coffrages et fondations, sous le nom dc « Coffrage Idéal dc Montréal inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 300 actions ordinaires de S100 chacune et en 100 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 11225, Ubald Paquin, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5107-1970 Comité des loisirs «le Sl-Tilc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Clément Veillcttc, commerçant, 145, St-Paul, Rcné'Désaulnicrs, technicien, 41, St-Gabricl, et Viatcur Bilodeaii, médecin vétérinaire, 301, Marchand, tous trois de Saint-Tite, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom dc « Comité des loisirs de St-Tite inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 875,000.Le siège social dc la corporation est Hôtel de ville dc Saint-Tite, district judiciaire de Saint-Maurice.Le sous-vwiislrc des institutions financières, conpagnics et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5082-1970 Les conseillers Cadrcx inc.Cadrcx Consultants Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Lise Bérubé, 1640, chemin Ste-Foy, Marie-Claire Poirier, 6, rue St-Stanislas, et Denise Turcotte, 91J^, rue d'Auteuil, toutes trois secrétaires, filles majeures, de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme conseillers en administration, sous le nom de « Les conseillers Cadrex inc.\u2014 Cadrcx Consultants Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 5570-1970 ber, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Noëlla Genest, housewife, wife of Marcel Laforcst, 11223 Ubald-Paquin, Philippe Gencst contractor, and Gisèle Brassard, secretary, wife of said Philippe Gencst, the latter two of 11225 Ubald-Paquin, all three of Montreal-North, for the following purposes: To carry on business as frame-work and foundation contractors, under the name of \"Coffrage Idéal dc Montréal inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 300 common shares of S100 each and 100 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 11225 Ubald-Paquin Montreal-North, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3S630 5107-1970 Comité des loisirs dc Sl-Tilc inc.Notice is given lliat under Part in of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Clément Veillcttc, trader, 145 St-Paul, René Desaulnicrs, technician, 41 St-Gabriel et Viatcur Bilodcau, veterinary physician, 301 Marchand, all three of Saint-Tite, for the following purposes: Organization of recreational activities, under the name of \"Comité des loisirs de St-Titc-inc\".The amount to which is limited the value of the immovable pro]>erly that the corporation may acquire and hold is S75.000.The head office of the corporation is at Town Hall of Saint-Tite, judicial district of Saint-Maurice.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5082-1970 Les conseillers Cadrex inc.Cadrcx Consultants Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Lise Bérubé, 1640 St.Foy Road, Marie-Claire Poirier, 6 St-Stanislas Street, and Denise Turcotte, 91^£ d'Auteuil Street, all three secretaries, spinsters of the full age of majority, of Québec, for the the following purposes: To carry on business as management consultants, under the name of \"Les conseillers Cadrcx inc.\u2014 Cadrex Consultants Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 2,000 common shares «of 810 each and into 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5570-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1071, Vol 103, No.7 Construction Pierre Laniothe inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de décembre 1970, constituant en corporation : Pierre Lamolhc, constructeur, (iisèle Langcvin, ménagère, épouse dudit Pierre Lamothc, tous deux dc 263, Iberville, Granby, et Lucien Desroches, ouvrier, Adamsville, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Construction Pierre Lamothc inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 100 actions ordinaires de $50 chacune et en 350 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 263, rue Iberville, Granby, district judiciaire dc Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5314-1970 Copperliood Kitchens of Quebec Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies .cl coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Stephen Ostrow, administrateur, 316, 71st Street West, New York, Carmen Russo, directeur, 695, Saint-George, Woodbridge, and Helen Baeringer, comptable, épouse divorcée de Joseph Herschorn, 97-11 Horace Harding Expressway, Corona, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce de toutes sortes tie nourritures, marinades, condiments, confitures, sauces, épices, aliments, boissons et vivres, sous le nom tie « Copperliood Kitchens of Québec Inc.», avec un capital divisé en 40,000 actions ortlinaires sans valeur au pair.Le siège social tic la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5457-1970 La Corporation Navis ltéc Navis Corporation Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie tic la Loi ties compagnies, il a accordé des lettres patentes, en tlate du 20c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Guy La vigueur, comptable agréé, 5000, Cedar Crescent, Montréal, André Royer, conseiller en administration, 117, De Gcntilly ouest, Lon-gucuil, André Laplante, ingénieur, 520, de Gaspé, app.310, Uc-aux-Soeurs, et André Lavigueur, comptable, 245, des Vosges, Saint-Lambert, pour les objets suivants : Fabriquer et faire le commerce d'aéroglisseurs, d'autos-neige, de camions, de tracteurs, d'automobiles et dc 1625 Construction Pierre Lamothc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Lamothc, builder, Gisèle Langcvin, housewife, wife of said Pierre Lamothc, both of 263 Iberville, Granby, and Lucien Desroches, workman, Adamsville, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Construction Pierre Lamothc inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $50 each and 350 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 263 Iberville Street, Granby, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard,.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5314-1970 Copperliood Kitchens of Québec Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies antl Cooperatives, incorporating: Stephen Ostrow, executive, 316, 71st Street West, New York, Carmen Russo, manager, 695 St.George, Woodbridge, and Helen Baeringer, accountant, divorced wife of Joseph Herschorn, 97-11 Horace Harding Expressway, Corona, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of foods, pickles, condiments, preserves, sauces, spices, victuals, beverages antl provisions, untler the name of \"Copperliood Kitchens of Québec Inc.\", with a capital stock divided into 40,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5457-1970 La Corporation Navis ltée Navis Corporation Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Lavigueur, chartered accountant, 5000 Cedar Crescent, Montreal, André Royer, management consultant, 177 De Gentilly West, Longueuil, André Laplante, engineer, 520 tic Gaspé, Apt.310, Ile-aux-Socurs, and André Lavigueur, accountant, 245 des Vosges, Saint-Lambert, for the following purposes: To manufacture antl deal hovercrafts, snow-mobiles, trucks, tractors, automobiles and vehicles of all kinds, 1626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, »° 7 -véhicules «le toutes sortes, sous le nom dc « La Corporation Navis ltée \u2014 Navis Corporation Ltd.», avec un capital divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 30,000 actions privilégiées d'une valeur nominale dc SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislrc del institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PinxipPE Bouchard.38630-o 5199-1970 Cilles Côté inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc In Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Gilles Côté, menuisier, Pierrette Girard, ménagère, épouse dudit Gilles Côté, tous deux de 515, route 16-A, et Jean-Yves Girard, marchand, 916, boulevard St-Paul, tous trois dc Chicoutimi, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Gilles Côté inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale dc S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Chicoulimi, district judiciaire dc Chicoulimi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 4839-1970 Jean-Jacques Côté ltéc Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour dc septembre 1970, constituant en corporation: Guy Godard, Guy Roy, tous deux avocats, et Micheline Guay, secrétaire, épouse de Jean-Paul Fontaine, tous trois de Sainte-Agathe, pour les objets suivants: Faire le commerce dc la bière et autres boissons, alcooliques ou non, sous le nom dc * Jcan-Jacqucs Côté ltéc », avec un capital total dc S40.000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc SI chacune et en 35,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de SI chacune._Le_ siège social dc la compagnie csl il Saint-Jérôme, district judiciaire dc Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4257-1970 Crndon Investment Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres under the name of \"Corporation Navis ltéc \u2014 Navis Corporation Ltd.\", with a capital stock divided into 10,000 common shares of without nominal value and 30,000 preferred shares of a nominal value of SI each.The head ollicc of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5199-1970 Gilles Côté inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles Côté, joiner, Pierrette Girard, housewife, wife of said Gilles Côté, both of 515, 16-A Route, and Jean-Yves Girard, merchant, 916 Si-Paul Boulevard, all three of Chicoulimi, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Gilles Côté inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of $10 each and 200 preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4839-1970 Jean-Jacques Côté liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Godard, Guy Roy, both advocates, and Micheline Guay, secretary, wife of Jean-Paul Fontaine, all three of Suinte-Agathe, for the following purposes: To deal in ales and other beverages, alcoholic or not, under the name of \"Jean-Jacques Côté ltée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 5,000 common shares of a nominal value of SI each and 35,000 preferred shares of a nominal value of SI each.The head office of the company is at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4257-1970 Cradon Investment Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day ot December, 1970, have been issued by the Minister of Financial QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 patentes, en date du 4c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Samuel Wcx, avocat, 21, chemin Clcve, Hampstcad, Pierrette Gougcon, épouse de François-Michel Gagnon, 5195, avenue Coolbrook, Montréal, et Erica Hume, épouse dc John B.Hume, 1210B, Havre des Iles, Laval, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants : Établir et diriger une compagnie dc placement, sous le nom de « Cradon Investment Corp.», avec un capital total tic 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $1 chacune et 300 actions privilégiées «l'une valeur au pair dc S100 chacune.Le siège social de la compagnie est au 500, Place d'Armes, bureau 1333, Montréal, «listrict judiciaire dc Montréal.Le sous-m iitislrc des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030 5376-1970 Créations Patapouf inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 11c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Jean-Pierre Lareau, vendeur, René Lareau, administrateur, tous deux de 7483, Argen-ton, Anjou, et Réal Théroux, contremaître, 7146, 14c Avenue, Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises faits totalement ou partiellement de textiles ou produits relatifs, sous le nom dc « Créations Patapouf inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 40,000 actions ordinaires dc $1 chacune.Le siège social dc la compagnie est 3555, boulevard Métropolitain, chambre 501, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le sous-ministre des institut ions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4684-1970 Crediehcx, Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi tics compagnies, il a accordé des lettres patentes, en «laie du 13e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Lewis Lcvrero, administrateur, ô.Place Bellcrivc, Laval, Ginette Murray, 2351, rue Bellechassc, et Danielle Trtidcl, 7125, Louis-Hémon, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: S'établir agents, conseillers cl experts et promoteurs en publicité, sous le nom dc * Crediehcx, Inc.», avec un capital divisé en 5,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair «le 810 chacune.1627 Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Samuel Wcx, advocate, 21 Cleve Road, Hampstcad, Pierrette Gougcon, wife of François-Michel Gagnon, 5195 Coolbrook Avenue, Montreal, and Erica Hume, wife of John B.Hume, 1210B Havre des Iles, Laval, the latter two secretaries, for the following purposes: To curry on the business of an investment company, under the name of \"Cradon Investment Corp.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of the par value of SI each antl 300 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company is at 500 Place d'Armes, suite 1333, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5376-1970 Créations Patapouf inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Pierre Lareau, salesman, René Lareau, administrator, both of 7483 Argenton, Anjou, and Réal Théroux, foreman, 7146, 14th Avenue, Montreal, for the following purposes : To manufacture and deal in all kinds of products, articles and goods made in whole or in part of textile or related products, under the name of \"Créations Patapouf inc.», with a total capital stock of 840,000, divided into 40,000, common shares of 81 each.The head office of the company is at 3555 Metropolitan Boulevard, suite 501, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4684-1970 Crcdichex, Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing tlate the 13th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies ami Cooperatives, iucor]x>ru-ling: Lewis Lcvrcro, executive, 5 Place Bellcrivc, Laval, Ginette Murray, 2351 Bellechassc Street, and Danielle Trudel, 7125 Louis Hcinon, the latter two secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To act as advertising and publicity agents, consultants, advisers and promoters, under the name of \"Crediehcx, Inc.\", with a capital stock divided into 5,000 common shares without par vuluc nnd 4,000 preferred shares of the par value of S10 each. 1628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, »° 7 Le siège social de la compagnie est au 5450, chemin -lia Iter Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 6c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Robert W.Agard, Richard S.Gottlieb, tous ileux avocats, et Marion Wnsscrman, secrétaire, fille majeure, tous trois du 800, carré Victoria, bureau 4115, Montréal, pour les objets suivants: S'établir capitalistes, financiers, courtiers et agents manufacturiers, sous le nom dc « Cybema ltée », avec un capital divisé en 40,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030 4867-1970 Cluudc Dcscliênes inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour dc décembre 1970, constituant en corporation : Jean-Noël Chalifour, comptable, 8995, Place du Berger, Claude Deschênes, entrepreneur, et Denise Portier, ménagère, épouse dudit Claude Dcschêncs, ces deux derniers de 8360, du Plateau, tous trois de Charlcsbourg, pour les objets suivants: Paire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce dc toutes sortes dc matériaux, sous le nom dc « Claude Dcschêncs inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 3,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 1,000 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 8360, avenue du Plateau, Charlcsbourg, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5599-1970 Domuinc dc Champvert limitée Ix; ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de novembre 1970, constituant en corporation Ross T.Clarkson, 220, avenue Chester, C.J.Michael Flavell, 10, place Park-man, Michael D.Levinson, 174, rue Ashton, Jacques Tétrault, 460 avenue Wood, James K.Hugessen, 17 avenue Fordcn et Derek A.Hanson, 987 Moncrieff, tous les six avocats, dc Montréal, pour les objets suivants: The head office of the company is at 5450 Côte des Neiges Road, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 o 4983-1970 Cybcrna ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 6th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies ami Cooperatives, incorporating: Robert W.Agard, Richard S.Gottlieb, both advocates, and Marion Wasserman, secretary, fille majeure, all three of 800 Victoria Square, bureau 4115, Montreal, for the following purposes: To carry on business as capitalists, financiers, brokers and manufacturers' agents, under the name of \"Cybcrna ltée\", with n capital slock divided into 40,000, common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Coopératives.38030-o 1867-1970 Claude Dcschêncs inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of I\u2022'i11:111ration est 7152, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniLippE Bouchard.38630-o 5059-1970 1629 To carry on the business of a real estate and construction compuny, under the numc of \"Domaine de Champvcrt limitée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 16,000 class \"A\" shares of the par value of SI each, 16,000 class \"B\" shares of the par value of SI each and 8,000 class \"C\" shares of the par value of 81 each.The head office of the company is ut Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5025-1970 Dorchester sport inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Edouard Patoine mechanic, Gaétanc Vachon, housewife, wife of said Edouard Patoine, and Léo Gosselin, representative salesman, all three of Saint-Malachic, for the following purposes: To deal in automobiles, snow-mobiles, trucks, motors, aircraf ts, aircraft motors, motor-boats, radio apparatus, refrigerators, and other electrical and electronic apparatus, bicycles, moto-cyclcs, and all their parts and accessories, under the name of \"Dorchester sport inc.\", with a total capital stock of 840,000 divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Saint-Malachic, judicial districtof Beauce.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5538-1970 Ensemble traditionnel Kébcc incorporée Notice is given that under Part in of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Denis Lessard, teacher, 7152 Lacordaire Boulevard, Saint-Léonard, Michel Paquettc, étudiant, 2509 Cadillac, and Michel St-Louis, artist, 1269 Dorion, the latter two of Montreal, for the following purposes: To develop members interests and in general public education for Québec traditions, under the name of \"Ensemble traditionnel Kébcc incorporée\".The amount to which is limited the value of the immovable that the corporation may acquire and hold is S100.000.The head office of the corporation is at 7152 Lacordaire Boulevard, Saint-Léonard, judicial district of Montreol.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5059-1970 1630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Les entreprises G.Taillefer, inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, (|u'cn vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Claude Taillefer, réali.->a-tcur, 1925, Lévcsqne, Claude Boisvert, avocat, 1505, Moore, et Guy Pépin, administrateur, 1055.Maison-neuve, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Exploiter des postes émetteurs et récepteurs de radio-dilTusion et de TSF, sous le nom dc « Les en! reprises C.Taillefer, inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 1350, Sherbrooke ouest, suite 900, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-mi nistre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Boitciiahd.38630-o 5532-1970 Les entreprises F.T.Carrier ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de In Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en dntcdu 1er jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jean-Paul Bédard, Gérald Guillot, tous deux comptables, et Danielle Hayfield, secrétaire, fille majeure, tous trois dc 1033.Route dc l'Église, Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les entreprises F.T.Carrier liée », avec un eupital total de 8150,000, divisé en 100 actions ordinaires de S100 chacune et en 1,400 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de lu compagnie est à Siiint-Duvid-dc-PAuberivière, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 5297-1970 Entreprises internationales J.B.C.ltéc J.B.C.International Enterprises Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Pierrette Morel, tisseuse dc cheveux, épouse dc Paul Bouchard, 9, rue Frechette, Saint-Dunst an-du-Liic-Bcauport, Phi lippe Damicn, vendeur, 3011, Laroche, et Réal Forest, avocat, 3177, de la Concorde, ces deux derniers de Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire le commerce dc tous produits, articles et marchandises, sous le nom de « Entreprises internationales J.B.C.ltéc \u2014 J.B.C.International Enterprises Ltd.», avec un capital total de S40.000, divisé en 3,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 1,000 actions privilégiées de 810 chacune.Les entreprises C.Taillefer, inc.Notice is given that under Purl I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th duy of December.1970, huvc been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude Taillefer, producer, 1925 Lèves-que, Claude Boisvert, advocate 1505 Moore, and Guy Pepin, administrator, 1055 Maisonncuvc, all three of Laval, for the following purposes: To operate broadcasting stations and radio an TV receiving stations, under the name of '\"Les entreprises ( '.Taillefer, inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of SI each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 1350 Sherbrooke St.West, suite 900, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5532-1970 Les entreprises F.T.Carrier ltée Notice is given that under Purl I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Paul Bédard, Gérald Guillot, both accountants, and Danielle Hayfield, secretary, spinster of the full age of majority, all three of 1033 de l'Église Route, Saintc-Foy, for the following purposes: To carry on business us a real estate and construction company, under the name of \"Les entreprises F.T.Currier ltéc\".with a total capital stock of 8150,000 divided into 100 common shares of $100 each and 1.400 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Saint-David-dc-l'Auberivière, judicial district of Quebec.Ls-Piiilippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institut unis.Companies and Cooperatives.38630 5297-1970 Entreprises internationales J.B.C.ltéc J.B.C.International Enterprises Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierrette Morel, hair-weaver, wife of Paul Bouchard, 9 Frechette Street, Saint-Dunstun-du-Lac-Beuu-port, Philippe Damien, salesman, 3011 Laroche, and Real Forest, advocate, 3177 dc la Concorde, the latter two of St.Foy, for the following purposes: To deal in all products, articles and goods, under the name of \"Entreprises internationales J.B.C.ltéc \u2014 J.B.C.International Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and into 1,000 preferred shares of 810 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1631 Le siège social de la compagnie est 1100, rue St-Jean, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 5390-1970 Les entreprises Jodan inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Jean-Guy Boisvert, administrateur, Claudette Gagné, ménagère, épouse iludit Jean-Guy Boisvert, tous deux dc 31, De l'Anse Bleue, et Claude Boisvert, avocat, 1505, Moore, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Effectuer des recherches, des enquêtes, pour fins éducatives, dans le domaine de l'éducation physique et des loisirs, sous le nom de \" Les entreprises Jodan inc.>\", avec un capital total de §40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc §10 chacune et en 300 actions privilégiées de 3100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38030-o 5006-1970 Les entreprises Lemieiix dc la Rive Sud inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Fcrnand Paré, menuisier, 5330, Westley, .lean Lemicux, contremaître, et Rachel Allard, ménagère, épouse dudit Jean Lemicux, ces deux derniers de 4915, Westley.tous trois de Saint-Hubert, pour les objets suivants: Paire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Les entreprises Lemieux de la Rive Sud inc.», avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 3,000 actions privilégiées de 310 chacune.Le siège social de la compagnie est 4915, Westley, .Saint-Hubert, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 4665-1970 Les entreprises Velia Lefcbvre inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Georges Lefcbvre, fils, Georges Lefebvre, tous deux industriels, et Velia Ziliani, ménagère, épouse dudit Georges Lefcbvre, tous trois dc 514, Saraguay, Pierrefonds, pour les objets suivants: The head office of the company is at 1100 St.John Street, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030 5390-1970 Les entreprises Jodan inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Guy Boisvert, administrator, Claudette Gagné, housewife, wife of said Jean-Guy Boisvert, both of 31 De l'Anse Bleue, and Claude Boisvert, advocate, 1505 Moore, all three of Laval, for the following purposes: To effect researches, investigations regarding educational purposes, in the field of physical education and recreational activities, under the name of \"Les entreprises Jodan inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of 310 each and 300 preferred shares of 3100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030 5006-1970 Les entreprises Lemicux de la Rive Sud inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Fcrnand Paré, joiner, 5330 Westley, Jean Lemieux foreman, and Rachel Allàrd, housewife, wife of said Jean Lemieux, the latter two of 4915 Westley, all three of Saint-Hubert, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors and to deal in'all kinds of materials, under the name of \"Les entreprises Lemieux de la Rive Sud inc.\", with a capital divided into 1,000 common shares without nominal value and 3,000 preferred shares of 310 each.The head office of the company is at 4915 West ley, Saint-Hubert, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3SG30 4605-1970 Les entreprises Velia Lefcbvre inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Georges Lefcbvre, junior, Georges Lefebvre, both industrialists, and Velia Ziliani, housewife, wife of said Georges Lefebvre, all three of 514 Saraguay, Pierre-fonds, for the following purposes: 1632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les entreprises Velia Lefebvre inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 400 actions ordinaires dc $10 chacune et en 360 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 514, Saraguay, Pierrefonds, district judiciaire de Montréal.Le .iou.i-mini.ilre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILlPPB bouchard.3S030-o 2153-1070 Evangelical Lutheran Latvian Church in Montreal Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de novembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Albert Berzins, dessinateur professionnel, 10440, rue Bclmorit, Pierrefonds, Rainis Gailitis, inspecteur, 12363, rue Jasmin.Kuiils Mazutis, 2057, boulevard Édouard-Montpetit, Richard Tutcrs, 4054 ouest, Dorchester,, app.12, tous trois de Montréal, et Fridbert Porietis, 1755, Wiltshire, Dorval, ces trois derniers dessinateurs industriels, pour les objets suivants: Établir, maintenir et diriger une secte religieuse et enseigner l'Évangile, sous le nom de « Evangelical Lutheran Latvian Church in Montréal».Le montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que peut posséder ou détenir la corporation est de $100,000.Le siège social de la corporation est au 4571, avenue Coolbrook, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 3331-1970 Expo télé-couleur inc.Le ministre des insitutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Normand Biais, 8401, boulevard Les Galeries d'Anjou, app.5, Anjou, Michel Vaillan-court, 7617, Louis-Hébert, tous deux vendeurs, Marcel Lépinc, gérant, 7779, St-Gérard, et Marguerite Giroux, secrétaire, fille majeure, 10355, Bois-de-Boulognc, app.407, ces trois derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens; fabriquer et faire le commerce de toutes sortes d'appareils et accessoires électriques, sous le nom de « Expo télé-couleur inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 1398, rue Beaubicn est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des instUulions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5265-1970 To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les entreprises Velia Lefebvre inc.\".with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of 810 each and 360 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 514 Saraguay, Pierrefonds, judicial district of Montreal.Ls-Phimppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 2153-1970 Evangelical Lutheran Latvian Church in Montreal Notice is given that under Part III of the Companies Act, Letters patent, bearing date the 30th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Albert Berzins, technical designer, 10440 Belmont Street, Pierrefonds, Rainis Gailitis, inspector, 12363 Jasmin Street, Emils Mazutis, 2057 Édouard-Montpetit Boulevard, Richard Tutcrs, 4054 Dorchester West, Apt.12, all three of Montreal, and Fridbert Porietis, 1755 Wiltshire, Dorval, the latter three draughtsmen, for the following purposes: To establish, maintain and conduct a Church and to carry on the teaching of the Gospel, under the name of \"Evangelical Luthcrun Latvian Church in Montreal\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold or possess is to be limited is 8100,000.The head office of the corporation is at 4571 Coolbrook Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 3331-1970 Expo télé-couleur inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Normand Biais, 8401 Les Galeries d'Anjou Boulevard, Apt.5, Anjou, Michel Vaillan-court, 7617 Louis-Hébert, both salesmen, Marcel Lépine, manager, 7779 St-Gérard, and Marguerite Giroux, secretary, spinster of the full age of majority, 10355 Bois-de-Boulogne, Apt.407, the latter three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as electricians; to manufacture and deal in all kinds of electric appliances and electrical accessories, under the name of \"Expo télé-couleur inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 1398 Beaubicn Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5265-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1633 F.W.R.Enterprises Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Lorne G.Hart, optométriste, 2147, Scott, Saint-Laurent, Jean Gillis, comptable, épouse dc Edgar Gillis, 80, Bcaconsfield, et Ellen Kowal, secrétaire, épouse divorcée dc Leo IL Kowal, 64, avenue Saint-Louis, ces deux dernières de Bcaconsfield, pour les objets suivants: S'établir constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de « F.W.R.Enterprises Inc.», avec un capital divisé en 20,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est au 207, avenue Ro-berval, l'incourt, district judiciaire de Montréal.Le nous-m inùlre des institutions financières, compagtiies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5240-1970 La ferme Devi inc.Le ministre des institutions financières, compagnies èt coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Fabien Decelles, Camille Decelles et Rosaire Vincent, tous trois hommes d'affaires, de Saint-Théodorc-d'Acton, pour les objets suivants: Exploiter une feime sous toutes ses formes, sous le nom dc « La ferme Devi inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Théodoie-d'Acton, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 4681-1970 Figure Magic Health Studio Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de décembre 1970, constituant en corporation : Gérard Choquette, gérant, route rurale 2, Hemmingford, Joyce Larivière, 10731, Hé-nault, Montréal, et Elaine Engelberg, 5774, avenue Léger, Côte Saint-Luc, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exploiter des établissements de santé, instituts de traitements amaigrissants et aménagements pour soins de beauté et de santé, sous le nom de « Figure Magic Health Studio Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.F.W.R.Enterprises Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Lorne G.Hart, optometrist, 2147 Scott, Saint-Laurent, Jean Gillis, accountant, wife of Edgar Gillis, 80 Bcaconsfield, and Ellen Kowal, secretary, wife divorced of Leo B.Kowal, 64 St.Louis Avenue, the latter two of Beaconsfield, for the following purposes: To carry on business as builders and contractors, under the name of \"F.W.R.Enterprises Inc.\", with a capital stock divided into 20,000 common shares without par value and 2,000 preferred shares at a par value of 810 each.The head office of the company is at 207 Roberval Avenue, Pincourt, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5240-1970 La ferme Devi inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Fabien Decelles, Camille Decelles and Rosaire Vincent, all three businessmen, of SaintThéodore-d'Acton, for the following purposes: To operate a farm in all its specialties, under the name of \"La ferme Devi inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Saint-Théodorc-d'Acton, judicial district of Saint-Hyacinthe.Ls-PniLiPPE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4681-1970 Figure Magic Health Studio Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérard Choquette, manager, Rural Route 2, Hemmingford, Joyce Larivière, 10731 Hénault, Montreal, and Elaine Engelberg, 5774 Léger Avenue, Côte Saint-Luc, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To operate health studios, reducing salons and health and beauty facilities, under the name of \"Figure Magic Health Studio Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30.000 preferred shares of $1 each. 1634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le snu.i-mini.ilre îles institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5307-1970 5150 Macdonald Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Sheldon Finkclstein, 5720, boulevard Cavendish, app.308, Côte Saint-Luc, Pinja E.Blitt, 3333 ouest, rue Jean-Talon, app.603, Michcl-A.Héroux, 10640, Hamclin, tous deux de Montréal, et Bernard Gardner, 405, chemin Xorthcole, Rosemèrc, tous les quatre avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « 5150 Macdonald Inc.», avec un capital total de $5,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est au 1440, rue Towers, bureau 101, Montréal, district judiciaire de Montréal.' Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S030 5430-1970 Flcisehman Commercial Equipment Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'octobre 1970, constituant en corporation : Si ici la Solomon, épouse divorcée de Allan Raymond, 89, Roxton Crescent, Montréal-Ouest, Rima Randolph, épouse de Malcolm Singer, 1540, Summerhill, Montréal, toutes deux secrétaires, et Julian Kotler, avocat, 5806, Hudson, Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce de systèmes de réfrigération domestiques et commerciaux, de chauffage à l'électricité, de climatisation; «l'équipement pour hotels, restaurants, magasins d'alimentation, bureaux et autres; de meubles, machinerie, accessoires, moteurs, outils, instruments, appareils, quincaillerie et fournitures dc toutes sortes, sous le nom dc « Fleischman Commercial Equipment Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est au 2114, rue Frontenac, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630 4709-1970 Foberl Marine Construction Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5307-1970 5150 Macdonald Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Sheldon Finkclstein, 5720 Cavendish Boulevard, Apt.308, Cole Saint-Luc, Pinja E.Blitt, 3333 Jean Talon Street West, Apt.603, Michcl-A.Héroux, 10640 Hamelin, both of Montreal, and Bernard Gardner, 405 Northcotc Road, Rosemèrc, all four advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"5150 Macdonald Inc.\", will a total capital slock of $5,000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 1440 Towers Street, Suite 101, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3S630-o 5430-1970 FIciscbman Commercial Equipment Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 28th day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Sheila Solomon, divorced wife of Allan Raymond, 89 Roxton Crescent, Montreal West, Rima Randolph, wife of Malcolm Singer, 1540 Summerhill, Montreal, both secretaries, and Julian Kotler, advocate, 5806 Hudson, Côte Saint-Luc, for the following purposes: To manufacture and deal in domestic and commercial refrigeration, electrical heating, air-conditioning and hotel, restaurant, food, office and other equipment and furniture, machinery, appliances, engines, tools, implements, apparatus, hardware, accessories and supplies of every kind, under the name of \"FIciscbman Commercial Equipment Ltd.\", with a total capital slock of $40,000, divided into 20,000 common shares of the par value of $1 each and 20,000 preferred shares of the par value of SI each.The head office of the company is at 2114 Frontenac Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Dejndy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4709-1970 Fobcrt Marine Construction Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of Decern- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Roger Faubert, homme d'affaires, Monique Chfttigny, marchande, fille majeure, tous deux de 116, Langlois, Châtcauguay, et Gilles-A.Denis, avocat, 4596, Marcil, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Fobert Marine Construction Inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et ne 2,000 actions privilégiées de §10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Châteauguay, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5293-1970 \u2022 Fondation Bergeron inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et*coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Gilles Coulombc, avocat, route rurale 1, Lennoxville, Françoise Fouquct, 1011, McManamy, et SolangesManseau, 488, London, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Sherbrooke, pour les objets suivants: Venir en aide aux familles ou personnes à faibles revenus, sous le nom de « Fondation Bergeron inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc S100.000.Le siège social dc la corporation est 105, rue Gordon, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5339-1970 Foreign & Domestic Surplus Merchandise Co.Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Henrietta Parzio, ménagère, épouse dc Morris Engelhardt, 1230, McGregor, David Goldenblatt, 3500, rue Mountain, app.67, tous deux de Montréal, et Lazarus L.ïinkoff, 250, avenue Clarke, app.716, Westmount, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises, sous le nom de « Foreign & Domestic Surplus Merchandise Co.Inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de §1 chacune et 39,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de §1 chacune.1635 ber, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Faubcrt, businessman, Monique Châtigny, merchant, spinster, both of 116 Langlois, Châteauguay, and Gillcs-A.Denis, advocate, 4596 Marcil, Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, and deal in all kinds of materials, under the name of \"Fobert Marine Construction Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 2,000 common shares of S10 each and 2,000 preferred shares of §10 each.The head office of the company is at Châteauguay, judicial district of Beauharnois.Ls-PniLippE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5293-1970 Fondation Bergeron inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital, Gilles Coulombe, advocate, Rural Route 1, Lennoxville, Françoise Fouquct, 1011 McManamy, and Solanges Manscau, 48S London, the latter two secretaries, spinsters of the full age majority, of Sherbrooke, for the following purposes: To assist low income families or persons, under the name of \"Fondation Bergeron inc.\".The amount to which is limited the annual revenue from the immovable property that the corporation may acquire and hold is 8100,000.The head office of the corporation is at 105 Gordon Street, Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3S630 .5339-1970 Foreign & Domestic Surplus Merchandise Co.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Henrietta Parzio, housewife, wife of Morris Engelhardt, 1230 McGregor, David Goldenblatt, 3500 Mountain Street, Apt.67, both of Montreal, and Lazarus L.Tinkoff, 250 Clarke Avenue, Apt.716, Westmount, the latter two attorneys, for the following purposes: To deal in all kinds of products, articles and marchandise, under the name of \"Foreign & Domestic Surplus Merchandise Co.Inc.\", with a total capital stock of §40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of 81 each and 39,000 preferred shares of a par value of 81 each. 1636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n\" 7 Le siège social de la compagnie est au 1, Van Horne, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-.ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 4797-1970 J.E.Fortier inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Paul Fortier, quincaillier, Jcan-ninc Lamarche, épouse dudit Paul Fortier, tous deux de 24, Garden City, et Jeannette Gosselin, veuve de Joseph-Eugène Fortier, 105, Stc-Annc, ces deux dernières ménagères, tous trois dc Saintc-Annc-dc-Bcllc-vue, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes espèces d'articles et marchandises qui font généralement l'objet d'un commerce d'épicerie, de viande et dc toutes sortes d'autres aliments, de ferronnerie et dc toutes sortes de matériaux et de marchandises sèches, sous le nom de « J.E.Fortier inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 24, Garden City, Sainte-Annc-dc-Bellevue, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 5123-1970 Fovimar limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Bernard Fontaine, hôtelier, 353, Hôtel de Ville nord, Gilles Viens, commis, 555, Magenta est, et Alain Martin, dentiste, 1030, St-Bruno nord, tous trois de Farnham, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels et motels, sous le nom de « Fovimar limitée », avec un capital total de 875,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de S10 chacune et en 600 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 353, Hôtel dc Ville, Farnham, district judiciaire dc Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o \u2022 4978-1970 Foyer Le Blanc Sommet inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Georges Dubé, 1105, avenue Belvédère, Québec, Roger Vallières, 2643, Brome, tous The head office of the company is at 1 Van-Home, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4797-1970 J.E.Fortier inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letter patent, bearing date the 23rd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Paul Fortier, hardware merchant, Jean-nine Lamarche, wife of said Paul Fortier, both of 24 Garden City, and Jeannette Fortier, widow of Joseph-Eugène Fortier, 105 Stc-Anne, both housewifes, all three of Sainte-Annc-de-Bcllevuc, for the following purposes: To deal in all kinds of articles and merchandise which arc usually the purposes of a grocery, meat and all kinds of other food products, hardware and all kinds of materials and dry goods business, under the name of \"J.E.Fortier inc.\", with a total capital stock of S40,000, divided into 2,000 common snares of 810 each and 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 24 Garden City, Sainte-Annc-de-Bellevue, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5123-1970 Fovimar limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bernard Fontaine, hotel keeper, 353 Hôtel de Ville North, Gilles Viens, clerk, 555 Magenta East, and Alain Martin, dentist, 1030 St-Bruno-North, all three of Farnham, for the following purposes: To operate hotels and motels, under the name of \"Fovimar limitée\", with a total capital stock of 875,000, divided into 1,500 common shares of $10 each and 500 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 353 Hôtel de Ville, Farnham, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4978-1970 Foyer Le Blanc Sommet inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing fate the 29th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Georges Dubé, 1105 Belvédère Avenue, Québec, Roger Vallières, 2643 Brome, both advocates, and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol 103, No.7 deux avocats, et Michel Doyon, étudiant, 1104, Dijon, ces deux derniers de Sainte-Foy, pour les objets suivants: Exploiter des maisons d'accueil pour personnes âgées, convalescents ou autres personnes, des hospices, des foyers d'hébergement et d'autres institutions de même nature, sous le nom de « Foyer Le Blanc Sommet inc.», avec un capital total dc 8100,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur nominale dc $10 chacune et en 750 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 3184, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sou.i-viini.ilre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe BoucnARD.38630-o 4250-1970 Frontier Inn (1970) Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour de novembre 1970, constituant en corporation : J.-Raoul Dumouchel, Yolande-D.Dumouchel, épouse dudit J.-Raoul Dumouchel, tous ileux rentiers, Jean-Yves Dumouchel, secrétaire, et Michel Dumouchel, gérant, tous quatre dc 55S, rue Frontière, Hemmingford, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Frontier Inn (1970) Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune, 5,000 actions privilégiées classe « A » d'une valeur nominale de Si chacune et en 340 actions privilégiées classe « B » d'une valeur nominale dc S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 459, nie Frontière, Hemmingford, district judiciaire dc Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5113-1970 Marcel Gauthier construction inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Marcel Gauthier, entrepreneur, Pauline Gagné, ménagère, veuve de Cyrice Valcourt, tous deux de 651, Dequen, et Clément Côté, notaire, 809, Giasson, app.6, tous trois «le Sept-Iles, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Marcel Gauthier construction inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 651, avenue Dequen, Sept-Iles,district judiciaire de Hauterive.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5393-1970 1637 Michel Doyon, student, 1104 Dijon, the latter two of Sainte-Foy, for the following purposes: To operate welcome homes for aged persons, conva-Iescents_ or others; hospices, refuge homes and other institutions of like nature, under the name of \"Foyer Le Blanc Sommet inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 2,500 common shares of a nominal value of S10 each and 750 preferred shares of a nominal value fo S100 each.The head office of the company is at 3184 Ste-Foy Road, Sainte-Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 .4250-1970 Frontier Inn (1970) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: J.-Raoul Dumouchel, Yolandc-D.Dumouchel, wife of said J.-Raoul Dumouchel, both annuitants, Jean-Yves Dumouchel, secretary, and Michel Dumouchel, manager, all four of 558 Frontière Street, Hemmingford, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Frontier Inn (1970) Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of SI each, 5,000 class \"A\" preferred shares of a nominal value of SI each and into 340 class \"B\" preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at 459 Frontière Street, Hemmingford, judicial district of Beauharnois.Ls-Phii.ippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5113-1970 Marcel Gauthier construction inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December, 197Ù, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marcel Gauthier, contractor, Pauline Gagné, housewife, widow of Cyrice Valcourt, both of 651 Dequen, and Clément Côté, notary, 809 Giasson, Apt.6, all three of Scpt-Iles, for the following purposes: To do business as a real estate and construction company, under the name of \"Marcel Gauthier construction inc.\", with a total capital stock of $40,000, into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 651 Dequen Avenue, Scpt-Iles, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5393-1970 1638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n?7 Rolland Gélinas Auto inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Rolland Gélinas, homme d'affaires, Marthe Founder, ménagère, épouse dudit Rolland Gélinas, Gisèle Gélinas, et Yolande Gélinas, ces deux dernières institutrices, filles majeures, tous quatre dc 645, rue Barkoff, Cap-dc-la-Madclcinc, pour les objets suivants: Faire la réparation du système électrique d'automobiles, sous le nom dc « Rolland Gélinas Auto inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur nominale dc 8100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 645, rue Barkoff, Cap-dc-la-Madclcinc, district judiciaire de Trois-Rivières.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5008-1970 Gestion Rio inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il n accorde des lettres patentes, en date du 1er jour de décembre 1970, constituant en corporation: Ronald Lapicrre, comptable agréé, Francinc Rodrigue, maîtresse de maison, épouse dudit Ronald Lapicrre, tous deux dc 301, Dcguirc, suite 1141, Saint-Laurent, François Limoges, avocat, et Monique Dubé, maîtresse dc maison, épouse dudit François Limoges, ces deux derniers dc 6254, boulevard Monk, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc portefeuille, sous le nom de « Gestion Rio inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 301, Dcguire, suite 1141, Saint-Laurent, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5300-1970 Gosselin, Sanison, Rancourt inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Paul-A.Gosselin, 325, St-Joseph, Fcrnand Samson, 15, rue Vaudrcuil, et Bernard Rancourt, 35, rue du Vieux Fort, tous trois courtiers en assurance, de Lauzon, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom de « Gosselin, Samson, Rancourt inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc $1 chacune Rolland Gélinas Auto inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Rolland Gélinas, businessman, Marthe Fournier, housewife, wife of said Rolland Gélinas, Gisèle Gélinas and Yolande Gélinas, the latter two teachers, spinsters of the full age of majority, all four of 645 Barkoff Street, Cap-dc-la-Madeleine, for the following purposes: To repair automobiles electric system, under the name of \"Rolland Gélinas Auto inc.\", with a total capital slock of 840,000, divided into 100 common shares of a nominal value of 8100 each and 300 preferred shares of a nominal value of 8100 each.The head office of the company is at 645 Barkoff Street, Cap-de-la-Madelcine, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5008-1970 Gestion Rio inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ronald Lapicrre, chartered accountant, Fran-cine Rodrigue, housewife, wife of said Ronald Lapierre, both of 301 Deguirc, suite 1141, Saint-Laurent, François Limoges, advocate, and Monique Dubé, housewife, wife of said François Limoges, the latter two of 6254 Monk Boulevard, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Gestion Rio inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company is at 301 Deguirc, suite 1141, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5300-1970 Gosselin, Samson, Rancourt inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Paul-A.Gosselin, 325 St-Joseph, Fcrnand Samson, 15 Vaudreuil Street, and Bernard Rancourt, 35 Vieux Fort Street, all three insurance brokers, of Lauzon, for the following purposes: To carry on business as insurance agents and brokers, under the name of \"Gosselin, Samson, Rancourt inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of a nominal value of 81 each and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 13, 1971, Vol.103, No.7 et en 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 44 avenue Bégin, Lévis, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlULIPPE bouchard.38G30-o 5594-1970 Granbour inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu delà troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Dominique Veillcux, commis livreur, Myonnc Vcillcux, ménagère, épouse dudit Dominique Veilleux, tous deux dc Dauville, Gaspard Lalandc, agronome, Lennoxville, Michel Ayottc, Séminaire de Sherbrooke, Daniel Pichcttc, route rurale 1, tous deux prêtres, Murielle Corriveau, 1455, Dorval, tous trois dc Sherbrooke, et Josscline Ayottc, 73, 2c Avenue, Windsor, ces deux dernières professeurs, filles majeures, pour les objets suivants: Exclusivement pour des fins de charité: réunir des gens de conditions sociales différentes et promouvoir une pédagogie susceptible d'épanouir, sous le nom de « Granbour inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8200,000.Le siège social dc la corporation est route rurale numéro 1, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, I^-Piiilippe Bouchard.38630-o 5571-1970 Les granits Frontenac inc.Frontenac Granite Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Picrrc-C.Fournicr, 1880, dc Rouville, André Rodriquc, 206, rue Kennedy sud, Ronald Dudcmaine, 630, boulevard Jacques-Cartier nord, et Claude Bédard, 405, Châtcauguay, tous quatre avocats, de Sherbrooke, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce dc toutes sortes dc pierres et produits dc la terre, sous le nom «le « Les granits Frontenac inc.\u2014 Frontenac Granite Inc.», avec un capital total dc 8100,000, divisé en 24,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc SI chacune et en 7,600 actions privilégiées d'une valeur nominale de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5327-1970 1639 into 3,000 preferred shares of a nominal value of S10 each.The head office of the company is at 44 Begin Avenue, Levis, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 \u2022 5594-1970 Granbour inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Dominique Veilleux, delivery clerk, Myonne Veilleux, housewife, wife of the said Dominique Veilleux, both of Dcauvillc, Gaspard Lalande, agronomist, Lennoxville, Michel Ayottc, Seminary of Sherbrooke, Daniel Pichcttc, rural route 1, both priests, Murielle Corriveau, 1455 Dorval, all three of Sherbrooke, and Josscline Ayotte, 73, 2nd Avenue, Windsor, the latter two professors, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: For charitable purposes only : to group together people of different social conditions and to promote pedagogy with a view to developing and broadening their horizons, under the name of \"Granbour inc.\".The amount to which is to be limited the annual revenues accruing from the immovable property which the corporation may acquire or possess is to be 8200,000.The head office of the corporation is at rural route No.1, Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5571-1970 Les granits Frontenac inc.Frontenac Granite Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Picrre-C.Fournicr, 1880 de Rouville, André Rodrigue, 206 Kennedy Street South, Ronald Dudcmaine, 630 Jacques-Cartier Boulevard North, and Claude Bédard, 405 Châteauguay, all four advocates, of Sherbrooke, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of stones and grounds products, under the name of \"Les Granits Frontenac inc.\u2014 Frontenac Granite Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 24,000 common shares of a nominal value of 81 each and 7,600 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at Sainte-Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe BoucnARD, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5327-1970 1640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n\" 7 Grégoire-Smith inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Pierre Laforcst, avocat, 4858, Côtc-des-Neigcs, app.001, Picrre-A.Grégoire, administrateur, 5050, lloslyn, et Jean Smith, commerçant, 2340, de Salaberry, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de récipients servant à recevoir les ordures provenant de maisons dc rapport ou de maisons à appartements, sous le nom dc « Gré-goirc-Smith inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'ime valeur nominale de SI chacune et en 3,900 actions privilégiées d'une valeur nominale de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 603, Côte Vertu, Saint-Laurent, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, com puantes cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5109-1970 Grolcc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé «les lettres patentes, en date du 15c jour de décembre 1970, constituant en corporation : Pierre Grondin, 32, des Bouleaux, Laval, Gilles Lepage, 445, Lockhart, Mont-Royal, et Yves Castonguny, 3435, boulevard Toupin, Saint-Laurent, tous trois médecins, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc portefeuille, «le placement et dc gestion, sous le nom dc « Grolec inc.», avec un capital total dc S100.000, divisé en 300 actions ordinaires de SI chacune, 9,940 actions privilégiées classe « A » «le S10 chacune et en 300 actions privilégiées classe « B » de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est 5200, rue Bélanger est, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5087-1970 Jean Guérard inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour d'avril 1970, constituant en corporation: Jean Guérard, entrepreneur-couvreur, Thérèse Robitaille, ménagère, épouse dudit Jean Guérard, tous deux «le 35, boulevard Central, et Lise Guérard, secrétaire, fille majeure, 428, 2c Rue, tous trois dc Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur-couvreur, fabriquer des articles et produits nécessaires à la pose de toiture et dc bardeaux de toutes sortes, sous le nom de « Jean Guérard inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc S10 chacune et en 200 actions privilégiées de S100 chacune.Grégoire-Smith inc.Notice is-given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Laforest, advocate, 4858, Côtc-dcs-Neiges, Apt.601, Picrre-A.Grégoire, administrator, 5050 Roslyn, and Jean Smith, trader, 2340 de Salaberry, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in containers used as receivers of garbage coming from apartments houses, under the name of \"Grégoirc-Smith inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of SI each ami 3,900 preferred shares of a nominal value of S10 each.The head office of the company is at 603 Côte Vertu, Saint-Laurent, district judiciaire dc Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5109-1970 Grolcc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Grondin, 32 des Bouleaux, Laval, Gilles Lepage, 445 Lockhart, Mont-Royal, and Yves Caston-guay, 3435 Toupin Boulevard, Saint-Laurent, all three physicians, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"Grolcc inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 300 common shares of 81 each, 9940 class \"A\" preferred shares of 810 each and 300 class \"B\" preferred shares of 81 each.The head office of the company is at 5200 Bélanger Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5087-1970 Jean Guérard inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of April, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean Guérard, roofing contractor, Thérèse Robitaille, housewife, wife of said Jean Guérard, both of 35 Central Boulevard, and Lise Guérard, secretary, spinster of the full age of majority, 428, 2nd Street, all three of Québec, for the following purposes: To carry on business as a roofing contractor, to manufacture the articles and goods necessary for the laying of roofs and shingles of all kinds, under the name of \"Jean Guérard inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and into 200 preferred shares of 8100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Le siège social de la compagnie est 319, rue des Sables, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Puilippe Bouchard.38030-o 1495-1970 liai Uni & Oucllcl construction inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Robert Harlon, menuisier, Charlinc Thériault, secrétaire, épouse dudit Robert Harlon, tous deux dc 943, Dupas, Réal Oucllcl, menuisier, et Marie-Laure S,uindon.secrétaire, épouse dudit Réal Ouellct, ces deux derniers de 923, Dupas, tous quatre de Longucuil, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce «le toutes sortes dc matériuux, sous le nom de « Harlon & Ouellct construction inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune, 2,000 actions privilégiées catégorie « A » de SI chacune et en 1,800 actions privilégiées catégorie « B » dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 943, Dupas.Longucuil, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5163-1970 Ilcpco Electric Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première parlie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Henri-A.Pinsonneault, électricien, Lise Lemirc, ménagère, épouse dudit Henri-A.Pinsonneault, tous deux dc 411, Racine, Paul Arts, électricien, et Fleurette Godfroy, ménagère, épouse dudit Paul Arts, ces deux derniers de 2641, McGill, tous qualrc dc Longucuil, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens; fabriquer et faire le commerce de toutes sortes d'appareils et accessoires électriques, sous le nom de « flepeo Electric Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de S10 chacune et en 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 411, rue Racine, Longueuil, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5120-1970 Hôpital Chashasipich (Fort-Georges) Chasliasipich Hospital (Fort-George) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième parlic dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres 1641 The head office of the company is at 319 des Sables Street, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 1495-1970 11 ail on & Ouellct construction inc.Notice is given thut under Part I of the Companies Act, letters putent, bearing date the 24th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Harton, joiner, Charlinc Thé-riault, secretary, wife of said Robert Harton, both of 943 Dupas, Réal Ouellct, joiner, and Marie-Laurc Suiudon, secretary, wife of said Real Ouellct, the latter two of 923 Dupas, all four of Longucuil, for the following purposes: To carry on business us general building contractors, and to deal in all kinds of building materials, under the name of \"Harton & Ouellct construction inc.\", with u lolul cupitul stock of $40,000, divided into 200 common shares of S100 each, 2,000 class \"A\" preferred shares of $1 each and 1,800 class \"B\" preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 943 Dupas, Longucuil, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5163-1970 1 Icpco Electric Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Henri-A.Pinsonneault, electrician.Lise Le mire, housewife, wife of said Henri-A.Pinsonneault, both of 411 Racine, Paul Arts, electrician, and Fleurette Godfroy, housewife, wife of said Paul Arts, the latter two of 2641 McGill, all four of Longucuil, for the following purposes: To carry on business as electricians; to manufacture and deal in all kinds of electrical apparatus and supplies, under the name of \"Hepco Electric Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $10 each and 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 411 Racine Street, Longueuil, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5120-1970 Hôpital Chasliasipich (Fort-Georges) Chashasipich Hospital (Fort-George) Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of 1642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 patentes, en date du 2c jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Josée Sam Atkinson, Jack Holiday, Roger Bcrthiauinc, tous trois gérants, James Merry, pasteur, Gaston Grcnon, prêtre, Tom Webb, hôtelier, Yves Léger, agent, tous sept de Fort-Gcorgcs, Benoit Robilnille, directeur des services, Jean-Marc Lessard, agent d'administration, tous deux dc Québec, Hugo Georgckish, agent local, Nouveau-Comptoir, Billy Diamond, chef de bande, Fort-Rupert, Teddy Moses, Eastmain, David Masl.y, tous deux gérants, et Silas Cookie, chef esquimau, ces deux derniers dc Postc-dc-la-Baleine, pour les objets suivants: Exploiter et administrer un hôpital situé à Fort-Georges, sous le nom dc « Hôpital Chnshasipich (Fort-Georges) \u2014 Chashasipich Hospital (Fort-George) ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc S1,500,000.Le siège social dc la corporation est à Fort-Gcorgcs, district judiciaire de Hauterive.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5229-1970 House of Molina (Québec) Ltd.Chez Mclina (Québec) ltéc Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu tie In première partie de la Loi des compagnies, il a accordé tics lettres patentes, en tlatc du 13e jour tie novembre 1970, constituant en corporation: Gerald W.Fostelnik, 7355, Ostell Crescent, Montréal, Clifford S.Postelnik, 5716, Mclling, Côte Saint-Luc, et Walter R.M.Wekarchuk, 5, Place Bellcrivc, Laval, tous trois avocats, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce de produits, articles et marchandises tie toutes sortes, sous le nom dc « House of Melina (Québec) Ltd.\u2014 Chez Mclina (Québec) ltéc», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées dc SI chacune.Le siège social dc la compagnie est au 16S2A est, Mont-Royal, Montréal, district judiciaire tic Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies cl coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 4948-1970 The 11% man & Estelle Barkun Foundation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi tics compagnies, il a accordé des lettres patentes, en tlatc du 23c jour d'octobre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Estelle Barkun, veuve tic Hyman Barkun, Michael Barkun, tous deux du 4555, avenue Bonavista, Montréal, et Ted Barkun, 1302, Ethier, Laval, tous trois administrateurs, pour les objets suivants: Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Josée Sam Atkinson, Jack Holiday, Roger Bcrthiaume, all three managers, James Merry, pastor, Gaston Grcnon, priest, Tom Webb, hotel keeper, Yves Léger, agent, all seven of Fort-Gcorgcs, Benoit Robitaillc, director of departments, Jean-Marc Lessard, management agent, both of Québec, Hugo Georgckish, local agent, Nouveau-Comptoir, Billy Diamond, Chief of tribe, Fort-Rupert, Teddy Moses, Eastmain, Davitl Masty, both managers, and Silas Cookie, Eskimo Chief, the latter two of Postc-de-la-Baleinc, for the following purposes: \u2022 To operate antl manage a hospital situated at Fort-Georges, under the name of \"Hôpital Chashasipich (Fort-Gcorgcs) \u2014 Chashasipich Hospital (Fort-Geor- ee)\"- The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire antl possess, is SI,500,000.The head office of the corporation is at Fort-Georges, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5229-1970 House of Melina (Québec) Ltd.Chez Mclina (Québec) ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gerald W.Postelnik, 7355 Ostcll Crescent, Montreal, Clifford S.Postelnik, 5716 Mclling, Côte Saint-Luc, and Walter R.M.Wekarchuk, 5 Place Bellcrivc, Laval, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in goods, wares antl merchandise of all kinds, under the name of \"House of Mclina (Québec) Ltd.\u2014 Chez Mclina (Québec) ltée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of SI each and 30,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at 1682A Mount Royal East, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4948-1970 The Hyman & Estelle Barkun Foundation Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Estelle Barkun, widow of Hyman Barkun, Michael Barkun, both of 4555 Bonavista Avenue, Montreal, and Ted Barkun, 1302 Ethicr, Laval, all three executives, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.108, No.7 Fournir et rendre des services de charité aux pauvres et aux nécessiteux, sous le nom dc « The Hyman & Estelle Barkun Foundation ».Le montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que peut posséder ou détenir la corporation est dc 81,000,000.Le siège social de la corporation est au 55, rue Lou-vain, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030 4736-1970 Immeubles Esther liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de décembre 1970, constituant en corporation: ltaymond Cantin, courtier en immeuble, 48, rue St-Charlcs, Neufchatcl, Valmond Boulianc, 3440, Massait, Sainte-Foy, et Louis-Philippe Marcotte, 3414, des Sumacs, Orsainvillc, ces deux derniers notaires, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et dc construction, sous le nom de « Immeubles Esther ltéc », avec un capital total dc 840,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 100 actions privilégiées dc S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 1019, boulevard St-Cyrille ouest, Québec, district-judiciaire de Québec.Le sous-ministre associé des iîistilutions financières, compagnies cl coopératives, J.-Albert Gagnon*.38630-o 5404-1970 Import-Export Drawback Consultants Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de novembre 1970, constituant en corporation : Arthur Yanofsky, avocat, 5872, Fcrncroft, Hampstcad, Shcila Raymond, 89, Roxton Crescent, Montréal-Ouest, et Grace Blackett, 5622 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: S'établir conseillers et experts auprès de l'administration et des administrateurs et directeurs dc toutes entreprises commerciales ou établissements industriels, sous le nom de « Import-Export Drawback Consultants Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc 81 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Ia: sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5201-1970 1643 To supply and render services of a charitable nature to poor and needy persons, under the name of \"The Hyman & Estelle Barkun Foundation\".The amount to which the value of the immoveable property which may be owned or held by the corporation is to be limited is $1,000,000.The head office of the corporation is at 55 Louvuin Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4736-1970 Immeubles Esther liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Raymond Cantin, real estate broker, 48 St-Charlcs Street, Neufchatel, Valmond Bouliane, 3440 Massart, Sainte-Foy, and Louis-Philippe Marcotte, 3414 des Sumacs, Orsainvillc, the latter two notaries, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Immeubles Esther ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 3,000 common shares of 810 each and 100 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 1019 St-Cyrille Boulevard West, Québec, judicial district of Québec.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5404-1970 Import-Export Drawback Consultants Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Arthur Yanofsky, advocate, 5872 Fern-croft, Hampstcad, Shcila Raymond, 89 Roxton Crescent, Montreal West, and Grace Blackett, 5622 Sherbrooke Street West, Montreal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To act as consultants and advisers in general to the management and executives of any commercial enterprise or industrial organization, under the name of \"Import-Export Drawback Consultants Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of a par value of 81 each and 3,000 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5201-1970 1C44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Les industries de Charolles liée Charollcs Industries Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en tlatc du 17e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Jacques-F.Baar-Nason, éleveur, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Maurice Berleau, 102, Sherwood, Cowansvillc, et Stacy Wighlman, Pigeon Hill, ces deux derniers comptables, pour les objets suivants: Exploiter des commerces d'abattoirs, dc boucheries, de charcuteries, pour l'abattage des animaux, la préparation des viandes et autres produits alimentaires, sous le nom de « Les industries de Charolles ltéc \u2014 Charolles Industries Ltd.», avec un capital total de $200,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 10,000 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Ignace-de-Stanbridgc, district judiciaire dc Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PllILIl'pe lion 'h a un.38630-o 5639-1970 I.es industries G.Bellerose inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Gérald Bellerose, homme d'affaires, Cécile St-Germain, ménagère, épouse dudit Gérald Bellerose, tous deux de 275, Gravel, et Bruno Bellerose, retraité, 1120, Notre-Dame, tous trois dc Nicolet, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de moteurs, machines, leurs parties et accessoires, et autres instruments et appareils, sous le nom de « Les industries G.Bellerose inc.», avec un capital total dc 8100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune et en 9,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 1120, rue Notre-Dame, Nicolet, district judiciaire dc Nicolet.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5022-1970 L'industrie Laçasse inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Albert Laçasse, manufacturier, 169A, rue Déragon, Denis Laçasse, commis de bureau, 13, avenue Simonds, et Marcel Laçasse, menuisier, 623, Frechette, tous trois de Granby, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de toutes sortes dc portes, chassis, fenêtres et autres ouvertures, sous Les industries dc Charolles ltéc Charollcs Industries Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and' Cooperatives, incorporating:.I acqucs-F.Baar-Nason, breeder, Sainl-Ignace-dc-Stanbridgc, Maurice Bertcau, 102 Sherwood, Cowansvillc, and Stacy Wightman, Pigeon Hill, the latter two accountants, for the following purposes: To operate slaughterhouses for the killing of animals, butcher and delicatessen shops for the preparation of meat and other food products, under the name of \"Les industries de Charolles ltée \u2014 Charolles Industries Ltd.\", with a total capital stock of 8200,000, divided into 10,000 common shares of 810 each and 10,000 preferred shares of 810 each.The head ollicc of the company is at Suint-Ignacc-dc-Stunbridgc, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5639-1970 Les industries G.Bellerose inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérald Bellerose, businessman, Cécile St-Germain, housewife, wife of said Gérald Bellerose, both of 275 Gravel, and Bruno Bellerose, annuitant, 1120 Notre-Dame, all three of Nicolet, for the following purposes: To manufacture and deal in motors, machines, their parts and accessories, and other instruments and apparatus, under the name of \"Les industries G.Bellerose inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of 810 each and 9,000 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is ut 1120 Notre-Dame Street, Nicolet, judicial district of Nicolet.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5022-1970 L'industrie Laçasse inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Albert Laçasse, manufacturer, 169A Déragon Street, Denis Laçasse, office clerk, 13 Simonds Avenue, and Marcel Laçasse, carpenter, 623 Frechette, all three of.Granby, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of doors, frames, windows and other openings, under the name of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 18, 1971, Vol.103, No.7 le nom de « L'industrie Laçasse inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 14, avenue Si-¦nonds, Granby, district judiciaire de Bedford.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5601-1970 Les industries R.& L.Girard inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Léo Girard, comptable, 1823, 76c Rue, Shawinigan-Est, René Girard, industriel, 235, boulevard St-Laurent, et Jean-Guy Girard, vendeur, 1097, 13c Avenue, ces deux derniersde Shawinigan-Sud, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Les industries R.& L.Girard inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur nominale de S100 chacune et en 500 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4725-1970 Island Terrace Restaurant Inc.Restaurant Terrasse dc l'Ile inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour de juillet 1970, constituant en corporation: Ben Schectcr, Stephen J.Roth, tous deux avocats, et Meta Hope, secrétaire, épouse de Keith Hope, tous trois dc Montréal, pour les objets suivants : S'établir restaurateurs, sous le nom de « Island Terrace Restaurant Inc.\u2014 Restaurant Terrasse de l'Ile inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social dc la compagnie est à PHe-des-Soeurs, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 3205-1970 La Jeune Chambre de St-Éphrem (Bcaucc) inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour dc décembre 1970, consti- 1645 \"L'industrie Laçasse inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 14 Simonds Avenue, Granby, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5601-1970 Les industries K.& L.Girard inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Léo Girard, accountant, 1823, 76th Street, Shawinigan-East, René Girard, industrialist, 235 St-Laurent Boulevard, and Jean-Guy Girard, salesman, 1097, 13th Avenue, the latter two of Sliawi-nigan-South, for the following purposes: To carry on business as garage keepers, and to dcul in automobiles, motors, machines and all their parts and accessories, under the name of \"Les industries R.& L.Girard inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 500 common shares of a nominal value of 8100 each and 500 preferred shares of a nominal value of 8100 each.The head office of the company is at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4725-1970 Island Terrace Restaurant Inc.Restaurant Terrasse de l'Ile inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ben Schectcr, Stephen J.Roth, both advocates, and Meta Hope, secretary, wife of Keith Hope, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Island Terrace Restaurant Inc.\u2014 Restaurant Terrasse de l'Ile inc.\", with a total capital stock of S40,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at Nun's Island, judicial district of Montréal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 3205-1970 La Jeune Chambre dc St-Éphrem (Bcaucc) inc.' Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorpo- 164G GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 tuant en corporation sans capital-actions: André Bol-duc, caissier, case postale 26, Roger Bureau, menuisier, boulevard Sle-Famillc, et Charles-Aimé Robert, rue du Collège, tous trois dc Saint-Éphrem-dc-Tring, pour les objets suivants: Intéresser les jeunes au progrès économique, social et civique dejeur milieu, sous le nom dc « La Jeune Chambre de St-Éphrcm (Beauce) inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, estdcSlOO.OOO.( \u2022 Le siège social de la corporation est à Sainl-Ëphrciu-de-Tring, district judiciaire de Bcaucc.Le sous-miiiislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5440-1970 La Jeune Chambre de Sl-Nazaire Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de décembre 1970.constituant en corporation sans capital-actions: Philippe Bouchard, instituteur, 23S, rue Principale, Jean-Marie Pelletier, reinbourreur, 283, rue Principale, et Jacques Tremblay, boucher, 209, rue Principale, tous trois de Saint-Nazaire, pour les objets suivants: Intéresser les jeunes au progrès économique, social et civique de leur milieu, sous le nom de « La Jeune Chambre de St-Nazairc ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc 850,000.Le siège social de la corporation est à Saint-Nazaire, comté de Lac St-Jean, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5438-1970 rate a corporation without share capital: André Bolduc, cashier, P.O.Box 26, Roger Bureau, carpenter, Ste-Famillc Boulevard, and Charles-Aimé Robert, College Street, all three of Saint-Éphrem-dc-Tring, for the following purposes: To interest young people in the economic, social and civic progress of their surroundings, under the name of \"La Jeune Chambre de St-Éphrem (Beauce) inc.\".The amount to which is to be limited the value of the immovable property which the corporation may acquire or possess is S100.000.The head office of the corporation is at Saint-Éphreni-de-Tring, judicial district of Bcaucc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies aiid Cooperatives.38630 5440-1970 La Jeune Chambre de St-Nazairc Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Philippe Bouchard, teacher, 23S Main Street, Jean-Marie Pelletier, upholsterer, 283 Main Street, and Jacques Tremblay, butcher, 209 Main Street, all three of Saint-Nazaire, for the following purposes: To interest youth in the economic, social and civic progress of their milieu, under the name of \"La Jeune Chambre dc St-Nazairc\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $50,000.The head office of the corporation is at Saint-Nazaire, county of Lake St.John, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5438-1970 Labrccquc & Du Tremble inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 11c jour dc décembre 1970, constituant en corporation : Gaston Du Tremble, 620, Antoine Girouard, app.1, Louis Labrccquc, tous deux installateurs d'aluminium, et Réjanc Lacoursière, ménagère, épouse dudit Louis Labrccquc, ces deux derniers de 854B.boulevard Fort St-Louis, tous trois dc Boucher-ville, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Labrecque & Du Tremble inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de 8100 chacune.Labrccquc & Du Tremble inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gaston Du Tremble, 620 Antoine-Girouard, Apt.1, Louis Labrccquc, both aluminum installers, and Réjanc Lacoursière, housewife, wife of said Louis Labrccquc, the latter two of S54B Fort St-Louis Boulevard, all three of Boucherville, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Labrecque & Du Tremble inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of 810 each and 200 preferred shares of a nominal value of 8100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Le siège social de la compagnie est 620, Antoine Girouard, appartement 1, Boucherville, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 5519-1970 Oscar Lafrenière & fils limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour de novembre 1970, constituant en corporation : Jacques Lafrenière, marchand, Agathe Alie, ménagère, épouse dudit Jacques Lafrenière, Jean-Charles Lafrenière, marchand, et Denise Bélanger, ménagère, épouse dudit Jean-Charles Lafrenière, tous quatre de Gracefield, pour les objets suivants : Faire affaires comme marchand général, sous le nom de « Oscar Lafrenière & fils limitée », avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 3,000 actions privilégiées dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Gracefield, district judiciaire de Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4787-1970 Robert Lagueux inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Robert Lagueux, 66, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Maryse LeBlanc, épouse divorcée d'Euclide Riel, 325, boulevard Ste-Elizabeth, La Prairie, tous deux courtiers d'assurances, et Camille Martellani, entrepreneur, 3020, Allard, Montréal, poulies objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom de « Robert Lagueux inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de SI chacune et en 380 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 325, boulevard Ste-Elizabeth, La Prairie, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5387-1970 Lamarche Crane Services Inc.Service de grues Lamarche inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de novembre 1970, consti- 1647 The head office of the company is at 620 Antoinc-Girouard, Apartment 1, Boucherville, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5519-1970 Oscar Lafrenière & fils limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Lafrenière, merchant, Agathe Alie, housewife, wife of said Jacques Lafrenière, Jean-Charles Lafrenière, merchant, and Denise Bélanger, housewife, wife of said Jean-Charles Lafrenière, all four of Gracefield, for the following purposes: To carry on business as general merchant, under the name of \"Oscar Lafrenière & fils limitée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Gracefield, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and- Cooperatives.38630 4787-1970 Robert Lagueux inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Lagueux, 66 Maric-Victorin boulevard, Candiac, Maryse LeBlanc, ex-wife of Euclide Riel, 325 Stc-Elizabeth boulevard, La Patrie, both insurance brokers, and Camille Martellani, contractor, 3020 Allard, Montreal, for the following purposes: To do business as agents and insurance brokers, under the name of \"Robert Lagueux inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 81 each and 380 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 325 Ste-Eliza-the boulevard, La Prairie, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5387-1970 Lamarche Crane Services Inc.Service de grues Lamarche inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorpora- 1648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 tuant en corporation: Julien Lamarche, opérateur, Jacqueline Lamarche, ménagère, épouse dudit Julien Lamarche, tous deux dc 5649, 14e Avenue, Montréal, Jean-Guy Pigeon, opérateur, et Madeleine Pigeon, ménagère, épouse dudit Jean-Guy Pigeon, ces deux derniers dc 1037, 19c Avenue, Laval, pour les objets suivants: Fabriquer cl l'aire le commerce dc grues, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom dc « Lamarche Crane Services Inc.\u2014 Services de grues Lamarche inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires dc SI chacune et en 3,000 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.l.c sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PiiiT.ippK Bouchard.38630-o 5173-1970 Lantech inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Michel Bonneville, comptable, 3343, rue Lacombc, Denise Lemay, 1685, rue Charles-Falkner, tous deux dc Montréal, et Claire Cardinal, 7553, rue Edouard, Lasalle, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exploiter des bureaux dc société professionnelle ou commerciale, sous le nom de « Lautcch inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phii.ippe Bouchard.38630-o 1950-1970 ting: Julien Lamarche, operator, Jacqueline Lamarche, housewife, wife of said Julien Lamarche, both of 5649, 14th Avenue, Montreal, Jean-Guy Pigeon, operator, and Madeleine Pigeon, housewife, wife of said Jean-Guy Pigeon, the latter two of 1037, 19th Avenue, Laval, for the following purposes: To manufacture and deal in cranes, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Lamarche Crane Services Inc.\u2014 Services de grues Lamarche inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of SI each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5173-1970 Lantech inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel Bonneville, accountant, 3343 Lacombc Street, Denise Lemay, 16S5 Charlcs-Falkncr Street, both of Montreal, an Claire Cardinal, 7553 Edouard Street, Lasalle, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To operate professional or commercial society offices under the name of \"Lautcch inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 1950-1970 G.Lcbeau ltéc G.Lebeau Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la.Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour dc décembre 1970, autorisant la fusion des compagnies « G.Lcbcau ltée » et « G.B.S.Glass Ltd.», toutes deux constituées en corporation en vertu dc ladite première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes respectivement datées du 14 janvier 1959 et du 1er décembre 1949, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes pièces et accessoires, outils, équipements et fournitures de toutes sortes, sous le nom de « G.Lebeau ltée \u2014 G.Lebeau Ltd.», avec un capital-actions divisé et 103 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair, dont toutes représentent un capital acquitté de 84,003.G.Lebeau ltée G.Lebeau Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, dated the 31st day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"G.Lebeau ltéc » and « G.B.S.Glass Ltd.\", both incorporated under the said Part I of the Companies Act, by letters patent dated, respectively, January 14, 1959, and December 1, 1949, for the following purposes: To manufacture and deal in all parts and accessories, tools, equipment and supplies of all kinds, under the name of \"6.Lebeau ltée \u2014 G.Lebeau Ltd.\", with a capital stock divided into 103 common shares without nominal or par value, all of which, representing a paid-up capital of $4,003. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Le siège social de la nouvelle compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 4977-70 La ligue des propriétaires dc Blainvillc Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Camille Guay, agent, 43, 70e Avenue ouest, Frank White, estimateur, 40, 70e Avenue ouest, Jean Boulais, vendeur, 47, Carré des Forges, Jean-Guy Bourbeau, 39, 70e Avenue ouest, Antonio Yale, 1006, Alain, tous deux commis, et Claude Clément, technicien, 53, 70c Avenue ouest, tous de Blainvillc, pour les objets suivants : Promouvoir les intérêts culturels et sociaux des membres, sous le nom de « La ligue des propriétaires de Blainvillc ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de S500.000.Le_ siège social dc la corporation est à Blainvillc, district judiciaire dc Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 4340-1970 Lionel Sales and Distribution Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Robert Vineberg, avocat, route rurale no 4, Godmanchcster, Barbara Komomicki, 4353, Saint-Urbain, Montréal, et Maureen Montgomery, 30, place Côte Vertu, Saint-Laurent, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce d'équipement pour le sport et les activités dc loisirs, sous le nom de « Lionel Sales and Distribution Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des i/islilulions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630 5258-1970 Lithographie Desjardins inc.Desjardins Lithographing Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres 1649 The head office of the new company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depxdy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4977-70 La ligue des propriétaires de Blainvillc Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Camille Guay, agent, 43, 70th Avenue, West, Frank White, estimator, 40, 70th Avenue west, Jean Boulais salesman, 47 des Forges Square, Jean-Guy Bourbeau, 39, 70th Avenue, West, Antonio Yale, 1006 Alain, both clerks, and Claude Clément, technician, 53, 70th Avenue West, all of Blainville, for the following purposes: To promote social and cultural interests of the members, under the name of \"La ligue des propriétaires de Blainville\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation mav acquire and hold is 8500,000.The head office of the corporation is at Blainville, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4340-1970 Lionel Sales and Distribution Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Vinebcrg, advocate, Rural Route No.4, Godrnanchester, Barbara Komomicki, 4353 St.Urbain, Montreal, and Maureen Montgomery, 30 Place Côte Vertu, Saint-Laurent, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To manufacture and deal in recreation and sports equipment, under the name of \"Lionel Sales and Distribution Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of a par value of S10 each and 3,000 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5258-1970 Lithographie Desjardins inc.Desjardins Lithographing Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial 1G50 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n\" 7 patentes, en date du 18c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Daniel Kochcnburger, 1545, Graham, app.5, Mont-Royal, Michel Blouin, 3328, Troie, app.212, et Michel Duranccau, 5775, Darlington, app.251, ces deux derniers dc Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, éditeurs, papetiers, lithographes, graveurs, relieurs, librairies, fondeurs typographes, et autres commerces semblables, sous le nom dc « Lithographie Desjardins inc.\u2014 Desjardins Lithographing Inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 3,000 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 3333, boulevard Métropolitain, Lachine, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5611-1970 Logex inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 30e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Claude Beauchamp, commis, 196, Tournelle, Alain Côté, avocat, et Suzanne Beau-champ, institutrice, épouse dudit Alain Côté, ces deux derniers de 177, Carignan, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce dc toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Logex inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 62, Goineau, Laval, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630-o 5261-1970 Les loisirs de la paroisse Sl-Joscph de Sherbrooke Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard Bourquc, mécanicien, 1434, Dorval, Firmin Bocquet, soudeur, 1261, Mclntoch, et Alexandre Basque, opérateur, 1272, Mclntoch, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Les loisirs de la paroisse St-Joscph de Sherbrooke ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de S40.000.Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Daniel Kochcnburger, 1545 Graham, Apt.5, Mount Royal, Michel Blouin, 3328 Troie, Apt.212, and Michel Duranceau, 5775 Darlington, Apt.251, the latter two of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as printers, publishers, stationers, lithographers, engravers, bookbinders, booksellers, type-founders, and to deal in other similar businesses, under the name of \"Lithographie Desjardins inc.\u2014 Desjardins Lithographing Inc.\", with a total- capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 3333 Métropolitain Boulevard, Lachinc, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5611-1970 Logex inc.Notice is given that under Part I of the Compnnies Ac,t, letters patent, bearing date the 30th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude Beauchamp, clerk, 196 Tournelle, Alain Côté, advocate, and Suzanne Beauchamp, teacher, wife of said Alain Côté, the latter two of 177 Carignan, all three of Laval, for the following purposes: To carry on business as general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Logex inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 62 Goineau, Laval, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5261-1970 Les loisirs de la paroisse St-Joscph de Sherbrooke Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Gérard Bourquc, mechanic, 1434 Dorval, Firmin Bocquet, welder, 1261 Mclntoch, and Alexandre Basque, operator, 1272 Mclntoch, all three of Sherbrooke, for the following purposes: The organization of recreational activities, under the name of \"Les loisirs de la paroisse St-Joseph de Sherbrooke\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $40,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 Le siège social de la corporation est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5530-1970 M.G.sports ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de décembre 1970, constituant en corporation : André St-Michcl, comptable, 31,.Jogues, Lucille Gauthier, ménagère, épouse de Marcel Gauthier, 30, Gadbois, tous deux de Sorel, et Lise Ethicr, secrétaire, fille majeure, 415, Decelles, Tracy, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, bateaux, autos-neige, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « M.G.sports ltée», avec un capital divisé en 5,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 350 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Sorel, district judiciaire de Richelieu.Le sous-7ninislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 3912-1970 Main Optical Inc.Optique Principale inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de décembre 1970, constituant en corporation : Eric Segal, technicien dc laboratoire, 5460, Bcssborough, app.22, Harvey Toulch, étudiant, 5615, Durocher, tous deux de Montréal, et Libby Craena Segal, administrateur, épouse dudit Harvey Toulch, 211, Netherwood Crescent, Hampstcad, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce de tout équipement d'optique, dc lunettes, lentilles et/ou dc tous autres objets qui s'y rattachent, sous le nom de « Main Optical Inc.\u2014 Optique Principale inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est au 4021, boulevard Saint-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5319-1970 La Maison du chômeur de St-Hcnri inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Jean Pilon, 1651 The head office of the corporation is at Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5530-1970 M.G.sports ltéc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: André St-Michcl, accountant, 31 .Toques, Lucille Gauthier, housewife, wife of Marcel Gauthier, 30 Gadbois, both of Sorel, and Lise Etliier, secretary, spinster of the full age of majority, 415 Deccllcs, Tracy, for the following purposes: To do business as garage-owners and to deal in cars, boats, snowmobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"M.G.sports ltée\", with a capital stock of 5,000 common shares of no nominal value of 250 preferred shares of 8100 each._ The head office of the company is at Sorel, judicial district of Richelieu.Ls-Phii.ippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 3912-1970 Main Optical Inc.Optique Principale inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Eric Segal, laboratory technician, 5460 Bcssborough, Apt.22, Harvey Toulch, student, 5615 Durocher, both of Montreal, and Libby Craena Segal, executive, wife of the said Harvey Toulch, 211 Netherwood Crescent, Hampstcad, for the following purposes: To manufacture and deal in all optical equipment, eye glasses, lenses and/or any other objects related thereto, under thc_ name of \"Main Optical Inc.\u2014 Optique Principale inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 40,000 common shares of 81 each.The head office of the company is at 4021 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5319-1970 La Maison du chômeur de St-IIcnri inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: 1652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 2229, De Villiers, Robert Lemieux, 4590, St-Jacques ouest, et J.-Normand Dugré, 2070, Place Henri-Bourassa, app.4, tous trois chômeurs, de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts économiques, culturels et sociaux des chômeurs qui sont dans le besoin, sous le nom dc « La Maison du chômeur dc St-Henri inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est dc S50.000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.3S630-o 5371-1970 Jean Pilon, 2229 De Villiers, Robert Lemieux, 4590 St-Jacques West, and J.-Normand Dugré, 2070 Henri-Bourassa Place, Apt.4, all three unemployed men, of Montreal, for the following purposes: To promote the social, cutlural and economical interests of unemployed men in necessity, under the name of \"La Maison du chômeur de St-Henri inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $50,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5371-1970 La Maison Lambert CIossc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du ISc jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Pierre Laforest, Mario-R.Girard, tous deux dc 4858, Côte des Neiges, Montréal, et Luc Parent, 560, Carlyle, Mont-Royal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, sous le nom dc «La Maison Lambert Clossc inc.», avec un capital total de $250,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 5,000 actions privilégiées d'une valeur nominale dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5608-1970 La Maison Lambert Clossc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, _ have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Laforest, Mario-R.Girard, both of 4858 Côte des Neiges, Montreal, and Luc Parent, 560 Carlylc, Mont-Royal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a real estate company, under the name of \"La Maison Lambert Closse inc.\", with a total capital stock of $250,000, divided into 20,000 common shares of a nominal value of $10 each and 5,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Ministcr of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5608-1970 La Manécanteric et les Choeurs de Montarville inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de novembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Georges Cournoyer, représentant, Armande Champagne, ménagère, épouse dudit Georges Cournoyer, tous deux de 480, Chapman, Jean-Marie Hébert, gérant, et Jeannine Veronneau, ménagère, épouse dudit Jean-Marie Hébert, ces deux derniers de 1905, rue Arvida, tous quatre de Saint-Bruno, pour les objets suivants: Former des chorales, choeurs de chants, groupes musicaux et enseigner la musique sous toutes ses formes, sous le nom de « La Manécanterie et les Choeurs de Montarville inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $100,000.La Manécanteric et les Choeurs de Montarville inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Georges Cournoyer, representative, Armande Compagne, housewife, wife of said Georges Cournoyer, both of 480 Chapman, Jean-Marie Hébert, manager, and Jcanninc Veronneau, housewife, wife of said Jean-Marie Hébert, the latter two of 1905 Arvida Street, all four of Saint-Bruno, for the following purposes: To form chorals, chorus, musical groups and to teach music in all its aspects, under the name of \"La Manécanteric et les Choeurs de Montarville inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $100,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiimppe Bouchard.38630-o 5058-1970 Les Maraudeurs de Duhamel inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Léonard Dion, garde forestier, François Gagnon, chauffeur, Yolande Lôvesque, ménagère, épouse de Gilles Léves-que, Madeleine Filiatreault, institutrice, épouse dc Richard Filiatreault, tous quatre de Duhamel, Robert Bélanger, vendeur, 1965, Hcnri-Bourassa est, et Philippe Patry, représentant, 251, Milton, app.29, ces deux derniers dc Montréal, pour les objets suivants: Établir et administrer un club sportif et promouvoir en particidicr le sport dc l'auto-neige, sous le nom de « Les Maraudeurs de Duhamel inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est dc 825,000.Le siège social de la corporation est à Duhamel, district judiciaire dc Hull.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phimppe Bouchard.38630-o 4837-1970 Marché Go-Go du Sagucnay inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Edgar Normandcau, 70, Cabot, Kénogami, Léo Gagnon, 458, Ste-Ursule, et Guy Va-chon, 412, St-Michel, ces deux derniers de Jonquière, tous trois marchands, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers licenciés, sous le nom de « Marché Go-Go du Sagucnay inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 70, rue Cabot, Kénogami, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-minislre des instituions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5565-1970 Marcoux transit inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de novembre 1970, constituant en corporation : André Marcoux, gérant, Colette Marcoux, ménagère, épouse dudit André Marcoux, tous deux de 191, Bellevue, Coaticook, Roger Marcoux, homme d'affaires, et Carole Marcoux, ménagère, épouse 1653 The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Inslilulions, Companies and Cooperatives.38630 5058-1970 Les Maraudeurs de Duhamel inc.Notice is given that under Part ni of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Léonard Dion, forest ranger, François Gagnon, chauffeur, Yolande Lévesque, housewife, wife of Gilles Lévesquc, Madeleine Filiatreault, teacher, wife of Richard Filiatreault, all four of Duhamel, Robert Bélanger, salesman, 1965 Hcnri-Bourassa East, and Philippe Patry, representative, 251 Milton, Apt.29, the latter two of Montreal, for the following purposes: To establish and manage a sports club and to promote snowmobiling in particular, under the name of \"Les Maraudeurs dc Duhamel inc.\".The amount to which is limited the annual revenue of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $25,000.The head office of the corporation is at Duhamel, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4837-1970 Marché Go-Go du Sagucnay inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing (late the 17th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Edgar Normandcau, 70 Cabot, Kénogami, Léo Gagnon, 458 Ste-Ursule, and Guy Vachon, 412 St-Michcl, the latter two of Jonquière, all three merchants for the following purposes: To do business as licensed grocers, under the name of \"Marché Go-Go du Saguenay inc.\", with a total capital stock of $100,000 divided into 10,000 common shares of a nominal value of S10 each.The head office of the company is at 70 Cabot street, Kénogami, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5565-1970 Marcoux transit inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: André Marcoux, manager, Colette Marcoux, housewife, wife of said André Marcoux, both of 191 Bellevue, Coaticook, Roger Marcoux, businessman, and Carole Marcoux, housewife, wife of said Roger Marxoux, 1G54 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103- année, n° 7 dudit Roger Marcoux, ces deux derniers dc 1265, Cousineau, app.7, Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Marcoux transit inc.», avec un capital total dc 8150,000, divisé en 20,000 actions ordinaires dc SI chacune, 60,000 actions privilégiées classe « A » dc SI chacune et en 70,000 actions privilégiées classe « B » dc $1 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Coaticook, district judiciaire dc Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralics, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5000-1970 Mnrlass Realties Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Marta Marton, secrétaire, épouse dc feu Andrew Marton, 3550, avenue Ridgc-wood, app.41, Laszlo Szemenyci, avocat, et Maria Szcmcnyci, ménagère, épouse dudit Laszlo Szcmcnyei, ces deux derniers du 4440, avenue Hingston, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble, sous le nom de « Marluss Realties Ltd.», avec un capital total dc 540,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 2015, rue Drum-mond, bureau 750, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5040-1970 Mar-Tcx Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Sonny Solomon, vendeur, 5460, Sunnybrookc, app.405, Morris Solomon, administrateur, et Selma Mendelsohn, secrétaire, épouse dudit Morris Solomon, ces deux derniers du 7913, West-brooke, tous trois dc Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: S'établir détaillants, commerçants en gros, intermédiaires, importateurs et exportateurs dc toutes sortes dc drap, textile ou tissus, sous le nom dc « Mar-Tcx Ltd.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 9400, boulevard Saint-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5467-1970 the latter two of 1265 Cousineau, Apt.7, Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Marcoux transit inc.\", with a total capital stock of $150,000, divided into 20,000 common shares of $1 each, 60,000 class \"A\" preferred shares of $1 each and 70,000 class \"B\" preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Coaticook, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial histitutions.Companies and Cooperatives.38630 5000-1970 Mnrlass Realties Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marta Marton, secretary, wife of the late Andrew Marton, 3550 Ridgcwood Avenue, Apt.41, Laszlo Szcmenyei, advocate, and Maria Szemcnyei, housewife, wife of the said Laszlo Szemcyei, the latter two of 4440 Hingston Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Marlass Realties Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of the par value of 810 each and 3,000 preferred shares of the par value of S10 each.The head office of the company is at 2015 Drummond Street, suite 750, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5040-1970 Mar-Tcx Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Sonny Solomon, salesman, 5460 Sunnybrookc, Apt.405, Morris Solomon, executive, and Sclma Mendelsohn, secretary, wife of the said Morris Solomon, the latter two of 7913 Westbrookc, all three of Côte Saint-Luc, for the following purposes : To carry on business as retailers, wholesalers, jobbers, importers and exporters of all kinds of cloth, textile or fabrics, under the name of \"Mar-Tex Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 9400 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Mi/iistcr of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5467-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1655 Maska Beef Packers Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de novembre' 1970, constituant en corporation: Robert Racine, commerçant, 705, St-Thonias, Saint-Joseph, Jean-Claude Grcnon, boucher, 565, d'Argencourt, Douville, et Yves Veilleux, livreur, 42, rue Roi, Sainte-Rosalie, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes espèces d'articles et marchandises qui font généralement l'objet d'un commerce d'épicerie, de charcuterie, dc boucherie et dc salaison, sous le nom dc « Maska Beef Packers Inc.», avec un capital total de S100.000, divisé en 6,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 400 actions privilégiées d'une valeur nominale dc S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Saint-Hyacinthe, district judiciaire dc Saint-Hyacinthe.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4899-1970 Mclri inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Robert Hamcl, ingénieur, 18, Place Dcstrembles, Jean Jacob, contremaître, et Lyscttc Lcith, ménagère, épouse dudit Jean Jacob, ces deux derniers de 235C, boulevard Fiset, tous trois de Sorel, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce dc machineries, moteurs, machines, leurs parties et accessoires, et autres instruments et appareils, sous le nom de « Mclri inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 150 actions ordinaires dc 8100 chacune et en 250 actions privilégiées dc S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Sorel, district judiciaire de Richelieu.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 5658-1970 Metro Spiralt niie Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentés, en date du 16e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Giuseppe Joseph Racanclli, directeur commercial, 542, Place de Beaucaire, Laval, Lucien Forest, 10896, Gariépy, Montréal-Nord, Jacques Perrault, 10625, Francis, et Rodrigue Durand, 3199, Jean-Talon est, app.7, ces deux derniers de Montréal, ces trois derniers techniciens, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce dc marchandises et articles fabriqués totalement ou en partie dc métaux Maska Beef Packers Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Racine, trader, 705 St-Thomas, Saint-Joseph, Jean-Claude Grcnon, butcher, 565 d'Argencourt, Douville, and Yves Veilleux, delivery-man, 42 Roi Street, Sainte-Rosalie, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of articles and goods usually found in grocery, pork-butchery, butchery and salting businesses, under the name of \"Maska Beef Packers Inc.\", with a total capital stock of SI00,000, divided into 6,000 common shares of a nominal value of S10 each and into 400 preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Ls-Philippf.Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030 4899-1970 Mclri inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Hamcl, engineer, 18 Place Dcstrembles, Jean Jacob, foreman, and Lysctte Lcith, housewife, wife of the said Jean Jacob, the latter two of 235C Fisct Boulevard, all three of Sorel, for the following purposes: To manufacture and to deal in machinery, motors, machines, their parts and accessories, and other instruments and applicances, under the name of \"Melri inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 150 common shares of S100 each and 250 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Sorel, judicial district of Richelieu.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 ' 5658-1970 Metro Spiraltube Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Giuseppe Joseph Racanelli, commercial director, 542 Place de Beaucaire, Laval, Lucien Forest, 10896 Gariépy, Montreal-North, Jacques Perreault, 10625 Francis, and Rodrigue Durand, 3199 Jean-Talon East, Apt.7, the latter two of Montreal, the latter three technicians, for the following purposes: To manufacture and deal in goods and articles manufactured in whole or in part in metal or wood, under 1656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n' 7 ou bois, sous le nom de « Metro Spiraltube Inc.>, avec un capital total dc 840,000, divisé en 50 actions ordinaires de S100 chacune et en 1,400 actions privilégiées de S25 chacune.Le siège social de la compagnie est 26, des Sulpiciens, L'Epiphanie, district judiciaire dc Joliettc.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Mouchard.38630-o 5560-1970 Meubles G.Lamothc -X fils ltéc Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour dc novembre 1970, constituant en corporation : Gérard Lamothc, commerçant, Béatrice Pctilclerc, ménagère, épouse dudit Gérard Lamothc, tous deux de 718, des Peupliers, et Bruno Girard, technicien, 105, des Pins, tous trois dc Dolbeau, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de meubles et nouveautés dc toutes sortes, sous le nom de « Meubles G.Lamothc & fils liée », avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 716, rue des Peupliers, Dolbeau, district judiciaire de Roberval.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5195-1970 Mini Putt Venise Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Robert Martineau, marchand, 4690, Ste-Catherine est, Denise Langlois, ménagère, fille majeure, 2171, Liébcrt, tous deux de Montréal, Rosaire Laplante, restaulareur,_ et Bernard Luplonle, commis, ces deux derniers de Vcnise-en-Québcc, pour les objets suivants: Exploiter des terrains de golf, dc « putting', sous le nom de « Mini Putt Venise Inc.», avec un capital total de S10.000, divisé en 10,000 actions ordinaires dc 81 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Venise-en-Québec, district judiciaire dc Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 4802-1970 Armand Miron & fils transport inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Armand Miron, chauffeur, Germaine Patcnaudc, ménagère, épouse dudit Armand Miron, tous deux dc 153, St-Pierrc, Saint-Constant, et the name of \"Metro Spiraltube Inc.\", with a totul capital stock of 840,000, divided into 50 common shares of 8100 each und into 1,500 preferred shares of S25 each.The head office of the company is at 26 des Sulpiciens, L'Epiphanie, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5560-1970 Meubles G.Lumotbc X fils liée Noticc is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérard Lamothc, trader, Béatrice Petit-clerc, housewife, wife of said Gérard Lamothc, both of 718 des Peupliers, and Bruno Girard, technician, 105 des Pins, all three of Dolbeau, for the following purposes: To manufacture und deul in furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Meubles G.Lamothc & fils liée\", with u total capital slock of S40.000, divided inlo 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company is at 716 Peupliers Street, Dolbeau, judicial district of Robcrval.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5195-1970 Mini Putt Venise Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, lettcrspatcnt, bearing dale Hie 3rd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Martineau, merchant, 4690 Stc-Cathcrinc East, Denise Langlois, housewife, spinster of the full age of majority 2171 Liébert, both of Montreal, Rosaire Laplante, restaurateur, and Bernard Laplante, clerk, the latter two of Venise-cn-Québec, for the following purposes: To operutc golf courses and \"putting\" in general, under the name of \"Mini Putt Venise Inc.\".with a total capital stock of S10,000, divided inlo 10,000 common shares of 81 each.The head office of the company is at Venise-en-Qué-bec, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4802-1970 Armand Miron & fils transport inc.Notice is given thai under Pari I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Armand Miron, driver, Germaine Patcnaudc, housewife, wife of said Armand Miron, both of 153 St-Picrre, Saint-Constant, und Réjcannc QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Iléjeannc Fatenaude, secrétaire, fille majeure, 8101, Montoir, app.203, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc transport, sous le nom de « Armand Miron & fils transport inc.» avec un capital total dc §40,000, divisé en 40.000, uctions ordinaires de §1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Constant, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5321-1970 Modern Air Spray Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres [latentes, en date du 13c jour dc novembre 1970, constituant en corporation: René Clouticr, agronome, Sainte-Rosalie, Paul Hajduk, pilote, et Delia Margarita Gonzales, ménagère, épouse dudit Paul Hajduk, ces deux derniers du 271, boulevard Saint-Luc, Saint-Luc, porr les objets suivants: Établir et diriger une entreprise d'extermination par voie aérienne par arrosage aérien de produits chimiques, sous le nom «le « Modem Air Spray Ltd.», avec un capital total dc §40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair dc §100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair dc §100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Jean district judiciaire dTbcrville.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 4967-1970 Modern Miss Sportswear Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé «les lettres patentes, en date du 13e jour «le novembre 1970, autorisant la fusion «le la compagnie \" Samay Juniors Inc.».et la compagnie « Modem Miss Sportswear Inc.», toutes deux constituées en corporation en vertu dc ladite première partie dc la Loi des compagnies, par lettres patentes respectivement datées du 8 août 1963 et du 16 février 1965, pour les objets suivants: Confectionner des vêtements et tissus à vêtements et produits des tissus, en faire le commerce, sous le nom dc «Modem Miss Sportswear Ltd.», avec un capital total de 860,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune, 5,250 actions privilégiées première catégorie d'une valeur au pair dc S10 chacune et 2,500 actions privilégiées deuxième catégorie d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à 160 est, rue St-Viateur, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 4522-1970 1657 Puteuuude, secretary, spinster, 8101 Montoir, Apt.203, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Armand Miron & fils transport inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 40,000 common shares of SI each.The head office of the company is at Suint-Constant, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instituions, Companies and Cooperatives.38630 5321-1970 Modern Air Spray Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: René Cloutier, agronome, Sainte-Rosalie, Paul Hajduk, pilote, and Delia Margarita Gonzales, housewife, wife of the said Paul Hajduk, the latter two of 271 St.Luc Boulevard, Saint-Luc, for the following purposes: To carry on the business of aerial extermination and aerial spraying of chemical proilucts, under the name of \"Modern Air Spray Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, dividctl into 200 common shares of the par value of 8100 each and 200 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company is ut Saint-Jean, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4967-1970 Modern Mi- Sportswear Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, dated the 13th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Samay Juniors Inc.\" and \"Modern Miss Sportswear Inc.\", both incorporated under the said Part I of the Companies Act, by letters patent dated, respectively, August 8, 1963, and February 16, 1965, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of clothing and garments fabric and fabric products under the name of \"Modern Miss Sportswear Ltd.\", with a total capital stock of 860,000, divided into 500 common shares of the par value of 810 each, 5,250 first preferred shares of the par value of 810 each and 2,500 second preferred shares of tlie par value of 81 each.The head office of the new company is at 160 St.Viateur Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, .Companies and Cooperatives.38630-o 4522-1970 1658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n\" 7 Mont Caron Ski Contre Inc.Centre de ski Mont Caron inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Roland Lévcsquc, homme d'affaires, 239, Principale, Tourainc, Richard Gauthier, 22, Normandie, app.5, et Marcel Sieard, 68A, Maison-neuve, ces deux derniers fonctionnaires, de Hull, pour les objets suivants: Exploiter un centre dc ski, sous le nom île « Mont Caron Ski Centre Inc.\u2014 Centre dc ski Mont Caron inc.», avec un capital total dc 860,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc SI chacune et en 590 actions privilégiées dc S100 chacune.Le siège social dc la compagnie st à Wakefield, district judiciaire dc Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 3810-1970 Motel Connelly-Nord inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Eugène Boucher, 8644, boulevard Provcnchcr, Saint-Léonard, Dollard Boucher, 8270, 9e Avenue, et Lionel Boucher, 8009, 9e Avenue, ces deux derniers de Montréal, tous trois entrepreneurs, pour les objets suivants: Exploiter des motels, hôtels, tavernes, bars-salons, auberges et restaurants, sous le nom dc « Motel Connelly-Nord inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 300 actions ordinaires dc S10 chacune et en 370 actions privilégiées dc S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est Lac Connelly, Saint-Hippolytc, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, 38630-o 4606-1970 Multi-service Granby inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne uvis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 27c jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Jean-Pierre Picottc, 66, boulevard Lcclcrc, Gilles-D.Dallairc, 156, boulevard Lcclerc, tous deux comptables agréés, et Mireille Bcrnicr, secrétaire, fille majeure, 486, Rachel, tous trois dc Granby, pour les objets suivants: Exploiter une étude dc conseillers en administration et offrir les services d'experts dans tous les domaines reliés dc près ou de loin à l'administration, sous le nom de « Multi-service Granby inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Mont Caron Ski Centre Inc.Centre dc ski Mont Caron inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions,, Companies and Cooperatives, incorporating: Roland Lévcsquc, businessman, 239 Main, Tourainc, Richard Gauthier, 22 Normandie, Apt.5 and Marcel Sicard, 68A Maisonneuvc, the latter two civil employees, of Hull, for the following purposes: To operate n ski centre, under the name of \"Mon I.Caron Ski Centre Inc.\u2014 Centre de ski Mont Caron inc.\", with a total capital stock of S60.000, divided into 1,000 common shares of SI each and 590 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Wakefield, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Firiancial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 3810-1970 Motel Connclly-Nord inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Eugène Boucher, 8644 Provcnchcr Boulevard, Saint-Léonard, Dollard Boucher, 8270, 9th Avenue, and Lionel Boucher, 8009, 9th Avenue, the latter two of Montreal, all three contractors, for the following purposes: To operate motels, hotels, taverns, burs-salons, inns and restaurants, under the name of \"Motel Connclly-Nord inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 300 common shares of S10 each and 370 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Lac Connelly, Saint-Hippolyte, judicial district of Terrebonne.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4606-1970 Multi-service Granby inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent; bearing date the 27th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Pierre Picottc, 66 Lcclerc Boulevard, Gilles-D.Dallairc, 156 Lcclcrc Boulevard, both chartered accountants, and Mireille Bcrnier, secretary, spinster of the full age of majority, 486 Rachel, all three of Granby, for the following purposes: To run and office of counsellors in administration and to offer the service of experts in fields closely or loosely connected with administration, under the name of \"Multi-service Granby inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.February 13.1971, Vol.103, No.7 Le siège social dc la compagnie est à Granby, district judiciaire de Bedford.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, \u2022T.-At.beht Gagnon.38630-o 5359-1970 Multi-Soins inc.Le minisire des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jean Marier, avocat, 2530, Chassé, Sainte-Foy, Thérèse DesRivières, 517, St-Cy-rillc ouest, Francine Raymond, 331, des Saules ouest, Louise Falardcau, 181, Aberdeen, et Nicole Lessard, 10S0, Bougainville, ces quatre dernières secrétaires, filles majeures, de Québec, pour les objets suivants: Agir comme conseillers en administration hospitalière, sous le nom dc « Multi-Soins inc.», avec un capital divisé en 6,000 actions ordinaires sans valeur nominale, 60,000 actions privilégiées classe « A » d'une valeur nominale dc SI chacune et en 6,000 actions privilégiées classe « B » d'une valeur nominale de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal., Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPF.bouchard.38630-o 5492-1970 .M ust a nu Investments Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour, de décembre 1970, constituant en corporation: Louise Dclormc, 350, avenue des Pins, Saint-Lambert, Dcnysc Marcoux, 1488, Galt, toutes deux secrétaires, Yolande Poliseno, réceptionniste, 7928, Durochcr, toutes trois filles majeures, et Guy-E.Boisvert, avocat, 4976, Glencairn, ces trois derniers dc Montréal, pour les objets suivants: Etablir et diriger une compagnie de placement, sous le nom de « Mustang Investments Inc.», avec un capital total de S300.000, divisé en 300,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5309-1970 National Containers Holdings Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de décembre 1970, constituant en corporation: Hyman Katz, industriel, 169, avenue Maplewood, Outremont, Moe Goodis, administrateur, 5772, avenue Palmer, et Isadorc 1659 The head office of the company is at Granby, judicial district of Bedford.J.-Albkrt Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3S630 5359-1970 Multi-Soins inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean Marier, advocate, 2530 Chassé, St.Foy, Thérèse DesRivières, 517 St-Cyrille West, Francine Raymond, 331 des Saules West, Louise Falardeau, 181 Aberdeen, and Nicole Lessard, 1080 Bougainville, the latter four secretaries, spinsters of the full age of majority, of Québec, for the following purposes: To act as hospital management consultants, under the name of \"Multi-Soins inc.\", with a capital stock divided into 6,000 common shares without nominal value, 60,000 class \"A\" preferred shares of a nominal value of SI each and into 6,000 class \"B\" preferred shares of a nominal value of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030 5492-1970 Mustang Investments Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Louise Delorme, 350 Pine Avenue, Saint-Lambert, Denyse Marcoux, 1488 Gait, both secretaries, Yolande Poliseno, receptionist, 7928 Durochcr, all three spinsters, and Guy-E.Boisvert, advocate, 4976 Glencairn, the latter three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Mustang Investments Inc.\", with a total capital stock of 8300,000, divide into 300,000 common shares of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minisler of Financial histilulions, Companies and Cooperatives.38630-o 5309-1970 National Containers Holdings Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Hyman Katz, industrialist, 169 Maple-wood Avenue, Outremont, Moe Goodis, executive, 5772 Palmer Avenue, and Isadorc Cohen, comptroller. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 16(30 Cohen, contrôleur, 5761, avenue Hudson, ces deux derniers dc Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de portefeuille et de placement, sous le nom de « National Containers Holdings Corp.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est au 23, du Moulin, Saint-Pierre, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030 5486-1970 Le nettoyeur « Maison Blanche » inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10c jour de décembre 1970, constituant en corporation : Jacques Jokish, nettoyeur, 11713, boulevard Gouin ouest, Pierrefonds, Hollande Vaillan-court, gérante, épouse de Roger Rivest, 5975, Louis-Hémon, Montréal, Paul-A.Crevicr, administrateur, 7271, Joseph-Renaud, Anjou, et Georgette Vaillancourl, ménagère, veuve de Bernard Isabelle, 1844, De La Rousselièrc, Pointe-aux-Trembles, pour les objets suivants: Faire affaires comme nettoyeurs, presseurs, teinturiers, buandiers et faire la répand ion de vêtements, tissus, marchandises et ameublements dc maison, sous le nom dc « Le nettoyeur « Maison Blanche » inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Anjou, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 5441-1970 Nictspil Sport Centres Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Allan Lipstcin, moniteur, Lise Gagnon, épouse dudit Allan Lipstein, et Fay Titleman, épouse de' William Lipstcin, ces deux dernières ménagères, tous trois du 1923, rue Romiti, Laval, pour les objets suivants: Établir et diriger un centre sportif et un gymnase, sous le nom de « Nietspil Sport Centres Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5274-1970 5761 Hudson Avenue, the latter two of Côte Saint-Luc, for the following purposes: To carry on the business of a holder and investment company, under the name of \"National Containers Holdings Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided inlo 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 23 du Moulin, Saint-Pierre, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5486-1970 Le nettoyeur \"Muison Blanche\" inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Jokish, cleaner, 11713 Gouin boulevard West, Pierrefonds, Rollande Vaillancourl, manager, wife of Roger Rivest, 5975 Louis-Hémon, Montreal, Paul-A.Crevier, administrator, 7271 Joseph-Renaud, Anjou, and Georgette Vaillancourt, housewife, widow of Bernard Isabelle, 1844 De La Rousselièrc, Pointe-aux-Trembles, for the following purposes : To do business as cleaners, pressors, dyers, washers and to repair clothes, materials, merchandise and furniture, under the name of \"Le nettoyeur « Maison Blanche » inc.\", with a total capital stock of $40,000 divided into 10,000 common shares of $1 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Anjou, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5441-1970 Nietspil Sport Centres Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Allan Lipstein, instructor, Lise Gagnon, wife of the said Allan Lipstein, and Fay Titleman, wife of William Lipstein, the latter two housewives, all three of 1923 Romiti Street, Laval, for the following purposes: To carry on a business of a sporl centre and gymnasium, under the name of \"Nietspil Sport Centres Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5274-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.108, No.7 \u2022Normez inc.Le ministre «les institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Normand St-Pierre, administrateur, 200, de Gaspé, app.1515, Ile-aux-Soeurs, Ezio Brignoli, estimateur, 5067, boulevard Samson, Laval, et .Tacciuclinc Théorêt, secrétaire, fille majeure, 345, boulevard Jacques-Cartier ouest, Longucuil, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de métaux et produits métalliques dc toutes sortes et leurs sous-produits, sous le nom de « Normez inc.», avec un capital divisé en 1,500 actions ordinaires sans valeur nominale et en 2,500 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 5665-1970 North Knd Sheet Metal Work and Hoofing Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Cécile Trudel, administratrice, veuve de Lucien Laurendeau, 3815, Sabrevois, Montréal-Nord, Rosaire Laurendeau, estimateur, 10240, Sacré-Coeur, et Gaston Boucher, contremaître, 4145, 56c Avenue, ces deux derniers dc Montréal, pour les objets suidants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage et réfrigération, sous le nom dc « North End Sheet Metal Work and Roofing Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 3815, rue Sabrevois, Montréal-Nord, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 3979-1969 Old Europe Travel Services Ltd.Les agences «le voyage Vieille Europe ltéc Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Robert Litvack, 590, Stanstead, Mont-Royal, Ralph Lippcr, 1550, McGregor, Montréal, et David Katznelson, 5526, avenue Ashdale, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une agence générale de vente de billets et une agence de voyages dans toutes ses spécialités, sous le nom dc « Old Europe Travel Services Ltd.\u2014 Les agences de voyage Vieille Europe ltée », uvec 1661 Normez inc.Notice is given that under l'art I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Normand St-Pierre, administrator, 200 de Gaspé, Apt.1515, Ile-aux-Socurs, Ezio Brignoli, estimator, 5067 Samson Boulevard, Laval, and Jacqueline Théorêt, secretary, spinster, 345 Jacques-Cartier Boulevard West, Longucuil, for the following purposes: To manufacture and deal in metals, and metal products of all kinds and their sub-products, under the name of \"Normez inc.\", with a capital stock divided into 1,500 common shares without nominal.value and 2,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouciiaud, Depidy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5665-1970 North End Sheet Metal Work and Hoofing Ltd.Notice is given that under l'art I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Cécile Trmlel, administrator, widow of Lucien Laurendeau, 3815 Sabrevois, Montreal-North, Rosaire Laurendeau, estimator, 10240 Sacré-Coeur, and Gaston Boucher, foreman, 4145, 56th Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as plumbing, healing and refrigeration contractors, under the name of \"North End Sheet Metal Work and Roofing Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 3815 Sabrevois Street, Montreal-North, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 3979-1969 Old Europe Travel Services Ltd.Les agences de voyage Vieille Europe liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Litvack, 590 Stanstead, Mount Royal, Ralph Lipper, 1550 McGregor, Montreal, and David Katznelson, 5526 Ashdale Avenue, Côte Saint-Luc, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a general ticket agency and travel bureau in all its branches, under the name of \"Old Europe Travel Services Ltd.\u2014 Les agences de voyage Vieille Europe ltéc\", with a total capital slock GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, »° 7 1662 un capital total dc 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et 39,000 actions privilégiées dc $1 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 3849, boulevard Saint-Laurent, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiimppe Hough Attn.38630 5421-1970 The Overseas-Canadian Club Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour dc novembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: John H.Wilson, architecte naval, Sharon Wilson, infirmière licenciée, épouse dudit John H.Wilson, tous deux de 4327, avenue Wilson, Michael Olsen, ingénieur des ventes, Lynn Cameron, secrétaire, célibataire, tous deux de 5130 avenue Clanranald et Colin Brown, ingénieur en dessin mécanique 2070, rue Drummond, tous de Montréal, pour les objets suivants: Procurer aux membres des activités sociales et récréatives, sous le nom dc « The Overseas-Canadian Club Inc.*.Le montant auquel est limitée la valeur dc la propriété immobilière que la corporation peut posséder et détenir est 350,000.Le siège social de la corporation est 2070, rue Drummond, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5016-1970 Pan time Mfg.Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Maximilien Polack, 7897, chemin Wavell, Côte Saint-Luc, Harvey M.Coopcrstonc, 1448, Beverley Crescent, Laval, tous deux avocats, Aline Beaulieu, 3801, Cavendish, Montréal, et Diane Malboeuf, 8495, boulevard Lasalle, Lasalle, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce dc toutes sortes dc produits, articles et marchandises, sous le nom de « Pantime Mfg.Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc S10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5161-1970 of S40.000, divided into 1,000 common shares of SI each and 39,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 3849 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5421-1970 The Overscas-Cunadian Club Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: John H.Wilson, naval architect, Sharon Wilson, registered nurse, wife of the said John H.Wilson, both of 4327 Wilson Avenue, Michael Olsen, sales engineer, Lynn Cameron, secretary, spinster, both of 5130 Clanranald Avenue, and Colin Brown, mechanical design engineer, 2070 Drummond Street, all of Montreal, for the following purposes: To provide social and recreational facilities for members, under the name of \"The Overseas-Canadian Club Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which may be owned or held by the corporation, is to be limited, is 850,000.The head office of the corporation is at 2070 Drummond Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5016-1970 Pantimc Mfg.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Maximilien Polak, 7897 Wavell Road, Côte Saint-Luc, Harvey M.Cooperstone, 1448 Beverley Crescent, Laval, both advocates, Aline Bcaulicu, 3801 Cavendish, Montreal, nnd Diane Malboeuf, 8495 Lasalle Boulevard, Lasalle, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Pantime Mfg.Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of a par value of S10 each and 3,000 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5161-1970 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE., February 13, 1971, Vol.103, No.7 I'iinl ornma Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Arthur Yanofsky, 5872, Fem-croft, Asher Kahn, 489, Duffcrin, tous deux avocats, de Hampstcad, et Peggy Tabak, secrétaire, fille majeure, 2211, rue Gold, Saint-Laurent, pour les objets suivants : Exploiter un ou plusieurs magasins de vente au détail, sous le nom de « Pantorama Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie est A Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5316-1970 Les placements Al-vi inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Vital Cliche, avocat, 1007, Bérard, Georges Cliche, stagiaire, 1020, 7e rue, tous deux dc Val d'Or, et Jean-Jacques Cossette, industriel, Champncuf, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de < Les placements Al-Vi inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 40 actions ordinaires dc 81 chacune, 3,992 actions privilégiées classe « A » dc 810 chacune et en 40 actions privilégiées classe « B » tic SI chacune.Le siège social tie la compagnie est à Champncuf, tlistrict judiciaire d'Abitibi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-e 5773-1970 Le prêt d'Argenteuil inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première prtie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Noël Campeau, notaire, 428, boulevard Bédard, André Paré, comptable, 152, boulevard Richelieu, et Yolande Beauchamp, secrétaire, épouse d'André Bergeron, 428, Lafleur, tous trois de Lachute, pour les objets suivants: Faire affaires comme prêteurs d'argent dans toutes ses spécialités, sous le nom de « Le prêt d'Argenteuil inc.», avec un capital total de 8125,000, divisé en 1,250 actions ordinaires de $100 chacune.1663 Pantorama Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd tlay of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies antl Cooperatives, incorporating: Arthur Yanofsky, 5872 Ferncroft, Asher Kahn, 489 Duffcrin, both advocates, of Hampstcad, and Peggy Tabak, secretary, spinster, 2211 Gold Street, Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the business of operating a retail store or stores, under the name of \"Pantorama Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of a par value of 81 each antl 3,000 preferred shares of a par value of S10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial tlistrict of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5316-1970 Les placements Al-vi inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Vital Cliche, advocate, 1007 Bérard, Georges Cliche, articled student, 1020, 7th Street, both of Val d'Or, and Jean-Jacques Cossette, industrialist, Champncuf, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment antl management company, under the name of \"Les placements Al-Vi inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 40 common shares of SI each, 3,992 class \"A\" preferred shares of $10 each and 40 class \"B\" preferred shares of SI each.The head office of the company is at Champncuf, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives.38630 5773-1970 Le prêt d'Argenteuil inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Noël Campeau, notary, 428 Bédard boulevard, André Paré, accountant, 152 Richelieu boulevard, and Yolande Beauchamp, secretary, wife of André Bergeron, 428 Lafleur, all three of Lachute, for the following purposes: To do business as money-lenders in all its specialities, under the name of \"Le prêt d'Argenteuil inc.\", with a total capital stock of S125.000 divided into 1,250 common shares of $100 each. 1064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1071, 103' année, n° 7 Le siège social dc lu compagnie est à Lachulc, district judiciaire dc Terrebonne.Le tout-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 5410-1970 Prêts fonciers (St-Jcan) inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de lu première partie dc lu Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour dc septembre 1970, constituant en corporation: Jacqueline MacAulay, épouse de Kenneth MacAulay, Saint-Jean, Clarisse Pomerlcau, épouse dc Clément Pomerlcau, Iberville, toutes deux ménagères, et Lorraine f Juay, secrétaire, fille majeure, Saint-Biaise, pour les objets suivants: Faire uffuires comme prêteurs d'argent dans toutes ses spécialités, sous le nom de « Prêts fonciers (St-Jean) inc.», avec un capital total de §200,000, divisé en 5,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 1,500 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 3918-1970 Production Après Ski inc.!ératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Roger Mol la, administrateur, Marcelle Dessurcault, ménagère, épouse dudit Roger Molla, tous deux dc 8465, Jean Nicolet, app.20, Saint-Léonard, et Hubert Leroux, notaire, 215, St-Jacques, Montréal, pour les objets suivants: Agir comme conseillers en administration, en comptes reccvablcs et en crédit, sous le nom dc « S.K.D.& associés ltée », avec un capital total dc 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc 810 chacune.Le siège social dc In compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5330-1970 Salon dc coiffure Chateaubriand inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25c jour dc septembre 1970, constituant en corporation: Yves Puquin, administrateur, Odette Pelletier, ménagère, épouse dudit Yves Paquin, tous deux dc 518, Laviolcttc, Nicolet, Gilles Paquin, représentant, et Christine Littahorsky, ménagère, épouse dudit Gilles Paquin, ces deux derniers dc 2244, St-Clément, Giffard, pour les objets suivants: Exploiter des salons «le coiffure, d'esthétique, «le manucure et pédicure, sous le nom de « Salon dc coiffure < 'hât cai il.ri and inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 400 actions ordinaires dc 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Giffard, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4121-1970 Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: François Briscbois, office employee, 337 Coupe-rin, Lucien Brisebois, 630 Bernard, both of Laval, and Jean-Marie Brisebois, 50 Des Forges Square, Blainville, the latter two characterologists, for the following purposes : To operate offices, to effect evaluation, appreciation and selection of personcl and to act as consultants, under the name of \"S.A.C.service d'analyse caractérologique inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 250 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 630, Bernard, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 3465-1970 S.K.D.& associés liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Molla, administrator, Marcelle Dessurcault, housewife, wife of the said Roger Molla, both of 8465 Jean Nicolet, apt.20, Saint-Léonard, and Hubert Leroux, notary, 215 St-Jacques, Montreal, for the following purposes: To act as advisers in administration, in accounts receivable and credit, under the name of \"S.KJD.& associés ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of a nominal value of $10 each.The hea«l office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minisler of Financial histitulions, Companies and Cooperatives.38630 5330-1970 Salon de coiffure Chateaubriand inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies antl Cooperatives, incorporating: Yves Paquin, administrator, Odette Pelletier, housewife, wife of said Yves Paquin, both of 518 Laviolette, Nicolet, Gilles Paquin, representative and Christine Littahorsky, housewife, wife of said Gilles Paquin, the latter two 2244 St-Clément, Giffard, for the following purposes: To operate hairdressing, esthetic, manicure antl pedicure parlors, under the name of \"Salon de coiffure Châteaubriaiul inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Giffanl, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4121-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Sandan Vehicles (Québec) Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Adrien-R.Paqucttc, 212, avenue iiloomficld, Outremont, Benoit Rivet, 3485, rue Papineau, tous deux avocats, et Denis Paqucttc, secrétaire, fille majeure, 9915, rue Esplanade, ces deux derniers dc Montréal, pour les objets suivants : Faire la location d'omnibus, taxis, calèches, autobus, remorques motorisées, camions ou autres moyens de transport privé ou public, sous le nom dc « Sandan Vehicles (Québec) Limited », avec un capital total dc 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc S10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 810 chacune.Le siège social dc la compagnie est 500, rue Saint-François-Xavier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 5264-1970 Scanlan's Publishing Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Clément Bessette, avocat, 465 ouest, rue Dcnison, Cécile Bernard, 382 rue, Saint-Viateur, et Jocelync Lacoste, 113, rue Clarence, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Granby, pour les objets suivants: S'établir éditeurs, imprimeurs, graveurs, relieurs et exploiter des entreprises du même genre, sous le nom dc « Scanlan's Publishing Ltd.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social dc la compagnie est 470, boulevard du Séminaire, Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5575-1970 Max Scigler Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour d'octobre 1970, autorisant la fusion des compagnies « Max Seigler Co.» et « Max-bow Corporation\", toutes deux constituées çn corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes respectivement datées du 7 août 1935 et du 17 septembre 1956, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placements et dc mise en valeur, sous le nom dc « Max Seigler Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 15,000 1671 Sandan Vehicles (Québec) Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Adrien-R.Paqucttc, 212 Bloomficld Avenue, Outremont, Benoit Rivet, 3485 Papineau Street, both lawyers, and Denise Paqucttc, secretary, spinster, 9915 Esplanade Street, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of lessors of omnibuses, cabs, drays, taxicabs, motor buses, auto drays, motor trucks or other private or public conveyances, under the name of \"Sandan Vehicles (Québec) Limited\", with a total capital stock of, 840,000, divided into 2,000 common shares of the par value of 810 each and 2,000 preferred shares of the par value of 810 each.The head office of the company is at 500 St-François-Xavier Street, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5264-1970 Scanlan's Publishing Ltd., Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Clément Bessette, advocate, 465 Denison Street West, Cécile Bernard, 382 St.Viateur Street, and Jocelync Lacoste, 113 Clarence Street, the latter two secretaries, spinsters, all three of Granby, for the following purposes: To carry on business as publishers, printers, engravers, bookbinders and in other similar businesses, under the name of \"Scanlan's Publishing Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at 470 Boulevard du Séminaire, Saint-Jean, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5575-1970 Max Scigler Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, dated the 1st day of October 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Max Seigler Co.\" and \"Maxbow Corporation\", both incorporated under the said Part I of the Companies Act, by letters patent dated, respectively, August 7, 1935, and September 17, 1956, for the following purposes: To carry on the business of an investment and development company, under the name of \"Max Seigler Inc.\", with a total capital stock of $40,000 divided 1672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1071, 103' année, n° 7 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 2,500 actions privilégiées d'une valeur au pair dc S10 chacune.Le siège social dc la nouvelle compagnie est en les ville et district dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 4327-1970 Scptimart Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Marcelle Payette, épouse dc Ghyslain Clément, 140A, 119c Avenue, Liifontainc, Mariette Légnré, épouse dc Claude Leroux, 844, rue St-Gcorgcs, toutes deux secrétaires, et Raymond Le-gault, notaire, 340, rue Gauthier, ces deux dentiers de Saint-Jérôme, pour les objets suivants: S'occuper dc productions audio-visuelles dc tous genres, sous le nom de « Scptimart inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 3,000 actions ordinaires dc S10 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4378-1970 Service Dégelis inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Jacques Dupuis, mécanicien, Anne-Marie Bclzile, institutrice, épouse dc Flo-rian Dupuis, tous deux de Dégclis, et Jean-Paul Dubé, comptable, Notrc-Dame-du-Lac, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, camions, tracteurs, instruments aratoires, bateaux, appareil-, de vol et autres véhicules, ainsi que leurs parties et accessoires, sous le nom de « Service Dégelis inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Dégelis, district judiciaire de Kamouraska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 5175-1970 Service des loisirs de Ferme Neuve inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26c jour dc novembre 1970, cons- into 15,000 common shares at a par value of $1 each 2,500 preferred shares at a par value of $10 each.The head office of the new company is in the city and judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4327-1970 Scptimart inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marcelle Payette, wife of Ghyslain Clement, 140A, 119th Avenue, Lafontaîne, Mariette Légaré, wife of Claude Leroux, 844 St-Gcorgcs Street, both secretaries, and Raymond Lcgault, notary.340 Gauthier Street, the latter two of Saint-Jérôme, for the following purposes: To be engaged in the business of audio-visual productions of all types, under the name of \"Scptimart inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4378-1970 Service Dégelis inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Dupuis, mechanic, Anne-Marie Belzilc, teacher, wife of Florian Dupuis, both of Dégelis, and Jean-Paul Dubé, accountant, Nolre-Damc-du-Lac, for the following purposes: i To carry on business as garage keepers, and to deal in automobiles, motors, trucks, tractors, farming implements, boats, aircrafts and other vehicles, their parts and accessories, under the name of \"Service Dégelis inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of S10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Dégelis, judicial district of Kamouraska.Ls-Piiimppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5175-1970 Service des loisirs de Ferme Neuve inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1673 I i tuant en corporation sans capital-actions: Real Monet-te, directeur d'école, 180, 7e Avenue, Claude Mayer, industriel, 04, 13e Rue, et Philippe Corbeil, cantonnier, 166, 10c Avenue, tous trois dc Ferme-Neuve, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Service des loisirs de Ferme Neuve inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8100,000.Le siège social de la corporation est à Ferme-Neuve, district judiciaire de Labelle.Le .sous-ministre îles institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 3495-1970 Snoopy's Pizza Shack Inc.\\m ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour de novembre 1970, constituant en corporation: André Frechette, professeur, 10, Centre, Aylmer, Michel Glazer, agent d'immeuble, 53, Sl-François, et André Parent, comptable, 673, St-Joscph, ces deux derniers dc Hull, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce du pain, dc gâteaux, pâtisseries, et autres articles d'alimentation produits par la cuisson, sous le nom de « Snoopy's Pizza Shack Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 150, boulevard St-Joseph, Hull, district judiciaire dc Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiaud.38630-o 5138-1970 Société dc développement de La Tuque inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Yvon Riberdy, agent d'immeubles, 290, Du Coteau, Claude Desmarais, 324, Vcillcttc, et J.-Dcnis Lambert, 541, St-Antoinc, ces deux derniers hommes d'affaires, tous trois dc La Tuque, pour les objets suivants : Construire et posséder des immeubles à revenu, sous le nom de « Société dc développement de La Tuque inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 290, avenue Du Coteau, La Tuque, district judiciaire de Saint-Maurice.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouciiaud.38630-o 5222-1970 incorporate a corporation without share capital: Réal Monette, school director, 180, 7th Avenue, Claude Mayer, industrialist, 64, 13th Street, and Philippe Corbeil, roadman, 166, 10th Avenue, all three of Ferme-Neuve, for the following purposes: Organization of recreational activities, under the name of \"Service des loisirs dc Ferme Neuve inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is 8100,000.The head office of the corporation is at Ferme-Neuve, judicial district of Labelle.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3s030 3495-1970 Snoopy's Pizza Shack Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: André Frechette, professor, 10 Centre, Aylmcr, Michel Glazer, real estate agent, 53 Saint-François and André Parent, accountant, 673 St-Joseph, the latter two of Hull, for the following purposes: To bake and deal in bread, cakes, pastries and other food products articles produces by cooking, under the name of \"Snoopy's Pizza Shack Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at 150 St-Joseph Boulevard, Hull, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5138-1970 Société de développement de La Tuque inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Yvon Ribcrdy, real estate agent, 290 Du Coteau, Claude Desmarais, 324 Veillette, and J.-Dcnis Lambert, 541 St-Antoine, the latter two businessmen, all three of La Tuque, for the following purposes: To build and own immovable property producing a revenue, under the name of \"Société de développement dc La Tuque inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company is at 290 Du Coteau avenue, La Tuque, -judicial district of Saint-Maurice.Ls-Piiilippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5222-1970 1674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n\" 7 La Société de gestion Arnaud ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Raymond Lemay, administrateur, 924, Doucet, Yves Désilets, comptable, 767, Giasson, et Jean Dionne, avocat, 202, Cartier, tous trois dc Sept-IIes, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc portefeuille (holding), sous le nom dc « La Société dc gestion Arnaud ltée », avec un capital total dc S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires «l'une valeur nominale dc S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est.à Scpl-Iles, district judiciaire dc Hauterive.Le soits-m inislrc des institution* financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 5491-1970 La Société d'investissements et de développements St-Gabriol-de-Brandon inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Hcnri-l'aul Lemay, 426, Cham-pagneur.Outremont, Maurice Paquin, 407, Radisson, Mont-Saint-Hilaire, Michel Gilbert, 200, Elgar, app.204, Ue-aux-Soeurs, Pierre Messier, 7505, Lacordaire, app.208, Saint-Léonard, Jean Keable, 1000, Lawlor, app.701, Saint-Laurent, tous cinq avocats, Gilbert Dupont, 10265, L'Ile, app.2, et Jean-Pierre Bourbeau, 3328, avenue Troie, app.110, ces deux derniers étudiants en droit, dc Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement et de portefeuille (holding), sous le nom de « La Société d'investissements et dc développements St-Gabriel-dc-Brandon inc.», avec un capital divisé en 300,000 actions ordinaires sans valeur nominale.Le siège social dc la compagnie est à Saint-Gabriel-de-Brandon, district judiciaire dc Joliette.Le sous-ministre des instituions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-O 4973-1970 La société Progarde inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Joseph Edward Cassar, avocat, 2230, Beckett Road, Helen E.Morrison, épouse dc Gordon Wadsworth, 605, rue Victoria, et Yvette Desjardins, épouse de Hervé Desjardins, 1112, rue Lincoln, ces deux dernières secrétaires, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de « La société Progarde inc.», avec un capital La Société dc gestion Arnaud ltéc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Raymond Lcmay, administrator, 924 Dou-cet, Yves Désilets, accountant, 767 Giasson, and Jean Dionne, advocate, 202 Cartier, all three of Sept-Ilcs, for the following purposes: To do business as a holding company, under the name of \"La Société de gestion Arnaud ltéc\", with a total capital slock of §40,000, divided into 4,000 common shares of a nominal value of §10 each.The head office of the company is at Sepl-Ilcs, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5491-1970 La Société d'investissements et de développements St-Gabricl-de-Brandon inc.Notice is given Uial under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Henri-Paul Lemay, 426 Champagneur, Outremont, Maurice Paquin, 467 Radisson, Slont-Saint-Hilairc, Michel Gilbert, 200 Elgar, Apt.204, Ilcs-aux-Socur, Pierre Messier, 7565 Lacordaire, Apt.208, Saint-Léonard, Jean Kcable, 1,000 Lawlor, Apt.701, Saint-Laurent, all five advocates, Gilbert Dupont, 10265 L'Ile, Apt.2, and Jean-Pierre Bourbeau, 3328 Troie Avenue, Apt.110, the latter two law students, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding Company, under the name of \"La Société d'investissements et dc développements St-Gabricl-de-Brandon inc.\", with a capital stock divided into 300,000 common shares without nominal value.The head office of the company is at Saint-Gabriel-i lc- Brandon, judicial district of Joliettc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4973-1970 La société Progarde inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Joseph-Edward Cassar, advocate, 2230 Beckett Road, Helen E.Morrison, wife of Gordon Wadsworth, 605 Victoria Street, and Yvette Desjardins, wife of Hervé Desjardins, 1112 Lincoln Street, the latter two secretaries, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"La société Progarde inc.\", with a QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.108, No.7 total de $40,000, divisé eu 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-0 5142-1970 Socicx inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Michel St-Jean, courtier, Guylainc Renaud, secrétaire, épouse dudit Michel St-Jean, tous deux dc 5560, boulevard Couture, Anjou, Jean-Jacques Lapicrre, courtier, et Lise Paquette, dessinatrice, épouse dudit Jean-Jacques Lapicrre, ces deux derniers de 637, Provcncher, Laval, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Sociex inc.», avec un capital total dc $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 6289, rue St-Hu-bert, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o - 5610-1970 Sogegan inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Jean Dionne, avocat, 700, Laurc, Yves-A.Rioux, notaire, et Jeannette Savard, commerçante, épouse dudit Yves-A.Rioux, 100, l'Acadie, tous trois de Sept-Iles, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille (holding), sous le nom de « Sogegan inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est a&cpt-Ilcs, district judiciaire de Hauterive.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5149-1970 Stanlecn Corporation Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Irving Shapiro, 4957, avenue Isabella, Montréal, Michael D.Worsoff, 7925, chemin Kingsley, Côte Saint-Luc, tous deux avocats, et Jacquelyn Hallctt, secrétaire, épouse dc Grant Hallelt, 785, de Roussillon, app.202, Longucuil, pour les objets suivants: 1675 total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Piiilippe Bouchard, DepiUy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5142-1970 Socicx inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel St-Jean, broker, Guylaine Renaud, secretary, wife of said Michel St-Jean, both of 5560 Couture Boulevard, Anjou, Jean-Jacques Lapicrre, broker and Lise Paquette, designer, wife of said Jean-Jacques Lapicrre, the latter two of 637 Provcncher, Laval, for the following purposes: To operate Hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Sociex inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 6289 St-Hubert Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy M mister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5610-1970 Sogegan inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean Dionnc, advocate, 700 Laure, Yvcs-A.Rioux, notary, and Jeannette Savard, merchant, wife of said Yves-A.Rioux, 100 l'Acadie, all three of Sept-Iles, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Sogegan inc.\", with a total capital stock of S40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Scpt-Iles, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5149-1970 Stanleen Corporation Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Irving Shapiro, 4957 Isabella Avenue, Montreal, Michael D.Worsoff, 7925 Kingsley Road, Côte Saint-Luc, both advocates, and Jacquelyn Hallette, secretary, wife of Grant Hallett, 785 de Roussillon, Apt.202, Longucuil, for the following purposes: 1676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Établir et diriger une compagnie dc portefeuille, sous le nom de « Stanleen Corporation Ltd.», avec un capital total dc 8100,000, divisé en 25,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc SI chacune et 75,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5255-1070 Steinberg Really Limited Les immeubles Steinberg limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour de novembre 1970, constituant en corporation : Ivan E.Phillips, 47, Fordcn Crescent, Westmount, Alan /.Golden, 4067, Vendôme, tous deux avocats, Lise Boston, 6405, Laurendeau, tous deux de Montréal, Franejne Thomson, 5266, boulevard Saint-Joseph/ Catherine Wattcrs, 4200, Sir George-Simpson, tousdeuxdcLachinc, et.Ianct Brovender,5778, Maplcridge, Côte Saint-Luc, ces quatre dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble cl dc construction, sous le nom de « Steinberg Realty Limited \u2014 Les immeubles Steinberg limitée», avec un capital total de 81,050,000, divisé en 50,000 actions ordinaires de 81 chacune et 10,000 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minisirc des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5193-1970 Studio 5, Recording & Booking Agency Inc.Studio 5, agence d'enregistrement et de placement artistique inc.Le ministre des institutions financières, compagnies, et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour dc décembre 1970, constituant en corporation : Gilbert Blanchette, gérant, 1455, St-Victor, l'Ancienne-Lorctte, Edward Joseph Taylor, 165, dc la Salle, et Daniel Nolet, 551, Signai, ces deux derniers musiciens, dc Québec, pour les objets suivants: Procéder à l'enregistrement de bandes sonores, sur disques ou sur rubans magnétiques, pour des fins commerciales ou artistiques et retenir à cette fin, les services d'artistes, de musiciens, dc chanteurs et de groupes vocaux ou d'orchestres, sous le \u2022 nom de « Studio 5, Recording & Booking Agency Inc.\u2014 Studio 5, agence d'enregistrement et de placement artistique inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 810 chacune.To carry on the business of a holding company, under the name of \"Stanleen Corporation Ltd.\", with a total capital stock of S100.000, divided into 25,000 common shares of a par value of $1 each and 75,000 preferred shares of a par value of 81 each.The head office of the company is al Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5255-1970 Steinberg Realty Limited Les immeubles Steinberg limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ivan E.Phillips, 47 Forden Crescent, Westmount, Alan '/.Golden, 4067 Vendôme, both advocates, Lise Rozon, 6405 Laurendeau, both of Montreal, Franchie Thomson, 5266 St.Joseph Boulevard, Catherine Walters, 4200 Sir George Simpson, both of Lachine, and Janet Brovender, 5778 Maplcridge, Côte Saint-Luc, the latter four secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Steinberg Realty Limited \u2014 Les immeubles Steinberg limitée\", with a total capital stock of 81,050,000, divided into 50,000 common shares of 81 each and 10,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company is al Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030-o 5193-1970 Studio 5, Recording & Booking Agency Inc.Studio 5, agence d'enregistrement et de placement artistique inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilbert Blanchette, manager, 1455 St-Victor, l'Ancienne-Lorette, Edward Joseph Taylor, 165 de la Salle, and Daniel Nolet, 551 Signai\", the latter two musicians, of Québec, for the following purposes: To record sound tracks on records or tapes, for commercial or artistic purposes and to retain, for this purpose, the services of artists, musicians, singers, vocal groups or orchestras, under the name of \"Studio 5, Recording & Booking Agency Inc.\u2014 Studio 5, agence d'enregistrement et de placement artistique inc.\", with à total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of a nominal value of $1 each and 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Le siège social dc la compagnie est 640, rue St-Joseph est, Quebec, district judiciaire de Québec.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPE bouchard.38630-o 5284-1970 Synth Company Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Roland Robillard, 10, Chambord, Lorraine, Daniel Boivin, 517, Lartiguc, Laval, tous deux avocats, Franchie Trudeau, fille majeure, 11927, James Morrice, et Anne-Marie Auclair, veuve dc Alfred Auclair, 9200, Waverly, ces deux dernières secrétaires, dc Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce du caoutchouc naturel ou synthétique et de la gutta-percha, sous le nom de « Synth Company Inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 0,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 5804, Chambord, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38G30-o 5443-1970 T.V.Radio-TV* inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Gaston Saulnier, scripteur, 11665, Notre-Dame est, Montréal, Jean Yale, annonceur, 7710, Des Vendéens, Anjou, et André Bergevin, administrateur, 8715, Barbeau, Saint-Léonard, pour les objets suivants : Faire affaires comme entrepreneurs et conseillers en publicité, sous le nom de « T.V.Radio-Tex inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et en 39,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4939-1970 Teracom inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Michel Imbeau, conseiller en administration, 13111, Lorraine, Pierrefonds, Serge Le Brun, administrateur, 451, De Pontivy, Laval, et Francine Charcst, secrétaire, fille majeure, 2170, boulevard O'Brien, Saint-Laurent, pour les objets suivants : 1677 The head office of the company is at 640 St.Joseph St.east, Québec, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 \u2022 5284-1970 Synth Company Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating Roland Robillard, 10 Chambord, Lorraine, Daniel Boivin, 517 Lartigue, Laval, both advocates, Francine Trudeau, spinster of the full age of majority, 11927 James-Morrice and Anne-Marie Auclair, widow of Alfred Auclair, 9200 Waverly, the latter two secretaries, of Montreal, for the following purposes: To deal in natural or synthetic rubber and guttapercha, under the name of \"Synth Company Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 40,000 common shares of $1 each und 6,000 preferred shares of $10 each.The head office of the com puny is at 5804 Chambord, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5443-1970 T.V.Radio-Tex inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gaston Saulnier, writer, 11665 Notre-Dame East, Montreal, Jean Yale, announcer, 7710 Des Vendéens, Anjou and André Bergevin, administrator, 8715 Barbeau, Saint-Léonard, for the following purposes: To carry on business as publicity contractors and consultants, under the name of \"T.V.Radio-Tex Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each and 39,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, , Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4939-1970 Teracom inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of Decern-ber, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel Imbeau, management consultant, 13111 Lorraine, Pierrefonds, Serge Le Brun, administrator, 451 De Pontivy, Laval, and Francine Charest, secretary, spinster of the full age of majority, 2170 O'Brien Boulevard, Saint-Laurent, for the following purposes: 1678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, »° 7 Exercer le commerce de distribution et dc mise en marché, dans le domaine des biens dc consommation, sous le nom de « Tcracom inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de SI chacune et en 370 actions privilégiées dc S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.Le .ion.i-mini.ilrc des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiaud.38030-o 5433-1970 Textiles St-Bruno ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Dolores Lcclerc, gouvernante, épouse de Laurent Leclcrc, Foyer St-Joscph, Sainte-Madeleine, Gérard Blain, peintre, Réjanc Lussier, épouse dudit Gérard Blain, Simon Blain, tous deux commerçants, et Alain Blain, artiste, ces quatre derniers dc 817, boulevard Laurier, Beloeil, pour les objets suivants : Fabriquer et faire le commerce de tissus, textiles, coupons, et autres produits semblables, sous le nom de « Textiles St-Bruno ltée », avec un capital total dc S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires dc SI chacune et en 3,000 actions privilégiées deSlO chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Bruno-dc-Montarville, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 4829-1970 Théroux Auto-Parts and Redistribution Inc.Pibces d'autos et redistribution Théroux inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jacques Desautels, 320A, Cela-nese, Jean-Pierre Théroux, tous deux vendeurs, et An drée Robillard, secrétaire, épouse dudit Jean-Pierre Théroux, ces deux derniers de 201, Cartier, tous trois de Drummondville, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Théroux Auto-Parts and Redistribution Inc.\u2014 Pièces d'autos et redistribution Théroux inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 390 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Drummondville, district judiciaire dc Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5363-1970 A distributing and marketing in the field of consumable goods business, under the name of \"Tcracom inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $1 each and into 370 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5433-1970 Textiles St-Bruno liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Dolores Leclerc, governess, wife of Laurent Leelerc, Foyer St-Joseph, Sainte-Madeleine, Gérard Blain, painter, Réjanc Lussier, wife of the said Gérard Blain, Simon Blain, both merchants, and Alain Blain, artist, the latter four of 817 Laurier Boulevard, Beloeil, for the following purposes: To manufacture and to deal in materials, textiles, remnants, and other similar products, under the name of \"Textiles St-Bruno ltéc\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Saint-Bruno-dc-Montarville, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Fi?iancial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 4829-1970 Théroux Auto-Parts and Redistribution Inc.Pibces d'autos et redistribution Théroux inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Dcsautcls, 320A Celanesc, Jean-Pierre Théroux, both salesmen, and Andrée Robillard, secretary, wife of said Jean-Pierre Théroux, the latter two of 201 Cartier, all three of Drummondville, for the following purposes: To carry on business as garage keepers, and to deal in automobiles, motors, machines, and all their parts and accessories, under the name of \"Théroux Auto-Parts and Redistribution Inc.\u2014 Pièces d'autos et redistribution Théroux inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of SI each and 390 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Drummondville, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5363-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Thiffeault & Gauthier transport inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jean-Marc Thiffeault, garagiste, 346, Hélène, Réjean Gauthier, menuisier, 403, Hélène, et Clnude Boisvert, avocat, 1505, Moore, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transix>rl, sous le nom de « Thiffeault & Gauthier transport inc.», avec un capital total dc 340,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 300 actions privilégiées de 3100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 1050, boulevard Labelle, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institulioiisfaiancièrcs, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030-o 5592-1970 Three Seasons Enterprises Ltd.Entreprises Trois Saisons ltce Le ministre îles institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Richard S.Gottlieb, 5626, Eldrid-ge, Côte Saint-Luc, Robert W.Agard, 3460, rue Duro-eher, app.601, Montréal, tous deux avocats, et Marion Wasserman, secrétaire, épouse divorcée de Léonard Wasserman, 260, Alexis Nihon, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Etablir et diriger une compagnie d'immeuble et dc construction, sous le nom de « Three Seasons Enterprises Ltd.-\u2014 Entreprises Trois Saisons ltée », avec un capital divisé en 40,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5463-1970 Timko-Gouin Holding Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour dc novembre 1970, constituant en corporation: Gerald W.Postelnik, 7355, Ostell Crescent,, Montréal, Clifford S.Postelnik, 5710, Melling, Côte Saint-Luc, et Walter R.M.Wekarchuk, 5, place Bellcrivc, Laval, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de portefeuille, sous le nom de « Timko-Gouin Holding Corporation », avec un capital total de 840,000, divisé eu 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées de 81 chacune.1679 Thiffeault & Gauthier transport inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Marc Thiffeault, garage keeper, 346 Hélène, Réjean Gauthier, carpenter, 403 Hélène, and Claude Boisvert, advocate, 1505 Moore, all three of Laval, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Thiffeault & Gauthier transport inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and into 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 1050 Labelle Boulevard, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5592-1970 Three Seasons Enterprises Ltd.Entreprises Trois Saisons ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Richard S.Gottlieb, 5626 Eldridge, Côte Saint-Luc, Robert W.Agard, 3460 Durocher Street, #601, Montreal, both advocates, and Marion Wasserman, secretary, divorced wife of Leonard Wasserman, 260 Alexis Nihon, Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Three Seasons Enterprises Ltd.\u2014 Entreprises Trois Saisons ltée\", with a capital stock divided into 40,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5463-1970 Timko-Gouin Holding Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gerald W.Postelnik, 7355 Ostell Crescent, Montreal, Clifford S.Postelnik, 5716 Melling, Côte Saint-Luc, and Walter R.M.Wekarchuk, 5 Place Belle-rive, Laval, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Timko-Gouin Holding Corporation\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of SI each and 30,000 preferred shares of 31 each. 1680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Le siège sociul dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.'18030 4012-1970 Tourisme Français inc.Le ministre tics institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie tie la Loi des compagnies, il a accortlé des lettres patentes, en tlatc du 3c jour tic novembre 1970, constituant en corporation: Charles Wolf son, avocat, 4865, chemin tic la Reine Marie, app.17, Yvette St.Jacques, comptable, fille majeure, 9850, Papineau, app.18, et Richard Doucher, administrateur, 6625, 33e Avenue, tous trois tic Montréal, pour les objets suivants: S'établir agents de voyage, sous le nom de « Tourisme Français inc., avec un capital total de 840,000, divisé en 30,000 actions ordinaires dc SI chacune et 10,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social tie la compagnie est au 1010 ouest, rue Sainte-Catherine, Montréal, tlistriet judiciaire tic Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Douciiard.38030 4811-1970 Trahan & Mcrcillc Electrical Co.Ltd.La Cie électrique Trahan & Mcrcillc ltée Le ministre tics institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu tic la première partie tic lu Loi tics compagnies, il a accordé tics lettres patentes, en tlatc du 16c jour tic novembre 1970, constituant en corporation: Gabriel Trahan, électricien, Yvonne Meunier, ménagère, épouse dudit Gabriel Trahan, tous deux du 8710, rue Sainte-Claire, Montréal, Richard Mcrcillc, électricien, et Francine Tessier, ménagère, épouse tludit Richard Mcrcillc, ces deux derniers tiu 1615, rue des Pins, LeMoync, pour les objets suivants: S'établir électriciens, sous le nom tic « Trahan & Mercillc Electricul Co.Ltd.\u2014 La Cie électrique Trahan & Mercillc ltéc», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires tic 810 chacune cl 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social tie la compagnie est à Montréal, tlistriet judiciaire tie Montréal.Le sous-minislre de's institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Douciiard.38630 5581-1970 Traklin Construction Ltd.Construction Traklin ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives tlonnc avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour tie novembre 1970, constituant en corporation: Alexander Werzberger, 5795, Durocher, Baruch Werzberger, tous deux cons- The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4912-1970 Tourisme Français inc.Notice is given that untler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Charles Wolfson, advocate, 4865 Queen Mary Roatl, Apt.17, Yvette St.Jacques, bookkeeper, spinster, 9850 Papineau, Apt.18, and Richard Boucher, administrator, 6625,33rd Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as travel agents, under the name of \"Tourisme Français inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 30,000 common shares of 81 each antl 10,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at 1010 St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-P 111 m pi'e Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3S630-o 4811-1970 Trahan & Mercillc Electrical Co.Ltd.La Cie électrique Trahan & Mercille ltée Notice is given that untler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies antl Cooperatives, incorporating: Gabriel Trahan, electrician, Yvonne Meunier, housewife, wife of the-said Gabriel Trahan.both of 8710 Stc-Clairc Street, Montreal, Richard Mercillc, electrician, and Francine Tcssicr, housewife, wife of the said Richard Mercillc, the latter two of 1615 ties Pins Street.Lemoyne.for the following purposes: To carry on business us electricians, under the name of \"Trahan & Mercille Electrical Co.Ltd.\u2014La Cie électrique Trahan & Mcrcillc ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each antl 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Montrenl, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minisler of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-t) 5581-1970 Traklin Construction Ltd.Construction Traklin ltéc Notice is given that under Part I of the Companies ' Act, letters patent, bearing date the 26th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Alexander Werzberger, 5795 Durocher, Baruch Werzberger, both builders, and Yanka Were- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 tructcurs, cl Yanka Werzberger, ménagère, épouse dudit Baruch Werzberger, ces deux derniers du 1126 ouest, Saint-Yiateur, tous trois d'Outremont, pour les objets suivants: Etablir et diriger une compagnie d'immeuble, de eonstruction et de placement, sous le nom de « Traklin Construction Ltd.\u2014 Construction Traklin ltée», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, tlistriet judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippf.Bouchard.38030 5227-1970 Trans-Canada Mobile and Trailers Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Réjean Roy, fonctionnaire, 178, lie Rue, Québec, Roland Roy, vendeur, 1084, route rurale #2, et Anita Lachance, infirmière, fille majeure, 1075, route rurale #2, ces deux derniers de L'Ancicnne-Lorette, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines, maisons mobiles, roulottes et tentes roulottes, sous le nom de « Trans-Canada Mobile and Trailers Inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 200 actions ordinaires dc 8100 chacune et en 800 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 1084, roule rurale #2, L'Ancicnne-Lorette, district judiciaire de Québec.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5651-1970 Transport International Pool (Québec) Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Adrien-R.Paquette, 212, Bloom-field, Outremont, Benoit Rivet, 3485, rue Papineau, tous deux avocats, et Denise Paquette, secrétaire, fille majeure, 9915, rue Esplanade, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de transport, sous le nom de « Transport International Pool (Québec) Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est au 500, rue Saint-François-Xavier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5241-1970 1681 berger, housewife, wife of the said Baruch Werzberger, the latter two of 1126 St.Viateur West, all three of Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Traklin Construction Ltd.\u2014 Construction Traklin ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38G30-o 5227-1970 Trans-Canada Mobile and.Trailers Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Réjean Roy, civil servant, 178, 11th Street, Québec, Roland Roy, salesman, 1084 rural route #2, and Anita Lachancc, nurse, spinster of the full age of majority, 1075 rural route #2, the latter two of L'Ancienne-Lorcttc, for the following purposes: To do business as garage-owners and to deal in cars, motors, machines, mobile homes, trailers and trailer tents, under the name of \"Trans-Canada Mobile and Trailers Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 200 common shares of $100 each and 800 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 1084 rural route #2, L'Ancienne Lorette, judicial tlistriet of Québec.Ls-Philippe Bouchard, , Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5651-1970 Transport International Pool (Québec) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Adrien-R.Paquette, 212 Bloomfield, Outre-mont, Benoit Rivet, 3485 Papineau Street, both lawyers, and Denise Paquette, secretary, spinster, 9915 Esplanade Street, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a transport company, under the name of \"Transport International Pool (Québec) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each antl 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 500 St.François Xavier Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5241-1970 1082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Trois-Rivicres Chevrolet (1970) ltée Three Rivers Chevrolet (1970) Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de novembre 1970, constituant en corporation : Marcel C.Houle, homme d'affaires, 3800, 5e Avenue, Shawinigan-Sud, Marcel J.G.Bcauraicr, avocat, 3000, Place d'Auteuil, Trois-Rivièrcs-Ouést, et Hélène Baribcau, secrétaire, fille majeure, 425, Arcand, app.3, Cap-de-la-Madeleine, pour les objets suivants : Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Trois-Rivières Chevrolet (1970) ltéc \u2014Three Rivers Chevrolet (1970) Ltd.», avec un capital total dc 8500,000, divisé en 250,000 actions ordinaires de SI chacune, 1,500 actions privilégiées classe « A » dc SI 00 chacune et en 100,000 actions privilégiées classe « 1$ » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 4001, boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest, district judiciaire de Trois-Rivières.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5118-1970 Turtle Productions Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Gary Moscowitz, 260, Saint-Aubin, Saint-Laurent, Donald W.Seal, 3435, rue Drummond, app.12B, David Goldcnblatt, 3500, rue Mountain, app.67, et Paul Nadlèr, 900, avenue Rockland, app.45, ces trois derniers dc Montréal, tous les quatre avocats, pour les objets suivants: S'établir cinéastes et éditeurs de films et exploiter des studios de montage dc films, sous le nom de « Turtle Productions Ltd.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5466-1970 Universal Fashions Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératifes donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Shlomo Feldman, 5783, avenue Durocher, Avrum Feldman, tous deux marchands, et Alizia Feldman, ménagère, épouse dudit Avrum Feldman, ces deux derniers dc 346, avenue Outremont, tous trois d'Outremont, pour les objets suivants: Trois-Rivicres Chevrolet (1970) ltée Three Rivers Chevrolet (1970) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marcel G.Houle, businessman, 3860, 5th Avenue, Shawinigan-South, Marcel J.G.Benumier, advocate, 3600 d'Auteuil Place, Trois-Rivières,-West, and Hélène Baribeau, secretary, spinster of the full age of majority, 425 Arcand, Apt.3, Cap-dc-la-Made-leine, for the following purposes: To carry on business as garage keepers and to deal in automobiles, motors, machines and all their parts and accessories, under the name of \"Trois-Rivières Chevrolet (1970) ltée \u2014 Three-Rivers Chevrolet (1970) Ltd.\", with a total capital stock of 8500,000, divided into 250,000 common shares of SI each, 1,500 class \"A\" preferred shares of 8100 each and 100,000 class \"B\" preferred shares of SI each.The head office of the company is at 4001 Royal Boulevard, Trois-Rivières-West, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5118-1970 Turtle Productions Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gary Moscowitz, 260 St.Aubin, Saint-Laurent, Donald W.Seal, 3435 Drummond Street, Apt.12B, David Goldenblatt, 3500 Mountain Street, Apt.07, and Paul Nad 1er, 900 Rockland Avenue, Apt.45, the latter three of Montreal, all four advocates, for the following purposes: To carry on the business of motion picture producers and to operate motion picture studios, under the name of \"Turtle Productions Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030-o 5466-1970 Universal Fashions Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Shlomo Feldman, 5783 Durocher Avenue, Avrum Feldman, both merchants, and Alizia Feldman, housewife, wifeof the said Avrum Feldman, the latter two of 346 Outremont Avenue, all three of Outremont, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 Faire le commerce de tous genres de tissus et vêtements, sous le nom de « Universal Fashions Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de SlOO chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 5100-1970 Vitrerie 11 nui inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'août 1970, constituant en corporation: Robert De Blois, étudiant, 890, Moncton, Sillery, Monique Juneau, 62, Ducliâtel, Beauport, et Anne-Marie Halle, 1445, Mailloux, Québec, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vitrerie, du verre et de tous ses produits et sous-produits, sous le nom dc « Vitretie Huot inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3SG30-o 3683-1970 Wolcat Development Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de décembre 1970, constituant en corporation: Max S.Kaufman, 574, Claremont, Westmount, Sydney B.Sederoff, 80, Crcstwood, Montréal-Ouest, et Philip Shugar, 6267, Macdonald, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'extension et de développement, sous le nom de « Wolcat Development Co.Ltd.», avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030 5487-1970 Woodvillc Realties Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Ralph Lipper, 1550, avenue 1683 To deal in all types of fabrics and clothing, under the name of \"Universal Fashions Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided inlo 100 common shares of a par value of S100 each and 300 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5100-1970 Vitrerie 11 not inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert De Blois, student, 890 Moncton, Sillery, Monique Juneau, 62 Duchfttel, Beauport, and Anne-Marie Halle, 1445 Mailloux, Québec, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To manufacture and deal in glaziery, glass and all its products and by-products, under the name of \"Vitrerie Huot inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of 810 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 3683-1970 Wolcat Development Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Max S.Kaufman.574 Claremont, Westmount, Sydney B.Scdcroff, 80 Crcstwood Montreal West, and Philip Shugar, 6267 Macdonald, Montreal, all three advocates, for the following purposes : To carry on the business of a development company under the name of \"Wolcat Development Co.Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5487-1970 Woodvillc Realties Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Companies antl Cooperatives, incorporating: Ralph Lipper, 1550 McGregor Avenue, 1684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n\" 7 McGregor, Sanclor Jack Klein, 6300, avenue Lennox, tous deux de Montréal, et David Katznelson, 5526, avenue Ashdale, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom de « Woodvillc Realties Inc.», avec un capital total de 540,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est 1, Place Ville-Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 5368-1970 X-L Screw Mfg.Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes, en date du 23e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Sheldon Finkclstein, 5720, boulevard Cavendish, app.30S, Côte Saint-Luc, Bernard Gardner, 405, chemin Northcotc, Rosemère, Pinja E.Blitt, 3333 ouest, rue Jean-Talon, app.603, et Michcl-A.Héroux, 10640, Hamelin, ces deux derniers de Montréal, tous les quatre avocats, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de vis, ccrous, boulons, clous, et de tous les autres produits et articles qui s'y rattachent, sous le nom de « X-L Screw Mfg.Co.Ltd.», avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de SI chacune et 36,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est 7230, rue Hamilton, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiaud.38630 5147-1970 Sandor Jack Klein, 6300 Lennox Avenue, both of Montreal, and David Katznelson, 5526 Ashdale Avenue, Côte Saint-Luc, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, imder the name of \"Woodvillc Realties Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of the par value of SI each and 36,000 preferred shares of the par value of SI each.The head office of the company is at 1 Place Ville Marie, Suite 3635, Montreal, judicial tlistriet of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 5368-1970 X-L Screw Mfg.Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of November.1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Sheldon Finkclstein, 5720 Cavendish Boulevard, Apt.308.Côte Saint-Luc, Bernard Gardner, 405 Northcotc Road, Rosemère, Pinja E.Blitt, 3333 Jean-Talon Street West, Apt.603, and Michel-A.Héroux, 10640 Hamelin.the latter two of Montreal, all four advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in screws, nuts, bolts, nails and all other related products and articles, under the name of \"X-L Screw Mfg.Co.Ltd.\".with a total capital stock of S40.000.divided into 4,000 common shares of SI each and 36,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at 7230 Hamillon Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippio Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Compaiiics and Cooperatives.38630-o 5147-1970 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Aronoff Bros.Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 15e jour de décembre 1970, à la compagnie « Aronoff Bros.Limited », augmentant son capital de S75.000 à S125.000 par la création de 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S50 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 2054-31 AronolT Bros.Limited Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Aronoff Bros.Limited\", increasing its capital from S75.000 to 8125,000 by the creation of 1,000 preferred shares of the par value of S50 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 2054-31 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1685 Arrow Plastics Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 4e jour de décembre 1970, à la compagnie « Arrow Plastics Ltd.».augmentant son capital de S 100,000 à $200.000 par la création de 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $100 chacune.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 12602-58 Bndcaux, Gosselin & Grenier inc.I* ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9c jour de décembre 1970, à la compagnie « Badeaux, Gosselin & Grenier inc.», modifiant les dispositions de ses lettres patentes et certains droits afférents aux actions privilégiées.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38030-o 1160-07 Bo-Koc, inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 15e jour dc décembre 1970, à « La Compagnie Avico ltée », constituée par lettres patentes en date du 30e jour de janvier 1957, changeant son nom en celui de « Bo-Koc, inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 10399-57 Bram Industries Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date «lu 21c jour d'octobre 1970, à la compagnie « Bram Industries Corp.», 1° diminuant son capital de $40,000 à $20,000 par l'annulation de 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune; 2e augmentant son capital de $20,000 à $40,000 par la création de 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630 11890-59 Canabec Exploration Company (No personal liability) Arrow Plastics Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 4th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Arrow Plastics Ltd.\", increasing its capital from S100.000 to $200,000 by the creation of 1.000 preferred shares of the par value of S100 each.Ls-Piiilippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030-o 12002-58 Badcaux, Gosselin & Grenier inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of December.1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and < 'oopcratives to \"Badeaux, Gosselin & Grenier inc.\", umending the provisions of its letters patent and certain rights relating to the preferred shares.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030 1160-67 Bo-Koc, inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day ol December, 1970, have been issued by the Mini-lei' of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"La Compagnie Avico ltée», incor-, porated by letters patent dated the 30th day of January 1957, changing its name to that of \"Bo-Koc, inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Finaiicial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 10399-57 Bram Industries Corp.Notice is given that, untler Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st tlay of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Bram Industries Corp.\", 1.reducing its capital from $40,000 to S20.000 by the cancellation of 2,000 preferred shares of the par value of SI0each; 2.increasing its capital from S20.000 to S40.000 by the creation of 20,000 preferred shares of the par value of SI each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 11890-59 Canabec Exploration Company (No personal liability) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première Notice is given that, under Part I of the Companies Act and the Mining Companies Act, supplementary 1686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1971, 103' année, n° 7 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 1er jour de décembre 1970, à la compagnie « Canabec Exploration Company » (No personal laibility », augmentant son capital from 875,000 to 8220,000 par la création de 145,000 actions additionnelles d'une valeur au pair de 81 chacune.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 1711-37 letters patent, dated 1st day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Canabec Exploration Company\" (No personal liability), increasing its capital from 875,000 to 8220,000 by the creation of 145,000 additional shares of the par value of 81 each.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 1711-37 Canadian Armature Works Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2Se jour de décembre 1970, à la compagnie « Environs Industries Ltd.\u2014 Les Industries Environs ltée», constituée par lettres patentes en date du 18e jour d'octobre 1966, changeant son nom en celui dc « Canadian Armature Works Corp ».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630 4272-66 Canadian Armature Works Corp.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Environs Industries Ltd.\u2014 Les Industries Environs ltée\", incorporated by letters patent dated the 18th day of October, 1966, changing its name to that of \"Canadian Armature Works Corp.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4272-66 Vincent Chartier inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9c jour de décembre 1970, à la compagnie « Vincent Chartier inc.», 1° augmentant son capital de 875,000 à 8200,000, par la création de 1,248 actions privilégiées classe « A » dc 8100 chacune et 200 actions privilégiées classe « B » dc SI chacune; 2° redésignant 050 actions privilégiées de S100 chacune en 650 actions privilégiées classe « A » de 8100 chacune.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630-o 2433-67 Vincent Chartier inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Vincent Chartier inc.\", 1.increasing its capital from S75.000 to S200,000, by the creation of 1,248 preferred shares class \"A\" of S100 each and 200 preferred shares class \"B\" of SI each; 2.redesignating 650 preferred shares of S100 each into 650 preferred shares class \"A\" of S100 each.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 2433-67 Chemical and Technical Services Inc.Services Chimiques et Techniques inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 15e jour de décembre 1970, à la compagnie « Chemical and Technical Services Inc.\u2014 Services Chimiques et Techniques inc.», augmentant son capital de 840,000 à 8240,000, par la création de 20,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 10083-55 Chemical and Technical Services Inc.Services Chimiques et Techniques inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Chemical and Technical Services Inc.\u2014 Services Chimiques et Techniques inc.\", increasing its capital from S40.000 to 8240,000, by the creation of 20,000 preferred shares of S10 each.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 10083-55 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 Ciné-Parc Mercier inc.Mercier Drive-In Theatre Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en tlatc du 1er jour dc décembre 1970, à la compagnie « Ciné-Parc Mercier inc.\u2014 Mercier Drive-In Theatre Inc.», 1° changeant son siège social dc Châtcauguay au numéro 8393, boulevard St-Laurent, Montréal; 2° modifiant les dispositions tic ses lettres patentes; 3° augmentant son capital tic 8250,000 à S321.000 par la création de 710 actions ordinaires dc S100 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 2441-69 Le Club dc Baseball les Aigles dc Trois-Rivicrcs inc.Trois-Rivicres Eagles Baseball Club Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie tie la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en dnte du 1er jour de décembre 1970, confirmant le règlement numéro 5 de la corporation « Le Club de Baseball les Aigles de Trois-Rivières inc.», déjà constituée en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite loi, par lettres patentes du 5e jour tic décembre 1968, 1° créant un capital-actions dc 840,000 divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et en 100 actions privilégiées de 8100 chacune; 2° changeant son nom en celui de « Le Club de Baseball les Aigles de Trois-Rivières inc.\u2014 Trois-Rivières Eagles Baseball Club Inc.¦\u2022 ; 3° établissant son siège social au numéro 1534, rue La Vérendryc, Trois-Rivières; 4° fixant le nombre dc ses administrateurs à 5.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 5336-68 Club de Golf Orléans inc.Orléans Golf and Country Club Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9e jour de décembre 1970, à la corporation « Club dc Golf Orléans inc.\u2014 Orléans Golf and Country Club Inc.», modifiant les dispositions dc ses lettres patentes.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 12305-61 Coiffel'l Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 22e jour d'octo- 1687 Ciné-Parc Mercier inc.Mercier Drivc-In Theatre Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies antl Cooperatives to \"Ciné-Parc Mercier inc.\u2014 Mercier Drive-In Theatre Inc.\", 1.changing its head office of Châteauguay to number 8393, St.Lawrence Boulevard, Montreal; 2.modifying the provisions of letters patent; 3.increasing its capital from S250.000 to §321,000 by the creation of 710 common shares of §100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 2441-69 l.o Club dc Baseball les Aigles de Trois-Rivifcrcs inc.Trois-Rivifcrcs Eagles Baseball Club Inc.Notice is given that, untler Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives confirming regulation number 5 of the corporation \"Le Club dc Baseball les Aigles dc Trois-Rivières inc.\", already incorporated pursuant to the provisions of Part III of the said act by letters patent of 5th tlay of December, 1968; 1.creating a share-capital of §40,000, divided into 300 common shares of §100 each and 100 preferred shares of §100 each; 2.changing its name to that of \"Le Club de Baseball les Aigles dc Trois-Rivières inc.\u2014 Trois-Rivières Eagles Baseball Club Inc.\"; 3.establishing its head office at number 1534 La Vérendryc Street, Trois-Rivières; 4.fixing the number of its directors at 5.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5336-68 Club de Golf Orléans inc.Orléans Golf and Country Club Inc.Notice is given that, under Part IDT of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Club de Golf Orléans inc.\u2014 Orléans Golf and Country Club Inc.\", amending the provisions of its letters patent.Ls-Piiilippe BoucnARD, Deputy M inister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 12305-61 Coiffel'l Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and 1688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1971, 108' année, n° 7 bre 1970, à la compagnie « Coiffel'l Inc.», 1° augmentant son capital de §40,000 à 8340,000 par la création de 200 actions privilégiées classe « A » de 8100 chacune et 2,800 actions privilégiées classe « B » de S100 chacune; 2° redésignant 300 actions privilégiées dc 8100 chacune en 300 actions privilégiées classe « A » de 8100 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 2534-70 Domaine du Bord dc l'Eau inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2c jour dc décembre 1970, à la compagnie « Domaine du Bord île l'Eau inc.»; 1° subdivisant 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc S10 chacune; 2° convertissant 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 8100 chacune.Le sous-minislre des institutions Jinaticicres, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 3797-70 Donalda Distributions Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du lie jour de décembre 1970, à la compagnie « E.D.Distributions Inc.», constituée par lettres patentes en date du 17e jour dc février 1970, changeant son nom en celui de « Donalda Distributions Inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 431-70 Eddy's Sportswear Mfg.Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 15e jour de décembre 1970, à la compagnie « Eddy's Sportswear Mfg.Co.Ltd.», subdivisant 400 actions ordinaires de S100 chacune en 40,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 12013-57 Les Entreprises de J.Armand Bombardier ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 14e jour de Cooperatives to \"Coiffel'l Inc.\"; 1.increasing its capital from 840,000 to 8340,000 by the creation of 200 preferred shares class \"A\" of 8100 each and 2,800 preferred shares class \"B\" of 8100 each; 2.re-designating 300 preferred shares of 8100 each into 300 preferred shares class \"A\" of 8100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030 2534-70 Domaine du Bord dc l'Eau inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Domaine du Bord dc l'Eau inc.\"; 1.subdividing 200 common shares of a par value of S100 each into 2,000 common shares of a par value of S10 each; 2.converting 200 common shares of a par value of 8100 each into 200 preferred shares of a par value of S100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 3797-70 Donalda Distributions Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent,-bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"E.D.Distributions Inc.\", incorporated by letters patent on 17th day of February, 1970, changing its name to that of \"Donalda Distributions Inc.\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 431-70 Eddy's Sportswear Mfg.Co.Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Eddy's Sportwear Mfg.Co.Ltd.\", subdividing 400 common shares of 8100 each into 40,000 common shares of the par value of §1 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 12013-57 Les Entreprises dc J.Armand Bombardier ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 18, 1971, Vol.103, No.7 Janvier 1971, à la compagnie « Les Entreprises de J.Armand Bombardier ltée », réduisant son capital de §36,500,000 à SI 1,756,800 par l'annulation de 2,474,320 actions privilégiées d'une valeur au pair de §10 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniLippE Bouchard.38630-o 50690-53 Les Entreprises dc J.Armand Bombardier ltéc Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 8e jour dc janvier 1971, à la compagnie « Les Entreprises de J.Armand Bombardier ltée », 1° réduisant son capital de §4,500,000 à §500,000 par l'annulation de 200,000 actions privilégiées classe « A » d'une valeur au pair de §5 chacune et 300,000 actions privilégiées classe « B » d'une valeur au pair dc S10 chacune; 2° augmentant son capital de §500,000 à §30,500,000 par la création de 3,600,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de §10 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38030-o 50690-53 Entreprises Place Verdun inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 23c jour de novembre 1970, à la compagnie « Advantus Industries Inc.», constituée par lettres patentes en date du 6e jour d'avril 1970, changeant son nom en celui de « Entreprises Place Verdun inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 1629-70 Les Entreprises Rolland Joyal & Fils inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9e jour de décembre 1970, à la compagnie « Les Entreprises Rolland Joyal & Fils inc.», étendant ses pouvoirs.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 1873-66 Esecs Holding Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2e jour de dé- 1689 Cooperatives to \"Les Entreprises de J.Armand Bombardier ltée\", reducing its capital from 836,500,000 to 811,756,800 by the cancellation of 2,474,320 preferred shares of a par value of S10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Com.panies and Cooperatives.38630 50690-53 Les Entreprises dc J.Armand Bom hardier I tee Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Les Entreprises de J.Armand Bombardier ltée\"; 1.reducing its capital from $4,500,000 to $500,000 by the cancellation of 200,000 preferred shares class \"A\" of a par value of $5 each and 300,000 preferred shares class \"B\" of a par value of $10 each; 2.increasing its capital from $500,000 to $36,500,000 by the creation of 3,600,000 preferred shares of a par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financiailnstitutions, Companies and Cooperatives.38630 50690-53 Entreprises Place Verdun inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Advantus Industries Inc.\", incorporated by letters patent dated the 6th day of April, 1970, changing its name to that of \"Entreprises Place Verdun inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 1629-70 Les Entreprises Rolland Joyal & Fils inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Les Entreprises Rolland Joyal & Fils inc.\", extending its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 1873-66 Esccs Holding Corp.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and 1690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 cembre 1970, à la compagnie « Esecs Holding Corp.>, changeant ses pouvoirs.Le sous-minislre des insiilulions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 15866-61 Cooperatives to \"Esecs Holding Corp.\", changing its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 15866-61 Feutre National inc.National Felt Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 21e jour de décembre 1970, à la compagnie « Feutre National inc.\u2014 National Felt Inc.\", augmentant son capital de 5100,000 à §450,000 par la création de 3,500 actions privilégiées dc $100 chacune.Le sous-ministre des insiilulions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 11978-61 Feutre National inc.National Felt Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Feutre National inc.\u2014 National Felt Inc.\", increasing its capital from S100.000 to 8450,000 by the creation of 3,500 preferred shares of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M inister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 11978-61 Fonds Richelieu inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé îles lettres patentes supplémentaires en date du 10e jour de décembre 1970, il la compagnie « Fonds Richelieu inc.», subdivisant et convertissant 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune en 12,000 actions ordinaires sans valeur au pair et que la considération totale pour l'émission desdites actions soit portée de 810,000 à S310.000.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-q 1850-69 Fonds Richelieu inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Fonds Richelieu inc.\", subdividing and converting 10,000 common shares of a par value of SI each into 12,000 common shares without par value and that the total consideration for the issuing of the said shares be carried from 810,000 to 8310,000.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Fitiancial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 1850-69 Gaby Productions inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9e jour de décembre 1970, à la compagnie « Gaby Productions inc.», subdivisant iO.OOO actions ordinaires sans valeur au pair en 300,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630-o 5096-67 Gaby Productions inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Gaby Productions inc.\", subdividing 10,000 common shares without par value into 300,000 common shares without par value.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5096-67 Hellenic Poultry Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patcntes^supplémentaires en date du 2e jour de décembre 1970, à la compagnie « Hellenic Poultry Co.Ltd.», augmentant son capital de SI,520,000 à Hellenic Poultry Co.Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Fiuancial Institutions, Companies and Coopearitives to \"Hellenic Poultry Co.Ltd.\", increasing its capital from Sl.520,000 to 81,540,000, by the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 1691 §1,540,000, par la création de 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de §10 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 4174-64 creation of 2,000 common shares of the par value of 810 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 4174-64 Iberville Excavation ine.Le ministre des institutions financières, compagnies el coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémcntairres en date du 14c jour de décembre 1970, à la compagnie « Les Immeubles Repcntigny inc.», constituée par lettres patentes en date du 29e jour d'octobre 1957, changeant son nom en celui de « Iberville Excavation inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 13445-57 Iberville Excavation inc.Xolicc is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Les Immeubles Repcntigny inc.\", incorporated by letters patent on the 29th day of October, 1957, changing its name to that of \"Rjcrvillc Excavation inc.\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Insiilulions, Companies and Cooperatives.38630 13445-57 Les Immeubles Mainvillc-Poiricr inc.Le ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 24e jour de novembre 1970, à la compagnie « Les Immeubles Bastien-Mainvillc' inc.», constituée par lettres patentes en date du 3c jour dc mars 1970, changeant son nom en celui dc « Les Immeubles Mainville-Poirier inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 958-70 Les Immeubles Mainville-Poirier inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Les Immeubles Bastien-Mainville inc.\", incorporated by letters patent on the 3rd day of.March, 1970, changing its name to that of \"Les Immeubles Mainville-Poirier inc.\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 958-70 Incosecd Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 20e jour d'octobre 1970, à la compagnie « Incoseed Ltd.», augmentant son capital de 8500,000 à SI,000,000 par la création de 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le soiis-minisl're des insiilulions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 13067-60 Laboratoires Cosmel'l inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 22e jour d'octobre 1970, à la compagnie « Laboratoires Cosmel'l inc.», 1° augmentant son capital dc 840,000 à S210,000 par la création de 700 actions privilégiées classe « A » de 8100 chacune et 1,000 actions privilégiées classe « B » de Incosecd Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of October 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Incoseed Ltd.\", increasing its capital from 8500,000 to 81,000,000 by the creation of 20,000 common shares of the par value of 810 each and 30,000 preferred shares of the par value of 810 each.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 13067-60 Laboratoires Cosmel'l inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Laboratoires Cosmel'l inc.\", 1.increasing its capital from §40,000 to 8210,000 by the creation of 700 preferred shares class \"A\" of 8100 each and 1,000 preferred shares class \"B\" of 8100 each; 2.redesignating 1692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 8100 chacune; 2° redésignant 300 actions privilégiées dc S100 chacune en 300 actions privilégiées classe « A » de 8100 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3863Ô-0 5121-59 La Salle Collège Inc.Collège La Salle inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 3c jour de décembre 1970, à la compagnie « La Salle Commercial Collège Inc.», constituée par lettres patentes en date du 28e jour de mai 1962, changeant son nom en celui tic « La Salle Collège Inc.\u2014 Collège La Salle inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 12312-62 Laval Médical Le.ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 7e jour de décembre 1970, à la corporation « Laval Médical », 1° étendant ses pouvoirs; 2° changeant le nombre de'ses administrateurs de 4 à 5.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630-t.483-36 Lesage, Protean ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour de décembre 1970, à la compagnie « Lesage, Proteau ltée », diminuant son capital par l'annulation de 71,358 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 522-38 Liberty Watch Case Company Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 15e jour dc décembre 1970, à la compagnie \" Liberty Watch Case Company Limited », 1° diminuant son capital de 8220,000 à 871,200 par l'annulation de 1,488 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune; 2° subdivisant 512 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune en 51,200 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune; 3° modifiant les privilèges et res- 300 preferred shares of 8100 each into 300 preferred shares class \"A\" of S100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M inister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5121-59 Lu Salle Collège lue.Collège La Salle inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"La Salle Commercial Collège Inc.\".incorporated by letters patent dated the 28th day of May, 1962, changing its name to that of \"La Salle Collège Inc.\u2014 Collège La Salle inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 12312-62 Laval Médical Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 7th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Laval Médical», 1.extending its powers; 2.changing the number of its directors from 4 to 5.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives.38030 483-30 Lesage, Proteau ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Lesage, Proteau liée\", reducing its capital by the cancellation of 71.358 preferred shares of the par value of SI each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.38G30-o 522-38 Liberty Watch Case Company Limited Notice is given that, under Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 15th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Liberty Watch Case Company Limited\", 1.reducing its capita] from S220.000 to 871,200 by the cancellation of 1,488 preferred shares of the par value of 8100 each; 2.subdividing 512 preferred shares of the par value of S100 each into 51,200 preferred shares of the par value of SI each; 3.modifying the privileges and restrictions attached to its preferred shares; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 13, 1971, Vol.103, No.7 trictions ai tachés à ses actions privilégiées; 4° augmentant son capital de S71-.200 à 8121,200 par la création de 50,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 81 chacune.Le noua-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38680 1541-31 B.C.Morris inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 26c jour dc novembre 1970, à la compagnie « B.et C.Morris Construction inc.»! constituée pur lettres patentes en date du 18e jour de février 1970, changeant son nom en celui de « B.C.Morris inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630-o 762-70 M y 11 ice Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 21c jour de décembre 1970, à la compagnie « Mylbcc Corporation», convertissant 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc S100 chacune en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune, 500 actions privilégiées classe « A » de S100 chacune et en 250 actions privilégiées classe « B » de S100 chacune.7.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630-o 972-70 Nicolet Asbestos Mines Ltd.\u2022 Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a uccordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour de décembre 1970, à la compagnie « Nicolet Asbestos Mines Ltd.», diminuant son capital de 8281,800 à 86,800 par l'annulation dc 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 14987-62 Nothern Oil Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopérative donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 10e jour de décembre 1970, à la compagnie «Northern Oil Limited», 1° diminuant son capital de $40,000 à 821,980 par l'annulation de 1,802 actions privilégiées d'une valeur 1693 4.increasing its capital from 871,200 to 8121,200 by the creation of 50,000 preferred shares of the par value of 81 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M inister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030-o 1541-31 B.C.Morris inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"B et C.Morris Construction inc.\", incorporated by letters patent on the 18th day of February, 1970, changing its name to that of \"B.C.Morris inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 762-70 Mylbec Corporation Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters pal en I.bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Mylbcc Corporation\", converting 1,000 preferred shares of a par value of 8100 each into 2,500 common shares of a par value of 810 each, 500 preferred shares class \"A\" of 8100 each and 250 preferred shares class \"B\" of $100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 972-70 Nicolet Asbestos Mines Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Nicolet Asbestos Mines Ltd.\", reducing its capital from 8281,800 to 86,800 by the cancellation of 1,000 common shares without nominal or par value.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 14987-62 Not hern Oil Limited Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Northern Oil Limited\", 1.reducing its capital from $40,000 to $21,980 by the cancellation of 1,802 preferred shares of the par value of $10 each; 1694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 au pair de S10 chacune; 2° subdivisant 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune; 1,198 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune en 11,980 actions privilégiées d'une valeur au pair dc SI chacune; 3° augmentant son capital de $21,980i à S100.000 par la création de 78,020 actions privilégiées d'une valeur au pair dc SI chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 16228-53 L'Oeuvre des Terrains de Jeux de St-Laurent dc Jonquière inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 15c jour de décembre 1970, à la corporation « Le Secrétariat des Oeuvres Paroissiales de St-Laurent dc Jonquière, Incorporé», constituée par lettres patentes en date du 7e jour de novembre 1945, changeant son nom en celui de « L'Oeuvre des Terrains dc Jeux dc St-Laurent dc Jonquière inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiaud.38630-o 6333-45 Pau Really Company Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 21e jour de décembre 1970, à la compagnie « Pan Realty Company », convertissant 6,000 actions privilégiées de SI chacune en 6,000 actions privilégiées catégorie \"A\" dc SI chacune, et 2,000 actions privilégiées dc SI chacune en 2,000 actions privilégiées catégorie \"B\" de SI chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippf.Bouchard.38630 10832-62 Candide Paquette inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du ISe jour de décembre 1970 à la compagnie « Paquelte, Paqucttc & Associés inc.>', constituée par lettres patentes en date du 29e jour de décembre 1901, changeant son nom en celui de « Candide Paquette inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 10036-62 Phciiccia Land Limited 2.subdividing 1,000 common shares of the par value of S10 each into 10,000 common shares of the par value of SI each; 1,198 preferred shares of the par value of S10 each into 11.9S0 preferred shares of the par value of SI each; 3.increasing its capital from 821,980 to 8100,000 by the creation of 78,020 preferred shares of the par value of 81 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 16228-53 L'Oeuvre des Terrains de Jeux de St-Laurent dc Jonquière inc.Notice is given that, under Part III of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives to \"Le Secrétariat des Oeuvres Paroissiales de St-Laurent de Jonquière, Incorporé\", incorporated by letters patent dated the 7th day of November, 1945, changing its name to that of \"L'Oeuvre des Tor-ruins de Jeux de St-Laurent de Jonquière inc.\".38630 Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.6333-45 Pan Really Company Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the the 21st day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Pan Realty Company\", converting 6,000 preferred shares of 81 each into 6,000 class \"A\" preferred shares of SI each, and 2,000 preferred shares of SI each into 2,000 class \"B\" preferred shares of SI each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 10832-62 Candide Paquette inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Paqucttc.Puquettc & Associés inc.\", incorporated by letters patent on the 29th day of December, 1961, changing its name to that of \"Candide Paqucttc inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 10036-62 Phenecia Land Limited Ix> ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première Notice is given that, under Part I of the Companies Ael, supplementary letters patent, bearing date the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.10S, No.7 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 18e jour de novembre 1970 ù la compagnie « Phcnccia Land Limited ».1° augmentant son capital par la création de 3,500 actions privilégiées catégorie « A » d'une valeur au pair de S100 chacune et 5,000 actions privilégiées catégorie « B » d'une valeur au pair dc SI chacune; 2° redésignant ses actions sans valeur nominale ou au pair en actions ordinaires.Le août-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouciiaud.38030 15228-59 Physico-Mcdica] Systems Corp.I.c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 27e jour de novembre 1970, à la compagnie « Physico-Médical Systems Corp.», augmentant son capital de 840,000 à 8250.000 par la création de 1,200 actions ordinaires d'une valeur au pair dc SI0 chacune et 19,800 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le sous-miitistrc associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.3S630 2915-08 Place Victoria - St.Jacques Co.Inc.\\x ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie «le la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 1er jour «le dé-cembre 1970, ù la compagnie « Place Victoria - St-Jacques Co.Inc.», augmentant son capital dc 85,000,000 à 815,000,000, par la création de 10,000,000 d'actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le sont-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 14832-60 Productions Roger Pilon inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en tlatc du 10e jour tic décembre 1970, à la compagnie « Productions Roger Pilon inc.», étendant ses pouvoirs.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 2962-67 Product-O-Metal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie tic la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 31c jour de mars 1969, à la compagnie 1695 18th tlay of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Phcnccia Land Limited\", 1.incrcaisng its capital by the creation of 3,500 class \"A\" preferred shares of the par value of 8100 each and-5,000 class \"B\" preferred shares of the par value of 81 each; 2.redesignating its shares without nominal or par value as common shares.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.38630-o 15228-59 Physico-Mcdical Systems Corp.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 27th day of November.1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Physico-Metlical Systems Corp.\", increasing its capital from 340,000 to 8250,000 by the creation of 1,200 common shares of the par value of $10 each and 19,800 preferred shares of the par value of 810 each.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 2915-68 Place Victoria - St.Jacques Co.Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Place Victoria - St.Jacques Co.Inc.\", increasing its capital from 85,000,000 to 815,000,000, by the creation of 10,000,000 preferred shares of the par value of 81 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M inister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 14832-60 Productions Roger Pilon inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970 have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies antl Cooperatives to \"Productions Roger Pilon inc.\", extending its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 2962-67 Product-O-Metal Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, the Lieutenant-Governor of the Province granted supplementary letters patent dated March 31, 1969, to \"Product-O-Mctal Inc.\", increasing its capital from 1696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 * Proiluct-O-Metal Inc.», augmentant son capital dc $20,000 à 3200,000, par la création dc 1,800 actions ordinaires de $100 chacune.Le sous-minislre des insiilulions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe ¦Bouchard.38630-o 5655-63 $20,000 to $200,000, by the creation of 1,800 common shares of $100 each.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5655-63 Ileal Estate Consultants of Canada Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et'coopérativcs donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour de novembre 1970, à la compagnie « Rcshaban Land Inc.», constituée par lettres patentes en date du 9e jour d'avril 1959, changeant son nom en celui dc « Real Estate Consultants of Canada Ltd.».Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 12203-59 Ileal Estate Consultants of Cunada I.td.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of November 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Rcshaban Land Inc.», incorporated by letters patent dated 9th day of April 1959, changing its name to that of \"Real Estate Consultants of Canada Ltd.\".J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-O 12203-59 Rentals Building Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour dc décembre 1970, à la compagnie * Rentals Building Corporation », diminuant son capital de $21,000 à $18,234 par l'annulation dc 290 actions émises sans valeur nominale ou au pair et 2,476 actions sans valeur nominale ou au pair.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 327-29 Roymor Ltd.Royinor ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu tie la première, partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9e jour d'octobre 1970, à la compagnie « Roymor Ltd.\u2014 Roymor ltée », 1° convertissant 100,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 81 chacune en 100,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune devant être émises en séries; 2° convertissant et subdivisant 1,530,000 actions catégorie «A» non-émises d'une valeur au pair dc S10 chacune en 15,300,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune devant être émises en séries; 3° augmentant son capital par la création de 600,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune devant être émises en séries.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 3675-68 Rentals Building Corporation Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Rentals Building Corporation », reducing its capital from 321,000 to 818,234 by the cancellation of 290 issued shares without nominal or par value and 2,476 shares without nominal or par value.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperaliées.38630-O 327-29 Roy nun- Ltd.Roymor ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of October 1970, have been issued by the Minister ot Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Roymor Ltd.\u2014 Roymor ltée », 1.converting 100,000 preferred shares of the par value of 81 each into 100,000 preferred shares of the par value of 81 each to be issued in series; 2.converting and subdividing 1,530,000 unissued class \"A\" shares of the par value of 810 each into 15,300,000 preferred shares of the par value of $1 each to be issued in scries; 3.increasing its capital by the creation of 600,000 preferred shares of the par value of $1 each to be issued in series.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-O 3675-68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1697 Salaisons Fleur «le Lys ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives_ donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 23e jour de novembre 1970, à la compagnie « Salaisons Fleur dc Lys ltéc », augmentant son capital de $40,000 à $320,000 par la création dc 3,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 25,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.38630 4388-65 Salaisons Fleur de Lys liée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of November 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Salaisons Fleur dc Lys ltée\", increasing its capital from $40,000 to $320,000 by the creation of 3,000 common shares of the par value of $10 each and 25,000 preferred shares of the par value of $10 each.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38030-o 4388-65 Sogexport inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 15e jour de décembre 1970, à la compagnie « Sogexport inc.», augmentant son capital dc $40,000 à $200,000 par la création de 16,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S630-o 5258-66 Treitel Enterprises Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16c jour dc décembre 1970, à la compagnie « Treitel Enterprises Ltd.», diminuant son capital de $1,500,000 à $1,201,700 par l'annulation dc 2,983 actions privilégiées catégorie « A » d'une valeur au pair de $100 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.3S630 14733-62 Sogexport inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Sogexport inc.\", increasing its capital from $40,000 to $200,000 by the creation of 16,000 preferred shares of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M inister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630 5258-66 Treitel Enterprises Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Treitel Enterprises Ltd.\", reducing its capital from $1,500,000 to $1,201,700 by the cancellation of 2,983 class \"A\" preferred shares of the par value of $100 each.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 14733-62 Unitex Watch Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 19e jour de novembre 1970, à la compagnie « Unitex Watch Ltd.» 1° redésignant ses actions ordinaires en actions catégorie « A » ; 2° augmentant son capital dc $40,000 à $80,000 par la création de 4,000 actions catégorie « B » d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38630 1786-63 Unitex Watch Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of November 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Unitex Watch Ltd.\"; 1.redesignating its common shares as class \"A\" shares; 2.increasing its capital from $40,000 to $80,000 by the creation of 4,000 class \"B\" shares of the par value of $10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 1786-63 1698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Vente pour taxes Municipalité* du comté dc Lac Saint-Jean-Est Avis public est par les présentes donné, que conformément aux dispositions du Code municipal dc la province de Québec, et au règlement numéro soixante dc ce Conseil dc Comté, adopté le 10 septembre 1947, et approuvé par l'honorable ministre des Affaires municipales, les propriétés ci-dessous décrites, seront vendues pour taxes, à l'Hôtel de Ville d'Alma, (Salle du Conseil) MERCREDI, le VINGT-HUITIEME jour d'AVRIL 1971, à DIX heures dc l'avant-midi.Cette vente comprendra les bâtiments érigés sur les terrains mis en vente, s'il en existe alors et sauf aussi à distraire les servitudes concédées.Sale for Taxes Municipality of the County of Lake St.John-East Public notice is hereby given that in conformity with the provisions of the Municipal Code of the Province of Québec\", and with by-law number sixty of this County Council, adopted on September 10, 1947, and approved by the Honourable Minister of Municipal Affairs, the properties hereunder described will be sold for taxes, at the Alma Town Hall, (Council Hall), on WEDNESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of APRIL, 1971, at TEN o'clock in the forenoon.This sale shall include all the buildings erected on the lands to be sold, if any exist and also save to withdraw the granted servitudes.L'Ascension \t\t\tCanton\tTaxes\t\tTaxes\tAutres Vendu contre\t\tRang\tcadastre\tmun.\t\tscol.\tet frais \tLot\t\t\t\tAqued.\t\t Sold against\t\tRange\tTownship\tM un.\t\tSchool\tOthers \t\t\tcadastre\ttaxes\t\ttaxes\tand costs Roland Tremblay (1).\tP.24.\t7.\tDel isle.\t8 7.00\t\tS 16.13\t$ 10.75 (1) Partie du lot 24, Rang 7, canton de Delislc, mesurant cinquante pieds dc largeur dans le sens est-ouest, sur cent pieds de profondeur dans le sens nord-sud, borné au nord aux vendeurs, s\\ l'est au terrain du vendeur, :\\ l'ouest au terrain appartenant déjà a l'acheteur et au sud au chemin de front des rangs six et sept, avec les servitudes actives et passives.(1) Part of lot 24, Range 7, township of Dolislc, measuring fifty feet in width in the eastwest direction by one hundred fect in depth in the northsouth direction, bounded on the north by the vendors, on the east by the land of the vendor, on the west by the land belonging to the purchaser and on the south by the road in front of ranges six nnd seven, with servitudes, active and passive.Saint-Gédéon Robert Audct (2).| P.7C.| 10.1 Signal.IS107.00 I |S 21.00 |S S.00 (2) Propriété située sur partie du lot 7C, Rang X, canton de (2) Property situated on part of lot 7C, Range X, township Signal, en la municipalité dc St-Gédéon, comté du Lac St-Jean.of Signal, in the municipality of St-Gédéon, county of Lake St.John.Rémi Thêriault (3).I P.13A.I 10.| Signal.| 35.50 | ' I 25.92 | 8.00 (3) Propriété située sur partie du lot 13A, Rang X, canton (3) Property situated on part of lot ISA, Range X, township de Signal, en la municipalité de St-Gédéon, comté du Lac of Signal, in the municipality of St-Gédéon, county of Lake St-Jean.St.John.Lucien Lavoie (5).'.| Pts 37a-37-b| 10.| Signal.| 92.25 | | 189.24 | 8.00 (5) Propriété située sur partie des lots 37A et 37B, Rang X, (5) Property situated on part of lots 37A and 37P>, Range X, canton de Signal, en la municipalité de St-Gédéon, comté du township of Signal, in the municipality of St-Gédéon, county Lac St-Jean.of Lake St.John.Aurélien Tremblay (6).I P.10T18.,| 10.1 Signal.| 08.75 I | 54.34 | S.00 (G) Propriété située sur partie du lot 18, Rang X, canton de (0) Property situated on Part of lot 18, Range X, township Signa!, en la municipalité de St-Gédéon, comté du Lac St-Jean.of Signal, in the municipality of St-Gédéon, county of Lake St.John.> Paul Béliveau (7).| P.14-b-l-7.| 10.1 Signal.I I 80.98 | 8.00 (7) Propriété située sur partie du lot 14-b-l-7, Rang X, (7) Property situated on part of lot 14-6-1-7, Range X, canton de Signal, en la municipalité de St-Gédéon, comté du township of Signal, in the municipality of St-Gédéon, county Lac St-Jean.of Lake St.John.P.19.Jean-Paul Tremblay et-and ou-or Bernard Daragon (8).(8) Propriété située sur partie du lot 19, Rang X, canton de Signal, en la municipalité de St-Gédéon, comté du Lac St-Jean.10.Signal.78.39 8.00 (8) Property situated on part of lot 19, Range X, township of Signal, in the municipality of St-Gédéon, county of Lake St.John. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 18, 1971, Vol.108, No.7 1699 Hébertville Vendu contre Sold against\tLot\tRang Range\tCanton cadastre Township cadastre\tTaxes mun.Mun.taxes\tAqued.\tTaxes _ scol.School taxes\tAutres et frais Others and costs \tP.20b-20a-\tI.\t\tS192.49\t$120.95\t$422.21\t$ 8.00 \t20c.21a.\tC.\t\t\t\t\t \t22c.\tD., .\tSignal.\t\t\t\t (9) 1° Les lots de terre connus et désignés sous les numéros vingt-A et vingt-C (Nos 20A et 20-C) du cadastre officiel pour .le Premier Rang du canton de Signal, dans le comté du Lac St-Jean; 2° Le lot numéro vingt-deux-C (No 22-C) du cadastre officiel pour le Rang lettre < D \u2022 dudit canton de SignnI; 3° La partie sud-est du lot numéro vingt et un A (P.S.E., 21-A) du cadastre officiel pour le Rang lettre « C » du canton de Signal, laquelle partie se trouve au bord de la Belle Rivière et mesure environ une acre en superficie; 4° Un certain lopin de terre faisant partie du lot numéro seize (P.16) du cadastre du Deuxième Rang du canton de Signai, de vingt-cinq acres en superficie, plus ou moins, borné au nord i\\ la ligne du chemin de fer de Québec et Lac St>Jean, au sud i\\ la ligne séparant le rang un du Deuxième Rang dudit canton de Signal, et à l'ouest a Cléophe Simard ou représentants.Le tout avec toutes les bâtisses érigées sur les susdits immeubles appartenances et dépendances.5° Le lot de terre connu et désigné sous le numéro vingt-B (No 20-B) du Premier Rang du canton de Signal, au cadastre de ce canton, avec bâtisses circonstances et dépendances.G° Le lot de terre connu et désigné sous le numéro vingt et un-A (No 21-A) du cadastre officiel pour le Rang lettre « C \u2022 du canton de Signal, de la contenance de quatre vingt-trois acres en superficie, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, sauf a en distraire la pointe de terre appartenant à Arthur Lemay ou représentants, et l'emplacement de la Corporation scolaire d'Hébertville.Souf à distraire les servitudes concédées.Lionel Fortin (10).| P.2.| 4.(10) Le tiers indivis du lot numéro deux (1/3, 2) du cadastre officiel pour le Quatrième Rang (4e) du canton de Mésy.Succ.-est.Argémir Gagné (11).| P.4.| 2, (11) Un certain terrain situé sur le bord du Lac Vert, et servant de résidence d'été, de forme irrégulière contenant une acre plus ou moins en superficie, faisant partie du lot de terre maintenant connu et désigné aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Mésy, sous le numéro quatre (P.4) pour le Deuxième Rang Est dudit canton et est ainsi borné: au nord au chemin public, ù.l'ouest à la ligne de division des lots 3A et 4 ou Leopold Tremblay, au sud et a l'est au reste du lot 4 dont il fait partie et appartenant nu vendeur ou encore a une coulée qui court en pointe.Alphonse Lamontagne (12).| P.41.| A.(12) Une maison avec un petit garage, sise et située en la paroisse de Notre-Dame d'Hébertville, dans le comté du Lac St-Jean, mesurant trente pieds par vingt-huit pieds, a un étage et demi et située sur: Un terrain mesurant trois cent trente-six pieds (336') à la route du Rang A, du canton de Caron, par trente-cinq pieds dans la ligne est, soixante-dix-huit pieds dans la ligne ouest, et cent soixante pieds pour partie et cent trois pieds pour l'autre partie dans la ligne nord, ledit terrain étant de figure irrégulière et faisant partie du lot numéro quarante et un (P.No 41) du cadastre pour le Rang A du canton de Caron, et compris dans les limites suivantes et bornes suivantes: au sud à la route du Rang A, il l'est et à l'ouest par le terrain de Jean-David Pelletier, et au nord en suivant la coulée qui (9) 1.Lots of land known and designated under numbers twenty-A and twenty-C (Nos.20A and 20C) on the official cadastre for the First Range of the township of Signal, in the county of Lake St.John ; 2.Lot number twenty-two-C (No.22-C) of the official cadastre for Range letter \"D\" of the said township of Signal; 3.The southeast part of lot number twenty-one-A (P.S.E., 21-A) on the official cadastre for Range letter \"C\" of the township of Signal; the said part on the edge of Belle River and measuring about one acre in area; 4.A certain strip of land forming part of lot number sixteen (P.16) on the cadastre of the Second Range of the township of Signal; twenty-five acres in area, more or less, bounded on the north by the Québec mid Lake St.John railroad line, on the south by the line separating range one from the second range of the said township of Signal, and on the west by Cléophe Simard or representatives.The whole with all buildings erected on the aforesaid immovables, appurtenances and dependencies.5.The lot of land known and designated under number twenty-B (No.20-B) of the First Range of the township of Signal in the cadastre of this township, with buildings, circumstances and dependencies.6.The lot of land known and designated under numljer twenty-one-A (No.21-A) of the official cadastre for Range letter \"C\" of the township of Signai, containing eighty-three acres in area, with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies, save to withdraw the piece of land belonging to Arthur Lemay or representatives, and the emplacement of the Hébertville School \"corporation.Save to withdraw the servitudes granted.I Mésy.I 17.60 I | 9.80 I 9.45 (10) The undivided third of lot number two (1/3, 2) of the official cadastre for the Fourth Range (4th) of the township of Mésy.E.I Mésy.5.40 20.35 8.00 (11) A certain piece of land situated on the edge of Vert Lake, and used for a summer residence, of nn irregular form containing one acre more or less in area, forming part of the lot of land now known and designated on the plans and in the official book of reference of the cadastre of the township of Mésy, under number four (P.4) for the Second East Range of the said township and is bounded as follows: on the north by the public rond, on the west by the line of division of lots 3A and 4 or Leopold Tremblay, on the south and east by the remainder of lot 4 of which it forms a part and belonging to the vendor or still by a \"coulée\" running in a point.____I Caron.| 88.56 I | 87.14 | 12.67 (12) A house with a small garage, situated and lying in the parish of Notre-Dame d'Hébertville, in the county of Lake St.John, measuring thirty feet by twenty-eight feet, one storey and one-half and situated on: A piece of land measuring three hundred and thirty-six feet (330') on the route of Range A, of the township of Caron, by thirty-five feet on the east line, seventy-eight feet on the west line, and one hundred and sixty feet on one part and one hundred and three feet on the other part on the north line, the said land forming nn irregular figure and forming part of lot number forty-one (P.No.41) of the cadastre for Range A of the township of Caron, and included in the following limits and boundaries: on the south by the route of Range A, on the east and west by the land of Jean-David Pelletier, and on the north 1700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, ti° 7 Hébertville (suite \u2014 continued) s'y trouve, sauf à distraire les servitudes concédées.following the \"coulée\" which exists there, save to withdraw the servitudes granted.\t\t\tCanton\tTaxes\t\tTaxes\tAutres Vendu contre\t\tRang\tcadastre\tmun.\t\tscol.\tet frais \tLot\t\t\t\tAqucd.\t\t Sold against\t\tRange\tTownship\tMun.\t\tSchool\tOthers \t\t\tcadastre\ttaxes\t\ttaxes\tand costs \tP.20-21-22-23-24.\tR.E.\t\tS245.51\t\t$077.33\tS19.0G \t\t\t\t\t\t\t (13) a) Toute cette partie est du lot numéro vingt-deux (P.E., lot No 22), du cadastre officiel pour le rang est du chemin Kénogami, canton de Labarre, mesurant un arpent et trois quart de largeur sur la profondeur dudit lot il partir du lac Kénogamichiche a aller il la partie nord dudit lot appartenant à Aimas Iludon ou représentants Martial Hudon, fils, laquelle partie dudit lot vingt-deux appartenant à Ephrem Guay, est bornée comme suit: au nord, il la terre d'Almas Hudon; au sud, au Lac Kénogamichiche, à l'est, il la ligne de division des lots vingt-deux et vingt-trois, ce dernier appartenant il Richard Paradis ou représentants, il l'ouest, au terrain de Charles Tremblay ou représentants, c'est-à-dire il trois cent trente-six pieds de largeur de la ligne de division des lots vingt-deux et vingt-trois dudit rang est, canton de Labarre,-avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.b) Une terre sise et située dans la paroisse de Notre-Dame d'Hébertville, dans le comté du Lac St-Jean, mesurant environ quatre arpents de largeur sur environ trente arpents de profondeur, plus ou moins, formant partie des lots de terre connus et désignés sous les numéros vingt et vingt et un (Pts lots 20 et 21), du cadastre officiel pour le rang est du chemin Kénogami, dans le canton de Labarre, cette terre dans sa totalité est bornée comme suit: au sud, au Lac Kénogamichiche; nu nord, i) la partie nord des mêmes lots appartenant il Martial Hudon, fils, la ligne de séparation devant être au premier cran qui se rencontre en partant du Lac Kénogamichiche en suivant la ligne de division entre le terrain de Joseph Paradis et en suivant la coupe traversant les susdits lots de l'est il l'ouest, il l'est, au reste du lot vingt et un appartenant à Philippe Hudon; et à l'ouest, il la demi-sud du lot numéro dix-neuf appartenant il Pierre Imbeault, avec ensemble toutes les bâtisses dessus construites, sur les susdits immeubles, appartenances et dépendances.c) Le lot de terre connu et désigné au cadastre officiel du canton de Labarre, sous le numéro vingt et un (lot 21) du rang Est du chemin Kénogami, canton dc Labarre, avec appartenances et dépendances, sauf il distraire dudit lot numéro vingt et un toute cette partie de terrain vendue il Irenée Vermette par Auguste Hudon suivant acte enregistré sous le numéro 25284, ainsi que la partie nord du même lot vendu par le shérif du district de Rolœrval il Aimas Hudon, suivant acte enregistré sous le numéro 32762; laquelle partie dudit lot vingt et un annoncée en vente et saisie est ainsi bornée: au nord, au terrain d'Almas Hudon ou représentants Martiid Hudon; au sud, au Lac Kénogamichiche; il l'est, à la ligne ou partie du lot vingt-deux appartenant il Philippe Hudon ou représentants; et il l'ouest, il la partie du lot vingt et un appartenant il Irenée Vermette; d) Toute cette partie ouest du lot numéro vingt-deux (P.O., lot No 22), du cadastre officiel pour le rang est du chemin Kénogami, au cadastre officiel du canton de Labarre, mesurant un arpent et quart de largeur, plus ou moins, soit deux cent quarante et un pieds et cinq dixièmes de largeur plus ou moins, sur la profondeur qu'il y a il partir du Lac Kénogamichiche à aller il la terre d'Almas Hudon, laquelle partie appartenant à Charles Tremblay ou Théophile Paradis, est bornée comme suit: au nord, à la partie nord dudit lot appartenant il Aimas Hudon; au sud, au Lac Kénogamichiche; il l'est, à la partie est du lot numéro vingt-deux appartenant il Éphrem Guay; et a l'ouest, au lot vingt et un du cadastre du rang est du chemin Kénogami, canton de Labarre.(13) (a) The entire cast part of lot number twenty-two (E.P.lot Ne.22).on the official cadastre for the east Range of Kénogami Road, township of Labarre, measuring one arpent and three-fourths of an arpent in width by the depth of the said lot from Kénogamichiche Lake to the north part of the said lot belonging to Almas Iludon or representatives of Martial Hudon, Jr., the said part of said lot twenty-two belonging to Ephrem Guay, is bounded as follows: on the north, by the land of Almas Hudon; on the south by Kénogamichiche Lake, on the east by the line of division of iots twenty-two and twenty-three, the latter l)clonging to Richard Paradis or representatives, on the west by the hind of Charles Tremblay or representatives, that is to say three hundred and thirty-six feet in width from the division line of lots twenty-two and twenty-three of the said east range, township of Labarre, with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.(6) A piece of hind situated and lying in the parish of Notre-Dame d'Hébertville, in the county of Lake St.John, measuring about four arpents in width by alxmt thirty arpents in depth, more or less, forming part of the lots of land known and designated under numbers twenty and twenty-one (P.lots 20 and 21), of the official cadastre for the east range of Kénogami Road, in the township of Labarre, this land in its entirely is bounded as follows: on the south by Kénogamichiche Lake; on the north by the north part of the same lots belonging to Martial Hudon, Jr., the line of separation found on the first notch which meets as it leaves from Kénogamichiche Lake following the line of division between the land of Joseph Paradis and following the woodlot crossing the aforesaid lots east to w;est, on the east by the remainder of lot twenty-one belonging to Philippe Hudon; and on the west, by the south-hnlf of lot number nineteen lwlonging to Pierre Imbeault, together with all the buildings built thereon, on the said immovables, appurtenances and dependencies.(c) The lot of hind known and designated on the official cadastre of the township of Labarre, under numl>er twenty-one (lot 21) of the east range of Kénogami Road, township of Labarre, with appurtenances and dependencies, save to withdraw from said lot number twenty-one the entire part of the land sold to Irenée Vermette by Auguste Hudon according to a deed registered under number 25284, as well as the north part of the same lot sold by the sheriff of the district of Ro-bcrval to Almas Hudon, according to a deed registered under number 32762; the said part of the said lot twenty-one proclaimed for sale and seized is thus bounded: on the north by the land of AlmasIIudon or representatives of Martial Hudon; on the south by Kénogamichiche Lake, on the east by the line or part of lot twenty-two lielonging to Philippe Hudon or representatives; and on the west by part of lot twenty-ono belonging to Irenée Vermette; (d) This entire west part of lot number twenty-two (W.P., lot No.22), on the official cadastre for the east range of Kénogami Road, on the official cadastre of the township of Labarre, measuring one arpent and one-fourth in width, more or less, two hundred and forty-one feet and five-tenths of a foot in width, more or less, by the depth existing from Kénogamichiche Lake to the land of Almas Iludon, the said part belonging to Charles-Tremblay or Théophile Paradis, is bounded as follows: on the north, by the north part of the said lot l>elonging to Almas Hudon; on the south by Kénogamichiche Luke; on the east, by the east part of lot numl>er twenty-two belonging to Ephrem Guay; and on the west by lot twenty-one of the cadastre of the east range of Kénogami Road, township of Labarre. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1701 Hébertville (suite \u2014 continued) Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.e) Une ferme située :\\ Notre-Dame d'Hébertville, étant et comprenant: 1° Le lot de terre connu et désigné au cadastre officiel du canton de Labarre, sous le numéro vingt-trois (lot 23), du rang est, chemin Kénogami, contenant en superficie cent deux acres et borné: au nord, il la ligne de division entre le rangest du chemin Kénogami et le Premier Rang est dudit canton; vers l'est, par le lot numéro vingt-quatre desdits rang et canton; vers le sud, par le Lac Kénogamichiche; et vers l'ouest, par le lot numéro vingt-deux desdits rang et canton.2° Le lot de terre connu et désigné sous le numéro vingt-quatre (lot 24), du rang est chemin Kénogami, au cadastre officiel du canton de Labarre, contenant en superficie cent une acres et borné: au nord, par la ligne cie division entre le rang est du chemin et le Premier Rang est; vers l'est pnr le lot numéro vingt-cinq desdits rang et canton; vers le sud, par le Lac Kénogamichiche; et vers l'ouest, par le lot numéro vingt-trois desdits rang et canton.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Lesdits lots vingt-trois et vingt-quatre, rang est chemin Kénogami, canton do Labarre, étant, sujet h une servitude consentie par Richard Paradis, en faveur de lu Compagnie Électrique du Saguenay, par acte reçu devant D.Langlois, notaire, le 13 juin 1940, enregistré â Hébertville, sous le numéro 43481, le 8 août 1940.Donné à Saint-Jérôme, ce 29e jour de janvier 1971.Le secrétaire-trésorier, 38587-6-2-0 Laurent Plourde.The whole with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.(c) A farm situated at Notre-Dame d'Hébertville, forming and including: 1.The lot of land known and designated on the official cadastre of the township of Labarre, under number twenty-three (lot 23), of the east range, Kénogami Road, containing in area one hundred and two acres, and bounded: on the north by the line of division between the east range of Kénogami Road and the first east range of the said township; on the east by lot number twenty-four of the suid range and township, on the south by Kénogamichiche Lake; and on the west by lot number twenty-two of the said range and township.2.The lot of land known and designated under number twenty-four (lot 24), on the east range of Kénogami Road on the official cadastre of the township of Labarre, containing in area one hundred and one acres and bounded: on the north by the line of-division between the east range of the road and the first east range; on the east by lot number twenty-five of the said range und township; on the south by Kénogamichiche Lake; and on the west by lot number twenty-three of the said range and township.The whole with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.The said lots twenty-three and twenty-four, east range of Kénogami Road, township of Labarre, are subject to a servitude grunted by Richard Paradis, in favor of \"Compagnie Electrique du Saguenay\", by a deed received before D.Langlois, notnry, on Juno 13, 1946, registered at Hébertville, under number 43481, on August 8, 1946.Given at Saint-Jérôme, this 29th day of January, 1971.Laurent Plourde, 38587-6-2 Secretary-Treasurer.Divers Compagnies Miscellaneous Companies Afgor inc.La compagnie « Afgor inc.», donne avis qu'elle a changé le nom ce ses administrateurs de 3 à 9.Le secrétaire, Gaston Duval.38643-0 6130-69 L'Association des Embouteilleurs d'Eaux Gazeuses du Qilébc'c The Québec Soft Drink Bottlers Association Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis'qu'il a approuvé le règlement numéro 4, de « L'Association des Embouteilleurs d'Eaux Gazeuses du Québec \u2014 The Québec Bottiers of Carbonated Berevages Association », constituée par lettres patentes en date du 15e jour d'octobre 1970, changeant son nom en celui de « L'Association des Embouteilleurs d'Eaux Gazeuses du Québec \u2014 The Québec Soit Drink Bottlers Association ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38644-0 4511-70 Afgor inc.Notice is given that \"Afgor inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 9.Gaston Duval, Secretary.3S043-o 6130-69 L'Association des Embouteilleurs d'Eaux Gazeuses du Québec The Québec Soft Drink Bottlers Association Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number 4, of \"L'Association des Embouteilleurs d'Eaux Gazeuses du Québec \u2014 The Québec Bottlers of Carbonated Beverages Association\", incorporated by letters patent dated the 15th day of October 1970.changing its name into that of \"L'Association des Embouteilleurs d'Eaux Gazeuses du Québec \u2014 The Québec Soft Drink Bottiers Associa-lion\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38644-0 4511-70 1702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 L'Association des Embouteilleurs d'Eaux Gazeuses du Québec The Québec Bottlers of Carbonated Beverages Association Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 22 janvier 1971, il a approuve les règlements généraux de « L'Association des- Embouteilleurs d'Eaux Gazeuses du Québec \u2014 The Québec Bottiers of Carbonated Beverages Association », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38645-0 4511-70 L'Association des Embouteilleurs d'Eaux Gazeuzes du Québec The Québec Bottlers of Carbonated Beverages Association The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on January 22, 1971, he approved the general by-laws of \"L'Association des Embouteilleurs d'Eaux Gazeuses du Québec \u2014 The Québec Bottlers of Carbonated Beverages Association\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instituions, Companies and Cooperatives.38645 4511-70 Conseil Régional de Développement Lanaudièrc Conseil Régional de Développement Lanaudière Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 2, de la corporation « Conseil Économique Régional Lanaudièrc », constituée par lettres patentes en date du 2e jour de février 1966, changeant son nom en celui de « Conseil Régional de Développement Lanaudière ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38646-0 5564-65 Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number 2, of the corporation \"Conseil Économique Régional Lanaudière\", incorporated by letters patent dated the 2nd day of February 1966, changing its name into that of \"Conseil Régional de Développement Lanaudière\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38646-0 5564-65 Crémerie St-Eustache ltée La compagnie « Crémerie St-Eustache ltée », donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, Roger Comtois.38647-0 10539-57 Crémerie St-Eustache ltée The company \"Crémerie St-Eustache ltée\", gives notice that it changed the number of its directors from 4 to 3.Roger Comtois, Secretary.38647 10539-57 Dames Auxiliaires de l'Hôpital Marie-Enfant La corporation « Dames Auxiliaires de l'Hôpital Marie-Enfant » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 16 ù 22.La secrétaire, Berthe L.Fortin.38648-0 11521-62 Dames Auxiliaires de l'Hôpital Marie-Enfant Notice is given that \"Dames Auxiliaires de l'Hôpital Marie-Enfant\" has changed the number of its directors from 16 to 22.Berthe L.Fortin, Secretary.38648-0 11521-62 Slender Magic Health Studio Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 14, de la compagnie « Venus Health Spa Inc.\u2014 Studio de Santé Vénus inc.», constituée par lettres patentes en date du 19e jour de mai 1970, changeant son nom en celui de « Slender Magic Health Studio Inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38650-o 2166-70 Slender Magic Health Studio Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number 14, of the company \"Venus Health Spa Inc.\u2014 Studio de Santé Vénus inc.\", incorporated by letters patent dated the 19th day of May 1970, changing its name into that of \"Slender Magic Health Studio Inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38650-o 2166-70 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1703 Les Établissements du Gentilhomme inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 18 janvier 1971, il a approuvé les règlements généraux de la corporation « Les Établissement du Gentilhomme inc.», et ce, en vertu de l'article 226 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.38649-o 1875-69 Horn Investments Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuve le règlement numéro spécial « A », de la compagnie « Paul Horn Investments Inc.», constituée par lettres patentes en date du 23e jour d'octobre 1969, changeant son nom en celui de « Horn Investments Inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38651-o 5140-69 La Maison des Enseignants dc l'Outaouais inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 22 janvier 1971, il a approuvé le règlement numéro 1 de la corporation « La Maison des Enseignants de l'Outaouais inc.», et ce, en vertu de l'article 226 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38690-o 6010-69 United Continental Engines Ltd.La compagnie « United Continental Engines Ltd.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 4.Le secrétaire, Jean-Paul Zioby.38660-o 2199-46 Clinique Financière et Administrative (Montréal) inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 3, de la compagnie « Placements Soulanges Investments Inc.», constituée par lettres patentes en date du 14e jour de janvier 1959, changeant son nom en celui de « Clinique Financière et Administrative (Montréal) inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38673-o 10172-59 Caprice Hosiery Sales Ltd.La compagnie « Caprice Hosiery Sales Ltd.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 5.Les Établissements du Gentilhomme inc.Notice is hereby given by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives that on January 18,1971 he approved the general by-laws of the corporation \"Les Etablissements du Gentilhomme inc.\", and such, pursuant to section 226 of the Companies Act.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.38649 1875-69 Horn Investments Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the number special by-law \"A\", of the company \"Paul Horn Investments Inc.\", incorporated by letters patent dated the 23rd day of October 1969, changing its name into that of \"Horn Investments Inc.\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38651-0 5140-69 La Maison-des Enseignants de l'Outaouais inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on January 22, 1971, approved by-law number 1 of \" La Maison des Enseignants dè l'Outaouais inc.\", and such, pursuant to section 226 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38690 6010-69 United Continental Engines Ltd.\"United Continental Engines Ltd.\", gives notice that it changed the number of its directors from 5 to 4.Jean-Paul Zigbt, Secretary.38660 2199-46 Clinique Financière et Administrative (Montréal) inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number 3, of the company \"Placements Soulanges Investments Inc.\", incorporated by letters patent dated the 14th day of January 1959, changing its name into that of \"Clinique Financière et Administrative (Montréal) inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38673-o 10172-59 Caprice Hosiery Sales Ltd.Notice is given that \"Caprice Hosiery Sales Ltd.\" has changed the number of its directors from 4 to 5.38689-0 Jack Keil, Secretary.12516-58 Le secrétaire, Jack Keil.38689 12516-58 1704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, il' 7 Service des Loisirs St-Simon-ct-St-Jude dc Charlemagne Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 13 janvier 1971, il a approuvé les règlements généraux «le la corporation « Service des Loisirs St-Simon-ct-St-Jude de Charlemagne », et ce, en vertu «le l'article 226 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.38691-0 13002-61 Service des Loisirs St-Simon-et-St-Jiide de Charlemagne Notice is hereby given by the Minister of Financial Institutions, Companies an«l Cooperatives that on January 13, 1971 he approvetl the general by-laws of 1 he corporation « Service des Loisirs St-Simon-et-St-Ju«lc de Charlemagne\", and such, in accordance with section 226 of the Companies Act.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.38691 13002-61 Sièges sociaux Head Offices Commodities & Metals Lid.Avis est donné que la compagnie « Commodities & Metals Ltd.», a transféré son siège social de Montréal au 6, Ronald Drive, Montréal-Ouest.Le secrétaire, S.Phillips.38653 10077-55 Les Éditions Solidarité Inc.Avis est donné que la compagnie « Les Éditions Solidarité Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 16 novembre 1970 et ayant son siège social à Québec, a établi son bureau au 2030, boulevard Père Lelièvre, Québec.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Québec, ce 28c jour «le décembre 1970.Le secrétaire, Jean-Paul Lkgarê.38654-o 5217-70 Les Entreprises Brisscltc & Roy inc.Avis est donné que la compagnie « Les Entreprises Brissette & Roy inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 septembre 1970, et ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau au numéro 2465 est, Bélanger.À compter de la date du présent avis, lc«lit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 7 janvier 1971.Le président, Hector Henri Roy.38655-0 3985-70 United Continental Engines Ltd.La compagnie « United Continental 'Engines Ltd.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 100, Port-Royal est, Montréal au numéro 8300, avenue de l'Industrie, Anjou.Commodities & Metals Ltd.Notice is given that \"Commodities & Metals Ltd.\", has transferred its head office from Montreal to 6 Ronald Drive, Montreal West.S.Phillips, Secretary.3S653-o 10077-55 Les Editions Solidarité Inc.Notice is given that \"Les Éditions Solidarité Inc.\", incorporated by letters patent on November 16, 1970, and having its head office in Québec, has established its office at 2030 Père Lelièvre Boulevard, Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Given at Québec, this 28th day of December, 1970.Jean-Paul Légaré, Secretari/.38654-o 5217-70 Les Entreprises Brissette & Roy inc.Notice is given that \"Les Entreprises Brissette &,Roy inc.\", incorporated by letters patent dated September 30, 1970, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 2465 Bélanger east.From and after the date of the present notice the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, January 7, 1971.Hector Henri Roy, President.38655-o 3985-70 United Continental Engines Ltd.\"United Continental Engines Ltd.\" gives notice that it changed its head office from 100 Port-Royal East.Montreal to 8300 Industrie Avenue, Anjou.38052 Jean-Paul Zigby, Secretary.2199-46 Le secrétaire, Jean-Paul Zigbv.38652-o 2199-40 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1705 Grand Prix Distributor Ltd.Avis est donné que In compagnie \" Grand Prix Distributor Ltd.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 21 décembre 1970, et ayant son siège social dans la ville de Farnham, a établi son bureau au numéro 628, rue Principale.A compter du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné A Montréal, ce 8e jour de janvier 1971.Le president, Denis Bahbeii.\"18656-0 \u2022 5621-70 Grand Prix Distributor Ltd.Notice is given that \"Grand Prix Distributor Ltd.\", incorporated by letters patent dated December 21,1970, and having its head ollicc in the town of Farnham, established its office at 628 Main Street.From and after this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 8th day of January, 1971.Denis Barber, President.38656 5621-70 Librairie du vieux Montreal inc.Avis est donné que la compagnie « Librairie du vieux Montréal inc.» constituée en corporation par lettres patentes en date du 17e jour de décembre 1970, et ayant son siège social à Montréal, a établi son bureau au numéro 451, rue St-Sulpicc.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, le 30 décembre 1970.La présidente, Geneviève Batteux.38657-o 4817-70 Silcan Mines Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné que la compagnie « Silcan Mines Ltd.» (No personal liability), constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 septembre 1970, et ayant son siège social à Montréal, a établi son bureau ù 1414, rue Crescent, Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré comme le siège social dc la compagnie.Signé ù Montréal, ce 20e jour de janvier 1971.Le secrétaire, Michael J.Riddell.38658-0 3659-70 Librairie du vieux Montréal inc.Notice is given that \"Librairie du vieux Montréal inc.\" incorporated by letters patent dated December 17, 1970, and having its head office at Montreal, established its office at 451 St-Sulpice Street.From and after the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, December 30, 1970.Geneviève Batteux, President.38657 4817-70 Silcan Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is given that the company \"Silcan Mines Ltd.\" (No personal liability), constituted in corporation by letters patent dated September 25th, 1970, and having its head office in Montreal, has established its office at 1414 Crescent Street, Montreal.As and from this date, the said office will be considered as its main office.Signed at Montreal, this 20th day of January, 1971.Michael J.Riddell, Secretary.38658-0 3659-70 Ucel Holdings Inc.La compagnie « Ucel Holdings Inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 100 est, Port-Royal, Montréal au numéro 8300, avenue dc l'Industrie, Anjou.Le secrétaire, Jean-Paul Zigby, 38659-0 15438-60 .lato Inc.La compagnie « Jato Inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 15-19, rue Myrand Sud, Sainte-Foy, au numéro 214, avenue Saint-Sacrement, Québec.Ucel Holdings Inc.\"Ucel Holdings Inc.\" gives notice that it changed its head office from 100 Port-Royal East, Montreal to 8300 Industrie Avenue, Anjou.Jean-Paul Zigby, Secretary.38659 15438-60 Jato Inc.Notice is given that \"Jato Inc.\" has changed its head office from number 15-19 Myrand Street South, Sainte-Foy to number 214 Saint-Sacrement Avenue, Quél>ec.< Jean Boiteau, President.38693 10944-54 Le président, Jean Boiteau.38693-o 10944-54 1706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Dc Gaspé Avenue Investments Inc.La compagnie « De Gaspé Avenue Investments Inc.> dûment constituée en corporation par lettres patentes datées du 28 mai 1957, et ayant son siège social à Montréal, où jusqu'à ce jour, son bureau était situé à 5420, avenue Dc Gaspé, donne avis qu'elle l'a transporté il 6155, rue Lafontainc, Montréal 427.À compter de la «laie de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, province de Québec, ce 19c jour dc janvier 1971.La secrétaire, Mme Rose Singerman.38674 11053-57 Steinberg Realty Limited Les Immeubles Steinberg limitée La compagnie « Steinberg Realty Limited \u2014 Les Immeubles Steinberg limitée » constituée en corporation en vertu des dispositions de la Loi des compagnies dc Québec, le 24c jour dc novembre 1970, cl ayant son siège social en la ville dc Montréal, en ladite province, donne avis qu'elle a établi son bureau à 110 ouest, boulevard Crémnzie.À compter du 9c jour de décembre 1970, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant le siège social de la compagnie.Daté en la ville dc Montréal, ce 21e jour de janvier 1971.Le secrétaire, James N.Doyle.38675 5193-70 François Bouvet liée Avis est donné que la compagnie « François Bouvet ltée », constituée en corporation par lettres patentes octroyées par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives du Québec, le 1er décembre 1970, et ayant son siège social à Bécancour, (Secteur St-Grégoire), comté et district de Nicolet, province de Québec, a établi son bureau audit lieu dc Bécancour, (Secteur St-Grégoire) comté et district de Nicolet, province de Québec.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Bécancour, comté de Nicolet, ce treizième jour du mois de janvier 1971.(Sceau) Le president de la compagnie, François Bouvet.38692-0 5283-70 Dc Gaspé Avenue Investments Inc.Notice is hereby given that \"De Gaspé Avenue Investments Inc.\" a company duly incorporated by letters patent dated May 28th, 1957, and having its head office in Montreal, where its office was situated up to to-day at 5420 De Gaspé Avenue, has moved it to 6155 Lafontainc Street, Montreal 427.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated at Montreal, Province of Québec, this 19lh day of January, 1971.Mrs.Rose Singerman, Secretary.38674-0 11053-57 Steinberg Really Limiled Les Immeubles Steinberg limitée Notice is hereby given that \"Steinberg Realty Limited \u2014 Les Immeubles Steinberg limitée\" incorporated under the provisions of the Québec Companies Act on the 24th day of November, 1970, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 110 Crémazie Boulevard West.From and after the 9th day of December, 1970, the said office is considered by the company as being the head office of the company.Dated at the city of Montreal, this 21st day of January, 1971.James N.Doyle, Secretary.38675-o 5193-70 François Bouvet liée Notice is given that \"François Bouvet ltéc\", incorporated by letters patent granted by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of Québec on December 1, 1970 and having its head office in Bécancour (Secteur St-Grégoirc), county and district of Nicolet, Province of Québec, established its office in the said place of Bécancour (Secteur St-Grégoire), county and district of Nicolet, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated at Bécancour, county of Nicolet, this thirteenth day of the month of January, 1971.(Seal) François Bouvet, President of the company.38692 5283-70 Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses Copcland Process Limited Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Copcland Process Limited » a été autorisée à faire affaires dans la province de Québec.Copcland Process Limited Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Copeland Process Limited\" has been authorized to carry on business in the Province. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1707 L'agent principal aux fins.de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie est M.W.Kcith Marshall, bureau 1440, Édifice de La Banque Royale, 1, Place Ville-Marie, Montréal.Le bureau principal dc la compagnie dans la province est établi au bureau 1440, Édifice de La Banque Royale, 1, Place Ville-Marie, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des insiilulions financières, 1 compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38630 2-71 The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.W.Keith Marshall, suite 1440, The Royal Bank Building, 1 Place Ville-Marie, Montreal.The principal office of the company in the Province is at suite 1440, The Royal Bank Building, 1 Place Villc-Marie, Montreal, judicial district of Montreal.38630-o Ls-Piiilippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.2-71 Oiucgu Investments Limited Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Omega Investments Limited » a été autorisée à faire affaires dans la province dc Québec.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre luditc compagnie est M.lean-Yves Gélinas, 555, O'Conncll, Dorval.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 555, O'Conncll, Dorval, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 1>s-Philippe Bouchard.38630 97-70 Omega Investments Limited Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Omega Investments Limited\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Jean-Yves Gélinas, 555 O'Conncll, Dorval.The principal office of the company in the Province is at 555 O'Conncll, Dorval, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38630-o 97-70 Chartes \u2014 demandes d'abandon de Charters \u2014 Applications for Surrender of Bcrnicr & Lahric inc.Avis est donné que « Bcrnicr & Labric inc.» demandera au ministre des institutions financières compagnies et coopératives de la province, la permission d'abandonner sa charte.Date à Québec, ce 1er février 1971.Les procureurs de la requérante, RlVARD, HlCKSON, SlROIS 38633-0 & Lemieux.Bcrnicr & Labric inc.Notice is hereby given that \"Bernicr & Labrie inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, for leave to surrender its charter.Dated at Québec, on February 1st, 1971.RlVARD, HlCKSON, SlROIS & Lemieux.38633-0 Attorneys for the Applicant Burnbrookc Holding Corporation La compagnie * Burnbrookc Holding Corporation » constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social et sa principale place d'affaires en les ville et district de Montréal, donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives dc la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 25e jour dc janvier 1971.Les procureurs des requérants, Chait, Salomon, Gelber, Ciaccia, Reis & Bronstein.38634 Par E.Dawbon.Burnbrookc Holding Corporation Notice is hereby given that \"Burnbrookc Holding Corporation\" a corporation constituted under the Companies Act and having its Head Office and principal place of business in the city and district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 25th day of January, 1971, Chait, Salomon, Gelber, Ciaccia, Reis & Bronstein, Attorneys for Applicants.38634-0 By E.Dawson. 1708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 Citadel Saw Chain Products Ltd.Avis est, par les présentes, donné que « Citadel Saw Chain Produets Ltd.», une compagnie dûment incorporée en vertu dc la Loi des compagnies (Québec) et ayant son siège social à Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de ladite Loi.Signé à Montréal, ce 3e jour de février 1971.Les procureurs de la requérante, Desjardins, Ducharme, Desjardins 38G35-0 Cordeau & Tellieh.Collège Saint-Vallier Avis est par les présentes donné que le « Collège Saint-Vallier», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la cité de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, aux fins d'obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Québec, ce 1er jour du mois de février 1971.IjC procureur de la compagnie, 38636-0 Marc Lakouette, notaire.École dc puériculture Notre-Dame de Liesse Avis est donné que « École de puériculture Notre-Dame de Liesse » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte Montréal, le 1er février 1971.Les procureurs de la requérante.Décary, Guy, Vaillancourt, 38637-0 Bertrand & Bourgeois.Majo inc.Avis est donné (pie « Majo inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnie et Coopératives de la Province la permission d'abandonner sa charte.Daté à Québec, ce 1er février 1971.Les procureurs de la requérante, 38038-o Rivahd, Hickson, Sirois & Lemieux.Shaiicdling Company Ltd.Avis est donné que \"Shanedling Company Ltd.», corporation légalement constituée en vertu de la Loi des compagnies, ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera \"au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, Québec, ce 3e jour de février, 1971.Les procureurs de la compagnie, Laing, Weldon, Courtois, Clarkson, 3804I-o Parsons, Gonthier & Tétrault.Citadel Saw Chain Produets Ltd.Notice is hereby given that \"Citadel Saw Chain Products Ltd.\", a company duly incorporated under the Companies Act (Québec) and having its head olficc in Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charier under the provisions of the said act.Signed at Montreal, this 3rd day of February 1971.Desjardins, Ducharme, Desjardins, Cordeau & Tellieh, 38635-0 Attorneys for the Petitioner.College Sainl-Vallicr Notice is hereby given that \"Collège Saint-Vallier\", incorporated under the Companies Act and having its head olficc in the city of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Québec, this 1st day of the month of February, 1971.Marc Lanouette, Notary, 38636-0 Attorney for the Petitioner.École de puériculture Notre-Dame dc Liesse Notice is given that \"École de puériculture Notre-Dame de Liesse\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies ami Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender ils charter.Montreal, February 1st, 1971.Décary, Guy, Vaillancourt, Bertrand & Bourgeois, 38637-o Attorneys for Petitioner.Majo inc.Notice is hereby given that \"Majo inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, for leave to surrender its charter.Dated at Québec, on February 1st, 1971.Rivard, Hickson, Siuois, Lemieux, 38638-e Attorneys for the A pplicanl.Shanedling Company Ltd.Notice is hereby given that \"Shanedling Company Ltd.\", a coiporation incorjx>rated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 3rd day of February, 1971.Laing, Weldon, Courtois, Clarkson, Parsons, Gonthier & Tétrault, 38641-0 Attorneys for the Company.t QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 18, 1971, Vol.103, No.7 1709 .Milieu Inc.Avis est donné que la compagnie « Millco Inc.», compagnie incorporée sous la Loi des compagnies et ayant son principal lieu d'affaires dans la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Datée à Montréal, ce 1er jour dc février 1971.Le secrétaire, 38639-0 S.Ken rose Caiiteu.Restituer Inc.Avis est donné que la compagnie « Restinter Inc.», incorporée en vertu de la Loi des compagnies et dont le siège social est dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 5c jour de novembre 1970.Le secrétaire, 38640-o Nicole Marquât; Millco Inc.Notice is hereby given that \"Millco Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 1st day of February 1971.S.Kenrose Carter, 3S039-o Secretary.Restinter Inc.Notice is hereby given that \"Restinter Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 5th day of November 1970.Nicole Marquât, 3S040-o Secretary.Les Voltigeurs de Granby inc.Avis est donné que la compagnie « Les Voltigeurs de Granby inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte Granby, le 11 janvier 1971.Le procureur de la compagnie, 38642-o Me Jean Ares.Les Autobus Itlier Inc.Avis est par les présentes donné que « Les Autobus Blicr Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, ayant son siège social à Rivière-du-Loup, comté Kamouraska, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, le tout conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies.Québec, le 27 janvier 1971.Les procureurs de la requérante, 38671-0 t Gravel & Germain.Winrite Homes Inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Winrite Homes Inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Boucherville, ce 22e jour dc janvier 1971.Les notaires, 38672-0 Duhamel & Prud'Homme.Isolation B.V.B.ltée Avis est donné que la compagnie « Isolation B.V.B.ltée » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.38686-0 Par: Mme Constance Gobeil Bolduc.-' Les Voltigeurs de Granby inc.Notice is given that \"Les Voltigeurs de Granby inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Granby, January 11, 1971.Me Jean Ares, 38642 Attorney for the company.Les Autobus Blicr Inc.Notice is hereby given that \"Les Autobus Blicr Inc.\", a corporation incorporated untler the Companies Act, having its head office at Rivière-du-Loup, county of Kamouraska, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for permission to surrender its charter, the whole in conformity with the provisions of the Companies Act.Québec, January 27, 1971.Gravel & Germain, 38671 Attorneys for the petitioner.Winrite Homes Inc.Notice is hereby given that the company \"Winrite Homes Inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Boucherville, this 22nd day of January, 1971.Duhamel & Prud'Homme, 38672-o Notaries.Isolation B.V.B.liée Notice is given that \"Isolation B.V.B.ltée\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives for leave to surrender its charter.38686-0 Per: Mrs.Constance Gobeil Bolduc: 1710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, «° 7 Arsenault, Francocur, Lapointe, Raymond Tremblay et Compagnie limitée Avis est donné que la compagnie « Arsenault, Francocur, Lapointe, Raymond, Tremblay et Compagnie limitée > , demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Saint-Jean, le 12 janvier 1971.Le président, 38683-o Rbal Arsenault.Arsenault, Francoeur, Lapointe, Raymond, Tremblay et Compagnie limitée Notice is given that \"Arsenault, Francoeur, Lapointe, Raymond, Tremblay et Compagnie limitée\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Saint-Jean, January 12, 1971.Real Arsenault, 38683-o President.Culhro Investments Inc.La compagnie « Giilbro Investments Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, ayant son siège social en la ville dc Montréal, donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 23c jour dc décembre 1970.Le secrétaire, 3868-1 Joseph Agui.nik.Hôtel, Motel La Caravelle inc.Avis est donné que la compagnie « Hôtel, Motel La Caravelle inc.» de Rivière-du-Loup, P.Q., demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Rivière-du-Loup, 25 janvier 1971.Le procureur de la compagnie, 38685-o Me Gérald Laforest.Gulbro Investments Inc.Notice is hereby given that \"Gulbro Investments Inc.», a corporation incorporated under the Companies Act, having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 23rd day of December, 1970.Joseph Agulnik, 38684-0 Secretary.Hôtel, Motel La Caravelle inc.\"Hôtel,, Motel La Caravelle inc.\" of Rivière-du-Loup, hereby gives notice pursuant to the provisions of the Companies Act that it intends to make application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender the charter of the said company.Rivière-du-Loup, P.Q., January 25, 1971.Me Gérald Laforest, 38685-0 Attorney of the company.Manoir Nominmguc inc.Avis est donné que la compagnie « Manoir Nominingue inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte 38687-o \u2022 Maurice D.Cousineau, ca.Propane Gas Utilities (1970) Limited \u2022 Avis est par les présentes donné que « Propane Gas Utilities (1970) Limited», une corporation organisée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Québec, le 5e jour de février, 1971.Manoir Nominingue inc.Notice is given that \"Manoir Nominingue inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.38687 Maurice D.Cousineau, ca.Propane Gas Utilities (1970) Limited Notice is hereby given that \" Propane Gas Utilities (1970) Limited », a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Québec, this 5th day of February, 1971.Gagnon, de Billy, Cantin, Dionne & Martin, 38688-0 Attorneys for the Company.Les procureurs de la compagnie, Gagnon, de Billy, Cantin, 38688-0 Dionne & Martin. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 18, 1971, Vol.103, No.7 1711 Alix Airborne Survey Ltd.Avis est donné que la compagnie « Alix Airborne Survey Ltd.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 38705-0 Philippe Germain, notaire.Northern Loan and Finance Corp.Avis est par les présentes donné que « Northern Loan and Finance Corp.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social dans la cité de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province dc Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 4e jour de février, 1971.Le secrétaire, 38706-o Manuel Siiacter.Princevillc Transport Inc.En vertu des dispositions île l'article 26 de la Loi des compagnies (Québec), « Princeville Transport Inc.» donne par les présentes avis qu'elle fera une demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour qu'il accepte l'abandon de sa charte et en ordonne l'annulation et fixe une date à compter de laquelle elle sera dissoute.Donné à Montréal, le 4e jour de février 1971.r La secrétaire, 38707-o Annette Carionan.le- Uniformes Québécois inc.Avis est par les présentes donné que « Les Uniformes Québécois inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social dans la cité de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 7e jour de janvier, 1971.La secrétaire, 38708-o Marion Stern.Alix Airborne Survey Ltd.Notice is given that \"Alix Airborne Survey Ltd.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter.Philippe Germain, notary, 38705 A ttorney for the company.Northern Loan and Finance Corp.Notice is hereby given that \"Northern Loan and Finance Corp.\", a corporation incorporated under the Companies' Act and having its head office in the city .of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 4th day of February, 1971.Manuel Shacter, 38706-o Secretary.Princeville Transport Inc.Under the provisions of Article 26 of the Companies Act (Québec) \"Princeville Transport Inc.\" hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter an to direct its cancellation and fix a date upon and from which it shall be dissolved.Dated at Montreal, P.Q., this 4th day of February, 1971.Annette Carignan, 38707-o Secretary.Les Uniformes Québécois inc.Notice is hereby given that \"Les Uniformes Québécois inc.\", a corporation incorporated under the Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies' Act.Dated at Montreal, this 7th day of January, 1971.Marion Stern, 38708-o Secretary.Bills \u2014 Assemblée nationale Bills \u2014 National Assembly Concernant les bills privés qui seront présentés pendant la prochaine session.Aux termes du règlement, les bills privés devront être déposés chez le secrétaire de la commission des bills privés avant le 2 février 1971 et présentés avant le 16 mars 1971, les pétitions introductives de bills privés devront être présentées avant le 5 mars 1971 et reçues avant le 10 mars 1971, et les rapport de commissions élues chargées de l'examen des bills privés devront être reçus avant le 30 mars 1971.Québec, le 21 janvier 1971.Concerning private bills to be introduced during the coming session.In accordance with Standing Orders, private bills must be deposited with the Secretary of the Private Bills Committee before February 2, 1971, and introduced before March 16, 1971; petitions for private bills must be presented before March 5, 1971 and received before March 10, 1971, and reports from select committees entrusted with the examination of private bills must be received before March 30, 1971.Québec, January 21, 1971.Le secrétaire, 38360-5-4-o René Blondin.René Blondin, 38360-5-4-o Secretary. 1712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1071, 103' année, n\" 7 Arrêtés en Conseil Arrête en conseil Chambre du Conseil Executif Numéro 32S Québec, le 27 janvier 1971.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'honorable Oswald Parent.Attendu qu'en vertu dc l'article 7 de la Loi de l'executif Statuts refondus 1904, chapitre 9 et amendements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, entre autres, définir les devoirs qui doivent être remplis par tout membre du Conseil Executif et modifier le nom sous lequel un membre du Conseil exécutif est désigné; Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que l'honorable Oswald Parent, membre du Conseil exécutif, soit désigne comme ministre d'état auprès du ministère des Finances, cl que lui soient confiées les responsabilités suivantes: a) représenter le gouvernement au sein dc la Commission Permanente des Engagements Financiers; b) Surveiller l'application dc la Loi dc la Curatelle publique (S.ll.1904.chapitre 314 et amendements); c) Surveiller l'application du Régime dc retraite des Fonctionnaires (1901.S.R.chapitre 14 et amendements); Que monsieur Oswald Parent, ministre d'étal auprès du ministère des Finances, soit autorisé à exercer les fonctions décrites ci-dessous, à l'égard des responsabilités mentionnées aux paragraphes b et c: Signer les demandes au Conseil exécutif et au Conseil de la trésorerie relativement à l'administration de la Loi de la Curatelle publique et du Régime dc retraite des fonctionnaires.Approuver ou signer les demandes relatives à la nomination et à la gestion du personnel, ainsi que tout document ayant trait à l'administration de ces deux lois.Approuver ou signer, relativement à ces deux lois, toute demande ou tout document se rapportant à un item pour lequel un crédit est prévu au budget des dépenses du ministère des Finances, à voter ou autorisé par statuts, conformément au cahier des « Crédits » pour l'année financière se terminant le 31 mars 1971.Le greffier du Conseil exécidif, 38077-o Julien Ciiouinard.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 427 , Québec, le 27 janvier 1971.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Orders in Council Order in Council Executive Council Chamber Number 328 Quebec, January 27, 1971.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning The Honourable Oswald Parent.Whereas pursuant to Section 7 of the Executive Power Act, Revised Statutes.1904, Chapter 9 and amendments, the Lieutenant-Governor in Council may.among other things, define the duties to be exercised by any member of the Executive Council and aller the liamc under which any member of the Executive Council is designated; .It is ordered, upon the recommendation of the Premier: That the Honourable Oswald Parent, member of the Executive Council, be designated Minister of State with the Department of Finance, and that the following responsibilities be conferred him: a) represent the Government within the Permanent Financial Commitments Commission; b) Supervise the application of the Public Curator-ship Act (R.S.1904.Chapter 314 and amendments); c) Supervise the application of the Civil Service Superannuation Plan (1901, U.S., Chapter 14 and amendments); * That Mr.Oswald Parent.Minister of State with the Department of Finance be authorized to exercise the functions hereunder described, with regard to the responsabilités mentioned in paragraphs b and c: Sign the petitions from the Executive Council and the Treasury Board regarding the enforcement of the Public Curatorsliip Act and the Civil Service Superannuation Plan.Approve or sign Ihc petitions regarding the appointment and management of personnel, as well as any document referring to the enforcement of both Acts.Approve or sign, with regard to both Acts, any petition or document referring to an item for which a credit is provided for in the expense budget of the Department of Finance, to be voted or authorized by Statutes, in conformity with the book of \"Credits\" for the financial year ending pn March 31, 1971.Julien Ciiouinard, 38077 Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 427 Québec, January 27, 1971.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the rules of the Advisory Committee in accordance with the Québec National Library Act.Concernant les règlements du comité consultatif en vertu de la Loi de la Bibliothèque nationale du Québec. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 13, 1071, Vol.103, No.7 1713 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires culturelles: Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi de la Bibliothèque nationale du Québec (1966-67, chapitre 24), les règlements produits en annexe adoptés par le comité consultatif, soient approuvés et entrent en vigueur dès cette approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Julien Ciiouinard.Règlements du comité consultatif en vertu de la Loi de la Bibliothèque nationale du Québec (1966-67, chap.24, art.4) 1.La fonction du Comité consultatif est de « conseiller le ministre sur toute question relative à la Bibliothèque nationale » et son année d'activité correspond à celle dc l'exercice financier du gouvernement du Québec, soit du 1er avril au 31 mars.2.Ce Comité consultatif se compose du conservateur en chef de la Bibliothèque nationale et de huit autres membres désignés par le ministre des Affaires culturelles dont le représentant personnel du ministre, le conservateur des Archives nationales, quatre personnes recommandées par les organismes mentionnés ci-dessous et dont la nomination est proposée par le conservateur en chef: Le Conseil supérieur du livre qui recommande une personne; La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, qui recommande une personne; La Conférence des principaux et recteurs des Universités du Québec, qui recommande deux personnes Deux autres personnes seront choisies parmi les usagers de la Bibliothèque nationale et proposées par le conservateur en chef.3.Sauf le représentant personnel du ministre, le conservateur en chef de la Bibliothèque nationale du Québec et le conservateur des Archives nationales, les membres du Comité consultatif sont nommés pour une période de trois ans et leur mandat est renouvelable.Ces membres peuvent démissionner en tout temps par avis écrit au ministre; toutefois, un membre est considéré comme démissionnaire après absence non motivée à trois réunions successives du Comité consultatif et le président doit en aviser immédiatement le ministre.En cas de vacance, le ministre pourvoit au remplacement selon les dispositions de l'article 2.4.Les membres du Comité consultatif, à l'exception du représentant personnel du ministre, du conservateur en chef de la Bibliothèque nationale du Québec et du conservateur des Archives nationales, siègent à titre personnel.5.Les membres du Comité consultatif choisissent annuellement parmi eux un président et un vice-président dont le mandat se termine le 31 mars de l'année suivante.Si l'élection du président et du vice-président n'a pas lieu en temps requis, elle peut se tenir lors de la première réunion du Comité consultatif qui suit le 31 mars et les membres du bureau sortant de charge demeu- It is ordered upon the recommendation of the Minister of Cultural Affairs: That, pursuant to section 4 of the Québec National Library Act (1966-67, chapter 24), the rules hereto annexed and adopted by the Advisory Committee be approved and come into force upon being approved.Julien Ciiouinard, Clerk of the Executive Council.Rules of the Advisory Committee in accordance with the Quebec National Library Act, (1966-67, chapter 24, section 4) 1.The duly of the Advisory Committee is to \"advise the Minister on any matter relating to the National Library\" and its year of operations shall correspond to the fiscal year of the Government of the Province of Québec, that is from April 1 to March 31.2.This Advisory Committee shall consist of the Chief Librarian and eight other members appointed by the Minister of Cultural Affairs, among whom the personal representative of the Minister, the Keeper of the National Archives, four persons recommended by the organizations listed below and whose nomination is proposed by the Chief Librarian : \"Le Conseil supérieur du livre\" which recommends one person ; \"La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec\" which recommends one person; \"La Conférence des principaux et recteurs des Universités du Québec\" which recommends two persons.Two other persons to be recommended by the Chief Librarian will be chosen among those using the National Library.3.With the exception of the personal representative of the Minister, the Chief Librarian of the Québec National Library and the Keeper of the National Archives, the members of the Advisory Committee are appointed for a period of three years and their term of office is renewable.These members may resign at any time by notifying the Minister in writing; however, a member shall be considered as having resigned following unjustified absences at three consecutive meetings of the Advisory Committee and the Chairman shall notify the Minister without delay.Should a vacancy occur, the Minister shall be responsible fulfilling the vacancy in accordance with the provisions of article 2.4.The members of the Advisory Committee, with the exception of the personal representative of the Minister, the Chief Librarian of the Québec National Library and the Keeper of the National Archives, sit in a personal capacity.5.Once a year the members of the Advisory Committee elect from among their ranks a chairman and a vice-chairman whose term of office ends on March 31st of the following year.If the election of the chairman and the vice-chairman does not take place within the prescribed period of time, it can be held at the first meeting of the Advisory Committee following March 1714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n' 7 rent en fonction jusqu'à ce que soient élus leurs successeurs.Les membres du bureau sortant de charge sont rééligibles, mais seulement pour un second mandat.Advenant une vacance au poste de président ou de vice-président par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le Comité consultatif doit le plus rapidement possible pourvoir nu remplacement pour le reste du mandat.6.Le président convoque et dirige les réunions du Comité consultatif, signe les documents ofliciels qui en émanent, tels que procès-verbaux des réunions, rapports annuels ou autres mémoires, etc.Il est chargé d'accomplir toute tache particulière que peut lui confier le Comité consultatif, d'exécuter toute action découlant de l'adoption dc recommandations par ce comité et d'établir à cette fin toutes relations utiles avec le ministre.7.Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et, en cas d'absence ou d'incapacité provisoire de celui-ci, le remplace avec les mêmes privilèges et responsabilités.8.Le conservateur en chef de la Bibliothèque nationale du Québec est d'office le secrétaire du Comité consultatif; il rédige les procès-verbaux des réunions, les soumet à l'approbation des membres et se tient responsable de la conservation dc tous les dossiers du Comité consultatif; il remplit toute autre tâche que lui confie ce comité et a notamment pour charge d'assister le président dans la préparation des documents requis aux travaux du comié.9.Le Comité consultatif tiendra au moins deux réunions régulières, chaque année.Le président ou la majorité des membres du comité peut au besoin convoquer toute réunion.Les réunions se tiennent habituellement à la Bibliothèque nationale du Québec.10.Les avis dc convocation, ainsi que l'ordre du jour, des réunions du Comité consultatif, sont transmis à chacun des membres, par écrit, au moins sept jours avant la tenue de toute réunion.Toutefois, ce délai peut être abrégé et une réunion valideinent tenue, si tous les membres sont présents ou si les membres absents ont préalablement accordé leur consentement, par écrit.11.La majorité des membres constiutue le quorum requis à chaque réunion.12.Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité des voix, chaque membre du comité, y compris le président, n'ayant droit qu'à un vote.Le vote se prend à main levée ou, si tel est le souhait d'un membre, au scrutin secret.13.Dans les trois mois qui suivent la fin de l'année d'activité, le président transmet au ministre un rapport annuel préalablement accepté par les membres du Comité consultatif.14.Tout amendement aux présents règlements requiert, au préalable, l'assentiment des deux tiers des membres du Comité consultatif.38677-0 31st and the members resigning shall remain in office until such time as their successors are elected.The outgoing members are eligible for re-election, but only for a second term of office.In the event of a vacancy occuring for the position of chairman or vice-chairman brought about by death, resignation or any other cause, the Advisory Committee shall as soon as possible fill the vacancy for the remainder of the term of office.6.The Chairman calls and presides over meetings of the Advisory Committee, signs the official documentation such as the minutes of the meetings, the annual reports or other reports, etc.He is expected to carry out any particular duty which the Advisory Committee refers to him, to carry out any recommendation adopted by the Committee and with this end in view to keep in touch with the Minister.7.The Vice-Chairman assists the Chairman in the discharge of his duties and, should the latter fall absent or be temporarily incapacitated, the Vicc-Chairman replaces him with the same privileges and responsibilities.8.The Chief Librarian of the Québec National Library is automatically secretary of the Advisory Committee; he writes up the minutes of the meetings, submits them to the members for approval and is responsible for keeping all the files of the Advisory Committee; he carries out any other task which the Committee might entrust him with, and in particualr he is required to assist the Chairman in the preparation of the documents required by the Committee.9.The Advisory Committee shall hold at least two regular meetings each year.The Chairman or the majority of the members of the Committee may on occasion call a meeting.Meetings arc usually held at the Québec National Library.10.Notices respecting the holding of a meeting, as well as the agenda, are transmitted to all members, in writing, at least seven days prior to the meeting.However, this delay may be shortened and a valid meeting held if all the members arc present, or if the absent members have given their assent in writing.11.The majority of the members constitutes the quorum required at each meeting.12.Decisions on all issues are reached by the majority of votes, each committee member, including the Chairman, having the right to one vote only.The vote is taken by a show of hands or, if such is the wish of a member, by secret ballot.13.In the three months following the end of the year of operations, the Chairman transmits to the Minister an annual report which has been accepted by the members of the Advisory Committee.14.Any amendment to the present rules first requires the agreement of two-thirds of the members of the Advisory Committee.38677 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1715 Arrête en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 418 Québec, le 27 janvier 1971.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la soustraction au jalonnement de deux (2) étendues dc terrain situées dans le district électoral de Saguenay.Attendu que la compagnie Canadian Javelin Limited désire aménager un pipe-line devant servir au transport de minerai de fer provenant de ses propriétés appelées Star O'Keefe Deposits et Julian Deposit; Attendu Qu'il est dans l'intérêt public dc prévenir tout jalonnement dc nuisance sur le terrain devant servir à l'aménagement dudit pipe-line; Attendu que, conformément au paragraphe 1) de l'article 268 de la Loi des mines (13-14 Elizabeth II, chapitre 34), le lieutenant-gouverneur en conseil peut réserver et soustraire par règlement au jalonnement en claims miniers tout terrain qui dans son opinion peut être nécessaire.à l'établissement de voies de transport .ou à toutes autres fins.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Richesses naturelles: Que soient réservés et soustraits au jalonnement pour une période d'un an à compter de la publication des présentes dans la Gazette officielle du Québec les terrains ci-après décrits: Première étendue: Un corridor de treize cent vingt (1320) pieds de largeur sur une distance d'environ cent quatre-vingt-dix-sept (197) milles dc longueur, ayant comme axe le parcours projeté du pipe-line, partant d'un point « A » situé dans le canton dc Desjordy, à l'intersection de la limite sud (latitude 52°33' N.et longitude 66°48'30\" W.) d'une étendue de terrain soustraite au jalonnement (voir arrêté en conseil numéro 481 du 7 mai 1958) ; de là, dans une direction générale sud-est, sur une distance approximative de quatorze (14) milles jusqu'à un point situé dans le canton de Courchesne à l'intersection de la latitude 52°22' N.et dc la longitude 66°44'30\" W.à environ trois milles et une demie (3.5) au sud-ouest du lac Félix, à l'ouest de la rive ouest de la rivière Moisie; de ht, dans une direction générale sud-ouest et sud, sur une distance approximative de douze (12) milles longeant la rive ouest de la rivière Moisie, jusqu'à l'embouchure de la rivière aux Pékans; de là, dans une direction générale >ud-ouest, sud et sud-ouest sur une distance approximative de dix-sept (17) milles, traversant les rivières aux Pékans et La Ronde jusqu'au point « B » situé dans le canton de Stagni à l'est de la rivière Sainte-Marguerite, à l'intersection de la latitude 52°03'45\" N.et de la longitude 67°04'20\" W.(le point « B » est situé approximativement à deux milles et une demie (2.5) au nord-est du lac Aux-Cèdres) ; de là, dans une direction générale sud-est, longeant la rive est de la rivière Sainte-Marguerite, sur une distance approximative de cent cinquante-quatre (154) milles jusqu'au point « C », situé dans le canton d'Arnaud, à six cent Order in Council Executive Council Chamber Number 418 Québec, January 27, 1971.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concernant the withdrawal from slaking of two (2) strips of land situated in the electoral district of Sagucnay.Whereas Canadian Javelin Limited wishes to develop a pipe-line for the transportation of iron ore coining from its estates called Star O'Kecfe Deposits and Julian Deposit; Whereas it is in the public interest to prevent any obnoxious slaking on the land to be used for the development of the said pipe-line; Whereas, in conformity with paragraph 1) of section 268 of the Mining Act (13-14 Elizabeln II, chapter 34), the Lieutenant-Governor in Council may, by regulation, reserve and withdraw from slaking on mining, claims any land which,,in his opinion, may be necessary.for the establishment of transportation facilities .or for any other purposes.It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Natural Resources: TiiAT'the lands hereafter described be reserved and withdrawn from staking for a period of one year from and after their publication in the Quebec Official Gazette: First strip: A corridor of thirteen hundred and twenty (1320) feet in width by a distance of about one hundred and ninety-seven (197) miles in length, the planned course of the pipe-line forming the centre-line, starting at Point \"A\" situalcd in the township of Dcsjordy, at the intersection of the .southern limit (latitude 52°33' N.and longitude 66°48'30\" W.) a strip of land withdrawn from staking (sec Order in Council number 481 of May 7, 1958) ; thence, in a general .southeasterly direction, an approximative distance of fourteen (14) miles to a point situated in the township of Courchesne at the intersection of latitude 52°22' N.and longitude 66°44'30\" W.at about three miles and one-half (3.5) southwest of Félix Lake, west of the west shore of Moisie River; thence, in a general southwesterly and southerly direction, a distance of about twelve (12) miles stretching along the western shore of Moisie River, to the mouth of Pékans River; thence, in a general southwesterly, southerly and southwesterly direction a distance of about seventeen (17) miles, crossing Pékans and La Ronde Rivers to Point \"B\" situated in the township of Stagni, east of Sainte-Marguerite River, at the intersection of latitude 52°03'45\" N.and longitude 07°04'20\" W.(Point \"B\" is situated at about two miles and one-half (2.5) northeast of Aux-Cèdres Lake); thence, in a general southeasterly direction, stretching along the cast shore of Sainte-Marguerite River, a distance of about one hundred and fifty-four (154) miles to Point \"C\", situated in the township of Arnaud, six hundred and sixty (660) feet 1716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, a\" 7 soixante (660) pieds au nord-est dc la rive est dc la rivière Sainte-Marguerite, sur la ligne separative des blocs e M » et « W » (limite nord-ouest de la cité de Scpt-Iles).Deuxième étendue: a) Une étendue de terrain de forme rectangulaire dont le périmètre se lit comme suit: Partant du milliaire vingt-deux (22) - Exploration 207 dc Robert GrefTard, a.g., déposée le 25 mars 1959 -situé sur la ligne separative des cantons de Franche-ville et Hauteville; de là, dans une direction ouest sur une distance dc deux mille six cent quarante (2040) pieds; de là, dans une direction nord sur une distance de cinq mille deux cent quatre-vingts (5280) pieds; de là, dans une direction est sur une distance de deux mille six cent quarante (2640) pieds jusqu'au milliaire vingt-trois (23) sur la ligne separative des cantons dc Hauteville et Franche ville; dc là, dans une direction est sur une distance de sept mille neuf cent vingt (7920) pieds; de là, dans une direction sud sur une distance de cinq mille deux cent quatre-vingts (5280) pieds; de là, dans une direction ouest jusqu'au point de départ.b) Un corridor dc treize cent vingt (1320) pieds de largeur, sur une distance d'environ cinquante (50) milles ayant comme axe le parcours projeté du pipe-linc, partant d'un point « D » situé au milliaire vingt-deux (22) sur la ligne dc division des cantons dc Frnnchc-ville et de Hauteville; dc là, sur une distance approximative de cinq milles et deux cinquièmes (5.4) dans une direction générale sud-est en contournant les rives nord-est et est «lu lac Tuttle jusqu'à un point situé dans le canton de Fabcr à l'intersection dc la latitude 52°32'50\" N.et de la longitude 67°37'40\" W'.; dc là, dans une direction sud-est longeant la rive est des rivières Peppier et Petite Rivière Manicouagan, sur une distance approximative de dix-sept milles et un cinquième (17.2) jusqu'à un point situé duns le canton dc Malapart à l'intersection de la latitude 52°19'20\" N.et de la longitude 67°30' W.; de là, dans une direction générale sud-est, traversant la Petite Rivière Manicouagan, sur une distance approximative dc vingt-deux (22) jusqu'à un point situé dans le canton dc Stagni à l'ouest de la rivière Sainte-Marguerite, à l'intersection dc la latitude 52°08'40\" N.et de la longitude 67°08'10\"; de là, dans une direction générale sud-est, traversant la rivière Sainte-Marguerite, sur une distance approximative de cinq milles et deux cinquièmes (5.4) jusqu'au point « B » situé dans le canton de Stagni à l'est de la rivière Sainte-Marguerite, à l'intersection dc la latitude 52°03'45\" N.et dc la longitude 67°04'20\" W.(le point « B » est situé approximativement à deux milles et une demie (2.5) au nord-est du lac Aux-Cèdres).Le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro B-992 à l'échelle de quatre (4) milles au pouce, lequel est initiale par le sous-ministre des Richesses naturelles et déposé aux archives de ce ministère.Que ce règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec et qu'il ait force dc loi dès sa publication.northeast of the cast shore of Sainte-Marguerite River, on the separative line of Blocks \"M\" and \"W\" (northwestern limit of the city of Scpt-Iles).Second strip: (a) A strip of land of a rectangular form, the perimeter of which reads as follows : Starting from milliary twenty-two (22) - Exploration 207 of Robert G re Hard, l.s., deposited on March 25, 1959 - situated on the separative line of the townships of Franchcvillc and Hauteville; thence, in a westerly direction a distance of two thousand six hundred and forty (2640) feet; thence, in a northerly direction a distance of five thousand two hundred and eighty (5280) feet; thence, in an easterly direction a distance of two thousand six hundred and forty (2640) feet to milliary twenty-three (23) on the separative line of the townships of Hautcvillc and Franchcvillc; thence, in an easterly direction a distance of seven thousand nine hundred and twenty (7920) feet; thence, in a southerly direction a distance of five thousand two hundred and eighty (5280) feet; thence, in a westerly direction to the starling point.(6) A corridor of thirteen hundred and twenty (1320) feet in width, by a distance of about fifty (50) miles, the planned course of the pipe-linc forming the centre-line, starting at Point \"D\" situated at milliary twenty-two (22) on the division line of the townships of Franche-ville and Hauteville; thence, a distance of about five miles and two-fifths (5.4) in a general southeasterly direction skirting the northeast and east shores of Tuttle Lake to a point situated in the township of Fabcr at the intersection of latitude 52°32'50\" X.and longitude 67°37'40\" W.J thence, in a southeasterly direction stretching along the cast shore of Peppier and Petite Manicouagan Rivers, a distance of abour seventeen miles and one-fifth (17.2) to a point situated in the township of Malapart at the intersection of latitude 52°19'20\" N.and longitude 67°30' W.; thence, in a general southeasterly direction, crossing Petite Manicouagan River, a distance of about twenty-two (22) miles to a point situated in the township of Stagni, west of Sainte-Marguerite River, at the intersection of latitude 52°08' 40\" N.and longitude 67°08'10\"; thence, in a general southeasterly direction, crossing Sainte-Marguerite River, a distance of about five miles and two-fifths (5.4) to Point \"B\" situated in the township of Stagni, cast of Sainte-Marguerite River, at the intersection of latitude 52°03'45\" N.and longitude 67°04'20\" W.(Point \"B\" is situated at about two miles and one-half (2.5) northeast of Aux-Cèdres Lake).The whole as indicated in red on Plan number B-992 on a scale of four (4) miles to an inch, the latter initialed by the Deputy Minister of Natural Resources and deposited in the Archives of this Department.That this regulation be published m the Quebec Official Gazette and that it come into force after its publication.Julien Ciiouinard, 38668 Clerk of the Executive Council.Le greffier du Conseil exécutif, 38668-o Julien Ciiouinard. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1717 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 3G5 Québec, le 27 janvier 1971.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil CONCERNANT l'adoption d'un règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi du ministère des Affaires sociales (1970, chapitre 42), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre, ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazelle officielle du Québec; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser monsieur Jean-Guy Houdc, sous-ministre adjoint, à signer certains actes, documents ou écrits du ministère; Il est ordonné en conséquence sur lu recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopte le présent règlement: « Monsieur Jean-Guy Houdc, sous-ministre adjoint responsable de l'administration interne du ministère îles Affaires sociales, est autorisé, par délégation du ministre, à signer (sauf lorsqu'il s'agit de cadres supérieurs, d'adjoints aux cadres supérieurs, d'étudiants, «l'employés occasionnels ou à honoraires dans les sept (7) premiers cas) : 1.les demandes dc personnel; 2.les actes dc nomination à titre temporaire; 3.les actes dc nomination à titre permanent; 4.les avis de mutation intra-ministériellc; 5.les avis de mutation extra-ministérielle; 6.les autorisations nécessaires pour mettre fin aux engagements à titre temporaire; 7.les actes dc suspension et les actes de révocation; S.les demandes d'amendement d'effectifs et d'addition d'effectifs; 9.les autorisations nécessaires au maintien des postes autorisés devenus vacants; 10.les autorisations dc congé, sans traitement, pour fins de perfectionnement et les demandes de congé avec traitement pour fins de perfectionnement également; 11.les autorisations pour l'exécution de travail en temps supplémentaire, ainsi que les demandes et autorisations pour la rémunération du travail accompli en temps supplémentaire; 12.les demandes dc rémunérations additionnelles; 13.les, demandes dc paiement dc primes d'éloigne-ment; 14.les demandes et autorisations de paiement ou de remboursement des frais dc voyage, de déplacement et «le séjour; 15.les demandes relatives aux indemnités et gratifications de départ.» Que le présent règlement soit publié dans la Gazelle officielle du Québec; Order in Council Executive Council Chamber Number 365 Québec, January 27, 1971.Present: The Lieutenant-Governor in Council Concerning adoption of a regulation respecting the signature of certain documents of the Department of Social Affairs.Whereas, pursuant to section 8 of the Social Affairs Department Act (1970, chapter 42), no deed, document or writing shall bind the Department or be attributed to the Minister unless it is signed by him, the Deputy Minister or a functionary and only, in the case of the latter, to the extent determined by regulation of the Lieutenant-Governor in Council published in the Québec Official Gazette.Whereas it is «lcemed expedient to authorize Mr.Jean-Guy Houdc, Assistant Deputy Minister, to sign certain deeds, documents or writings of the Department ; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Social Affairs: That the following regulation be adopted: \"Mr.Jean-Guy Houdc.Assistant Deputy Minister responsible for the internal management of the Department of Social Alfairs, is authorized as delegated by the Minister to sign the following documents (except in the first seven (7) instances respecting officers, assistant senior officers, students, casuals or employees on a fee basis): 1.requests for personnel; 2.nominations for temporary appointments; 3.nominations for permanent appointments; 4.transfer notices within the department; 5.notices of interdepartmental transfers; 6.authorizations required to terminate temporary employment; 7.documents for the suspension and dismissal of staff; 8.requests to modify or increase manpower; 9.authorizations necessary for the retention of authorized positions falling vacant; 10.authorizations for leave without pay for further training purposes, ami requests for leave with pay for further training purposes; 11.authorizations to carry out work on an overtime basis as well as requests and authorizations for the payment of work on an overtime basis; 12.requests for additional remuneration; 13.requests for removal allowances; 14.requests and authorizations for the reimbursement of travelling, hotel and living expenses; 15.requests for indemnities and bonuses granted upon an employees departure.\" That this by-law be published in the Québec Official Gazette; 1718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, IS février 1971, 103' année, n\" 7 Que l'arrêté en conseil 3354 du 2 septembre 1970, qui conférait une partie de ces pouvoirs à Me Camille Blier, soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, 38G67-0 Julien Ciiouinard.That Order in Council 3354 of September 2, 1970 which conferred part of this authority to Me Camille Blier be abrogated.Julien Chouinard, 38667 Clerk of the Executive Council.Régie des Marchés Agricoles du Québec Québec Agricultural Marketing Board Règlement dc quotas dc la Fédération des producteurs dc volailles du Québec Avis Prenez avis que lors de sa séance du 29 janvier dernier, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement de quotas ci-après adopté par la Fédération des producteurs de volailles du Québec: Règlement de quotas Chapitre I.\u2014 Définition: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « Plan »: le plan conjoint des producteurs dc volailles du Québec; b) « Fédération » : la Fédération des producteurs dc volailles du Québec; c) « Régie » : la Régie des marchés agricoles du Québec; d) « producteur » : le producteur intéressé, tel que défini dans le plan; c) « mise en marché »: la définition donnée dans le plan; /) « poulet Bar-B-Q » : le poulet dont le poids vivant, moyen est de 3.8 livres ou moins lors de la livraison pour abattage; g) « poulet à griller » : le poulet dont le poids vivant moyen se situe entre 3.8 livres et 5 livres lors de la livraison pour abattage ; h) « gros poulet » : le poulet dont le poids vivant moyen est de 5 livres ou plus lors de la livraison pour abattage ; i) « dindon à griller » : le dindon dont l'âge est inférieur à 17 semaines lors de la livraison pour abattage; j) « gros dindon »: le dindon dont l'âge est de 17 à 30 semaines lors de la livraison pour abattage; k) «dindon de reproduction »: le dindon dont l'âge est de 30 semaines ou plus lors dc la livraison pour abattage; l) « production » : le poulet Bar-B-Q, le poulet à griller, le gros poulet, le dindon à griller, le gros dindon, ou le dindon de reproduction ; m) « volaille » : l'ensemble des productions; n) « éleveur » : tout producteur qui élève, dans des locaux dont il est propriétaire ou locataire, une ou des productions pour son compte ou celui d'autrui; Quota regulation of the Fédération des producteurs dc volailles du Québec Notice Take notice that the Québec Agricultural Marketing Board has approved at its meeting held on January 29 last the following quota regulation adopted by the Fédération des producteurs de volailles du Québec: Quota regulation Chapter I.\u2014 Definition: 1.In the present regulations, unless the context indicates a different meaning, the following expressions and words mean : (a) \"Plan\": the Québec Poultry Producers' Joint Plan; (6) \"Fédération\": the Fédération des producteurs de volailles du Québec; (c) \".Board\": the Québec Agricultural Marketing Board; (d) \"Producer\": the interested producer, as specified in the plan; (e) \"Marketing\": the definition given in the plan; (/) \"Bar-B-Q Chicken\": the chicken whose average live weight is 3.8 lb or less at the time of delivery for slaughtering; (g) \"Chicken broiler\": the chicken whose average live weight is between 3.8 lb and 5 lb at the delivery for slaughtering; (h) \"Roaster\": the chicken whose average live weight is 5 lb or more at the time delivery for slaughtering; (i) \"Turkey broiler\": the turkey whose age is less than 17 weeks at the time of delivery for slaughtering; (j) \"Heavy turkey\": the turkey whose age is between 17 and 30 weeks at the time of delivery for slaughtering; (£\u2022) \"Turkey for reproduction\" : the turkey whose age is 30 weeks or more at the time of delivery for slaughtering; (J) \"Production\"; the Bar-B-Q chicken, chicken broiler, roaster, turkey broiler, heavy turkey, turkey for reproduction; (m) \"Poultry\": all the productions; (n) \"Poultry-farmers\": any producer who raises, in a poultry farm of which he is the owner or the lessee, one or many of the productions, on his own or somebody else's account; (o) \"Global quota\": the sum of all quotas attributed to the poultry-farmers by the Fédération; o) « quota global » : la somme des quotas attribués aux éleveurs par la Fédération; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February IS.1971.Vol.10S, No.7 1719 p) «période»: le nombre de jours consécutifs au cours desquels la consommation per capita se maintient au même niveau; 17) « demande » : le pourcentage que donnent les possibilités dc consommation d'une période divisées par les possibilités dc production (base: équivalences établies à l'article 10) du quota global multipliées par 100; r) « exploitation » : l'ensemble des bâtiments et de toute installation requise pour l'élevage dc la volaille.Chapitre II.\u2014 Quotas: 2° Tout éleveur doit détenir un quota établi eu vertu du présent règlement.3° Il est interdit ù tout producteur de mettre en marché de la volaille qui n'a pas été élevée dans l'exploitation d'un éleveur à qui la Fédération a attribué un quota.4\" La Fédération doit attribuer un quota à toute personne qui remplit les conditions du présent règlement.ô° Pour obtenir un quota, l'éleveur doit avoir fait ou commencé l'élevage dc la volaille entre le 1er juin 1970 et la publication du présent règlement dans la Gazette officielle du Québec.6° Quand un éleveur cesse définitivement «l'élever dc la volaille, son quota est annulé.S'il cesse d'élever dc la volaille pour plus d'une période d'élevage, il doit demander à la Fédération de lui conserver son quota en suspens pendant cette période; le quota ne peut cependant être suspendu pour une période plus longue que 12 mois.7° Mode dc calcul du quota: a) Le quota de l'éleveur est déterminé en établissant d'abord son quota dc base, lequel peut être modifié périodiquement selon les facteurs et dans les proportions prévues au chapitre III.b) I ., 25-A-238 (rue), 25-A-239 (rue) du rang IV, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin ouest du lot 25-A-239 (boulevard Rivière aux Sables); de là, successivement, les lignes el démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest du lot 25-A-239 et la ligne sud-ouest du lot 25-A-l-l, ces lignes faisant en partie le côté sud-ouest du boulevard de la Rivière aux Sables jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 25-A-215; les lignes nord-ouesl et sud-ouest dudil lot 25-A-215; la ligne sud des lots 25-A-215 en rétrogradant jusqu'au lot 25-A-210; la ligne est des lots 25-A-210 et 25-A-238 (boulevard Rivière aux Sables) enfin la ligne nord des lots 25-A-238 et 25-A-239 jusqu'au point de départ Le sous-minislre des Affaires municipales, 38676-0 Richard Beaulieu.City of Jonquière Notice is given that, by Order in Council Number 40S of January 27, 1971 and in accordance with section 43 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 1964, chapter 193), the Lieutenant-Governor in Council was pleased to approve by-law Number 746 of the municipal council of the city of Jonquière and to decree that, from and after the date of publication of the present notice, the territory mentioned in the said by-law and described below is detached from the municipality of the parish of Saint-Dominique-de-Jonquières, county of Chicoutimi, and annexed to the city of Jonquière.The territory is as follows: Official description of the limits of the territory detached from the municipality of the parish of Saint-Dominique-dc-Jon-quières, and annexed to the city of Jonquière.A territory now forming part of the municipality of the parish of Saint-Dominique-de-Jonquières, county of Chicoutimi, comprising, with reference to the cadastre of the township of Jonquière, lots 25-A-l-l (slrccl), 25-A-210, 25-A-211, 25-A-212, 25-A-213, 25-A-214, 25-A-215, 25-A-238 (street), 25-A-239 (street) in range IV, the whole enclosed within the boundaries described hereinafter, to wit: starling from the western corner of loi 25-A-239 (Rivière aux Sables Boulevard); thence, successively, the following lines and boundaries: pari of the southwestern line of lot 25-A-239 and the south-western line of lot 24-A-l-l, these lines forming a part of the southwestern side of Rivière aux Sables Boulevard to the norlh-western line of lot 25-A-215; the north-western and south-wcsterii lines of said lot 25-A-215; the south line of lots 25-A-215 moving backwards to lot 25-A-210; the east line of lots 25-A-210 and 25-A-238 (Rivière aux Sables Boulevard), finally the northern line of lots 25-A-238 and 25-A-239 to the starting point.Richard Beaulieu, 38676 Deputy Minister of Municipal Affairs.Liquidation \u2014 Loi de la Magasin Co-op dc Hauterive (Loi des associations cooj)ératives) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres du « Magasin Co-op de Hauterive », tenue à Hauterive, le 17 décembre 1970, il a été résolu que les affaires de ladite association coopérative soient liquidées, que celle-ci soit dissoute, et ce eu vertu des dispositions de la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que MM.Grégoire Bellavance, Claude Gaeremynck et Mme Fernande Fortin ont été nommés liquidateurs.Le sous-minislre des institutions financière, compagnies et coopératives.3709-o Ls-Philippe Bouchard.Winding Up Act Magasin Co-op dc Hauterive (Cooperative Associations Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of \"Magasin Co-op de Hauterive\", held at Hauterive on December 17, 1970, a resolution was passed stating that the affairs of the said cooperative association be wound up, that it be dissolved, pursuant to the provisions of the Cooperative Associtions Act and the Winding-Up Act, and that Messrs.Grégoire Bellavance, Claude Gaeremynck and Mrs.Fernande Fortin were appointed liquidators.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 38709 Companies and Cooperatives. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1727 Gérald Martineau in*.Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires dc la compagnie « Gérald Martineau inc.», tenue à Québec, le 1er décembre 1970, il a été résolu que les affaires dc ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu île la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Guy Fortier, comptable agréé, a été nommé liquidateur.Le directeur du service des compagnies, \u2022 Rocu Rioux.38G01-o 2735-66 Gérald Martineau inc.Notice is given that at.a special general meeting of the shareholders of \"Gérald Martineau inc.\", held at Québec, on December 1, 1970, a resolution was passed stating that the affairs of the said company be wound up, and that it be dissolved, pursuant to the Winding-lip Act, and that Mr.Guy Fortier, chartered accountant, was appointed liquidator.38661 Rocii Rioux, Director oj the Companies Branch.2735-66 Proclamation Proclamation HUGUES LAPOINTE Canada, Province de Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et dc ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la loi.À nos très aimés et fidèles conseillers les membres de l'Assemblée nationale du Québec, Salut.Proclamation Attendu que, pour diverses considérations, il est à propos de convoquer la Législature dc la province de Québec pour l'expédition des affaires, Nous vous convoquons par les présentes pour le vingt-troisième jour de février prochain et, en conséquence, vous mandons et ordonnons dc vous assembler à cette date, au palais législatif, en la ville de Québec, pour y expédier les affaires de la province et y examiner, discuter et décider les questions qui vous seront soumises.En foi de quoi, Nous avons fait rendre nos présentes lettres patentes et sur icclles apposer le grand sceau de la province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, cp., c.r., lieutenant-gouverneur de ladite province.Donné en Notre hôtel du gouvernement, à Québec, le vingt et unième jour de janvier, l'an de grâce mil neuf cent soixante et onze et de Notre règne le dix-neuvième.Par ordre.38360-5-4-o Le secrétaire de la chancellerie à Québec, René Blondin.HUGUES LAPOINTE Canada, Province of Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To our Beloved and Faithful Councillors, the members of the National Assembly of Québec., Greeting.Proclamation Whereas, for various considerations, it is expedient to summon the Legislature of the Province of Québec for the dispatch of business, We hereby convene you for the twenty-third day of February next and, accordingly, command and order you to meet on such date at the Parliament Buildings, in the city of Québec, for the dispatch of the business of the Province and to examine, discuss and decide the questions to be submitted to you.In testimony whereof, Wc have caused these Our letters to be made patent and the Great Seal of our Province of Québec to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of the said Province.Given at Our Government House, in Québec, on the twenty-first day of January, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventy-one, in the nineteenth year of Our Reign.By command, 38360-5-4-o Rene Blondin, Clerk of tlte Crown in Chancery, al Québec.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec (Loi des caisses d'épargne cl de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives approved the GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 février 1971, 103e année, n\" 7 1728 formation de la caisse d'épargne et de crédit: « Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec ».Le groupe dans lequel la caisse recrutera ses membres, sera: « Les travailleurs des corporations, institutions ou sociétés suivantes: Le Syndicat des permanents et des employés de bureau de la C.S.N.; les employés de l'Hôpital Général de Québec; les employés de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatièrc; les employés de l'Hôpital St-Augustin (Courville); les employés, de l'Hôpital St-Michel Archange (Mastaï) ».Le siège social de cette caisse d'épargne et de crédit est situé dans la cité dc Québec, tlistriet électoral Louis-Hébert.Québec, le 8 février 1971.Le sous-minislre des insiilulions financières, compagnies el coopératives, 38734-0 Ls-Philippe Bouciiaud.La Caisse populaire de Ste-Thérèsc de l'Enfant-Jésus (Correction) Dans l'avis publié dans la Gazelle du Québec numéro 5 du 30 janvier 1971, à la page 1332, sixième ligne, nous aurions dû lire: « soit au nord le chemin de fer du C.N.R.» au lieu de « soit au nord du chemin dc fer du C.N.R.» 38631-0 Caisse d'économie Wayagamack (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a approuvé le règlement adopté le 13 novembre 1970 par la « Caisse d'économie Wayagamack », modifiant son groupe qui était: Les employés de Consolidated Paper Corporation de Trois-Rivières « Division Wayagamack » en y ajoutant « les employés dc Les Emballages Consolidated Bathurst Limitée du Cap-de-la-Madeleinc ».Québec, le 1er février 1971.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 38704-o Ls-Philippe Bouchard.formation of the savings and credit union: \"Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec\".The group from which the union will recruit its members will be: \"The employees of the following corporations, institutions or firms: \"Le Syndicat des permanents et des employés dc bureau dc la C.S.N.\"; the employees of l'Hôpital Général dc Québec; the employees of l'Hôpital Notre-Dame dc Fatima dc la Pocatièrc; the employees of l'Hôpital St-Augustin (Courville); the employees of l'Hôpital St-Michel Archange (Mastaï)\".The head office of this savings and credit union is situated in Québec City, electoral district of Louis-Hébert.Québec, February 8, 1971.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 38734 Companies and Cooperatives.La Caisse populaire de Ste-Thérèsc de l'Enfant-Jésus (Correction) In the notice published in Québec Officiai Gazelle number 5 of January 30, 1971, on page 1332, in the sixth line, one should have read: \"on the north the C.N.R.railroad\" instead of \"on the north of the C.N.R.railroad.\" 38631 Caisse d'économie Wayagamack (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives approved the by-law adopted on November 13, 1970 by the \"Caisse d'économie Wayagamack\", modifying its group which was the employees of Consolidated Paper Corporation .of Trois-Rivières \"Division Wayagamack\" by adding \"the employees of Les Emballages Consolidated Bathurst Limitée du Cap-dc-la-Madcleine\".Québec, February 1, 1971.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 38704 Companies and Cooperatives.Avis divers Conseil Mercier No 3370 des Chevaliers de Colomb dc Mercier inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 13 janvier 1971, il a approuvé les règlements généraux de la corporation « Conseil Mercier No 3370 des Chevaliers de Colomb de Mercier inc.», et ce, en vertu de l'article 9 de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec et l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38682-0 10-70 Miscellaneous Notices Council Mercier No.3370 of the Knights of Columbus of Mercier Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on January 13,1971, approved general by-laws of \"Council Mercier No.3370 of the Knights of Columbus of Mercier Inc.\", and such pursuant to section 9 concerning the Knights of Columbus of the Province of Québec and section 225 of the Companies Act.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38682 10-70 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1729 Université du Québec Avis par les présentes est donné que l'Assemblée des Gouverneurs de l'Université du Québec a amendé, dans le sens suivant, le règlement No 17.1 relatif à l'engagement du personnel de l'Université du Québec, de ses universités constituantes, écoles supérieures et instituts de recherche, et le règlement No 17.2 relatif à l'établissement d'un régime de rentes pour le personnel à l'emploi de l'Université du Québec et des autres corporations auxquelles il s'applique: 1.Que le règlement général No 17.1 relatif à l'engagement du personnel dc l'Université du Québec, de ses universités constituantes, écoles supérieures et instituts dc recherche, soit amendé comme suit: a) en remplaçant partout où clic apparaît, l'expression « No 17.1 » par l'expression « No 17.6 » ; b) en ajoutant, à la fin de l'article 4, les mots: « sauf en ce qui a trait au régime dc rentes supplémentaires; » c) en ajoutant à l'article 5 l'alinéa suivant: « l'annexe VII du présent règlement, qui en fait partie, régit le régime dc rentes supplémentaire dc tout le personnel; » (/) en ajoutant, à l'article 6, après les mots: « le plan dc classification et les attributions » les mots suivants: « ainsi que le régime dc rentes supplémentaire; » c)_cn ajoutant, à l'article 6, après les mots: «à l'article 5 », les mots: « et définis aux annexes IV, V, VI et VII » /) en remplaçant, dans l'article 7, les mots: « aux annexes I, II et III » par les mots: « aux annexes I, II, III et VII ».2.Que soient incorporés audit règlement général les amendements qui y ont déjà été apportés, savoir: a) à l'article 2, alinéa A) le remplacement des mots: «le corps professoral» par les mots: «le personnel d'enseignement et de recherche » ; b) le remplacement de l'article 9, par le suivant: « toute convention collective ou toute entente faite entre une université constituante, école supérieure ou institut de recherche et un syndicat, association ou groupe d'employés de telle institutions doit, pour être valide, Ctre signée par les officiers autorisés desdites unités et le président dc l'Université du Québec ».3.Que le règlement général No 17-2 concernant l'établissement d'un régime dc rentes pour le personnel de l'Université du Québec et des autres corporations auxquelles il s'applique devienne l'annexe Vit du règlement général No 17.6.Les deux amendements visés à l'article 2 de la présente résolution ne s'appliquent pas aux conventions ou ententes en cours de négociation en date du 19 août 1970.38702-O Succession Gaétan Picard Avis est par les présentes donné que MM.Marc Picard, Laurent Picard et Guy Picard, ont accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de M.Gaétan Picard, leur frère, en son vivant domicilié au numéro 63, rue Buade, Québec, décédé à Québec, le 5 janvier 1971, intestat et célibataire, par acte signé devant Me Ber- University of Québec Notice is hereby given that the Board of Governors of the University of Québec has amended, in the following way, By-law No.17.1 respecting the hiring of staff for the University of Québec, its constituent universities, superior schools and research institutes, and By-law No.17.2 respecting the setting-up of an annuity plan for the staff of the University of Québec and of the other corporations the plan covers: 1.That general By-law No.17.1 respecting the hiring of staff for the University of Québec, its constituent universities, superior schools and research institutes be amended as follows: (a) by replacing expression \"No.17.1\" by expression \"No.17.6\" whenever the former is used; (6) by adding, at the end of section 4, the words: \"except where the supplemental annuity plan is concerned\"; (c) by adding to section 5 the following paragraph \"annex VII of this by-law, of which it forms part, governs the supplemental annuity plan for all the staff\"; (d) by adding, in section 6, after the words: \"the classification plan and duties the following words: \"as well as the supplemental annuity plan\"; (c) by adding, in section 6, after the words: \"in section 5\" the words: \"in section 5\", the words: \"as defined in Appendices IV, V, IV and VII\", (/) by replacing, in section 7, the words: \"in Appcn-dendices I, II and III\" by the words: \"In Appendices I, II, III and VII\".2.That be incorporated in the said general by-law the amendments which have already been mode, to wit: (a) in section 2, paragraph (A) substituting the words : \"teaching staff\" by the words: \"the teaching and research staff\"; (6) substitution section 9 by the following: \"a collective agreement or understanding between a constituent university, superior school or research institute and a union, association or group of employees of such an institutions must, in order to be valid be signed by authorized officers of the said units and the President of the University of Québec\".3.That beneral by-law No.17.2 respecting the setting up of an annuity plan for the staff of the University of Québec and of the other corporations the plan covers become Appendix VII of general by-law No.17.6.The two amendments referred to in section 2 of this resolution only apply to the agreements or understandings which were being ncgatiatcd as of August 19, 1970.38702 Estate of Gaëtan Picard Notice is hereby given that Messrs.Marc Picard, Laurent Picard and Guy Picard have accepted under benefit of inventory the estate of Mr.Gaëtan Picard, their brother, in his life time domiciled at 63, Buade Street, Québec, deceased at.Québec on January 5th, 1971, intestate and unmarried, by deed passed before 1730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1071, 103- année, n° 7 nard Samson, notaire à 970, avenue Cartier, Québec, le 1er février 1971, sous le numéro 11,966 de ses minutes, et enregistré au bureau d'enregistrement de Québec, le 3 février 1971, sous le numéro 6S4.866.Québec, ce 3 février 1971.Le notaire pour les héritiers, 38701-o (Signé) Bernard Samson.Associations coopératives Association coopérative des consommateurs d'huile de Windsor (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation tic l'association coopérative « Association coopérative des consommateurs d'huile de Windsor».Le siège social dc cette association coopérative est situé à Windsor, Québec, dans le district électoral de Richmond.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, 38703-o Ls-Piiilippe Bouchard.Me Bernard Samson, notary at 970, Cartier Avenue, Québec, on February 1st, 1971, under number 11,966 of his minutes, and registered at the Québec registry office on February 3, 1971, under number 684,866.Québec, February 3, 1971.(Signed) Bernard Samson, 38701 -o Notary for the heirs.Cooperative Associations Association coopérative des consommateurs il \"li n i N- de Windsor (Cooperative Associations Art) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives approved the formation of \"Association coopérative des consommateurs d'huile dc Windsor\".The head office of this cooperative association is situated at Windsor, Québec, in the electoral district of Richmond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 38703 Companies and Cooperatives.Ventes d'effets non reclames Sales of Unclaimed Baggage Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada Réclamations marchandises Avis est par les présentes donné que tous les effets reçus avant le premier jour de septembre 1970, et non réclamés aux bureaux de la Compagnie des Chemins dc Fer Nationaux du Canada, à divers endroits dc la Région du Saint-Laurent des Chemins dc Fer Nationaux du Canada seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Allan Harvey & Company, encanteurs, 2276 est, rue Ontario, Montréal, à midi, le mercredi 10 mars 1971, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Montréal, Québec, le 28 janvier 1971.Le directeur, 38509-6-5-o W.W.R.Bradford.Compagnie du chemin dc fer canadien du Pacifique.Avis est par les présentes donné que tous les effets de bagage reçus avant le premier jour de novembre 1970, et non réclamés aux bureaux de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, seront vendus aux enchères pur Fraser Brothers (Canada) Limited, 4950 de la Savane, Montréal, à dix heures dc Pavant-midi, lundi, le vingt-neuvième (29e) jour dc mars 1971, conformément il la Loi des Chemins dc Fer du Canada, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Montréal, le 1er février 1971.Le superviseur, 38669-7-6-0 (1.P.Watson.Canadian National Railway Company Merchandise Claims Department Notice is hereby given that all goods received previous to the first day of September 1970, and still remaining unclaimed in the offices of the Canadian National Railway Company, at different points in the St-Lawrence Region of the Canadian National Railway Company, will be sold at public auction to the highest bidder by Allan Harvey & Company, Auctioneers, 2276 Ontario Street East, Montreal, at 11:30 a.m., Wednesday, March 10, 1971, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.Montreal, Québec, January 28, 1971.W.W.R.Bradford.38509-6-5-o Manager.Cnnadian Pacific Railway Company Notice is hereby given that all baggage received prior to the first day of November 1970, and still remaining unclaimed in the offices of Canadian Pacific Railway Company, will be sold by public auction to the highest bidder by Fraser Brothers (Canada) Limited, auctioneers, at 4950 de la Savane, Montreal, at ten o'clock in the forenoon, on Monday, the twenty-ninth (29th) day of March 1971, under the authority of the Railway Act of Canada, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.Montreal, February 1, 1971.G.P.Watson, 38(560-7-6-0 Supervisor. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1731 Régie de l'électricité et du gaz Electricity and Gas Board Gaz Métropolitain, inc.Avis public est donné par les présentes que « Gaz Métropolitain, inc.» a demandé à la Régie de l'Électricité et du Gaz d'autoriser l'émission et la mise en circulation au pair et la livraison par « Gaz Métropolitain, inc.» à Northern and Central Gas Corporation Limited de §15,000,000 d'obligations (debentures), Série A (non garanties), portant intérêt au taux dc 9J^% par année, échéant le 2 juillet 1991 et de $15,000,000 d'obligations (debentures), Série B (non garanties), portant intérêt au taux dc 9 5/8% par année, échéant le 15 janvier 1991, en remboursement de prêts dus à Northern and Central Gas Corporation Limited pour un montant équivalent.Toute personne désirant obtenir une copie de la demande ou ayant des représentations à faire au sujet de ladite demande devra s'adresser à la Régie de l'Électricité et du Gaz, 2100, rue Drummond, Montréal 107, Québec, dans les 15 jours de la date de publication des présentes.Montréal, ce 5e jour tic février 1971.Gaz Métropolitain, inc., Le secrétaire, 38711-0 Camille Antaki.Gaz Métropolitain, inc.Public notice is hereby given that application has been made to the Electricity and Gas Board by \"Gaz Métropolitain, inc.\" for authorization to issue, put in Central Gas Corporation Limited $15,000,000 Debentures, Series \"A\" (unsecured), bearing interest at the rate of 9J^% per annum, maturing on July 2, 1991, and $15,000,000 Debentures, Scries \"B\" (unsecured), bearing interest at the rate of 9 5/8% per annum, maturing January 15, 1991, in payment of loans due to Northern and Central Gas Corporation Limited in like amounts.Any person desiring to obtain a copy of the application or desiring to make representations in respect thereof should communicate with the Electricity and Gas Board, 2100 Drummond Street, Montreal 107, Québec, within 15 days of the publication of this notice.Montreal, this 5th day of February 1971.Gaz Métropolitain, inc., Camille Antaki, 3871 l-o Secretary.Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for Ville dc Chandler Comté tie Gaspé-Sud Avis publie est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné J.-A.Arsenault, secrétaire-trésorier.Hôtel tie ville, 35, rue Commerciale Ouest, Case postale 459, Chandler, comté tie Gaspé-Sud, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi: le 3 mars 1971, pour l'achat de $182,000 d'obligations tie la ville tie Chandler, comté de Gaspé-Sud, tlatées tlu 15 mars 1971 et remboursables par série tlu 15 mars 1972 au 15 mars 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non intérieur à 7J^%, ni supérieur à SJ/£%, payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre tie chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 mars 1971.Tableau d'amortissement \u2014 $182,000 \u2014 20 ans Année Capital 15 mars 1972.$ 4,000 15 mars 1973 .4,500 15 mars 1974 .5,000 15 mars 1975.5,000 15 mars 1976.5,500 Town of Chandler ( 'ounty of Gaspé-South Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.-A.Arsenault, Secretary-Treasurer, Town Hall, 35 Commercial Street West, P.O.Box 459, Chandler, county of Gaspé-South.P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Wednesday, March 3, 1971, for the purchase of an issue of $182,000 of bonds for the town of Chandler, county of Gaspé-South, dated March 15, 1971, and redeemable serially from March 15, 1972 to March 15, 1991 inclusively, at a rate not less than 7M%' nor more than 8J^%, payable semi-annually on March 15 and September 15 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from March 15, 1971.Table of redemption \u2014 $182,000 \u2014 20 years Year Capital March 15, 1972.% 4,000 March 15, 1973.4,500 March 15, 1974 .5,000 March 15, 1975.5.000 March 15, 1976.5,500 1732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103e année, n' 7 15 mars 1977.$ 6,000 15 mars 1978.6,500 15 mars 1979.7,000 15 mars 1980 .7,500 15 mars 1981.8,000 15 mars 1982 .8,500 15 mars 1983.9,500 15 mars 1984.10,000 15 mars 1985.11,000 15 mars 1986.:.11,500 15 mars 1987.12,500 15 mars 1988.13,500 15 mars 1989.14,500 15 mars 1990.15,500 15 mars 1991.16,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 ù 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à SI (i,500 et si supérieur à ce dernier montant, cet excécent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 mars 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Chandler.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachctablcs par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $16,500 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement suivant: V-93 \u2014 $182,000 \u2014 aqueduc, égouts, pavage.March 15.1977.S 6.000 March 15, 1978 .6,500 March 15, 1979.7,000 March 15, 1980 .7,500 March 15, 1981.8,000 March 15, 1982 .8.500 March 15, 1983.9,500 March 15, 1984.10,000 March 15, 1985.11.000 March 15, 1986.11,500 March 15, 1987.12,500 March 15, 1988.13,500 March 15, 1989.14,500 March 15, 1990.15,500 March 15, 1991.16,500 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered : 1.One to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.One to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fiftccnt year.3.One to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One to 10-ycar serial bonds with the balance carried forward to ten years for one part and as 20-year fixed-term bonds for the other part.However, for the latter terms and conditions, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $16,500 and if higher than this latter amount, this surplus must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the tabic of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of March 15, 1991.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Chandler.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation, save if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount higher than $16,500, and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, on March 15, of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of maturities appearing in the present notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds shall be issued pursuant to the following by-law: V-93 \u2014 $182,000 \u2014 aqueduct, sewers, paving. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1733 Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mercredi, le 3 mars 1971 à 8 heures du soir, Hôtel de ville, 35, rue Commerciale Ouest, case postale 459, Chandler, comté de Gaspé-Sud, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haure ni aucune des soumissions.Chandler (Comté de Gaspé-Sud), ce 4 février 1971.Le secrétaire-trésorier, J.-A.Arsenault.Hôtel de ville, 35, rue Commerciale Ouest, Case postale 459, Chandler, Comté de Gaspé-Sud, P.Q.Téléphone: 689-2221, code 418.38664-o The tenders will be opened and considered at a meeting of the countil to be held on Wednesday, March 3, 1971, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 35 Commercial Street M'est, P.O.Box 459, Chandler, county of Gaspé-South, P.Q.The council do not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Chandler (County of Gaspé-South), February 4, 1971.J.-A.Arsenault;, Secretary-Treasurer.Town Hall, 35 Commercial Street West, P.O.Box 459, Chandler, County of Gaspé-South, P.Q.Telephone: 689-2221, code 418.38664 Municipalité de St-Donat Comté de Montcalm Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jules Saint-Georges, secrétaire-trésorier.Hôtel dc Ville, 475, rue Desrochers, Saint-Donat, comté de Montcalm, P.Q., jusqu'à 8 heures 30 du soir, mardi, le 2 mars 1971, pour l'achat de $107,000 d'obligations de la municipalité de Saint-Donat, comté dc Montcalm, datées du 15 mars 1971 et remboursables par série du 15 mars 1972 au 15 mars 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7J4%, ni supérieur à 8J4%, payable semi-annuellcment les 15 mars et 15 septembre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré aux tableaux «l'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 mars 1971.Tableau d'amortissement \u2014 S107,000 \u2014 S0 ans Année Capital 15 mars 1972.S 1,500 15 mars 1973.1,500 15 mars 1974.2,000 15 mars 1975.2,000 15 mars 1976.2,500 15 mars 1977.3,000 15 mars 1978.3,000 15 mars 1979.4,000 15 mars 1980.4,000 15 mars 1981.4,000 15 mars 1982.2,500 15 mars 1983.2,500 15 mars 1984.3,000 15 mars 1985.3,500 15 mars 1986.3,500 15 mars 1987.4,000 15 mars 1988.4,500 15 mars 1989.4,500 15 mars 1990.5,500 15 mars 1991.46,000 Municipality of St-Donat County of Montcalm Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Jules Saint-Georges, Secretary-Treasurer, Town Hall, 475 Desrochers Street, Saint-Donat, county of Montcalm, P.Q., until 8:30 o'clock p.m., on Tuesday, March 2, 1971, for the purchase of an issue of $107,000 of bonds for the municipality of Saint-Donat, county of Montcalm, dated March 15, 1971 and redeemable serially from March 15, 1972 to March 15, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 7]/^%> nor more than $14%> payable semi-annually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different, rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from March 15, 1971.Table of redemption \u2014 S107,000 \u2014 20 years Year Capital March 15, 1972.$ 1,500 March 15, 1973.1,500 March 15, 1974.2,000 March 15, 1975 .2,000 March 15, 1976 .2,500 March 15, 1977.3,000 March 15, 1978.3,000 March 15, 1979 .4,000 March 15, 1980.4,000 March 15, 1981.4,000 March 15, 1982.2,500.March 15, 1983.2,500 March 15, 1984.3,000 March 15, 1985.3,500 March 15, 1986 .3,500 March 15, 1987 .4,000 March 15, 1988.4,500 March 15, 1989 .4,500 March 15, 1990.5,500 March 15, 1991.46,000 1734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1971, 108' année, n\" 7 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 ù 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie cl l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 50,000 et si supérieur ù ce dernier montunt, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 mars 2001 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul tics termes suuf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 mars 1991 nu montant dc S46.000 comprend un solde dc 840,500 renouvelable pour une période additionnelle dc 10 ans et échéant comme suit: Année Capital 15 mars 1992.82,500 15 mars 1993.3,000 15 mars 1994.3,000 15 mars 1995.3,500 15 mars 1996.3,500 15 mars 1997 .4,000 15 mars 1998 .4,500 15 mars 1999 .5,000 15 mars 2000 .5,500 15 mars 2001.6,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Saint-Donat.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à S46.000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Moreover, only the following terms and conditions shall be considered: 1.One to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.One to 15-ycar serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.One to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-ycar fixed-term bonds.However, for the latter terms and conditions, the 20-ycar fixed-term bonds shall not be for an amount less than 86,000 and if higher than this latter amount, this surplus must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the tables of redemption appearing in this notice, and starling with the last years of maturities excluding the maturity of March 15, 2001 of the renewable part hereinafter mentioned.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only and shall comprise one only of the terms save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The maturity of March 15, 1991 in the amount of S46.000 includes a balance of 840,500 renewable for an additional 10-year period and maturing as follows: Year Capital March 15, 1992.82,500 March 15, 1993.3,000 March 15, 1994.3,000 March 15, 1995.3,500 March 15, 1996.3,500 March 15, 1997.4,000 March 15, 1998 .4,500 March 15, 1999.5,000 March 15, 2000 .5,500 March 15, 2001.6,000 The succcssfid tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Saint-Donat.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation save if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount higher than 846,000, and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, on March 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue in accordance with the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the (fate of their delivery is included or not in the price of the tenders. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1735 Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 91 \u2014 §63,000 \u2014 aqueduc, égouts; 93 \u2014 $25,000 \u2014 aqueduc, égouts; 94 \u2014 $3,000 \u2014 aqueduc, égouts; 97 \u2014 $16,000 \u2014 achat de mobilier et équipement dc bureau.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le 2 mars 1971, à 8 heures 30 du soir.Hôtel dc Ville, 475, rue Dcsro-chers, Saint-Donat, comté dc Montcalm, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Donat (Comté dc Montcalm), ce 2 février 1971.Le secrétaire-trésorier, Jules Saint-Georges.Hotel de Ville, 475, rue Dcsrochers, Saint-Donat (Montcalm), P.Q.Téléphone: 424-2383, code 819.38665-o The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 91 \u2014 $63,000 \u2014 aqueduct, sewers; 93 \u2014 $25,000 \u2014 uqucduct, sewers; 94 \u2014 $3,000 \u2014 aqueduct, sewers; 97 \u2014 $16,000 \u2014¦ purchasing of office furniture and equipment.The lenders will be o|>cncd and considered at meeting of the council to be held on Tuesday, March 2, 1971, at 8:30 p.m., at the Town Hall, 475 Desrochers Street, Saint-Donat, county of Montcalm, P.Q.The council does not bind itself lo acccpl the highest or any of the tenders.Saint-Donal (County of Montcalm), February 2, 1971.Jules Saint-Georges, Secretary-Treasurer.Town Hall, 475 Desrochers Street, Saint-Donat (Montcalm), P.Q.Telephone : 424-2383, code 819.38665 Ville de Don vil le Comté dc Saint-Hyacinthe Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jacques Archambault, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 610, rue Chapleau.Douville, comté dc Sainl-Hyacinthe, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 2 mars 1971, pour l'achat de S96.500 d'obligations de la ville de Douville, comté dc Saint-Hyacinthe, datées du 15 mars 1971 et remboursables pur série du 15 mars 1972 au 15 mars 1991 inclusivement, avec intérêt à un luux non inférieur à 7J4%.ni supérieur à 8}^%, payable scmi-annuellement les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis ù chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 mars 1971.Tableau d'amortissement \u2014 $96,600 \u2014 20 ans Année Capital 15 mars 1972.81,500 15 mars 1973.2,000 15 mars 1974.2,000 15 mars 1975 .2,500 15 mars 1976 .2,500 15 mars 1977.2,500 15 mars 1978.3,000 15 mars 1979.3,500 15 mars 1980.3,500 15 mars 1981.4,000 15 mars 1982 .4,500 15 mars 1983.5,000 15 mars 1984.5,500 15 mars 1985.6,000 15 mars 1986 .6,500 15 mars 1987.7,000 15 mars 1988.7,500 Town of Douville County of Saint-Hyacinthe Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Jacques Archambault, Secretary-Treasurer, Town Hall, 610 Chapleau Street, Douville, county of Saint-Hyacinthe, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, March 2, 1971, for the purchase of an issue of 896,500 of bonds for the town of Douville, county of Saint-Hyacinthe, dated March 15, 1971 and redeemable serially from March 15, 1972 to March 15, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 7}4%> nor mere than 8J^%, payable semi-annually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from March 15, 1971.Table of redemption \u2014 $96,600 \u2014 20 years Year Capital March 15, 1972.S1.500 March 15, 1973 .2,000 March 15, 1974.2,000 March 15, 1975.2,500 March 15, 1976.2,500 March 15, 1977.2,500 March 15, 1978 .3,000 March 15, 1979.3,500 March 15, 1980.3,500 March 15, 1981.4,000 March 15, 1982 .4,500 March 15, 1983 .5,000 March 15, 1984 .5,500 March 15, 1985.6,000 March 15, 1986.6,500 March 15, 1987 .7,000 March 15, 1988 .7.500 1736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103e année, n° 7 15 mars 1989.$ 8,500 15 mars 1990.9,000 15 mars 1991.10,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 310,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 mars 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Saint-Hyacinthe.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec dc la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachctablcs par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à S10.000 et seul cet excédent sera rachctable par anticipation, au pair, le 15 mars dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans lé présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement suivant: 125 \u2014 $96,500 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le 2 mars 1971, à 8 heures du soir.Hôtel dc Ville, 610, rue Cha-pleau, Douville, comté de Saint-Hyacinthe.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Douville (Comté «le Saint-Hyacinthe), ce 4 février 1971.Le secrétaire-trésorier, Jacques Archambault.Hôtel de Ville, 610, rue Chaplcau, Douville (Comté de Saint-Hyacinthe), P.Q.Téléphone : 774-4655, code 514.38694-o March 15, 1989.$ 8,500 March 15, 1990.9,000 March 15, 1991.10,000 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: 1.One to 10-year serial bonds with the balance-carried forward to the tenth year.2.One to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.One to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One to 10-year serial bonds with the balance carried forward to 10-year for one part and as 20-year fixed-term for the other part.However, for the latter terms and conditions, the 20-ycar fixed-term bonds shall not be for an amount less than $10,000 and if higher than the latter amount, the said surplus must comprise only one or several whole annual amortizations, taking into account the tabic of redemption apjK-aring in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of March 15, 1991.However, lenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall include one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Saint-Hyacinthe.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation save if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount higher than $10,000 and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, on March 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue in accordance with the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tenders.The said bonds will be issued pursuant to the following by-law: 125 \u2014 $96,500 \u2014 aqueduct, sewers.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, March 2, 1971, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 610 Chapleau Street, Douville, county of Saint-Hyacinthc.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Douville (County of Saint-Hyacinthe), February 4, 1971.Jacques Archambault, Secretary-Treasurer.Town Hall, 610 Chapleau Street, Douville (County of Saint-Hyacinthe), P.Q.Telephone : 774-4655, code 514.38694 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 1737 Ville de Port-Alfred Town of Port-Alfred Comté «lu Dubuc County of Dubuc Avis public est par les présentes donne que «les soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Willie Tremblay, greffier, Hôtel de ville, 491, 2e Rue, Port-Aldrcd, comté de Dubuc, P.Q., jusqu'à 7.30 heures «lu soir, lundi, le 1er mars 1971, pour l'achat de 8200,000 d'obligations dc la ville dc Port-Alfred, comté dc Dubuc, datées «lu 15 mars 1971 et remboursables par série du 15 mars 1972 au 15 mars 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7J-£%, ni supérieure à 8J^%, payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre «le chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent «loit couvrir un ou des amortissements, annuels entiers, tels que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 mars 1971.Publie notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Willie Tremblay, clerk, City Hall, 491, 2nd Street, Port-Alfred, county of Dubuc, P.Q., up to 7:30 p.m., Monday, March 1, 1971; for the purchase of 8200,000 worth of bonds for the town of Port-Alfred, county of Dubuc, dated March 15, 1971, and redeemable serially from March 15, 1972 to March 15, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 7J^%, nor more than 8%%> payable semiannually on March 15 and September 15, each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each tliffercnt rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from March 15, 1971.Tableau d'amortissement \u2014 $200,000 \u2014 20 ans Année Capital 15 mars 1972.S 3.500 15 mars 1973.4,000 15 mars 1974.4,500 \u2022 15 mars 1975.5,000 15 murs 1976.5,500 15 mars 1977 .6.000 15 mars 1978 .6,500 15 mars 1979 .7,000 15 mars 1980.7,500 15 mars 1981.8,500 15 mars 1982.9,000 15 mars 1983.10,000 15 mars 1984.11,000 15 mars 1985.12.000 15 mars 1986.13.000 15 mars 1987.14,500 15 mars 1988.15,500 15 mars 1989.17,500 15 mars 1990.19,000 15 mars 1991.20,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporte à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 ù 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 A 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $20,500 et si supérieur ù ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le Table of Redemption \u2014 $200,000 \u2014 20 years Year Capital March 15, 1972.$ 3,500 March 15, 1973 .4,000 March 15, 1974.4,500 March 15, 1975.5,000 March 15, 1976.5,500 March 15, 1977 .6,000 March 15, 1978.6,500 March 15, 1979.7,000 March 15,1980.7,500 March 15, 1981.8,500 March 15, 1982 .9,000 March 15, 1983.10,000 March 15, 1984.11,000 March 15, 1985.12,000 March 15,1986.13,000 March 15, 1987.14,500 March 15, 1988.15,500 March 15, 1989.17,500 March 15, 1990.19,000 March 15, 1991.20,500 Moreover, only the following terms and conditions shall be considered.1.One to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.One to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.One to 10-year serial bonds with the balance carried forward as 20-year fixc«l-term bonds.4.One to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year for the one part and to the twentieth year for the other part.However, for the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $20,500, and if greater than the latter amount, the said part must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the tab le of redemption appearing in this notice, and starting with 1738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 108' année, n° 7 présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 mars 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Port-Alfred.Le capital cl les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 820,500 et seul cet excédent sera rachclablc par anticipation, au pair, le 15 mars dc chaque année, pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conforment au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt cl devra spécifier si le prix olfert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement suivant: 382 \u2014 8200.000 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 1er mars 1971, ù 7.30 heures du soir.Hôtel de ville.491.2e Rue, Port-Alfred, comté dc Dubuc, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Port-Alfred (Comté dc Dubuc), ce 2 février 1971.Le greffier, Willie Tremblay.Hôtel dc ville, 491, 2e Rue, Port-Alfred, comté de Dubuc.P.Q.Téléphone: 544-3344, code 418.38695-o Ville de St-Jean Comté de Saint-Jean Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par la soussignée Mlle Charlotte Morais, greffier, Hôtel dc Ville, 188, rue Jacques-Cartier, Saint-Jean, comté de Saint-Jean, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 1er mars 1971, pour l'achat dc 81,772,500 d'obligations de la ville de Saint-Jean, comté de Saint-Jean, datées du 1er mars 1971 et femboursables par série du 1er mars 1972 au 1er mars 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%%, ni supérieur à 8J n> supérieur à 834%, payable semi-annuel lenient les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'im taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 mars 1971.Tableau d'amortissement- \u2014 $408,000 \u2014 20 ans Année Capital 15 mars 1972.S 3,000 15 mars 1973 .3,000 15 mars 1974.3,500 15 mars 1975 .3,500 15 mars 1976.4,500 15 mars 1977 .4,500 15 mars 1978 .5,000 15 mars 1979.5,500 15 mars 1980.6,000 15 mars 1981.6,500 15 mars 1982.6,500 15 mars 1983.7,500 15 mars 1984 .8,000 15 mars 1985.8,500 15 mars 1986.10,000 15 mars 1987.10,000 15 mars 1988.11,500 15 mars 1989.13,000 15 mars 1990.13,500 15 mars 1991.269,500 The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 194 \u2014 884,500 \u2014 loan renewal; 198 \u2014 819,000 \u2014 loan renewal; 269 \u2014 8115,000 \u2014 aqueduct and sewers.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Thursday, March 4, 1971, at 8:00 o'clock p.m.Town Hall, 25 St-Jacques-Strcct West, Princeville, county of Arthabaska, P.Q.The council docs not.bind itself to accept the highest or any of the tenders.Princeville (County of Arthabaska), February 4, 1971.Fernand Poiré, Secretary-Treasurer.Town Hall, 25 St-Jacques Street West, Princeville (Arthabaska), P.Q.Telephone: 364-5179, code 819.38735 Town of Windsor County of Richmond Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Joseph Plante, Town Clerk, Town Hall, 22 Saint-Georges Street, Windsor, county of Richmond, P.Q., until 7:30 o'clock p.m., Thursday, March 4, 1971, for the purchase of an issue of 8403,000 of bonds for the town of Windsor, county of Richmond, dated March 15, 1971 and redeemable serially from March 15, 1972 to March 15, 1991 inclusively, with interest at a rale not less than 7J-2%, nor more than 834%, payable semi-annually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from March 15, 1971.Table of redemption \u2014 $403,000 \u2014 20 years Year Capital March 15, 1972.S 3,000 March 15, 1973 .3,000 March 15, 1974.3,500 March 15, 1975 .3,500 March 15, 1976.4,500 March 15, 1977.4,500 March 15, 1978 .5,000 March 15, 1979.5,500 March 15, 1980.6,000 March 15, 1981.6,500 March 15, 1982.6,500 March 15, 1983.7,500 March 15, 1984.8,000 March 15, 1985.8,500 March 15, 1986.10,000 March 15, 1987.10,000 March 15, 1988.11,500 March 15, 1989.13,000 March 15, 1990.13,500 March 15, 1991.269,500 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.108, No.7 1747 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 828,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 mars 2011 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 mars 1991 au montant de 8269,500 Comprend un solde de 8255,000 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans, et échéant comme suit: Année Capital 15 mars 1992.S 5,000 15 mars 1993.5,000 15 mars 1994.6,000 15 mars 1995.6,000 15 mars 1996.7,000 15 mars 1997 .8,000 15 mars 1998.8,000 15 mars 1999.9,000 15 mars 2000.10,000 15 mars 2001.11,000 15 mars 2002.12,000 15 mars 2003.13,000 15 mars 2004.14,000 15 mars 2005.15,000 15 mars 2006.16,000 15 mars 2007.18,000 15 mars 2008.20,000 15 mars 2009.21,000 15 mars 2010.23,000 15 mars 2011.28,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Windsor.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie- à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8269,500 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: 1.One to 10-ycar serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.One to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.One to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4._ One to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten year for one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the latter case the 20-ycar fixed-term bonds shall not be for an amount less than §28,000 and if higher than the latter amount, this surplus must comprise only one or severul whole annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of March 15, 2011, of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders shall be sent for one of the methods of issue only, and shall comprise one only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The March 15, 1991 maturity in the amount of S269.500 includes a balance of 8255,000 renewable for an additional 20-year period and maturing as follows: Year Capital March 15, 1992.S 5,000 March 15, 1993.5,000 March 15, 1994.6,000 March 15,1995.6,000 March 15, 1996.7,000 March 15, 1997.8,000 March 15, 1998.8,000 March 15, 1999.9,000 March 15, 2000.10,000 March 15, 2001.11,000 March 15, 2002.¦.12,000 March 15, 2003.13,000 March 15, 2004.14,000 March 15, 2005.15,000 March 15, 2006.16,000 March 15, 2007.18,000 March 15, 2008.20,000 March 15, 2009.21,000 March 15, 2010.23,000 March 15, 2011.28,000 ' The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Windsor.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation save if they arc issued in part as 20-year fixed-term bonds for an amount higher than 8269,500 and this surplus alone shall be redeemable by anticipation, 1748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1971, 108' année, n° 7 pair, le 15 mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 377 tel que modifié \u2014 S300.000 \u2014 usine de filtration; 378 \u2014 $103,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, éclairage, etc.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, jeudi, le 4 mars 1971, à 7.30 heures du soir, Hôtel de Ville, 22, rue Saint-Georges, Windsor, comté de Richmond, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Windsor (Comté de Richmond), ce 8 février 1971.Le greffier, Joseph Plante.Hôtel de Ville, 22, rue Saint-Georges, Windsor (Comté de Richmond), P.Q.Téléphone: 845-2252, code 819.38736-0 ViHe dc Pierrefonds Comté de Robert Baldwin Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Gabriel Legault, greffier, Hôtel de Ville, 11072 ouest.Boulevard Gouin, Pierrefonds, comté de Robert Baldwin, P.Q., jusqu'à 12 heures (midi), lundi, le 1er mars 1971, pour l'achat dc $1,600,000 d'obligations de la ville de Pierrefonds, comté de Robert Baldwin, datées du 15 mars 1971 et remboursables par série du 15 mars 1972 au 15 mars 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7J-£%, ni supérieur à 8J-^%, payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre de chaque anuée.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 mars 1971.Tableau d'amortissement \u2014 SI,600,000 \u2014 S0 ans Année Capital 15 mars 1972.$ 21,000 15 mars 1973.'23,000 15 mars 1974 .25,000 15 mars 1975.28,000 15 mars 1976.31,000 15 mars 1977 .34,000 15 mars 1978.37,000 15 mars 1979 .41,000 15 mars 1980.'.45,000 15 mars 1981.48,000 at par, on March 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accurcd on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tenders.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 377 as modified \u2014 $300,000 \u2014 filtration unit; 378 \u2014 $103,000 aqueduct, sewers, roads, lighting, etc.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Thursday, March 4, 1971, at 7:30 o'clock p.m., Town Hall, 22 Saint-Georges Street, Windsor, county of Richmond, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Windsor (County of Richmond), February 8, 1971.Joseph Plante, Town Clerk.Town Hall, 22 Saint-Georges Street, Windsor (County of Richmond), P.Q.Telephone: 845-2252, code 819.38736 City of Pierrefonds County of Robert Baldwin Public notice is hereby given that tenders sealed and bearing the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Gabriel Legault, Clerk, City Hall, 11072 Gouin Boulevard West, Pierrefonds, county of Robert Baldwin, P.Q., until 12:00 o'clock (noon), on Monday, March 1, 1971, for the purchase of an issue of $1,600,000 of bonds for the city of Pierrefonds, county of Robert Baldwin, dated March 15, 1971 and redeemable serially from March 15, 1972 to March 15, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 7J^%, nor more than 8J4%.payable semi-annually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from March 15, 1971.Table of redemption \u2014 SI,600,000 \u2014 SO years Year Capital March 15, 1972.S 21,000 March 15, 1973.'.23,000 March 15,1974.25,000 March 15,1975.28,000 March 15,1976.31,000 March 15,1977.34,000 March 15,1978.37,000 March 15,1979.41,000 March 15,1980 .45,000 March 15,1981.48,000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1749 15 mars 1982.$ 50,000 15 mars 1983.54,000 15 mars 1984.60,000 15 mars 1985.65,000 15 mars 1986.71,000 15 mars 1987 .77,000 15 mars 1988.86,000 15 mars 1989.93,000 15 mars 1990.:.102,000 15 mars 1991.609,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: , 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $72,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 mars 2001 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et'ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 mars 1991 au montant de $609,000 comprend un solde dc $496,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Année Capital 15 mars 1992.$ 32,000 15 mars 1993.35,000 15 mars 1994.38,000 15 mars 1995.42,000 15 mars 1996.46,000 15 mars 1997.50,000 15 mars 1998.55,000 15 mars 1999.60,000 15 mars 2000.66,000 15 mars 2001.72,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé payable au pair à Pierrefonds.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec dc la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme March 15, 1982.$ 50,000 March 15, 1983.54,000 March 15, 1984.60,000 March 15, 1985.65,000 March 15, 1986.71,000 March 15, 1987.77,000 March 15, 1988.86,000 March 15, 1989.93,000 March 15, 1990.102,000 March 15, 1991.609,000 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: 1.One to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.One to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.One to.10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One to 10-ycar serial bonds with the balance carried forward to ten years for one part, and as 20-year fixed-term bonds for the other part.However, in the latter case, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $72,000 and if higher than the latter amount, this surplus must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the tables of maturity appearing in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of March 15, 2001 of the renewable part hereafter indicated.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The maturity of March 15, 1991 in the amount of $609,000 includes a balance of $496,000 renewable for an additional 10-year period, and maturing as follows: Year Capital March 15, 1992.$ 32,000 March 15, 1993.35,000 March 15,1994.38,000 March 15, 1995.42,000 March 15, 1996.46,000 March 15,1997 .50,000 March 15,1998.55,000 March 15,1999.60,000 March 15, 2000 .66,000 March 15, 2001.72,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Pierrefonds.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation save if they are issued in part as 20-year fixed- 1750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1971, 103' année, n° 7 fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8609,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 mars de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 532 \u2014 829,000 \u2014 aqueduc et égouts; 539 \u2014 S160.000 \u2014 voirie, aqueduc et égouts; 540 \u2014 821,000 \u2014 voirie; 560 \u2014 8125,000 \u2014 voirie, aqueduc et égouts; 564 \u2014 8775,000 \u2014 aréna; 566 \u2014 S65.000 \u2014 voirie; 568 \u2014 842,000 \u2014 voirie; 569 \u2014 8100,000 \u2014 voirie, aqueduc et égouts; 578 \u2014 8100,000 \u2014 électricité; 582 \u2014 8183,000 \u2014 voirie.Les soumissions seront ouvertes publiquement en comité à 12 heures (midi), lundi, le 1er mars 1971, et elles seront prises en considération à une séance du conseil qui sera tenue à 8 heures du soir, le même jour, à l'Hôtel de Ville, 11072 ouest, Boulevard Gouin, Pierrefonds, comté de Robert Baldwin, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Pierrefonds (Comté de Robert Baldwin), ce 8 février 1971.Le greffier, Gabriel Lecault.Hôtel de Ville, 11072 ouest, Boulevard Gouin, Pierrefonds, (Robert Baldwin), P.Q.Téléphone : 684-4480, code 514.38710-o term bonds for an amount higher than 8609,000 and only this surplus shall be redeemable by anticipation, at par, on March 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and shall specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tenders.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 532 \u2014 829,000 \u2014 aqueduct and sewers; 539 \u2014 $160,000 \u2014 roads, aqueduct and sewers; 540 \u2014 821,000 \u2014 roads; 560 \u2014 8125,000 \u2014 roads, aqueduct and sewers; 564 \u2014 $775,000 \u2014 arena; 566 \u2014 S65.000 \u2014 roads; 568 \u2014 842,000 \u2014 roads; 569 \u2014 $100,000 \u2014 roads, aqueduct and sewers; 578 \u2014 $100,000 \u2014 electricity; 582 \u2014 $183,000 \u2014 roads.The tenders will be opened publicly in a committee at 12:00 o'clock (noon), on Monday, March 1, 1971, and shall be taken into consideration at a meeting of the council to be held at 8:00 o'clock, p.m., on the same day, at the City Hall, 11072 Gouin Boulevard West, Pierrefonds, county of Robert Baldwin, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Pierrefonds (County of Robert Baldwin), February 8,1971.Gabriel Leqault, Clerk.City Hall, 11072 Gouin Boulevard West, Pierrefonds, (Robert Baldwin), P.Q.Telephone: 684-4480, code 514.38710 Société d'habitation du Québec Office municipal d'habitation de Rivicrc-Blcue Municipal Housing Bureau of Rivière-Bleue Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 dc la Loi de la Société d'habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du 15e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans but lucratif : Maurice Castonguay, administrateur, Rivière-Bleue Fernand (.'assistai, administrateur, Rivière-Bleue Jean-Paul Gagné, douanier, Rivière-Bleue Charlemagne Gagnon, maître dc poste, Rivière-Bleue pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans les limites du territoire de Rivière-Bleue, district judiciaire de Kamouraska.Le secrétaire, 38662-0 Richard Valois.Québec Housing Corporation Office municipal d'habitation dc Rivicrc-Bleuc Municipal Housing Bureau of Rivicrc-Blcue Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the 15th, day of January 1970, incorporating as a nonprofit corporation: Maurice Castonguay, director, Rivière-Bleue Fernand Cassistat, director, Rivière-Bleue Jean-Paul Gagné, customs agent, Rivière-Bleue Charlemagne Gagnon, post master, Rivière-Bleue for the following purposes: To acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of Rivière-Bleue, judicial district of Kamouraska.Richard Valois, 38662-0 Secretary. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 Oilier municipal d'habitation de Montmagny M«ui l m -.mnj Municipal Housing Bureau Avis est donné qu'en vertu dc l'urticle 55 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le licutcnunt-gouvcrncur a délivré, sous le grand sceau dc la province, des lettres patentes, en date du 15c jour dc janvier 1970, constituant en corporation sans but lucratif: Me Réjean Boulet, avocat, 125, rue St-Thomus, Montmagny Mme Gabricllc-R.Dcnault, employée civile, 153, rue St-Ignace, Monlmagny Jean-Jacques Huinbcrt-Droz, technicien, 312, Boulevard Taché Est, Montmagny Bernard Landry, ingénieur, 237, Des Écorcs, Montmagny Valérien Lachance, administrateur, 75, Avenue dc la Gare, Montmagny Roger Dallaire, industriel, 90, Boulevard Taché Ouest, Montmagny Rolland Nicole, cultivateur, Route Rurale No 1, Montmagny pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation ik loyer modique pour personnes ù faible revenu.Le siège social est situé dans les limites du territoire de Montmagny, district judiciaire de Montmagny.Le secrétaire, 38662-o Richard Valois.Office municipal d'habitation de Sillery Municipal Housing Bureau of Sillery Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du 10e jour dc février 1970, constituant en corporation sans but lucratif: Monsieur Jules Bcaulicu, maire, industriel Monsieur Georges Gravel, greffier, ingénieur civil et arpenteur-géomètre pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social dc la corporation est situé dans les limites du territoire dc Sillcry, district judiciaire de Québec.Le secrétaire, 38662-0 Richard Valois.Office municipal d'habitation de Terrebonne Municipal Housing Bureau of Terrebonne Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, \u2022 en date du 15c jour de janvier 1970, constituant en corporation sans but lucratif: 1751 OU in- municipal d'habitation dc Monlmagny Montmagny Municipal Housing Bureau Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the 15th day of January, 1970, incorporating as a non-profit corporation: Me Réjean Boulet, lawyer, 125, St-Thomus, Montmagny Mrs.Gabricllc-R.Dcnault, civil servant, 153, St-Ignace, Montmagny Jean-Jacques Humbcrt-Droz, technician, 312, Taché Est, Montmagny Bernard Landry, engineer, 237, Des Écorcs, Montmagny Valérien Lachance, director, 75, de la Gare, Montmagny Roger Dallaire, industrialist, 90, Taché Ouest, Montmagny Rolland Nicole, farmer, R.R.No.1, Montmagny for the following purposes: To acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of Montmagny, judicial district of Montmagny.Richard Valois, 38662-o Secretary.Office municipal d'habitation de Sillery Municipal Housing Bureau of Sillcry Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the 10th day of February, 1970, incorporating as a non-profit corporation: Mr.Jules Beaulieu, mayor, industrialist Mr.Georges Gravel, clerk, civil engineer and surveyor for the following purposes: To acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of Sillcry, judicial district of Québec.Richard Valois, 38662-o Secretary.Office municipal d'habitation de Terrebonne Municipal Housing Bureau of Terrebonne Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date the 15th day of January 1970, incorporating as a non-profit corporation: 1752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1971, 103- année, n\" 7 Claude Paquette, avocat, 845, Place Eyniard, Terre-bonne Antonio Daunais, journalier, 1025, rue St-Paul, Terrebonne Lucien Bcaulieu, professeur, 741, rue St-Paul, Terrebonne Jean Vézina, assistanl-secrétnirc-trésorier, 645, rue St-Louis, App.2, Terrebonne Jean-Louis Paquin, directeur des services, 696, rue Paul VI, Terrebounc pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social dc la corporation est situé duns les limites du territoire dc la ville dc Terrebonne, distict judiciaire de Terrebonne.Le secrétaire, 38662-o Richard Valois.Office municipal d'habitation de la ville dc Bagotvillc Municipal Housing Bureau of the town of Bagotvillc Avis est donné qu'en vertu dc Particle 55 de la Loi île la Société d'habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du 15e jour de février 1970, constituant en corporation sans but lucratif : Camil Tremblay, machiniste, 120, St-Joseph, Bagotvillc Jean-Jacques Pouliot, gérant dc Caisse Populaire, 139, rue de la Baie, Bagotville Jean-Yves Gagnon, employé de bureau, 115, rue de la Baie, Bagotville Antonio Girard, concierge, 231, St-Louis, Bagotvillc Henri-Paul Tremblay, employé de bureau, 1141, Bagot, Bagotville pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans les limites du territoire de Bagotville, district judiciaire de Chicoutimi.Le secrétaire, 38662-o .Richard Valois.Office municipal d'habitation de la ville de Bécancour Municipal Housing Bureau of the town of Bécancour Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi dc la Société d^habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du 23e jour de février 1970, constituant en corporation sans but lucratif : L.-Gaston Gaudet, directeur de funérailles, maire dc la ville, ville de Bécancour Claude Paquette, lawyer, 845, Place Eymard, Terrebonne Antonio Daunais, laborer, 1025, St-Paul, Terrebonne Lucien Beaulicu, teacher, 741, St-Paul, Terrebonne Jean Vézinu, ussistant-secretary-treasurer, 645, St-Louis, Apt.2, Terrebonne Jean-Louis Paquin, director of services, 696, Paul VI, Terrebonne for the following purposes: To acquire, to construct and to administer low reniai lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the town of Terrebonne, judicial district of Terrebonne.Richard Valois, 38662-0 Secretary.Office municipal d'habitation de la ville de Bagotvillc Municipal Housing Bureau of the town of Bagotvillc Xotice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province bearing date of the 15th day of February, 1970, incorporating as a non-profit corporation: Camil Tremblay, machinist, 120, St-Joseph, Bagotville Jean-Jacques Pouliot, manager, 139, de la Baic, Bagotville Jean-Yves Gagnon, office clerk, 115, de la Baic, Bagotville Antonio Girard, janitor, 231, St-Louis, Bagotvillc Henri-Paul Tremblay, office clerk, 1141, Bagot, Bagotville for the following purposes: To acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of Bagotvillc, judicial district of Chicoutimi.Richard Valois, 38662-0 Secretary.Office municipal d'habitation dc la ville de Bécancour Municipal Housing Bureau of the town of Bécancour Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the 23rd day of February, 1970, incorporating as a nonprofit corporation : L.-Gaston Gaudet, Funeral Director, mayor, town of Bécancour QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 Yves Beauchesne, trésorier de la ville, ville de Bécancour Me André Villeneuve, notaire, greffier dc la ville, ville dc Bécancour pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour i>ersonnes à faible revenu.Le siège social dc la corporation est situé dans les limites du territoire dc la ville dc Bécancour, district judiciaire de Nicolet.Le secrétaire, 38662-o Richard Valois.Office municipal d'habitation dc Kénogami Municipal Housing Bureau of Kénogami Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi dc la Société d'habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du 3c jour de février 1970, constituant en corporation sans but lucratif : Joachim Demcrs, préposé à l'expédition, 31, Lamarche, Kénogami Simon Dominguc, employé de bureau, 11, boul.des Étudiants, Kénogami Benoit Labbé, dessinateur industriel, 5, St-Joscph, Kénogami .Rosaire Bezeau, contremaître, 125, Racine, Kénogami Raymond Gilbert, ingénieur, 93, Bourassa, Kénogami pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans jes limites du territoire de Kénogami, district judiciaire de Chicoutimi.Le secrétaire, 38662-o Richard Valois.i h I'm i municipal d'habitation de Maniwaki Maniwaki Municipal Housing Bureau Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi dc la Société d|habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du 15e jour dc janvier 1970, constituant en corporation sans but lucratif: Lionel Carie, maire, 279, rue King, Maniwaki Gabriel Lefebvre, surintendant, 305, rue Des Oblats, Maniwaki Léo-Paul Grondin, secrétaire-trésorier, 96, rue Notre-Dame, Maniwaki pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes a faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans les limites du territoire dc Maniwaki, district judiciaire de Labellc.1753 Yves Beauchesnc, treasurer of the town, town of Bécancour Me André Villeneuve, notary, clerk of the town, town of Bécancour for the following purposes: To acquire, to construct and to administer- low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the cor|>oration is within the limits of the territory of the town of Bécancour, judicial district of Nicolet.Richard Valois, 38662-0 Secretary.Office municipal d'habitation de Kénogami Municipal Housing Bureau of Kénogami Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the 3rd day of February, 1970, incorporating as a nonprofit corporation : Joachim Dcmers, dispatcher, 31, Lamarche, Kénogami Simon Domingue, office clerk, 11, des Étudiants, Kénogami Benoit Labbé, industrial designer, 5, St-Joseph, Kénogami Rosaire Bezeau, foreman, 125, Racine, Kénogami Raymond Gilbert, engineer, 93, Bourassa, Kénogami for the following purposes: To acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of Kénogami, judicial district of Chicoutimi.Richard Valois, 38662-0 Secretary.Office municipal d'habitation de Maniwaki Maniwaki Municipal Housing Bureau Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the 15th, day of January, 1970, incorporating as a non-profit corporation: Lionel Carle, mayor, 279, King, Maniwaki Gabriel Lefebvre, superintendant, 386, Des Oblats, Maniwaki Léo-Paul Grondin, secretary-treasurer, 96, Notre-Dame, Maniwaki for the following purposes: To acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of Maniwaki, judicial district of Labelle.Richard Valois, 38662-0 Secretary.Le secrétaire, 38662-0 ' Richard Valois. 1754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 108' année, n° 7 Office municipal d'habitation dc la ville dc Pointe-Gatincau Avis est donné qu'en vertu dc l'article 55 de la Ix>i de la Société d'habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau dc la province, des lettres patentes, en date du deuxième jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans but lucratif : Pierre Lafontainc, gérant, 3, rue Raoul, Pointe-Gatincau, Jean Bourbonnais, pharmacien, 20, boul.Lufortune, Pointe-Gatincau, Elzéar Richard, instituteur, 8, rue St-Jcan-Baptistc, Pointc-Gatineau, Laurcntien Carrière, contremaître, 5, rue Morcau, Pointe-Gatincau, Claude Richard, électricien, 128, rue St-Antoinc, Pointe-Gatincau, pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitations à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social dc la corporation est dans les limites de la ville dc Pointe-Gatincau.Le secrétaire, S.H.Q., 38662-o Richard Valois.Office municipal d'habitation de Victoriaville Municipul Housing Bureau of Victoriaville Avis est donné qu'en vertu île l'article 55 dc la Loi de la Société d'habitation du Québec (1966-1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du dix-huitième jour de décembre 1970, constituant en corporation sans but lucratif : Pierre Lafontainc, gérant, 3, rue Raoul, Pointe-Gatincau, Jean Bourbonnais, pharmacien, 20, boul.Lafortune, Pointe-Gatincau Elzéar Richard, instituteur, 8, rue St-Jean-Baptiste, Pointe-Gatincau, Laurentien Carrière, contremaître, 5, rue Morcau, Pointe-Gatincau, Claude Richard, électricien, 128, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, pour les fins suivantes: Acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitations à loyer modique pour personnes ù faible revenu.Le siège social de la corporation est dans les limites de la ville de Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska.Le secrétaire, S.H.Q., 38662-0 Richard Valois.Office municipal d'habitation de la ville de Pointe-Gatincau Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the second day of December, incorporating as a non-profit corporation: Pierre Lafontainc, manager, 3, Raoul Street, Pointe-Gatincau, Jean Bourbonnais, druggist, 20, Blvd.Lafortune, Pointe-Gatineau, Elzéar Richard, teacher, 8, St-Jcan-Baptistc Street, Pointe-Gatineau, Laurentien Carrière, foreman, 5, Morenu Street, Pointe-Gatineau, Claude Richard, electrician, 128, St-Antoinc Street, Pointe-Gatineau, for the following purposes: To acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the town of Pointe-Gatincau.Richard Valois, 38662-o Secretary, Q.II.C.Office municipul d'hahitulioii de Victoriaville Municipal Housing Bureau of Victoriaville Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the eighteenth day of December 1971, incorporating as a non-profit corporation: Pierre Lafontainc, manager, 3, Raoul Street, Pointe-Gatincau, Jean Bourbonnais, druggist, 20, Blvd.Lafortune, Pointe-Gatineau, Elzéar Richard, teacher, 8, St-Jean-Baptistc Street, Pointe-Gatincau, Laurcntien Carrière, foreman.5, Morcau Street, Pointe-Gatineau, Claude Richard, electrician, 128, St-Antoine Street, Pointe-Gatineau, for the following purposes: To acquire, to construct and to administer law rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the town of Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Richard Valois, 38662-o Secretary, Q.II.C.Ventes par licitation Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T\\AME YVONNE BELLEFEUILLE, No 733-801.\\ ^-^ épouse commune en biens de Mi-v chel Malofy, résidant et domiciliée au numéro 715 dc la rue Sherbrooke dans la cité de La-chine, district de Montréal et ledit MICHEL MALOFY pour assister et autoriser son épouse, demanderesse, vs DAME MARIA PRESSEAU & AL, défendeurs, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Montréal, mis en cause.Sales of Licitation Superior Court \u2014 District of Montreal / \"T)AME YVONNE BELLEFEUILLE, No.733-801X wife common as to property of v Michel Malofy, residing and domiciled at number at number 715 Sherbrooke Street in the City of Lachine, district of Montreal, and the said MICHEL MALOFY for assisting and authorizing his wife, plaintiff, vs DAME MARIA PRESSEAU & A L, defendants, and THE REGISTRAR of Montreal Registration Division, mis en cause. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol 103, No.7 1755 Conformément au jugement- de l'honorable Jugc H.L.Aronovitch, de la Cour Supérieure du district de Montréal, en date du 3e jour d'octobre 1969, ordonnant la licitation des immeubles ci-après décrits: « Emplacements ayant front sur la neuvième avenue, en la Cité de Lachine, connus et désignés comme étant les subdivisions numéros trois cent cinquante-deux et trois cent cinquante-trois du lot originaire numéro sept cent cinquante-deux (752-352 et 353) aux plan et livre de renvoi officiels dc la ville dc Lachine, sans bâtisse.» Pour être vendu au bureau du protonotaire, chambre #129, au Vieux Palais de Justice, en la ville de Montréal, le DIX-HUITIÈME jour dc MARS 1971, à DEUX heures dc l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 2 février 1971.38724-0 Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( TE AN-PIERRE TURCOTTE, No 800-759.< J comptable, de la ville de Mont-v réal, district de Montréal de la souche Henri Turcotte, demandeur, tu J.TÉLESPHORE TURCOTTE & AL., défendeurs.Conformément au jugement de l'honorable Jean-Paul Bergeron, de la Cour Supérieure du district de Montréal, en date du 27e jour de novembre 1970, ordonnant la licitation des immeubles ci-après décrits : « Un emplacement connu et désigné comme subdivision quatre-vingt-seize du lot originaire mille deux cent onze (1211-96) du cadastre du Quartier St-Jacques de la ville de Montréal avec les bâtisses dessus érigées, portant les numéros trois mille huit cent (3800) à trois mille huit cent quatre (3804) de la rue Parc Lafontainc et neuf cent soixante-quinze (975) à neuf cent quatre-vingt-cinq (985) rue Roy.» Pour être vendu au bureau du protonotaire, chambre #129, au Vieux Palais de Justice, en la ville de Montréal, le DIX-HUITIÈME jour dc MARS 1971, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 2 février 1971.38725-0 Pursuant to the judgement of the Honourable Judge H.L.Aronovitch, of the Superior Court for the district of Montreal, dated of the 3rd day of October, 1969, ordering the licitation of the hereinafter described immovables: \"Emplacements fronting on the ninth Avenue, in the City of Lachine, known and designated as being subdivisions three hundred and fifty-two and three hundred and fifty-three of the original lot number seven hundred and fifty-two (752-352 and 353) on official plan and book of reference for the town of Lachine, without building.\" To be sold at the Prothonolary'.s Office, Room #129, at the Old Court House, in the city of Montreal, the EIGHTEENTH day of MARCH, 1971, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, February 2, 1971.38724 Superior Court \u2014 District of Montreal ( TEAN-PIERRE TURCOTTE, No.800-759.) Mrs.Blanche Demers: Property of Blanche Demers (Blanche Osborne, widow of Omer Demers).\"All of this property known and designated as forming part of lot number ninety-three of the subdivision of lot number twenty-three (23-93 Pt.), Range one of the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.-February 13, 1971, Vol.103, No.7 1763 de Buckingham, mesurant soixante-quinze pieds dans la ligne est, quarante pieds dans la ligne ouest, par la largeur existante entre la propriété de M.Albert Mai-sonneuve connue comme étant partie du lot numéro quatre-vingt-deux et un lot vendu à M.Maurice Mi-ncault, borné comme suit: au sud, par partie du même lot, propriété dc Madame Blanche Osborne, au nord, par le chemin d'Angers; à l'est par la propriété de M.Albert Maisonneuvc et à l'ouest par la propriété de M.Mineault.Avec les bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.» 5° La corporation municipale du Lac-des-Plages.a) Mme Robert Desormeaux (Carole) : Lot No P.34 et non P.34-4.6° La corporation municipale de la paroisse de L'Ange-Gardien.a) Robert Lanthier: Ajouter: Pour bornes complètes et la superficie.Référence: Acte enregistré sous No 116126.Donné à St-André-Avellin, P.Q., ce 29e jour de janvier 1971.Le secrétaire-trésorier, 38631-0 C.A.Montreuil.Municipalité du comté de Québec Erratum Avis public est par les présentes donné que la vente pour défaut dc paiement de taxes aura lieu, JEUDI, le ONZIÈME jour de MARS 1971 et non le dixième jour de mars 1971, tel que mentionné dans l'avis public publié dans la Gazelle officielle du Québec, les 23 et 30 janvier 1971.Le secrétaire-trésorier, Adélard L'Heureux, n.p., 38713-o C.M.C.Q.Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEAUHARNOIS De Terris Cour Supérieure \u2014 District de Beauharnois C T A CAISSE POPULAIRE DE STE-No 11 510.< -L< CÉCILE DE SALABERRY, socié->\u2022 té régie par la Loi des Caisses d'Épargne et de Crédit, ayant son siège social à 15 rue St-Thomas, Salaberry de Valleyfield, district de Beauharnois, demanderesse, vs ROSAIRE DEMERS, domicilié et résidant à 29 avenue Bassin, Salaberry de Valleyfield,.district, défendeur et LE REGISTRATEUR de la vidi-sion d'enregistrement dc Beauharnois, mis en cause.township of Buckingham, measuring seventy-five feet on the east line, forty feet on the west line, by the width existing between the property of Mr.Albert Maison-neuve known as forming-part of lot number eighty-two and a lot sold to Mr.Maurice Mincault, bounded as follows: on the south by part of the same lot, property of Mrs.Blanche Osborne, on the north by Angers Road; on the east by the property of Mr.Albert Maisonneuvc and on the west by the property of M.Mineault.With Buildings erected thereon, circumstances and dependencies.5.The Municipal Corporation of Lac-dcs-Plages.(a) Mrs.Robert Desormcaux (Carole) : Lot No.P.34 and not P.34-4.6.The Municipal Corporation of the parish of Ange-Gardien.(o) Robert Lanthier (Add) : For complete boundaries and area.Reference : Deed registered under No.116126.Given at St-André-Avellin, P.Q., this 29th day of January, 1971.C.A.Montreuil, 38631 Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Québec Erratum Public notice is given by this present that the sale for default of payment of taxes will take place, on THURSDAY, the ELEVENTH day of MARCH 1971 and not on the tenth day of March 1971 as mentioned in the public notice published in the Québec Official Gazette on the 23rd and on 30th, January 1971.Adélard L'Heureux, n.p., -Secretary- Treasurer, \u202238713-0 ' C.M.C.Q.Sheriffs' Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEAUHARNOIS De Terris Superior Court \u2014 District of Beauharnois (TA CAISSE POPULAIRE DE STE-No.11 510.< -L* CÉCILE DE SALABERRY, a v company governed by the Savings and Credit Unions Act, haying its head office at 15 St-Thomas Street, Salaberry dc Valleyfield, district of Beauharnois, plaintiff, pa ROSAIRE DEMERS, domiciled and residing at 29 Bassin Avenue, Salaberry de Valleyfield, district, defendant, and THE REGISTRAR for the registration division of Beauharnois, mis en cause. 1764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103' année, n° 7 « Un emplacement situé au Bassin connu et désigné comme étant le lot numéro quinze de la subdivision du lot numéro cent trente et un (No 131-15) au cadastre officiel de la paroisse Stc-Cécilc, mesurant soixante pieds (60') dc largeur par cent pieds (100') de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins.* À distraire cependant du lot présentement hypothéqué la partie vendue à M.Eugène Bourcier suivant vente passée devant Me Philippe Malouin, notaire, le 9 octobre 1963, et enregistrée à Beauharnois sous le No 112724.Avec bâtisses ci-dessus construites.» i Pour être vendu au bureau du shérif, Palais dc Justice, Salaberry dc Valleyfield, le SEIZIÈME jour dc MARS 1971, à DIX heures dc l'avant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, J.Lucien Primeau, Salaberry de Valleyfield, par: Mme Thérèse Leblanc ce 3e jour de février 1971.38714-0 Bonis et de\" Terris District de Beauharnois Cour Supérieure, l \"D OOF TRUSS INC., compagnie No 788 162..siège social et sa principale place d'affaires, à Montréal, district de Montréal, demandeur, contre GEORGE GARTNER, gérant de production, résidant au 1395 Carol Crescent, à Chomedey, district de Montréal, et SAMUEL EDWARDS, contrôleur, résidant à 1319 Red Cross, Westmount, district dc Montréal, défendeurs, et LE REGISTRATEUR du bureau d'enregistrement de la division de Huntingdon, mis en cause.« Ce lot de terre situé dans le deuxième rang de la ville de Havelock, connu et désigné comme étant composé de : a) Lot numéro quatre-vingt-douze B (92B) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Havelock; h) Lot numéro quatre-vingt-treize A (93A) auxdits plan et livre dc renvoi; et c) La moitié ouest du lot numéro quatre-vingt-douze A t}/2 O.92A) auxdits plan et livre de renvoi, contenant cinquante-trois (53) acres et plus ou moins et borné en front par le chemin public, en arrière par la terre du troisième rang, à l'ouest par la propriété de R.W.Jackson, décédé, et à l'est par le résidu dudit lot 92A» Et des constructions ci-dessus érigées.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Huntingdon, à Huntingdon, le DIX-HUITIÈME jour de MARS 1971, à DIX heures dc l'avant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, J.Lucien Primeau.Par: Mme Thérèse Leblanc.Salaberry de Valleyfield, 2 février 1971.38716-0 District de Beauharnois Cour Supérieure, C f\"\\MER GUIMOND, contracteur No 11 616.\\ général, domicilié au 1305 rue v.Notre-Dame, St-Sulpice, district de Joliette, demandeur, vs RAYMOND GUIMOND, domicilié et demeurant au 3 de la rue Claude, à Chft- \"An emplacement situated at Bassin known and designated as forming lot number fifteen of the subdivision of lot number one hundred and thirty-one (No.131-15) on the official cadastre of the parish of Ste-Cécilc, measuring sixty feet (60') in width by one hundred feet (100') in depth, English measure, more or less.To withdraw however from the lot now mortgaged the part sold to Mr.Eugène Bourcier according to a deed passed before Me Philippe Malouin, notary, on October 9, 1963, and registered at Beauharnois under No.112724.With buildings built thereon.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, in Salaberry de Valleyfield, on the SIXTEENTH day of MARCH, 1971, at TEN o'clock in the forenoon.J.Lucien Primeau, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Salaverry de Valleyfield, by: Mrs.Thérèse Leblanc.February 3, 1971.38714 Bonis et de Terris District of Beauharnois Superior Court, ( T> OOF TRUSS INC., a company No.788 162.-s ¦»->\u2022 duly incorporated having its v head office and its principal place of business in Montreal, district of Montreal, plaintiff, versus GEORGE GARTNER, production manager, residing at 1395 Carol Crescent, in Chomedey, district of Montreal, and SAMUEL EDWARDS, comptroller, residing at 1319 Red Cross, Westmount, district of Montreal, defendants, and THE REGISTRAR of the registry office of the division of Huntingdon, mis en cause.\"That lot of land situate in the second range of the town of Havelock, known antl designated as being composed of: (a) lot number ninety-two B (92B) upon the official plan and book of reference for the township of Havelock; (6) lot number ninety-three A (93A) upon the said plan and book of reference; and (c) the western half of lot number ninety-two A (l/2 W- 92A) upon the said plan and book of reference, containing fifty-three (53) acres and more or less and bounded in front by the public road, in rear by the land of the third range, to the west by the property of the late R.W.Jackson, and to the east by the residue of said lot 92A\".And buildings erected thereon.\" To be sold at the Registry Office of the Division of Huntingdon, at Huntingdon, on the EIGHTEENTH day of MARCH, 1971, at TEN o'clock in the forenoon.J.Lucien Primeau, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.by: Mrs.Thérèse Leblanc.Salaberry de Valleyfield, February 2, 1971.38716 District of Beauharnois Superior Court, ( /~\\MER GUIMOND, general con-No.11 616.< ^ tractor residing at 1305 Notre-v Dame Street, St.Sulpice, district of Joliette, plaintiff, vs RAYMOND GUIMOND, domiciled and residing at 3 Claude Street, at Châteauguay QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 18, 1971, Vol.108, No.7 1765 teauguay, district dc Beauharnois, défendeur et LE REGISTRATEUIt de la division de Châteauguay, mis en cause.« Un emplacement situé à Châteauguay, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Joachim, comme étant la subdivision numéro onze du lot originaire numéro deux cent vingt et un (221-11) et comme étant partie de la subdivision numéro quatre «lu susdit lot originaire numéro deux cent vingt et un (221-ptic 4) mesurant quatre-vingt-trois pieds au nord, cinquante pieds à l'ouest, cinquante-cinq pieds et neuf dixièmes au sud et cinquante-sept pieds à l'est; mesure anglaise, plus ou moins, avec bâtisse dessus érigée, portant le numéro civique 3 dc la rue Claude, à Châtcauguay; bornée au nord par le lot 221-11 du susdit cadastre, à l'ouest par le résidu dudit lot 221-4, à l'est par partie du lot originaire 222 et au sud par le lot 221-3.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division dc Châteauguay, à Ste-Martine, le DIX-SEPTIÈME jour dc MARS 1971, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, J.Lucien Primeau.Salaberry de Valleyfield, par: Mme Thérèse Leblanc.ce 2 février 1971.38715-0 district of Beauharnois, defendant, and THE REGISTRAR of the division of Châteauguay, mis en cause.\"An emplacement situated at Châteauguay, known and designated on the official plan and in the book of reference of the parish of St.Joachim, forming subdivision number eleven of original lot number two hundred and twenty-one (221-11) and forming part of subdivision number four of the aforesaid original lot number two hundred and twenty-one (221-P.4) measuring eighty-three feet on the north, fifty feet on the west, fifty-five feet and nine tenths on the south and fifty-seven feet on the east; English measure, more or less, with a building erected thereon, bearing civic number 3 Claude Street, at Châteauguay; bounded on the north by lot 221-11 of the aforesaid cadastre, on the west by the remainder of daid lot 221-4, on the east by part of original lot 222 and on the south by lot 221-3.\" To be sold at the Registry Office of the Châteauguay Division, at Ste-Martine, on the SEVENTEENTH day of MARCH, 1971, at TEN o'clock in the forenoon.J.Lucien Primeau, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Salaberry de Valleyfield, by: Mrs.Thérèse Leblanc February 2, 1971.38715 BEDFORD Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District dc Bedford ( T\\AME LISE BESSETTE, demanderes-No 7977.< ¦M se, vs RITA MULLINS, defende-v resse.« 1° Un certain lot à bâtir ou emplacement de terrain, situé et étant sur le côté est de la rue Elgin, dans ledit village de Granby, maintenant cité de Granby, connu et décrit aux plans et livre dc renvoi du même cadastre, comme formant partie du lot numéro cent trente-cinq (135), mesurant soixante-douze pieds de largeur à partir de la ligne sud dudit lot cent trente-cinq en allant dans une direction nord, le long dc ladite rue Elgin, sur la profondeur dudit lot et des lots adjacents, avec les bâtisses dessus érigées.2° Un certain lot de terre sis et étant situé en la cité dc Granby, sur le côté est de la rue Elgin, formant partie du lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du village de Granby comme étant le lot numéro cent trente-six (P.No 136) ; ledit lot vendu mesurant soixante-six pieds de largeur sur la rue Elgin, devant être mesuré à partir de la ligne sud dudit lot numéro cent trente-six, en allant vers le nord sur la profondeur entière dudit lot numéro cent trente-six; avec les améliorations.Sauf et excepté cette partie dudit lot numéro cent trente-six (P.136) vendue par Joseph S.Mullin à Albert Guertin devant Me Joseph Lemieux, notaire, le vingt; troisième jour de février mille neuf cent trente-huit, dont une copie est dûment enregistrée au bureau BEDFORD Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Bedford C \"TYÀME LISE BESSETTE, plaintiff, vs No.7977.j I-* RITA MULLINS, défendant.\"1.A certain building lot or emplacement of land, situate and being on the east side of Elgin Street, in said village of Granby, now city of Granby, known and described on the official plan and in the book of reference of the same cadastre, as being part of lot number one hundred and thirty-five (135), measuring seventy-two feet in width from the south line of said lot 135, going in a northerly direction, along said Elgin Street, by the depth of said lot and adjoining lots, with the buildings thereon erected; 2.A certain lot of land lying, being and situate in the city of Granby, on the cast side of Elgin Street, forming part of the lot known and designated at the official plan and in the book of reference for the village of Granby as being number one hundred and thirty-six (P.No.136) ; the said lot sold, measuring sixty-six feet in width, on Elgin Street to be measured from the south line of said lot number one hundred and thirty-six, going to the north, by the whole depth of said lot number one hundred and thirty-six; with improvement thereon.Save and except that part of the said lot number one hundred and thirty-six (P.136) sold by Joseph S.Mullin to Albert Guertin before Joseph Lemieux, notary on the twenty-third day of February one thousand nine hundred and thirty-eight, whereof a copy is 1766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février .1971, 103' année, n\" 7 d'enregistrement du comté de Shcfford sous le numéro 1004S0 et la décrivant comme suit: Un certain morceau de terrain sis et situé sur le côté est dc la rue Elgin, en la cité de Granby, formant partie du lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du village de Granby, comme étant le lot numéro cent trente-six (P.136); ledit morceau de terrain mesurant cinquante pieds dc largeur sur la rue Elgin; commençant à mesurer à partir d'un point sur la ligne ouest dudit lot No 136 situé à seize pieds de la ligne sud dudit lot No 136, de là, se dirigeant vers le nord le long de la ligne ouest dudit lot No 136, ladite largeur dc cinquante pieds sur cent soixante-quinze pieds de profondeur à partir de la ligne ouest dudit lot No 136 allant vers l'est.Avec les bâtisses dessus érigées.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Shcfford à Waterloo, district de Bedford, MERCREDI, le DIX-SEPTIEME jour de MARS 1971, à DEUX heures dc l'après-midi.Cowansville, le 4 février 1971.Le shérif, 3S719 Antonin Bourassa.Canada \u2014 Province de Québec District de Bedford Cour Supérieure, ( \"RLORIDE HAMELIN, deman-No 16,040.olitiquc et dûment incorporé ayant une place d'affaires au numéro 2460 Benny Crescent, app.502, Montréal 261, district de Montréal, défenderesse.Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal ( QUN LIFE ASSURANCE COMPA-No.799-514.< \u2022>-> NY OF CANADA, body politic '¦ and duly incor]>orated, having its head office and a principal place of business in Montreal, district of Montreal, plaintiff, is MODAL INC., body politic and duly incorporated having a place of business at 2460 Benny Crescent, Apt.502, Montreal 261, district of Montreal, defendant. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1773 « Un emplacement ayant front sur la rue Jean-Picard, en la ville de Laval, province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision deux cent seize du lot trois cent -quatre-vingt (380-216) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin mesurant quatre-vingts pieds dc largeur et une profondeur de cent vingt-trois pieds mesure anglaise, plus ou moins.Avec la bâtisse en voie de construction dessus érigée portant le numéro 1920 de ladite rue Jean-Picard, dont le mur nord-ouest est mitoyen.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté dc Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, le SEIZIÈME jour dc MARS 1971, à DEUX heures de l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 2 février 1971.38732-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( IMPERIAL OIL CO.LTD.cor-Cour Provinciale, 1 A poration légalement constituée.No 56-488.) ayant une place d'affaires à 861 ' boulevard Champlain, Québec, district de Québec, vs OSCAR PICHETTE, résidant à 525 avenue Royale, St-Féréol, district de Québec.« Partie du lot numéro 284 de la paroisse St-Féréol, comté de Montmorency, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances et dont la propriété appartient à Oscar Pichette du 525 avenue Royale, St-Féréol, district de Québec.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Châ-teau-Richer, à Château-Richcr, comté dc Montmorency, le SEIZIÈME jour de MARS 1971, à DIX heures dc l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 9 février 1971.38726 \"An emplacement fronting on Jean-Picard Street, in the town of Laval, Province of Québec, known and designated as forming subdivision two hundred and sixteen of lot three hundred and eighty (380-216) on the official plan and in the book of reference of the parish of St-Martin, measuring eighty feet in width and a depth of one hundred and twenty-three feet, English measure, more or less.With the building under construction erected thereon bearing number 1920 of the said Jean-Picard Street, the northwest wall of which is a party wall.\" To be sold at the Registry Office of the county of Laval, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, on the SIXTEENTH day of MARCH, 1971, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, , Assistant Sheriff.Montreal, February 2, 1971.38732 QUEBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit .( IMPERIAL OIL CO.LTD., cor-Provincial Court, Ï J- poration legally incorporated.No.56-488.1 having its place of business at ' 861 Champlain Boulevard, Québec, district of Québec, vs OSCAR PICHETTE, residing at 525 Royale Avenue, St-Féréol, district of Québec.\"Part of lot No.284 of St-Féréol Parish, county'of Montmorency, with the buildings thereon constructed, circumstances and dependencies and of which the property belongs to Oscar Pichette of 525 Royale Avenue, St-Féréol, district of Québec.\" To be sold at the registry office of Chateau-Richer, at Chateau-Richer, county of Montmorency, the SIXTEENTH day of MARCH, 1971, at TEN o'clok in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, February 9, 1971.38726-o Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 Montréal Québec, à savoir, C COCIÉTÉ NATIONALE DE FI-No 777-123.< P DUCIE, coprs politique léga-v lement incorporé, ayant son siège social au 385 est, rue Sherbrooke, dans les cité et district de Montréal, contre CONSTRUCTION CHERBOURG INC., corporation légalement constituée par lettres patentes en date du 1er septembre 1966, ayant eu son siège social au 2350, avenue du Mont Thabor à Québec, district de Québec, et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUFCHATEL INC., corporation légalement constituée par lettres patentes en date du 1er septembre 1966, ayant eu son siège social au 2350, avenue du Mont Thabor à Québec, district de Québec.« Une parcelle de terrain faisant partie du lot 1106 du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise de la Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec.Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 Montreal Québec, to wit, ( QOCIÉTÉ NATIONALE DE FI- No.777-123.\u2022! P DUCIE, body politic legally v incorporated, having its head office at 385 Sherbrooke Street East, in the city and district of Montreal, agaiitst CONSTRUCTION CHER-BOURD INC., corporation legally incorporated by letters patent on September 1, 1966, having its head office at 2350 Mont Thabor Avenue, at Québec, district of Québec, and SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUFCHATEL INC., corporation legally incorporated by letters patent on September 1, 1966, having its head office at 2350 Mont Thabor Avenue, at Québec, district of Québec.\"A plot of land forming part of lot 1106 on the official cadastre of the parish of St-Ambroisc dc la Jeune-Lorette, registration division of Québec. 1774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1971, 103- année, n\" 7 De figure mixtilignc: bornée au nord-ouest et au nord-est par une partie du lot 1106 (rues projetées), au sud-est par les lot 1106-30, 1106-31 et 1106-32, au sud-ouest par une partie du lot 1106, mesurant quatre-vingt-deux pieds et trois dixièmes de pied (82.3') au nord-ouest, cent cinquante-deux pieds (152') uu sud-est; contenant en superficie soixante-quatorze mille pieds carrés (74,000 p.c.) mesure anglaise.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement dc Québec, 10, avenue Chauveau, Québec, le SEIZIÈME jour dc MARS 1971, a DIX heures de l'avant-midi.IjC shérif adjoint, ¦Sureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 9 février 1971.38727-o TERREBONNE Of mixtilincal form: bounded in the northwest and in the northeast by part of lot 1106 (streets in the planning stage), in the southeast by lots 1106-30, 1106-31 and 1106-32, in the southwest by part of lot 1106, measuring eighty-two feet und three-tenths (82.3') in the northwest, one hundred and fifty-two feet (152') in the southeast; comprising an area of seventy-four thousund square feet (74,000 s.f.), English measurement.\" To be sold at the registry office of Québec, 10 Chauveau Avenue, Québec, the SIXTEENTH day of MARCH, 1971, at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, February 9, 1971.38727 TERREBONNE Canada \u2014 Province de Québec Cour Su|)éricure \u2014 District dc Montréal fCOCÏËTÊ D'ENTREPRISE DU No.798.217X CANADA, un corps politique et v constitué, dûment incorporé selon la Loi, uyunt sa principale place d'affaires pour lu province de Québec, en les ville et district de Montréal, demanderesse; m PETER A.LAWRENCE, c.a., Syndic licencié, en sa qualité de syndic envers la succession de « Alpine Inn Limited », un corps politique et constitué, dûment incorporé selon la loi, par lettres patentes datées du 8 novembre 1947, sous le nom de « Cardy-Alpine Inc.» et subséquemment sous le nom dc * Alpine Inn Limited», par lettres patentes supplémentaires datées du 23 août 1950, ayant son siège social à Sainte-Marguerite Station, district de Terrebonne, défendeur es-qualité, et PHILIPPE BÊRUBÊ, de Saint-Jérôme, district of Terrebonne, en sa qualité de régistralcur de la division d'enregistrement dc Terrebonne, mis en cause.Avis de vente Les immeubles ci-après désignés et en la possession du défendeur cs-qualité.« Un emplacement situé à Sainte-Marguerite Station en la municipalité de la paroisse de Sainte-Adèle, comté de Terrebonne, Québec, dans le onzième rang du canton Morin, aux plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse dc Sainte-Adèle d'Abcrcrombic, ce qui suit: 1° Une partie du lot numéro treize, les lots trente-sept, trente-huit et une partie du lot trente-neuf, les lots soixante-dix (rue), soixante et onze, soixante-douze, soixante-treize, soixante-quatorze, soixante-quinze et le résidu du lot soixante-seize dc la redivision d'une partie du lot originaire numéro un (1-ptic 13, 37, 38, ptie 39, 70 (rue) 71, 72 (rue), 73, 74, 75 et résidu 76), lesdites parties de lot 13 et 39, et le résidu 76 étant décrites comme suit: Partie 13: Canadu \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal C COCIÉTÉ D'ENTREPRISE DU No.798,217.< O CANADA, a body politic and v corporate, duly incorporated according to law, having its principal place of business for the province of Québec, in the city and district of Montreal, plaintiff, m PETER A.LAWRENCE, o.a., licensed trustee, in his capacity as trustee to the estate of Alpine Inn Limited, a body politic and corporate, duly incorporated according to law, by letters patent dated November 8, 1947, under the name of Cardy-AIpinc Inc., and subsequently under the name of Alpine Inn Limited by supplementary letters paient dated Aug.23/50, having its head office at Ste-Margucrite Station, district of Terrebonne, defendant es-quality, and PHILIPPE BÉRUBÉ, of St.Jérôme, district of Terrebonne, in his capacity as registrar of the registration division of Terrebonne, mis en cause.Notice of sale The immovables hereinafter designated and in the possession of the defendant es-quality.\"An emplacement situated at Ste.Marguerite Station in the municipality of the parish of Ste.Adèle, county of Terrebonne, Québec, in the eleventh range of the township of Morin, in the plan and book of reference for the parish of Ste.Adèle d'Abcrcrombic, as follows: (1) Part of lot number thirteen, lots numbers thirty-seven, thirty-eight and part of lot thirty-nine, lots seventy (Street), seventy-one, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five, and the residue of seventy-six, of the rcdivision of a part of original lot number one (1-P.13, 37, 38, P-39, 70 (Street) 71, 72 (Street) 73, 74, 75 and residue 76), the said parts of lots 13 and 39, and residue 76 being described as follows: Pari 13: The portion of lot No.1-13 is of triangular figure, is bounded towards the south by the residue of lot No.La portion du lot No 1-13 est dc forme triangulaire et est bornée vers le sud par le résidu du lot No 1-13, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1775 vers le nord-ouest et l'est par une portion non divisée du lot No 1-76, elle mesure vingt-huit pieds sur sa ligne sud, 45 pieds\" sur sa ligne nord-ouest, 50 pieds sur sa ligne est; et contient six cent cinquante pieds carrés (650 p.c.) Partie 39: La portion du lot No 1-39 est bornée vers le sud par le lot No 1-73, vers le nord-ouest par le lot No 1-3S, vers le nord par le lot No 1-74, vers le sud-est par le résidu dudit lot No 1-39 (chemin public), elle mesure 48.6 pieds sur sa ligne sud, 44.6 pieds sur sa ligne nord sur 125 pieds de profondeur; et contient en superficie quatre mille sept cents pieds carrés (4,700 p.c).Résidu 76: La portion du lot No 1-76 est bornée vers l'est par les portions non-divisées des lots Nos 1, 1-28A, 1-32-A (chemin public), vers le nord par les lots Nos 1-72 et 1-77 (rues), vers le nord-ouest par le lot No 2A-304, vers le sud-ouest par des portions non-divisées des lots\" Nos 1 et 1-18, vers le sud-est et l'ouest par des portions non-divisées du lot No 1-13, vers le sud par le résidu dudit lot No 1-76, elle mesure 188 pieds sur sa ligne est, 335 pieds sur sa ligne nord, 84 pieds sur sa ligne nord-ouest, 135 pieds sur sa ligne sud-ouest, 220 pieds sur sa ligne sud-est, 50 pieds sur sa ligne ouest, 68 pieds sur sa ligne sud et contient une superficie de trente-quatre mille cinq cent soixante-trois pieds carrés (34,563 p.c.) 2° Les lots numéros cent vingt-quatre, deux cent quatre-vingt-dix et deux cent quatre-vingt-onze, trois cent six (rue, trois cent neuf, le résidu du lot trois cent dix et le lot numéro trois cent douze dc la redivision d'une partie du lot originaire numéro 2A (2A-124, 290, 291 (rue), 306 (rue), 309, résidu 310, 312), ledit résidu 310 étant décrit comme suit: Hisidu partie 810: La portion du lot 2A-310 est bornée vers le sud-ouest pur le lot Nô 2A-305 (rue) par le lot No 2A-310-2, vers le nord-ouest par ledit lot No 2A-310-2, par les lots Nos 2A-310-4, 2A-310-5, 2A-190-1, 2A.P.189, 2A-188-1, 2A-135, vers le nord par le lot No 2A-190-1, par les portions des lots Nos 2A-190-2, 2A-191-2, par les lots Nos 2A-311 (rue), 2A-181-1, 2A-182-1, 2A-182-2, 2A-135, 2A-136, 2A-137, 2A-177, 2A-178, 2A-P.179, 2A-124, vers l'est par les lots Nos 2A-183-2, 2A-184-2, 2A-185-2, 2A-186-2, vers le sud-est par une portion du lot No 2A-180, par les lots Nos 2A-174, 2A-137, 2A-124, 1-74, et 1-73, vers le sud par les lots Nos 2A-174 à 2A-178, 2A-124; elle mesure 236.4 pieds sur l'une de ses lignes sud-ouest, 137.3 pieds sur l'une de ses lignes nord-ouest, 110.6 pieds sur une autre ligne sud-ouest, 171.4 pieds sur une autre ligne nord-ouest, 8.6 pieds sur une autre ligne sud-ouest, 40 pieds sur une de ses lignes nord, 49.5 pieds sur une autre ligne nord, 164.15 pieds sur une autre ligne nord-ouest, 52 pieds sur une autre ligne nord, 131 pieds sur une de ses lignes est, 103.65 pieds sur une autre ligne nord, 31 pieds sur l'une de ses lignes sud-est, 257.5 pieds sur l'une de 1-13, towards the northwest and the east by an undivided portion of lot No.1-76, measures 28.0 feet in its southerly line, 45.0 feet in its north-westerly line, 50.0 feet in its easterly line; and contains in area six hundred and fifty square feet, (650.0').Part 89: The portion of lot No.1-39 is bounded towards the south by lot No.1-73, towards the northwest by lot No.1-38, towards the north by lot No.1-74, towards the southeast by the residue of said lot No.1-39 (Public Road), measures 48.6 feet in its southerly line, 44.6 feet in its northerly line by 125.0 feet in depth; and contains in area four thousand seven hundred square feet, (4,700.0').Residue 76: The portion of lot No.1-76 is bounded towards the east by undivided portions of lots Nos 1, 1-28A, 1-32A (Public Road), towards the north by lots Nos 1-72 and 1-77 (Streets), towards the northwest by lot No.2A-304, towards the southwest by undivided portions of lots Nos 1 and 1-18, towards the southeast and the west by undivided portions of lot No.1-13, towards the south by the residue of said lot No.1-76, measures 188.0 feet in its easterly line, 335.0 feet in its northerly line, 84.0 feet in its north-westerly line, 135.0 feet in its south-westerly line, 220.0 feet in its south-easterly line, 50.0 feet in its westerly line, 68.0 feet in its southerly line; and contains in area thirty-four thousand five hundred and sixty-three square feet (34,563.0').(2) Lots numbers one hundred and twenty-four, two hundred and ninety, two hundred ninety-one, three hundred and six (Street), three hundred and nine, the residue of lot three hundred and ten, and lot number three hundred and twelve, of the redivision of part of original lot number 2A.(2A-124, 290, 291 (Street), 306 (Street), 309, residue 310, 312), the said residue 310 being described as follows: Residue part 310: The portion of lot No.2A-310 is bounded towards the southwest by lot No.2A-305 (Street), by lot No.-2A-310-2, towards the northwest by said lot No.2A-310-2, by lots Nos 2A-310-4, 2A-310-5, 2A-190-1, 2A.P.189, 2A-188-1, 2A-135, towards the north by lot No.2A-190-1, by portions of lots Nos 2A-190-2, 2A-191-2, by lots Nos 2A-311 (Street), 2A-181-1, 2A-182-1, 2A-182-2, 2A-135, 2A-136, 2A-137, 2A-177, 2A-178, 2A-P.179, 2A-124, towards the east by lots Nos 2A-183-2,\" 2A-184-2, 2A-185-2, 2A-186-2, towards the southeast by a portion of lot No.2A-180, by lots Nos 2A-174, 2A-137, 2A-124, 1-74 and 1-73, towards the south by lots Nos 2A-174 to 2A-178, 2A-124, measures 236.4 feet in one of its south-westerly lines, 137.3 feet in one of its north-westerly lines, 110.6 feet in another south-westerly line, 171.4 feet in another north-westerly line, 8.6 feet in another south-westerly line, 40.0 feet in one of its northerly lines, 49.5 feet in another northerly line, 164.15 feet in another north-westerly line, 52.0 feet in another northerly line, 131.0 feet in one of its easterly lines, 103.65 feet in another northerly line, 31.0 feet in one of its south-easterly lines, 257.5 1776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 février 1971, 108' année, n\" 7 ses lignes sud, 250 pieds sur une autre ligne sud-est, 154.5 piedssur une autre ligne nord, 125 pieds sur une autre ligne nord-ouest, 152 pieds sur une autre ligne nord, 290 pieds sur une autre ligne sud-est, 38.5 pieds sur une autre ligne sud, 125 pieds sur une autre ligne sud-est, 25 pieds sur une autre ligne nord, 50 pieds sur son autre ligne sud-est; et elle contient en superficie cent quatorze mille six cent quarante-deux pieds carrés (114,642 p.c.) 3° Le lot numéro trois cent soixante et onze de la redivision d'une partie du lot originaire numéro 34 (3A-371).4° Le lot numéro quatre de redivision d'une partie du lot originaire numéro quatre (4-4).Avec toutes les bâtisses dessus érigées, y compris l'hôtel » Alpine Inn », la pischu- extérieure fuisant partie de cet hôtel, les chalets, le motel, les bâtisses réservées au personnel, le local du club de golf qui comprend aussi les terrains du curling et la piscine intérieure et toutes les autres bâtisses accessoires à iccux, et toutes les autres bâtisses dessus érigées.Sujet, pour lesdits lots 1-70, 1-72, 2A-305, 2A-307, à une servitude perpétuelle pour droit de passage à pieds et en voiture en faveur des autres lots ci-dessus décrits et hypothéqués et leurs propriétaires, une servitude créée par le débiteur par destination de père de famille, afin de communiquer avec le chemin public.Ledit immeuble antérieurement décrit avec toutes choses y attachées, sans exception ou réserve'.» Pour être vendu, au bureau d'enregistrement du comté de Terrebonne, situé chambre 106, Palais de Justice, 400 rue Laviolette, Saint-Jérôme, MERCREDI le DIX-SEPTIÈME jour de MARS 1971 à DEUX heures de l'après-midi.Conditions: comptant.Le shérif intérimaire.Bureau du Shérif, Gabrielle Fournelle.Saint-Jérôme, le 5 février 1971.38733 feet in one of its southerly lines, 250.0 feet in another south-easterly line, 154.5 feet in another northerly line, 125.0 feet in another north-westerly line, 152.0 feet in another northerly line, 290.0 feet in another south-easterly line, 38.5 feet in another southerly line, 125.0 feet in another south-easterly line, 25.0 feet in another northerly line, 50.0 feet in its other southeasterly line; and contains in area one hundred and fourteen thousand six hundred and forty-two square feet, (114,642.0').(3) Lot number three hundred and seventy-one of the redivision of part of original lot number 3A (3A-371).(4) Lot number four of the redivision of part of original lot number four (4-4).With all the buildings thereon erected, including the hotel \"Alpine Inn\", the exterior swimming pool forming part of this hotel, the cottages, the motel, the buildings reserved for the personnel, the club-house for the golf club, which includes also the curling grounds and the interior swimming pool and all other buildings accessory thereto, and all other buildings erected thereon.Subject for the said lots 1-70, 1-72, 2A-305, 2A-307, to a perpetual servitude for the right of passage on foot and by voiture in favour of the other lots described above and hypothecated and their owners, a servitude created by the debtor par destination de père de famille, in order to communicate with the public road.The said previously-described immovable, with everything thereto attached, without exception or reserve.\" To be sold at the Registry Office for the county of Terrebonne, located room 106, Court House, 400 Laviolette Street, Saint-Jérôme, WEDNESDAY, the SEVENTEENTH day of MARCH, 1971, at TWO o'clock in the afternoon.Conditions: Cash.Gabrielle Fournelle, Sheriff's Office, Interim Sheriff.Saint-Jérôme, February 5, 1971.38733-o INDEX TSo 7 ARRÊTÉS EN CONSEIL ORDERS //V COUNCIL 328 \u2014 Parent, l'honorable Oswald.1712 328 \u2014 Parent, the Honourable Oswald.1712 365 \u2014 Affaires sociales (Adoption d'un règlement relatif à la signature de certains documents du ministère).1717 365 \u2014 Social Affairs (Adoption of a regulation respecting the signature of certain documents of the Department).1717 418 \u2014 Soustraction au jalonnement de deux (2) étendues de terrain situées dans le district électoral de Saguenay.1715 418 \u2014 Withdrawal from Staking of two (2) strips of land situated in the electoral district of Saguenay.1715 427 \u2014 Bibliothèque nationale du Québec (Règlements du comité consultatif).1712 427 \u2014 Québec National Library Act (Rules of the Advisory Committee).1712 ASSOCIATION COOPERATIVE \u2022 COOPERATIVE ASSOCIATION Association coopérative des consommateurs d'huile dc Windsor (Formation).1730 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1777 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Chevaliers de Colomb de Mercier inc., Conseil Mercier No 3370 (Règl.).1728 Estate of Gaëtan Picard (Benefit of inventory).1729 Knights of Columbus of Mercier Inc., Council Mercier No.3370 (By-laws).1728 Succession Gaétan Picard (Benefice d'inventaire).1779 Université du Québec (Amendement aux règlements 17.1 et 17.2).1729 University of Québec (Amendments to the regulations 17.1 and 17.2).1729 CHANGEMENT DE NOM \u2014 I.lu Demandes: Malouin dit Rinfret, Marie-Louise, Cécile, Annette.Schwartz, Abie.Thomschitz, Johann.CHANGE OF NAME ACT Applications: CHANGEMENT DE NOM \u2014Loi du Accordas: Born, Abraham.CHANGE OF NAME ACT Granted: Cosma, Max.Ellis, Peter Anthony.Homma, George.1723 1723 1723 1722 1722 1723 1723 BILLS BILLS Privés (Présentation).1711 Private (Presentation).1711 CAISSES D'EPARGNE ET DE CRÉDIT SAVINGS AND CREDIT UNIONS Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec (Formation).1727 Caisse «l'économie Wayagamack (Ch.groupe) 1728 Caisse populaire dc Ste-Thérèse dc l'Enfant-Jésus (La) (Correction).1728 COMPAGNIES ÉTRANGÈRES Permis: KXTRA-PROVINCIAL COMPANIES Licenses: Copcland Process Limited.1706 Omega Investments Limited.1707 COMPAGNIES \u2014 LOI DES Demandes d'abandon de charte COMPANIES ACT Applications for Surrender of Charter Alix Airborne Survey Ltd.1711 Arsenault, Francoeur, Lapointe, Raymond, Tremblay et compagnie limitée.1710 Autobus Blier inc.(Les).1709 Bernier & Labric inc.1707 Burnbrookc Holding Corporation.1707 Citadel Saw Chain Products Lt«l.1708 Collège St-Vallicr.1708 École dc puériculture Notre-Dame de Liesse.1708 Gulbro Investments Inc.1710 Hôtel, motel La Caravelle inc.1710 Isolation B.V.B.ltée.1709 Majo inc.1708 Manoir Nominingue inc.1710 Millco Inc.1709 Northern Loan and Finance Corp.1711 Princeville Transport Inc.\" 1711 Propane Gas Utilities (1970) Limited.1710 Restinter Inc.1709 Shanedling Company Ltd.1708 Uniformes Québécois inc.(Les).1711 Voltigeurs de Granby inc.(Les).1709 Winrite Homes Inc.1709 Divers M^iscellaneous Afgor inc.(Dir.).1701 Association des embouteilleurs d'eaux gazeuses du Québec (L') (Nom ch.).1701 Association des embouteilleurs d'eaux gazeuses du Québec (L') (Règl.).1702 Caprice Hosiery Sales Ltd.(Dir.).1703 Clinique financière et administrative (Montréal) inc.(Nom-Name ch.).1703 Conseil régional «le développement Lanaudièrc (Nom-Name ch.).1702 Crémerie St-Eustache ltée (Dir.).1702 Damcs^auxiliaires «le l'hôpital Marie-Enfant (Dir.).1702 Établissements du gentilhomme- inc.(Les) (Règl.-By-laws).1703 Horn Investments Inc.(Nom-Name ch.).1703 Maison des enseignants dc l'Outaouais inc.(La) (Règl.-By-laios).1703 Québec'Soft Drink Bottlers Association (The) (Name ch.).1701 Québec Bottlers of Carbonated Beverages Association (The) (By-laxcs).1702 Service des loisirs St-Simon-et-St-Jude de Charlemagne (Règl.-By-laws).1704 Slender Magic Health Studio Inc.{Nom-Name ch.).i.1702 United Continental Engines Ltd.(Dir.).1703 1778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1971, 103' année, n° 7 Lettres patentes Letters Patent A.I.M.S.Inc.1603 Agences de voyage Vieille Europe ltée (Les).1661 Allen Feeders Inc.1603 Alliance Israélite culturelle (Am Israël Chai).1603 American Industrial Research Corporation.1604 Anthony Shine Inc.1604 Arena Charlevoix incorporée.1605 Ash Transportation Service Inc.1605 Association des commerçants du Centre-Ville de Val d'Or inc.(L').1605 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Van Horne.1606 Association dc villégiature du Lac Fer à Cheval 1606 Association Québécoise des Fabricants dc tuyau dc béton inc.(L').1607 Auto American Shop L.S.Inc.1607 Automates Parent liée (Les).1608 B & G Sales'Inc.1608 B.M.Woodwork Inc.1608 Bayside Investments Ltd.1609 Beauchcmin (Jean-Guy) inc.1609 Belle reliure de Montréal inc.(La).1609 Blair (C.K.) Inc.1610 Blanchette & Blanchette inc.1610 Bland (John) Incorporated.1611 Bordeleau (G.et M.) inc.1611 Bouchard (Emile) ine.1611 Boucherie de France inc.1612 Bourgon & Quenneville inc.1612 Boutique Hora inc.(La).1613 Bowl ami Board, (Québec) Incorporated.1613 Breault & Gosselin Construction Co.Ltd.1613 Bristamalg Limited.1614 Buckingham Beavers Club.1621 C.L.Distribution inc.1614 Cadrex Consultants Inc.1624 Carrefour d'entr'aide et bénévolat dc Richelieu inc.1615 Carrefour Papineau ltée (Le).1615 Cayne Insurance Agencies Inc.1615 Centre Audio de Chicoutimi inc.1616 Centre d'études de réformes sociales dc Québec inc.1616 Centre Équestre Olympique inc.161/ Centre Gallcgo de Montréal.1617 Centre dc ski Mont Caron inc.1658 Cercle d'études en conduite automobile CE.C.A.).161\" Charolles Industries Ltd.1644 Chashasipich Hospital (Fort George).1641 ( '.hâteauguay Convenience Food Store Inc- 1618 ( îhez Mclina (Québec) ltée.1642 Cie électrique Trahan & Mercillc ltée (La).1680 Cie dc produits Rodico ltée.1618 Club autos sports de Laval Ouest.1619 Club de golf St-Laurent inc.1619 Club de moto-ncige les Montagnards de Saint-Alban inc.1620 Club de natation Laval.1620 Club d'équitation de Rivière-du-Loup inc.1620 Club de Moto-ncige les Campagnards inc.1621 Club des Castors de Buckingham.1621 Club de ski Val d'Irène inc.1622 Club Équestre d'Arvida inc.1622 Club Le Sanglier inc.1622 Club de moto-neige Abénaquis de St-Prosper (Le).1623 Club Optimiste d'Hoehclaga (Le).1623 Coffrage Idéal dc Montréal inc.1623 Comité des loisirs de St-Tite inc.1624 Conseillers Cadrex inc.(Les).1624 Construction Pierre Lamothc inc.1625 Construction Traklin ltée.1680 Cooperhood Kitchens of Québec Inc.1625 Corporation Navis ltée (La).1625 Côté (Gilles) inc.1626 Côté (Jean-Jacques) ltée.1626 Cradon Investment Corp.1626 Créations Patapouf inc.1627 Crediehcx, Inc.1627 Cyberna ltée.1628 Deschênes (Claude) inc.1628 Desjardins Lithographing Inc.1649 Domaine de Champvcrt limitée.1628 Dorchester sport inc.1629 Ensemble traditionnel Kébcc incorporée.1629 Entreprises C.Taillefer, inc.(Les).1630 Entreprises F.T.Carrier ltée (Les).1630 Entreprises internationales J.B.C.ltéc.1630 Entreprises Jodan inc.(Les).1631 Entreprises Lemieux de la Rive Sud inc.(Les) .1631 Entreprises Trois Saisons ltée.1679 Entreprises Velia Lefebvre ine.(Les).1631 Evangelical Lutheran Latvian Church in Montreal.1632 Expo télé-couleur inc.1632 F.W.R.Enterprises Inc.1633 Fédération de lutte amateur du Québec inc.1665 Ferme Devi inc.(La).1633 Figure Magic Health Studio Inc.1633 5150 Macdonald Inc.1634 FIciscbman Commercial Equipment Ltd.1634 Fobert Marine Counstruction Inc.1634 Fondation Bergeron inc.1635 Foreign & Domestic Surplus Merchandise Co.Inc.1635 Fortier (J.E.) inc.\u2022.1636 Fovimar limitée.1636 Foyer Le Blanc Sommet inc.1636 Frontenac Granite Inc.1639 Frontier Inn (1970 Inc.1637 Gauthier (Marcel) construction inc.1637 Gélinas (Rolland) Auto inc.1638 Gestion Rio inc.1638 Gosselin, Samson, Rancourt inc.1638 Granbour inc._.1639 Granits Frontenac inc.(Les).1639 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Van Horne School.1606 Grégoirc-Smith inc.1640 Grolcc inc.1640 Guérard (Jean) inc.1640 Harton & Ouellct construction inc.1641 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February IS, 1971, Vol.103, No.7 1779 Lettres patentes fetters Patent (suite) (continued) Hepco Electric Inc.1641 Hôpital Chashasipich (Fort-Georges).1641 House of Melina (Quebec) Ltd.1642 Hyman & Estelle Barkun Foundation (The) .1642 Immeubles Esther ltée.1643 Immeubles Steinberg limitée (Les).1676 Import-Export Drawback Consultants Ltd.1643 Industries de Charolles ltéc (Les).1644 Industries G.Bellerose inc.(Les).1644 Industrie Laçasse inc.(L').1644 Industries It.& L.Girard inc.(Les).1645 Island Terrace Restaurant Inc.1645 J.B.C.International Enterprises Ltd.1630 Jeune Chambre dc St-Éphrem (Beauce) inc.(La).1645 Jeune Chambre de St-Nazaire (La).1646 Labrccquc & Du Tremble inc.1646 Lafrenière (Oscar) & fils limitée.1647 Lagueux (Robert) inc.1647 Lamarche Crane Services Inc.1647 Lautcch inc.iwS Laval Swimming Club.1620 Lebeau (G.) Ltd.1648 Lebeau (G.) ltée.1648 Ligue des propriétaire de Blainville (La).1649 Lionel Sales and Distribution Ltd.1649 Lithographie Desjardins inc.1649 Logex inc.1650 Loisirs de la paroisse St-Joscph de Sherbrooke (Les).1650 M.G.sports ltéc.1651 Main Optical Inc.1651 Maison du chômeur de St-Henri inc.(La).1651 Maison Lambert Closse inc.(La).1652 Manécanteric et les Choeurs de Montarville inc.(La).1652 Maraudeurs de Duhamel inc.(Les).1653 Marclié Go-Go du Saguenay inc.1653 Marcoux transit inc.1653 Marlass Realties Ltd.1654 Mar-Tex Ltd.1654 Maska Beef Packers Inc.1655 Mclri in.-.1655 Metro Spiraltubb Inc.1655 Meubles G.Lamothe & fils ltée.1656 Mini Putt Venise Inc.1656 Miron (Armand & fils transport inc.1656 Modem Air Spray Ltd.1657 Modem Miss Sportswear Ltd.1657 Mont Caron Ski Centre Inc.1658 Motel Connelly-Nord inc.1658 Multi-service Granby inc.1658 Multi-Soins inc.1659 Mustang Investments Inc.1659 National Containers Holdings Corp.1659 Navis Corporation Ltd.1625 Nettoyeur « Maison Blanche » inc.(Le).1660 Nietspil Sport Centres Inc.1660 Normez inc.1661 North End Sheet Metal Work and Roofing Ltd.1661 Old Europe Travel Services Ltd.1661 Olympic Equestrian Centre Inc.1617 Optique Principale inc.1651 Overseas-Canadian Club Inc.(The).1662 Pantime Mfg.Inc.1662 Pantorama Inc.- - 1663 Pièces d'autos et redistribution Théroux inc.1678 .Placements Al-vi inc.(Les).1663 Prêt d'Argenteuil inc.(Le).1663 Prêt fonciers (St-Jean) inc.1664 Production Après Ski inc.1664 Productions Da Sylva inc.(Les).1664 Produits marins T.R.inc.1665 Québec Amateur Wrestling Federation Inc.1665 Québec Concrete Pipe Manufacturers Association Inc.1607 Querol inc.1666 Quincaillerie Sillcry inc.1666 Raftery Caterers (Montreal) Ltd.1666 Résidences Élie inc.(Les).1667 Resytec International (Canada) ltée.1667 Restaurant Terrasse de l'Ile inc.1645 Resytec International (Canada) Ltd.1667 Robert (F.) & Fils inc.1668 Robitaille (J.) Auto inc.1668 Rodico Products Co.Ltd.1618 Rolfib Limited.1668 Rolfib limitée.1668 Rousseau & Girard inc.1669 Royal Photo-Litho Ltd.1669 St.Lawrence Golf Club Inc.1619 S.A.C.service d'analyse caractérologique inc.1669 S.K.D.& associés ltée.1670 Salon dc coiffure Chateaubriand inc.1670 Sandan Vehicles (Québec) Limited.1671 Scanlan's Publishing Ltd.1671 Seigler (Max) Inc.1671 Scptimart inc.\u2022 1672 Service Dégelis inc.;.1672 Service des loisirs de Ferme Neuve inc.1672 Services de grues Lamarche inc.1647 Sillery Hardware Inc.1666 Snoopy's Pizza Shack Inc.- \u2022 1673 Société de développement de La Tuque inc.1673 Société de gestion Arnaud ltée (La).1674 Société d'investissements et de développements St-Gabriel-de-Brandon inc.(La) ¦ ¦ 1674 Société Progarde inc.(La).1674 Sociex inc.1675 Sogegan inc.1675 Stanleen Corporation Ltd.1675 Steinberg Realty Limited.1676 Studio 5, agence d'enregistrement et de placement artistique inc.1676 Studio 5, Recording & Booking Agency Inc.1676 Synth Company Inc.1677 T.R.Sea Products Inc.1663 T.V.Radio-Tex inc.1677 Teracom inc.1677 Textiles St-Bruno ltée.1678 Théroux Auto-Parts and Redistribution Inc.1678 1780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1971, 103' année, ra° 7 Lettres patentes Letters Patent (suite) (continued) Thiffeault & Gauthier transport inc.1679 Three Rivers Chevrolet (1970) Ltd.16S2 Three Seasons Enterprises Ltd.1679 Timko-Gouin Holding Corporation.1679 Tourisme Français inc.16S0 Trahan & Mercille Electrical Co.Ltd.1680 Traiteurs Raftery (Montréal) liée (Les).1666 Traklin Construction Ltd.16S0 Trans-Canada Mobile and Trailers Inc.16S1 Transport International Pool (Québec) Ltd.16S1 ' Trois-Rivières Chevrolet (1970) liée.16S2 Turtle Productions Ltd.16S2 Universal Fashions Inc., 16S2 Vitrerie Huot inc.16S3 Wolcat Development Co.Ltd.16S3 Woodvillc Realties Inc.16S3 X-L Screw Mfg.Co.Ltd.1684 Lettres patentes Letters Patent supplémentaires supplcmen tary Aronoff Bros.Limited.16S4 Arrow Plastics Ltd.1685 Badenux, Gosselin & Grenier inc.1685 Bo-Koc, inc.16S5 Bram Industries Corp.16S5 Canabcc Exploration Company.1685 Canadian Armature Works Corp.16S6 Chartier (Vincent) inc.16S6 Chemical and Technical Services Inc.1686 Ciné-Parc Mercier inc.;.16S7 Club dc Baseball les Aigles de Trois-Rivières inc.(Le).16S7 Club de Golf Orléans inc.1687 Coiffel'l Inc.».1687 Collège La Salle inc.1692 Domaine du Bord de l'Eau inc.1688 Donalda Distributions Inc.1688 Eddy's Sportswear Mfg.Co.Ltd.____ 1688 Entreprises dc J.Armand Bombardier ltéc (Les).1688 Entreprises de J.Armand Bombardier ltée (Les).16S9 Entreprises Place Verdun inc.1689 Entreprises Rolland Joyal & Fils inc.(Les).1689 Esecs Holding Corp.16S9 Feutre National inc.1690 Fonds Richelieu inc.1690 Gaby Productions inc.1690 Hellenic Poultry Co.Ltd.1690 Iberville Excavation inc.1691 Immeubles Mainville-Poirier inc.(Les).1691 IncoseedLtd.1691 Laboratoires Cosmel's inc.1691 La Salle Collège Inc.1692 Laval Médical.1692 Lesage, Proteau ltée.1692 Liberty Watch Case Company Limited.1692 Mercier Drive-In Theatre Inc.1687 Morris (B.C.) inc.1693 Mylbec Corporation.1693 National Felt Inc.1690 Nicolet Asbestos Mines Ltd.1693 Nothern Oil Limited.1693 Oeuvre des Terrains de Jeux de St-Laurent de Jonciuièrc inc.(L').1694 Orléans Golf and Country Club Inc.1687 Pan Realty Company.1694 Paqucttc (Candide) inc.1694 Phenccia Land Limited.1694 Physico-Médical Systems Corp.1695 Place Victoria \u2014 St.Jacques Co.Lie.1695 Productions Roger Pilon inc.1695 Product-O-Metal Inc.1695 Real Estate Consultants of Canada Ltd.1696 Rentals Building Corporation.1696 Roymor LUI.1696 Roymor ltée.1696 Salaisons Fleur de Lys ltée.1697 Services Chimiques et Tccliniques inc.1686 Sogexport inc.1697 Treitel Enterprises Ltd.1697 Trois-Rivières Eagles Baseball Club Inc.1687 Unitex Watch Ltd.1697 Sièges sociaux Head Offices Bouvet (François) ltée.1706 Commodities & Metals Ltd.1704 De Gaspé Avenue Investments Inc.1706 Éditions Solidarité Inc.(Les).1704 Entreprises Brissette & Roy inc.(Les).1704 Grand Prix Distributor Ltd.1705 Immeubles Steinberg limitée (Les).1706 Jato Inc.1.705 Librairie du vieux Montréal inc.'.1705 Silcan Mines Ltd.1705 Steinberg Realty Limited.1706 Ucel Holdings Inc.1705 United Continental Engines Ltd.1704 DEMANDES À APPLICATIONS LA LÉGISLATURE TO LEGISLATURE Commission d'écoles pour la municipalité scolaire dc ville d'Anjou.1724 Congregation Avath Sholom Nusoch Haori.1724 Corporation municipale de St-Donat (La).1724 Municipal Corporation of St-Donat (The).1724 School Commissioners for the municipality of ville d'Anjou.1724 LIQUIDATION DES WINDING-UP COMPAGNIES \u2014 Loi de la ACT Magasin Co-op de Hauterive.1726 Martineau (Gérald) inc.1727 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Christie, munie.(Nom-Name ch.).1725 Jonquière, cité-city (Annex.).1726 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 13, 1971, Vol.103, No.7 1781 Institutions Financial financières, Institutions, compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurance: Insurance: Glens Falls Insurance Company (Annul.).1722 Richesses naturelles Natural Resources Tenders for operating leases for petroleum and natural gas.1721 Vente de permis dc recherche pour le pétrole et le gaz naturel.1721 Terres et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Orford, canton-township.1724 Provost, canton-township.1725 Ste-Geneviève, par.1725 St-Hubert, par.1725 PROCLAMATION PROCLAMATION Convocation de la législature.1727 Convocation of the Legislature.1727 Régie de l'Électricité Electricity et du Gaz and Gas Board Gas Métropolitain, inc.(Requête-Pétition).1731 Régie Québec des marchés Agricultural agricoles du Québec Marketing Board Fédération des producteurs de volailles du Québec (quotas).1718 Société d'habitation Québec Housing du Québec Corporation Maniwaki Municipal Housing Bureau (L.P.) 1753 Montmagny Municipal Housing Bureau (L.P.).1751 Municipal Housing Bureau of the town of Bagotville (L.P.).1752 Municipal Housing Bureau of the town of Bécancour (L.P.).1752 Municipal Housing Bureau of Kénogami (L.P.).;.1753 Municipal Housing Bureau of Rivière Bleue (L.P.).1750 Municipal Housing Bureau of Sillery (L.P.).1751 Municipal Housing Bureau of Terrebonne (L.P.).e.1751 Municipal Housing Bureau of Victoriaville (L.P.).,.1754 Office municipal d'habitation de la ville dc Bagotville (L.P.).1752 Office municipal d'habitation de la ville de Bécancour (L.P.).-.1752 Office municipal d'habitation de Kénogami (L.P.).1753 Office municipal d'habitation de Maniwaki (L.P.).1753 Office municipal d'ahabitation de Montmagny (L.P.).1751 Office municipal d'habitation dc Pointe-Gatincau (L.P.).1754 Office municipal d'habitation dc Rivière-Bleue (L.P.).1750 Office municipal d'habitation dc Sillery (L.P.).1751 Office municipal d'habitation dc Terrebonne (L.P.).1751 Office municipal d'habitation dc Victoriaville (L.P.).1754 SOUMISSIONS \u2014 TENDERS \u2014 demandes dc Requests for Chandler, ville-town.:.1731 Cowansville, ville-town.1742 Douville, ville-town.1735 Pierrefonds, ville-town.1748 Port-Alfred, ville-town.1737 Princeville, ville-town.1744 St-Donat, munie.1733 St- Jean,' ville.1738 St-Jean-Chrysostome, ville-town.1740 St.John's, city.1738 Windsor, ville-town.1746 VENTES SALES Effets non réclamés Unclaimed Baggage Canadian National Railway Company.1730 Canadian Pacific Railway Company.1730 Compagnie du chemin de fer canadien Pacifique.1730 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.1730 Licitation Licitation Bellefcuillc vs Presseau et al.1754 Turcotte vs Turcotte et al.1755 Par Shérifs By Sheriffs Beauharnois Beauharnois Caisse populaire dc Stc-Cécilc de Salaberry (La) vs Demers.1763 Guimond vs Guimond.1764 Roof Truss Inc.vs Gartner.1764 Bedford Bedford Bessette vs Mullins.1765 Hamelin vs Morin.1766 Chicoutimi Chicoutimi Boivin & fils auto ltée vs Beaulieu.1767 Chicoutimi-Nord-North, cité-city vs succession-Estate Boucher.:.1768 Lalancette vs Produits Igloo inc (Les).1768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 février 1971, 103' année, n' 7 1782 Hull Huit Avco Finance Ltd.vs Cliaycr.1769 Avco Finance ltée vs Chayer.1769 Joliette Joliette Papier Rouville inc.vs Cousineau et al.1769 Montréal Mon treal Guèvremont vs Colibri Construction ltée.1770 Prudential Insurance Company of America (The) vs Joncs.1771 Prodentielle d'Amérique compagnie d'assurance (La) vs Jones.1771 Sun Life Assurance Company of Canada vs Modal Inc.1771 Sun Life Assurance Company of Canada vs Modal Inc.1772 Sun Life Assurance Company of Canada vs Modal Inc.1772 Québec Québec Imperial Oil Co.Ltd.vs Pichcttc.1773 Société nationale dc fiducie vs Construction Cherbourg inc.1773 Terrebonne Terrebonne Société d'entreprise du Canada vs Lawrence etal.1774 Taxes Taxes Abitibi, comté-county.1755 Compton, comté-county (Correction).1759 Gatineau, comté-county (Correction).1760 Lac St-Jean-Est.1698 Lake St.Jolm-East.1698 Laprairie, comté-county (Correction).1760 Lévis, comté-county (Correction).1760 Montcalm comté-county (Correction).1761 Papineau, comté-county (Correction).1762 Portneuf, comté-county (Correction).1760 Québec, comté-county (Correction).1763 "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.