Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 décembre 1969, samedi 13 (no 50)
[" 101' ANNÉE VOL.101 t 2UEBEC N» 50 6871 -ÎUEBEC kzette officielle à Québec QUEBEC OFFICIAL A Z E T T E Québec, samedi 13 décembre 1969 Règlements Is Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazette officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paie-uicnt sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, December 13, 1969 I Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is sub-ect to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officia du Québec, ROCH LEFEBVRE, Québec Officiai Publuher 6872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° «50 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 35 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 15 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $4 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocn Lefebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1969 Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 35 cents per agate line, for cacli version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 15 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $4 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, $20; April 1st to December 31st, $15 and July 1st to December 31st, $10.N.B.\u2014 Key to figures beliow notces: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying I he first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Roch Lefebvre, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, April 30, 1969 27440 \u2014 l-52-o Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis No 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107).Lettres patentes Agence de Voyages A.L.I, ltée A.L.I.Travel Agency Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour «l'octobre 1969, constituant en corporation: Abraham Gurman, 80, chemin Holtham, Hampstead, Stephen Marcovitch, 260, boulevard Alexis-Nihon, Saint-Laurent, tous deux avocats, et Muriel Kcanc, secrétaire, célibataire, 7425, avenue Querbes, appartement 9, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'une ugence générale de billets et bureau de voyage dans toutes ses spécialités, sous le nom de « Agence «le Voyages A.L.L ltée \u2014 A.L.I.Travel Agency Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre de* institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.32147 4849-69 Gérard Allard inc.Avis est donné «m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en tlate du 3e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gérard Allard, constructeur, Aurore Boudreau, veuve de Roméo Letters Patent Agence de Voyages A.L.L ltée A.L.I.Travel Agency Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th «lay of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Abraham Gurman, 80 Holtluim Road, Hampstead, Stephen Marcovicth, 260 Alexis Ni lion Boulevard, Saint-Laurent, both advocates, and Muriel Keane, secretary, spinster, 7425 Qucrbes Avenue, Apartment 9, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a general ticket agency and travel bureau in all its branches, under the name of \"Agence de Voyages A.L.I, ltée \u2014 A.L.L Travel Agency Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-PiiiLii'pe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Coopérât iff-32147-o 4849-69 Gérard Allard inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérard Allard, constructor, Aurore Boudreau, widow of Roméo Allard, and Annette QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 6873 Allard, et Annette Allard, épouse de Jasmin Portier, ces deux dernières ménagères, tous trois de 220, 13e avenue sud, Sherbrooke, pour les objets suivants: l'aire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de < Gérard Allard inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.l.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4788-69 Association des Propriétaires de Camions du Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième IKirtie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Olivier Tremblay, Saint-Siméon, Ulysse Tremblay.Clermont, Doria Laforest, Aima, tous trois camionneurs, et Oscar Tellier, agent d'affaires, 2133, des Ormeaux, Shawinigan, pour les objets suivants: Grouper les propriétaires de camions de province et promouvoir leurs intérêts culturels et sociaux, sous le nom de « Association des Propriétaires de Camions du Québec inc.».I* montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $1,000.Le siège social de la corporation est à Québec, district judiciaire de Québec.Le snus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.:12II7-o 5198-69 Les Assurances Henri Casault inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Henri Casault, 266, .île rue ouest, Réjean Tardif, 169, 47e rue est, tous deux courtiers d'assurances, et Jacques Dorion, comptable, 565, De Chantel, tous trois de Cliarlesbourg, pour les objets suivants: l'uirc affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom de « Lea Assurances Henri Casault inc.», avec un capital total de $60.000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 cliucunc.Le siège social de la compagnie est 4471, Ire avenue, Charlesbourg, district juduciaire de Québec.If sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4918-69 Assurances Marcel Payette inc.- Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Râtelle, 71, Allard, wife of Jasmin Fortier, the latter two housewives, all three of 220,13th Avenue South, Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as constructors and general building contractors and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Gérard Allard inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4788-69 Association des Propriétaires de Camions du Québec inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Olivier Tremblay, Saint-Siméon, Ylysse Tremblay, Clermont, Doria Laforest, Alma, all three truckers, and Oscar Tcllier, business agent, 2133 des Ormeaux, Shawinigan, for the following purposes: To group together the truck owners of the Province and to promote their cultural and social interests, under the name of \"Association des Propriétaires de Camions du Québec inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $1,000.The head office of the corporation is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 5198-69 Les Assurances Henri Casault inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Henri Casault, 266, 54th St.West, Réjean Tardif, 169, 47th St.East, both insurance brokers, and Jacques Dorion, accountant, 565 Dc Chantel, all three of Charlesbourg, for the following purposes: To carry on business as insurance agents and brokers, under the name of \"Les Assurances Henri Casault inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 4471, 1st Ave., Charlesbourg, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4918-69 Assurances Marcel Payette inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Râtelle, 71 Juge-Guibault, 6874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 10V année, n' 60 Jugc-Guibault, Luc Râtelle, tous deux avocats, et Nicole Râtelle, professeur, épouse de Gilles Pelletier, ces deux derniers de 684, De Lanau-dière, tous trois de Joliettc, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom de « Assurances Marcel Payette inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 50 actions ordinaires de $100 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 565, Archam-bault, Joliettc, district judiciaire de Joliettc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4248-69 Au Coin du Tapis inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean-Guy Hudon, représentant, boulevard Pie XI, Montréal, Michel Hudon, dessinateur, chemin Lavaltrie, Sherbrooke, Armand Hudon, gérant, Carmen B.Hudon, ménagère, épouse dudit Armand Hudon, Jean-Pierre Hudon, étudiant, André Hudon, réceptionniste, Nicole Hudon, Suzanne Hudon, toutes deux filles majeures, et Normand Hudon, ces trois derniers commis, ces sept derniers de 69, St-Roch, Chicoutimi-Nord, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous produits, articles et marchandises, sous le nom de « Au Coin du Tapis inc.», avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune, 900 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées classe «11» «le $1 chacune.Le siège social «le la compagnie est 69, St-Roch, Chicoutimi-Nor«l, district judiciaire de Chicou-timi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4751-69 Autobus scolaires de Levis inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Henri Beaudry, 159, Principale, Saint-Romuald-d'Etchcmin, Pnul Mercure, 1351, Maguire, Sillery, tous deux avocats, et Jean Beaudry, stagiaire, 876, Paradis, Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom «le « Autobus scolaires de Lévis inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Lévis, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4987-69 B.J.M.ventilation inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres Luc Râtelle, both advocates, and Nicole Râtelle, professor, wife of Gilles Pelletier, the latter two of 684 De Lanaudière, all three of Jolictte, for the following purposes: To carry on business as insurance agents and brokers, under the name of \"Assurances Marcel Payette inc.\", with a total capital stock of $40,000 divided into 50 common shares of $100 each ami into 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 565 Archambault, Jolictte, judicial district of Joliettc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4248-69 Au Coin du Tapis inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 20th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Guy Hudon, representative, Pie XI Boulevard, Montreal, Michel Hudon, draftsman, Lavaltrie Road, Sherbrooke, Armand Hudon, manager, Carmen B.Hudon, housewife, wife of said Armand Hudon, Jean-Pierre Hudon, student, André Hudon, receptionist, Nicole Hudon, Suzanne Hudon, both spinsters of the full age of majority, and Normand Hudon, the latter three clerks, the latter seven of 69 St-Rocli, Chicoutimi North, for the following purposes: To deal in all products, articles and merchandise, under the name of \"Au Coin du Tapis inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $10 each, 900 preferred class \"A\" shares of $10 each and into 1,(100 preferred class \"B\" shares of $1 each.The head office of the company is at 69 St-Roch, Chicoutimi North, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4751-69 Autobus scolaires de Levis inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Henri Beaudry, 159 Principale, Saint-Romuald-d'Etchemin, Paul Mercure, 1351 Maguire, Sillery, both advocates, anil Jean Beaudry, articled student, 876 Paradis, St.Foy.for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Autobus scolaires de Lévis inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Levis, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4987-00 B.J.M.ventilation inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing datt the 17th day of October, 1969, liave been tolled QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 6875 patentes, en date du 17e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Coulombe, avocat, 874, Kennedy nord, Françoise Fouquet, 1011, McManamy, et Nicole Gingras, 777, Victoria, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire le commerce, la réparation et l'entretien de tout équipement et appareils de ventilation et de refroidissement de quelque genre que ce soit, sous le nom de « B.J.M.ventilation inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 1158, Montée-de-Liesse, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 5013-69 Babin Construction inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Perreault, 2968, de Francheville, Yvon Martincau, 1695, Place Gaudet, tous deux de Trois-Rivières, et Guy St-Onge, 521, Lacerte, Trois-Rivières-Ouest, tous trois comptables, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Babin Construction inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Trois-Rivières-Ouest, district judiciaire de Trois-Rivières./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4713-69 Itarbcuu, Bilodeaii, Thivicrgc & associés inc.Barbeau, Bilodeau, Thivierge & Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Pierre Barbeau, courtier d'assurance, Place Quatre Vents, Saint-I;élix-du-Cap-Rouge, Matte Bilodeau, assureur-vie, 8480, de Longchamps, Charlesbourg, et Dame Ghislaine Ouellet, secrétaire, épouse de Michel Ouellet, 21, Boisjoli, Saint-Romuald-d'Etchemin, pour les objets suivants: Agir comme agents et courtiers en assurance, sous le nom de « Barbeau, Bilodeau, Thivierge & associés inc.\u2014 Barbeau, Bilodeau, Thivierge & Associates Inc.», avec un capital divisé en 500 actions ordinaires sans valeur nominale.I.e siège social de la compagnie est 2700, boulevard Laurier, suite 70S, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32117-0 4763-69 by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Coulombe, advocate, 874 Kennedy North, Françoise Fouquet 1011 McManamy, and Nicole Gingras, 777 Victoria, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, all three of Sherbrooke, for the following purposes : To deal, repair and maintain all ventilation and cooling equipment and apparatus of whatever nature, under the name of \"B.J.M.ventilation inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 1158, Montée deLiesse, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 5013-69 Babin Construction inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Perreault, 2968 de Franche-ville, Yvon Martineau, 1695 Place Gaudet, both of Trois-Rivières, and Guy St-Onge, 521 Laccrte, Trois-Rivières-West, all three accountants, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Babin Construction inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of $10 each and 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Trois-Rivières-West, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4713-69 Barbeau, Bilodeau, Thivicrgc & associés inc.Barbeau, Bilodeau, Thivierge & Associates Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Barbeau, insurance broker, Place Quatre Vents, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, Matte Bilodeau, life insurer, 8480 de Longchamps, Charlesbourg, and Dame Ghislaine Ouellet, secretary, wife of Michel Ouellet, 21 Boisjoli, Saint-Romuald-d'Etchemin, for the following purposes: To carry on business as insurance agents and brokers, under the name of \"Barbeau, Bilodeau, Thivierge & associés inc.\u2014 Barbeau, Bilodeau, Thivierge & Associates Inc.\", with a capital stock divided into 500 common shares without nominal value.The head office of the company is at 2700 Laurier Boulevard, Suite 708, St.Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4763-69 6876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° 60 Barbo Agencies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Maurice Baron, administrateur, 326, Alexis Nihon, David I.Schatia, 7025, chemin Clover, tous deux de Montréal, et Larry S.Sazant, 40, Maisonncuve Drive, Dollard-des-Ormeaux, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: La confection et le commerce de vêtements et accessoires vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de « Barbo Agencies Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et 390 actions privilégiées de $100 chacune._ Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.32147 5092-69 Barbo Agencies Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Maurice Baron, executive, 326 Alexis Nihon, David I.Schatia, 7025 Clover Road, both of Montreal, and Larry S.Sazant, 40 Maisonneuve Drive, Dollard-des-Ormeaux, the latter two advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Barbo Agencies Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phimppk Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-0 5092-09 Basma Construction inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Guy Main ville, administrateur, 33, Upper Trafalgar, Paul Verner, comptable agréé, 1227, Sherbrooke ouest, tous deux de Montréal, et André Basticn, entrepreneur, Chemin Lac Rennud, Sainte-Adèle, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Bnsma Construction inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sainte-Adèle, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 3657-69 Hasina Construction inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy Mainville, executive, 33 Upper Trafalgar, Paul Vcrner, chartered accountant, 1227 Sherbrooke West, both of Montreal, and André Basticn, contractor, Lac Renaud Road, Sainte-Adèle, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Basma Construction inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Sainte-Adèle, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 3657-69 Beautiful People Handicrafts Boutique Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de septembre 1969, constituant en corporation: José Essebag, apprê-teur du cuir, Theresa Dussault, ménagère, épouse de Serge Dussault, tous deux de 4565,-rue Hutchison, app.3, Montréal, et Hersh Bilerman, gérant de ventes, 5761, chemin côte Saint-Luc, 1 lamps-tend, pour les objets suivants: Confectionner toutes sortes d'articles vestimentaires, en faire le commerce, sous le nom de « Beautiful People Handicrafts Boutique Inc.», avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 3818, boulevard Perron, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4722-69 Beautiful People Handicrafts Boutique lue.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: José Essebag, leather worker, Theresa Dussault, housewife, wife of Serge Dussault, both of 4565 Hutchison Street, Apt.3, Montreal, and Hcrsh Bilerman, sales manager, 5761 Côte St.Luc Road, Hampstead, for the following purposes: To manufacture anil deal in wearing apparel of all kinds, under the name of \"Beautiful People Handicrafts Boutique Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 3SIS Perron Boulevard, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-0 4722-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 6877 La Bergerie de St-André inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Latour, courtier d'assurance, 37, St-Eustache, Yvon Désor-meaux, étudiant, 134, 2e avenue, et Nicole Nicolas, secrétaire, fille majeure, 360, St-Eusta-chc, tous trois de Saint-Eustache, pour les objets suivants: Exploiter une entreprise agricole et un verger, sous le nom de « La Bergerie de St-André inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-André-d'Argenteuil, district judiciaire de Terre-lioime.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIlLlPPE BOUCIIAUD.32l47-o 3715-69 La Bergerie de St-André inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Latour, insurance broker, 37 St-Eustache, Yvon Désormcaux, student, 134 2nd Ave., and Nicole Nicolas, secretary, spinster of the full age of majority, 360 St-Eustache, all three of Saint-Eustache, for the following purposes: To operate an agricultural business and an orchard, under the name of \"La Bergerie de St-André inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Saint-André-d'Argenteuil, judicial district of Terrebonne.Ls-PllILH'PK BOUCHARD, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 3715-69 Roy R.Billing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de juin 1969, constituant en corporation: Roy Billing, homme d'affaires, Shirley Billing, ménagère, épouse dudit Roy Billing, tous deux de St-Elie-d'Orford, cl Nelson Richards, contremaître, Birchton, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de « Roy R.Billing Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Elie-d'Orford, district judiciaire-de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 2897-69 CD.Bilodeau électrique inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Clément Bilodeau, homme d'affaires, Françoise Danis, ménagère, épouse dudit Clément Bilodeau, tous deux de 461.Hostonnais, Denis Bilodeau, homme d'affaires, et Cécile Pothier, ménagère, épouse dudit Denis Bilodeau, ces deux derniers de 425, St-\u2022loseph, tous quatre de La Tuque, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs-électriciens et faire le commerce d'appareils électriques de toutes sortes, sous le nom de « CD.Bilodeau électrique inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 546, rue St-Antoine, La Tuque, district judiciaire de Saint-Maurice.If sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32117-0 5188-69 Roy R.Billing Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of June, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roy Billing, businessman, Shirley Billing, housekeeper, wife of the said Roy Billing, both of Saint-Elie-d'Orford, and Nelson Richards, foreman, Birchton, for the following purposes: To carry on business as builders and contractors, under the name of \"Roy R.Billing Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each._ The head office of the company is at Saint-Élie-d'Orford, judicial district of Saint-François.Ls-Puilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-o 2897-69 CD.Bilodeau électrique inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Clément Bilodeau, businessman, Françoise Danis, housewife, wife of said Clément Bilodeau, both of 464 Bostonnais, Denis Bilodeau, businessman, and Cécile Pothier, housewife, wife of said Denis Bilodeau, the latter two of 425 St-Joseph, all four of La Tuque, for the following purposes: To carry on business us electrical contractors and to deal in electrical appliances of all kinds, under the name of \"CD.Bilodeau électrique inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 456 St-Antoine Street, La Tuque, judicial district of Saint-Maurice.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 5188-69 6878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° 60 Boulevard Delicatessen inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Louis-A.Toupin, 3455, McCarthy, Saint-Laurent, Adrien-R.Pa-quette, 212, Bloomfield, Outremont, François Perreault, 5305, Churchill, tous trois avocats, et Micheline 1 .amoureux, secrétaire, épouse de Jean-Pierre Lamoureux, 2265, Sauriol est, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Boulevard Delicatessen inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $5 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Léonard, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-o 4996-69 Bouthillette électrique inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Denis Brassard, 9250, De Ségur, Saint-Léonard, Bernard Roy, 81, Beau Lieu, Val-Morin, tous deux avocats, et Paul Laframboise, ingénieur, 535, Lartigue Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en électricité, sous le nom de « Bouthillette électrique inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune, 100 actions privilégiées classe « A » de $100 chacune et en 2,000 actions privilégiées classe « B » de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Waterloo, district judiciaire de Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4875-69 Guy Broquet maçonnerie inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'août 1969, constituant en corporation: Guy Broquet, maçon, Mauricette Legrand, ménagère, épouse dudit Guy Broquet, tous deux de 2480, boulevard Gouin est, Montréal, et René Legrand, rentier, 190, boulevard Ducharme, Blainville, pour les objts suivants: Faire affaires comme compagnie de construction, de maçonnerie, de développement général, de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de « Guy Broquet maçonnerie inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 2480, boulevard Gouin est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4008-69 Boulevard Delicatessen inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis-A.Toupin, 3455 McCarthy, Saint-Laurent, Adrien-R.Paquette, 212 Blooiii-field, Outremont, François Perreault, 5305 Churchill, all three advocates, and Micheline Lamoureux, secretary, wife of Jean-Pierre Lamoureux, 2265 Sauriol east, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Boulevard Delicatessen inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $5 each and 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Sainl-Léonard, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4996-09 Bouthillette électrique inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Denis Brassard, 9250 De Ségur, Saint-Léonard, Bernard Roy, 81 Beau Lieu, Val-Morin, bolh advocates, and Paul Laframboise, engineer, 535 Lartigue, Laval, for the following purposes: To carry on business as electrical contractors, under the name of \"Bouthillette électrique inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each, 100 preferred class \"A\" shares of $100 each and into 2,000 preferred class \"B\" shares of $10 each.The head office of the company is at Waterloo, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4875-69 Guy Broquet maçonnerie inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of August, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy Broquet, mason, Mauricette Legrand, housewife, wife of said Guy Broquet, both of 2480 Gouin Boulevard East, Montreal, and René Legrand, annuitant 190 Ducharme Boulevard, Blainville, for the following purposes: To carry on business as a construction, masonry, general development, holding and investment company, under the name of \"Guy Broquet maçonnerie inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 24S0 Gouin Boulevard East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4008-6'.) QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.60 6879 Brumard inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Pierre Simard, 380, des Franciscains, Québec, Pierre Brunelle, 3785, lo Corbusier, Sainte-Foy, tous deux industriels, et Serge Vermette, avoct, 377, des Franciscais, Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme fleuristes, pépiniéristes et cultivateurs de graines, sous le nom de « Brumard inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 330, des Franciscains, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 5022-69 Bureau de Développement Economique de Thetford Mines inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Christian Beaudoin, 694, St-Patrick, Pierre Paradis, 440, 7e rue, tous deux avocats, et .Marie-Reine Dionne, secrétaire, fille majeure, 285, Notre-Dame nord, tous trois de Thctford-Mines, pour les objets suivants: Promouvoir, encourager et développer l'économie de la région de Thetford Mines, sous le nom de « Bureau de Développement Économique de Thetford Mines inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $200,000.Le siège social de la corporation est à Thetford Mines, district judiciaire de Mégantic.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32117-0 4977-69 Camions Sud inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean-G.Audcttc, industriel, 11285, Pasteur, Montréal, Yves l'oliquin, gérant de transport, 222, Louis-Joseph Lafortune, Bouclierville, et Pierre St-Picrrc, avocat, 139, de Touraine, Saint-Lambert, pour les objets suivants: fabriquer et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Camions Sud inc.», avec un capital divisé en 400 actions sans valeur nominale.Le siège social de la compagnie est à Lon-gueuil, district judiciaire de Montréal, /.r sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147m 4654-69 Canabel inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres Brumard inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Simard, 380 des Franciscains, Quebec, Pierre Brunelle, 3785 Le Corbusier, Sainte-Foy, both industrialists, and Serge Vermette, advocate, 377 Des Franciscains, Québec, for the following purposes: To carry on business as florists, nurserymen and seed growers under the name of \"Brumard inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 330 Des Franciscains, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Inslitulio?is, Companies and Cooperatives.32147 5022-69 Bureau de Développement Economique de Thetford Mines inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Christian Beaudoin, 694 St-Patrick, Pierre Paradis, 440, 7th St., both advocates, and Marie-Rcinc Dionne, sccetary, spinster of the full age of majority, 285 Notre-Dame north, all three of Thetford Mines, for the following purposes: To promote, encourage and develop the economy of the Thetford Mines area, under the name of \"Bureau de Développement Économique de Thetford Mines inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $200,000.The head office of the corporation is at Thetford Mines, judicial district of Mégantic.Ls-Phillippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Inslitutiotis, Companies and Cooperatives.32147 4977-69 Camions Sud inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-G.Audette, industrialist, 11285 Pasteur, Montreal, Yves Poliquin, transport manager, 222 Louis-Joseph Lafortune, Boucher-ville, and Pierre St-Pierre, advocate, 139 de Touraine, Saint-Lambert, for the following purposes: To manufacture and deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Camions Sud inc.\", with a capital stock divided into 400 shares of no nominal value.The head office of the company is at Longucuil, judical district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4654-69 Canabel inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of October, 1969, have been issued 6880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n\" 60 patentes, en date du 15e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Daniel Bocqué, entrepreneur, Alice Doignon, agent, veuve de Joseph Bocqué, tous deux de 9128, 15e avenue, Montréal, et Suzanne O'Brien, secrétaire, fille majeure, 9084, rue Chambellé, Saint-Léonard, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction, de placement et de portefeuille (holding), sous le nom de « Canabel inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4107-69 by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Daniel Bocqué, contractor, Alice Doignon, agent, widow of Joseph Bocqué, both of 9128, 15th Ave., Montreal, and Suzanne O'Brien, secretary, spinster of the full age of majority, 9084 Chambellé St., Saint-Leonard, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction, investment and holding company, under the name of \"Canabel inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4107-69 L.R.Cam in & associés inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Louis-René Cantin, 3341, La Chesnaie, André Jobin, 709, Colonel Jones, tous deux commerçants, Jacques-R.Géli-nas, comptable agréé, 3092, de la Paix, tous trois de Sainte-Foy, et J.-Arthur Gélinas, administrateur agréé, 1190, de Lorraine, Québec, pour les objets suivants: Agir comme conseillers en administration et conseillers financiers, sous le nom de « L.R.Cantin & associés inc.», avec un capital total de $250,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune, 15,000 actions privilégiées de classe « A » d'une valeur nominale de $10 chacune et en 9,000 actions privilégiées de classe « B » d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 155, Marie-de-l'Incarnation, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-o 5054-69 L.R.Cantin & associés inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis-René Cantin, 3341 La Chesnaie, André Jobin, 709 Colonel Jones, both traders, Jacques-R.Gélinas, chartered accountant.3092 de la Paix, all three of Ste-Foy, and J.-Arthur Gélinas, chartered administrator, 1190 De Lorraine, Québec, for the following purposes: To act as management consultants and financial advisers, under the name of \"L.R.Cantin & associés inc.\", with a total capital stock of $250,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of $10 each, 15,000 class \"A\" preferred shares of a nominal value of $10 each and 9,000 class \"B\" preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 155 Marie-de-l'Incarnation, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 5054-69 Cari-All inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Albert Bissonnette, avocat, 2, avenue Brynmor, Montréal-Ouest, Kathleen Higgins, 439, avenue Grosvenor, Westmount, et Françoise Bourbeau, 3, Place Bellerive, Laval, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Faire le commerce de machinerie, outillage et équipement servant à la manutention, l'étalage et le transport de produits alimentaires, sous le nom de « Cari-All inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal-Est, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4944-69 Cari-All inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Albert Bissonnette, advocate, 2 Brynmor Avenue, Montreal-West, Kathleen Higgins, 439 Grosvenor Avenue, Westmount.and Françoise Bourbeau, 3 Bellerive Place, Lavai, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To deal in machinery, tools and equipment used in handling, display and transport of food products, under the name of \"Cari-All inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal-East, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4944-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December IS, 1969, Vol.101, No.60 6881 Centre du Bon Marché (Thetford Mines) inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres palentes, en date du 16e jour d'octobre 1969, constituant enn corporation: Gaston Dubois, marchand, Marie-Jeanne Bilodeau, gérante, épouse dudit Gaston Dubois, tous deux de Thetford Mines, et Diane Gagnon, secrétaire, épouse de Roland Moore, Black-Lakc, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce des vêtements et tissus de toutes sortes, sous le nom de « Centre du Bon Marché (Thetford Mines) inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $50 chacune et en 400 actions privilégiées de $50 chacune.Ioration: David Segal, pharmacien, Rcisha Bar/.a, ménagère, épouse dudit David Segal, tous deux du 6770 «le Vimy, et Sarah Herman, ménagère, épouse «le Dennie Segal, 5367, avenue Prince of Wales, tous trois de Montréul, pour les objets suivants: S'établir compagnie d'immeubles, sous le nom de « Day's Realties Ltd.», avec un cupital total dc 840,000, divisé en 500 actions ordinaires dc S10 chacune et 3,500 actions privilégiées «le S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 3723, boulevard Saint-Laurent, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4632-69 Delta aviation Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province u accordé des lettres patentes, en date «lu 14c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Robert Sl-Laurcnt, commerçant, Yvonne Rusnell, ménagère, épouse dudit Robert St-Laurcnt, tous deux «le 3418, «les Bois, Saintc-Foy, et André Tunnel, gérant, rue Beauvillc, Ncufchntcl, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vaisseaux aériens, uéropluncs, bipluns, machines et appareils «le vol, hydravions ou automobiles, sous le nom «le « Delta aviation inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc 810 chacune et en 200 actions privilégiées dc $100 chacune.The head office of the company is ut 21 Radncr Street, Cup-de-la-Mudeleine, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ins.32147 5001-69 Daroc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incoriwrating: Gilles Coulombe, advocate, 871 Kennedy North, Françoise Fouquet, secretary, spinster of the full age of majority, 1011 McManamy, and Carole St-Roch, secretary, wife of Jean-Guy St-Roch, 1060 Fédéral, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To deal on all kinds of products, articles or goods, under the name of \"Daroc inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into I.(Hill common shares of SI each, 3,700 class \".V\" preferred shares of 810 each and 2.000 class \"II\"' preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 11.VI Sherbrooke East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 5012-09 Day's Realties Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: David Segal, pharmacist, Rci.sha Bar/.a, housewife, wife of the said David Segal, both of 6770 dc Vimy, and Sarah Herman, housewife, wife of Dennic Segal, 5367 Prince of Wales Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real oslulc company, under the name of \"Duy's Realties Ltd.\", with a total cupital stock of $40,0(10.divided into 500 common shurcs of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 372:i St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-0 4632419 Delta aviation Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of October, 1969, have been issued by the Licutenunt-Govcrnor of the Province, incorporating: Rolicrt St-Luurent, trader, Yvonne Rusnell, housewife, wife of the said Robcrl St-Laurcnt, both of 3418 des Bois, St.Foy, and André Tunnel, manager, Bcauville Street, Ncuf-chatel, for the following purposes: To manufacture and deal in airships, aircraft-, biplanes, flying machines and appliances, seaplanes or automobiles, under the name of \"Delia aviation inc.\", with a total capital slock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December IS, 1969, Vol.101, No.60 6889 Le siège social tic la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec./.oscs: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Elvi liée\", with a total capital stock of $60,000.divided into 10,000 common shares of a nominal value of 81 each and 10,000 preferred shares of a nominal value of 85 each.The head office of the company is at 7780 des Cascades St., Saint Hyacinthe, judicial district of Saint Hyacinthe.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instituions, Companies and Coopératives.32147 4642-69 Ixs Entreprises Cardon inc.Avis est donné qu'en vertu de la première |>arlie dc la Loi des compagnie*, le lieutcnant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gérard Nadon, restaurateur, Normand Cartier, vendeur, et Claude Nadon, cuisinier, tous trois de Saint-Sauvcur-des-Monts, pour les objets suivants: Paire le commerce dc tous produits, articles et marchandises et faire affaires comme compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom dc \u2022 Les Entreprises Cardon inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Ia:s Entreprises Cardon inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dutc the 20th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérard Nadon, restaurant-keeper, Normand Cartier, salesman, and Claude Nadon.cook, all three of Saint-Sauvcur-des-Monts, for the following purposes: To deal in all products, goods and merchandise and to carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les Entreprises Cardon inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 300 preferred shares of $100 each. 6892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 19G9, 101' année, «° 50 Le siège social orating: Bertrand Rioux, trader, Mariette Lapninlo, housewife, wife of said Bertrand Rioux, both of 406 Cité Jardin, and Louise Rioux, secretary, spinster of the full age of majority, 175 St-Picrre, all three of Matanc, for the following purposes : To carry on business us a real estate and construction company, under the name of \"Habitat G898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n\" 50 tane inc.», avec un capital total de SI00,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Matanc, district judiciaire de Rimouski.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4590-69 Matane inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 common shares of $100 each.The head office of the company is at Matanc, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4590-69 H6lcl Union d'Alma (1969) inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 6c jour il'octobre 1969, constituant en corporation: Laurier Gcncst, homme d'affaires, Jeannette Abud, ménagère, épouse dudit Laurier Gcncst, tous deux île route St-Bruno, et Lucien Boivin, gérant, 514, rue St-Joscph ouest, tous trois d'Alma, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Hôtel Union d'Alma (1969) inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Ia: siège social dc la compagnie est à Aima, district judiciaire de Robcrval.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4850-69 Hôtel Union d'Alma (1969) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Laurier Genest, businessman, Jeannette Abud, housewife, wife of said Laurier Genest, both of St-Bruno Route, and Lucien Boivin, manager, 514 St-Joseph Street West, all three of Alma, for the following purposes: To o]>crate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Hôtel Union d'Alma (1969) inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares of S10 each and into 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Alma, judicial district of Robcrval.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4850-69 Hyberbiand inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur île la province a accordé des lettres patentes, en date du Se jour d'octobre 1969, constituant en corporation: André Valiquette, 59, Franklin, Guy-F.Gervais, 223, Lazard, tous deux dc Mont-Royal, et Michel Duranceau, 5775, Darlington, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de construction et de placement, sous le nom de « Hyberbiand inc.», avec un capital total dc $150,000, divisé en 5,000 actions ordinaires dc SI chacune et en 145,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social île la compagnie est 182, rue Michel Peltier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phii.ippe Bouchard.32147-d 4554-69 Hyberbiand inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dntc the 8th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André Valiquette, 59 Franklin, Guy-F.Gervais, 223 Lazard, both of Mount Royal, and Michel Duranceau, 5775 Darlington, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a construction and investment company, under the name of \"Hyberbiand inc.\", with a total capital stock of SI50,000.divided into 5,000 common shares of SI each anil into 145,000 preferred shares of SI each.The head olficc of the company is at 182 Michel Peltier Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.32147 4551-69 Ilymm- Holding Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu île la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé îles lettres patentes, en date du 18c jour de septembre 1969, constituant en corporation: Louis Orenstein, 5654, avenue MacDonald, Hampstead, Jason Ruby, 47, place du Bois, Dollard-des-Ormeaux, John Michelin, 5754, rue Lockwood, tous trois avocats, et Glacia Miller, secrétaires, célibataire, 3201, avenue Forest Hill, ces deux derniers de Montreal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de « Hymur Holding Co.Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et 600 actions privilégiées de S50 chacune.Hymur Holding Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Orenstein, 5654 MacDonald Avenue, Hampstead, Jason Ruby, 47 Place_du Bois, Dollard-des-Orincaux, John Michelin.5754 Lockwood Street, all three advocates, and Glacia Miller, secretary, spinster, 3201 Forest Hill Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes: To curry on the business of a holding company, under the name of \"Hymur Holding Co.Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 000 preferred shares of 850 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.60 0899 Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 .4479-69 Les Immeubles Adalbert Cyr inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Adalbert Cyr, commerçant, May Cormier, ménagère, épouse dudit Adalbert Cyr, et Evangeline Whitton, secrétaire, épouse de Fcrnand Wbitton, tous trois de Bona-venture, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom de « Les Immeubles Adalbert Cyr inc.», avec un capital total de S75.000, divisé en 750actions ordinaires dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Bona-venturc, district judiciaire de Bonavcnture.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-o 4611-69 The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-o 4479-69 Les Immeubles Adalbert Cyr inc.Notice is given that under Part -I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Adalbert Cyr, trader, May Cormier, housewife, wife of the said Adalbert Cyr, and Evangeline Wbitton, secretary, wife of Fcrnand Whitton, all three of Bonaventurc, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Les Immeubles Adalbert Cyr inc.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 750 common shares of $100 each.The head office of the company is at Bonavcnture, judicial district of Bonavcnture.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4611-69 Imprimeur & Lithographe Andco ltée Andco Printer & Litographer Ltd.Avis est donné (m'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean-Marc Nantcl, 175, boulevard Longpré, J.-Hcrvé Dépcltcau, 105, rue Seville, et Pierre Audcltc, 6100, rue Sorel, tous trois hommes d'affaires, de Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs et entrepreneurs en publicité, sous le nom de « Imprimeur & Lithographe Andco ltée \u2014 Andco Printer & Lithographer Ltd.», avec un capital total dc $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.l.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4878-69 Imprimeur & Lithographe Andco ltée Andco Printer & Litographer Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Marc Nantel, 175 Longpré Blvd., J.-Hervé Dépclteau, 105 Seville St., and Pierre Audette, 6100 Sorel St., all three businessmen, of Laval, for the following purposes: To carry on business as printers and advertising contractors, under the name of \"Imprimeur & Lithographe Andco ltée \u2014 Andco Printer & Lithographer Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4878-69 Independent Electric Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Adrien-R.Paquettc, avocat, 212, Bloomfield, Outremont, Benoit Rivet, stagiaire, 4370, Brébcuf, et Gisèle Tourville, secrétaire, fille majeure, 3241 Forest Hill, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs électriciens cl faire le commerce et l'entretien dc toutes sortes d'appareils et accessoires électriques, sous le nom de « Independent Electric Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Independent Electric Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Adrien-R.Paquette, advocate, 212 Bloomfield Avenue, Outremont, Benoit Rivet, articled student, 4370 Brébeuf, and Gisèle Tourville, secretary, spinster of the full age of majority, 3241 Forest Hill, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as electrician-contractors and to deal in and maintain all kinds of electrical apparatus and accessories, under the name of \"Independent Electric Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each apd 300 preferred shares of $100 each. 6900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° 60 Le siège sociul de la compagnie est 11S04, Belle-voix, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniLii'pb Bouchard.32147-0 4999-09 The head office of the company is at 11801 Bellevoix, Montreal-North, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4099-0'.i Les Industries P.E.B.liée Avis est donné epi'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Louis Vézina, 1231, Charles Huot, Pierre-F.Pouliot, 1048, Chau-mont, tous deux dc Sillery, et Paul Vézina, 7040, Place Montclair, Charlesbourg, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de tous genres de matériaux, sous le nom dc « Les Industries P.E.B.ltée », avec un capital total dc S200.000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et en 18,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Lac Saint-Charles, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Pmlippe Bouchard.32147-0 4886-69 Les Industries P.E.B.ltde Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Vézina, 1231 Charles Iluot, Pierre-F.Pouliot, 1048 Chaumont, both of Sillery, and Paul Vézina, 7040 Montclair Place.Charlesbourg, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Les Industries P.E.B.ltée\", with a total capital stock of 8200,00(1 divided into 20,000 common shares of 81 each and 18,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Lac Saint-Charles, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies a?id Cooperatives.32147 4886-69 Les Industries Stoke inc.Avis est donné (m'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8c jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Pauline Lacroix, secrétaire, fille majeure, S67, St-Louis, Yves Messier, 725, Cambrai, tous deux dc Sherbrooke, et W.Warren Lynch, 33, Park Lemioxvillc, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom dc «Les Industries Stoke inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 3,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 1,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Stoke, district judiciaire dc Saint-François.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4761-69 Les Industries Stoke inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 8th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pauline Lacroix, secretary, spinster of the full age of majority, 867 St-Louis, Yves Messier, 725 Cambrai, both of Sherbrooke, and W.Warren Lynch, 33 Park, Lennoxvillc, the latter two advocates, for the following purposes: The lumber industry and trade, under the name of \"Les Industries Stoke inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 3,000 common shares of 810 each and 1,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Stoke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4761-09 Institut Leacoin inc.Lcacom Institute Inc.Avis est donné (m'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Ezra Lcithman, Victor Glazer, tous deux avocats, et Dorothy Herman, secrétaire, veuve de Nathan Herman, tous trois de 1255, Carré Phillips, Montréal, pour les objets suivants: Instruire dans les lungues et les méthodes d'enseignement, sous le nom dc « Institut Lcacom inc.\u2014 Lcacom Institute Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 200 actions ordinaires dc S100 chacune et 200 actions privilégiées de S100 chacune.Institut Lcacom inc.Leacom Institute Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Ezra Lcithman, Victor Glazer, both advocates, and Dorothy Herman, secretary, widow of Nathan Herman, all three of 1255 Phillips Square, Montreal, for the following purposes: To provide instruction in languages and methods of teaching, under the name of \"Institul Lcacom inc.\u2014 Leacom Institute Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shnres of 8100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 6901 Le siège social de la compagnie est à Montreal, district judiciaire de Montreal.l.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4960-69 Rémi .loyal inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour dc septembre 1969, (\u2022(instituant en corporation: Rémi Joyal, marchand, Madeleine Joyal, ménagère, épouse dudit Rémi Joyal, tous deux dc Saint-Gérard-Majclla, d Gilles Bélisle, comptable, 148, St-Jcan, Drummondville, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de pain, gâteaux, pâtisseries, et autres articles d'alimentation produits par la cuisson, sous le nom dc « Rémi Joyal inc.», avec un capital total dc S 100,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune et en 7,500 actions privilégiées d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-(iérurd-Majclla, district judiciaire dc Richelieu.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 3646-69 Kénogami Pizza ltée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'octobre 1969, constitutant en corporation: Roland Tremblay, vendeur, Lina Jomphc, ménagre, épouse dudit Roland Tremblay, tous deux de 205, Hudson, Richard Tremblay, gérant, et Pauline Goulet, ménagère, épouse dudit Richard Tremblay, ces deux derniers de 683, St-Michel, tous quatre d'Arvida, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Kénogami Pizza ltée », avec un capital total de 820,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 1S9, rue Sic-Famille, Kénogami, district judiciaire de Chicoutimi.l.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4775-69 The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-0 4960-69 Rémi Joyal inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rémi Joyal, merchant, Madeleine Joyal, housewife, wife of the said Rémi Joyal, both of Saint-Gérard-Majella, and Gilles Bélisle, accountant, 148 St-.Icun, Drummondville, for the following purposes: To manufacture und deal in bread, cake, pastry and other food produced by baking, under the name of \"Rémi Joyal inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 2,500 common shares of a nominal value of 810 each and 7,500 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at Saint-Gérard-Majclla, judicial district of Richelieu.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 3046-69 Kénogami Pizza liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roland Tremblay, salesman, Lina Jomphe, housewife, wife of the said Roland Tremblay, both of 205 Hudson, Richard Tremblay, manager, and Pauline Goulct, housewife, wife of the said Richard Tremblay, the latter two of 6S3 St-Michcl, all four of Arvida, for the following purposes: To carry on business us restaurateurs, under the name of \"Kénogami Pizza ltée\", with a total capital stock of 820,000, divided into 2,000 common shares of 810 each.The hcud office of the company is ut 189 Ste-Famille St., Kénogami, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4775-69 Koscot Distribution Centre of Québec Limited Centre de Distribution Koscot de Québec limitée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Farid A.Cheftcclii, 6950, avenue Fielding, app.615, John Hamilton junior, 5820, de Louisbourg, app.26, et Ruby A.Oxner, 3555, chemin de la côte des Neiges, app.401, tous trois commis légistes, dc Montréul, pour les objets suivants: La fnbrication et le commerce d'articles, produits et marchandises dc toutes sortes, sous le nom de c Koscot Distribution Centre of Québec Limited \u2014 Centre dc Distribution Koscot dc Koscot Distribution Centre of Québec Limited Centre de Distribution Koscot de Québec limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Farid A.Chcftcchi, 6950 Fielding Avenue, Apt.615, John Hamilton junior, 5820 «le Louisbourg, Apt.26, and Ruby A.Oxner, 3555 Côte des Neiges Road, Apt.401, all three law clerks, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in goods, wares and merchandise of all kinds, under the name of \"Koscot Distribution Centre of Québec Limited \u2014 Centre de Distribution Koscot de Québec 6902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, ?i° 60 Québec limitée », avec un capital divisé en 40,000 actions sans valeur au pair.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPF.bouchard.32147 5052-69 limitée\", with a capital stock divided into 40,01)0 shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montrcnl.Ls-Piiilippe Bouciiahi), Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-o 5052-69 Lady Gold Products Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres [latentes, en date du 7c jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Lawrence Schneider-man, gérant dc bureau, 370, Thompson, app.G-25, Saint-Laurent, Jack Schncidcrman, vendeur, 5550, Trent, app.703, Côte Saint-Luc, et Alexander I.Popliger, avocat, 1455 ouest, Sherbrooke, Montréal, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce d'articles, produits et marchandises et accessoires dc toutes sortes, sous le nom dc « Lady Gold Products Inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc $10 chucunc.Le siège social dc la compagnie est 370, boulevard Thompson, app.G-25, Saint-Laurent, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-PlllI.ippe BoUCHAHD.32147 4665-69 Jean Langclicr chaussures liée Jean Langclicr Shoes Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc lu province a accordé des lettres patentes, en date du Se jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean Langclicr, commerçant, 1762, rue Markham, Normand Lcfebvrc, administrateur, et Suzanne Des Chutelcts, sans occupation, épouse dudit Normand Lcfebvre, ces deux derniers dc 52, avenue Russell, tous trois dc Mont-Royal, pour les objets suivants: Fuire le commerce au détail dc chaussures dc toutes sortes, sous le nom dc « Jean Langclicr chaussures ltée \u2014 Jean Langclicr Shoes Ltd.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 390 actions privilégiées d'une valeur nominale dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 659S, rue St-Hubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4887-69 Jacques Larivièrc assurances inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Bernard Desjarlais, 1600, Stephens, Verdun, Louis Vaillancourt, 4519, Oxford, et Roma Cousineau, 5652, Drake, ces deux derniers dc Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents en nssurunce, sous le nom de « Jacques Larivièrc assurances inc.», avec un capitul totul dc Lady Gold Products Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lawrence Schncidcrman, office manager, 370 Thompson, Apt.G-25, Saint-Laurent, Jack Schncidcrman, salesman, 5550 Trent, Apt 703, Côte Saint-Luc, and Alexander I.Popliger, advocate, 1455 Sherbrooke West, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in goods, wares, merchandise and accessories of all kinds, under the name of \"Lady Gold Products Inc.\", with a totul capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 370 Thompson Boulevard, Apt.G-25 Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-0 4665-09 Jean Langclicr chaussures liée Jean Langclicr Shoes Ltd.Notice is given that under Part I of I he Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean Langclicr, trader, 1762 Mnrkham St., Normand Lcfebvrc, administrator, and Suzanne Des Chutelets, unemployed, wife of the said Normand Lefcbvre, the two latter of 52 Russell Ave., all three of Mount-Royal, for the following purposes: To operate a retail business dealing in all kinds of footwear, under the name of \".ban Langclicr chaussures liée \u2014Jean Langclicr Shoes Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a nominal value of $10 each and 390 preferred shures of a nominal value of $100 each.The head office of the company is ut 659S St.Hubert St., Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4SS7-09 Jacques Larivièrc assurances inc.Notice is given that under Part I of I he Companies Act, letters patent, bearing date I he 4 th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Bernard Desjarlais, 1600 Stephens, Verdun, Louis Vaillancourt, 4519 Oxford, anil Roma Cousineau, 5652 Drake, the latter two of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, under the name of \"Jacques Larivièrc assurances inc.\", with a total capital stock of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December IS, 19G9, Vol.101, No.50 6903 S 10,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une videur nominale de SI chacune et en 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de S10 chacune.l.c siège social dc la compagnie est 2365, Springland, Montréal, district judiciaire de Montréal.l.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32M7-0 5308-69 $40,000, divided into 10,000 common shares of a nominal value of $1 each and 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 2365 Springland, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 5308-69 Georges Lasfargues inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Georges Lasfargues, entrepreneur en maçonnerie, Heine Lasfargues, secrétaire, épouse dudit Georges Lasfargues, tous deux de 170, Labrèche, Saint-Jean, et Paul-André Laroche, entrepreneur en maçonnerie, 20, rue Dcluncl, Lacadic, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et dc placement, sous le nom de « (ieorges Lasfargues inc.», avec un capital total de 8-10,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 170, Labrèche, Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Li> sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32I17-0 3714-69 Lcmaro inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé îles lettres patentes, en date du 30c jour dc septembre 1969, constituant en corporation: Alain Létourneau, I1S13, De Tracy, René Roy, 12170, rue James Morrice, tous deux dc Montréal, et André Deniers, 265, River Drive, Saint-Lambert, tous trois avocats, pour les objets suivants: Agir comme conseillers financiers, sous le nom de « Lcmaro inc.», avec un capital total de 810,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et en 360 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 ' 4525-69 Georges Lasfargues inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Georges Lasfargues, masonry contractor, Reine Lasfargues, secretary, wife of the said Georges Lasfargues, both of 170 Lafrcche, St.John's, and Paul-André Laroche, masonry contractor, 20 Deland Street, Lacadie, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Georges Lasfargues inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 200 common shares of S100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 170 Labrèche, St.John's, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 3714-69 Lcmaro inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Alain Létourneau, 11813 De Tracy, René Roy, 12170 James Morrice St., both of Montreal, and André Demers, 265 River Drive, Saint-Lambert, all three advocates, for the following purposes: To act as financial consultants, under the name of \"Lemaro inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $10 each and 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4525-69 Lewis Shoes Limited Chaussures Lewis limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de ln province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: David Terence \"ingle, 561, avenue Lansdowne, Raymond Eric \"arsons, 11, chemin Dc Casson, Michael Dennis, 681, avenue Grosvenor, Charles John Michael Flavell, 4643 ouest, rue Sherbrooke, app.19, tous les quatre de Westmount, Derek Austin Hanson, 987, chemin Moncrieff, Mont-Royal, Lewis Shoes Limited Chaussures Lewis limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: David Terence Dingle, 561 Lansdowne Avenue, Raymond Eric Parsons, 11 De Casson Road, Michael Dennis, 681 Grosvenor Avenue, Charles John Michael Flavell, 4643 Sherbrooke Street West, Apt.19, all four of Westmount, Derek Austin Hanson, 987 Moncrieff Road, Mount Royal, Graham Nesbitt, 1524 Pine 6904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101- année, n° 60 Graham Nesbitt, 1524 ouest, avenue des Pins, app.3, et Richard William Pound, 4530, chemin de la Côte des Neiges, app.1001, ces deux derniers de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: La fabrication et la vente dc chaussures, bottes, articles et accessoires de cuir de toutes sortes et de toute nature, sous le nom de « Lewis Shoes Limited \u2014 Chaussures Lewis limitée», avec un capital-actions divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4883-69 Avenue West, Apt.3, and Richard William Pound 4530 Côte des Neiges Road, Apt.1001, the latter two of Montreal, all advocates, for the following purposes: To manufacture and sell shoes, boots, leallu-r goods and accessories of every kind and nature, under the name of \"Lewis Shoes Limited \u2014 Chaussures Lewis limitée\", with a capital stock divided into 10,000 common shares without nominal or par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-0 48S3-69 Licar Inc.Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Irving I.Finkelberg, avocat, 35, Mcrton Crescent, Hampstead, Rosa Bergman, 2800, Place Darlington, app.21, et Patricia Borlace, 5225, Randall, ces deux dernières secrétaires, célibataires, de Montréal, pour les objets suivants: S'établir compagnie d'immeuble, de construction et dc placement, sous le nom de < Licar Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 39,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.IjC siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippk Bouchard.32147 4920-69 Licar Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 10th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Irving I.Finkelberg, advocate, 35 Mcrton Crescent, Hampstead, Rosa Bergman, 2800 Darlington Place.Apt.21, und Patricia Borlace, 5225 Randall, the latter two secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Licar Inc.\", with a total capital slock of $40.000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 39,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head oflice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32l47-o 492049 La Ligue dc Hockey Intermédiaire Chaudière Etchemin inc.Avis est donné qu'en vertu de lu troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province u accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation suns capital-actions: Robert Boulunger, agent manufacturier, 101), Place du Paysan, Luc Jacques, garagiste, 17, (iravel, tous deux de Saint-Romuuld-d'Etchemin, Sylva Couture, technicien, 532,13c rue sud, Char-ny, Laurent Lacroutz, hôtelier, Saint-Lamliert-dc-Lauzon, Irénéc Samson, électricien, nie Commerciale, Saint-Jean-Chrysostomc, et Gilles Boutin, étudiant, 19, avenue Boutin, Saintc-Hélènc-de-Breakeyvillc, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif, sous le nom de « La Ligue de Hockey Intermédiaire Cliau-dière Etchemin inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels provenant des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est dc $20,000.Ix siège social de la corporation est 100, Place du Paysan, Saint-Romuuld-d'Etchemin, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4646-69 La Ligue dc Hockey Intermédiaire Chaudière Etchemin inc.Notice is given thut under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a corporation without share capital: Robert Boulanger, manufacturing agent.100 Place du Paysan, Luc Jacques, garage-keeper, 17 Gravel, both of Saint-Romualil-d'Etchemin, Sylva Couture, technician, 532, 13th Street South.Charny, Laurent Lucroulz, innkeeper, Saint-Lambert-de-Lauzon, Irenes Samson, electrician.Commerciale Street.Saint-.lean-Chrysostomc, and Gilles Boutin, student.19 Boutin Avenue, Sainte-Hélcne-dc-Breakey-ville, for the following pur|M>ses: To form and operate a sports club, under I he name of \"La Ligue de Hockey Intermédiaire ( 'huudièrc Etchemin inc.\".The amount to which is limited the annual revenue from the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $20.110(1.The head office of the corporation is at 190 Place du Paysan, Saiut-Romuald d'Etchemin, judicial district of Québec.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.32147 4646-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December IS, 1969, Vol.101, No.60 Limagi inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneuT dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Michel Tessier, avocat, Paulctte Gagnon, secrétaire, épouse dudit Michel Tessier, tous deux de 167, rue Hudon, et Maurice Tessier, avocat, 102, rue Tessier, tous trois dc Rimouski, pour les objets suivants: l'aire affaires comme restaurateurs, sous le nom de «Limagi inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Rimouski, district judiciaire dc Rimouski.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4424-69 Mac Callum \u2014 Irving Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Tibor J.Lcbovics, avocat, 1255, rue University, bureau 1527, Montréal.Bluma Lcbovics, secrétaire, épouse dudit Tibor J.Lcbovics, 5791, avenue Trinity, Côte Saint-Luc, et Leonard Simcoe, avocat, 1255, rue University, bureau 1527, Montréal, pour les objets suivants: La confection et le commerce de vêtements et d'accessoires vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de « Mac Callum \u2014Irving Inc.», avec un capital total dc S50.000, divisé en 30 actions, classe « A », de $100 chacune, 30 actions, classe \u2022 Il , de S100 chacune et 440 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.te sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32117 5067-69 Bernard Magnan, incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Georges Hétu, avocat, 6720, Christophe-Colomb, Paul Julien, rentier, 6735, 20e avenue, tous deux de Montréal, et Lise Lcfebvre, technicienne, fille majeure, 642, (iodin, Verdun, pour les objets suivants: l'aire le commerce de tous articles de quincaillerie, accessoires électriques et matériaux dc construction, sous le nom de * Bernard Magnan, incorporée», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune cl en 390 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Blainville, district judiciaire de Terrebonne.l.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32117-0 4658-69 Maison d'Escompte Plessis inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres 6905 Limagi inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Michel Tessier, advocate, Paulette Gagnon, secretary, wife of said Michel Tessier, both of 167 Hudon Street, and Maurice Tessier, advocate, 102 Tessier Street, all three of Rimouski, for the following purposes: To carry on business as restaurant keepers, under the name of \"Limagi inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Rimouski, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4424-69 Mac Callum \u2014 Irving Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Tibor J.Lebovics, lawyer, 1255 University Street, Suite 1527, Montreal, Bluma Lebovics, secretary, wife of the said Tibor J.Lebovics, 5791 Trinity Avenue, Côte Saint-Luc, and Leonard Simcoe, lawyer, 1255 University Street, Suite 1527, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Mac Callum\u2014Irving Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 30 class \"A\" shares of $100 each, 30 class \"B\" shares of $100 each and 440 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-o 5067-69 Bernard Magnan, incorporée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Georges Hétu, advocate, 6720 Christo-phe-Colomb, Paul Julien., annuitant, 0735, 20th Ave, both of Montreal, and Lise Lefebvre, technician, spinster of the full age of majority, 642 Godin, Verdun, for the following purposes: To carry on business dealing in all hardware articles, electrical appliances and building materials, under the name of \"Bernard Magnan, incorporée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Blainville, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4658-69 Maison d'Escompte Plessis inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of October, 1969, have been issued by 0906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 19G9, 101' année, n° 50 patentes, en date du 1er jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Suzanne Labelle, secrétaire, fille majeure, 23, boulevard Kirouac, Jean Gagnon, avocat, 26, boulevard Kirouac, tous deux dc Warwick, et Phil Guillemette, comptable agréé, 1510, avenue Gosselin, Plessis-villc, pour les objets suivants: Faire le commerce de tissus, vêtements et chaussures dc toutes sortes, sous le nom de « Maison d'Escompte Plcssis inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc $10 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur nominale dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Plessis-villc, district judiciaire dc Mégantic.Le sous-ministre de.i institutions financières, compagnies et coopérantes, L.s-PllILlPPE bouchard.32147-0 4753-69 Maniwaki Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en dute du 30e jour de septembre 1969, constituant en corporation: Leonard J.Barrett, 162, Melbourne, Mont-Royal, George W.Wcston, 12140, Jasmin, Montréal, tous deux administrateurs, Sydney Phillips, 5616, avenue Palmer, Wolfe M.Friedman, 5750, avenue Smart, tous crty which the corporation may acquire and possess, is $1,000,000.The head office of the corporation is at Saint-Lambert, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 3860-69 Cluudc et Marcel Martin inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Claude Martin, restaurateur, Lyscttc Farrel, ménagère, épouse dudit Claude Martin, tous deux dc 470, 70c rue, Marcel Martin, homme d'affaires, et Nicole Delisle, ménagère, épouse dudit Marcel Martin, ces deux derniers de 760,Nicollc, tous quatre dc Charlesbourg, pour les objets suivants: l'aire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Claude et Marcel Martin inc.», avec un capital divisé en 100 actions suns valeur nominale cl eu 200 actions privilégiées de $100 chacune.Claude et Marcel Martin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17tll day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorpornting: Cluudc Martin, restaurant keeper, Lyscttc Furrcl, housewife, wife of said Cluudc Martin, both of 470, 70th Street, Marcel Martin, businessman, and Nicole Dclislc, housewife, wife of suid Marcel Martin, the latter two of 760 Nicolle, all four of Charlesbourg, for the following purposes; To carry on business as restaurant keepers, under the name of \"Claude et Marcel Martin inc.\", with a capital stock divided into 100 shares without nominal value and into 200 preferred shares of $100 each. C908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, h' ÔO Le siège social dc la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 5003-69 Maxi-Ko Hmitéc Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean Bilodeau, technicien, 20, Richelieu, Raymond Bilodeau, imprimeur, 154, 18e rue, André Fitzback, professeur, 1460, boulevard Benoît XV, tous trois dc Québec, Lise Boulanger, ergothérapeute, fille majeure, 71, St-Dominiquc, Luuzon, Jacques Deslauricrs, étudiant, 1233, route dc l'Église, Sainte-Foy, Michel Gagné, ingénieur maritime, 4722, Villa St-Vinccnt, Charlesbourg, Lucien Racine, imprimeur, 24, Jacqucs-Bédard, Lac Saint-Charles, et Milford Havens, ingénieur chimiste, 1229, St-Cyrillc ouest, Sillery, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom dc « Maxi-Ko limitée », avec un cupitnl total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires tic $5 chacune et en 2,000 actions privilégiées tic $10 chacune.Le siège social tic la compagnie est 1460, boulevard Benoit XV, Québec, district judiciaire tie Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 3280-69 Les Meubles St-Paul inc.Avis est donné qu'en vertu tie la première partie tic la Loi tics compagnies, le lieutenant-gouverneur tie la province a accordé tics lettres patentes, en date du 23c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Râtelle, 71, Jugc-Guilbault, Luc Râtelle, tous deux avocats, et Nicole Râtelle, professeur, épouse de Gilles Pelletier, ces deux derniers tic 6S4, Dc Lanautlièrc, tous trois de Jolictte, pour les objets suivants: Faire le commerce tic meubles et nouveautés tie toutes sortes, sous le nom dc « Les Meubles St-Paul inc.», avec un capital total tie $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social tic la compagnie est 590, boulevard l'Industrie, Joliette, district judiciaire de Jolictte./«e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippk Bouchard.32147-0 4836-69 Mobec Équipement ltée Avis est tlonné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc lu province a uccordé des lettres putentes, en tinte tlu 7c jour d'octobre 1969, constituunt en corporation : Marcel Paquettc, 2020, Melba, Suint-Bruno-tle-Monturville, Louis-A.Toupin, 3455, McCurthy, Suint-Luurent, tous deux avocats, et Ginette Lafrenière, secrétaire, épouse de Pierre Lafrenière, 7513, Roi René, Anjou, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le The head office of the company is al Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ins.32147 500349 Maxi-Ko limitée Notice is given that under Part I of Hie Companies Act, letters patent, bearing date I ho 24th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean Bilodeau, technician, 2(1 Richelieu, Raymond Bilodeau, printer, là I, 18th Street, André Fitzback, professor, 1400 Benoit XV Boulevard, all three of Québec, Lise Boulanger, \"ergothérapeute\", spinster of I he full age of majority, 71 St-Dominiquc, Lauzon, Jacques Deslauricrs, stutlcnt, 1233 de I'Kglisc Route, Saintc-Foy, Michel Gagné, naval engineer, 4722 St-Vincent Villa, Charlesbourg, Lucien Racine, printer, 24 Jacqucs-Bédard Lac Saint-Charles, and Milford Havens, engineer, chemist, 1229 St-Cyrille West, Sillery, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Maxi-Ko limitée\", with a total capital stock of 840.000, divided into 4,000 common shares of $\"> each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1 lilt I Benoit XV Boulevard, Québec, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 3280-00 Les Meubles St-Paul inc.Notice is given that untler Part I of I lie Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of Octolier, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: (Jilles Râtelle, 71 Jtigc-Guilhaull, Luc Ratclle, both advocates, and Nicole Bali lie, professor, wife of Gilles Pelletier, the latter I wo of 684 De Lanautlièrc, all three of Joliette, for the following purposes: To deal in furniture and novelties of all kinds under the name of \"Les Meubles St-Paul inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is ut 5! HI Industrie Boulevard, Jolictte, judicial district \"f Jolictte.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperative.32147 4836-09 Mnlier Équipement liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date tho 7th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marcel Paquette, 2020 Melba, Saint-Bruno-tle-Montarville, Louis-A.Toupin, 3455 McCarthy, Saint-Laurent, both advocates, and Ginette Lafrenière, secretary, wife of Pierre lafrenière, 7513 Roi René, Anjou, for the following purposes: To carry on business as general building constructors and contractors and to deal in machines, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 6909 commerce dc machines, moteurs, outils, instruments et quincaillerie de toutes sortes, sous le nom de « Mobec Équipement ltée », avec un capital total de 850,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 400 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 11650, boulevard Métropolitain, Montréal-Est, district judiciaire de Montréal./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchai™.32147-0 4669-69 motors, tools, instruments and hardware of all kinds, under the name of \"Mobec Équipement ltée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 11650 Métropolitain Boulevard, Montreal East, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchaiid, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4669-69 Mond Bee inc.Avis est donné qu'en vertu de la première pailie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Raymond Harbcc, comptable, Marguerite Bernard, ménagère, épouse dudit Raymond Harbec.tous deux de 721, rue Elm est.et .lean-Paul Bernard, courtier en assurance, 774, Magenta, tous trois dc Purnham, pour les objets suivants: Exploiter un terrain pour golf miniature et terrain de pratique dc golf, sous le nom dc « Moud Bec inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune cl en 2.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 721, rue Ivhil est, Parnham, district judiciaire de Bedford.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiakd.32147-0 4820-69 Mond Bec inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th clay of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Raymond Harbcc, accountant.Marguerite Bernard, housewife, wife of the said Raymond Harbcc, both of 721 Elm St.East, and Jean-Paul Bernard, insurance broker, 774 Magenta, all three of Farnham, for the following purposes: To operate a miniature golf course and a golf practise range, under the name of \"Mond Bee inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 721 Elm St.East, Farnham, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouciiakd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4820-69 Robert Mont pel it inc.Avis est donné qu'en vertu de la première parlic de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de septembre 1969, constituant en corporation: Robert Montpetit.administrateur, Muriel Montpetit, ménagère, épouse dudit Robert Montpetit, tous deux de 166, (Jaspé, ('hâtcauguay-('entre, et Louis-Paul Nolct.comptable agréé, 3471.Hingston, Montréal, pour les objets suivants: l'aire affaires comme épiciers, sous le nom de Robert Montpetit inc.», avec un capital total de 840,000.divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 200 acl ions privilégiées d'une valeur nominale de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 323, Des ( onimunes.Montréal, district judiciaire de Montréal.l.r sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PllI LIPPE BolCHAHD.32147-0 4493-69 Robert Montpetit inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert Montpetit, administrator, Muriel Montpetit, housewife, wife of the said Robert Montpetit, both of 166 Gaspé, Chûteuu-guay-('entre, and Louis-Paul Nolct, chartered accountant, 3471 Hingston, Montreal, for the following purposes: To carry on business us grocers, under the nunie of \"Robert Montpetit inc.\", with u totul cupitul stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of $10 each and 200 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at 323 Des Communes, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4493-69 Robert Morin inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Robert Morin, camionneur, Madeleine Martel, institutrice, épouse dudit Robert Morin, et Jean-Marie Ouellet, professeur, tous trois dc Maniwaki, pour les objets suivants: Robert Morin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roliert Morin, trucker, Madeleine Martel, teacher, wife of said Robert Morin, and Jean-Marie Ouellet, professor, all three of Maniwaki, for the following purposes: 0910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° 50 Exploiter une entreprise de camionnage, sous le nom de « Robert Morin inc.», avec un capital divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 30,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Maniwaki, district judiciaire de Labelle.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4929-69 Motel Le Chalutier inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Marc Pelletier, gérant, case postale 337, Fcrnand Guérettc, avocat, case postale 52, tous deux dc Saint-Anne-«les-Monts, et Agnès Fournicr, secrétaire, épouse de Lévis Fournicr, Cap-Chat, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, motels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de < Motel Le Chalutier inc.», avec un capital total de S80.000, divisé en 400 actions ordinaires dc S100 chacune et en 200 actions privilégiées dc S200 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Saintc-Annc-dcs-Monts, district judiciaire de Gaspé.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-u 4690-69 Multi-Fund.Investments (Québec) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour «l'octobre 1969, constituant en corporation: Irving L.Adessky, 56, Place Heath.Hampstead.Daniel Kingstone, 4985, Iona, Montréal, Peter Virug, 75, Village Drive, Dollard-dcs-Ormeaux.et Gilles Pouliu, 103, Ash ton, Saint-I.aunni.tous les quatre avocats, |>our les objets suivants: S'établir courtiers en placements, vendeurs, agents cl courtiers en fonds mutuels, assureurs, conseillers en propriétés et urbanistes, agents et courtiers en immeubles, sous le nom de « Multi-Fund Investments (Québec) Ltd.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et 2,000 actions privilégiées de S10 chacune.I.c siège social dc la compagnies est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.IéC sous-ministre de.i institution*financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4638-69 Parallel Investment Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province u accordé des lettres patentes, en date du 20e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Murray Lapin, 167, Edgehill, Westmount, Norman May, 55, Hol-tham, Hampstead, et Ezra Beinhnker, 3328, Troie.Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir une compagnie «le placement sous le nom de « Parallel Investment Cor|>oration Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair To operate a trucking enterprise, under the name of \"Robert Morin inc.\", with capital stock divided into 10,000 common shares without nominal value and 30,000 preferred shares of $] each.The head c.fnee of the company is at Maniwaki, judicial district of Labelle.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4929-69 Motel Lc Chuluticr inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marc Pelletier, manager, post office box 337, Fcrnan«l Guérettc, advocate, post office box 52, both of Sainte-Anne-dcs-Monts, and Agnès Fournicr, secretary, wife of Levis Fournicr, Cap-Chat, for the following purposes: To operate hotels, motels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Motel Le Chalutier inc.\", with a total capital stock of $80,0(111, divided into 400 common shares of $100 each ami 200 preferred shares of S200 each.The head office of the company is at Sainte-Annc-dcs-Monts, judicial district of (iaspé.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4690-69 Multi-Fund Investments (Québec) Lid.Notice is given that under Part I of I lie Companies Act, letters patent, bearing dale the 7th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Irving L.Adessky, 56 Heulh Place, Hampstead, Daniel Kingstone, 4085 lonu, Montreal, Peter Virug, 75 Village Drive, Dollanl-des-Ormcaux, anil Gilles Poulin, 103 Ashtou, Saint-Laurent, all four advocates, for the following purposes: To carry on business as investment brokers mutual fund brokers, agents and vendors, underwriters, estate planners and consultants, real estate agents and brokers, under the name of \"Multi-Fund Investments (Québec) Ltd.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phii.ippi: Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Coopérai in 32147-o 4638-69 Parallel Investment Corporation Ltd.Notice is given that under Part.I of I he Companies Act.letters patent, bearing dale the 20th day of October.1969.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Murray Lapin, 167 Edgchill, Westmount, Norman May, 55 Holtham.Hampstead, and Ezra Bcinhaker, 3328Troie.Montreal, all three advocates, for the following pun.To carry on the business of un investment company, under the name of \"Parallel Investment Corporation Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December IS, 19G9, Vol.101, No.50 6911 île SI chacune et 3,900 actions privilégiées d'une mi leur au pair de S10 chacune.l.c siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal./,scs: To carry on business us a holding, investment and management company, under the name of \"Placements Bernard Courteiuanche ltée\", with 6912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n\" 50 avec un capital total «le S40,000, divisé en 6 actions ordinaires de $10 chacune, 3,992 actions privilégiées classe « A » de 810 chacune et en 20 actions privilégiées classe « B » de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est 1090, des Casca«les, Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sou.i-miniulre des institutions financière, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-o 4619-69 Plastiques renforcés Québécois inc.Québécois Reinforced Plastics Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la premiere partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accorde des lettres patentes, en date du 14e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Roland Rioux, entrepreneur, 255, Tarrant, Ronald Boisvcrt, 590, Pinc, et Claude Cîérin, 442, Main ouest, ces deux derniers comptables agréés, tous trois de M agog, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'articles fabriqués totalement ou en partie dc métaux, plastique ou bois, sous le nom de « Plastiques renforcés Québécois inc.\u2014 Québécois Reinforced Plastics Inc.», avec un en pilai total dc 840,000, divisé en 8,000 actions ordinaires de S5 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Magog, district judiciaire «le Saint-François.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4885-69 a total capital stock of $40,000, divided into 6 common shares of $10 each, 3,992 class \"A\" preferred shares of $10 each and 20 class \"IP preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 1090 des Cascades, Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4619-69 Plastiques renforcés Québécois inc.Québécois Reinforced Plastics Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roland Rioux, contractor, 255 Tarrant, Ronald Boisvcrt, 590 Pinc, and Claude Gcrin, 442 Main West, the hitter two chartered accountants, all three of Magog, for the following purposes: To manufacture and deal in articles manufactured wholly or partially in metal, plastic or wood, under the name of \"Plastiques renforcés Québécois inc.\u2014 Québécois Reinforced Plastics Inc.\", with a total capital stock of 840.01111.divided into 8,000 common shares of 85 each.The head office of the company is at Magog, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4885-69 Plaza Ontario Pizza and Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu de.la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de In province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour dc septembre 1969, constituant en corporation: Bill Gianoulias, restaurateur, 833 est, boulevard Maisonneuvc, Julius Rosenblum, avocat, 1010 ouest, rue Sainte-Catherine, tous deux de Montréal, et Nick Gianoulias, restaurateur, 7617, rue Boischatcl, Saint-Léonard, pour les objets suivants: Tenir restaurant et une « pizzeria », sous le nom de « Plaza Ontario Pizza and Restaurant Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 3,500 actions privilégiées «l'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4333-69 Plomberie P.M.inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentés, en date du 31e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Paul Martel, plombier, 3249, boulevard Bellerive, Carignan, Maurice Rivard, plombier, et Pauline Larose, ménagère, épouse dudit Maurice Rivard, ces deux derniers dc 5120, rue Légion, Saint-Hubert, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chaulfuge et en réfrigération, sous le nom de « Plomberie P.M.inc.», avec un capital total Plaza Ontario Pizza and Restaurant Inc.Notice is given that under Purt I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 9th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Bill Gianoulias, restaurant owner.833 Maisonneuvc Boulevard East, Julius Rosenblum, advocate, 1010 St.Catherine Street West, both of Montreal, and Nick Gianoulias, restaurant owner, 7617 Boischatcl Street, Saint-Leonard, for the following purposes: To carry on the business of a restaurant anil pizzeria, under the name of \"Plaza Ontario Pizza and Restaurant Inc.\", with a total capilal stock of 840,000, divided into 500 common shares of a par value of 810 each and 3,500 preferred shares of a par value of S10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-0 4333-60 Plomberie P.M.inc.Notice is given that under Part I of I lie Companies Act, letters patent, bearing date I lie 31st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul Martel, plumber, 3249 Bellerive Boulevard, Carignan, Maurice Rivard, plumber, and Pauline Luro.sc, housewife, wife of the said Maurice Rivard, the latter two of 5120 Légion Street, Saint-Hubert, for the following purposes: To carry on business us contractors in plumbing} heating and refrigeration, under the name of \"Plomberie P.M.inc.\", with a total capital slock QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1909, Vol.101, No.50 6013 île $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 200 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 3249, boulevard Bcllcrive, Carignan, district judiciaire de Montréal.I.c sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 5058-69 of 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 3249 BeUerive Boulevard, Carignan, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 5058-69 Portuguese Cultural Centre of Canada Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25e'jour dc septembre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Antonio Pereira Lourenço, 4764, St-Hubcrt, Dclfim Leitc Fcrrcira, 3754, Colonial, Armando Conçoives Ladeira, 4400, Colonial, tous trois machinistes, José des Ncvcs Rodrigucs, typographe, 8403, 10c avenue, et Gastao de Moura Florcncio, agent dc voyage, gérant, 3537, avenue du Parc, tous de Montréal, pour les objets suivants: Stimuler la culture portugaise parmi tous les gens et leur réserver un lieu dc rencontre, sous le nom de « Portuguese Cultural Centre of Canada Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur dc la propriété immobilière que la corporation peut posséder ou détenir est dc 850,000.Le siège social dc la corporation est 3509, avenue du Parc, Montréal, district judiciaire dc Montréal.I.c sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4624-69 Portuguese Cultural Centre of Canada Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a corporation without share capital: Antonio Pereira Lourenço, 4764 St.Hubert, Delfim Lcitc Pcrreira, 3754 Colonial, Armando Gonçalvcs Ladcira, 4400 Colonial, all three machinists, Jose das Neves Rodrigucs, typographer, 8403, 10th Avenue, and Gastao dc Moura Florencio, travel agent manager, 3737 Park Avenue, all of Montreal, for the following purposes: To promote Portuguese culture amongst all peoples and have a place for them to.meet, under the name of \"Portuguese Cultural Centre of Canada Inc.\".The amount to which the value 'pi the immovable property which may owned or held by the corporation, is to be limited, is 850,000.The head office of the corporation is at 3509 Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-o 4624-69 Ia-h Produits Addolinc du Quebec liée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 22c jour dc septembre 1969, constituant en corporation: Gaston Basticn, industriel, 250, le Baron, Bouclierville, Roger Dulude, industriel-restaurateur, 1101, Fontainebleau, Snintc-Foy, et Christianc Lepage, secrétaire, fille majeure, 1850, boulevard Benoit XV, Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce des huiles, graisses, pétroles, et tous leurs produits, et du gaz naurel, sous le nom de « Les Produits Addolinc du Québec ltée », avec un capital total dc S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Ia: siège social de la compagnie est ù Québec, district judiciaire dc Québec.1.1- sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32U7-o 4538-69 Les Produits Addolinc du Quebec ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gaston Basticn, industrialist, 250 le Baron, Bouclierville, Roger Dulude, industrialist-restaurateur, 1101 Fontainebleau, St.Foy and Christianc Lepage, secretary, spinster of the full age of majority, 1850 Benoit XV Blvd., Québec, for the following purposes: To deal in oils, grease, petroleum and all their products, and in natural gas, under the name of \"Les Produits Addolinc du Québec ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4538-69 Les Produits Avicoles Mnricttu inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province n accordé des lettres patentes, en date du 20c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Émilicn Biais, aviculteur.Mariette Bilodeau, ménagère, épouse dudit l'ànilien Biais, tous deux dc Lac Mégantic, et Léo Bilodeau, industriel, Courcelles, jxwr les objets suivants: le- Produits Avicoles Marietta inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Émilicn Bluis, breeder of fowls, Mariette Bilodeau, housewife, wife of the said Émilicn Bluis, both of Luke Mégantic, and Léo Bilodeau, industrialist, Courcelles, for the following purposes: 6914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n' 50 Faire le commerce «le produits d'aviculture et d'agriculture, sous le nom dc « Les Produits Avicoles Marietta inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 400 actions ordinaires dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 4574, Pic XI, Lac Mégantic, district judiciaire dc Saint-François.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-o 4773-69 Produits Carut inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première parlic dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 29c jour dc septembre 1969, constituant en corporation: Micheline Durand, comptable, 315, 9c Rue, Marthe Lessard, réceptionniste, 354, rue Lavigueur, et Louise Bou-chard, secrétaire, 1296, Chanoine Morel, toutes trois filles majeures, dc Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce dc tuyaux ou conduits en ciment ou béton ou leurs dérivés, des blocs ou dc la pierre artificielle, sous le nom île « Produits Carat inc.-, avec un capital total de S100.000, divisé en 2.000 actions ordinaires île $10 chacune et en 8,000 actions privilégiées île $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Ragot-ville, district judiciaire dc Chicoutimi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32117-0 4096-69 Puhlicad International Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province n accordé des lettres patentes, en date du 15c jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Raymond Lctte, 27, avenue McNidcr, Jean-Pierre Sutto, 5160, Gatincau, et Colin A.Gravenor junior, 3660, Peel, tous trois avocats, de Montreal, pour les objets suivants: S'établir agents et conseillers en publicité, sous le nom de * Puhlicad International Ltd.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.I/C siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4869-69 Puhli-Mcdiu Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le liculciianl-gouverneur dc la province n accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'août 1969, constituant en corporation: Simon Dorval, 4920, Parkinson, Pierrefonds, F.-Panet Raymond, 74, Dunrac, Mont-Royal, et Joseph-Maurice Renaud, 7769, Tcllicr, Montréal, tous trois administrateurs, pour les objets suivants: Agir à titre de spécialistes en relations publiques, conseillers, consultants et aviseurs, sous le nom dc « Publi-Mcdia Inc.:, avec un capital total île $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 36,000 actions privilégiées de $1 chacune.To deal in avicultural and agricultural products, under the name of \"Les Produits Avicoles Marietta inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 4574 Pie XI, Lake Mégantic, judicial district of Suint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4773-69 Produits Carat inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Micheline Durand, accountant.315.9th St., Marthe Lessard, receptionist, 354 Lavigueur St., and Louise Bouchard, secretary, 1296 Chanoine' Morel, all three spinsters of I he full age of majority, of Québec, for the following purposes: To manufacture anil deal in pipes or duels of cement or concrete or their derivatives, blocks or artificial stone, under the name of \"Produits Carat inc.\", with a total capital stock of $100.(10(1.divided into 2,000 common shares of $10 cad I and 8,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Bngol -ville, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 4096-69 Puhlicud Inlcrnntionul Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 15th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Raymond IyCttc, 27 McNidcr Avenue, Jean-Pierre Sut to.5160 Gatincau, and Colin A.Gravenor junior, 3660 Peel, nil three lawyers, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as advertising agents ami counsel, under the name of \"Publicutl International Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperative*.32147-0 4860-09 Publi-Mcdia Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of August, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Simon Dorval, 4920 Parkinson, Pierre-fonds, F.-Panet Raymond, 74 Dunrac, Mount Royal, and Joseph-Maurice Renaud, 7769 Tcllicr, Montreal, all three executives, for the following purposes: To act as public relations experts, counsellor-, consultants and advisers, under the name of \"Publi-Mediu Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 36,000 preferred shares of $1 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 19G9, Vol.101, No.50 Le siège social de la compagnie est 16, Elgin, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le .iou.i-mini.ilre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 4097-69 Radio-Tel.inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province n accordé des lettres patentes, en date du 15c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Flcury, technicien, Eruneine Lnferrièrc, ménagère, épouse dudit Gilles Fleury, tous deux dc 291, François-Séguin, Bouclierville, et Gaston Lafcrrière, technicien, 86, Des Sulpicicns, l'Epiphanie, pour les objets suivants: Exploiter des postes émetteurs et récepteurs ainsi que des systèmes dc communication par radio, sous le nom de « Radio-Tel.inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 291, François-Séguin, Bouclierville, district judiciaire dc Montréal.Ix sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-0 4029-69 Itcmbourrugc Industriel Kebcc inc.Kebeo Industrial Upholstering Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Robert Vineberg, avocat, 1559 ouest, avenue des Fins, Barbara Komornicki, 4353, Saint-Urbain, tous deux de Montréal, et Maureen Montgomery, 30, Place Cote Vertu, Saint-Laurent, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce dc tissus pour recouvrir les meubles, de matières plastiques, d'articles et tissus de plastique, de produits dc métal, produits chimiques, dc caoutchouc et produits de caoutchouc, île peintures, verre, matériaux et fournitures pour lu construction, .-ous le nom dc « Rembourrage Industriel Kebcc inc.\u2014 Kebcc Industrial Upholstering Inc.», avec un capital totul de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.I capital from $40,000 to $1,101, the capital stock annulled being divided into 38,899 preferred shares of the par value of $1 each.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-0 12412-62\u2014 1515 0 La Compagnie Pelchat ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters paten!, bearing date the 23rd day of October, 196'.), have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"La Compagnie Pelchat ltée\", extending its powers.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147 683-68 \u2014 1515/51 J.B.D'Aoust inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 6927 gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 12e jour de septembre 1969, à la compagnie « J.B.D'Aoust inc.», réduisant son capital de $225,000 à $132,500 par l'annulation de 925 actions privilégiées classe « B » d'une valeur au pair de $100 chacune.U sous-minislre des institutions financières, compagnies el coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32117-0 13181-54 \u20141516/98 Guy Ernest Drolet inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partit) de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour île septembre 1969, à la compagnie « Guy Drolet inc.constituée par lettres patentes en date du 20b jour de mai 1969, changeant son nom en celui de « Guy Ernest Drolet inc.».I.c sous-minislre des institutionsfinancières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147-e» 2481-69\u20141517/22 Hubert Dufault ltée Robert Dufault Ltd.Avis est donné qu'en vertu tie la première pailie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 27e jour de décembre 1968, à la compagnie « Robert Dufault ltée \u2014Robert Dufault Ltd.», augmentant son capital a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent, principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est Frumkin & Feldman, avocats, 995, Place du Canada, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi a 995, Place du Canada, .Montréal, district judiciaire dc Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 35-69 \u2014 1519/76 Cyanumid Americas Trading Company Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Cyanamid Americas Trading Company», a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est Monsieur Robert A.Dunford, 635 ouest, boulevard Dorchester, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 635 ouest, boulevard Dorchester, Montréal, district judiciaire de Montréal, /.c sous-minislre des institutions finfincières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32147 70-69 \u2014 1519/8S Transalta Oil & Gas Ltd.Notice is given that under the Extra-Provincial Companies Act \"Transalta Oil & Gas Ltd.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Robert S.Vineberg, c/o Phillips, Vineberg, Goodman, Phillips & Rothman, barristers & sollicitons, 1 Place Ville Marie, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 1 Place Ville Marie, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-o 71-69 \u2014 1519/74 Zugitan A.G.Zug Notice is given that under the Extra-Provincial Companies Act \"Zugitan A.G.Zug\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Frumkin & Feldman, attorneys, 995 Place du Canada, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 995 Place du Canada, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-0 35-69 \u2014 1519/76 Cyanamid Americas Trading Company Notice is given that under the Extra-Provinciul Companies Act \"Cyanamid Americas Trading Company\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proccdings against the company is Mr.Robert A.Dunford, 635 Dorchester Boulevard West, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 635 Dorchester Boulevard West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32147-o 70-69 \u2014 1519/88 Divers Compagnies Miscellaneous Companies The Québec Pulp & Paper Safety Association Inc.Association de Sécurité des Pûtes et Papier du Québec inc.Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 26 novembre 1969, approuvé les règlements spécial «A », spécial « B » et spécial « C » et les règlements généraux de « The Québec Pulp & Paper Safety Association Inc.\u2014 Association de Sécurité des Putes et Papiers du Québec inc.», et ce, en vertu dc l'article 226 de la Loi des compagnies.J.c aous-mïnistré des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.¦>'-'! GO-o 1559-34 The Québec Pulp & Paper Safely Association Inc.Association de Sécurité des Pâtes et Papier du Québec inc.Notice is hereby given that the Minister of financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on November 26, 1969, approved Special by-laws \"A\", \"B\" and \"C\" and the general by-laws of \"The Québec Pulp & Paper Safety Association Inc.\u2014 Association de Sécurité des Pâtes et Papiers du Québec inc.\", and such, pursuant to section 226 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32160 1559-34 6948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n' 50 The Québec Pulp & Paper Safety Association Inc.Association dc Sécurité des Pûtes et Papiers du Québec inc.Avis est donné que « The Québec Pulp & Paper Safety Association Inc.\u2014 Association de Sécurité des Pâtes et Papiers du Québec inc.» a changé le nombre de ses administrateurs de 24 à 20.Le secrétaire-gérant, E.N.Denison.32160-o 1559-34 The Québec Pulp & Paper Safety Association Inc.Association dc Sécurité des Pûtes et Papiers du Québec inc.Notice is hereby given that \"The Quebec Pulp & Paper Safety Association Inc.\u2014 Association de Sécurité des Pâtes et Papiers du Québec inc.\", has changed the number of its directors from 24 to 20.E.N.Denison, Secretary-Manager.32160 1559-34 Association de Sécurité des Exploitations Forestières du Québec inc.Québec Logging Safety Association Inc.Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 27 novembre 1969, approuve les règlements généraux de l'« Association de Sécurité des Exploitations Forestières du Québec inc.\u2014 Québec Logging Safety Association Inc.», et ce, cn vertu de l'article 226 de la Loi des compagnies.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIII.IPPE bouchard.32161-0 4120-69 Association dc Sécurité des Exploitations Forestibres du Québec inc.Québec Logging Safety Association Inc.Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on November 27, 1969, approved tlie general by-laws of \"Association de Sécurité des Exploitations Forestières du Québec inc.\u2014 Québec Logging Safety Association Inc.\", and such, pursuant to section 226 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32161 4120-69 Canada Packaging Ltd.Avis est donné que la compagnie « Canada Packaging Ltd.», a changé le nombre dc ses administrateurs de 4 à 7.Le secrétaire, Robert Vineberg.32163-0 11506-59 Canada Packaging Ltd.Notice is given that \"Canada Packaging Ltd.\", has changed the number of its directors from I to 7.Robert Vineberg, Secrelari/.32163 11506-59 Les Chiflbnnicrs-Bûtisscurs d'Emniaiis de Hull incorporée Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 27 novembre 1969, approuve les règlements généraux de la corporation < Les Chiffonniers-Bâtisseurs d'EmmaUs de Hull incorporée », et ce, cn vertu dc l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.32164-0 11129-57 Les Chiffonnicrs-Bûtisseurs d'Emmaiis dc Hull incorporée Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has.on November 27, 1969, approved the general bylaws of \"Les Chiffonniers-Bâtisseurs d'Emmaiis de Hull incorporée\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Phipille Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32164 11129-57 Corporation dc Placements Hillcuth Hillcath Investments Corporation Avis est donné que la « Corporation dc Placements Hillcath \u2014 Hillcath Investments Corporation\", a changé le nombre de ses administrateurs dc 3 i\\ 4.Le secrétaire, Marie E.Lalonde.32165-0 1286-67 Eastern Townships Agricultural Association 1967 Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 25 novembre 1969, approuvé les règlements généraux de la corporation « Eastern Townships Agricultural Association 1967 », et ce, en vertu de l'article 8 de la Loi des clubs de récréation et de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.32167-0 57-67 Corporation dc Placements Hillcath Hillcath Investments Corporation Notice is given that \"Corporation de Placements Hillcath \u2014 Hillcath Investments Corporation\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Marie E.Lalonde, Secretary.32165 1286-07 Eastern Townships Agricultural Association 1967 Notice is given that the Provincial Secretary has approved, on November 25,1969, the general by-laws of \"Eastern Townships Agricultural Association 1967\", and such, pursuant to section 8 of the Amusement Clubs Act and to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.32167 57-07 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1909, Vol.101, No.50 6949 Eagle Toys Export Corp.Avis est donné que « Eagle Toys Export Corp.», a changé le nombre de ses adrainis-I râleurs dc 4 à 6.L'assislant-secrêtaire, E.H.Drymeh.32100 10855-58 Les Entreprises Fcmand Seguin inc.Avis est donné que la compagnie « Les Entreprises Fcrnand Seguin inc.» a changé son siège social du numéro 1110, rue Sherbrooke ouest, Montréal, au numéro 215, chemin Richelieu, Sl-Churlcs-sur-lc Richelieu, comté de St-Hyacinthe.¦ Le secrétaire, Fernande Giroux.32168-0 146-69 Football Festival 69 Inc.Le Festival dc Football 69 inc.Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 18 novembre 1969, approuvé les règlements numéros 1 à 12 inclusivement de la corporation « Football Festival 69 Inc.\u2014Le Festival de Football 69 inc.\", et ce, cn vertu de l'article 225 de lu Loi des compugnies.l.c tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32169-0 3996-69 Eagle Toys Export Corp.Notice is given that \"Eagle Toys Export Corp.\", has changed the number of its directors from 4 to 6.E.H.Drymer, Assistant Secretary.32166-0 10855-58 Les Entreprises Fcrnand Seguin inc.Notice is hereby given that \" Les Entreprises Fernand Seguin inc.\", has changed its head office from 1110 Sherbrooke Street West, Montreal, to 215 Richelieu Road, St-Charles-sur-Ic-Ricliclieu, county of St-Hyacinthe.Fernande Giroux, Secretary.32168 146-69 Football Festival 69 Inc.Le Festival dc Football 69 inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives has approved, on November 18, 1969, By-laws numbers 1 to 12 inclusively of \"Football Festival 69 Inc.\u2014 Lc Festival de Football 69 inc.\", and such, in pursuance of section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32169 3996-69 Produits Forestiers Généraux limitée < .en.i ni Forest Products Limited Avis est donné que la compagnie « Produits Forestiers Généraux limitée \u2014 General Forest Products Limited», a changé le nombre dc ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, L.N.Riopel.32IT0-o 2289-50 Produits Forestiers Généraux limitée General Forest Products Limited Notice is given that \"Produits Forestiers Généraux limitée \u2014 General Forest Products Limited\", has changed the number of its directors from 4 to 3.L.N.Riopel, Secretary.32170-o 2289-50 Gold Nugget Dairy Ltd.Luiteric Pépite d'or ltée Avis est donné que « Gold Nugget Dairy Ltd.\u2014 I .i i i m ii- Pépite d'or ltée », a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 6.Le secrétaire, Nelson Pillion.32171 82-69 The Hillside Tennis Club, Inc.Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a, le 21 novembre 1969, approuvé les règlements numéro I i\\ XI inclusivement dc la corporation 5 The Hillside Tennis Club, Inc.», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies./.'\u2022 sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32172-0 925-35 Hum Investments Ltd.Avis est donné que la compagnie « Hum Investments Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire.Fen Kin Hum.:!2174-o 1260-68 Gold Nugget Dairy Ltd.Laiterie Pépite d'or ltée Notice is given that \"Gold Nugget Dairy Ltd.\u2014 Laiterie Pépite d'or ltée\", has changed the number of its directors from 3 to 6.Nelson Fillion, Secretary.32171-o 82-69 The Hillside Tennis Club, Inc.Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on November 21, 1969, approved bylaw numbers I to XI inclusively of \"The Hillside Tennis Club, Inc.\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32172 925-35 Hum Investments Ltd.Notice is given that \"Hum Investments Ltd.\", has changed the number of its directors from 5 to 3.Fen Kin Hum, Secretary.32174 1260-6S G950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 19C9, 101' année, n' 60 Horizon Tower Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 1 (a) de la compagnie « Lombok Investments Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 17c jour d'octobre 1968, changeant son nom cn celui de « Horizon Tower Ltd.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32173 4837-68 Horizon Tower Ltd.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and |Cooperatives lias approved the by-law No.1 (a) of the company \"Lombok Investments Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 17th day of October, 1968, changing its name into that of \"Horizon Tower Ltd.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32173-0 4837-lis Ideal Electric Inc.Avis est donné que « Ideal Electric Inc.», a changé le nombre dc ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Alice Grandmont.32175 825-69 Ideal Electric Inc.Notice is given that \"Ideal Electric Inc.\", has changed the number of its directors from 3 to I.32175-0 Alice Grandmont, Secretary.S25-69 International Knitting Mills Ltd.Avis est donné que « International Knitting Mills Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 7.Le président, David Bloomfield.32176 1417-64 International Knitting Mills Ltd.Notice is given that \"International Knitting Mills Ltd.\", has changed the number of ils directors from 4 to 7.David Bloomkield, 1'rcsidenl.32176-o 1417-61 L.& R.Electronics Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'il a approuve le règlement numéro 23 dc la compagnie « Authorized Radio & T.V.Service Corp.», constituée par lettres patentes en date du 2c jour dc mars 1961, changeant son nom cn celui de « L.& R.Electronics Inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32178-o 10950-61 L.& R.Electronics Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives lias approved the by-law No.23 of the company \"Authorized Radio & T.V.Service Corp.\", incorporated by letters patent dated the 2nd day of March, 1961, changing its name into that of \"L.& R.Electronics Inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32178 1095061 Lac Pin Rouge Citizen's Association Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 1er décembre 1969, approuvé les règlements généraux dc la corporation « Lac Pin Rouge Citizen's Association », et ce, cn vertu dc l'article 8 dc la Loi des clubs dc récréation et île l'article 225 dc ln Loi des compagnies.Lf sous-secrétaire dc la province, Raymond Douville.32l79-o 97-69 Lac Pin Rouge Citizen's Association Notice is given that the Secretary of the Province has approved, on December 1, 19119.the general by-laws of \"Lac Pin Rouge Citizen's Association\", anil such, pursuant to section 8 of the Amusement Clubs Act and to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.97-69 32179 Bcrnurd Lniircndcau inc.Avis est donné que la compagnie « Bcrnurd Laurcndeau inc.» a changé le nombre dc ses administrateurs dc 4 à 6.Le secrétaire-trésorier, D.L.Inwood.32180-o 4541-64 Bernard Luurcndeau inc.Notice is given that \"Bernard Laurcndeau inc.\" has changed the number of its directors from 4 to 6.D.L.Inwood, Secretary-Treasurer.32180 4541-04 Savon Majestic ltée Majestic Soap Ltd.Avis est donné que la compagnie « Savon Majestic ltée \u2014 Majestic Soap Ltd.» a chungc le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire, Yvon Roy.32181-0 2405-37 Savon Majestic ltée Majestic Soap Ltd.Notice is given that \"Savon Majestic liée Majestic Soap Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.Yvon Roy, Secretary.32181 2405-37 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 6951 Montreal Picture Frame Company Ltd.Montreal Picture Frame Company Ltd.Avis est donné que la compagnie « Montreal Picture Frame Company Ltd.» a change lc nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, I.Krukin.32182 12923-56 Pax Construction Inc.Avis est donné que la compagnie « Pax Construction Inc.» a changé lc nombre dc ses administrateurs de 7 ù 6., Le secrétaire-trésorier, Maurice Tremblay.321S3-0 14233-GO Si.Patrick Development Corporation Ltd.Avis est donné que la compagnie « St.Patrick 1 )e\\-clopinent Corporation Ltd.» a changé le nombre dc ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, EL Reaulieu.321S4-0 1972-51 Services Sanitaires Sanico inc.-aiiicn Sanitary Services Inc.Avis est donné que la compagnie « Services Sanitaires Sanico inc.\u2014 Sanico Sanitary Services Inc.» a changé le nombre de ses administrateurs ¦le 3 à 5.Lc secrétaire, Jean Marier.32185-0 872-68 Services Sanitaires Sanico inc.Sanico Sanitary Services Inc.Avis est donné que la compagnie « Services Sanitaires Sanico inc.\u2014 Sanico Sanitary Services lue.» a changé le nombre dc ses administrateurs de 5 ù 3.32186-0 Le secrétaire, Jean Marier.872-68 Service Plastics & Chemicals Corp.Avis est donné que « Service Plastics & Chemicals Corp.» a changé le nombre de ses administrateurs dc 6 à 7.Le président, David Bloomfield.32187 5260-51 Société des Éditeurs de Manuels Scolaires du Québec Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 21 novembre 1969, approuvé ]es règlements généraux _de la « Société des Éditeurs dc Manuels Scolaires du Québec», et ce, en vertu dc l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies el coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32188-0 4321-68 Sport Games Mfg.Inc.Avis est donné que « Sport Games Mfg.Inc.», a changé le nombre de ses directeurs de 4 à 6.L'assistant-secrétaire, E.H.I ': i mer.32189 11214-56 Notice is given that \"Montreal Picture Frame Company Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.I.Krukin, Secretary.32182-o 12923-56 Pax Construction Inc.Notice is given that \"Pax Construction Inc.\" has changed the number of its directors from 7 to 6., Maurice Tremblay, Secretary-Treasurer.32183-o 14233-60 St.Patrick Development Corporation Ltd.Notice is given that \"St.Patrick Development Corporation Ltd.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.R.Beaulieu, Secretary.32184-0 1972-51 Services Sanitaires Sanico inc.Sanico Sanitary Services Inc.Notice is hereby given that \"Services Sanitaires Sanico inc.\u2014 Sanico Sanitary Services Inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 5.Jean Marier, Secretary.32185 872-68 Services Sanitaires Sanico inc.Sanico Sanitary- Services Inc.Notice is hereby given that \"Services Sanitaires Sanico inc.\u2014 Sanico Sanitary Services Inc.\", has changed the number of its directors from 5 to 3.Jean Marier.Secretary.32186 872-68 Service Plastics & Chemicals Corp.Notice is given that \"Service Plastics & Chemicals Corp.\" has changed the number of its directors from 6 to 7.David Bloomfield, President.32187-0 5260-51 Société des Éditeurs de Manuels Scolaires du Québec Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives approved, on November 21, 1969, the general bylaws of \"Société des Éditeurs de Manuels Scolaires du Québec\", and such, in pursuance of section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32188 4321-68 Sport Games Mfg.Inc.Notice is given that \"Sport Games Mfg.Inc.\", has changed the number of its directors from 4 to 6.E.II.Drymer, Assistant Secretary.32189-0 11214-56 0952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1909, 101' année, n\" 50 Unigro inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 3 dc la compagnie « Quincaillerie Hobby inc.\u2014 Hobby Hardware Inc.», constituée par lettres patentes cn date du 21c jour d'août 1968, changeant son nom en celui de « Unigro inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32190 3782-6S The Western Lake Bexie Proprietors Association Avis est donné que le secrétaire dc la province a, le 1er décembre 1969, approuvé les règlements généraux de la corporation « The Western Lake Bexie Proprietors Association», et ce, en vertu dc l'article 8 dc la Loi des clubs dc récréation et de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.32191-o 98-69 Bench & Table Service (1967) Limited Avis est donné que « Bench & Table Service (1967) Limited », a changé le nombre de ses administrateurs de 9 à 3.Le secrétaire, Irving Vosko.32254 136-67 Corfincx inc.Avis est donné que la compagnie « Corfincx inc.», a changé lc nombre dc ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire, Claude Gagné.32255-0 885-63 Unigro inc.Notice is given that the Minister ot Financial Institutions, Companies and Copcratives has approved the by-law number 3 of the company \"Quincaillerie Hobby inc.\u2014 Hobby Hardware Inc.\", incorporated by letters patent dated I lie 21st day of August, 1968, changing its name into that of \"Unigro inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperative: 32190-o 3782-68 The Western Lake Bexie Proprietors Association Notice is given that the Secretary of I lie Province has approved, on December 1, 1969, the general by-laws of \"The Western Lake Bexie Proprietors Association\", and such, pursuant to section 8 of the Amusement Clubs Aet and to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, .Insistant Secretary of the Province.32191 98-69 Bench & Table Service (1967) Limited Notice is given that \"Bench & Table Service (1967) Limited\", has changed the number of ils directors from 9 to 3.Irving Vosko, Sccrelan/.32254-0 136-67 Corfincx inc.Notice is given that \"Corfincx inc.\", has changed the number of its directors from 5 to 3.Claude Gagné, Secretary.32255 885-63 The Cimnrd Steam-Ship Company Limited The Cimard Steam-Ship Company Limited Avis est par les présentes donné qu'en vertu d'une nouvelle procuration datée du 30 mai 1969, dont copie a été envoyée au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Monsieur Alec N.Simpson, 133, Flamingo Drive, Bcaconsfield, a été nommé agent principal dans la province de la compagnie « The Cunard Stcam-Sliip Company Limited », une compagnie étrangère dûment autorisée à faire affaires dans la province dc Québec, conformément aux dispositions .on northwest by the lots 08-83, 09-102.P-09-lOli t.121.09-73 and P-09-122-1.A part of lot 09 containing an area of approximately 0,800 square feet and more or less and bounded as follows, on the northeast by Moutarville Street, on the northwest by a part of lot 70, on the southeast by a part of lot 09-1 and on the southwest by a pail >.f lot 09.A part of lot containing an area of approximately 44,108 square feet, more or leys,and bounded rut follows: on the northwest by a part of lots 09-132 ami 09-133, on the southwest by a part of lots 07-90 and 7-t'7.on the northeast by a part of lot 09-132 and on the southeast by Joseph lluet Street, a part of lot 08 and the lot 09-135.3-70-280 Prestige Dev.Ltd.3-70-204 Prestige Dev.Ltd.3-13-400 Prestige Dev.Ltd.l'ne partie du lot 71 liornée comme suit: au nord-est pur lu rue Monturville.au nord-ouest par le lot 71-20.au sud-est par le lot 71-12 et au sud-ouest pur les lots 71-2.71-3.71-5 il 71-11.09 135.09 137.0» 98, A part of lot 71 bounded as follows: ou the northea*! by Moutarville Street, on northwest by lot No.71-20, on the southeast by lot 71-12 and on the southwest by lots 71-2.71-3.71-5 to 71-11.3 08- 359 3-08 351 3-08-345 3-08-337 3-08-331 3-08-323 3-08-317 3-08-311 3-08-301 3-08-203 3-08-285 3-08-277 3 72-1081 3-72-1085 3-72-1089 3-72-1093 3-72-1097 3-72-1101 3-72-1105 1-70-051 1-70-1155 2 49 570 Prestige Dev.Ltd.l'restige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestigo Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Lid.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd_____ Prestige Dev.Ltd.Guay, Gerald Mine-Mrs.Guay.Géndd Mine-Mrs.Hiiilu Corp.71 22.71 23.71 24, 71 25.71 20.71 27.71 28.71 29, 71 30.71 31.71 32.71 33.71 35, 71 30, 71 37, 71 38.71 39, 71 40.71 41.88 02.88 03.08 110.08 117.08 118.08 119.08 120.08 121.08 122.08 141.OS 140.08 139.08 138.08 142.08 143.08 144.08 146.OS 140.08 147.68 148. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 0971 l'ne partie (lu lot de terre connu et désigné sous le numéro cent vingt-deux (Ptie 122) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Fumille de Bouclierville: mesurant cent quatre-vingt-sept pieds et huit dixièmes de pied (187.8') en front dans sa ligne nord-ouest, cent quatre-vingt-dix pieds et six dixièmes île pied (190.(1') en arrière dans sa ligne sud-est, cinq initie quatre-vingt-dix-huit pieds (5,098') d'un côté dans stl ligne nord-est et cinq mille soixante-deux pieds et unis dixièmes de pied (5,002.3') dans sa ligne sud-oMcsl : humée en front au nord-ouest pur la rue De Normandie, en arrière au sud-est par une partie du lot numéro 200 dudit cadastre au nord-est et au sud-ouest par d'autres parties dudit lot numéro 122.A part of original lot number one hundred and twenty-two (122 Pt.) on the official plan and book of reference of the parish of Ste-Fnmille de Bouclierville, measuring one hundred and eighty-seven feet and eight tenths of a foot (187.8') in front in its northwest line, one hundred and ninety feet, and six tenths of a foot.(190.0') in rear in its southeast line, five thousand ninety-eight feet (5.098') on one side in its northeast line and five thousand sixty-two feet and three tenths of a foot (5,002.3') in its southwest line, bounded as follows: in front to the northwest by De Normandie Street, in rear to the southeast by a part of lot 200.to the northeast and to the southwest by other parts of lot 122.Cadastre de la paroisse de Sainte-Famille de Bouclierville (strife) Cadastre of the parish of Sainte-Famille de Bouclierville (continued) Hole Hull Nom du propriétaire Name of proprietor 2 111 570 Genest, Romeo.Tue partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro cent vingt-deux (Ptie\" 122) aux plan et livre île renvoi officiels de la paroisse de Ste-Fumille de Biiiii'lierville, mesurant cent quatre-vingt-neuf pieds et quatre dixièmes de pied (189.4') en front dans sa ligue nord-ouest, cent quatre-vingt-deux pieds et quaire dixièmes de pied (182.4') en arrière dans sa ligne sud-est, cinq mille soixante-deux pieds et trois dixièmes de pied (5.002.3') d'un côté dans sa ligne nord-est et cinq mille trenteet un pieds et sept dixièmes île pied (5,031.7') de l'autre côté dans sa ligne sud-otiést; bornée en front au nord-ouest pur la rue De Normandie, en arrière au sud-est par une partie du lot numéro 200 dudit cadastre, au nord-est pur partie du lut numéro 122 et de l'autre côté au sud-ouest par de- parties des lots 124 et 159.Description de l'immeuble Description of immovable A part of original lot number one hundred and twenty-two (122 Pt.) on the official plan and book of reference of the parish of Ste-Fnmille de Bouclierville.measuring one hundred and eighty-nine feet and four tenths of a foot (189.4') in front in its northwest line, one hundred and eighty-two feet and four tenths of a foot (182.4') in rear in its southeast line, five thousand sixty-two feet and three tenths of a foot (5,002.3') on one side in its northeast line and five thousand thirty-one feet and seven tenths of a foot (5.031.7') on the other side in its southwest line, bounded as follows: in front to the northwest by De Normandie Street, in rear to the southeast by a part of lot 200.on one side to the northeast by purl of lot 122 and on the other side to southwest by parts of lots 124 and 159.3-4\" 150 I Prestige Dev.Ltd.l'ne partie du lot 120 bornée comme suit : au nord-est par la rue Moutarville, au nord-ouest par une partie 'lu lui 71.au sud-ouest par les lots 128-28 a 128-30.120-39 el au sud-est par le lot 120-14.3- 49-450 I Prestige Dov.Ltd.lue partie du lot 120 bornée comme suit: au nord-ouest piir le lot 120-14, au nord-est par la rue Moutarville.au sud-est par la rue De Normandie et au sud-ouesl par le lot 120-3 et une partie du lot 128.3-13-400 | Prestige Dev.Ltd.l'ne partie du lot 71 bornée connue suit: au nord-ouesl pur le lot 71-12, au nord-est par la rue Montai-ville, au sud-ouest par les lots 71-35 il 71-41 et au sud-c»t par une partie du lot 120.A part of lot 120 bounded as follows: on the northeast by Moutarville Street, on the northwest by a part o> lot 71.on the southwest by lots 128-28 to 128-30-120-39 and on the southeast by lot 120-14.A part of lot 120 bounded as follows: on the northwest by lot 120-14, on the northeast by Moutarville Street and on thc southwest by lot 120-3 and a part of lot 128.3 40 150 \u2022t 108 1151 :< HIS 1138 3 Ins 1130 ¦I ins h34 3 His 1122 \u2022I HI -Hit) 3 01-401 3 72 1121 \u2022I 72 1125 3 72 1129 3 72 1129 3 ill 407 :i m 171 3 III 370 Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Prestige Dev.Ltd.Hilda Corporation.A part of lot 71 hounded as follows: oil the northwes1 by lot 71-12, on the northeast by Moutarville Street-on the southwest by lots 71-35 to 71-41 and on the southeast by a part of lot 120.120 1.120 0.12s 09.120 8, 128 78.120 9.128 79.120 10, 128 80.120 12, 128 84.120 13.128 47.120 10, 128 42.120 31.120 32.120 33.128 80, 08.152.120 38.120 39.1 ne partie du lot 127 ayant une superficie approximative dc 27.84 arpents, plus ou moins, et bornée pomme suit: au nord-ouest par les lots 127-114 il 127-127.au nord-est par une partie du lot 127, au sud-ouest pin la partie du lot 129 el au sud-est pur une purtie 'lu lot 155.\u2022'< 1» 301 I Mike Puvlutos cl Uxor.^ distraire une partie expropriée appert numéro ?j'-'355 Hinla Corporation.¦i 10-340 Hinla Corporation.\\ distraire une purtie expropriée appert numéro 202123.A part of lot 127 containing un urea of approximately 27.84 arpents and more or less, and bounded as Follows: on the northwest bv lots 127-114 to 127-127.on the northeast by a part of lot 127, on the southwest by a part of lot 129 and on the southeast by a part of lot 15j.I 127 0.To lie deducted a part of said lot expropriated as apiiears number 292423.127 7.127 8.To be deducted a part of said lot expropriated as appears number 292423.3 19 349 I Hilda Corporation.\u2022\".i,M,'3stra're U\"e '\"'rt'e exl,r°l>r'fc \"Wert numéro To be deducted a part of said lot expropriated as appears number 292423. 6972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n\" ÔO Rôle Roll Nom du propriétaire Name of proprietor Description de l'immeuble Description of immovable 3-40-343 I Kolnsis, Savas.I 127 0.A distraire une purtie expropriée appert numéro To be deducted a part of said lot expropriated a, 292423.apiiears number 292423.3-49-330 I Fotinos.George.I 127 10.A distraire une purtie expropriée appert numéro To lie deducted a parrt of said lot expropriated n 292423.iipiiears number 292423.3-49-336 I Kolasis.Savas.I 127 II.A distraire une partie expropriée appert numéro To be deducted a part of said lot expropriated m 292423.appears number 292423.3-13-1165 Fotinou Fotini.(Mile-Miss).3-13-1151 Hinla Corporation.3-13-1145 Hinla Corporation.3-13-11441 Hinla Corporation.3-03-339 Sam Vasilinkos.3-93-341 Sam Vasillakos.3-03-345 Tarnvakos, Georges.3-93-361 Hinla Corporation.3-93-353 Hinla Corporation.3-93-357 Hinla Corporation.3-03-350 Hinla Corporation.3-72-1131 Hinla Corporation.3-93-330 Hinla Corporation.3-49-300 Hinla Corporation.3-110-1189 Hinla Corporation.3-110-1191 Hinla Corporation.3-110-1105 Hinla Corporation.3-110-1199 Mourtakos, Elias el Uxor.3-110-1201 Hinla Coriioration.3-110-1205 Hilda Corporation.3-110-1200 Hilda Corporation.3-110-1211 Hinla Corporation.3-110-1215 Hinla Corporation.3-110-1221 Hinla Corporation.; 3-110-1225 Hinla Corporation.3-110-1229 Hinla Corporation.3-110-1231 Hinla Corporation.3-110-1235 Hatzuglidis, Antonios.3-49-350 Hinla Corporation.3-40-344 Hinla Corporation.3-49-340 Hinla Corporation.3-49-330 Voutsinas, Konstantinos Andreas.A distraire une partie expropriée appert acte numéro 202423.To lie deducted a .np|«ars under number 127 12.127 13.127 16.127 10.127 19.127 20.127 21.127 24.127 26.127 20.127 29.127 34.127 35.127 30.127 38.127 30.127 40.127 41.127 42.127 43.127 44.127 45.127 40.127 48.127 49.127 50.127 61.127 52.127 55.127 56.127 57.127 68.>art of said lot expropriated n 292423.3-49-330 Bouyoucus, George Mme-Mrs.\u2022 \u2022 \u2022 ¦ ¦ \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022 ¦ \u2022 \u2022 I V2J .ovnr\u201ellri,.lc,l A distraire une purtie expropriée appert acte numéro To lie deducted a partiof sold lot expropriated 202423.appears under number 292423.3-96-335 3-95-339 3-95-345 3-95-349 3-95-340 3-05-344 3-05-350 3-116-11081 3-110-1200 3-110-1204 3-110-1220 3-110-1222 3-110-12281 3-110-1230 3-110-1234 '3-110-1238] 3-101-349 3-101-345 3-114-1231 3-114 1229 3-114-1221 3-114-1219 3-114-12151 3-114-1211 3-114-1201 3-114-11991 3-114-1195 3-114-1191 3-114-1269 3-110-1270| 3-116-1270 3-110-1208 3-110-1251 3-110-1205] 3-110-1275] 3-110-1277 3-110-1291 3-40-387 Hinla Corporation.Christodoulos, Steve.Hinla Corporation.11 a rem-.Allgelo.Spiliopoulos, George.Hinla Coriioration.Goltsios, Gus.Dimopoulos.Démétrios el Uxor.Hinla Corporation.Hinla Corporation.Hinla Corporation.Hinla Coriioration.¦ Hinla Corporation.Hatzis, Vassilios et Vxor.Kollias, Nicolaos.Hinla Corporation.Kolasis.Savas.Hinla Coriioration.Hinla Corporation.Hinla Coriioration.Hinla Coriioration.Hinla Corporation.Hinla Corporation.Hilda Coriioration.Hilda Coriioration.Hinla Corporation.Dimopoulos, Démétrios \"»\"« suit: au nord-ouest par les lots P-129-1388, 129-1389 à 129-1393.129-1386.au nord-est par une partie \"lu lut 127, au sud-ouest par une purtie du lot 131 et au sud-csl pur une purtie des lots 151.153, 154.3 W 300 | Peter Evdokias.128 4.128 5.128 0.128 7.128 8.128 0.128 10.128 11.128 12.128 13.128 14.128 15.128 10.128 17.128 18.128 10.128 20.128 21.128 23.128 24.128 25.128 20.128 27.128 28.128 29.128 48.128 49.128 50.128 51.128 52.128 53.128 54.128 55.128 50.128 57.128 68: 128 59.128 00.128 04, 120 5.128\" 05.128 00.128 07.128 08.128 70.128 71.128 72.128 73.128 74.128 75.128 70.128 81.128 82.128 83.128 87.120 34, 08 153.128 88.120 35.08 154.128 89.120 37.128 90.120 30.128 91.'\".i;M-,'i\"'r,l're \"\"e l>\"r,ie txPmPrfée appert acte numéro :i 10 328 | Bouyoucas, George Mine-Mrs.I 120 1101.A part of lot 129 containing an area of approximately 40.97 arpents and more or less and liounded as follows: on the northwest by lots P-120-1388.129-1389 to 129-1393.129-1386.on the northeast by a part of lot 127, on the southwest by a part of lot 131 and on the south-cast by a part of lots 151.153.151.I 120 1201.To lie deducted a part of said lot expropriated us appcai» under number 292423. 6974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° 60 A distraire une partie expropriée appert acte numéro 292423.To be deducted a part of said lot expropriated a* appears under number 292423.Cadastre de In paroisse de Sninte-FnmUle de Bouclierville (suite) Cadastre of the parish of Suinte-Famille de Bouclierville (continued) Hole Hull Nom du propriétaire Name of proprietor 3-49-320 I Hinla Corporation.A distraire une purtie expropriée appert acte numéro 292423.Description de l'immeuble Description of immovable 3-49-322 I Myrinnthopoulos.John.A distraire une partie expropriée appert acte numéro 292423.129 1192.To lie deducted a part of said lot expropriated aa appears under number 292423.I 120 1193.To be deducted n pari of said lot expropriated as appears under number 292423.3-49-310 I Hinla Corporation.I 129 1195.A distraire une partie expropriée appert acte numéro To be deducted a part of said lot expropriated Us 292423.appear.- under number 292423.3-49-314 I Peter Evdokias.A distraire une partie expropriée appert acte numéro 292423.3-19-310 | Peter Evdokias.A distraire une partie expropriée appert acte numéro 292423.| 129 1190.To be deducted a part of said lot expropriated as appears under niunlicr 292423.I 120 1108.To be deducted a part of said lot expropriated as appears under number 292423.3-40-302 I I'eter Evdokias .A distraire une purtie expropriée appert uelc numéro 292423.| 129 1200.To be deducted a part of said lot expropriated as appears under numlier 292423.3-95-311 Hilda Corporation.3-95-313 Liokarcas, i'eter.3-95-315 Liokarcas.I'eter.3-95-321 Myrianthupoulos, John.3-95-325 Hinlu Corporation.3 95-329 Bouyoucas, George Mme-Mrs.3-95-333 Hilda Corporation.3-49-290 I'eter Evdokias.A distraire une partie expropriée appert acte numéro 292423.129 1200.129 1207.129 1208.129 1210.129 1211.129 1212.129 1213.129 1215.To lie deducted a part of said lot expropriated as appears under number 292423.3-07-1182 Nikius.Horolambos.3-07-1 ISO Tsursitnllidis, Elias.3-07-1184 Hinlu Corporation.3-07-1188 Hinla Corporation.3-07-1200 Hinlu Coriioration.3-97-1202 Hinla Corporation.3-120-1232 Villemaire.Germain.3-120-1238 Hinla Corporation.3-120-1242 MuierLudvig.3 120-1240 Dulin Dieter.3-120-1274 I'eter Evdokias.3-97-1190 Hinlu Corporation.3-97-1199 I'eter Evdokius.3-97-1197 I'eter Evdokias.3-97-1193 Vithoulkus, Spiros.3-1*5-404 I'eter Evdokius.3-95-300 I'eter Evdokias.3-120-1191 Kostenns.John et Uxor., .3-120-1195 Kostenns, John it Uxor.3-120-1199 Theodorou, John et Uxor.3-114-1202 Hinlu Corporation.3-114-1200 Hilda Corporation.3-114-1210 Hinla Corporation.3 114-1214 Hinlu Corporation.3-114 1210 Hinlu Corporation .3 114-1228 Hinla Corporation.3-120-1229 Hinla Corporation.3-114-1232 Mitrakos, I'eter.3 114-1234 .Mitrakos.I'eter.3-120-1213 Kaliméris.Spiros.3-120-1201 Hinla Cur|x>riilion.3-00-310 Gasparinatos, Alexis Mme-Mrs.3 00-310 Gasparinatos, Alexis Mme-Mrs.3-00-320 Hilda Coriioration.3 120 1222 Hilda Corporation.3-120-1220 Lufrnnee.Alphonse.3-120-1228 Lufrnnee, Alphonse.Alphonse Lufrnnee est propriétaire de lu moitié nord-ouest du lot 129-1303, cotte purtie mesurunt 30 pieds de hirgeur pur 100 pieds de profondeur, et est Ixirnée comme suit: en front nu nord-est par le lot 129-1293 (rue), en arriére au sud-ouest par une purtie du lot 129-1321.d'un côté nu sud-est pur le résidu du lot 129-1303 et dc l'autre côté pur le lot 1302 nu nord-ouest.129 1217.129 1210.129 1218.129 1220.129 1224.129 1225.129 1301.129 1300.129 1307.120 1308.129 1312.129 1221.129 1242.129 1243.129 1245.129 1251.129 1252.129 1208.129 1209.129 1270.129 1271.129 1272.129 1274.129 1275.129 1270.129 1279.129 1284.129 1280.129 1281.129 1289.129 1292.129 1299.129 1298.129 1300.129 1301.129 1302.129 1303.Alphonse Lufrnnee is owner of the half aorthwesl pnrt of lot one thousund three hundred nnd three ol tnç subdivision of originnl lot numlier one hundred ami twenty-nine (120-1-1 N.W.1303 Pt.) on the ollniid plan and book of reference of the parish of Ste-rumille de Bouclierville, measuring the said part thirty feet (30') in width by one hundred feet (100') in depth mid Ixiunded as follows: in front to the northeast by the lot 129-1293 (Street), in rear to the southwest by a part of lot 129-1321, on one side to the southeast by the residue of said lot 129-1303 and on thc other - .de to the northwest by the lot 129-1302. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 19, 1969, Vol.101, No.50 6975 Cadastre de la paroisse de Sainte-Famille de Bouclierville (suite) Cndustre of the parish of Sainte-Famille de Bouclierville (continued) Hole Roll Nom du propriétaire Name of proprietor 3-120-1228 Villemaire, Germain.i icrmain Villemaire est propriétaire de lu moitié sud-est du lot 129-1303, Mtte partie mesurant 30 pieds de largeur par 100 pieds de profondeur, et est bornée connue suit: en front au nord-est par le lot 129-1293 (roc), en arrière au sud-ouest par une purtie du lot 129-1321, d'un côté au sud-est par le lot 129-1304 et île l'autre côté au nord-ouest par le résidu du lot 120-1308.Description de l'immeuble Description of immovable 129 1303.Germain Yillemiiirc is owner of the half southeast part of lot one thousand three hundred and three of the 'subdivision of original lot number one hundred nnd twenty-nine (129-H S.E.1303 Pt.) on the official plan and book of reference of the parish of Ste-Famille de Bouclierville, measuring the said part thirty feet (30') in width by one hundred feet (100') in depth and bounded as follows: in front to the northeast by the lot 120-1293 (Street) in rear to the southwest bv a part of lot 129-1321, on one side to the southeast by lot 129-1304 and on the other side to tho northwest by the residue of said lot 129-1303.3-1 IS-1200 I'eter Evdokias.3 I IK 1280 Tsotroudis, Athina Mile-Miss.3 IIS 1282 I'eter Evdokias.3 I IS-1284 Hinla Corporation.3 lis 1288 I'eter Evdokias.3 I IS-1290 I'anigiotis, Izaneas.3 11(1 1308 Hinla Corporation.3 I III-1300 I'eter Evdokias.3 I Hi 1298 I'eter Evdokias.3 110-1299 I'eter Evdokias.3 120-1230 Limberis, Léo.3 120 1243 Limberis, Léo.3 114 1290 Hinlu Corporation.3 III 1290 Hinln Corporation.('ne partie du lot 129-1351 ayant une superficie approximative de 3,027 pieds carrés et bornée comme suit: au nord-ouest par une partie du lot 129-1346, au sud-ouest par le lot 129-1350, au nord-est par une purtie ¦In lot 129-1351 et au sud-est par la rue Dc Granville.3 114-1280 3 III 1200 3 III 1254 3 III 1250 ¦I III 1240 3 114-1240 3 114 1201 3 114 1281 3 III 1285 3 111 12113 3 110 1274 3 110-1292 3 110 1287 3 118 1293 3 77 401 129 1320.129 1330.129 1331.129 1332.129 1333.120 1334.129 1375.129 1370.129 1377.129 1392.129 1338.129 1339.129 1350.129 1351.A part of lot 129-1351 containing an urea of approximately 3.027 square feet and bounded us follows: on the northwest by purt of lot 129-1340, on the southwest by lot No.129-1350, on the northeast by part of lot 129-1351 nnd on the southeast bv De Granville Street.Hinla Corporation.Hinla Corporation.Hilda Corporation.Hinla Corporation.Mirnnthopoulos, William.Miranthopoulns.William.Hinla Corporation.Knlabokes, G us.I'eter Evdokius.Metaxiotis, Lazaros.Hinln Corporation.Hinlu Corporation.Hinla Corporation.Hinln Corporation.Hinla Corporation.Une partie du lot 155 usant une superficie approximative de 9.084 arpents, plus ou moins et bornée comme suit: au nord-ouest par une pnrtie du lot 127, au sud-l'si par la route Trans-Cunndienne, nu nord-est par une partie du lot 155 et au sud-ouest par une partie du lot 151.3 77 401 | Hinla Corporation.t'ne partie du lot 155 avant une superficie npproxinin- 129 1353.129 1357.129 1358.129 1359.129 1300.129 1301.129 1306.120 1370.120 1371.120 1373.120 1384.129 1385.120 1388.129 1380.live ois de construction et de tout autre matériau de construction, soit cn gros ou cn détail, ainsi que tout établissement dc préparation dc bois cn transit.3.08 Lc sciage, lc débitage, lc rabotage, lc façonnage, l'empilement, lc transport, la réception, l'expédition, la livraison et la manutention de bois de construction seulement ou à la fois de bois et de tout autre matériau.3.09 Exemption: Le présent décret ne régit pus les scieries et les travailleurs cn forêt.Article IV.Taux de notaire minimaux: 4.01 Les taux minimaux de salaires seront les suivants: Section III.Professional jurisdiction: 3.01 The present Decree covers all employers and all skilled and unskilled employees of any establishment that carries out, as a prinei|ml ,ir secondary occupation, one or another of the following work: 3.02 Joinery operations: preparation und fini, siting pieces of wood with manual or machine tools, fabrication, préfabrication and repair of any piece or accessory of wood only or of wood und any other material at the same time, performed according to plans or other given measures, with or without specifications, intended for any dwelling, public building or any type of building, constructed or already existing.3.03 Any prefabricated article, made exclusively of wood, or of wood and any other material.Préfabrication of partitions or repair inside apartments.3.04 Any trimming of wood, uny type of cupboard of wood, without limiting the general sense of these terms.3.05 The selling, transportation, reception, shipping, delivery and handling of these accessories of wood.3.06 The present Decree covers also the establishments performing the following work, without limiting the general sense of thc terms.3.07 The preparation, selling of wood und any other material for building puiposes either in wholesale or in retail, as well as uny establishment for the preparation of wood in transit.3.08 Thc sawing, cutting, planing, shaping, piling up, transportation, reception, shipping, delivery ami handling of merely wood for building purposes of wood and uny other material at the sume time.3.09 Exception: Thc present Decree docs not govern employees in saw-mills or forest-workers.Section IV.Minimum wage rates: 4.01 The minimum wuge rates arc us follow: A compter delà publication de l'arrêté en conseil From publication of order Chef d'équipe - Atelier dc menuiserie \u2014 Shift-boss - joinery shop.$2.59 Chef d'équipe - Cours à bois \u2014 Shift-boss - lumberyard- 2.32 Menuisier d'atelier - Classe « A » \u2014 Shop joiner - Class \"A\" 2.49 Menuisier d'atelier - Classe « B > \u2014 Shop joiner - Class \"B\" 2.37 Menuisier sur machine\u2014 Machine joiner.2.32 Tourneur \u2014 Turner.2.45 Conducteur de machine - Class « A » \u2014 Machine operator - Class \"A\".2.27 Class « B » 1er semestre \u2014 Class \"B\", 1st six months.2.16 Classe « B », 2ème semestre \u2014 Class \"B\", 2nd six months.2.22 Aide conducteur de machine - moins de 19 ans \u2014 Machine operator's helper - to 19 years.1.95 Plus de 19 ans \u2014 Over 19 years.2.16 Machiniste \u2014 Machinist.2.49 Conducteur (mécanicien) dc machines fixes \u2014 Stationary engineman.2.16 Classeur, mesureur, vérificateur \u2014 Grader, scaler, checker.2.27 Expéditeur, receveur \u2014 Shipper, receiver.2.22 Chauffeur de camion \u2014 Truck driver.2.27 Conducteur de tracteur \u2014 Tractor operator.2.27 A compter du \u2014 From H4I70 1UI71 nom S2.74 2.74 2.64 2.52 2.47 2.60 2.42 2.31 2.37 2.10 2.31 2.64 2.31 2.42 2.37 2.42 2.42 $2.94 2.67 2.84 2.72 2.67 2.80 2.62 2.51 2.57 2.30 2.51 2.84 2.51 2.62 2.57 2.62 2.62 $3.01 2.77 2 91 2.82 2.77 2.90 2.72 2.61 2.67 2.40 2.61 2 91 2.61 2.72 2.67 2.72 2 72 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.60 6983 Conducteur de chariot-élevatcur \u2014 Lift-truck operator (in-dieu \u2014 Watchman.Manoeuvre \u2014 Labourer.Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année \u2014 1st year.2ème année \u2014 2nd year.3ème année \u2014 3rd year.Compagnon débutant \u2014 Junior journeyman.Étudiant \u2014 Student.4.02 Salaires effectifs: Les taux dc salaires effectifs des employés devront être augmentés de lu façon suivante: S0.25 l'heure à compter de la publication dc l'arrêté cn conseil \u2014 80.15 l'heure à compter du 1er avril 1970 \u2014 S0.20 l'heure à compter du 1er janvier 1971 et $0.10 l'heure ù compter du 1er juin 1971.4.03 Etudiants: Un employeur peut engager des étudiants pour la période des vacances, soit du 15 mai uu 1er octobre, muis cela ne doit pas rire l'occasion dc licenciements.De plus, lc nombre d'engagements d'étudiants ne doit pas dépasser dix pour cent (10%) de l'effectif total (les salariés de l'entreprise assujetti au présent décret.» 1.01 Avantages supérieurs: Tout salarié à l'emploi de l'employeur, qui bénéficie d'un taux de salaire supérieur ù l'échelle des taux de salaires mentionnés ù l'article 4.01 conserve les mêmes avantages dans les mêmes proportions, ù la suite de> majorations définies à l'article 4.02 et ne subira aucune diminution dc salaire à l'occasion de l'entrée en vigueur du décret ou pendant toute sa durée.4.05 Alternance: Tout salarié, dont la tache exige une alternance régulière et continue entre deux (2) ou plusieurs occupations, reçoit le salaire prévu pour l'occupation la mieux rémunérée.4.06 Nouvelle lâche \u2014 Emplois non prévus: l.a rémunération de tout salarié exerçant un emploi non mentionné ù l'article 4.01 du décret doit être supérieure d'au moins dix (80.10) cents l'heure au minimum fixé pour le manoeuvre ou journalier.4.07 Travail de nuit: Tout salarié faisant partie d'une équipe de nuit, u droit ù une prime additionnelle dc dix (10) cents l'heure eu plus du taux de suluire effectifs, pour chaque heure de travail.Article Y.Heures normales de travail: \u2022\").') 1 Les heures normales de travail des salariés son1 les suivantes: n) Quarante-deux heures et demi (421£) par semaine, réparties cn cinq (5) jours «le huit heures et demi (8}4), du lundi au vendredi inclii-siv< ment.''i A partir du 1er janvier 1971: Quarante (40) heures par semaine, réparties en cinq (5) jours de huit (8) heures, du lundi au vendredi inclusivement.' i Ces heures normales de travail sont réparties entre 7 heures et 18 heures.5.02 Pour les chauffeurs de camion, les machinistes, les conducteurs de tracteurs et les conducteurs «le chariot élévateur, la semaine normale de travail est la suivante: A compter\t\t\t de la\t\t\t publication\t\t\t de l'arrêté\t\t\t en conseil\tA compter du \u2014\t\tFrom From\t114170\t111171\t116171 publication\t\t\t of order\t\t\t 82.27 .\t$2.42\t82.62\t$2.72 2.00\t2.15\t2.35\t2.45 2.16\t2.31\t2.51\t2.61 1.56\t1.71\t1.91\t2.01 1.73\t1.88\t2.08\t2.18 1.89\t2.04\t2.24\t2.34 2.25\t2.40\t2.60\t2.70 1.75\t1.75\t1.75\t1.75 4.02 Regular wages: Thc regular wage rates of employees shall be increased as follows: $0.25 per hour from publication of thc Order in Council \u2014 80.15 per hour from April 1st 1970 \u2014 80.20 per hour from January 1st 1971 and $0.10 per hour from June 1st 1971.4.03 Students: An employer may hire students for thc vacation period, viz.from May 15 to October 1st, but it shall not occasion layoff.Moreover, the number of hiretl students shall not exceed 10% of the total number of employees of the establishment governed by the present Decree.4.04 Higher advantages: Every employee who is presently in an employer's service and who receives a wage rate higher than those specified in the wage scale given in section 4.01, shall continue to receive the same advantages in the same proportions, following the increases stipulated in section 4.02.His wages shall not be reduwd either on the effective date of the present decree or during its term.4.05 Alternance: Every employee who has to work alternately in two or more categories, shall receive thc wage rate of the better-paying category.4.06 New trade \u2014 Unforeseen occupations: Every employee whose occupation is not listed in section 4.01 of the present decree shall be paid at least ten cents (10é) an hour above the minimum herein specified for lubourers.4.07 Night shift: Every employee working on a night shift is entitled to a 10d-an-hour shift differential (bonus) for each hour worked.Section V.Standard working hours: 5.01 Standurd working hours of employees are as follows: (a) forty-two and a half (42>^) working hours per week divided into five (5) days of eight and a half 1,814) working hours each, Monday through Friday.(b) From January 1971 : Forty (40) working hours divided into five (5) days of eight (8) hours each, Monday through Friday.(c) Standard working hours are scheduled between 7:00 a.m.and 6:00 p.m.5.02 Standard hours of work for truck drivers, machinists, tractor operators and lift-truck operators arc as follows: 6984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 19G9, 101- année, n° 50 a) Quarante-huit (48) heures réparties cn cinq (5) jours, du lundi au vendredi inclusivement.Dix (10) heures par jour, les mardis, mercredis et vendredis.Neuf (9) heures par jour, les lundis et jeudis.b) À partir du 1er avril 1970: Quarante-six (46) heures, réparties en cinq (5) jours, du lundi au vendredi inclusivement.Neuf (9) heures par jour, les lundis, mardis, mercredis et jeudis; dix (10) heures par jour les vendredis.c) A partir du 1er avril 1971 : Quarante-cinq (45) heures réparties en cinq (5) jours dc neuf (9) heures, du lundi au vendredi inclusivement.d) Ces heures régulières de travail sont réparties entre 6 heures et 20 heures.e) La durée de la journée normale de travail du machiniste est constitué d'un maximum dc dix (10) heures.5.03 Aide camionneur: Pour les aides camionneurs, la semaine normale de travail est dc quarante-cinq (45) heures, réparties cn cinq (5) jours dc neuf (9) heures du, lundi au vendredi inclusivement, soit entre 6 heures et 20 heures.5.04 Mécanicien de machines fixes: Pour les mécaniciens dc machines fixes, la semaine normale dc travail est dc soixante (60) heures, réparties entre 6 heures et 24 heures.Lu durée maximale de la journée de travail est dc douze (12) heures.5.05 Gardien: La semaine normale dc travail des gardiens est dc soixante-douze (72) heures.La durée maximale de la journée de travail est de douze (12) heures.5.06 Travail de nuit: La semaine normale pour le truvail de nuit est de quarante (40) heures, réparties cn cinq (5) jours de huit (8) heures, du lundi uu vendredi inclusivement.5.07 Période de repas: a) tout salarié a droit ù une période de repos d'une demi (}\u2022\u2022>) heure ou d'une (1) heures pour son dîner.b) tout salarié affecté à une équipe de nuit a droit à une période d'une demi (p£) heure ou d'une (1) heure pour prendre un repas, après avoir complété une période de quatre (4) heures dc travail.5.08 Système d'équipe: Trois (3) équipes: L'employeur accorde uux salariés, qui travaillent sous le régime de trois (3) équipes rotatives, une pause de trente (30) minutes sans perte dc saluirc pour permettre uux salariés de prendre leur repus.5.09 Période de repos: a) Tout salarié a droit ù une période dc repos de dix (10) minutes, l'avant-midi et dc dix (10) minutes l'après-midi sans perte dc salaire.b) Tout salarié qui travaille la nuit, ù droit ù une période de repos de dix (10) minutes dans la première ainsi que dans la deuxi me période de quatre (4) heures dc travail.(c) Pour les salariés qui travaillent sous le régime de trois (3) équipes rotatives, chacune dc ces |>ériodes dc repo< de dix (10) minutes est accordée duns lu première ainsi que dans la seconde moitié de chaque équipe Article Vf.Travail supplémentaire: 6.01 Tout travail exécuté cn plus du nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires ou cn dehors des limites horaires fixées ù l'article 5, est considéré comme du travail supplémentaire et doit être rémunéré au taux de salaire effectif majoré dc 50%.(a) forty-eight (48) hours divided into live (5) days from Monday through Friday.Ten (10) hours u day on Tuesday, Wednesday and Friday.Nine (9) hours a day on Monday und Thursduv (b) From April 1st 1970: Forty-six (46) hours divided into five (5) days Monday through Friday.Nine (9) hours a day on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday; ten (10) hours a day on Friday.(c) From April 1st 1971: Forty-five (45) hours, divided into five (5) days of nine (9) hours each, Monday through Friday.(d) These standard hours of work arc scheduled between 6:00 a.m.and 8:00 p.m.(e) Standard working day for a machinist shall not exceed ten (10) hours.5.03 Truck driver's helper: The standard working week for a truck driver's helper is forty-five (45) hours, divided into five (5) days of nine (9) hours each, Monday through Friday, scheduled between 6:00 u.m.and 8:00 p.m.5.04 Stationary engineman: The standurd working week of stationary enginemcn is sixty (60) hours scheduled between 6:00 a.m.and midnight.Standard hours of work shall not exceed twelve (12) hours.5.05 Watchman: Thc standard working week of watchmen is seventy-two (72) hours.Standard hours of work shall not exceed twelve (12) hours.5.06 Night shift: Hours of work at night shall not exceed forty (40) hours a week, divided into five (5) days of eight (8) hours each, Monday through Friday.5.07 Meal periods: (a) All employees are entitled to one-half hour's rest or one (I) hour's for their dinner.(o) All employees on a night shift are entitled to one-half (J4) hour's or one (1) hour's rest for their meals, after having completed u four (4) hours' period of work.5.08 Shift rotating system: The employer shall give to thc employees, working in a three-shift rotating system, a thirty (30) minutes' rest with pay for their meals.5.09 Rest periods: (a) All employees shall be entitled to ten l II» minutes' rest with pay in both morning und afternoon.(b) All employees working on a night-shift, shall be entitled to ten (10) minutes' rest both in the first and in the last four (4) hours' working period.(c) All employees working in a three-shift rotating system shall be entitled to ten (10) minutes' rest in both of thc two halves of the shift.Section VI.Overtime: 6.01 Time and one half shall be paid for ail work performed over and above the maximum weekly or daily working hours stipulated in the present decree, section V. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 6985 6.02 Travail sur équipe de nuit: Même si la durée de travail sur l'équipe de nuit est inférieure ù trente-sept (37) heures, tout salarié requis d'y travailler doit être rémunéré pour un minimum de trente-sept (37) heures au taux de salair,' effectif et de la prime qui s'applique.6.03 Travail le dimanche: Tout travail exécuté le dimanche est rémunéré au taux de salaire ell'eelif majoré de 100%.6.01 Tout salarié appelé ù travailler, un jour férié et payé, énumérés à l'article 9.01 doit être rémunéré au taux du salaire effectif majoré de 100%.en plus de son indemnité du jour férié payé.Article VII.Minimum de paie: 7.111 Heures de travail: On désigne en outre, comme heures de travail à être rémunérées, les heures ou fraction d'heure pendant lesquelles le salarié doit, à la demande de l'Employeur, demeurer sur les lieux dc son travail ou pendant lesquelles il attend une assignation sur les lieux du travail.7.02 llappel au travail: Tout salarié qui a quitté les lieux du travail et qui est rappelé pour venir travailler en dehors de ses heures normales île travail est rémunéré au taux de truvail supplémentaire et doit recevoir une indemnité minimum égale à trois (3) heures de salaire, sauf si rappelé le malin il y a continuité de la période dc travail supplémentaire dit au rappel au travail et de la journée régulière de travail.7.03 Avis préalable: Tout salarié qui se rapporte à son travail à l'heure habituelle et qui n'a pas été informé que ses services ne sont pas requis, reçoit une indemnité égale à trois (3) heures de travail à son taux de salaire effectif.Article VIII.Système à la pièce: S.01 Si un système ù la pièce, ù forfuit ou autrement, est établi duns un établissement, les salariés doivent recevoir uu moins le taux horaire normal ou majoré prévu selon le cas dans lc décret.Article IX* Jours fériés chômés et payés: 9.01 Tout salarié iloit recevoir une indemnité égale à une ( 1 ) journée de salaire uu taux dc salaire effectif pour les jours fériés suivants': I-e premier \u2022lourde l'An, le 2 janvier, la St-Jean-Baptistc, la Confédération, la Fête du Travail, le Jour dc Noël cl ù partir de 1970, le 26 décembre.9.02 Les jours fériés sont rémunérés au taux dc solaire effectif et pour lc nombre d'heures fixé à l'article 5 du décret pour une journée normale de travail.9.03 Tout salarié a droit ù la rémunération des jouis fériés suivants, même si ces jours fériés surviennent un samedi ou un dimanche: Le Premier Jour de l'An, la .St-Jean-Baptiste, la Confederation et lc Jour dc Ncël.9.04 Si l'un ou plusieurs dc ces jours fériés et payes surviennent durant la période des congés annuels d'un salarié, son congé est alors prolongé d'autant.9.05 Pour avoir droit à la rémunération des jouis fériés et payés, le salarié doit être uu service «le l'employeur depuis douze (12) mois et appa-raîl re sur la liste de paie dans les quinze (15) jours qui précèdent ou dans les quinze (15) jours qui suivent le jour férié et payé.Le salarié qui quitte volontairement le service de son employeur ou congédié pour cause, dans les quinze (15) jours qui précèdent le jour férié » a pas droit à telle rémunération.6.02 Night shift: Even though working hours of the night shift were less than thirty-seven (37) hours a week, all employees in such a shift shall be paid for at least thirty-seven (37) hours at regular wage rates with addition of the bonus stipulated.6.03 Work on Sunday: All employees called in for work on Sunday shall be paid double time.6.04 All employees called in for work on a general holiday with pay, as listed in section 9.01, shall be paid double time over and above their holiday pay.Section VII.Minimum pay: 7.01 Working hours: Full or part time an employee has to remain on the working area, on request of the employer, or during which he waits there for his work order, shall be paid as working hours.7.02 Call for overtime: Any employee who has left working grounds and who is called in for work beyond regular working hours, shall be paid at overtime rate and receive a compensation that equals at least three (3) hours' wages, excepted if he is called back in the morning and overtime period is continuous with thc regular working hours.7.03 Notice period: Any employee reporting for work at the regular time and who has not been informed that his services are no longer required, shall be entitled to a compensation equal to three working hours at regular wage rate.Section VIII.Piece-unrk: 8.01 If an establishment adopts a piece-work, contract or other type system, employees shall be paid at least the minimum hourly wage rate or hourly overtime rate herein stipulated.Section IX.General holidays toith pay: 9.01 Every employee is entitled to one (1) full day's pay for each of the following days: New Year's Day, January 2nd, St.John the Baptist Day, Canada Day, Labour Day and Christmas Day, and beginning in 1970, December 26th.9.02 General holidays shall be paid at the regular wage rate for the number of hours stipulated in section V for a standard working day.9.03 All employees are entitled to a vacation pay as well on Saturday or Sunday for the following days: New Year's Day, Saint John the Baptist Day, Canada Day and Christmas Day.9.04 Every employee is entitled to one additional day's vacation for each general holiday with pay falling during his annual vacation period.9.05 To be entitled to such holiday pay, the employee shall have been in the same employer's service for twelve (12) months and his name must appear on the payroll fifteen (15) days before and fifteen (15) days after the holiday.Any employee who quits the employer's service or who is dismissed for a valuable reason within fifteen (15) days before such a holiday, is not entitled to thc vacation. 0986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 décembre 1969, 101' année, n° 50 Article X.Congés annuels payés: 10.01 Période dc référence: Pour les fins d'application du régime de congés annuels payés, lu période de référence s'étend du 1er janvier uu 31 décembre.10.02 Tout salarié ayant inoins d'une (I) année de services continus ù l'emploi dc l'employeur a droit ù un (1) jour de congé par mois civil dc travail, jusqu'à concurrence de dix (10) jours ouvrables, rémunéré au taux dc quatre pourcent (4%) du salaire gagné.10.03 Tout salarié ayant une (1) année de services continus ù l'emploi de l'employeur a droit n deux (2) semaine de congés, rémunérées uu taux de quatre pourcent (4%) jusqu'au 14 août I960, et par la suite, au taux dc cinq pourcent (5%) du salaire gagné pendant lu période de référence.Cette indemnité est calculée sur le salaire effectif gagné qui figure sur la formule T-4 du service de l'Impôt, fourni par l'employeur uu salarié, avant le 1er mars dc chaque année.10.04 Tout salarié ayant dix (10) ans et plus de services continus ù l'emploi de l'employeur a droit ù deux (2) semaines de congés, rémunérées uu taux de six pour cent (6%) du salaire gagné, après le 1er janvier 1970, conformément ù lu clause 10.03.10.05 Pour les fins d'upplication du présent article, lu durée des services continus comprend, les jours de maladie, les jours dc fermeture, les mises-n-pied, les périodes de congé, les grèves, les absences autorisées, les absences pour accident de travail.10.06 « Les congés annuels se prennent en premier lieu en même temps (pie lu période prévue pour l'industrie de lu construction dans le district de Québec et/ou pur rotation, selon lu préférence exprimée pur les salariés suivant leur ancienneté, dans la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.-> Lu date des congés annuels est affichée du 1er mai nu 1er juin de chaque année.10.07 L'employeur verse uu sularié son indemnité dc congés annuels avant son départ pour vueunces.10.08 Lorsqu'un sularié quitte le service de l'employeur, il a droit aux crédits de congés annuels accumulés jusqu'à lu date de son départ suivant les dispositions des paragraphes 10.01.10.02, 10.03 et 10.04 ci-dessus.10.09 L'employeur ne peut remplacer par une indemnité compensatrice les congés annuels prévus uu présent article.10.10 L'employeur continue de procurer à tout salarié en vueunces les avantages en nature auxquels il a droit en vertu du décret.Article XI.Congés sociaux \u2014 Congés maladie: 11.01 Congés sociaux: Tout salarié ayant une année d'ancienneté a droit aux congés payés suivants, à son taux de salaire effectif, pourvu qu'il s'agisse de jours ouvrables pour le salarié concerné: a) à l'occasion du décès de son conjoint, dc son père, de sa mère ou dc son enfant, trois (3) jours consécutifs, dont le dernier jour est celui des funérailles: b) ù l'occasion du décès d'un frère, d'une soeur, dc ses beaux-parents ou de ses grands-parents, une (1) journée soit le jour de funérailles, pour lui permettre d'ussister à ces funérailles.11.02 Congés maladie: Tout sularié ayant un (I) un d'ancienneté a droit à trois (3) jours de congé maladie payés par année, non cumulatifs.Section X.Annual vacation with pay: 10.01 Qualifying period: To applicale annual vacation with pay stipulations, thc qualifying period extends from January 1st to December 31st.10.02 Any employee who has less than one year's continuous service with an employer shall be entitled to one day's vacation for each calendar month worked, up to maximum ten (10) working days.Vacation pay equals four per cent (4%) of wages earned.10.03 Any employe who has one (1) year's continuous service with un employer shall he entitled to two weeks' vacation.Vacation pay shall be set at four per cent (4%) of wages until August 14th, 1969, and then at five (5) per cent of wages earned in the qualifying period.This com|>ensation is calculated on thc wuge rate of earnings figuring on the T-4 income taxe sheet, provided by the employer every year licforc March 1st.10.04 Any employee who has ten (10) years' continuous service and over with an employer shall be entitled to two (2) weeks' Vacation; Vacation pay shall be set at six (6) per cenl of wages, pursuant to subsection 10.03.10.05 To applicate the present section.Hie continuous service jK'riod comprises sick leave, holidays, lay-offs, vacation duys, strike days, authorized leave, accident leave.10.06 Annual vacation shall be taken in the first place at the same time as the construction industry stipulated period in Québec district and/or shull be chosen according to seniority by thc employees in thc period extending from .lime 1st to September 30th.Annual vueution dûtes shall be posted from May 1st to June 1st.10.07 The employer shall pay the vacation pay before the employee leaves on vacation.10.08 When un employee quits un employer's service, he shall be entitled to thc vacation days accumulated up to thc separation date ami uccording to the proportions stipulated in subsections 10.01, 10.02, 10.03 and 10.04.10.09 No employer may substitute a monetary compensation for the annual vacutions stipulated in this section.10.10 During his employer's vaeution.the employer shall continue to provide him with advantages in kind or other to which lie is entitled, according to the present Decree.Section XI.Special leave \u2014 Sick leave: 11.01 Special leave: Every employee who has one (1) year's continuous service with uu employer, is entitled to the following leave days with pay; at regular wage rate, falling on :i working day for the employee: (a) at the occasion of the death of his « lie, father, mother or child: three days' continuous leave, the last day being the day of thc funeral: (b) on the occasion of thc death of a brother, sister, father-in-law, mother-in-law, grandfather or grandmother, one (1) day's leave on the day of the funeral to allow him to attend the funeral.11.02 Sick leave: Every employee who bus one (1) year's continuous service is entitled to three days of sick leave per year.These leave days cannot be accumulated. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1909, Vol.101, So.50 0987 Avant «le payer un congé maladie, l'employeur peu) exiger In production d'un certificat médical établissant la cause de l'absence ou que le salarié subisse un examen médical par un médicin choisi el payé par l'employeur.Article XII.Dispositions spéciales: 12.01 Rémunération de l'accidenté: Tout salarié, blessé pendant sa période normule dc travail et qui requiert des soins immédiats, peut s'ubsen-ler «le son travail, sans perte dc salaire pour sa période normale dc travail, dans le but dc recevoir les -oins que son état requiert.12.02 Droits acquis: Tout salurié, qui, en vertu d'une entente intervenue avec l'employeur, jouit d'avantages non prévus au décret, continue de jouir dc tels avantages cn autant que les circonstances (pii ont permis leur établissement ne soient lia- changées.Article XIII.Paiement du salaire: 13.01 l.c salaire doit être payé intégralement au salarié chaque semaine au plus tard le jeudi midi, l.c bulletin dc paie doit contenir les mentions suivantes: 1.Le nom et prénom du salarié; 2.La date dc paie et la période de travuil .:i -pondant au paiement; 3.Le taux dc saluirc; \u2022I.Les heures normales et supplémentaires; ô.Les déductions faites; fi.Le montant net payé.Article XIV.Apprentissage: 14.111 Age: Tout apprenti commençant ù apprendre son métier doit avoir uu moins seize (16) ans révolus.14.02 Examens: Au terme de son apprentissage, lottl apprenti doit subir un examen devant un bureau d'examinateurs.Selon le résultat de cet examen, l'apprenti est classé compagnon ou demeure apprenti de troisième année.14.03 II ne peut y avoir d'apprenti pour les emplois où le certifiait de qualification n'est pus obligatoire.1-1.04 Sombre d'apprentis: l.c nombre d'apprenti- dans chaque atelier doit être lc suivant pour chacun des métiers ci-après: Menuisier d'atelier à l'établi et menuisier d'atelier sur machine: un (1) apprenti pour quutre ill compagnons, deux (2) apprentis pour sept (7) compagnons, trois (3) apprentis pour dix (10) compagnons.La même échelle s'applique pour iliaque multiple dc dix (10).Machiniste: un (1) apprenti pour chaque atelier assujetti un décret.14.05 Calcul du nombre d'apprentis: Dans le calcul du nombre des apprentis, on ne doit pas tenir compte du compagnon débutant (junior) ni de l'apprenti qui reçoit le salaire du compagnon.Article XV.Durée: « Le présent décret demeurera en vigueur jusqu'au 31 mars 1972.\u2022 Lu publication du présent avis ne rend pus obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté cn conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendements.I.arrêté cn conseil ne peut entrer en vigueur ayant lu date de sa publication dans la Gazelle offii ielle du Québec.Before paying a sick leave compensation an employer may require a medical certificate establishing the reason of absence or a medical test made by a doctor chosen and paid by the employer.Section XII.Special provisions: 12.01 Accident benefits: Any employee, injured during his regular working hours and needing immediate care, may leave to receive that care, und shall be paid for the regular working hours' period.12.02 Vested interests: Any employee who by a special agreement with the employer has advantages not provided for by the present Decree, continues having those advantages if circumstances having lead to the agreement were not changed.Section XIII.Wages pay: 13.01 Every employee shall be paid in full every Thursday before noon.The pay bulletin shall list thc following particulars: 1.employee's name and surname; 2.date of payment and work period corresponding thereto; 3.wugc rate: 4.number of regular and overtime hours; 5.deductions made; 6.take-home pay.Section XIV.Apprenticeship: 14.01 Age: No apprentice may begin learning his trade before his sixteenth (16th) birthday.14.02 Examinations: Upon completing his apprenticeship, every apprentice shall sit for an examination before a Board of Examiners.According to his examination results, the apprentice shall liccomc u journeyman or shull remain a third-year apprentice.14.03 No apprenticeship shall exist for occupations not requiring a competency certificate.14.04 Xumbcr of apprentices: The number of apprentices in each shop shull be us follows for each trade listed below: Joiner (shop, bench and machiné): one (1) apprentice for every four (4) journeymen: two (2) apprentices for every seven (7) journeymen; three (3) apprentices for every ten (10) journeymen.The same ratio applies for each multiple of ten (10).Machinist: one (1) apprentice for each shop subject to this ugreemcnt.14.05 Calculation of numlier of apprentices: Thc junior journeyman and the apprentice with journeyman's pay shall not be considered, when calculating thc number of apprentices.Section XV.7Vr»i of the Decree: The present Decree shall remain into force until March 31, 1972.Publication of this notice does not make binding thc provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an order in council that cannot come into force before the dale of its publication in thc Québec Official Gazelle. 6988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° 50 Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazelle officielle du Québec, l'honorable ministre du Travad et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Robeht Sauvé.Ministère du Travail et de la Main-d'œuvre, Québec, le 13 décembre 1969.32275-0 Avis dc modification Coiffeurs pour hommes \u2014 Coiffeurs pour daines Jolictte Le ministre du Travail et dc la Main-d'oeuvrc l'honorable Maurice Bellemare, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux dc Joliettc, Berthicr, l'Assomption et Montcalm, rendue obligatoire par lc décret numéro 343 du 17 avril 1958 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet dc soumettre à l'appréciation et ù la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret: 1° L'article 102° sera remplacé par le suivant: « 102° a) les dimanches et les jours dc fêtes suivants sont chômés: Lc Premier Jour de l'An, le 2 janvier, lc lundi dc Pflqucs, la St-Jean-Baptiste, lu Confédération, la Fête du Travail, le Jour dc Ncël, le 26 décembre ainsi «pie les fêtes civiques décrétées par les autorités municipales d'une localité.b) Si le jour dc Noël et le Premier dc l'An tombent un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi ou un samedi, il peut y avoir du travail le lundi précédent aux mêmes heures que le mardi.» 2° Les paragraphes « d » et « e » «le l'article 103° seront remplacés par les suivants: « d) La dernière semaine complète de juillet sera chômée pour les coiffeurs pour hommes, «les endroits suivants: 1.Toutes les municipalités du district électoral dc Joliettc; 2.Toutes les municipalités du district électoral dc l'Assomption; 3.Lavaltric \u2014 St-Barthélémy \u2014 Lanoraie \u2014 Berthicrvillc \u2014 St-Michcl «les Saints.e) La première semaine complète d'octobre sera chômée pour les coiffeurs pour hommes dc toutes les autres municipalités.» 3° L'article 117° sera remplacé par le suivant: « 117° Durée régulière: La semaine normale «le travail du coiffeur pour hommes, est dc quarante-deux heures et demie (42J^h) réparties comme suit: Lundi: chômé; mardi, mercredi, jeudi: de 8h30 ù 18h; vendredi de 8h30 à 20h; samedi dc 8h30 à 16h.» 4° L'article 118° sera remplacé par lc suivant: « 118° Exception: Durant les mois de juillet et août, le travail doit cesser à Hire p.m.lc samedi dans les municipalités dc Jolictte, l'Assomption et Crabtree Mills.» 5 Les parties contractantes ont également sollicité une majoration des prix minimaux des services suivants: During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazelle, the Honourable Minister of Labour and Manpower will consider objections which interested parlies may wish to make.Robert Sauvk, Deputy Mini Department of Labour and Manpower, Québec, December 13, 1969.32275-0 Notice of Amendment Men's hairdressers \u2014 Ladies' hairdressers Joli el le Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (Revised Statutes of Québec, 1964, chapter 143), thc Honourable Maurice Bellemare, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the con-trading parties to thc collective labour agreement respecting men's and ladies' hairdressers in the electoral districts of Jolictte.lierlliier, l'Assomption and Montcalm, made binding by Decree number 343 of April 1958 and amendments, have petitioned him to submit certain amendments to the said decree to the Lieutenant-Governor in Council for consideration and decision: 1.Section 102.will lie replaced by the follow, tag: \"102.(a) There shall be no work on Sunday nnd on the following general holidays: New year's Day, January 2nd, Foster Monday, St.John the Baptist Day, Canada Day.Labour Day, Christmas Day, December 26th.civic holidays proclaimed by the municipal authorities of a locality.(6) If Christinas Day und New Year's Day fall on a Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday or a Saturday, the preceding Monday may lie worked and working hours on such Monday shull be those of a Tuesday.\" 2.Subsections \"a\" und \"c\" of section 103 will be replaced by the following: \"(«7) In the following pluccs, men's hairdressers shull not work the last full week in July: 1.All the municipulilics of the electoral district of Joliette; 2.All the municipalities of the electoral district of l'Assomption; 3.Lavaltric \u2014 St-Bcrlhélémy \u2014 Lanoraie Berthicrvillc \u2014 St-Michel-des-Saints.(c) In all other municipalities, men's hairdressers shall not work the first full week in October.\" 3.Section 117 will be replaced by the following: \"117.Standard working hours: For men's hairdressers, the standard workweek shall consist of forty-two and one half (42J4) hours scheduled us follows: Monday: non-working day; Tuesday, Wednesday and Thursday : 8:30 a.m.to 6:00 p.m.; Friday: 8:30 u.m.to 8:00 p.m.; Saturday: 8:30 a.m to 4:00 p.m.\" 4.Section 118 will lie replaced by the following: \"118.Exception: During the months of July and August, work shall cease at 1:00 p.m.on Saturduy, in the municipalities of Jolictte, l'Assomption and Crabtree Mills.\" 5.The contracting parties arc also seeking increases in the minimum prices of the following services: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 18, 1969, Vol.101, No.50 6989 Coiffeurs pour hommes (Article 122°) Prix Prix actuel demandé Coupe de cheveux ordinaire: Adultes.$1.40 $1.75 Enfants dc moins de 15 ans.0.85 1.05 Coupe de cheveux en brosse: Adultes.;.1 65 2.00 Enfants dc moins de 15 ans.1.10 1.35 Coupe de cheveux au rasoir.2.00 Coupe de cheveux au rasoir (y compris shampooing et ondula-lion).3.50 4.00 Ondulation.1.00 1.00 Rasage de la barbe.1.00 1.25 Shampooing.1.00 1.25 Message.1.50 1.50 Teinture des cheveux.4.00 4.00 Tonique et lotion.0.50 0.50 Traitement du cuir chevelu.1.50 2.00 Rinçage colorant.0.75 1.00 Flambage des cheveux.0.50 0.50 Aiguisage dc rasoir.1.00 1.00 Note: Les prix minima fixés ci-dessus s'appliquent également lorsque lc travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.» Coiffeurs pour dames (Article 130°) Prix Prix actuel deman- dé Ondulation permanente ou indéfrisable, comprenant coupe et mise en plis: Adultes.$8.00 $8.00 Enfants.6.00 6.00 Ondulation au papier.1.75 2.00 Ondulation au fer-.- 1.75 2.00 Ondulation à l'eau (mise cn plis).1.50 2.00 Shampooing ordinaire.1.00 1.00 Rcpcignage ù sec.1.00 1.00 Rinçage (rince-crème).0.50 0.50 Rinçage (colorant à l'eau).1.00 1.00 Rinçage nuanceur ou colorant (sans l'aide d'oxydants).3.00 3.00 Teinture ou retouche de teinture avec l'aide d'oxydants (mise cn plisnoncompri.se).5.00 5.00 Shampooing colorant ou décolorant i mise en plis non comprise).5.00 5.00 Décoloration (par application) .5.00 5.00 Flambage des cheveux.0.50 0.50 Epilation des sourcils.0.75 1.00 Coupe de cheveux: Adultes.1.50 2.00 Enfants de moins de 14 ans.1.10 1.40 Traitement du cuir chevelu.1.50 2.00 Massage.2.00 2.00 Manucure.1.25 1.50 Aitfe; Les pris minima fixés ci-dessus s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.™ id un arrêté cn conseil peut rendre obligutoiies '\u2022\u2022s dispositions, avec ou sans amendements.I.arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant lu date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Men's hairdressers (Section 122) Actual Price price pro- poned Ordinary huircut: Adults.$1.40 $1.75 Children under 15.0.85 1.05 Brushcut: Adults.1.65 2.00 Children under 15.1.10 1.35 Razor cut.2.00 Razor cut (including shampoo and setting).3.50 4.00 Setting.1.00 1.00 Shave.1.00 1.25 Shampoo.1.00 1.25 Massage.1.50 1.50 Dyeing of hair.4.00 4.00 Tonic and lotion.0.50 0.50 Scalp treatment.1.50 2.00 Colour rinse.0.75 1.00 Hair singeing.0.50 0.50 Razor honing.1.00 1.00 Note: The minimum prices mentioned above also apply when work is performed on wigs or hairpieces.\" Ladies' hairdressers (Section 130) Actual Price price proposed Permanent wave (including cutting and setting) : Adults.$8.00 88.00 Children.6.00 6.00 Paper wave.1.75 2.00 Waving (curler iron).1.75 2.00 Water wave (setting).1.50 2.00 Regular shampoo.1.00 1.00 Dry combing.1.00 1.00 Rinse (cream rinse).0.50 0.50 Rinse (colour rinse, water).1.00 1.00 Tinting rinse or toner (without oxidizing agents).3.00 3.00 Dyeing or dye touch-up, with oxidizing agents (setting not included).5.00 5.00 Tinting or colour-stripping shampoo (setting not included).5.00 5.00 Colour-stripping (per application).5.00 5.00 Hair singeing.0.50 0.50 Eyebrow depilation.0.75 1.00 Haircut: Adults.1.50 2.00 Children under 14.1.10 1.40 Scalp treatment.1.50 2.00 Massage.2.00 2.00 Manicure.1.25 1.50 Sole: The minimum prices mentioned above also apply to work performed on wigs or hairpieces.\" Publication of this notice does not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an order in council that cannot come into force before the date of its publication in the Québec Official Gazelle. 0990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° ÔO Durant les trente jours à compter de la date de publication dc cet avis dans la Gazelle officielle du Québec, l'honorable ministre du Travail et dc la Main-d'œuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le nou.s-mini.ilrc, Robert Sauve.Ministère du Travail et dc la Main-d'œuvre, Québec, le 13 décembre 1969.32275-0 During the thirty days following publication of this notice in thc Québec Official Gazelle.Hie Honourable Minister of Labour and Manpower will consider objections which interested parties may wish to make.Robert Sauvk, Deputy Minister.Department of Labour and Manpower, Quebec, December 13, 1969.32275- Avis dc modification Le ministre du Travail et dc la Main-d'oeuvre, l'honorable Maurice IJellemure, donne avis pur les présentes, conformément uux dispositions de la Loi sur les Relations du travail dans l'industrie de la construction, tpic les associations représentatives mentionnées à l'article 5 de luditc Loi lui ont présenté une requête à l'effet dc modifier les décrets ci-dessous mentionnés se rapportant ù l'industrie de la construction dc la façon suivante: 1° Les amendements ci-dessous s'appliquent aux décrets suivants: Décret numéro 3135 du 22 octobre 1969, relatif ù l'industrie dc la construction dans la région d'Abitibi; Décret numéro 3133 du 22 octobre 1969, rclutif à l'industrie dc la construction dans lu région Granby, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean; Décret numéro 3129 du 22 octobre 1969, relatif ù l'industrie de la construction dans la région dc Hull; Décret numéro 3134 du 22 octobre 1969, rclutif ù l'industrie de la construction dans la région dc Jolictte; Décret numéro 3130 du 22 octobre 1969, relatif ù l'industrie «le la construction dans la région des Laurentidcs; Décret numéro 3132 du 22 octobre 1969, rclutif ù l'industrie dc la construction dans lu région de Montréal; Décret numéro 3127 du 22 octobre 1969, relatif à l'industrie dc la construction dans la région de Québec; Décret numéro 3128 du 22 octobre 1969, relatif ù l'industrie de la construction dans la région dc Rimouski; Décret numéro 3131 du 22 octobre 1969, rclutif ù l'industrie dc la construction dans la région de Sorel: Décret numéro 3136 du 22 octobre 1969, relatif ù l'industrie de la construction dans la région de Trois-Rivières: a) L'échelle de salaire apparaissant n la Partie II-A (Lignes dc transport d'énergie électrique), du Chapitre Premier, sera remplacée par la suivante: 1er janr.« Taux de .salaires: 1970 Monteur « A ».$ 3.85 Monteur « B ».3.55 Monteur* C».3.21 Apprcnti-inontcur.3.06 Aide-monteur à terre.3.06 Aide.2.85 Soudeur.3.5S Mécanicien.3 58 Conducteur d'engin très lourd.3.81 Conducteur d'engin lourd.3.55 Conducteur d'engin moyen.3.06 Conducteur d'engin léger.2.85 Charpentier.3.74 Foreur dc roc.2.91 Boutcfcu.3.06 Gardien (pur semaine).89.44» Notice of Amendment Pursuant to thc provisions of the Construction Industry Labour Relations Act, thc Honourable Maurice Bellemare, Minister of Labour und Manpower, hereby gives notice that the representative associations mentioned in section 5 of the said Act have petitioned him to amend us follows thc construction industry decrees mentioned hereinbelow: 1.Thc amendments mentioned below to thc following decrees: Decree number 3135 of October 22, respecting thc Construction Industry Abitibi region; Decree number 3133 of October 22.respecting thc Construction Industry Granby-St.Hyacinthe-St.Jean region: Decree numlier 3129 of October 22, respecting thc Construction Industry Hull region; Decree number 3134 of October 22, respecting thc Construction Industry Jolictte region; Decree number 3130 of Octolier 22, respecting the Construction Industry Laurcntian region: Decree number 3132 of October 22, respecting thc Construction Industry Montreal region; Decree number 3127 of October 22.respecting the Construction Industry Québec region; Decree number 3128 of Octolier 22.respecting the Construction Industry Rimouski region; Decree number 3131 of October 22 respecting the Construction Industry Sorcl region; Decree number 3136 of Octolier 22 respecting the Construction Industry Trois-Rivières region: (o) Thc wage scale given in section Part II-A (Electric Power Transmission of Chapter One will be replaced by thc fol apply I960, in the 969, in the 1969, in the 1969, in the I960, in the 1969.in the , 1969, in the , 1969.in the , 1900, in the , I960, in the 4.00 of bines) owing: Jan./.« Wage rate.s: W Lineman, class \"A\".S 3.8o Lineman, class \"B\".;! Lineman, class \"C\".3.21 Apprentice lineman.3.0U Groundman.3 00 Helper.2.83 Welder.3.58 Mechanic.;.3 58 Operator, extra heavy duty equipment.3 si Operator, heavy-duty equipment.3.58 Operator, medium-sized equipment- \u2022 \u2022 3 '\"j Operator, light equipment.2.85 Carpenter.3.7-1 Rock driller.2.9) Shotfirer.3.06 Watchman (per week).89.44 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1909, Vol.101, No.60 b) L'échelle de salaire apparaissant à la Purtie III-A (Lignes dc distribution d'énergie électrique), du Chapitre Premier, sera remplacée par la suivante: 1er jaur.« Taux de salaires: 1970 Chef des équipes de ligne.$ 4.11 Monteur dc ligne « A ».3.95 Monteur de ligne « B ».3.70 Mouleur de ligne « C ».3.43 Aiile-montcur à terre, apprenti-monteur.3.17 Émondeur.3.43 Conducteur de camion dc ligne.3.29 Chef d'équipe dc creusage et mise cn pince des poteaux.3.70 Koutefcu.3.17 ( '(inducteur dc compresseur.3.17 ( 'onducteur de machinerie.3.29 Aide.2.87» c) L'échelle de salaire apparaissant à la Partie IV-A (Installation et réparation d'ascenseurs), du Chapitre Premier, sera remplacée pur lu suivante: Taux horaire* minima Mêca- « Taux de salaires: nicien Aide lUgion dc Québec: comprenant toute la partie est de la province dc Québec, à partir d'une ligne imaginaire du nord au sud passant ù un point si i né ù 25 milles à l'ouest de la cité dc Québec.«4.72 $3.30 Région de Hull: comprenant toute la partie ouest de la province dc Québec, à partir d'une ligne imaginaire du nord au sud des limites ouest de la ville dc Hawkesbury.4.82 3.37 Région dc Montréal: comprenant tout le territoire -.iliié entre la région dc Hull et la région de Québec.5.09 3.56» (/) L'échelle «le salaire apparaissant à.la Partie V-A (Acier dc structure), du Chapitre Premier, sera remplacée par la suivante: « 7'ai/.r dc salaires: Compagnon: monteur d'acier dc structure, soudeur.$4.65 < onipagnon : gréeur et finisseur.4.55» 2° a) Les conditions dc travail dc la Partie V-A du ( 'luipitrc Premier de l'arrêté cn conseil numéro 3132 (région de Montréal), modifiées par lc poste l°-d) ci-dessus, sont incluses dans les décrets mentionnés ci-dessous: Numéro 122 du 29 février 1956 et amendements (Sherbrooke); Numéro 1743 du 11 juillet 1941 et amendements (Chicoutimi et Roberval); Numéro 988 du 2 octobre 195S et amendements (Drummond, Arthabaska et Nicolet); Numéro 2218 du 9 novembre 1961 et amendements (Duplessis); Numéro 1323 du 16 août 1962 et amendements (Sagucnay); devront être extensionnées jusqu'au 1er mai 1970.6991 (6) The wage scale given in section 4.00 of Part III-A (Electric Power Distribution Lines) of Chapter One will be replaced by the following: Jan.I, \"Wage rales: 1970 Group leader.$4.11 Lineman, class \"A\".3.95 Lineman, class \"B\".3.70 Lineman, class \"C\".3.43 Groundman, apprentice lineman.3.17 Trimmer.3.43 Driver, line truck.3.29 Group leader, digging and installation of poles.3.70 Shotfirer.3.17 Compressor operator.3.17 Machine operator.3.29 Xelper.2.87\" (c) The wage scale given in Part IV-A (Elevator Installation and Repairs) of Chapter One will be replaced by the following: Minimum hourly rales Mecha- \"Wage rales: nics Helpers Quebec Cily region: including all the eastern section of thc Province of Québec from a line running due north and south and passing through a point twenty-five (25) miles due west of Québec City.$4.72 $3.30 //ull region: including all the western part of thc Province of Québec from a line running due north and south at the western limits of the town of Hawkesbury.4.82 3.37 Montreal region: including all the territory lving between the Hull region and the Québec City region.5.09 3.56\" (rf) The wage scale given in Part V-A (Structural Steel) of Chapter One will be replaced by the following: \"Wage rales: Journeyman: structural, ironworker and welder.$4.65 Journeyman, rigger and finisher.4.55'' 2.(a) Working conditions stipulated in Pari V-A (Structural Steel) of Chapter One of Order in Council number 3132 (Construction Industry in the Montreal region) and amended by item l-(rf) above, are included in the decrees listed hereunder: Decree number 122 of February 29, 1956, as amended (Construction Industry in the Sherbrooke region) ; Decree number 1743 of July 11, 1941, as amended (Construction Industry in thc Chicou-timi-Robcrval region) ; Decree number 988 of October 2, 1958, as amended (Construction Industry in the Drum-mond-Arthabaska-Nicolct region) ; Decree number 2218 of N'ovember 9, 1961, as amended (Construction Industry in the Duplessis region) ; Decree number 1323 of August 16, 1962, as amended (Construction Industry in thc Saguenay region); will be cxtcnted until May 1st 1970.* ' C992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° 50 b) Les décrets ci-dessous énumérés seront prolongées jusqu'au 1er mai 1970: Décret numéro 1575 du 14 juin 1967 et amendements, relatif aux lignes dc transport «l'énergie électrique; Décret numéro 1057 du 14 avril 1967 et amendements, relatif aux lignes de distribution d'énergie électrique.3° Les amendements ci-dessous s'appliquent au décret numéro 3132 du 22 octobre 1969, relatif à l'industrie dc la construction dans la région dc Montréal: i.Serrurerie el menuiserie métallique: L'échelle dc salaire apparaissant à l'article Il-a de l'édition administrative du 22 juin 1968, du «lécret relatif à la serrurerie et menuiserie métallique, rendue obligatoire par la Partie I-B du décret numéro 3132 du 22 octobre 1969, relatif à l'industrie de la construction dans la région dc Montréal, sera remplacée par la suivante: «Mécanicien-monteur.$4.38 Ajusteur.3.83 Ouvrier de services auxiliaires.3.56 Aide.3.39» ii.Construction \u2014 Montréal: Les deux derniers alinéas dc la puge 9 dc l'édition administrative du 21 septembre 1968, rendue obligatoire par la Partie I-B du décret numéro 3132 du 22 octobre 1969, relatif ù l'industrie de la construction dans la région dc Montréal, seront biffés.iii.Industrie du verre plat \u2014 Montréal: Les taux dc salaires suivants apparaissant dans l'édition administrative «lu 27 août 1966, rendue obligatoire par lc Chapitre Deuxième «lu décret numéro 3132 du 22 octobre 1969, relatif à l'industrie de la construction dans la région «le Montréal, seront remplacés par les suivunts: « Monteur mécanicien: Classe A.$3.72 Classe B.3.24 Monteur compagnon : Classe A.3.72 Classe B.2.92 Monteur de verre et «lc panneaux à tympan: Classe A.3.29 Classe B.2.74» 4° Construction \u2014 Québec: Les conditions de travail relatives aux travaux sur chantier pour l'industrie du verre plat dans la région dc Québec, (décret 878 du 2 août 1950 et amendements), devront être incluses dans l'arrêté en conseil numéro 3127 pour ladite région avec échéance au 1er mai 1970.5° Construction \u2014 Granby, St-IIyacinlhc, Sl-Jean: L'alinéa « a » des articles 10.00, 30.00 el 50.00 respectivement «les sections I, II et III «lu «lécret numéro 3133, seront ralliés.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendements.L'arrêté cn conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication dans lu Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la «Iule de publication de cet avis dans lu Gqzelle officielle du Québec, l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'œuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Lc sous-minislre, Robert Sauvé.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, Québec, le 13 décembre 1969.32275-o (b) The decrees listed below will be extended until May 1, 1970: Decree number 1575 of June 14, 1967.as amended (Electric Power Transmission Lines)* Decree number 1057 of April 14, 1967, as amended (Electric Power Distribution Lines).3.Thc following amendments apply to Decree number 3132 of October 22, 1969 (Const met ion Industry in thc Montreal region) : i.Son-structural Melalwork Industry: Thc wage scale given in Section II-u of I lie office edition dated June 22, 1968 (Decree respecting the Non-structural Mctalwork Industry in thc Montreal region) and made binding liv Part I-B of Decree number 3132 of October 22, 1969 (Construction Industry in thc Montreal region) will be replaced by: \"Mechanic-erector.$4.IS Fitter.3.S3 Utility man.3.56 Helper.3.39\" ii.Construction Industry \u2014 Montreal region: The last two paragraphs on page 9 of the ollice edition (lated September 21, 1968 which was made binding by Part I-B of Decree number 3132 of October 22, 1969 (Construction Industry in the Montreal region) will be abrogated.iii.Flat.Glass Industry \u2014 Montreal region: Thc following wage rates set forth in the ollice edition dated August 27, 1966 which was made binding by Chapter Two of Decree number 3132 of October 22, 1969 (Construction Industry in thc Montreal region) will be superseded by: \"Setter-mechanic: Class A.$3.72 Class B.3.24 Setter-journeyman : Class A.3.72 Class B.2.92 Setter, glass an«I spandrel panels: Class A.3.29 Class B.2.74\" 4.Const ruction Industry \u2014 Quebec Cily region: Working conditions covering work on construction sites for thc Flat Glass Industry in the Québec City region (Decree number 878 of August 2, 1950, as amended) will be incorporated into Ortlcr in Council number 3127 covering the saiil region and expiring on May 1, 1970.5.Construction Industry \u2014 Granby-Sl.////«-cinlhe-St.Jean region: In Decree number 3133, each paragraph \"«\" of sections 10.00, 30.00 and 50.00 in Divisions I, II and III respectively will be abrogated.Publication of this notice docs not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an Order in Council thut cannot come into force before the date of its publication in the Québec Official Gazelle.During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazelle, the Honourable Minister of Labour und Manpower will consider objections which interested parlies may wish to make.Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Labour ami Manpower, Québec, December 13, 1969.32275-0 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1069, Vol.101, No.50 6993 Avis dc modification Coiffeurs pour hommes \u2014 Coiffeurs pour dames Région de Sherbrooke Le ministre «lu Travail et de la Main-d'oeuvre, l'Iionorable Maurice Bellemare, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets dc convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 255 du 5 mars 1953 et amendements, relatif aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région dc Sherbrooke, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur cn conseil certaines modifications audit décret: 1° L'article 101 sera remplacé par le suivant: « 101.Jours chômés: Il n'y a pas de travail lc dimanche, lc premier jour de l'an, lc 2 janvier, la l'été de la Reine, la Saint-Jean-Baptiste, le premier juillet (Confédération), la fête du Travail, le jour de l'Action de Grftce, le jour de Noël et le 26 décembre.» 2e L'article 106 sera remplacé par le suivant: ' 106.Tout salarié assujetti au présent décret a droit, après un (1) an «le service continu pour un même employeur ou dans lc même salon, à un congé payé de 2 semaines rémunéré à raison de 4% du salaire gagné et des commissions reçues au cours de ladite période.» 3° L'article 107 sera remplacé par le suivant: « 107.Tout salarié ayant moins de 12 mois de service continu pour le même employeur ou dans le même salon a droit à un (1) jour dc congé payé par mois d'emploi rémunéré, à raison de 4% du salaire gagné et des commissions reçues.La durée totale du congé ne peut excéder deux (2) semaines.» 1° L'article 115 sera remplacé par le suivant: «115.Champ d'application territorial: Le champ d'application territorial de cette partie du décret comprend les districts électoraux dc Sherbrooke, Richmond, Stanstead, Compton, Wolfe cl Frontenac.Aux fins d'application, ce champ d'application territorial est divisé comme suit: Zone I: Les districts électoraux de Sherbrooke, Stan-slcitd et Richmond, les villes de Disraeli, East Angus et Lac Mégantic et lc territoire compris dans un rayon dc cinq (5) milles de leurs limites ainsi que les villages dc Watervillc et Ascot < orner.Zone II: Les territoires non compris dans la zone I.» 5° L'exception 1) apparaissant à la Zone I 'le l'article 117 sera remplacée par la suivante: « 1) Les heures de travail sont prolongées jusqu'à 9 heures du soir chaque jeudi, veille «le jour férié chômé.» 6° L'exception 3) apparaissant à la Zone I dc l'article 117 sera remplacée par la suivante: « 3) Dans la ville de Lac Mégantic et un rayon de 5 milles dc ses limites, la durée du travail est prolongée jusqu'à 8 heures du soir les 20, 21 et 22 décembre, lorsque ces jours sont ouvrables.» 7° Les exceptions 5), 6) et 7) suivantes seront ajoutées ù la Zone I de l'article 117; Notice of Amendment Men's and ladies hairdressers \u2014 Sherbrooke region Pursuant to thc provisions of thc Collective Agreement Decrees (RSQ 1964, c.143) the Honourable Maurice Bellemare, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that thc contracting parties to the collective labour ugreement, made binding by Decree number 255 of March 5, 1953 an«l amendments respecting thc men's an«l ladies' hairdressers in the Sherbrooke region, have petitioned him to submit to thc consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to thc said Decree : 1.Section 101 will be replaced by the following: \"101.Holidays: No work shall be performed on Sunday, New Year's Day, January 2nd, Queen's Birthday, St.John the Baptist Day, Canada Day, Labour Day, Thanksgiving Day, Christmas Day anil December 26th\".2.Section 106 will be replace«l by the following: \"106.Every employee governetl by the present Decree who has one (1) year's continuous service with thc same employer or in the same parlour, is entitled to two (2) weeks' vacation with pay, remunerated at the rate of 4% of the wages earned and commissions received during the said period.\" 3.Section 107 will be rcplaceil by the following: \"107.Every employee having less than twelve (12) months' continuous service with the same employer or in thc same parlour, is entitled to one (1) day's vacation with pay per month of service, remunerated at the rate of 4% of the wages earned and the commissions received.The vacation term shall not exceed two (2) weeks.\" 4.Section 115 will be replaced by the following: \"115.Territorial jurisdiction: Thc territorial jurisdiction of this part of the decree comprises the electoral districts of Sherbrooke, Richmond, Stanstead, Compton, Wolfe antl Frontenac.For the purposes of enforcement, this territorial jurisdiction is divided as follows: Zone I: The electoral districts of Sherbrooke, Stanstead and Richmond, thc towns of Disraeli, East-Angus and Lac Mégantic and the territory comprised in a 5-mile radius from their limits as well as thc villages of Waterville and Ascot Corner.Zone II: The territories not comprised in zone I.\" 5.In section 117, Zone I, the exception (1) will be replaced by the following: \"(1) On every Thursday, being a holiday eve, working hours arc exteniled to 9:00 p.m.\" 6.In section 117, Zone I, thc exception (3) will be replaced by thc following: \"(3) In thc town of Lac Mégantic and the territory comprised in a 5-milc radius from its limits, working hours arc extended to 8:00 p.m.on December 20th, 21st and 22nd, when these are working days.\" 7.In section 117, exceptions (5), (6) and (7) will be adiled to Zone I, as follows: (S994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, «° 60 « 5) Dans la ville de Rock Island et les municipalités dc Reebe Plain et Stanstead et un rayon dc cinq (5) milles dc leurs limites, les heures dc travail sont les suivantes: le lundi: chômé toute la journée les mardi et mercredi: de 8 h 30 du matin ù 6 h du soir le jeudi: de 8 h 30 du matin à 9 h du soir lc vendredi : dc 8 h 30 du matin à 6 h du soir, lc samedi : dc 8 h 30 «lu matin à 4 h dc l'après-midi.Durant les mois dc juillet et août, la fermeture est ù une (1) heure «le l'après-midi.6) À East Angus, le travail débute à 8 h du matin tous les jours et se termine ù 5 h le samedi après-midi.7) A Disraeli, les heures dc travail sont de 8 h 30 «lu matin ù 10 b du soir lc vendredi.» 8° L'article 119-A sera remplacé par le suivant: « 119-A.Jours chômés: a) Dans la zone II seulement, nonobstant les dispositions dc l'article 101, le travail est permis, la fétc «le la Reine, la Saint-Jean-Baptiste, le 1er juillet (Confédération), et le jour d'Actions-) In Rock Island.Bccbc Plain and Stanstead.thc fourth (4th) complete week of July shall lie thc annual vacation period.(c) In Luc Mégantic, the week in which falls August 1st, shall be thc annual vacation period, («7) On January 3rd, 4th, 5th und 6th.Hie men's parlours shall be closed in both zones.\" 10.In section 125 (Zone \"A\"), exception 3 will be replaced by thc following: \"3.In Holy Week, working hours are as follows: Monday: non-working day; Tuesday : 9:00 a.m.to 6:00 p.m.; Wednesday, Thursday and Friday: 9:00 a.m.to any time, without limits; Saturday: 8:00 a.m.to 6:00 p.m.4.When All Saints Day and Immaculate Conception Day fall on working days the M lowing Tuesday shall be a holiday.\" 11.In section 127 the following will be added to the services: \"Tinting shampoo without oxydizing agent .3.00\".12.Section 129 will be cancelled.13.Thc contracting parties arc also seeking increases in thc minimum prices of the following services : Prix actuel Prix demandé Actual prices Proposed pria - Zones Zones I II III I II Coupe de cheveux ordinaire pour adultes \u2014 Onlinurv haircut, adults.$1.40 SI 25 80.85 $2.00 $1.50 Coupe de cheveux ordinaire pour enfants de moins de 815 uns \u2014 Ordinary haircut, children to 15.0.85 0.75 0.60 1 25 1.00 Coupe «le cheveux cn brosse pour udultes \u2014 Brushcut, adults.1.65 1.40 1.00 2.25 1.75 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 18, 1969, Vol.101, No.50 6995 Prix actuel Prix demandé Actual prices Proposed prices Zones Zones I II III I II Coupe bornée au nord-est par la ligne entre les Neuvième et Dixième Rangs, au sud-ouest par le résidu dudit lot, au sud-est par le lot quatre cent vingt et au nord-ouest par lc lot quatre cent dix-huit, ayant en front sept chaînes, dix mailles sur une.profondeur de trente-sept chaînes et demie.Un morceau de terrain connu et désigné comme faisant partie du lot numéro trois cent cinquante-neuf (P.359) aux plan et livre de renvoi du cadastre de la paroisse de St-Épl irem, Beauce, mesurant deux arpents et demi de largeur par mille neuf cents pieds dc profondeur, plus ou moins, borné au nord-est par lc chemin entre les Rangs Huit et Neuf, au sud-est par partie du lot trois cent cinquante-huit appartenant à Fcrnand Veilleux, au nord-ouest par partie du lot trois cent soixante appartenant ù Nap.Grenier et au sud-ouest au résidu dudit lot appartenant à J.-P.Vachon ; avec droit dc passage sur le terrain ci-dessus en faveur dudit J.-P.Vachon ou ayants droit dans un chemin de dix pieds de largeur, du côté nod-ouest entre la ligne dc division entre le terrain de J.-P.Vachon et le terrain de Nap.Grenier; cependant vis-à-vis dc la source existante à quelques deux cents pieds du trait carré.Rang 9, ledit droit de passage pourra être déplacé dc quelques pieds du côté sud-est de manière à ne pas nuire à ladite source de manière à ce que le chemin soit sur un terrain solide.Lc tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Sauf et à distraire: Un lopin dc terre situé en la paroisse dc Stc-Clothilde, comté dc Beauce, mesurant 3 arpents dc largeur sur une profondeur dc 520' laquelle profondeur est calculée à une distance de 80' du chemin du 8ièmc Rang, le tout plus ou moins, mesures anglaises, connu et désigné comme étant une partie du lot numéro cent quatre-vingt-huit (P.188) du cadastre officiel pour la paroisse de St-Éphrem, comté dc Beauce, lequel lopin de terre est borné cn avant par une partie du même lot étant les 80' qui restent la propriété dc Fernand Veilleux, cn arrière par une partie du même lot appartenant à Fcrnand Veilleux, «l'un côté par le lot 189 appartenant à Dominique Grondin et de l'autre côté par le lot 187 appartenant à Clément Nadeau, avec bâtisse, mais ne comprend pas lc grément de sucrerie.Lc vendeur Fernand Veilleux accorde à l'acquéreur Jcanncl Poulin un droit dc passage pour lui permettre de communiquer du chemin public au terrain ci-dessus vendu sur une lisière dc 30' de largeur lc long dc la ligne du lot 189, de son côté l'acquéreur Jcanncl Poulin accorde un droit de passage sur le terruin ci-dessus désigné |M>ur lui permettre dc communiquer du terrain en avant au terrain cn arrière sur une lisière de 30' dc largeur lc long dc la ligne du lot 187.Lesdites servitudes étant réelles et perpétuelles et affectant le terrain de l'un nu profit du terrain dc l'autre et vice-versa.A farm known and designated as being lot number one hundred and eighty-eight (188) on the plan and in the book of reference of the cadastre for the parish of St-Éphrem, Beauce subject to a servitude in favour of \"The Shawinigan Water & Power Co.\", according to registration 145167.A farm known and designated as forming part of lot number four hundred and nineteen (P -119) on the plan and in the book of reference of lhe cadastre for the parish of St-Éphrem, county of Beauce, bounded on the northeast by the line between the Ninth and Tenth Ranges, on thc southwest by the remainder of thc said lot, on thc southeast by lot four hundred and twenty nnd on the northwest by lot four hundred unit eighteen, measuring in front seven chains, ten links by a depth of thirty-seven and one-half chains.A piece of land known and designated as forming part of lot number three hundred mid fifty-nine (P 359) on the plan and in thc book of reference of thc cadastre for thc parish of Sl-Éphrem, Beauce, measuring two and one-half arpents in width by one thousand nine hundred feet in depth, more or less, bounded on thc northeast by the road between the Eighth and Ninth Ranges, on the southeast by part of lot three hundred and fifty-eight belonging to Fernand Veilleux, on thc northwest by part of lot three hundred and sixty belonging to Nap.Grenier, and on the southwest by the remainder of the said lot belonging to J.-P.Vachon; with a right of way on the above land in favour of thc said J.-P.Vachon or those entitled thereto on u ten-foot wide road on thc northwest side between the division line between thc land of J.-P.Vachon nnd that of Nap.Grenier; however, fucing thc existing spring some two hundred feet from lhe trait carré, Range 9, the said right of way may be displaced a few feet to the southeast so thut thc road be on solid ground and not be u hindrance to the said spring.The whole with the buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.Save and to be withdrawn: A lot of land situated in thc parish of Stc-Clothildc, county of Beauce, measuring 3 arpents in width by a depth of 520', which depth is calculated at a distance of 80' from thc road of the 8th Range, the whole more or less, English measure, known and designated as being a part of lot number one hundred and eighty-eight (P 188) on thc official cadastre for thc parish of St-Éphrcm, county of Beauce; thc said lot of land is bounded in front by a part of the same lot, which part is the 80* remaining thc property of Fernand Veilleux.in the rear by a part of the same lot belonging to Fcrnand Veilleux, on one side by lot 189 belonging to Dominique Grondin, and on the other side by lot 187 belonging to Clément Nadeau.with the building, but not including thc equipment in thc sugaring camp.The vendor, Fernand-Veilleux, grants to the purchaser, Jcanncl Poulin, a right of way permitting him to go from the public road to the abovesold land on a strip of land measuring 30' in width along the line of lot 189; on his part, the purchaser, Jcanncl Poulin, grants a right of way on the abovc-dcsignulcd land permitting him to go from thc land in front to that in thc rear, on a strip of land measuring 30' in width along the line of lot 187.Thc said servitudes arc real and in perpetuity, and ailed the land belonging to the one in favour of that of thc other, and vice-versa QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.50 7005 Sujets lesdits immeubles à un bail pour une période de dix (10) ans à compter du 28 décembre 1005, avec droit de passage consenti par M.Fer-nand Veilleux en faveur de La Corporation Municipale de Ste-Clothilde sur une lisière de terrain de 80 pieds de largeur par 80 pieds de profondeur; à distraire du lot 358 du cadastre officiel de la paroisse de St-Éphrem de Tring (aujourd'hui Ste-Clothilde), et consistant en le droit pour ladite corporation de construire un aqueduc, y compris les travaux inhérents de construction et d'entretien, et avec droit ce passage pour effectuer lesdits travaux; le tout à la charge et responsabilité de ladite Corporation de Ste-Clothilde pour les dommages qui pourraient survenir pendant la période dudit bail.Une terre connue et désignée sous le numéro trois cent cinquante et un (351) au cadastre officiel pour le Neuvième Rang du canton de Tring, paroisse de St-Éphrem, comté de Beauce, circonstances et dépendances, contenant vingt cl un acres et un rood cn superficie, plus ou moins.Sauf et à distraire: La partie boisée du lot numéro trois cent cinquante et un (P.351) du cadastre officiel pour la paroisse de St-Éphrem, comté de Beauce, mesurant 1 arpent dc largeur sur une profondeur d'environ 12 arpents, bornée d'un bout par la ligne separative des Rangs 9 et 10, à l'autre bout par le résidu dudit lot appartenant à Fernand Veilleux, d'un côté par le lot 350 appartenant à Alfred Rodrigue et dc l'autre côté par le lot 352 appartenant à Emile Rodrigue, le tout sans bâtisse.» Pour être vendu « cn bloc » au bureau d'enregistrement de la division de Beauce, à Beaucc-ville-Est, comté de Beauce, le VINGTIÈME jour de JANVIER 1970, à DIX heures de l'avant-midi.Le député shérif.Bureau du Shérif, Adalbert Lessard.St-.!oseph de Beauce, le 1er décembre 1969.32276-0 HAUTERIVE De Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Hauterive < our provinciale, ( TEAN-PAUL BRISEBOIS, No 4047.\u2022j J épicier, domicilié à Les ' Escoumins, district de Hautcrive, demandeur, contre ARTHUR THER-1(1 EX, domicilié à Les Escoumins, district de Hautcrive, défendeur.Une partie du lot numéro huit (Ptie 8), du rang deux (Rg 2), au cadastre officiel du canton Les Escoumins, étant un terrain de figure irré-gulicre mesurant au nord-ouest 284 pieds, au sud-ouest 315 pieds, au nord-est 275 pieds, et au sud-est l'espace entre lc chemin de la concession cl le terrain de Johnny Robertson, mesure anglaise, borné au sud-ouest par lc chemin de la Concession, au nord-ouest par Ronaldo Roussel, au nord-est par Johnny Robertson, et au sud-est par lu route de la Concession, avec la maison et autres bâtiments dessus construits, circonstances cl dépendances.Pour être vendu au bureau du régistrateur, de la division d'enregistrement du comté de Saguenay, au Palais dc Justice dc Baie-Comeau, MARDI, le TREIZIEME jour du mois de JAN-\\ 1ER, 1970, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, liureau du shérif, Marcel Rodrigue.Baie-Comeau.32277-0 The said immovables arc subject to a ten-year (10) lease from December 28, 1965, with a right of way granted by Mr.Fernand Veilleux to the Municipal Corporation of Ste-Clothilde on a strip of land measuring 80 feet in width by 80 feet in depth; to be withdrawn from lot 358 on the official cadastre for the parish of St-Éphrem de Tring (now Ste-Clothilde), and consisting in the right for the said corporation to build an aqueduct, including the works inherent in construction and maintenance, and with the right of way to carry out the said works; the whole is in the charge of and is the responsibility of the said corporation of Ste-Clothilde for damages which may result during the term of the said lease.A farm known and designated under number three hundred and fifty-one (351) on the official cadastre for the Ninth Range in the township of Tring, parish of St-Éphrem, county of Beauce, circumstances and dependencies, having an area of twenty-one acres and one rood, more or less.Save and to be withdrawn: the wooded part of lot number three hundred and fifty-one (P 351) on the official cadastre for the parish of St-Éphrem, county of Beauce, measuring 1 arpent in width by a depth of approximately 12 arpents, bounded at one end by the line separating Ranges 9 and 10, at the other end by the remainder of the said lot belonging to Fernand Veilleux, on one side by lot 350 belonging to Alfred Rodrigue, and on the other side by lot 352 belonging to Emile Rodrigue, the whole without buildings.\" To be sold \"en bloc\" in the registry office for the division of Beauce, at Bcauccville-East, county of Beauce, on the TWENTIETH day of JANUARY, 1970, at TEN o'clock in the forenoon.Adalbert Lessard, Sheriff's Office, Deputy Sheriff.St-Joseph de Beauce, December 1, 1969.32276 HAUTERIVE De Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Hautcrive Provincial Court,/ TEAN-PAUL BRISEBOIS, No.4047.S J grocer, domiciled at Les ' Escoumins, district of Hauterive, plaintiff, against ARTHUR THER-RIEN, domiciled at Les Escoumins, district of Hauterive, defendant.A part of lot number eight (P.of 8), on range two (R.2), in the official cadastre of the township of Les Escoumins, being a lot of land of irregular shape, measuring, on the north-west 284 feet, on the south-west 315 feet, on the north-cast 275 feet, and on the south-east the space between the concession road and the land belonging to Johnny Robertson, English measure, bounded on the south-west by thc concession road, on the north-west by Ronaldo Roussel, on the north-east by Johnny Robertson, and on the south-east by the concession road, with the house and other buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.To be sold in the office of thc registrar for the registration division of the county of Saguenay, in the Baic-Comcau Court House, on TUESDAY, the THIRTEENTH day of the month JANUARY 1970.at TEN o'clock in the forenoon.Marcel Rodrigue, Sheriff's Office, Associate Sheriff.Baie-Comeau.32277 7006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n\" 50 JOLIETTE Fieri Facias de Bonis el de Terris ' 'anaci.a \u2014 Province de Québec District dc Joliette Cour Supérieure, / rT»ASMARK LTD., une cor-No 23,590.) poration ayant son siège > social dans les ville et district de Montréal, demanderesse, vs JEAN BILODEAU & GILLES GAGNIER, tous deux de la ville de Saint-Donat, district dc Joliettc, défendeurs.\" L'ne certaine propriété immobilière dc forme irrégulière, qui est la partie sud-est dc la subdivision de lot numéro deux du lot originaire numéro cinquante cl un du cinquième rang de canton dc Lussicr, dans le comté de Montcalm, représentant toute cette partie dudit lot appartenant au vendeur, sur lc côté nord-est dc la Houle numéro IS, mesurant cn largeur, deux cent soixante-six pieds et quatre dixièmes de pied sur son côté sud-ouest, le long de ladite route 18 sur une profondeur, sur sa ligne nord-ouest, longeant la ligne de division entre la propriété immobilière vendue pur la présente et cette propriété au nord-ouest qui est une autre partie dudit lot appartenant à Gérard Côté ou représentants, mesurant mille quatre cent douze pieds (1,412 pieds), sur une profondeur, sur sa ligne sud-est de deux mille quatre-vingt-seize pieds (2,096 pieds) et comprenant une superficie dc six cent quarante-quatre mille, sept cent cinquante pieds carrés (644,750 pi.ca.), l'équivalent dc 14.90 acres.Toutes les mesures sont mesures anglaises et plus ou moins.Ladite partie du lot 51-2 est bornée en avant au sud-ouest par ladite route numéro 18, à l'arrière au nord-est par le Lac Ouimet, sur un côté au nord-ouest, partie par nue autre purtie dudit lot 51-2 appartenant ù Gérard Côté ou représentants et partie par le Lac Ouimet, et sur l'autre côté au sud-est par une partie du lot 50-2 dudit cinquième rang auxdits plan et livre de renvoi officiels dudit canton dc Lussicr.Avec toutes les bâtisses y érigées.Cette certaine propriété immobilière, terrain vague dc forme irrégulière faisant front sur la route numéro 18 et faisant partie dc la partie à l'extrémité sud de la subdivision dc lot numéro deux du lot originaire numéro cinquante et un (51-p.2) du cinquième rang du canton Lussicr, dans lc comté Montcalm, représentant toute cette partie dudit lot appartenant au vendeur sur le côté sud-ouest de ladite roule numéro 18, mesurant en largeur deux cent soixante-six pieds et cinq dixièmes de pied (206.5') sur son côté nord-est lc long dc la route numéro 18 sur la même largeur ù l'arrière sur son côté sud-ouest, pur une profondeur sur sa ligne nord-ouest lc long dc la ligne de division entre cette propriété immobilière vendue par les présentes et cette propriété au nord-ouest étant une autre partie dudit lot appartenant à Gérant Côté ou représentants ayant quatre-vingt-cinq pieds et six dixièmes de pied (85.6') sur une profondeur sur sa ligne dc côté sud-csl de soixante-neuf pieds et cinq dixièmes de pied (69.5') et comprenant une superficie totale de vingt mille six cent, soixante-quinze pieds carrés (20,675 pi.eu.), mesure anglaise et plus ou moins, bornée ladite parcelle de terrain comme suit: cn avant au nord-est par ladite route numéro 18, à l'arrière au sud-ouest par la ligne de division entre les cinquième et JOLIETTE Fieri Facias de Bonis el de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Joliettc Superior Court, l rPASMARK LTD., a cor-No: 23,590.\\ *¦ poration having its v head office in the City & District of Montreal, plaintiff vs JEAN BILODEAU & GILLES GAGNIER both of lhe Town of St.Donat, District of Joliette, dependants.\"That certain immovable property of irregular figure being the southeast part of lut subdivision number two of original lot number fifty-one of thc fifth range of thc township of Lussicr, in the county of Montcalm, being all that part of the said lot belonging to thc Vendor on the northeast side of highway route number 18, measuring in width, two hundred and sixty-six fect and four tenths of a foot on its southwest side along said highway route number 18, by a depth on its northwest line along the division line between thc immovable property hereby sold and that property to the northwest being another part of the said lot belonging to Gérard Côté or representatives, of one thousand four hundred and twelve feet (1,412 ft.) by a depth on its southeast line of two thousand and ninety-six feet (2,096 ft.) and containing a superficial area of six hundred and forty-four thousand seven hundred and fifty square feet, (614,700 sq.ft.) equivalent to 14.90 acres.All measurements being English measure and more or less.Bounded said part of lot 51-2 in front to lhe southwest by said highway route number IS, in rear to the northeast by Lake Ouimet, on one side to thc northwest partly by another part of said lot 51-2 Belonging to Gérard Côté or representatives and partly by Lake Ouimcl, and on thc remaining side to the southeast by u part of lot 50-2 of the said fifth range of the said official plan and book of reference of the said township of Lussicr.With thc buildings thereon erected.That certain vacant immovable property of irregular figure fronting on highway route number 18 and forming part of thc extreme south part of lot subdivision number two of original lot number fifty-one (51 pt.2) of the fifth range of the township of Lussier, in the county of Montcalm, being all that part of said lot belonging to the vendor on the southwest s de of said highway route number 18, measuring in width two hundred and sixty-six fect and five-tenths of a foot (266.5') on its northeast side along said highway route number 18 by lhe same width in rear on its southwest side, by a depth on its northwest line along the division line between the immovable property hereby sold and that property to the northwest being another part of said lot belonging to Gerard Côté or representatives of eighty-five feet and six-tenths of a foot (85.6') by a depth on ils southeast side line of sixty-nine feet and live-tenths of a foot (69.5') and containing a total superficial area of twenty thousand six hundred and seventy-five square feet (20,675 sq.ft) English measure and more or less, bounded said parcel of land as follows: in front to the northeast by said highway route number 18, in rear to the southwest by the division line between the fifth and fourth ranges of said township QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, No.60 7007 quatrième rangs dudit canton dc Lussicr, d'un côté au nord-ouest par une autre partie du même loi, propriété dc Gérard Côté ou représentants, cl de l'autre côté au sud-est par une partie du lot 50-2 dudit cinquième rang du canton de Lussicr.Ix- tout tel qu'il apparaît sur un relevé dc ladite propriété préparé par l'arpenteur Jacques Poulin.le 14 novembre I960, souligné cn rouge sur le document annexé à l'acte de vente dc M.et.Mme Raymond Carmichacl à « Freedom (l)ror) Young Zionist Organization Inc.», passé devant C.J.Campbell, notaire, le 21 décembre I960, enregistré au comté de Montcalm sous le numéro 84466.Telle que ladite propriété existe présentement avec tous les droits, membres et appartenances, sans exception ou réserve d'aucune sorte dc la part, du vendeur.» Pour être vendue à la division d'enrcgislre-menl dc Montcalm, à Sainte-Julienne, district de Joliettc, MARDI, le VINGTIÈME jour dc JANVIER 1970, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif, Itureau du Sheriff, CHRISTIAN Roy.Joliette, le 5 décembre 1969.32288 of Lussicr, on one side to the northwest by another part of the same lot, thc property of Gérard Côté or representatives, and on the remaining side to the southeast by a part of lot 50-2 of thc said fifth range of the township of Lussier.The whole as shown on a survey of thc said property prepared by Jacques Poulin, q.l.s., dated November 14, I960, outlined in red annexed to the (Iced of sale from Mr.& Mrs.Raymond Carmichacl to Freedom (Dror) Young Zionist Organization Inc., passed before C.J.Campbell, Notary, on December 21, 1960, registered at the county of Montcalm under No.84466.As thc said immovable property now subsists with all its rights, mcmlicrs and appurtenances, without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.\" To be sold at thc registration division of Montcalm, in Stc-Julicnnc, district of Joliettc, TUESDAY, the TWENTIETH day of JANUARY, 1970 at ELEVEN o'clock in the forenoon.Christian Roy, Sheriff's Office, Slteriff.Joliette, December 5, 1969.32288-0 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: 1 T?LZÉAR BEAUDOIN, do-Cour Provinciale,/ *-* micilié à 1062, Avenue No 35-124.\\ Royale, Villeneuve, P.Q., con-\\lre Mb GEORGES BOU-DREAU, avocat faisant affaires à 466, de la Couronne, Québec.« Lc lot 2394 subdivision 147 du cadastre officiel de St-Sauvcur.ville dc Dubcrger, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureuu d'enregistrement de Québec, 3, avenue Chauvcau, Québec, le QUATORZIÈME jour du mois de JANVIER 1970, à DIX heures de l'avant-midi.Ix shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 9 décembre 1969.32278-o Fieri Facias de Terris Québec, à savoir:f COCIÉTÉ D'ADMINIS-( our Supérieure,j TRATION ET DE FI-No 493.) DUCIE, corporation légale-\\ ment constituée, ayant son siège social à Montréal, et une place d'affaires à 1091, Chemin St-Ix>uis, Sillery, district de Québec, contre ROLAND BOUCHARD, résidant à 163, rue Seigneuriale.Beauport, district de Québec, et LE RÉGISTRATEUR DE LA DIVISION D'ENREGISTREMENT DE QUÉBEC, niis-en-causc._« lji subdivision 25 du lot originaire 548 (548-25) du cadastre officiel dc Beauport, comté de Québec,, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances et avec toutes les servitudes actives et passives pouvant affecter le susdit immeuble.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, avenue Chauvcau, Québec, le QUATORZIEME jour du mois de JANVIER 1970, à DIX heures de l'a van l-midi.Ix shérif adjoint, ISureau du Shérif, Raymond Hains.Quebec, le 9 décembre 1969.32281 -o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( TfLZEAR BEAUDOIN, do-Provincial Court, J miciled at 1062 Royale No.35-124.\\ Avenue, Villeneuve, P.Q., I against Me GEORGES BOU-DREAU, advocate carrying on business at 466 dc la Couronne Street, Québec.\"Lot 2394, subdivision 147 on the officiai cadastre of St-Sauvcur, town of Duberger, with thc buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at the registry office of Québec, 3 Chauvcau Avenue, Québec, the FOURTEENTH .lay of the month JANUARY, 1970, at TEN o'clock in thc forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Associate Sheriff.Québec, December 9, 1969.32278 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( COCIÉTÉ D'ADMINIS-Superior Court.) O TRATION ET DE FI-No.493.j DUCIE, a corporation legally ' constituted, having its head office in Montreal, and a place of business at 1091, St-Louis Road, Sillery, district of Québec, against ROLAND BOUCHARD, residing at 163 Seigneuriale Street, Beauport, district of Québec, and THE REGISTRAR OF QUÉBEC REGISTRATION DIVISION, mis-en-euusc.\"Subdivision 25 of original lot 548 (548-25) on the official cadastre for Beauport, county of Québec, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies and with all the servitudes active and passive that may uffect the uforcsaid immovable.\" To be sold at the Registrv Office of Québec, Chauvcau Avenue, Québec, thc FOURTEENTH day of the month of JANUARY, 1970, at TEN o'clock in thc forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office.Associate Sheriff.Québec, December 9, 1969.32281 7008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 101' année, n° 50 Fièri Facias de Terris Québec, à savoir:/ TA M U T U A L LIFE Cour Supérieure,; *-> COMPAGNIE D'AS-No 1629.\\ SURANCE DU CANADA, l.corporation légalement constituée ayant, son siège social à Waterloo, province d'Ontario, et une place d'affaires en les ville et district dc Québec, contre LAWRENCE MORIN, résidant au numéro civique 3389.avenue St-Victoricn, cité de Giffard, district de Québec, et LE REGISTRATEUR DE LA DIVISION D'ENREGISTREMENT DE QUÉBEC, mis-en-cause.« La subdivision cinq cent dix-neuf du loi originaire numéro six cent quatre-vingt-dix (690-519) aux plan et livre dc renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de Beauport, avec toutes les bâtisses dessus construites) circonstances et dépendances et notamment la maison située à Giffard, rue St-Victorien, No.3389.» Pour être vendu au Bureau d'enregistrement de Québec, 3, Avenue Chauvcau, Québec, le QUINZIÈME jour du mois de JANVIER 1970 à DIX heures dc l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif.Raymond Hains.Québec, le 9 décembre I960.32279-0 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( T A MUTUAL LIFE COM-Cour Supérieure, J ¦L' PAGNIÈ D'ASSURAN- No 1167.) CE DU CANADA, corporu-' tion légalement constituée ayant son siège social à Waterloo, province d'Ontario et une place d'affaires en les ville et district de Québec, vs ST-GEORGES CÔTÉ, résidant au numéro civique 1710, Parc Chesnaye, Cité de Sillery, district de Québec, et, LE RÉGISTRATEUR DE LA DIVISION D'ENREGISTREMENT DE QUÉBEC, mis-en-cause.« La redivision vingt-neuf de la subdivision deux cent cinquante-neuf du lot originaire numéro deux cent trois (203-259-29) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de St-Colomb de Sillery, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, notamment la maison située à Sillery, Parc Chesnaye, numéro 1710.» Pour être vendu au Bureau d'enregistrement de Québec, Avenue Chauvcau, Québec, P.Q., le TREIZIÈME jour du mois de JANVIER 1970 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 9 décembre 1969.32280-c» R O B E R V A L Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Roberval Cour Supérieure, ( T 'OFFICE DU CRÉDIT Cause No 34,059.j ^ AGRICOLE DU QUÉ-' BEC, corps politique et incorporé, ayant siège social à Québec, demanderesse, vs OVIDE POTVIN, cultivateur, R.R.No 2, Stc-.Icannc d'Arc, comté dc Roberval, P.Q., défendeur.« Les lots de terre connus et désignés sous les numéros vingt-trois, vingt-quatre et vingt-cinq (lots 23, 24 cl 25) du troisième rang (rg III), aux plan et livre dc renvoi officiels du cadastre Fieri Facias dc Terris Québec, lo wit:/ fHE MUTUAL LI PB Superior Court, ) J- ASSURANCE COM.No.1629.1 PANY OF CANADA, n ' corporation legally incorporated having its head office in Waterloo, Province of Ontario, and a place of business in the City and district of Québec, vs LAWRENCE MORIN.residing at 3389 St-Victorien Avenue, city of Giffard, district of Québec, and THE REGISTRAR OF THE REGISTRATION DIVISION OF QUÉBEC, mis-en-cause.\"Subdivision five hundred and nineteen of original lot number six hundred and liinelv (690-519) on the plan and book of reference for the official cadastre for the parish of Beauport, with all buildings constructed thereon, circumstances and dependencies and notably the house situated in Giffard.Sl-Victorien Street, ul No.3389.\" To be sold at the Québec Registry Office.:( Chauvcau Avenue, Québec, on the FIFTEENTH day of the month of JANUARY, 1970 at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains.Sheriff's Office.Associate Sheriff.Québec.December 9, 1969.32279 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( r~pHE MUTUAL LIKE AS-Superior Court, J J- SURANCE COMPANY No.1167.I OF CANADA, a corporation ' legally incorporated having its head office in Waterloo, Province of Ontario and a business place in the City and District of Québec, vs ST-GEORGES CÔTÉ, residing at 1710 Chesnaye Park, City of Sillery, District of Québec, and, THE REGISTRAR OF THE REGISTRATION DIVISION OF QUÉBEC, mis-en-cause.\"Redivision twenty-nine of subdivision two hundred and fifty-nine of original lot number two hundred und three (203-259-29) on the plan and book of reference of the official cadastre of St.Columban of Sillery, with all buildings constructed thereon, circumstances and dependencies, notablv the house situated in Sillery, at Chesnaye Park, Number 1710.\" To be sold at the Québec Registry Office, Chauvcau Avenue, Québec, P.Q.on the THIRTEENTH day of the month of JANUARY, 1970.at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Associate Sheriff- Québec, December 9, 1969.32280 R 0 B E R V A L Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Roberval Superior Court, I THE QUÉBEC FARM Case No.34,059.A CREDIT BUREAU, ' body politic and corporate, having its head office in Québec, plaintiff, is OVIDE POTVIN, farmer, R.R.No.2.Sic Jeanne d'Arc, county of Roberval, P.Q.defendant.\"The lots of land known und designated under numbers twenty-three, twenty-four and twenty-five (lots 23, 24 and 25) on the third range (R.Ill), on the official plan und in the book of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 19G9, Vol.101, No.BO 7009 du canton Dolbcau, division d'enregistrement !,ac St-Jean Ouest, avec bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances.Sauf ù distraire desdits lots la lisière dc terrain cédée au Ministère dc la Voirie dc la province dc Québec pour élargissement dc la route régionale 55.Sauf réserve, concernant lesdits lots, de la servitude existant cn faveur dc la « Coopérative d'Électricité Régionale dc Péribonka » suivant acte enregistré sous le numéro 85,743.Sauf réserve, concernant lesdits lots, des droits de « Saguenay Power Company Limited » suivant acte enregistré.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement île lu division dc Lac St-Jcan Ouest à Roberval, le QUINZIÈME (15) jour dc JANVIER 1970, à ONZE (11) heures de Pavant-midi.Ia: shérif, Bureau du Shérif, Léon-Maurice Lavoie.Palais de Justice, Roberval, le 3 décembre 1969.32282-0 SAINT\u2014FRANÇOIS Fieri Facias de Bonis cl dc Terris District de St-François ( our Provinciale, ( \"DORDER PETROLEUM (Sherbrooke), ) & PRODUCTS LTD., corps No.16,130.1 politique et incorporé, ayant t.une place d'affaires à Stanstead, district dc Saint-François, demanderesse, vs JOS MACLURE, résidant à Stanstead, district île Saint-François, défendeur.« Lc lot numéro 24 pour le Village dc Stanstead avec maison dessus construite, portant lc numéro civique 151 rue Dufferin.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement, à Stanstead Plain, MARDI, le TREIZIÈME jour dc JANVIER 1970, ù DIX heures dc l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Don at Jacques.Sherbrooke, le 3 décembre 1969.32283-o reference of thc cadastre of the township of Dolbcau, registration division of Lake St.John West, with thc buildings constructed thereon, appurtenances and dependencies.Save to be withdrawn from thc said lots is the strip of land ceded to the Department of Roads of the Province of Québec for thc widening of regional highway 55.Save reserve, concerning the said lots, of the servitude existing in favour of the \"Coopérative d'Électricité Régionale dc Péribonka\", according to thc deed registered under number 85,743.Save reserve, concerning the said lots, of thc rights of \"Saguenay Power Company Limited\" uccording to the deed registered.\" To be sold in thc registry office of thc division of Lake St.John West at Roberval, on the FIFTEENTH (15) day of JANUARY.1970, at ELEVEN (11) o'clock in thc forenoon.Léon-Maurice Lavoie, Sheriff's Office, Sheriff.Court House.Roberval, December 3, 1969.32282 SAINT \u2014FRANÇOIS Fieri Facias dc Bonis el de Terris District of Saint-François Provincial Court, ( \"DORDER PETROLEUM (Sherbrooke), ) J-> PRODUCTS LTD., a No.16,130.J body corporate and politic, \\ having a place of business at Stanstead, district of Saint-François, Plaintiff, va JOS MACLURE, residing at Stanstead, district of Saint-François, defendant.\"Lot number 24 for the Village of Stanstead with house thereon erected, bearing civic number 151 Duffcrin Street.\" To be sold at thc registry office, at Stanstead Pluin, TUESDAY, thc THIRTEENTH day of JANUARY, 1970, at TEN o'clock in thc forenoon.Donat Jacques, Sheriff's Office, Sheriff.Sherbrooke, December 3.1969.32283 INDEX No 5 O ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 3629 \u2014 Réduction du montant dc lu rente et du coût des travaux requis payables par la compagnie Shell Québec Limitée.6963 3629 \u2014 Reduction in the amount of thc rental and of thc cost of thc required work payable by the Compagnie Shell Québec Limitée.6963 3630 \u2014 Soustraction au jalonnement dc deux (2) étendues de terrain situées duns le comté de Gaspé-Sud.;.6964 3630 \u2014 Withdrawal from staking of two (2) strip-, of land situated in the county of Gus|)é South.6964 VMS divers MISCELLANEOUS Notices ( Micvaliers de Colomb de Acton Vale inc., Conseil St-André No 2825 (Régi.).6935 < 'hevaliers de Colomb d'Amos inc., Conseil Amos 2218 .6935 Chevaliers de Colomb dc Champlain inc., Conseil Champlain No 2915.6935 ( 'hevaliers de Colomb de Havre St-Picrrc, comté dc Duplessis, P.Q., Conseil No 5875 (Régi).6936 Chevaliers dc Colomb de Hudson, Conseil No 4135 (Régi)-.6935 Chevaliers dc Colomb dc l'Annonciation inc., Conseil l'Annonciation No 5851.6936 ( hevaliers dc Colomb de Pierrcville, Conseil No 1889 (Règl.).6936 ( hevaliers dc Colomb dc Pointe St-Charles inc.Conseil Pointe St-Charles No 4766 (Régi).6936 ('hevaliers dc Colomb dc Pont-Rouge, Conseil Pont-Rouge No 3017 (Règl.).6937 Chevaliers dc Colomb dc St-André Avellin, Conseil No 3007 (Règl.).6936 (.'hevaliers de Colomb de St-Casimir inc., Conseil St-Casimir No 2940.6937 ( 'hevaliers de Colomb dc Ste-Justine, Conseil Stc-Justinc No 3236 (Règl.).6938 7010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 décembre 1969, 10V année, n\" 60 AVIS divers (suite) MISCELLANEOUS Notices (continued) Chevaliers de Colomb de St-Jacques de Montculm inc.Conseil Montcalm No 3074 (Règl.).Chevaliers de Colomb dc St-Pic dc Bagot inc., Conseil St-Pic No 2958 (Règl.).Chevaliers dc Colomb de Sept-Iles inc., Conseil Sept-Iles No 3638 (Règl.).Knights of Columbus of Acton Vale Inc., Council St-André No.2825 (By-laws).Knights of Columbus of Amos Inc., Council Amos 2218.Knights of Columbus of Champlain Inc., Council Champlain No.2915.Knights of Columbus of Havre St-Picrrc, County of Duplessis, P.Q.Council No.6875 (By-laws).Knights of Columbus of Hudson, Council No.4135 (By-laws).Knights of Columbus of L*Annonciation Inc., Council L'Annonciation No.5851.Knights of Columbus of Pierrcville, Council Pierrcville No.1889 (By-laws).Knights of Columbus of Pointe St-Charles Inc., Council Pointe St-Charles No.4766 (Unlaws).Knights of Columbus of Pont-Rouge, Council Pont-Rouge No.3017 (By-laws).Knights of Columbus of St-André Avellin, Council No.3007 (By-laws).Knights of Columbus of St-Casimir Inc., Council St-Casimir No.2940.Knights of Columbus of St-Jacqucs de Montcalm Inc., Council Montcalm No.3074 (By-laws) Knights of Columbus of St-Pic de Bagot Inc., Council St-Pic No.2958 (By-laws).Knights of Columbus of Sept-Iles Inc., Council Scpt-Ilcs No.3638 (By-laws)-.Knights of Columbus of Stc-Justinc, Council Ste-Justine No.3236 (By-laws).Montmagny, cité-city (Programme de rênovalion-Reneual Program).Montreal, ville-city (Rachat d'obligatious-Rcdemption of Bonds).CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME \u2014Act 6(137 8937 0937 0935 0935 6H35 0930 0935 6930 0930 6930 6937 6930 6037 0037 6037 0937 6938 0938 6978 Boulet, Joseph Élic (Dcm.-Appl.).Chong, Maire Eva Nancy (Dem- Appl.) ¦.Denmark, Margaret Norccn (Dem - Appl.) Kalen, Maury (Acc.-Grant.).Kioussi, George (Acc.-Grant.).See, Wilfried Louis (Dcm.-Appl.).Shishakly, Moufid William (Acc.-Grant.).Treibich, Danny Irving (Dem-Appl.) Tang, Frances Wu (Acc.-Grant.).0954 6954 6954 695,) 6955 6954 (1955 6954 6955 COMPAGNIES COMPANIES Notices relative to the Art of Licensed to do Business Avis relatifs ù la loi des Autorisées ù faire des affaire* Arvida A.G.6946 Canriv S.A.6946 Cyanamid Americas Trading Company.6947 Transalta Oil & Gas Ltd.6947 Zugitan A.G.Zug.6947 Chartes \u2014 demandes d'abandon dc Charters \u2014 Applications for Surrender of Conseil économique dc la région dc Charlevoix inc.6955 Conseil économique de comté de.Portneuf inc.6956 (\"ouverture Nationale Compagnie limitée (La).6956 Distribution Bartolini liée.6956 Eastern Canada Exhibitions Inc.6956 Eclipse Investment Corp.6957 Fashion Guild Incorporated.6956 Gregory Investment Corp.6957 Guiline (B.A.) Company (The).6957 Harvey Realties Limited.6957 Hôtel Union (Alma) ltée.6956 Immeubles Harvey limitée (Les).6957 Industrial Sites (1956) Limited.6957 Koban Cosmetics Ltd.695S Manufacture de Meubles d'Amqui ltée.6957 Modem Poultry Inc.695S Rénovation Moderne inc.6958 Tobias Investments Ltd.695S Van tines (Canada) Inc.6955 Woolnough (E.II.) Incorporated.695S Dissoutes Dissolved Affco Investments Corp.6931 Arrow Investment Corp.6931 Association des Pharmaciens d'Hôpitaux de la province de Québec inc.6931 Association Tcx-Club inc.0931 Beaumont Litho Plate Corp.6931 Berjaco ltée.6931 Cadillac Holdings Ltd.6932 Centre dc Service G M ltée.6932 Cinéma Normandie inc.693'.' Claudini inc.6932 Compagnie dc Téléphone de Risborough (La).Dominion News Bureau Limited ( I lie).Duquette & Garicpy incorporée.Glickman Dress (Mtl) Corp.Granville Enterprises Inc.Harper (Lmitcd) (J.B.).Harper (limitée) (J.B.).Importateurs de Fruits et de Légumes de St-Hyacinthe ltée (les).Janice Corp.Lc Foyer Restaurant inc.Meuble Victoria ltée (Au).Morencv-incorporéc (J.l*s).Morin ltée (Unis M.).6934 Restaurant Le Foyer inc.''934 St.Viateur Restaurant Inc.6934 Stratford Interests Ltd.0035 Divers Miscellaneous Association dc Sécurité des PAtes et Papiers du Québec inc.(Dir.).094h Association de Sécurité des l'Aies et Papiers du Québec inc.(Règl.).6941 Association de Sécurité des Exploitations Forestières du Québec inc.(Règl.).IHM8 6932 6932 6933 6933 6933 0933 6933 6933 6934 6934 6934 6934 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 13, 1969, Vol.101, Nol 60 7011 Divers Miscellaneous (suite) (continued) Bench & Table Service (1907) Limited (Dir.).0952 ( Canada Puckaging Ltd.(Dir.).0948 ( lliiffonniers-Bfttisseurs d'Eminalls dc I lull incorporée (Les) (Règl.-By-laws) 6948 ( orfinex inc.(Dir.).6952 Corporation dc Placements Hillcath (Dir.).:.v-.6948 Cunard Steam-Ship Company Limited (The) (Agent).6952 Eagle Toys Export Corp.(Dir.).6949 Eastern Townships Agricultural Association 1967 (Règl.-By-laws).694S Kngrais du Saint-Laurent ltée (.Les) (Dir.).6952 Festival de Football 69 inc.(U) (Règl.) 6949 football Festival 69 Inc.(liy-lam)- 6949 General Apparel Contractors Inc.(Dir.) 6953 General Forest Products Limited (Dir.) 6949 Cold Nugget Dairy Ltd.(Dir.)-.6949 Hillcath Investments Corporation (Dir.) 6948 Hillside Tennis Club Inc.(The) (Règl.- By-laws).6949 Horizon Rower Ltd.(Noni-Nanie ch.).6950 Hum Investments Ltd.(Dir.).6949 Meal Electric Inc.(Dir.).6950 International Knitting Mills Ltd.(Dir.) 6950 Ipsco inc.(Dir.).6953 Kales Ltd.(Dir.).6953 L & R.Electronics Inc.(Xom-Xume ch.),.0980 Lac Pin Rouge Citizen's Association (lièyl.-lly.tuic*).6950 Laiterie Pépite d'or ltée (Dir.).6949 Laurendeuii (Bcrnurd) inc.(Dir.).6950 Lewis (Fred) Shoe Corporation (Dir.) 6953 Maison Pie XII (Règl.-By-laws).6953 Majestic Soap Ltd.(Dir.).6950 Montreal Picture Frame Compuny Ltd.(Dir.).6951 Original Textiles Ltd.(Dir.).6953 Pax Construction Inc.(Dir.).6951 Produits Forestiers généraux limitée (Dir.).6949 Québec Logging Safety Association Inc.(Bylaws).694S Québec Pulp & Paper Safety Association Inc.(Dir.).6948 Québec Pulp & Paper Safety Association Inc.(Bylaws).6947 St.lAwrence Fertilizers Ltd.(Dir.).6952 St.Patrick Development Corporation Ltd.(Dir.).6951 Sanico Sanitary Services Inc.(Dir.).6951 Sanico Sanitary Services Inc.(Dir.).6951 Savon Majestic ltée (Dir.).6950 Services Sanitaires Sanico inc.(Dir.).6951 Services sanitaires Sanico inc.(Dir.).6951 Service Plastics & Chemicals Corp.(Dir.).6951 Société u).6904 Limagi inc.6905 Mue Callum \u2014 Irving Inc.6905 Mugnun, (Bernard) incorporée.6905 Maison d'Escompte Plessis inc.0905 Maniwaki Industries Ltd.6906 Manbec inc.6906 Manufacture Farbstein (Québec) ltée .6907 Manoir S1 -1 .a m I ht t.6907 Martin (Claude et Marcel) inc.6907 Maxi-Ko limitée.6908 Meubles St-Paul inc.(Les).6908 Mobec Equipement ltée.6908 Mond Bec inc.6909 Montpetit (Robert) inc.6909 Morin (Robert) inc.6909 Motel Lc Chalutier inc.6910 Multi-Fund Investment (Quélx-c) Ltd.6910 Parallel Investment Corporation Ltd.6910 Pièces d'Autos Astronautes inc.6911 Placements Buckingham inc.6911 Placements Bernard Courtemanche ltée 6911 Plastiques renforcés Québécois inc.6912 Plaza Ontario Pizza and Restaurant Inc.0912 Plomberie P.M.inc.6912 Portuguese Cultural Centre of Canada Inc.6913 Produits Addolinc du Québec ltée (Les) 6913 Produits Avicoles Marietta inc.(Les).6913 Produits Carat inc.6911 Publicad International Ltd.6914 Publi-media Inc.6914 Québécois Reinforced Plastics Inc.6912 Radio-Tel.inc.691.\") Rembourrage Industriel Kebec inc.6915 Restaurant La Ripaille inc.6915 Restaurant Lc Héron inc.6916 Rénovations dc l'Est inc.(Les).6916 Revue Internationale de l'Auto-ncige inc.(La).6916 Richard (Raymond) inc.6917 Richardson (Barbara) Wildlife Foundation.6917 Robert (Raymond) ltée.6917 Robert (Raymond) Ltd.6917 St-Lambcrt Manor.6907 St-I^awrcncc Foundries Limited.6894 St-Picrrc & Romo ltée.6918 Sept-Iles Industries Inc.6918 Shclford Armature Manufacturing Inc.6918 Société H.B.L.inc.(La).6919 Société Populaire «l'Éducation Socio-Familiale inc.6919 Stay-Set Inc.6919 Sullivan Mining Group Ltd.6920 Swiss Precision Automatic Inc.6920 T.C.Electronics Ltd.6921 Tapis Beloeil inc.6921 Télé-Page inc.6921 Tissot inc____.6922 Union Collection Inc.6885 Valleyficld Curling Club Inc.6883 Val-Maurice inc.6922 Val Séjour inc.6922 Verdi Investment Inc.6923 Verrucci & Larivièrc assurances inc.6923 Ward Services Ltd.6923 West-End Oil Ltd.6924 Lettres patentes Supplementary supplémentaires tetters Patent Anwal Limited.6924 Artmctwork Inc.6921 Au Pavillon dc l'Auto (Montréal) inc.6925 B.G.Service d'Entretien inc.6925 Baron (H.).6925 Brady Realties Corporation.6925 Camp Maromac inc.6926 Canadian Slovuk Building Ltd.6926 Capital Garment Co.Inc.6926 Clarond LUI.6926 Compagnie Pelchat ltée (La).6926 D'Aoust (J.B.) inc.6926 Drolet (Guy Ernest) inc.6927 Dufault (Robert) ltée.6927 Dufault (Robert) Ltd._.6927 Dufrcsnc, McLagan, Daignault, inc.8927 Entreprises Bolac inc.(Les).6921 Harwood, (Henri) fils & Compagnie ltée 8928 Harwood (Henri) Sons & Company Ltd.692-.Industries Suguenay limitée (Les).89311 Informatcl inc.692 s Kent-Labclle Inc.09'2n M.S.M.Industries Inc.6928 Matcomart inc.6929 Mibcl Investments Inc.6929 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December IS, 19G9, Vol.101, No.50 7013 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent (suite) (continued) Murray Hill Limousine Service Limited 6929 Placements Jean-Paul Tanguay, ltée.6929 Provost Cartage Inc.6930 R M Communication Inc.6930 Sagucnay Industries Limited.6930 Service dc Communication R M inc.6930 Service dc Limousine Murray Hill limitée.6929 Transport Centre inc.6930 Sieges sociaux Head Offices Allyn Enterprises Ltd.6939 Ameublements Mailhot & Dussault inc.(Les).6939 Ameublement Vaudreuil inc.6946 Au Rois brillé inc.6939 11.& F.Enterprises Inc.6939 liellon lue.6939 bourret Transport ltée.6940 brackhall Corporation Ltd.6940 ( entrai Design & Drafting Ltd.6946 Centre Culturel et Communautaire de Warwick inc.6940 Centre dc Distribution Koscot dc Québec limitée.6940 Centre du Pneu Hauterive inc.6941 Compagnie dc traitements thermiques de métaux de Montréal limitée (La).6940 Compagnie diversifiée St-Laurent (La).6941 De Foy Construction Inc.6941 Ecole secondaire classique de Joliette.6941 Bcoîe secondaire classique «le Sorel.6942 École secondaire classique Villa-Maria.6942 Enco Corporation.6942 Entreprises P.& F.inc.6939 Entreprises Fcrnand Seguin inc.(Les).6949 Foyer Furnham inc.(Les).6942 General Building Products Ltd.6945 Gciidron (Viateur) & Fils ltée.6943 Glenreet Inc.6941 Hanmur Limited.6943 Industries Parick inc.(Les).6943 Ipsco Inc.6938 Koscot Distribution Center of Québec Limited.6940 M.G.Communications Visuelles inc.6943 Montreal Metal Heat Treating Company Limited.6940 Parick Industries Inc.0943 Patisserie 1c Midi inc.6943 Placements Bcauchcmin inc.(Les).6944 Placements Bourassa inc.(Les).6944 Produits Généraux «le la Construction inc.(Les).6945 Produits Sanus inc.6944 Rubin (S.) Realty Corp.6942 St.Lawrence Diversified Company.6941 Sanus Products Inc.6944 Société Pyramex inc.6944 Sonorité TR ltée.6945 Transport Centre inc.6945 Trudel (Adrien) inc.6945 Vaisseau d'Or limitée (Le).6945 Watts (Herbert A.) (Québec) Limited.6944 LIQUIDATION WINDING avis de up Notices Clay Construction Inc.6953 DEMANDE APPLICATION h la Législature to Legislature Bahary, Alfred A.6954 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Dégelis, villc-town (L.P.).6995 New-Richmond, villc-town (L.P.).6997 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Beauport, cité-city (Acc.-Grant.).6960 Bellefeuille, (Acc.-Grant.).6960 Buckingham (Prot.) (Dem.-Appl.).6960 Des Cascades (Dem- Appl.).6959 Jean Rivard (Acc.-Grant.).6961 La Tuque (Prot.) (Dem- Appl.).6959 Mitis (La) (Acc.-Grant.).6961 Outaouais, s.s.r.-r.s.b.(Acc.-Grant.).6959 Poltimorc (Prot.) (Dem.-Appl.).6960 Secteur-Amqui (Acc.-Grant.).6960 Trois-Saumons (Acc.-Grant.).6961 Institutions Financial financières, Institutions, compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurance: Insurance: Ladies Catholic Benevolent Association (Nom-Name ch.).6959 Terres et Forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Fraservillc, villc-town.6962 St-Antoinc dc Longueuil, par.6963 St-Clémcnt.par.6963 Travail Labour Industrie ou métiers de: Industry or Trades of: Bois ouvré, Québec (Mod.).6979 Coiffeurs pour hommes et dames, Joliette (Mod.).6988 Coiffeurs pour hommes et dames, Sherbrooke (Mod.).6993 Construction, Province (Mod.-Amend.).6990 Hairdressers, (Men's and Ladies') Joliette (Amend.).6988 Hairdressers, (Men's and Ladies') Sherbrooke (Amend.).6993 Wrought Wood, Québec (Amend.)____ 6979 PROCLAMATION PROCLAMATION Land Titles Act in certain electoral district of the Province, applitaition of thc provisions of the Act.6976 Titres de propriété «lans certains districts électoraux de la province, application des dispositions de la Loi.6976 RÉGIE QUÉBEC de l'assurance récolte Crop du Québec Insurance Board Culture spéciale.6999 Grande culture.6999 Mixed farming land.6999 Specialized farming lan«l.6999 7014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1S décembre 1969, 10V année, n\" 50 Société Cooperative coopérative Agricultural agricole Associations Coopérative des producteurs dc lait de Montréal (Siège social).6999 Montreal Milk Producers Cooperative (Head Office).6999 SOUMISSIONS TENDERS Stc-Anne-des-Plaincs, par.7001 Saint-Pierre, villc-town.7000 SYNDICATS PROFESSIONAL Professionnels Syndicates Association professionnelle des cadres et de la gérance dc la fonction publique du Québec (Ext.terni.).6979 Fédération des employés dc services publics inc.(CSN) (Nom-Name ch.).6979 VENTES SALES SHÉRIFS SHERIFFS Ilcauce Beauce Office du crédit agricole du Québec (L') es Veilleux el al.7003 Québec Farm Credit Bureau (The) M Veilleux et al.7003 Hautcrive Hauterive Brisebois vs Therrier.7005 Joliette Jolictte Tosmark Ltd rs Bilodeau et al.7006 Québec Québec Beaudoin vs Boudreau.7007 Mutual Life Compagnie d'Assurance du Canada (La) vs Morin.700S Mutual Life Compagnie d'Assurance du Canada (La) vs Côté.700$ Société d'Administration et dc Fiducie rs Bouchard.7007 Roberval Roberval Office du crédit ugricolc du Québec (L') M Potvin.7008 Québec Farm Credit Bureau (The) M Potvin.7008 Saint-François Saint-François Border Petroleum Products Ltd.vs Ma-clure.7009 Taxes Taxes Bouclierville, ville-town.6966 Jonquière, cité-city.\".6965 "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.