Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 19 (no 16)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1969-04-19, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" 101° ANNÉE N\" 16 vol.101 ?2287 kiette officielle ûu Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 19 avril 1969 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hotel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième in-erlion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazelle officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dons ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dons une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.0° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, April 19,1969 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such cose, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be mode by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gaulle is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typograpliical error occurs in the first insertion, interested parties arc requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, KOCH LEFEBVRE, Québec Official Publxêher 2288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate pour cliaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $3 des 100 mots.Exemplaire séparé: 50 cents chacun.Feuilles volantes: $2 la douzaine.Abonnement: $10 par année à compter «le janvier.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Roch Lefebvue.Hotel du Gouvernement, Québec, 5 mai 1002 Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, for euch version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per ugutc line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $3 per 100 words.Single copies: 50 cents each.Slips: $2 per dozen.Subscriptions: $10 per year from January, N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazelle carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once arc followed by our invoice number.Rocii Lefbbvhk, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Quebec.May 5.1002 27440 \u2014 1-62-0 Le Ministère des Postes, & Ottawa, a autorisé l'affranchissement en numéraire et l'envoi comme objet de deuxième classe do la présente publication.Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.Lettres patentes A 2k Z surplus Iter Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé «les lettres patentes, en «latc du 6e jour de mars 1969, constituant en corporation: Claude Leroux, comptable, Marcelle Brisebois, secrétaire, épouse séparée de biens dudit Claude Leroux, tous «leux de 45, Pasteur, Jacques-Cartier, et Roger Brise-bois, vendeur, 10345, Grande-Allée, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises, sous le nom de « A à Z surplus ltée », avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Longueuil, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.28785-0 713-69 Les Agences de publicité Succès ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de mars 1969, constituant en corporation: Gilles Picard, industriel, Jean-Louis Roy, comptable, et Gérard-F.Lapointc, comptable agréé, tous trois de Saint-Pascal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs et conseillers en publicité, sous le nom de « Les Agences «le publicité Succès ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Letters Patent A a Z surplus ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 6th Marcotte, Alexander S.Konigsberg, 2378 Frenctte, both of Saint-Laurent, and Jacques-I^mattrc Auger, 8462 Drolct, Montreal, all three advocates, for the following purposes: The wood inilustry, under the name of \"Duplac inc.\", with a total capital stock of $40,00(1.divided into 20,000 common shares of $1 cadi and into 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 5465 Rosemont Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.28785 1025-60 Les Éditions Maintenant inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «laie tho 4 th ilay of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of I he Province, incorporating: Vincent Harvey, professor, Yves Gosselin, both of 2715 (Vite Ste-Cathcrinc Road, Hélène Pelletier, wife of Jacques Baillargeon, 2265 Sheridan Road, both journalists, André Charbonneau, student, 3350 Man'- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 19G9, Vol.101, No.16 2301 lionneau, étudiant, 3350, Maréchal, app.314, et Pierre Saucier, fonctionnaire, 4326, Marcil, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme éditeurs, imprimeurs, graveurs, relieurs et agents de publicité, sous lc nom de « Les Éditions Maintenant inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.I.c .sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 609-69 Edutec inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour de février 1969, constituant en corporation: Jacqucs-Lcmattrc Auger, 8402, Drolet, Mark lloscnstein, 5003, Lncombe, tous deux de Montréal, Pierre-L.La|k>inte, 155, Marcotte, Saint-Laurent, et Michel Saint-Aubin, 531, Davaar, Outremont, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Etablir une école ou un collège privé dont l'orientation en général sera l'enseignement de toutes les techniques se rapportant ù l'antomation et au traitement des données, sous lc nom de « I Muter inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est 1600, rue Herri, suite 220, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le suus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S785-0 674-69 Les Entreprises A.Bisson inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de mars 1969, constituant en corporation: Alban Bisson, cultivateur, Elisabeth Bérard, ménagère, épouse commune en biens dudit Alban Bisson, tous deux de 8200, boulevard des Mille Iles, Saint-Francois, et Claude Bisson, opérateur dans le travail tlu béton, 45, rue Mathieu, Terrebonne, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous lc nom de < Les Entreprises A.Bisson inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de ¦Sluii chacune.Le siège social de la compagnie est 8200, boulevard des Mille Iles, Laval, district judiciaire de Montréal.Le .mus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-6 615-69 Les Entreprises I)u-EI inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour île mars 1969, constituant en corporation: René Raymond, courtier d'assurance, 6560, Lemay, Nicole Lâ- chai, Apt.314, and Pierre Saucier, civil servunt, 4326 Marcil, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as publishers, printers, engravers, book-binders and advertising agents, under the name of \"Les Éditions Maintenant inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 609-69 Edutec inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques-Lcmaftre Auger, 8462 Drolet, Mark Rosenstcin, 5003 Lacombc, both of Montreal, Picrre-L.I.a pointe, 155 Marcotte, Saint-Laurent, and Michel Saint-Aubin, 531 Davaar, Outremont, all four advocates, for the following purposes: To establish a private school or college in which the general guidance will be based upon the teaching of all techniques related to automation and data processing, under the name of \"Edutec inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1600 Berri St., Suite 220, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 674-69 Les Entreprises A.Bisson inc.\u2022 Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Alban Bisson, fanner, Elisabeth Bérard, housewife, wife common as to property of the said Alban Bisson, both of 8200 des Mille Iles Boulevard, Saint-François, and Claude Bisson, operator in concrete work, 45 Mathieu Street, Terrebonne, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les Entreprises A.Bisson inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 8200 des Mille Iles Boulevard, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 615-69 Les Entreprises Du-EI inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: René Raymond, insurance broker, 6560 Lcmay, Nicole LaSalle, 2302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101- année, n° 16 Salle, secrétaire, épouse contractuellcment séparée de biens de Pierre Toupin, 6555, Lcmoy, tous deux de Montréal, et Muriel Ycrgcau, secrétaire, épouse contractuellemcnt séparée de biens de Jean-Marie Payeur, 385, des Bouleaux, Pointe-aux-Tremblcs, pour les objets suivants: Agir comme teneurs de livres et experts évaluatcurs, sous lc nom de « Les Entreprises Du-El inc.-, avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de lu compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el cooperatives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 291-69 Les Entreprises C.II.D.ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, 1'administrutcur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de mars 1969, constituant en corporation: Claude Dugas, 540, Stc-Thérèse, Jacques Dugas, 111, Tcllier, tous deux avocats et conseils en Loi de la reine, et Claude Bélanger, comptable, 590, Gadoury, tous trois de Jolictte, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les Entreprises G.H.D.ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Saintc-Émélic-de-l'Éncrgie, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 483-69 Fabre Building Inc.Immeuble Fabre inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de février 1969, constituant en corporation: Max Zcntncr, 45, Belsize, Morris Rickcl, 210, Finchley, tous deux de Hampstead, et Irving Wiscbcrg, 5663, Edgc-morc, Côte Saint-Luc, tous trois administrateurs, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles, de construction et de placements, sous le nom de « Fabre Building Inc.\u2014 Immeuble Fabre inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est 5663, Edge-morc, Côte Saint-Luc, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 991-69 Fédération d'Éducation physique du Québec Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1 lc jour de mars 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Arthur Sheedy, directeur d'éducation physique, secretary, wife contractually separate as to property of Pierre Toupin, 6555 Lcmay, both of Montreal, and Muriel Yergeau, secretary, wife contractually separate as to property of Jean-Marie Payeur, 385 des Bouleaux, Pointc-aux-Trcmbles, for the following purposes: To carry on business as bookkeepers and expert appraisers, under the name of \"Les Entreprises Du-El inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 291-69 Les Entreprises G.H.D.ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Claude Dugas, 540 Stc-Thérèse, Jacques Dugas, 111 Tellier, both advocates and Queen's Counsel learned in the law, and Claude Bélanger, accountant, 590 Gadoury, all three of Jolictte, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les Entreprises G.H.D.ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Sainlc-ÉméHe-dc-l'Énergie, judicial district of Jolictte.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 483-09 Fabre Building Inc.Immeuble Fabre inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Max Zentncr, 45 Belsize, Morris Rickcl, 210 Finchley, both of Hampstead, and Irving Wiscbcrg, 5663 Edgemore, Côte Saint-Luc, all three executives, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Fabre Building Inc.\u2014 Immeuble Fabre inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of a pur value of $1 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 5663 Edgemore, Côte Saint-Luc, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-o 991-09 Fédération d'Éducation physique du Québec Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dute the 11th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Arthur Sheedy, director of ;>h>- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 5035, Woodbury, Montreal, Jean-Marc Dion, nimlyste-conseil en éducation physique, 1101, Dijon, Sainte-Foy, Yves Gascon, directeur d'éducation physique, 31, rue Carillon, Saint-Jean, Yvon-L.Théroux, professeur d'éducation physique, 189, avenue Sunford, Saint-Lambert, Louis (,'linmpoux, professeur d'éducation physique, 3100, Carré-Rochon, Saintc-Foy, Robert Attar, conseiller pédagogique, 2430, rue Maskinongé, Laval, et Claude Guérette, superviseur en éducation physique, 720, 74e rue est, Charlesbourg, pour les objets suivants: Etudier, promouvoir, protéger et développer de toutes manières les intérêts économiques, sociaux et professionnels des personnes qui s'occupent d'éducation physique et de récréation, sous le nom de « Fédération d'Éducation physique du Québec ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $500,000.Le siège social de la corporation est à Québec, district judiciaire de Québec, /.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S7S5-0 1107-69 La Ferme St-Urbain inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1909, constituant en corporation: Lucien Croft, cultivateur, Saint-Urbain, Claude Picard, 7821, d'Aubigny, Anjou, et Laurier Dugas, 9415, llasilc-Routhicr, Montréal, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Posséder et exploiter une ou des fermes, sous le nom de « La Ferme St-Urbain inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Saint-Urbain, comté de Charlevoix, district judiciaire de Saguenay.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPE bouchard.2S785-0 710-69 Ferme Thibaudeau ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1909, constituant en corporation: Jules Thibaudeau, Gustave Thibaudeau et Simon Thibaudeau, tous trois cultivateurs, de Thurso, pour les objets suivants: Exploiter une ferme dans toutes ses spécialités, sous le nom de « Ferme Thibaudeau ltée », avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est it Thurso, district judiciaire de Hull.Lv sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, ¦ Ls-Philippe Bouchard.28786-0 94-69 I.c Fer Ornemental de Sherbrooke inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'udministrateur du gouvernement de la province a accordé des 2303 sicol training, 5635 Woodbury, Montreal, Jean-Marc Dion, advisory analyst in physical training, 1101 Dijon, Sainte-Foy, Yves Gascon, director of physical training, 31 Carillon Street, Saint-Jean, Yvon-L.Théroux, teacher in physical training, 189 Sanford Avenue, Saint-Lambert, Louis Champoux, teacher in physical training, 3460 Carré-Rochon, Saintc-Foy, Robert Attar, pedagogical adviser, 2340 Maskinongé Street, Lava), and Claude Guérette, supervisor in physical training, 720, 74th Street East, Charlesbourg, for the following purposes: To study, promote, protect and develop in every way the economical, social and professional interests of the people who deal with physical training and recreational activities, under the name of \"Fédération d'Éducation physique du Québec\".The amount to which is limited the value of the immovables which may be acquired and owned by the corporation is of $500,000.The head office of the corporation is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 1107-69 La Ferme St-Urbain inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Lucien Croft, farmer, Saint-Urbnin, Claude Picard, 7821 d'Aubigny, Anjou, and Laurier Dugas, 9415 Basile-Routhier, Montreal, the latter two advocates, for the following purposes : To own and operate one or several farms, under the name \"La Ferme St-Urbain inc.\", with a total capital of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Saint-Urbain, county of Charlevoix, judicial district of Saguenay.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 710-69 Ferme Thibaudeau ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Jules Thibaudeau, Gustave Thibaudeau and Simon Thibaudeau, all three farmers of Thurso, for the following purposes: To operate a farm in all its specialties, under the name of \"Ferme Thibaudeau ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Thurso, judicial district of Hull.Ls-Piiiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 94-69 Le Fer Ornemental de Sherbrooke inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of March, 1969, have been issued by 2304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 lettres patentes, en date du lie jour de mars I960, constituant en corporation : Marc Dumas, notaire, 1108, Gravel, André Robert, étudiant, 470, Chftteauguay, et Lise Drouin, secrétaire, épouse contractuellement séparée de biens de Marc-André Paquette, 1281, Dorval, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire le commerce de métaux de toutes sortes, leurs produits et sous-produits, sous le nom de « Le Fer Ornemental de Sherbrooke inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 300 actions ordinaires de $10 chacune et en 470 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire tic Saint-François.Le mus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 1044-69 Flciiry automobile inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de février 1969, constituant en corporation: François Boisclair, 702, Hartland, Outremont, Jean-Louis I,amoureux, 10581, Grande-Allée, et Yvon Brizard, 6538, Louis-Hébert, ces deux derniers de Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce de véhicules, automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Fleury automobile inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 711-69 Les Fonds S.L.B.inc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26c jour de février 1969, constituant en corporation: Raymond Dicaire, 11895, Frigon, Philippe Bibeau, 6387, de Cari-gnan, tous deux industriels, et Jean Bertrand, estimateur, 6427, de Repentigny, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous lc nom de « Les Fonds S.L.B.inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 11220, Hamon, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 732-69 Germaine Fortin inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de février 1969, constituant en corporation: Germaine Fortin, marchande, épouse de René Fortin, 22, Main, Bedford, Pierre Lacaille, avocat, 1230, McGregor, the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Marc Dumas, notary 1108 Gravel, André Robert, student, 470 Chit' teauguay, and Lise Drouin, secretary, wife contractually separate as to property of Marc-André Paquette, 1281 Dorval, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To deal in metals of all kinds, their products and by-products, under the name of \"Le Fer Ornemental de Sherbrooke inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 300 common shares of $10 each and into 470 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 1044 -69 Fleury automobile inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: François Boisclair, 702 Hartland, Outremont, Jean-Louis Lamoureux, 10581 Grande-Allée, and Yvon Brizard, 6538 Louis-Hébert, the latter two of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as garage keepers and to deal in vehicles, automobiles, motors, machines and any accessories and parts thereof, under the name of \"Fleury automobile inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 711-00 Les Fonds S.L.B.inc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Raymond Dicairc, 11895 Frigon, Philippe Bibeau, 6387 de Carignan, both industrialists, and Jean Bertrand, estimator, 6127 de Repentigny, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment, and management company, under the name of \"Les Fonds S.L.B.inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 112211 Hamon, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 732-69 Germaine Fortin inc.Notice is given that under Part I of Iho Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Germaine Fortin, merchant, wife of René Fortin, 22 Main, Bedford, Pierre Lacaille, advocate, 1230 McGregor, and Jean-Guy Bcrnier, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 et Jean-Guy Bernier, teneur de livres, 145A, St-Plnlippe, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des magasins de lingerie, sous le nom de « Germaine Fortin inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 50 actions ordinaires de S100 chacune et en 50 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Bedford, district judiciaire de Bedford, /.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 479-69 \u2022 Frigard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour de février 1969, constituant en corporation: Martin Gross, 1105, Ilidgcwood Drive, Laval, Joel Pinsky, 69, chemin Downshire, Hampstead, et Harold Dizgun, 1000, avenue Pratt, Outremont, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exploiter un commerce d'entreposage et réfrigération, sous le nom de « Frigard Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions catégorie « A » d'une valeur au pair de SI chacune et 39,000 actions catégorie « B » d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 911-69 Frontenac Distributors Inc.Les Distributeurs Frontenac inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1969, constituant en corporation: Murray Lapin, avocat et conseil en Loi de la reine, 167, chemin Edgehill, Westmount, Norman May, 55, chemin Ilollham, Hampstead, Avrum Itubinger, 5885, Centennial, Côte Saint-Luc, et Ezra Bcinhaker, 332S, Troy, Montréal, ces trois derniers avocats, pour les objets suivants: -Manufacturer, distribuer toutes sortes de produits « Polyethylene », en faire le commerce, sous le nom de « Frontenac Distributors Inc.\u2014 Les Distributeurs Frontenac inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 2600, Wurlclc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 942-69 Lu Galerie du meuble Loisellc ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de février 1969, constituant en corporation: Arthur Loiselle, marchand, 555, Jennne-Mance, Claude Loiselle, décorateur, et Monique Landry, ménagère, 2305 bookkeeper, 145A, Saint-Philippe, the latter two of Montreal, for the following purposes: To operate underwear stores, under the name of \"Germaine Fortin inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 50 common shares of $100 each and 50 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Bedford, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 479-69 Frigard Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Martin Gross, 1105 Ridgewood Drive, Laval, Joel Pinsky, 69 Downshire Road, Hampstead, and Harold Dizgun, 1000 Pratt Avenue, Outremont, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of warehousing and cold storage, under the name of \"Frigard Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 class \"A\" shares of a par value of $1 each and 39,000 class \"B\" shares of a par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-o 911-69 Frontenac Distributors Inc.Les Distributeurs Frontenac inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Murray Lapin, advocate and Queen's Counsel, 167 Edgehill Road, Westmount, Norman May, 55 Holtham, Road Hampstead, Avrum Rubinger, 5885 Centennial, Côte Saint-Luc, and Ezra Beinhakcr, 3328 Troy, Montreal, the latter three advocates, for the following purposes: To manufacture, distribute and deal in all kinds of polyethylene products, under the name of \"Frontenac Distributors Inc.\u2014 Les Distributeurs Frontenac inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of the par value of SI each and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at 2600 Wurtele, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 942-69 La Galerie du meuble l.oisidle ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Arthur Loiselle, merchant, 555 Jeanne-Mance, Claude Loiselle, decorator, and Monique Landry, housewife, wife separate as to property GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 2306 épouse séparée de biens dudit Claude Loiselle, ces deux derniers de 215, Marie-Rose, tous trois de Salaberry-de-Valleyfield, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles et nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « La Galerie du meuble Loiselle ltée», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Salaberry-de-Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 888-69 Garage R.F.De Roose & fils inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation: Roger De Roose, ingénieur professionnel, Laidy Van Hecke, ménagère, épouse commune en biens dudit Roger De Roose, tous deux de 368, Beaudoin, et Jean Fontaine, notaire, 389, Bordcleau, tous trois de Jolictte, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, camions ou autres véhicules et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Garage R.F.De Roose & fils inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 202, rue Brassard, Joliette, district judiciaire de Joliette.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.28785-0 612-69 Gury Cape Agency Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour de février 1969, constituant en corporation: Edward I.Blanshay, procureur, 5999, Monkland, Jean Zacharts-chenko, 4237, 41e rue, tous deux de Montréal, et Karen Anne Cooke, 690, Graham, Dorval, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Diriger une entreprise générale d'agence théâtrale, de propriétaires, constructeurs, directeurs et gérants de théâtres, sous le nom de « Gary Cape Agency Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 5803, chemin de la Côte des Neiges, bureau 105, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 809-69 GIcn Mountain Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de février 1969, constituant en corporation: Robert J.Stocks, of the said Claude Loiselle, the latter two of 215 Marie-Rose, all three of Salaberry-de-Valleyfield, for the following purposes: To deal in furniture and novelties of all kinds, under the name of \"La Galerie du meuble Loiselle ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shores of $10 each.The head office of the company is at Salabcrry-de-Valleyfield, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 8SS-09 Garage R.F.De Roose & fds inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Roger De Roose, professional engineer, Laidy Van Hecke, housewife, wife common as to property of the said Roger De Roose, both of 368 Beaudoin, and Jean Fontaine, notary, 389 Bordeleau, all three of Joliette, for the following purposes: To carry on business as garage keepers and to deal in automobiles, trucks or other vehicles and any accessories and parts thereof, under the name of \"Garage R.F.De Rose & fils inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 2112 Brassard Street, Jolictte, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 612-0!) Gary Cape Agency Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters pntent, bearing date the 20th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Edward I.Blanshay, attorney, 5999 Monkland, Jean Zachartschcnko, 4237, list Street, both of Montreal, and Karen Anne Cooke, 690 Graham, Dorval, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on the general business of theatrical agents, theatre proprietors, builders, operators and managers, under the name of \"Gary Cape Agency Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 5803 Côte des Neiges Road, Suite 105, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Compatties and Cooperative-: 28785-0 809-69 Glen Mountain Inc.Notice is given that under Part I of I he Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert J.Stocks, Peter E.Graham, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 Peter E.Graham, Roger S.Ackman, tous trois avocats, John McDougall, avocat et conseil en Loi «le la reine, et Ivan Ralston, commis juridique, Unis les cinq du 600 ouest, boulevard Dorchester, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter toutes sortes de centres pour les .sports d'hiver et d'été, sous le nom de « Glen Mountain Inc.», avec un capital total de 850,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 4,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Knowlton, district judiciaire de Bedford.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.¦ 28785 695-69 Helen Gongcon's Belle Cuisine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 10e jour de février 1969, constituant en corporation: Joseph Schull, scripteur, Helen Gougeon, spécialiste en cuisine, épouse dudit Joseph Schull, tous deux de 544, Grande Côte, Rosemère, et Deirdre O'Connell, publicitaire, 1540, avenue Summerbill, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter la fabrication de produits alimentaires et épiceries, d'ustensiles, d'appareils, de fournitures et de décorations pour la cuisson, le service, la cuisine et la table, en fnirc le commerce, sous lc nom de « Helen Gougeon's Belle l'iii-iiic Inc.», avec un capital actions divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1200, rue llishop, Montréal, district judiciaire de Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28786 79-69 Grand Prix Moto-ncigc St-Jovitc Mont-Tremblant inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de février 1969, constituant en corporation : Pierre Théorêt, tïniidc-F.Archambault, tous «leux avocats, et Jacinthe Dupont, secrétaire, fille majeure, tous trois «le 180, Dorchester est, suite 320, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des pistes de moto-ncigc et autres sports d'hiver en général, sous lc nom «le « Grand l'rix Moto-ncige St-Jovite Mont-Tremblant inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 3,000 actions ordinaires de SI chacune et en 370 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.28785-0 828-69 G.S.M.Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de lu Loi «les compugnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de février 1969, constituant en corporation: Robert Vinebcrg, 2307 Roger S.Ackman, all three advocates, John McDougall, advocate and Queen's Counsel, and Ivan Ralston, law clerk, all five of 600 Dorchester Boulevard West, Montreal, for the following purposes: To operate winter and summer recreational resorts of all kinds, under the name of \"Glen Mountain Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each and 4,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Knowlton, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-o 695-69 Helen Gougcon's Belle Cuisine Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of February, 1969, have been issuc«l by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Joseph Schull, writer, Helen Gougcon, cooking expert, wife of the said Joseph Schull, both of 544 Grande Côte, Rosemère, and Deirdre O'Connell, publicist, 1540 Summerbill Avenue, Montreal, for the following purposes: To manufacture ami deal in food products and groceries and in cooking, serving, kitchen an«l dining utensils, equipment, furnishing and decorations, under the name of \"Helen Gougeon's Belle Cuisine Inc.\", with a capital stock divide«l into 10,000 common shares without par value and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1200 Bishop Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 79-69 Grand Prix Moto-ncigc St-JovitC Mont-Tremblant inc.\u2022 Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Théorêt, Clautlc-F.Archambault, both atlvocatcs, an«l Jacinthe Dupont, secretary, spinster of the full age of majority, all three of 180 Dorchester East, suite 320, Montreal, for the following purposes: To operate snowmobile trails and organize other winter sports generally, under the name of \"Grand Prix Moto-neige St-Jovite Mont-Treniblant inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 3,000 common shares of SI each and 370 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 828-69 G.S.M.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11 tli day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert Vineberg, 1559 Pine 2308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 1559 ouest, avenue des Pins, William Fraiberg, 335, Clarke, tous deux de Montréal, Mitchell Klein, 188, Wexford Crescent, Hampstead, tous trois avocats, Anne Scaroni, 3484, Aylmer, Montréal, Maureen Montgomery, 30, Place Côte Vertu, Saint-Laurent, et Ann Ibberson, 6, Prairie Drive, llcaconsficld, ces trois dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce de comptoirs, sous le nom de « G.S.M.Inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 100,000 actions ordinaires de $1 chaenc.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 662-69 Harrington Harbour Sports Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en dote du 26c jour de février 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Clarence Rowsell, aubergiste, Paul Bobbitt, commis, Mary Rowsell, ménagère, épouse de Clarence Milton Rowsell, Betty Rowsell, ménagère, épouse de Roy William Rowsell, Launic Cox, pêcheur, Myrtle Rowsell, ménagère, épouse de Douglas Albert Rowsell, Burleigh Jones, ménagère, épouse de James Jones, Lizzie Ransom, ménagère, épouse de William Ransom, and Lillian Cox, ménagère, épouse de William Teldon Cox, tous les neuf de Harrington Harbour, pour les objets suivants: Stimuler les sports de jeunesse et d'adultes, sous le nom de « Harrington Harbour Sports Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut acquérir et détenir est de $40,000.Le siège social de la corporation est sur la Côte Nord du Golfe Saint-Laurent, district judiciaire de Hauterive.I^e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 354-69 Gérard Hébert limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de février 1969, constituant en corporation: John J.Pepper, 3637, The Boulevard, Westmount, John R.Laffoley, 204, Kindersley, Mont-Royal, Jacques Caron, 11462, Tardivcl, et Pierre Fournier, 4522, Girouard, app.8, ces deux derniers de Montréal, tous les quatre avocats, pour les objets suivants: Exploiter des stations-service, sous le nom de « Gérard Hébert limitée », avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1155 ouest, boulevard Dorchester, Montréal, district judiciaire de Montréal.I^e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 721-69 Avenue West, William Fraiberg, 335 Clarke, both of Montreal, Mitchell Klein, 188 Wexford Crescent, Hampstead, all three advocates, Anne Scaroni, 3484 Aylmer, Montreal, Maureen Montgomery, 30 Place Côte Vertu, Saint-Laurent and Ann Ibberson, 6 Prairie Drive, Bcaconsfield, the latter three secretaries, spinsters, for the following purposes: To manufacture and deal in counters, under the name of \"G.S.M.Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 100,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 662-00 Harrington Harbour Sports Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 26th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a corporation without share capital: Clarence Rowsell, innkeeper, Paul Bobbitt, clerk, Mary Rowsell, housewife, wife of Clarence Milton Rowsell, Betty Rowsell, housewife, wife of Roy William Rowsell, Launic Cox, fisherman, Myrtle Rowsell, housewife, wife of Douglas Albert Rowsell, Burleigh Jones, housewife, wife of James Jones, Lizzie Ransom, housewife, wife of William Ransom, and Lillian Cox, housewife, wife of William Teldon Cox, all nine of Harrington Harbour, for the following purposes: To promote sports for youth and adults, under the nume of \"Harrington Harbour Sports Inc.\".The amount to which the value of the immovable property which may be owned or held by the corporation is to be limited, is $40,000.The head office of the corporation is al Cole Nord du Golfe Saint-Laurent, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 354-69 Gérard Hébert limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: John J.Pepper, 3637 The Boulevard, Westmount, John R.Laffoley, 204 Kindersley, Mount Royal, Jacques Caron, 11462 Tnrdi-vel, and Pierre Fournier, 4522 Girouard, Apt.8, the latter two of Montreal, all four advocates, for the following purposes: To operate service stations, under the name of \"Gérard Hébert limitée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at II*»'1 Dorchester Boulevard West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperative.28785-0 721-09 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 Hcnmar Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de février 1969, constituant en corporation: Henry Mansfeld, administrateur, Gustawa Mansfeld, ménagère, épouse dudit Henry Mansfeld, tous deux du 5734, Lockwood, Marceli Frymcl, administrateur, et Genia Frymel, ménagère, épouse dudit Marceli Frymcl, ces deux derniers du 5743, Lockwood, tons les quatre de Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Diriger une compagnie d'immeuble de cons- ' t ruction et de placement, sous le nom de « Hen-mar Construction Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et 39,000 actions privilégiées de $1 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 757-69 M.Humidité inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de mars 1969, constituant en corporation: Richard Barbeau, .lean Geoffrion et Gilles Duchesne, tous trois avocats, de 210, Ste-Cathcrine est, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage et en réfrigération, sous le nom de « M.Humidité inc.», avec un capital total de S-10,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est 4835, rue .Messier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 700-69 Ideal Dry Wall Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de février 1969, constituant en corporation: Pierre Mondor, 1665, île l'Église, Luc Mousseau, 7070, Jean-Bourdon, tous deux avocats, de Saint-Laurent, et Micheline Meunier, secrétaire, fille majeure, 5, Venise, Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de construction et de portefeuille, sous le nom de « Ideal Dry Wall Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Lc siège social de lu compagnie est 91, boulevard Gouin est, Montréal, district judiciaire de Montréal.An sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S785-0 795-69 2309 Hcnmar Construction Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Henry Mansfeld, executive, Gustawa Mansfeld, housewife, wife of the said Henry Mansfeld, both of 5734 Lockwood, Marceli Frymel, executive, and Gcnia Frymel, housewife, wife of the said Marceli Frymel, the latter two of 5743 Lockwood, all four of Côte Saint-Luc, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Henmar Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 39,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 757-69 M.Humidité inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Richard Barbeau, Jean Geoffrion and Gilles Duchesne, all three advocates of 210 Stc-Catherine East, Montreal, for the following purposes: To carry on business as plumbing, heating and refrigeration contractors, under the name of \"M.Humidité inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and into 1,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 4835 Messier Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 700-69 Ideal Dry Wall Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Mondor, 1665 de l'Église, Luc Mousseau, 7070 Jean-Bourdon, both advocates, of Saint-Laurent, and Micheline Meunier, secretary, spinster of the full age of majority, 5 Venise, Laval, for the following purposes: To carry on business as a construction and holding company, under the name of \"Ideal Dry Wall Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 200 common shares with a nominal value of $100 each and 200 preferred shares with a nominal value of $100 each.The head office of the company is at 91 Gouin East Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 795-69 2310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 Immeubles Léger inc.Léger Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de mars 1969, constituant en corporation: Femand-J.Léger, contrôleur, Mireille Voiznrd, courtier d'immeubles, épouse contractuellement séparée de biens dudit Fernand-.I.Léger, et Yves B.De Passille, agent d'immeubles, tous trois de Sainte-Adèle, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de placement, sous le nom de « Immeubles Léger inc.\u2014 Léger Realties Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 3,800 actions privilégiées d'une valeur nominale de S10 chacune.Lc siège social de la compagnie est 211, boulevard Stc-Adèle, Sainte-Adèle, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 602-69 Imprimerie Brassard ltée Brassard Printing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du ISc jour de février 1969, constituant en corporation: Gérard- Alfred Goulet, imprimeur, Lisette Cécyre, ménagère, épouse séparée de biens dudit Gérard-Alfred Goulet, et Jacques Goulet, vendeur, tous trois de 531, Miles, Greenfield Park, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, éditeurs, graveurs et relieurs, sous lc nom de \" Imprimerie Brassard ltée \u2014 Brassard Printing Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Greenfield Park, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-o 759-69 Les Industries de disques multicolores inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de décembre 1968, constituant en corporation: Lucien Richard, imprésario, 3875, Louis-Pinard, app.3, Trais-Rivières, Lucien Richard, pèrp, comptable, et Michel Richard, étudiant, ces deux derniers de case postale 207, Roxton Falls, pour les objets suivants: Établir et exploiter une maison d'édition de disques, une agence de spectacles, de réservation et de vente de billets, sous le nom de « Les Industries de disques multicolores inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de S100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Immeubles Léger inc.Léger Realties Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Government Administrator of the Province, incorporating: Fernand-J.Léger, comptroller, Mireille Voizard, real estate broker, wife contractually separate as to property of the saidFcrnuiid-J.Léger, and Yves B.De Passille, real estate agent, all three of Sainte-Adèle, for the following purposes : To carry on business us a real estate and investment company, under the name of \"Immeubles Léger inc.\u2014 Léger Realties Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of SI each and 3,800 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 211 Sic-Adèle Boulevard, Sainte-Adèle, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 602-01) Imprimerie Brassard ltée Brassard Printing Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérard-Alfred Goulet, printer, Lisette Cccyre, housewife, wife separate us to property of said Gérard-Alfred Goulet, and Jacques Goulet, salesman, all three of 531 Miles, Greenfield Park, for the following purposes: To carry on business as publishers, editors, engravers and bookbinders, under the name of \"Imprimerie Brassard liée \u2014 Brassard Printing Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Greenfield Park, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 .759-00 Les Industries de disques multicolores inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 30th day of December, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lucien Richard, imprésario, 3875 Louis-Pinard, apt.3, Trois-Rivièrcs, Lucien Richard Sr., accountant, and Michel Richard, student, the latter two of Post Office Box 207.Roxton Falls, for the following purposes: To establish and operate a record publishing house, an entertainment, reservation and ticket agency, under the name of \"Les Industries de disques multicolores inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 19G9, Vol.101, No.16 Le siège social de la compagnie est à Trois-Rivièrcs, district judiciaire de Trois-Rivières.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.'.'S785-0 5859-68 Input Trends Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de février 1969, constituant en corporation: Abraham Shuster, 5710, avenue Wolseley, Richard Gottlieb, 7519, chemin Bailey, Lawrence Glazer, 7920, chemin Kingsley, et Arthur Marcovitch, 5525, avenue Trent, tous les quatre avocats, de Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Diriger une entreprises de service des données cl de l'analyse et de service de l'analyse des marchés, sous le nom de « Input Trends Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Montréal, ¦ listrict judiciaire de Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.-'8785 519-69 jeunson avicole inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de février 1969, constituant en corporation: Michel Pothier, avocat, 2720, Page, Françoise Lévesquc, 260, St-François, tous deux de Saint-Hyacinthe, et Pauline Bilodcau, 40, Guy, Sainte-Rosalie, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Manufacturer et faire lc commerce de produits alimentaires, épiceries, viandes, volailles et vivres d'éleveurs de toutes sortes, sous le nom de ' Jeanson avicole inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 5350, Wilson, Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Ls-Piiii.ippe Bouchard.2S785-0 5852-6S Jobcrt construction inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de juin 1968, constituant en corporation: Léonard Laportc, entrepreneur en construction, 1975, O'Brien, Jcan-F.Cadoret, administrateur, 2125, Mékinac, tous deux de Laval, Jacqueline Bazinct, ménagère, épouse de feu Dr Lucien Fcrland, 271, Principale, Saintc-Émélie-de-l'Énergie, Jacques Laportc, 116, Beaudry sud, et Sylvain Laporte, \u2022vj8, Manscau, ces deux derniers médecins-chirurgiens, de Joliette, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction cl faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le 2311 The head office of the company is at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 5859-68 Input Trends Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Abraham Sinister, 5710 Wolseley Avenue, Richard Gottlieb, 7519 Bailey Road, Lawrence Glazcr, 7920 Kingsley Road, and Arthur Marcovitch, 5525 Trent Avenue, all four advocates, of Côte Saint-Luc, for the following purposes: To carry on the business of data and analysis services and market analysis services, under the name of \"Input Trends Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of the par value of $1 each and 3,500 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 519-69 Jeanson avicole inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Michel Pothier, advocate, 2720 Page, Françoise Lévesquc, 260 St-François, both of Saint-Hyacinthe, and Pauline Bilodcau, 40 Guy, Sainte-Rosalie, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To manufacture and deal in food products, groceries, meats, poultry and breeders' supplies of all kinds, under the name of \"Jeanson avicole inc.\", with a total capital of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 5350 Wilson, Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Ls-Philippe Bouchard.Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 5852-6S Jobcrt construction inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of June, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Léonard Laporte, construction contractor, 1975 O'Brien, Jean-F.Cadoret, executive, 2125 Mékinac, both of Laval, Jacqueline Buzinct, housewife, wife of the late Dr.Lucien Ferland, 271 Principale, Saintc-Émélic-de-l'Énergie, Jacques Laportc, 116 Beaudry South, and Sylvain Laportc, 59S Manseau, the latter two physicians and surgeons, of Joliette, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Jobcrt construe- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 2312 nom de « Jobert construction inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de la valeur nominale de SI chacune et en 3,950 actions privilégiées de lu valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 390, rue Ferlnnd, Sainte-Émélic-de-l'Ënergie, district judiciaire de Joliette.Le sous-secrélaire de la province, Raymond Douville.28785-0 2994-68 Antonio Label le liée Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de mars 1969, constituant en corporation: Antonio Labclle, entrepreneur, Gisèle Guay, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Antonio Labellc, tous deux de 345, St-Paul, et Claude Labclle, menuisier, 560, Côte St-Louis, tous trois de Blainville, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de construction et de portefeuill, sous le nom de « Antonio Labclle ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 345, rue St-Paul, Blainville, district judiciaire de Terre-bonne.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 791-69 Laboratoire Dcca liée Dcca Laboratory Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de février 1969, constituant en corporation: Claude Champagne, 12430, Lanthier, Montréal-Nord, Sylvio Latella, 2131, Graham, André Soucy, 211, rue Devon, et Jean-Paul Morncau, 324, Monmouth, ces trois derniers de Mont-Royal, tous quatre pharmaciens, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits chimiques et toutes espèces de produits et articles connexes, sous le nom de « Laboratoire Dcca ltée \u2014 Dcca Laboratory Ltd.», avec un capital total «le $100,000, divisé en 2,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 750 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est a Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 973-69 Lacollc électronique inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province u accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation: André Liivoie, homme d'affaires, Béatrice Turcot, ménagère, épouse séparée de biens dudit André Lavoie, tous scux de 4, rue de l'Eglise, Liicollc, et Vves-J.Deniers, uvocat, 55, rue de lu Station, Dclson, pour les objets suivants: tion inc.\", with a total capital stock of $40,00(1, divided into 500 common shares with a nominal value of $1 each and 3,950 preferred shares with a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 390 Ferland Street, Saintc-ÉméIic-dc-1'Ëiicrgic, judicial district of Jolictte.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.28785 2994-6S Antonio Labellc ltée Notice is given that under Purl 1 of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 3rd day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Antonio Labellc, contractor, Gisèle Guay, housewife, wife contractually separate as to property of the said Antonio Labellc, both of 345 Saint-Paul, and Claude Labellc, joiner, 560 Côte St-Louis, all three of Blainville, for the following purposes: To carry on business as a building and holding company, under the name of \"Antonio Labellc ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares with a nominal value of $100 each and 100 preferred shares with a nominal value of $100 each.The head office of the company is at 345 Saint-Paul Street, Blainville, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 701-011 Laboratoire Dcca ltée Dcca Laboratory Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Claude Champagne, 12430 Lanthier, Montreal-North, Sylvio Latclla, 2131 Graham, André Soucy, 211 Devon St., and Jean-Paul Morncau, 324 Monmouth, the three latter of Mount-Royal, all four pharmacists, for the following purposes: To carry on business dealing in chemical products, and all types of related products and articles, under the nnmc of \"Laboratoire Dcca ltée \u2014 Dcca Laboratory Ltd.\", with a total capital stock of SIOO.OOO, divided into 2,500 common shares of $10 each and 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 973-00 Lacollc électronique inc.Notice is given that under Part I of I he Companies Act, letters patent, bearing dale the 4th day of March, 1969, have been issued by the Government Administrator of the Province, incorporating: André Lavoie, businessman, Béatrice Turcot, housewife, wife separate as to property of the suid André Envoie, both of 4 de l'Église St., Lucolle, and Yves-J.Deniers, udvocatc, 55 de lu Station St., Dclson, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1909, Vol.101, No.10 Faire lc commerce, l'entretien et la réparation de toutes sortes d'appareils et accessoires électriques et électroniques, sous lc nom de « Lacollc électronique inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Lacollc, district judiciaire d'Iberville.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S785-0 549-69 Luc S t-Jean Oxygène inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation: Kelvin J.MacDou-gall, 423, Fontainebleau sud, Jacques-Cartier, Andrée-Anne Charbonncau, 611c majeure, 2121, St-Matbieu, Montréal, et Pierre Raymond, Warden, tous trois avocats, pour les objets suivants: Distribution d'acétylène, «l'oxygène, d'air comprimé et de tous autres gaz, sous le nom de « Lac St-Jcan Oxygène inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Aima, district judiciaire de Robcrval.I.c sous-ministre des institxdions financières, compagnies cl coopératives.Ls-Phiuppe Bouchard.2S785-0 5S6-69 The Lukc Aylmcr Farm Ltd.La Ferme du Lac Aylmcr ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de février 1969, constituant en corporation: William Edgar Bronstcttcr, Norbert Kevin Donovan, tous deux avocats, et Ina Pearen, secrétaire, célibataire, tous les trois de 1 Place Ville Marie, Montréal, pour les objets suivants: Diriger une entreprise générale de ferme et d'agriculture, sous lc nom de « The Lake Aylmcr Farm Ltd.\u2014La Ferme du Lnc Aylmer ltée», avec un capital total de $200,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 19,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Thetford Mines, district judiciaire de Mégantic.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 83-69 Lamonlagne auto électrique ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de février 1969, constituant en corporation: Jean Guy, 5400, de Ixuiisbourg, Marc Bourgeois, 4050, Jauron, tous deux de Montréal, Gilles Bertrand, 147, Dunrae, \u2022lean Lcfrançois, 41, Morrison, et Claudc-E.I.cduc, 105, Beverley, ces trois «lerniers de Mont -Royal, tous cinq avocats, pour les objets suivants: 2313 'I' odcal in, maintain and repair all kinds of electrical and electronic apparatus and appliances, under the name of \"Lacolle électronique inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Lacollc, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 549-69 Lac Si -,ban Oxygène inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Kelvin J.MncDougall, 423 Fontainebleau South, Jacques-Cartier, Andrée-Anne Charhonneau, spinster of the full age of majority, 2121 St-Mathieu, Montreal, and Pierre Raymond, Warden, all three advocates, for the following purposes: The distribution of acetylene, oxygen, compressed air and all other gases, under the name of \"Lac St-Jcan Oxygène inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Alma, judicial district of Roberval.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 586-69 The Lake Aylmer Farm Ltd.Lu Ferme du Lac Aylmer ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of February, 1969, have been issuc«l by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: William Edgar Bronstctter, Norbert Kevin Donovan, both advocates, and Ina Pearen, secretary, spinster, all three of 1 Place Ville Marie, Montreal, for the following purposes: To carry on the general business of farming and agriculture, under the name of \"The Lake Aylmcr Farm Ltd.\u2014 La Ferme du Lac Aylmer ltée\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each and 19,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Thetford Mines, judicial district of .Mégantic.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 83-69 Lumontagne auto électrique ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean Guy, 5400 de Louisbourg, Marc Bourgeois, 4050 Jauron, both of Montreal, Gilles Bertrand, 147 Dunrae, Jean Lcfrançois, 41 Mor-risson, ami Claudc-E.Leduc, 105 Beverley, the hitter three of Mount-Royal, all live advocates, for the following purposes: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n' 16 2314 Faire affaires comme garagistes et faire le commerce de véhicules de toutes sortes, sous le nom de «Lamontagnc auto électrique ltée», avec un capital total de $40,000, divisé en 15,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à La Tuquc, district judiciaire de Saint-Maurice.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPE bouchard.2S785-0 932-09 Oruer Landrcvillc & fils inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de mars 19,69, constituant en corporation: Orner Landrcvillc, 676, St-Louis, Luc Landreville, 684, St-Louis, et Marcel Paradis, 1537, Piette, tous trois directeurs de funérailles, de Joliette, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs de pompes funèbres, sous lc nom de « Omer Landreville & fils inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est 674, rue St-Louis, Jolictte, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiltppe Bouchard.28785-0 471-69 Lane Sportswear lue.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de février 1969, constituant en corporation: Simon Richtcr, 7920, Kingslcy, app.2, Stephen M.Byer, 7925, Kingsley, app.703, tous deux avocats, de Côte Saint-Luc, et Aurèle Boni, secrétaire juridique, célibataire, 982, Harvard, Montréal, pour les objets suivants: La confection et lc commerce de vêtements et accessoires vestimentaires de toutes sortes, sous lc nom de « Lane Sportswear Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est 926, Emerson Drive, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.28785 756-69 F.X.Lange inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour de décembre 196S, constituant en corporation: André Valiquette, 3340, Beauséjour, Guy-F.Gcrvais, 1195, Quen-ncvillc, J.-V.-Bcrnard Boudrias, 1307, Brochu, tous trois avocats, de Saint-Laurent, et Thérèse Beaulieu, secrétaire épouse séparée «le biens de Jean Ouellctlc, 9073, Logan, Pierrefonds, poulies objets suivants: To carry on business as garage-keepers, and to deal in all kinds of vehicles, under the name of \"Lamontagnc auto électrique ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 15,01)1) common shares of a nominal value of $1 each and 250 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at La Tuquc, judicial district of Saint-Maurice.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 932-0!) Omcr Landrcvillc & Ills inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Government Administrator of the Province, incorporating: Orner Landreville, 676 Sl-I .miis, Luc Landreville, 684 St-Louis, and Marcel Paradis, 1537 Piettc, all three funeral directors, of Jolictte, for the following purposes: To carry on business as undertakers, under i he name of \"Omcr Landrcvillc & fils inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 671 Sl-Iamis St., Joliette, judicial district of Jolictte.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 471-0!) I.unc Sportswear Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 18tli day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Simon Richtcr, 7920 Kingsley.Apt.2, Stephen M.Byer, 7925 Kingslcy, Apt 703, both advocates, of Côte Saint-Luc, and Aurèle Boni, legal secretary, spinster, 982 Harvard, Montreal, for the following purposes: To manufacture and «leal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Lane Sportswear Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of the par value of $1 each and 300 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company is at 020 Emerson Drive, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 756-69 F.X.Lange inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André Valiquette, 3340 Beauséjour.Guy-F.Gcrvais, 1195 Quenncvillc, J.-V.-Bcniard Boudrias, 1307 Brochu, all three advocates, of Saint-Laurent, and Thérèse Beaulieu, secretary, wife separate as to properly of Jean Ouellelle.9073 Logan, Pierrefonds, for the following pin poses: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 l'aire le commerce de marchandises, articles cl effets de toutes sortes, sous le nom de « F.X.1,ange inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 30,000 actions ordinaires de $1 chacune cl en 10,000 actions privilégiées de $1 chacune.I.c siège social de la compagnie est 565, Préfon-lainc, Montréal, district judiciaire de Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.2S785-0 42-69 Lasha Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour de février 1969, constituant en corporation: .loim G.Gibson, administrateur d'immeubles, 100 sud, avenue Brock, Montréal-ouest, Gordon L.McGilton, avocat et solliciteur, 636, avenue Belmont, Westmount, et Miriam Bernstein, secrétaire, épouse de David Barasb, 1755, avenue North, Outremont, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de « Lasha Investments Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune, 3,800 actions privilégiées catégorie « A » d'une valeur au pair de $10 chacune et 100 actions privilégiées catégorie « B » d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippe Bouchard.2S7S5 95-69 Ligne de Hockey Intermédiaire « C » Rurale inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation sans capital-actions: .lean-Paul Goudrcau, commis, Aurèle Plante, manoeuvre, Louis-Pierre Plante, assistant maître île poste, tous trois de Saint-Alexis, Scrge-D.Therriault, hôtelier, Marccl-D.Lemyre, journalier, tous deux de Maskinongé, Léon Guillemettc, journalier, Cliarettc, André Garant, professeur, .lean Matt eau, journalier, tous deux de Saint-Elie, Louis Gendron, et André Dcsaulnicrs, ces deux derniers journaliers, de Yamachichc, pour les objets suivants: Promouvoir par tous les moyens jugés utiles et opportuns le sport du hockey, sous le nom de * Ligue de Hockey Intermédiaire « C » Rurale inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $20,000.Le siège social de la corporation est à Saint-Alexis, district judiciaire de Saint-Maurice.le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Pihlippe Bouchard.2S785-0 693-69 Ligue de Hockey Intermédiaire « C » de Sept-1 les inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur 2315 To deal in merchandise, wares and goods of all kinds, under the name of \" I'.X.Lange inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and 10,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 565 Préfontaine, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 42-69 Lasha Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: John G.Gibson, estate administrator, 100 Brock Avenue South, Montreal West, Gordon L.McGilton, barrister and solicitor, 636 Belmont Avenue, Westmount, and Miriam Bernstein, secretary, wife of David Barash, 1755 North Avenue, Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Lasha Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $1 each, 3,800 class \"A\" preferred shares of the par value of $10 each and 100 class \"B\" preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 95-69 Ligue de Hockey Intermédiaire \"C\" Rurale inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jean-Paul Goudrcau, clerk, Aurèle Plante, labourer, Louis-Pierre Plante, assistant postmaster, all three of Saint-Alexis, Serge-D.Therriault, innkeeper, Marcel-D.Lcmyre, labourer, both of Maskinongé, Léon Guillemettc, labourer, Charette, André Garant, professor, Jean Mattcau, labourer, both of Saint-Élic, Louis Gendron, and André Desaulniers, the latter two labourers of Yamachichc, for the following purposes: To promote hockey by all means judged useful and opportune, under the name of \"Ligue de Hockey Intermédiaire \"C\" Rurale inc.\".The amount to which is limited the annual revenue of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is S20.000.The head office of the corporation is at Saint-Alexis, judicial district of Saint-Maurice.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 693-69 Ligue de Hockey Intermédiaire \"C\" de Scpt-Iles inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dntc the 231C GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 19G9, 101' année, n° 1G du gouvernement de In province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Antoine (Tony) Abud, restaurateur, 77, Smith, Léon llérubé, officier des relations extérieures, 138, Brochu, Réal Ouellet, superviseur, 8, Pam-palon, Yves Bellavance, magasinier, 4, Bourdages, et Conrad Parent, gérant, 26, Levcntoux, tous de Sept-Iles, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif et promouvoir en particulier le sport du hockey, sous le nom de « Ligue de Hockey Intermédiaire « C » de Scpt-IIes inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation est a Sept-Iles, district judiciaire de Hautcrive.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-o 500-69 L.S.R.construction ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation: Roger Houle, 697, Marie-Victorin, Boucherville, Serge Lemieux, 6600, Matte, Brassard, tous deux techniciens, et Luc Lemieux, surveillant, 3165, Édouard-Montpctit, Montréal, pour les objets suivants: Faire affuircs comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « L.S.R.construction ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est 6600, boulevard Matte, Brassard, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 221-69 Marché Barrina inc.Barrina Market Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de mars 1969, constituant en corporation: Jacques Baron, marchand, 290, 2c avenue, Pearl Cooper, ménagère, épouse contractucllcment séparée de biens de Jolin Harrison, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, 313, Mclrosc, et Fred Harrison, préparé à l'entretien, 390, 3c avenue, tous trois de Verdun, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises, articles et produits de toutes sortes ou descriptions de rapportant aux épiceries, sous lc nom de « Marché Barrina inc.\u2014 Barrina Market Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions catégorie « A » de $1 chacune, 10,000 actions catégorie « B » de $1 chacune, 10,000 actions privilégiées catégorie « A.» de $1 chacune et 10,000 actions privilégiées catégorie « B » de $1 chacune; 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Antoine (Tony) Abud, restaurant keeper, 77 Smith, Léon Bérubè, foreign relations officer, 138 Brochu, Real Ouellet, supervisor, 8 Pampa-lon, Yves Bellavance, store-keeper, 4 Bourdages.and Conrad Parent, manager, 26 Levcntoux, all of Sept-Iles, for the following purposes: To form and operate a sports club and to promote kockey in particular, under the name of \"Ligue de Hockey Intermédiaire \"C\" de Sept-Iles inc.\".The amount to which is limited the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $50,000.The head office of the corporation is at Sept-Iles, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 500-69 L.S.R.construction ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters paent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Rogre Houle, 697 Maric-Vic-torin, Boucherville, Serge Lemieux, 6600 Matte, Brossard, both technicians, and Luc Lemieux, supervisor, 3165 Édouard-Montpetit, Montreal, for the following purposes: To carry on business as constructors and general building constructors and to deal in all kinds of materials, under the name of \"L.S.R.construction ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 6600 Matte Boulevard, Brossard, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 221-09 Marché Barrina inc.Barrina Market Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Jacques Baron, merchant, 290, 2nd Avenue, Pearl Cooper, housewife, wife contractually separate as to property of John Harrison, and duly authorized by him for the purpose of these presents, 313 Melrose, and Fred Harrison, maintenance man, 390, 3rd Avenue, all three of Verdun, for the following purposes: To deal in goods, wares and merchandise of all kinds or descriptions connected with groceries, under the name of \"Marché Barrina inc.\u2014 Barrina Market Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 class \"A\" shares of $1 each, 10,000 class \"B\" shares of $1 each, 10,000 class \"A\" preferred shares of $1 each and 10,000 class \"B\" preferred shares of $1 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 19G9, Vol.101, No.16 Le siège social de la compagnie est 545, avenue île l'Eglise, Verdun, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislrc des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S785 993-69 Le Mazot inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-pou verneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour de janvier 1969, constituant en corporation: Henry Allemann, maître d'hôtel, Saga Maria Elizabeth Johansson, ménagère, épouse dudit Henry Allemann, tous deux de 11415, de Poutincourt, et Ernest Sonney, commerçant, 11855, Poincarré, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Le Mazot inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1668, rue St-Dcnis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 472-69 M, C.Ménard inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 11c jour de mars 1969, constituant en corporation: Pierre Gagnon, 6175, boulevard Métropolitain est, Saint-Léonard, Camille Fcrlond, 83A, rue Bernard, Joliette, tous deux assureurs-conseils, et René Leroux, notaire, 215, St-Jacques ouest, Montréal, |iour les objets suivants: Faire nffaires comme électriciens et faire le commerce et l'entretien de toutes sortes d'appareils et accessoires électriques, sous le nom de « M.C.Ménard inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de Sa chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 3806, rue Adam, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.2S785-0 6079-68 Metro Catering Service of Montreal Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de mars 1969, constituant en corporation: Sylvia Magid, ménagère, épouse séparée de biens de Louis Magid, 2485, Mantha, Saint-Laurent, Leonard \u2022I.Obcrfeld, comptable, 50S2, chemin du Souvenir, et Joey Rashcovsky, administrateur, 1000 rue Carmel, ces deux derniers de Laval, pour les objets suivants: Manufacturer des machines pour la vente de produits liquides, bonbons, confiserie, produits du tabac, produits alimentaires et laitiers et tous autres produits de toute sorte et genre, çh fnire le commerce, sous le nom de « Metro 2317 The head office of the company is at 545 Church Avenue, Verdun, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 993-69 Le Mazot inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Henry Allemann, head waiter, Saga Maria Elizabeth Johansson, housewife, wife of said Henry Allemann, both of 11415 de Poutrin-court, and Ernest Sonney, trader, 11855 Poincarré, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurant keepers, under the name of \"Le Mazot inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 166S St-Denis Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 472-69 M.C.Ménard inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of March, 1969, have been issued by the Government Administrator of the Province, incorporating: Pierre Gagnon, 6175 Metropolitan Blvd.East, Saint-Léonard, Camille Ferland, 83A Bernard St., Joliette, both insurance consultants, and René Leroux, notary, 215 St James St.West, Montreal, for the following purposes: To carry on business as electricians, and to deal in and maintain all kinds of electrical apparatus and appliances, under the name of \"M.C.Ménard inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $5 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 3806 Adam St., Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 6079-68 Metro Catering Service of Montreal Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Sylvia Magid, housewife, wife separate as to property of Louis Magid, 2485 Mantha, Saint-Laurent, Leonard J.Ober-fcld, accountant, 5082 Souvenir Road, and Joey Rashcovsky, executive, 1000 Carmel Street, the latter two of Laval, for the following purposes: To manufacture and deal in machines for the vending of liquid products, candy, confectionery, tobacco products, food and dairy products and all other products of any kind and nature, under the name of \"Metro Catering Service of Montreal GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 2318 Catering Service of Montreal Ltd.», avec un capital total de §40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions privilégies d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est il Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 990-69 Metro Woodcraft Ltd.Artisanat en hois Metro ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de février 1969, constituant en corporation: John Drouin, 5129, Blond in, Pierrefonds, Joseph Chambers, 11640, Lavigne, Montréal, et Henry Stuer, 65, West-park, Dollard-des-Ormeaux, tous trois administrateurs, pour les objets suivants: Conduire et exploiter un commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de « Metro Woodcraft Ltd.\u2014 Artisanat en bois Metro ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 5650, Petit Bois Franc, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 967-69 Modem Poultry Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour de février 1969, constituant en corporation: Bernard Reis, 213, chemin Finchley, Hampstead, Samuel Wex, 150, chemin Radcliffe, Montréal-ouest, et Bernard Lamarchc, 4870, chemin de la Heine Marie, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce de viandes et volailles de toutes sortes, sous lc nom de « Modem Poultry Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 39,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Lc siège social de la compagnie est 1, place Ville Marie, bureau 3635, Montréal, district privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 785-69 Montreal Home Renovation Associates Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de février 1969, constituant en corporation: Paul Handclman, avocat, 5532, Rosedale, Côte Saint-Luc, Lilian Radinovitch, avocate, épouse séparée de biens de Moc Rcinblatt, 4520, Rosedale, Montréal, et Dorecn Bertin, secrétaire, fille majeure en plein exercice de ses droits légaux, 712, 31c avenue, Lacbine, pour les objets suivants: Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of the par value of $10 each and 2,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 990-00 Metro Woodcraft Ltd.Artisanat en bois Metro ltcc Notice is given that under Part I of llie Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: John Drouin, 5129 Blondin, Pierrefonds, Joseph Chambers, 11640 Lavigne, Montreal, and Henry Stuer, 65 Wcstpnrk, Dollard-des-Ormeaux, all three executives, for the following purposes: To conduct und carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Metro Woodcraft Ltd.\u2014 Artisanat en hois Metro ltée\", with a total capital stock of $40,000 divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and 2,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 5650 Petit Bois Franc, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Pinlippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 967-09 Modern Poultry Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Bernard Reis, 213 Finchley Road.Hampstead, Samuel Wex, 150 Radcliffe Road, Montreal West, and Bernard Lamarchc, 4S70 Queen Mary Road, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To deal in meat and poultry of all kinds, under the name of \"Modern Poultry Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $1 each and 39,000 preferred shares of the par value of SI each.The head office of the company is at 1 Place Ville Marie, Suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-PniLiPPE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 785-69 Montreal Home Renovation Associates Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Saul Handclman, advocate, 553-Rosedale, Côte Saint-Luc, Lilian Rabinovitch.advocate, wife separate as to property of Moc Rcinblatt, 4520 Rosedale, Montreal, and Dorecn Bcrtin, secretary, fille majeure in the full exercice of her legal capacity, 712, 31st Avenue, Lachinc, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2319 Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de « Montreal Home Renovation Associates Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 8230, May-rund, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 863-69 Mont Sic-Adèle Lodge Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres [latentes, en date du 31e jour de janvier 1969, constituant en corporation: Fernand Beauregard, 0437, Pie IX, Montréal, Hendrik Kooiman, 396, (ilengarry, Mont-Royal, tous deux avocats, et Nicole Charron, secrétaire, épouse séparée de biens de Guy Charron, 5132, Rimbaud, Saint-Léonard, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, auberges, motels et restaurants, sous le nom de « Mont Ste-Adèle Lodge Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Sainte-Adèle, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 248-69 Les Moussaillons de Cité Jacques-Cartier Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Léo Richard, contremaître, 95, Poincarré, J.Ernest Guénette, magasinier, 262, Curé Poirier, et Jean-Louis Tardif, menuisier, 432, Dubuc, tous trois de Jacques-Cartier, pour les objets suivants: Exploiter un corps de majorettes, sous le nom de « Les Mousaillons de Cité Jacques-Cartier ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.Le siège social de la corporation est i\\ Jueques-( 'urtier, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 503-69 L'Oeuvre des Terrains de Jeux de St-Malachie inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Larochellc, chef de gare, Charles Mathieu, distributeur, Isidore Gourde, marchand général, Holland Dion, boucher, Laurier Bélanger, restaurateur, Yves Lacroix, professeur, Jacques Fau-elion, journalier, Franchie Royer, commis de bureau, fille majeure, et Noémic Aubé, rentière, veuve de Apollinaire Chabot, tous de Saint-Malachie, pour les objets suivants: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Montreal Home Renovation Associates Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 8230 Mayrand, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.28785-0 863-69 Mont Ste-Adèle Lodge Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Fernand Beauregard, 6437 Pie IX, Montreal, Hendrik Kooiman, 396 Glengarry, Mount Royal, both advocates, and Nicole Charron, secretary, wife separate as to property of Guy Charron, 5132 Rimbaud, Saint-Léonard, for the following purposes: To operate hotels, inns, motels and restaurants, under the name of \"Mont Ste-Adèle Lodge Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Sainte-Adèle, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Distitutions, Companies and Cooperatives.28785 248-69 Les Moussaillons de Cité Jacques-Cartier Notice is given that under Part IH of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Léo Richard, foreman, 95 Poincarré, J.-Er-nest Guénette, store-keeper, 262 Curé Piorier, and Jean-Louis Tardif, carpenter, 432 Dubuc, all three of Jacques-Cartier, for the following purposes: To operate a majorette corps, under the name of \"Les Moussaillons de Cité Jacques-Cartier\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire und possess, is $100,000.The head office of the corporation is at Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 503-69 L'Oeuvre des Terrains de Jeux de St-Malachic inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Marcel Larochellc, station chief, Charles Mathieu, distributor, Isidore Gourde, general trader, Rolland Dion, butcher, Laurier Bélanger, restaurant keeper, Yves Lacroix, professor, Jacques Fauchon, labourer, Francine Royer, office clerk, spinster of the full age of majority, and Noéniic Aubé, annuitant, widow of Apollinaire Chabot, all of Saint-Malnchic, for the following purposes: 2320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 L'organisation des loisirs, sous lc nom de « L'Oeuvre des Terrains de Jeux de St-Malachie inc.».Le montant auquel est limitée la valeur «les biens immobiliers que peut acquérir et iwssédcr la corporation, est de $100,000.Le siège social de la cm punition est ù Suint-Malacbic, «listrict judiciaire «le Beaucc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPE bouchard.28785-o 425-09 Optimist Club \u2014¦ L'Assomption Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 5c jour «le mars 1909, constituant en corporation sans capital-actions: \u2022lean-H.Labclle, 157, St-Joscph, Jean-Guy Lefebvre, 645, Faribault, tous deux comptables, et Pierre Duvul, notaire, 330, l'Ange-Gardien, tous trois de L'Assomption, pour les objets suivants: Développer l'optimisme comme philosophie de la vie, sous le nom «le « Optimist Club \u2014 L'Assomption ».Lc montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $20,000.Lc siège social de la corporation est ù L'Assomption, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Lh-Philippe Bouchard.28785-0 1547-08 P.A.& F.métal inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province u accordé des lettres patentes, en date du 24c jour de février 1909, constituant en corporation : Fcrnand Pellerin, homme d'affaires, 435, rue Elizabeth, Laval, André Pellerin, machiniste, 2180, 4e avenue, Trois-Rivières, et Pierre Pellerin, étudiant, 98, rue du Sanctuaire, Cap-dc-la-Madeleini', pour les objets suivants: Faire le commerce «lc métaux de toutes sortes, leurs produits et sous-produits, sous lc nom de « P.A.& F.métal inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 350 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-o 865-69 Paré inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a arcordé des lettres patentes, en «hue du 25c jour «le février 1969, constituant en corporation: Robert Doylc, Jean-Marie Paré, tous deux menuisiers, et Louis-Philippe Paré, constructeur ù sa retraite, tous trois de Plcssisville, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Paré inc.», avec un capital total de The organization of a recreational centre under the name of \"L'Oeuvre des Terrains do St-Malachie inc.».The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $100,000.The head office of the corporation is at Suinl-Malachie, judicial district of Bcauce.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 425-09 Optimist Club \u2014 L'Assomption Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jcan-R.Labellc, 157 Saint-Joscpli.Jean-Guy Lefebvre, 645 Faribault, both accountants, and Pierre Duval, notary, 330, L'Ange-Gardien, all three of L'Assomption, for the following purposes: To develop optimism us u philosophy of life, under the name of \"Optimist Club \u2014 L'Assomption\".The amount to which is limited the value of the immovables which may be acquired anil owned by the corporation is of $20,000.The head office of the corporation is ut L'As, somption, judicial district of Jolictte.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 1547-00 P.A.& F.métal inc.Notice is given that under Purt I of the Companies Act, letters paient, bearing date the 24th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Fcrnand Pellerin, businessman, 435 Elizabeth St., Laval, André Pellerin, machinist.2180, 4th Ave, Trois-Rivières, and Pierre Pellerin, student, 98 du Sanctuaire St., Cnp-dc-la- Madeleine, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of metals, their proxlucts an«l by-products, under the name of \"P.A.& F.métal inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of a nominal value of $10 each and 35(1 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is ut Montreal, judiciul district of Montreal.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 86549 Pare inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert Doyle, Jean-Marie Pan'-, both joiners, and Louis-Philippe Paré, retired builder, all three of Plessisville, for the following purposes: To curry on business as.builders and general building contractors, and to deal in ull kinds >l building materials, under the name of \"Pare inc.\", with a totul cupital stock of $50.000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 $00,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $5 chacune et en 8,000 actions privilégiées de $5 chacune.I,e siège social de la compagnie est 1687, avenue du Collège, Plessisville, district judiciaire de Mégantic.h: sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S785-0 892-69 Marcel Peck inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de février 1969, constituant en corporation: Marcel Peck, commerçant, Suzanne Bombardier, ménagère, épouse commune en biens dudit Marcel Peck, tous deux de Roxton Falls, et Marc Lufontaine, comptable agréé, Sherbrooke, pour les objets suivants: Exploiter des moulins à farine, sous le nom de < Marcel Peck inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Roxton Fulls, district judiciaire de Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 5902-68 Placements Boraje inc.Boraje Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1969, constituant en corporation: Serge Desrochers, 4635, Clanranald, Jean Legault, 6999, Terrasse Sugamo, John K.Archambault, 5724, Déom, tous trois de Montréal, et Gilles St-Pierre, 2060, Ostiguy, Marieville, tous quutre avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous lc nom de « Placements Boraje inc.\u2014 Boraje Investments Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune.Lc siège social de la compagnie est 8265, Peterborough, Anjou, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 923-69 Les Placements J.J.Ducharme ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes ,en date du 4c jour de mars 1969, constituant en corporation: Gilles Hébert, 22, de Barcelone, Candiac, Jean-Pierre Hurlet, 1315, boulevard Jules Poitros, Saint-Laurent, et Raymond Page, 31, Sunset, Outremont, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille (holding), sous le nom de « Les Placements J.J.Ducharme ltée», avec un capital total de $500,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 2321 divided into 2,000 common shares of $5 each and 8,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company is at 1687 du Collège Ave., Plessisville, judicial district of Mégantic.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 892-69 Marcel Peck inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marcel Peck, trader, Suzanne Bombardier, housewife, wife common as to property of the said Marcel Peck, both of Roxton Falls, and Marc Lâfontaine, chartered accountant, Sherbrooke, for the following purposes: To manage flour mills, under the name of \"Marcel Peck inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares with a nominal value of $10 each and 2,000 preferred shares with a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Roxton Falls, judicial district of Bedford.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 5902-68 Placements Boraje inc.Boraje Investments Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Serge Desrochers, 4635 Clanranald, Jean Legault, 6999 Terrasse Sagamo, Jolin K.Archambuult, 5724 Déom, all three of Montreal, and Gilles St-Pierre, 2060 Ostiguy, Marieville, all four advocates, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Placements Boraje inc.\u2014 Boraje Investments Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 8265 Peterborough, Anjou, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 923-69 Les Placements J.J.Ducharme ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Government Administrator of the Province, incorporating: Gilles Hébert, 22 de Barcelone, Candiac, Jean-Pierre Hurlet, 1315 Jules Poitras Blvd., Saint-Laurent, and Raymond Page, 31 Sunset, Outremont, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Les Placements J.J.Ducharme ltée\", with a total capital stock of $500,000, divided into 10,000 common shares of GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, «\u2022 16 2322 $10 chacune, 1000 actions privilégiées classe « A » de $100 chacune et en 3,000 actions privilégiées classe « B » de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 .561-09 Le Plein Jour inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation: Pierre Laurin, 1845, de l'Église, Frédéric Lallemand, 1150, Côte Vertu, et Roger Laperrière, 1080, St-Germain, tous trois hommes d'affaires, de Saint-Laurent, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Le Plein Jour inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées «le $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est 2210, Henri-Bourassa est, Montréal, district judiciaire de Montréal.7crs, and to deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, un«ler the name of \"Service de Radiateurs A.G.inc.\u2014 A.(i.Radiator Service Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of SI each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-PlI i li ppk bouchar i), Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 1026-00 Service des Ondes limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of March, 1969, have been issued by the Government Administrator of the Province, incorporating: Jacques Guillemettc.specialist in electronics, Nicole Bourbonnais, secretary, wife of the said Jacques Guillemettc, and duly authorized by him for these presents, both of 2258 McNamara, and Romuald Guillemettc, student, 2221 Place Rigault, all three of Laval, for the following purposes: To operate transmitting and receiving stations, antennae, for commercial radio communication, under the name of \"Service des Ondes limitée\", with a total capital stock of $40,000.divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 2258 McNamara Blvd., Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives.28785 68:09 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 19G9, Vol.101, No.10 Société de gestion Richelieu inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 5c jour de mars 1969, constituant en corporation: Félix Gcndron, arpenteur-géomètre 327, Bernard, Pierre La-niarche, chirurgien-dentiste, 330, Rodin, Ferdinand Noël de Tilly, médecin, 167, Orsali, tous trois de Belocil, et Gaétan Ménard, comptable agréé, 100, boulevard du Centre Civique, Mont-Saint-Hilaire, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous lc nom de « Société de gestion Richelieu inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 350 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Belocil, district judiciaire de Richelieu.Le noua-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe bouchard.2S785-0 699-69 La Société d'investissement industriel Betisa inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour de février 1969, constituant en corporation: Jacques Sirois, 3334, Lambert Closse, Guy Béliveau, 3326, Lambert Closse, Michel Samson, 3375, Bécancourt, Jules Couture, 659, Routhier, tous quatre de Sainte-Foy, et Rodrigue Tremblay, 124, Provcnchcr, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, tous arpenteurs-géomètres, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de « La Société d'investissement industriel Betisa inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.I.28785-0 900-69 La Société Prodcv inc.Prodcv Corporation Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de mars 1969, constituant en corporation: Joseph E.Cassar, avocat, 25, Wellington, suite 702, Wilfrid Olivier, homme d'affaires.313, Bryant, et Yvette D.Desjardins, secrétaire, épouse d'Hervé Desjardins, 101, rue Short, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: Gérer et exploiter aucune et toutes propriétés immobilières, sous le nom de « La Société l'mdev inc.\u2014 Prodcv Corporation Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.2329 Société de gestion Richelieu inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of March, 1969, have been issued by the Government Administrator of the Province, incorporating: Félix Gendron, land surveyor, 327 Bernard, Pierre Lamarchc, dental surgeon, 330 Rodin, Ferdinand Noël de Tilly, physician, 167 Orsali, all three of Belocil, and Gaétan Ménard, chartered accountant, 100 Centre Civique Blvd., Mont-SainUHilaire, for the following purposes: ' To carry on business as a real estate, construction, and investment company, under the name of \"Société de gestion Richelieu inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares df a nominal value of $10 each and 350 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Bcloeil, judicial district of Richelieu.Ls-PllILlPPE bouciiaiid, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 699-69 La Société d'investissement industriel Bel i-a inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, lettprs patent, bearing date the 21st day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Sirois, 3334 Lambert Closse, Guy Béliveau, 3326 Lambert Closse, Michel Samson 3375 Bécancourt, Jules Couture, 659 Routhier, all four of Sainte-Foy, and Rodrigue Tremblay, 124 Provcnchcr, Saint-Félix-du-Cap-Rougc, all land-surveyors, for the following purposes: To carry on business us an investment company, under the name of \"La Société d'investissement industriel Betisa inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head olHce of the company is at 2873 Sainte-Foy Road, Saintc-Foy, judicial district of Quél>ec.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 900-69 Lu Société Prodcv inc.Prodci Corporation Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Joseph E.Cassar, lawyer, 25 Wellington, suite 702, Wilfrid Olivier, businessman, 313 Bryant, nnd Yvette D.Desjardins, secretary, wife of Hervé Desjardins, 101 Short Street, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To manage and operate any and all kinds of real property, under the name of \"La Société Prodcv inc.\u2014 Prodev Corporation Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,500 common shares of the par value of $10 each and 150 preferred shares of the par value of $100 each. 2330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 19G9, 101' année, n° 1G Le siège social de la compagnie est 1976, rue Adam, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 293-69 Stadcon Limited Avis est ' donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de février 1969, constituant en corporation: Irving L.Adessky, 56, place Heath, Hampstead, Daniel Kingstone, 4985, Iona, Montréal, et Gilles Poulin, 1270, Quennevillc, Saint-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de « Stadcon Limited», avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchakd.28785 933-69 Steve Stccko Transport Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour de février 1969, constituant en corporation: Steve Stecko, excavateur, Sigrid Sontag, ménagère, épouse séparée de Hans Sontag, tous deux du 6380, Léger, Montréal, et Regent Bannon, vendeur, 4, rue Guy, Saint-Constant, pour les objets suivants: Diriger une compagnie de construction, sous lc nom de « Steve Stecko Transport Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est a Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des inslitiUions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 798-69 Jean E.Surprenant & associes ltée Jean E.Surprenant & Associates Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé dcs_ lettres patentes, en date du 23e jour de mai 1968, constituant en corporation: Jean E.Surprenant, courtier en assurances, 8644, de Gaspé, Colette Courey, secrétaire, fille majeure, 5592, des Grandes Prairies, et Georges LeBourdai.s, administrateur, 6319, Langelicr, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme courtiers et agents en assurances, sous le nom de « Jean E.Surprenant & associés ltée \u2014 Jean E.Surprenant & Associates Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 600 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune, 3,910 actions privilégiées classe « A » d'une vnlcur nominale de $10 chacune et en 300 actions privilégiées classe « B » d'une valeur nominale de $1 chacune.The head office of the company is at 1976 Adam Street, Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 293-011 Stadcon Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Irving L.Adessky, 56 Heath Place, Hampstead, Daniel Kingstone, 4985 Ion», Montreal, and Gilles Poulin, 1270 Quennevillc, Saint-Laurent, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as builders and contractors; under the name of \"Stadcon Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is ut Mont real, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 933-00 Steve Stccko Transport Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Steve Stecko, excavator, Sigrid Sontag, housewife, wife separate from Hans Sontag, both of 6380 Léger, Montreal, and Regent Bannon, salesman, 4 Guy Street, Saint-Constant, for the following purposes: To carry on the business of a construction company, under the name of \"Steve Stecko Transport Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.28785-0 798-69 Jean E.Surprenant & associés liée Jean E.Surprenant & Associates Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean E.Surprenant, insurance broker, 8644 de Gaspé, Colette Courcy, secretary, spinster of the full age of majority, 5502 des Grandes Prairies, and Georges LeBourdais, executive, 6319 Langelicr, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, under the name of \"Jean E.Surprenant & associés ltée \u2014 Jean E.Surprenant & Associates Ltd.\", with a total capital stock ol $40,000, divided into 600 common shares with a nominal value of $1 each, 3,910 class \"A\" preferred shares with a nominal value of $10 each and 300 class \"B\" preferred shares with a nominal value of $1 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 Le siège social de la compagnie est 2950, rue Masson, chambre 306, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S785-0 2389-68 Swiss Jewellery G.W.Inc.Bijouterie Suisse G.W.inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de février 1969, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat et conseil en Loi de la reine, 574, Clarc-uiont, Westmount, Oscar Rcspitz, 4945, Glencairn, Montréal, et Sydney B.Sederoff, 80, Creswood, Montréal-Ouest, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Faire lc commerce de bijoux, souvenirs, nouveautés et montres de toutes sortes et de toute description, sous le nom de « Swiss Jewellery (i.W.Inc.\u2014 Bijouterie Suisse G.W.inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.la sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S785 735-69 Tapis Casimir inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 11c jour de février 1969, constituant en corporation : Suzanne Labclle, secrétaire, 611e majeure, 23, boulevard Kirouuc, Jean Gagnon, avocat, et Louise Gagnon, ménagère, épouse contractucllement séparée de biens dudit Jean Gagnon, ces deux derniers de 26, boulevard Kirouac, tous trois «le Warwick, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de draperies, tentures, prélarts, tapis, tuiles et autres accessoires domestiques et industriels du même genre, sous lc nom de « Tapis Casimir inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une vulcur nominale de $1 chacune et en 2,000 uctions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Acton Vale, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.2S785-0 654-69 Taverne Champlain inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation : Jan Grcniuk, 7898, Thelma, LaSallc, Ronald Woo, 5521, Hudisson, et Raymond Boucher, 5595, des Groseilliers, ces deux derniers de Montréal, tous trois hommes d'affaires, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Taverne Champlain inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune 2331 The head office of the company is at 2950 Masson Street, Room, 306 Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 2389-68 Swiss Jewellery G.W.Inc.Bijouterie Suisse G.W.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Max S.Kaufman, advocate and Queen's Counsel, 574 Clarcmont, Westmount, Oscar Rcspitz, 4945 Glencairn, Montreal, and Sydney B.Scderoff, 80 Crestwood, Montreal West, the latter two advocates, for the following purposes: To deal in jewellery, gift ware and watches of every kind and description, under the name of \"Swiss Jewellery G.W.Inc.\u2014 Bijouterie Suisse G.W.inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 735-69 Tapis Casimir inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Suzanne Labclle, secretary, spinster of the full age of majority, 23 Kirouac Boulevard, Jean Gagnon, advocate, and Louise Gagnon, housewife, wife contractually separate as to property of the said Jean Gagnon, the latter two of 26 Kirouac Boulevard, all three of Warwick, for the following purposes: To manufacture and to deal in draperies, drapes, linoleums, rugs, tiles and other similar household and industrial accessories, under the name of \"Topis Casimir inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares with a nominal value of $1 each and 2,000 preferred shares with a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Acton Vale, judicial district of Saint-Hyacinthe.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 654-69 Taverne Champlain inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Jan Greniuk, 7898 Thelma, LaSalle, Ronald Woo, 5521 Radisson, and Raymond Boucher, 5595 des Groseilliers, the two latter of Montreal, all three businessmen, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Taverne Champlain inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each. 2332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 19G9, 101' année, »\u2022 16 Lc siège social de la compagnie est 7770, Sherbrooke est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.28785-0 004-69 Les Textiles Mondor inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour de février 1969, constituant en corporation: Henri Deslauriers, industriel, 38, rue Bessette, Iberville, J.-Émile Robinson, comptable, 440, rue St-Hubert, Saint-Jean, et Jean-Marc Poulin, avocat, 11765, Alexandre-Lacoste, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de vêtements de toutes sortes, sous le nom de « Les Textiles Mondor inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 39,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Iberville, district judiciaire d'Iberville.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 62-69 Tuatara Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour «le février 1969, constituant en corporation: John G.Gibson, administrateur de successions, 100 sud, avenue Brock, Montréal-Ouest, Gordon L.McGilton, procureur et solliciteur, 636, avenue Belmont, Westmount, et Miriam Bernstein, secrétaire, épouse de David Barash, 1755, avenue North, Outremont, pour les objets suivants: Diriger une compagnie de portefeuille (holding), sous lc nom de » Tuatara Holdings Inc.», avec un capital total de $250,000, divisé en 75,000 uctions ordinaires d'une valeur au pair «le $1 chacune, 500 actions privilégiées, classe «A», d'une valeur au pair de $100 chacune et 1,250 actions privilégiées, classe « B », d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 356-69 Unité de n'adaptai ion (Domrémy) Accueil Rouyn-Noranda inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a a«x;ordé des lettres patentes, en date du 20e jour «le mars 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Marie Sinclair, mécanicien, 882, chemin St-Luc, René Quevillon, plombier, 295, chemin St-Luc, Philippe Trudel, contremaître-mécanicien, 52, St-François, Roland Perron, commis de magasin, 175, chemin St-Luc, tous quatre de Noranda, Albert Rochette, menuisier, 305, Pinder ouest, Lucien Rancourt, mineur, 892, Larivière, Georges I^aroucbc, électricien, 66, Perreault est, tous trois de Rouyn, et Gilles Poisson, vendeur, Noranda-Nord, pour les objets suivants: The head office of the company is at 7770 Sherbrooke St.East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, 28785 604-69 les Textiles Mondor inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Henri Deslauriers, industrialist, 38 Bessette St., Iberville, .1.-Emile Robinson, accountant, 440 St-Hubert St., Saint-Jean, anil Jean-Marc Poulin, advocate, 11765 Alexandre-Lacoste, Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of clothing, under the name of \"Les Textiles Mondor inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and into 39,000 preferred shares of $1 each.The head office of the rompany is at Iberville, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 62-69 Tuatara Holdings Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th «lay of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: John G.Gibson, estate administrator, 100 Brock Avenue South, Montreal West, Gordon \" L.McGilton, barrister and solicitor, 636 Belmont Avenue, Westmount, and Miriam Bernstein, secretary, wife of David Barash, 1755 North Avenue, Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Tuatara Holdings Inc.\", with a total capital stock of $250,000.divided into 75,000 common shares of the par value of $1 each, 500 class \"A\" preferred shares of the par value of $100 each and 1,250 class \"B\" preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-1) 356-09 Unité de réadaptation (Domrémy) Accueil Rouyn-Noranda inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of March, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jean-Marie Sinclair, mechanic, 882 St-Luc Road, René Quevillon, plumber, 295 St-Luc Road.Philippe Trudel, foreman-mechanic, 52 St-François, Roland Perron, store-clerk, 175 St-Luc Road, all four of Noranda, Albert Rochelle, joiner, 305 Pinder west, Lucien Rancourt, miner, 892 Larivière, Georges Larouche, electrician, 66 Perreault East, all three of Rouyn, and Gilles Poisson, salesman, Noranda-North, for I he following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, A'o.16 2333 Lu rehabilitation et l'entr'aide uux alcooliques sous toutes ses formes, sous le nom de « Unité de réadaptation (Domrémy) Accueil Rouyn-No-runda inc.».Lc montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $25,000.Le siège social de la corporation est à Noranda, district judiciaire de Rouyn-Noranda.I.c sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, l.s-l'ini.ii'i'i: liorniAHi).2S785-o 285-69 Vador inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de février 1969, constituant en corporation : Liliane Gervuis, 263, 13e rue, Ginette (îingras, 434, d'Aiguillon, toutes deux secrétaires, filles majeures, de Québec, et Louis Dorion, avocat, 1651, Place de Bruyère, Saintc-Foy, pour les objets suivants: Paire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous lc nom de « Vador inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordianires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Thetfrod .Mines, district judiciaire de Mégantic.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopératives, Ls-Philippk Bouchard.2S785-0 833-69 \\ a n pro Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'udministrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation: Habib Stephen, homme d'affaires, 716, Mitchell Avenue, Mont-Royal, Pierre Lalande, avocat, 315, Dubord, Saint-Eustachc, et Denise Dagcnais, secrétaire, veuve non remariée de Georges Dagenais, 1681, Sauvé est, Montréal, pour les objets suivants: l'aire le commerce de tous produits, articles et marchandises, sous le nom de « Vanpro Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 uctions privilégiées de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est 1, Place Laval, suite 305, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies el coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785-0 552-69 VE 2 RM Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de mars 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Larry Dobby, ingénieur, 310, Inglcwood, Pointc-f'Iaire, David R.McFall, 4351, avenue Kensington, Montréal, et Guy Dumas, 397A, Montcalm, Salaberry-de-Valleyfield, ces deux derniers techniciens, pour les objets suivants: Favoriser la communication moderne radio-phouique entre les postes amateurs, sous le nom det VE 2 RM Inc.».Rehabilitation and mutual aid to habitual drinkers under all forms, under the name of \"Unité de réadaptation (Domrémy) Accueil Rouyn-Noranda inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $25,000.The head office of the corporation is at Noranda, judicial district of Rouyn-Noranda.Ijs-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 285-69 Vador inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Liliane Gcrvais, 263, 13th Street; Ginette (îingras, 434 d'Aiguillon, both secretaries, spinsters of the full age of majority, of Québec, and Louis Dorion, advocate, 1651 Place de Bruyère, Sainte-Foy, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Vador inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Thetford Mines, judicial district of Mégantic.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 833-69 Vanpro Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Habib Stephan, businessman, 716 Mitchell Avenue, Mount Royal, Pierre Lalande, advocate, 351 Dubord, Saint-Eustache, and Denise Dagenais, secretary, unremarried widow of Georges Dagenais, 1681 Sauvé East, Montreal, for the following purposes: To deal in all products, articles and merchandise, under the name of \"Vanpro Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 1 Place Laval, Suite 305, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785 552-69 VE 2 RM Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Administrator of the Government of the Province to incorporate a corporation without share capital: Larry Dobby, engineer, 310 Inglcwood, Pointe-Claire, David R.McFall, 4351 Kensington Avenue, Montreal, and Guy Dumas, 397A Montcalm, Salaberry-de-Valleyfield, the latter two technicians, for the following purposes: To promote modern radio communication between amateur stations, under the name of \"VE 2 RM Inc.\". 2334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, »\u2022 16 Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut acquérir ou détenir est de $75,000.Lc siège social de la corporation est à Rigaud, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 306-69 Westridge Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de février 1969, constituant en corporation: Herbert Geicr, constructeur, Margot Walz, secrétaire, épouse dudit Herbert Geier, tous deux du 5042, Terrasse Coursol, Pierrefonds, et Fernando Alvercz, peintre, 29A, Goycr, Montréal, pour les objets suivants: Diriger une compagnie d'immeuble, de construction et de portefeuille (holding), sous le nom de « Westridge Construction Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Lc siège social de lu compagnie est 5042, Terrasse Coursol, Pierrefonds, district judiciaire de Montréal.Ia: sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 381-69 The amount to which the value of the immovable property which the corporation may hold or possess is to be limited, is $75,000.The head office of the corporation is at Rigaud, judicial district of Beauharnois.Ls-Piiilippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 300-09 Westridge Construction Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of February, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Herbert Geier, builder, Margot Walz, secretary, wife of the said Herbert Geier, both of 5042 Coursol Terrace, Pierrefonds, und Fernando Alvcrcz, painter, 29A Goyer, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and holding company, under the name of \"Westridge Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of the par value of $10 each and 2,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at 5042 Coursol Terrace, Pierrefonds, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 381-09 Ministère des Terres et Forêts Department of Lands and Forests Cadastre Cadastre Paroisse de Charlesbourg Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, municipalité de la ville d'Orsuinville, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 409-6, 409-22, 409-23 et 409-24 sont annulés en vertu «le l'article 2174A du Code civil.Quél>ec, le 25 mars 1969.Le sous-ministre, 28818-0 Fernand Boutin.Canton de Letellicr Cadastre officiel du canton «le Lctcllier, municipalité de la cité de Sept-Iles, division d'enregistrement de Sept-Iles.Avis est par la présente donné que dans le rang II, village des Sept-Iles, les lots 16A-96 à 16A-131, 1 in-Ill et une partie des lots 16A-92 à 16A-95, 16B-4, 16A, 16B et 16i sont annulés et les lots 2660 à 2779 sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 20 mars 1969./. 5° Les paragraphes « a » et * b » de l'article IV sont remplacés par les suivants: « IV.Taux de salaires minimaux: Les taux de-salaires minimaux sont les suivants: or outside a metal-fabricating plant where it constitutes the main or secondary industry thereof and provided such work be the object of a business transaction.Notwithstanding the foregoing provisions, this decree does not cover the production or conversion of boilers and tanks as well as elevator building or repairs, whenever such work is performed outside a metal-fabricating establishment.Moreover, this decree docs not cover: employees working on high-output machines producing metal parts; those who contribute to the usscmbly, tracing and setting of such parts; those who fabricate mechanical parts in an establishment whose annual output exceeds ten thousand (10,000) similar units.However, the provisions hereof do not cover the fabrication of thanks and boilers.Autobus manufacturers arc not governed by this decree.3.Paragraph \"iv\", subsection \"(c)-2.\", section II, is replaced by the following: \"iv.Employees working in an establishment where metal-work is not the main concern ami where a private collective agreement guarantees them better employment conditions and wages than those of this decree.\" 4.Section III is superseded by the following: \"III.Hours of icork: (a) Day shift: Standard hours of work shall not exceed 42 a week in zone I and 44 a week in zone II.Such hours of work shall be scheduled between 7:00 a.m.and 6:00 p.m., Monday through Friday in zone I; between 7:00 a.m.and 6:00 p.m., Monday through Friday and between 7:00 a.m.and noon on Saturdays in zone II.(6) Night shift: Hours of work are scheduled between the cud and beginning of the day shift's standard working hours.Standard hours of work shall not exceed 43 a week in zone I and 44 in zone II.A night's work shall not exceed ten (10) bonis.However, most of the hours shall be worked within the working night.(c) Extra shifts: When three shifts work in un establishment, hours of work shall be as follows: midnight to 8:00 a.m.; 8:00 a.m.to 4:00 p.m.: 4:00 p.m.to midnight Notwithstanding any other provision herein, such shifts shall be paid the following overtime rates: 1.time and a half for the first five (5) hours worked outside their standard hours of work: 2.double time for all time worked beyond Ihe aforementioned five (5) hours.\" 5.Subsections \"a\" and \"b\" of section IV arc replaced by the following: \"IV.Minimum wage rules: Minimum wage rules arc as follows: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2357 À compter du A compter du Effective Effective Wjuil.Wjuil.July 10 July 10 1969 1970 Zones Zones Zones Metiers\u2014Trades: I 11 I II I II Outillcur \u2014Toolmakcr.$3.09 $2.99 $3.33 $3.23 $3.58 $3.48 Traceur en mécanique \u2014 Mccliunical tracer.2.97 2.87 2.20 3.10 3.45 3.35 Soudeur (général) au chalumeau et à l'arc électrique \u2014 Welder, general (acetylene and electric arc).2.84 2.74 3.06 3.96 3.31 3.21 Machiniste général \u2014 Machinist, general.2.84 2.74 3.06 2.96 3.31 3.21 Soudeur au chalumeau ou à l'arc électrique \u2014 Welder, acetylene and electric arc.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Mécanicien (métal en feuille) \u2014 Mechanic, sheet-metal.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Machiniste sur tour, fraiseuse, etc.\u2014 Machinist (lathe, milling machine, and so on).2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Mécanicien de marine \u2014 Mechanic, marine.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Mécanicien ajusteur \u2014Fitter-Machinist.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Chaudronnier \u2014Boilermaker.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.13 Tuyauteur (Mécanicien en tuyauterie) \u2014 Pipe-mechanic.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Trempeur \u2014Tempérer.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Pantograveur \u2014 Pantographer.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Peintre \u2014 Painter.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Polisseur \u2014 Polisher.2.77 2.67 2.99 2.89 3.24 3.14 Menuisier d'atelibr mécanique \u2014Joiner, machine shop.2.71 2.61 2.93 2.83 3.18 3.08 Forgeron \u2014 Blacksmith.2.71 2.61 2.93 2.83 3.18 3.08 Découpeur \u2014Flamecutter.2.71 2.61 2.93 2.83 3.18 3.08 Vérificateur \u2014 Checker.2.34 2.24 2.55 2.45 2.79 2.69 Expéditeur \u2014Shipping clerk.2.34 2.24 2.55 2.45 2.79 2.69 Les chaudronniers, monteurs, mécaniciens de Boilermakers, erectors, steam engine mechanics machines à vapeur et soudeurs qui travaillent à and welders working outside a metalworking l'extérieur d'un établissement métallurgique à establishment on the repair of boilers and tanks la réparation de chaudières et de réservoirs shall be paid $3.03 an hour; $3.25 an hour doivent recevoir $3.03 l'heure, $3.25 l'heure à effective July 10,1969, and $3.50 an hour effective compter du 10 juillet 1969 et $3.50 l'heure à July 10,1970.Their helpers shall be paid $2.47 an compter du 10 juillet 1970.Leurs aides doivent hour; $2.68 an hour effective July 10, 1969, and recevoir $2.47 l'heure, $2.68 l'heure à compter $2.92 an hour effective July 10, 1970.du 10 juillet 1969 et $2.92 l'heure à compter du 10 juillet 1970.Métiers \u2014 Trades: A-l) Apprenti tous les métiers: Apprentices, all trades: lrc année\u20141st year.$1.72 $1.64 $1.S4 $1.76 81.98 $1.90 2c année \u2014 2nd year.1.80 1.72 1.92 1.84 2.07 1.99 3e année \u2014 3rd year.1.92 1.84 2.06 1.98 2.21 2.13 4e année \u2014 4th year.2.06 1.98 2.21 2.13 2.38 2.30 5e année, 1er semestre \u2014 5th year, 1st six months.2.20 2.12 2.36 2.28 2.54 2.46 5c année, 2c semestre \u2014 5th year, 2nd six months.2.36 2.28 2.53 2.45 2.75 2.67 6c année, 2e semestre \u2014 6th year, 2nd six months.2.55 2.47 2.74 2.66 2.95 2.87 B) Assembleur et conducteur de machines \u2014 Assembler and machine operator: 1 re année, 1er semestre \u2014 1st year, 1st six months.1.72 1.64 1.84 1.76 1.98 1.90 lrc année, 2e semestre\u20141st year, 2nd six months.1.80 1.72 1.92 1.84 2.07 1.99 2e année \u2014 2nd year.1.92 1.84 2.06 1.98 2.21 2.13 3c année \u2014 3rd year.2.06 1.98 2.21 2.13 2.38 2.30 4c année \u20144th year.2.19 2.11 2.35 2.27 2.54 2.46 5e année \u2014 5th year.2.3S 2.30 2.57 2.49 2.78 2.70 U-l) Aide\u2014Helper.2.34 2.27 2.55 2.48 2.79 2.72 Manoeuvre \u2014 Labourer.2.27 2.20 2.45 2.38 2.66 2.59 Magasinier en charge \u2014 Head storekeeper.2.57 2.50 2.77 2.70 2.99 2.92 Conducteur de camion \u2014 Truck driver.2.38 2.31 2.57 2.50 2.79 2.72 11-2) Magasinier\u2014 Storekeeper: lrc année \u2014 1st year.1.73 1.66 1.84 1.77 1.98 1.91 2c année \u2014 2nd year.1.80 1.73 1.92 1.85 2.07 2.00 3c année \u2014 3rd year.2.01 1.94 2.15 2.08 2.32 2.25 4c année \u2014 4th year.2.21 2.14 2.37 2.30 2.56 2.49 5e année \u2014 5th year.2.42 2.35 2.61 2.54 2.82 2.75- 6° 1,'alinéa 1° du paragraphe « c de l'article 6.Paragraph 1 of subsection \"c\", section IV, IV est remplacé par le suivant: is superseded by the following: 2358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101- année, n° 16 «1° Chef d'équipe: Les chefs d'équipe ont droit à $0.20 de plus l'heure que leur salaire normal.» 7° L'article V est remplace par lc suivant: « V.Heures supplémentaires: a) Tout travail exécuté dans l'un des cas suivants entraîne une majoration de salaire de cinquante pour cent (50%) : 1.Après huit heures et demie (8}4) dans la même journée, dans la zone I et après neuf (9) heures dans la même journée dans la zone II: 2.En plus du nombre d'heures de la semaine normale de travail déterminé au paragraphe « a» de l'article HI: 3.En dehors des heures normales spécifiées à l'article III: 4.Pour les équipes de nuit, les cinq (5) premières heures qui suivent la fin des heures normales de leur équipe; 5.Pour les équipes de jour, entre 7h 30 et 22 h, le samedi dans la zone I et entre midi et 22 h le samedi dans la zone II.6.Pour les équipes de nuit, entre 7h 30 et 22 h lc samedi.b) Tout travail exécuté dans l'un des cas suivants entraîne une majoration de salaire de cent pour cent (100%); 1.Pour les équipes de nuit, entre le début de la sixième heure (6ème) suivant la fin de leur équipe habituelle et le début de leur équipe habituelle suivante; 2.Pour les équipes de jour, tout travail exécuté entre 22 h et le début de la journée régulière suivante; 3.Pour les équipes de nuit, entre 22 h et minuit le samedi; 4.Lc dimanche et un jour de fête chômé et payé tel que le détermine l'article IV paragraphe c,4°.c) Nonobstant l'article III, l'horaire de travail des camionneurs pourra être fixé entre quatre (4) h a.m.et 17 h, à condition de ne pas excéder la durée de la journée normale de travail.Tout travail excédant cette durée est rémunéré au taux majoré de 50%.» 8° Les paragraphes «d», «c» et «/» de l'article VI sont remplacés par les suivants: « d) Le salarié qui, le 1er janvier de l'année courante, justifie d'un (1) an de service continu chez un même employeur, doit recevoir un congé dont la durée est de dix (10) jours ouvrables.L'indemnité afférente audit congé est égale à quatre (4%) pour cent de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence (indemnité de congé incluse).e) Période des congés: L'employeur doit informer le salarié de la période de congé au moins quarante-cinq (45) jours à l'avance./) Le salarié doit prendre la première période de cinq (5) jours ouvrables de congé entre le 1er mai et le 30 septembre qui suivent immédiatement l'année de référence.La deuxième période de cinq (5) jours ouvrables de congé doit être accordée entre le 1er mai qui suit l'année de référence et le 1er mars suivant.» 9e Le paragraphe « 6 » de l'article VU est remplacé par le suivant: « 6) Dès l'entrée en fonction d'un nouveau salarié susceptible d'être assujetti au présent décret, l'employeur doit en informer le comité paritaire par écrit dans les cinq (5) jours de la date d'embauchage.» 10° Le paragraphe « g ¦ suivant est ajouté à l'article VII: \"1.Group leader: Group leaders shall be paid 20é an hour over and above their regular wage rate.\" 7.Section V is replaced by the following: \"V.Overtime: (a) Time and a half shall be paid for all work Informed in the following instances: 1.after 8J^ hours in one day in zone I and after 9 hours in one day in zone n-, 2.over and above the standard working bonis in a week stipulated in subsection \"a\" of section in, 3.outside the standard hours set forth in section TO; 4.on might shifts: the first 5 hours that follow the shift's standard hours of work; 5.on day shifts: between 7:30 a.m.and 10:(li) p.m.on Saturdays in zone I and between noon and 10:00 p.m.on Saturdays in zone II; G.on night shifts: between 7:30 a.m.and 10:00 p.m.on Saturdays.(b) Double time shall be paid for all work performed in the following instances: 1.on night shifts: between the beginning of the 6th hour that follows the end of their regular shift and the beginning of their next regular shift; 2.on day shifts: between 10:00 p.m.and the beginning of their next regular shift; 3.on night shifts: between 10:00 p.m.and midnight on Saturdays; 4.Sundays and general holidays with pay, as set forth in subsection (c)-4.of section IV.(c) Notwithstanding the provisions of section III, truck drivers' hours of work may be scheduled between 4:00 a.m.and 5:00 p.m., provided that they do not exceed the standard daily hours of work.Time and a half shall be paid for all work that exceeds such limits.\" 8.Subsections \"d\", \"e\" and \"/\" of section VI arc superseded by the following: \"(d) Every employee who, on January 1st of the current year, has three years' continuous service with the same employer shall be granted a vacation equal to ten (10) working days.Vacation pay shall equal four per cent (4%) of total wages earned by the employee during the qualifying period (including vacation pay).(e) Vacation dales: The employer shall advise the employee of his vacation dates at least forty-five (45) days beforehand.(/) The employee shall take his first five loi days' vocation between the May 1st and September 30th that immediately follow the qualifying year.The second five (5) days' vacation the qualifying period and the following March 1st.\" 9.Subsection \"b\" of section VII is replaced by the following: \"(b) Whenever a new employee who is likely to be governed by this decree begins work, the employer shall advise the Parity Committee in writing, within five (5) days of the hiring date.\" 10.The following subsection \"g\" is added to section VII: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Avril 19, 1969, Vol.101, No.16 2359 « g) Tous les apprentis exerçant ou voulant exercer les métiers visés par le présent décret doivent s'inscrire au bureau du comité paritaire où une carte d'apprentissage leur est remise.Aucun employeur ne peut alors, dans le champ d'application territorial du présent décret, prendre ù son emploi un apprenti si celui-ci ne s'est pas préalablement inscrit au comité.11° L'article XI est remplacé par le suivant: « XI.Durée du décret: Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 10 juillet 1971.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite à moins que l'une des parties contractantes ne donne un avis écrit ù ce contraire, à l'autre partie et au ministre du Travail, entre le soixantième et le trentième jour avant l'expiration de toute année subséquente.» 12° La section II (Dispositions particulières relatives aux entreprises de fabrication de disjoncteurs, de transformateurs et de panneaux de distribution d'électricité) est biffé.Le greffier du Conseil exécutif, 28817-0 Jacques Fremont.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1049 Québec, 2 avril 19G9.Présent: Lc Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant lc transport du poisson pris dans certaines réserves.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 65 ce la Loi de la chasse (Statuts refondus 1964, chapitre 202), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements concernant la pèche dans les réserves; Attendu que pour un meilleur contrôle de la pèche, il y n lieu d'interdire que du poisson capturé dans certaines réserves soit transporté en dehors de ces réserves autrement qu'à l'état entier; Il est ordonné en conséquence, sur lu proposition du Ministre du tourisme, de la chasse et de la pèche: Que le règlement suivant s'applique dans le Parc de la Vérendrye ainsi que dans les réserves de Chibougamau et Mistassini: « Nul ne doit transporter en dehors de la réserve autrement qu'à l'état entier, du poisson pris ou capturé dans la réserve.Lc poisson peut cependant être vidé.» Que publication soit faite dans la Gazelle officielle du Québec.Copie conforme.Le greffier suppléant du Conseil exécutif, 2SS25-0 D.Tanouav.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1050 Québec, 2 avril 1969.Présent: Lc Lieutenant-gouverneur en conseil.CONCERNANT les Règlements sur le classement et la vente des produits de l'érable.Il est ordonné, sur la proposition du Ministre de l'agriculture et de la colonisation : QUE, conformément à l'article 3 de lu Loi des produits agricoles et des aliments (Statuts refon- \"(g) Every apprentice plying or wishing to ply one of the trades hereby covered shall register at the Parity Committee's offices so as to be issued with an apprenticeship curd.No employer within the territorial jurisdiction of this decree may hire an apprentice who has not complied with the foregoing provision.\" 11.Section XI is superseded by the following: \"XL Term of the decree: This decree remains in force until July 10, 1971.It automatically renews itself from year to year thereafter unless one of the contracting parties gives the other a written notice to the contrary between the sixtieth and thirtieth day prior to the expiry of any subsequent year.Such notice shall also be filed with the Minister of Labour and Manpower.12.Division II (Special provision respecting firms manufacturing circuit-brakers, transformers and electrical distribution panels) is abrogated.Jacques Prémont, 28817-0 Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1049 Québec, April 2, 1969.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the transportation of fish taken within certain reserves.Whereas pursuant to paragraph 6 of section 65 of the Game Act (Revised Statutes 1964, chapter 202), the Lieutenant-Governor in Council may make regulations concerning fishing in the reserves; Whereas for better fishing control, it is expedient to forbid the transportation, outside of these reserves, of fish captured in certain reserves, unless said fish arc still intact; Therefore, it is ordered, upon the recommendation of the Minister of Tourism, Fish and Game: That the following regulation apply to de la Vérendrye Purk as well as to the Chibougamau and Mistassini Reserves: \"No one may transport, outside of the reserve, fish taken or captured in the reserve, unless said fish are still intact.The fish however, may be cleaned\".That publication be made in the Québec Official Gazette.True copy.D.Tanguât, 28825 Assistant Clerk of lite Execulirc Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1050 Québec, April 2, 1969.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Regulations relative to the grading anil sale of maple products.It is ordained, upon the rcocmmciidatiou of the Minister of Agriculture and Colonisation: That, in conformity with section 3 of the Agricultural Products and Food Act (Revised 2360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 19G9, 101' année, n° 16 dus, 1964, chapitre 119) les Règlements concernant lc classement et la vente des produits de l'érable, édictés par l'arrêté en conseil No 652 du 18 mars 1943 publié à la Gazette officielle du Québec du 20 mars 1913 et modifiés par l'arrêté en conseil No 294 du 16 mars 1950 public à la Gazette officielle du Québec du 1er avril 1950 et par l'arrêté en conseil No 667 du 10 mars 1961 publié à la Gazette officielle du Québec du 25 mars 1961, soient de nouveau modifiés comme suit: En remplaçant l'article 19 par le suivant: * Article 19.\u2014 Par dérogation au présent règlement, le classificateur agissant en vertu de l'article 7 classe le sirop qui n'a- pas le minimum de 65° Brix mais répond aux autres normes d'une catégorie prévue a l'article 18: a) dans la catégorie inférieure qui suit immédiatement la susdite catégorie, lorsque ce minimum n'est pas inférieur à 62° Brix; _fc) dans la catégorie inférieure qui suit immédiatement la catégorie visée au paragraphe a) lorsque le minimum est inférieur à 62° Brix mais non inférieur à 60° Brix.» Copie conforme.Le greffier suppléant du Conseil exécutif, 28826-0 D.Tanguay.Statutes, 1964, chapter 119), the Regulations concerning the grading and sale of maple products, enacted by Order in Council No.652 of March 18, 1943 published in the Québec Official Gazette of March 20, 1943 and amended by Order in Council No.294 of March 16, 1950 published in the Québec Official Gazelle of April 1, 19.'u and by Order in Council No.667 of March 10, 1961 published in the Québec Official Gazelle of March 25, 1961, be again amended as follows: By replacing article 19 by the following: \"Article 19.Notwithstanding these regulations, the grader acting in conformity with article 7 grades the syrup which docs not have a minimum of 65° Brix but complies with the other standards of a grade provided for in article 18: (a) in the inferior grade immediately follow-ing that abovementioncd when this minimum is not below 62° Brix; (b) in the inferior grade immediately following that referred to in paragraph (a) when the minimum is below 62° Brix but not below til)0 Brix.\" True copy.D.Tanguay.28826-0 Acting Clerk of the Executive Council.Lettres patentes Letters Patent Centre Administratif de Sorcl inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Lui des compagnies, il a plu au lieutenant-gouverneur de la province de Québec, de corriger les lettres patentes, en date du 15 janvier 1969, de la compagnie « Centre Administratif de Sorel inc.», de façon à ce que la valeur des actions ordinaires soit de 810 au lieu de $100.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchahd.28S05-o 224-69 Centre Administratif de Sorcl inc.Notice is given that pursuunt to Part I of I In: Companies Act, the Lieutenant-Governor of the Province of Québec has been pleased to correct the letters patent, dated January 15, 196(1, of \"Centre Administratif de Sorel inc.\" so that the value of the common shares be S10 instead 8100.Ls-Philippe BoUCIIAIII).Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperative*.28805 224-till Chartes \u2014\tCharters \u2014 demandes d'abandon de\tApplication for Surrender of Atlas Trimmings Ltd.\tAtlas Trimmings Ltd.Avis est, par les présentes, donné que « Atlas Trimmings Ltd.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conforniénent aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, 17 février 1968.(Sceau) Phyllis M en dell.28792 Onetc a changé son siège social de Montréal, au numéro 3670, Sabrevois, Montréal-Nord.Le président, Paul Houle.28843-0 373-69 Head Offices Dicco inc.Notice is given that \"Dieco inc.\" has changed its head office from Montreal, to number 3670 Sabrevois, Montreal-North.Paul Houle.President.28843 373-0'.' QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2363 Développement Lac-des-Monts inc.Avis est donné que la compagnie < Développements Lac-des-Monts inc.» a changé son siège social du numéro 4855, rue Bourret, Montréal, au numéro 595, 77e avenue, Laval.Le secrétaire, Mme I'avi.Schaller.28842-0 2179-64 Globelmi inc.Avis est donné que la compagnie < Globelmi inc.» a changé son siège social de Montréal, au numéro 1530, boulevard Labclle, Laval.Le secrétaire, Andre Mionault.2S844-0 2796-68 Jeminosy Inc.Avis est donné que la compagnie « Jeminosy Inc.», constituée en corporation en vertu de la partie I de la Loi des compagnies, en date du 24 décembre 1963, et ayant son siège social dans la ville de Montréal, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au 6340, Boulevard Décarie, l'a transporté à 5889, boulevard Gouin, Montréal, P.Q.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné A Montréal, ce 4ièmc jour de février 1969.Le président, Jui.es Lefrançois.28845-0 5261-63 Landex Realties Inc.Avis est donné que la compagnie - Landex Realties Inc.», a changé son siège social de 1, Place Ville Marie, suite 3635, Montréal, au numéro 42, Crescent Mulberry, Dollard des Ormeaux.Le secrétaire, Harry Duhkovsky.28810-o 3038-68 Z.Rivard inc.Avis est donné que la compagnie < Z.Rivard inc.», constituée en corporation en .vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes datées du 1er septembre 1966, a transporté son siège social du .05, boulevard ('barest est, Québec au 1011, Bourlamaquc, Québec.Signé & Québec, ce 7 novembre 1968.Le secrétaire, Marguerite Mercier Coulombe.28834-0 3178-66 Andc Construction Ltd.Construction Ande ltée Avis est donné que la compagnie « Ande Construction Ltd.\u2014 Construction Andc ltée » constituée en corporation par lettres patentes en date du 1er février 1956, et ayant son siège social dans la Ville de Ste-Genevièvc a établi son bureau au numéro 15,757 ouest, Boulevard Gouin. compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné ù Stc-Gcncviève, ce 22 janvier 1969.Le président, Andre Tiieoret.2S836-0 10296-56 Développement Lac-des-Monts inc.Notice is given that \"Développements Lac-des-Monts inc.\" has changed its head office from number 4855 Bourret Street, Montreal, to number 595, 77th Avenue, Laval.M us Paul Sciialler, Secretary.28842 2179-64 Globelmi inc.Notice is given that \"Globelmi inc.\" has changed its head office from Montreal, to number 1530 Labellc Boulevard, Laval.André Mionault, Secretary.28844 2790-68 Jeminosy Inc.Notice is given that \"Jeminosy Inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act on December 24, 1963, and having its head office in the city of Montreal, where its office was situated at 6340 Decaric Boulevard up to today, has moved it to 5889 Gouin Boulevard, Montreal, P.Q.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given in Montreal, this 4th day of February 1969.Jules Lefrançois, President.28845 5261-63 Landex Realties Inc.Notice is given that \"Landex Realties Inc.\", has transferred its head office from 1 Place Ville Marie, Suite 3635, Montreal to 42 Mulberry Crescent, Dollard des Ormeaux.2S810-O Harry Dubrovsky, Secretary.3038-68 Z.Rivard inc.Notice is given that \"Z.Rivard inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent dated the 1st day of September 1966, has changed its head office from 705 Charcst Boulevard East, Québec, to 1011 Bour-lamaque, Québec.Signed at Québec, November 7, 1968.Marguerite Mercier Coulombe, Secretary.28834 3178-66 Andc Construction Ltd.Construction Ande ltée Notice is given that \"Ande Construction Ltd.\u2014 Construction Andc ltée\" incorporated by letters patent dated February 1st, 1956, and having its head office in the town of Stc-Gencviève, hns established its office nt number 15,757 Gouin Boulevard west.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Ste-Gencviève, January 22, 1969.André Théorêt, President.28S36 10296-56 2304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 19 avril 19G9, 101' année, n\" 16 Germain Carbonneau et Fils inc.Avis est donné que la compagnie « Germain Carbonneau et Fils inc.», constituée en corporation par lettres patentes émises en date du 20 décembre 1967, et ayant son siège social dans la ville de Sbawinigan-Sud a établi son bureau d'affaires au numéro 624, 5c avenue.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné a Sbawinigan-Sud, ce premier février 1969.Le président, Germain Carbonneau.28838-o 5035-67 Jean Carslcy Interiors Inc.Avis est, par les présentes, donné que « Jean Carsley Interiors Inc.», une corporation constituée par lettres patentes datées du 10 octobre 1968, et ayant son siège social en la cité de Duvernay, a établi son bureau à 715, rue Hoc-quart, en ladite cité.À compter de la date de ce présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant sa principale place d'affaires.Inscrit à Montréal, ce 30c jour d'octobre 1908.28839 Le président, Jean Carsley.4707-68 Chrysta Pizza Inc.Avis est donné que la compagnie « Chrysta Pizza Inc.», constituée en corporation en date du 16e jour de mai 1968, et ayant son siège social dans les cité et district de Montréal, a établi son bureau au numéro 5889, Boulevard Gouin, Montréal, P.Q.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 12e jour de février 1969.(Sceau) 28S40-O Jules Lefrançois.2305-68 The Lido Inc.Le Lido inc.Avis est, par les présentes, donné que « The Lido Inc.\u2014 Le Lido inc.», une corporation constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes datées du 26 septembre 1968, et ayant son siège social à Montréal, province de Québec, a établi son bureau à 2350 ouest, rue Notre-Dame.À compter de la date du présent avis, ledit .bureau sera considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 27e jour de septembre 1968.Le secrétaire, l'un.Bell.28847 4506-68 Ternis Pole Line Ltd.Les Lignes Ternis ltée Avis est donné que la compagnie « Ternis Pole Line Ltd.\u2014 Les Lignes Ternis ltée » a changé son siège social de Rivière-du-Loup, au numéro 470, nie Godin, Vanier.Ac secrétaire, L.J.Gaudreault.28833-0 15402-60 Germain Carbonneau et Fils inc.Notice is given that \"Germain Carbonneau et Fils inc.\", incorporated by letters patent issued on December 20, 1967, and having its head office in the town of Shawinigan-South, has established its business office at number 624, 5th Avenue.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being the head office of the company.Given at Shawinigan-South, this first February, 1969.Germain Carbonneau, President.28838 5035-67 Jean Carsley Interiors Inc.Notice is hereby given that \"Jean Carsley Interiors Inc.\", incorporated by letters patent dated October 10, 1968, and having its head office in the city of Duvcrnay, has established its office at 715 Hocquart Street, in the said city.From the date of these present, the said office is considered by the company as being its principal place of business.Entered into at Montreal, this 30th day of October 1968.Jean Carsley, President.28839-0 4707-6S Chrysta Pizza Inc.Notice is given that \"Chrysta Pizza Inc.\", incorporated on the 16th day of May, 1968, and having its head office in the city and district of Montreal, has established its office at number 5889 Gouin Boulevard, Montreal, P.Q.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company ns being the head office of the company.Given at Montreal, this 12th day of February, 1969.(Seal) Jules Lefrançois.28840 2305-0S The Lido Inc.Le Lido inc.Notice is hereby given that the company namely \"The Lido Inc.\u2014 Le Lido inc.\", constituted in corporation under Part I of the Companies Act, by letters patent dated September 26, 1968, and having its head office in Montreal, Province of Québec, has established its office at 2350 Notre-Dame Street West.Starting from date of present notice, the company will consider the said office as its head office.Given at Montreal, this 27th day of September 1968.Phil Bell, Secretary.28847-o 4506-6S Tcmis Pole Line Ltd.Les Lignes Ternis ltée Notice is given that \"Tcmis Pole Line Ltd.\u2014 Les Lignes Ternis ltée\" has changed its head office from Rivièrc-du-Loup, to number 470 Godin Street, Vanier.L.J.Gaudreault, Secretary.28833 15402-60 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2365 Les Appartements Lacordaire inc.Avis est donné que la compagnie « Les Appartements Lacordaire inc.- a changé son siège social du numéro 6260,43ième avenue, Montréal, au numéro 11501, boulevard.Lacordaire, Montréal-Nord.Le secrétaire, Jean-PXul Ciiarbonneau.2S837-0 1957-65 Designers Three Inc.Avis est donné que la compagnie « Designers Three Inc.», constituée en corporation en vertue de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes datées du 23 décembre, 1963, a transporté son siège social du 1253 avenue McGill College à Montréal au 1115, rue Sherbrooke ouest, Suite 1702, Montréal, Québec.Le secrétaire, Carole A.Krohn.2S841-0 5433-63 Kcrr Automobiles Ltd.Avis est, par les présentes, donné que « Kerr Automobiles Ltd.», une corporation dûment constituée par lettres patentes, en date du 14e jour de janvier 1969, et ayant son siège social à Do!lard des Ormeaux, district de Montréal, a établi son bureau à 339 ouest, Acres Crescent, Dollard des Ormeaux.À compter de cette date, ledit bureau est considéré comme étant le siège social de la compagnie.Signé à Dollard «les Ormeaux, ce 20e jour «le janvier 1969.Le président, Robert Kerr.28846 6201-68 Logging Development Corporation Avis est, par les présentes, donné que « Logging Development Corporation », une corporation constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, en ladite province, a établi son siège social à 680 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, Québec.À compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 26e jour de février 1963.(Sceau) 28848 Le président, E.E.Grainger.15056-62 Nadon Sport inc.Avis est donné que la compagnie « Nadon S|)ort inc.», constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies en date du 25 novembre 1968, et ayant son siège social dans la ville de St-Eustachc où elle avait son bureau situé jusqu'à aujourd'hui au 40 rue St-Louis, St-Eustache, l'a transporté à 62 rue St-Louis, St-Eustache.À compter de la date «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à St-Eustachc, ce 3e jour de février 1969.Le procureur de la requérante, Marc Latour, notaire.28849-0 4334-68 Les Appartements Lacordaire inc.Notice is given that \"Les Appartements Lacordaire inc.\" has transferred its head office from 6260, 43th Avenue, Montreal to 11501 Lacordaire Boulevard, Montreal North.Jean-Paul Ciiarbonneau, Secretary.28837-0 1957-65 Designers Three Inc.Notice is hereby given that the Company \"Designers Three Inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent dated December 23, 1963 has moved its head office from 1253 McGill College Avenue, Montreal to 1115 Sherbrooke St.West, Suite 1702, Montreal, Québec.28841 Carole A.Kroiin, Secretary.5433-63 Kcrr Automobiles Ltd.Notice is hereby given that \"Kerr Automobiles Ltd.\", corporation duly incorporated by letters patent, dated January 14th, 1969, and having its head office in Dollard «les Ormeaux, district of Montreal, has established its head office at 339 West Acres Crescent, in Dollard des Ormeaux.From to date, the said office is considered as being the head office of the company.Signed at Dollard des Ormeaux, this 20th of January, 1969.Robert Kerr, Prèeiient.28846-0 6201-68 Logging Development Corporation Notice is hereby given that \"Logging Development Corporation\", incorporated under Part I of the Companies Act on the 14th day of December, 1962, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its head office at 680 Sherbrooke Street West, Montreal, Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 26th day of February, 1963.(Seal) E.E.Grainger, President.28848-0 15056-62 Nadon Sport inc.Notice is given that \"Nadon Sport inc.\", a company incorporated under Part I of the Companies Act, dated the 25th day of November, 1968 and having its head office in the town of Saint-Eustache where its office was situated up to today at 40 Saint-Louis Street, Saint-Eustache, has moved it to 62 Saint-Louis Street, Saint-Eustache.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Given at Saint-Eustachc, this 3rd «lay of February, 1969.Marc Latoor, notary, Attorney for the Applicant.28849 4334-68 2306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 10V année, «° 16 Produits Trouvex inc.Trouvex Products Inc.Avis est donné que la compagnie « Produits Trouvex inc.\u2014 Trouvex Products Inc.>, constituée en corporation par lettres patentes en date du 4e jour de mars 1969 et ayant son bureau principal u Montréal, a établi son bureau au numéro 1070, rue Bleury.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, le 25 mars 1969.(Sceau) Ia> secrétaire, Jacques Corbeau.28850-o 686-69 Société de Placement Triangle inc.Triangle Investment Corp.Avis est donné que la compagnie « Société de Placement Triangle inc.\u2014 Triangle Investment Corp.», a transféré son siège social du 4141 ouest, rue Sherbrooke, bureau 500, Montréal, nu 236, rue Elm, Saint-Lambert.Le secrétaire, Monique Allain.28851 2783-67 La Société Immobilière Lailèche inc.Avis est donné que la compagnie « La Société Immobilière Lailèche inc.>, constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie de la loi des compagnies, le 7 février 1969 et ayant son siège social en la cité et district de St-Mauricc, a établi son bureau au 765, 6e avenue à Grand Mère, district de St.-Maurice, dans la Province de Québec.Signé u Grand'Mère, ce 14c jour de mars 1969.28852-0 Le secrétaire, Jean-Guy Veillette.4682-68 Frederic Viau Transport limitée Avis est donné que la compagnie « Frederic Viau Transport limitée », constituée en corporation par lettres patentes en date du 17 juin 1968 et ayant son siège social dans la cité de Montréal, a établi ses bureaux a 10720 rue Vcrville à Montréal. compter de la date du présent avis, cet endroit est considéré par la compagnie comme l'endroit de son siège socul.Signé à Montréal, ce 13 mars 1969.Le secrétaire, 28853-0 Michel Lamoureux.Produits Trouvex inc.Trouvex Products Inc.Notice is given that \"Produits Trouvex inc.\u2014 Trouvcx Products Inc.\", incorporated by letters patent dated the 4th day of March 1909, and having its head office in Montreal, has established its office at number 1070 Blcury Street.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being the head office of the company.Given at Montreal, March 25, 1969.(Seal) Jacques Corbeau, Secretary.28850 680-6!) Société de Placement Triangle inc.Triangle Investment Corp.Notice is given that \"Société de Placement Triangle inc.\u2014 Triangle Investment Corp.\", has transferred its head office from 4141 Sherbrooke Street West, Suite 500, Montreal, to 236 Elm Street, St.Lambert.Monique Allain, Secretary.28851-0 2783-67 La Société Immobilière Laflèchc inc.Notice is hereby given that \"La-Société Immobilière I,allèche inc.\", incorporated by letters patent under the provisions of Part I of the Companies Act, on the February 13th, 1969 ami having its head office in the city and district of St-Mauricc, has established its office at 765, 6th avenue in Grand'Mère district of St-Mauricc, Province of Québec.Signed at Grand'Mère, this 14th day of March, 1969.Jean-Guy Veillette, Secretary.28852-o 4682-68 Frederic Viau Transport limitée Notice is hereby given that \"Frederic Viau Transport limitée\", company incorporated by letters patent on the 17th June 1968, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 10720 Vcrville in Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company ns being its head office.Signed at Montreal, this 13th March 1969.Michel Lamouruex, 28853-0 Secretary.Divers Compagnies Miscellaneous Companies C.G.M.Enterprises Ltd.Avis est donné que « C.G.M.Enterprises Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs, de 3 il 4.Le secrétaire, Ernest Gluck.28807 5181-68 Blier Inc.Avis est donné que la compagnie « Blier Inc.», a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 6.Le secrétaire, Roger L.Beaulieu.28800 13125-59 C.G.M.Enterprises Ltd.Notice is given that \"C.G.M.Enterprises Ltd.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Ernest Gluck, Secretary.28807-o 5181-68 Blier Inc.Notice is given that \"Blier Inc.\", has changed the number of its directors from 5 to 6.Roger L.Beaulieu, Secretary.28800-o 13125-59 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2367 A.B.E.G.Camping inc.Avis est donné que la compagnie « A.B.E.G.Camping inc.», a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Gilles Dion.28804-q 1617-67 Adams Motel Inc.Prenez avis que l'avis concernant l'augmentation du nombre des administrateurs de 3 à 4 de la compagnie « Adams Motel Inc.», publié dans la Gazette officielle du Québec, 21 décembre 1068, 100e année, No 51, à la page 6860, est nul et de nul effet.2SS05-o Cublovision inc.Avis est donné que la compagnie « Cublovision inc.», a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, Louis Lanolais.2S808-o 11878-60 Kute-Knit Mfg.Corp.Avis est donné que « Kute-Knit Mfg.Corp.» a changé lc nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, B.Douek.28809 3633-59 Landex Realties Inc.Avis est donné que la compagnie < Landex Realties Inc.» a changé le nombre de ses administrateurs de 3 & 6.Le secrétaire, HAiuiv Dubrovsky.28810-o 3038-68 S.R.Maçonnerie inc.S.R.Masonry Inc.Avis est donné que la compagnie « S.R.Maçonnerie inc.\u2014 S.R.Masonry Inc.» a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Mme Maria ïorossi Ronco.2S811-0 5210-68 St.Johns Paper Products Co.Ltd.Avis est donné que la compagnie < St.Johns Paper Products Co.Ltd.» a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, P.1 /ECLAIR.28812-0 16988-59 L.P.Thibault inc.Avis est donné que la compagnie « L.P.Thibault inc.», a changé le nombre de ses adminis-I rateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Gaétan Mercier.28815-o 13600-62 Silver « K » Aluminum Products Ltd.Avis est donné que la compagnie « Silver « K » Aluminum Products Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs de 7 à 8.Le secrétaire, Mortimer Besner.2S814 10680-55 A.B.E.G.Camping inc.Notice is given that \"A.B.E.G.Camping inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Gilles Dion, Secretary.28804 1617-67 Adams Motel Inc.Notice is given that the notice concerning the increasing of the number of its directors from 3 to 4 of the company \"Adams Motel Inc.\", published in the Québec Official Gazette, on December 21, 1968, 100th year.No.51, on page 6860, is null and void.28805 Cublovision inc.Notice is given that \"Cublovision inc.\", has changed the number of its directors, from 4 to 3.28808 Louis Lanolais, Secretary.11878-60 Kute-Knit Mfg.Corp.Notice is given that \"Kute-Knit Mfg.Corp.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.B.Douek, Secretary.28809-o 3633-59 Landex Realties Inc.Notice is given that \"Landex Realties Inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 6.Harry Dubrovsky, Secretary.28810-o 3038-68 S.R.Maçonnerie inc.S.R.Masonry Inc.Notice is given that \"S.R.Maçonnerie inc.\u2014 S.R.Masonry Inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.28811 Mrs.Maria Torossi Ronco, Secretary.5210-68 St.Johns Paper Products Co.Ltd.Notice is given that \"St.Johns Paper Products Co.Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.P.Leclair, Secretary.28812 16988-59 L.P.Thibault inc.Notice is given that \"L.P.Thibault inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Gaétan Mercier, Secretary.28815 13600-62 Silver \"K\" Aluminum Products Ltd.Notice is given that \"Silver \"K\" Aluminum Products Ltd.\", has changed the number of its directors from 7 to 8.Mortimer Besner, Secretary.28814-0 106S0-55 2368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 Shirley K.Maternity Inc.Shirley K.Maternité inc.Avis est donné que * Shirley K.Maternity Inc.\u2014 Shirley K.Maternité inc.» a changé le nombre de ses administrateurs, de 3 à 4.Le secrétaire, Jack Feinberg.28813 2296-68 Wolfgang ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le 28 février 1969 le règlement numéro 4 de la compagnie « Wolfgang Langhcit ltée », changeant son nom en celui de « Wolfgang ltée ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28816-o 2982-67 Bolton, Tremblay & Company Bolton, Tremblay & Compagnie Avis est donné que la compagnie « Bolton, Tremblay & Company \u2014 Bolton, Tremblay & Compagnie», a change le nombre de ses administrateurs de 7 à 9.Le secrétaire, C.Chartrand.28831 4605-50 Superior Brush Mfg.Co.Cic de Fabrication de Brosses Superior Avis est donné que la compagnie < Superior Brush Mfg.Co.\u2014 Cie de Fabrication de Brosses Superior », a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 6.Le secrétaire, Samuel Engels.28832 8168-49 Williams and Esbcr Co.Avis est donné que « Williams and Esbcr Co.».a changé le nombre de ses administrateurs, de 4 a 3.Le secrétaire, Morris Esber.28835 4356-66 Shirley K.Maternity Inc.Shirley K.Maternité inc.Notice is given that \"Shirley K.Maternity Inc.\u2014 Shirley K.Maternité inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Jack Feinberg, Secretary.28813-0 2296-08 Wolfgang ltée Notice is given that the Minister of Financiul Institutions, Companies and Cooperatives has, on February 28,1969, approved the by-law No.4 of the company \"Wolfgang Langheit ltée\", changing its name into that of \"Wolfgang ltée\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28816 29S2-67 Bolton, Tremblay & Company Bolton, Tremblay & Compagnie Notice is given that \"Bolton, Tremblay & Company \u2014 Bolton, Tremblay & Compagnie\", has changed the number of its directors from 7 to 9.C.Chartrand, Secretary.28831-o 4605-50 Superior Brush Mfg.Co.Cie de Fabrication de Brosses Superior Notice is given that \"Superior Brush Mfg.Co.\u2014 Cie dc Fabrication de Brosses Superior\", has changed the number of its directors from 4 to 6.Samuel Engels, Secretary.28832-o 8168-11» Williams and Esbcr Co.Notice is given that \"Williams and Esber Co.\", has changed the number of its directors from 4 to 3.Morris Esber, Secretary.28835-0 4356-66 Proclamations Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icclles pourront concerner.Salut.Proclamation IjC sous-procureur ( A TTENDU que, confor-gênêral, ) mément à l'article 1, Antonio Dubé.j de la Loi du cadastre, Statuts \\ refondus, 1964, chapitre 320, il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan et un livre de renvoi d'une partie du canton dc Landry, soit le Bloc B, située dans la division d'enregistrement d'Ahitibi; Proclamations Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom the presents shall come or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Antonio Dubé,/ V\\7HEREAS pursuant to Deputy Attorney,) section 1 of the Cadns- General.] tre Act, Revised Statu le-, 1.1964, chapter 320, a plan and book of reference of a part of the township of Landry, being Block B, situated in the registration division of Abitibi was prepared under tin' superintendence of the Minister of Lands and Forests; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1968, Vol.101, No.16 2369 Attendu que ces plan et livre de renvoi font maintenant partie des archives du ministère îles terres et forêts, et qu'une copie exacte en a été (lôiwsée au bureau d'enregistrement d'Abitibi; Attendu qu'en vertu de l'article 2169 du Code civil, il y a maintenant lieu d'annoncer, par une proclamation du lieutenant-gouverneur on conseil, le dépôt de ces plan et livre de renvoi officiels, et de fixer en même temps la date où l'article 2168 du Code civil y deviendra en vigueur relativement ù cette partie du canton de Landry.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 661, en date du 12 mars 1969, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons qu'une proclamation soit émise: a) pour annoncer le dépôt des plan et livre de renvoi officiels de cette partie du canton de Landry, située dans la division d'enregistrement d'Abitibi; b) pour fixer, à la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle du Québec, le jour où l'article 2168 du Code civil sera en vigueur relativement à cette partie dudit canton; c) pour inviter toute personne intéressée, à peine de perdre la priorité conférée par le Code civil, à renouveler, dans les deux (2) ans qui suivent la date fixée ci-dessus, l'enregistrement de tous les droits réels sur tout lot de terre compris dans cetc partie dudit canton.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce deuxième jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la dix-huitième année.Par ordre, Le sous-secrétaire de la province, 2S805-o Raymond Douville.Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grûcc de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.Proclamation Le sous-procureur C A TTENDU que le conseil général, ) **¦ municipal du village Antonio Dubé.j de Saint-Ambroise, comté de ' Chicoutimi, a soumis, pour approbation, son règlement numéro 174, a l'effet Whereas these plans and books of reference are now part of the Archives of the Department of Lands and Forests, and that an exact copy was deposited at the registry office of Abitibi; Whereas pursuant to section 2169 of the Civil Code, it is now expedient to announce, by a proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of these official plans and books of reference, and to fix at the same time the date when section 2168 of the Civil Code will come into force in relation to this part of the township of Landry.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 661, dated March 12, 1969, We have decreed and ordered and, hereby decree and order that a proclamation be issued: (a) to announce the deposit of the official plans and books of reference of this part of the township of Landry, situated in the registration division of Abitibi; (6) to fix, on the date of the publication of the present proclamation in the Québec Official Gazette, the day when the provisions of section 2168 of the Civil Code will be in force in relation to this part of the said township; (c) to invite any interested person, under pain of losing the priority conferred by the Civil Code, to renew, within the two (2) years following the date fixed hereabove, the registration of all real rights on any lot of land included in this part of the said township.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our city of Québec, in Our Province of Québec, this second day of April, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and sixty-nine and in the eighteenth year of Our Reign.By command, Raymond Douville, 28805 Assistant Secretary of the Province.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Antonio Dubé, C VJL/HEREAS the Municipal Deputy Attorney,) V Y Council of the Village General.\\ of Saint-Ambroise, county of ' Chicoutimi, has submitted for approval, its by-law number 174, to the effect 2370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 de soumettre le territoire de cette municipalité à la juridiction de la Cour municipale de la cité de Jonquière; Attendu que le conseil municipal de la cité de Jonquière, par son règlement numéro 717 a concouru dans la teneur dudit règlement adopté par le conseil municipal du village de Saint-Ambroisc; Attendu que, sous l'autorité de l'article 7 de la Loi des Cours municipales (Statuts refondus, 1964, chapitre 24) le lieutenant-gouverneur en conseil a donné son approbation ù ces règlements.A ces causes, de l'avis et du consentement de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 691, en date du 12 mars 1969, et vu les dispositions des articles 693 à 697 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), et des articles 3 à 7 de la Loi des Cours municipales (Statuts refondus, 1964, chapitre 24), Nous avons décrété et décrétons qu'à compter de trente et un jours après la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle du Québec, le territoire de la municipalité du village de Saint-Ambroise sera soumis à la juridiction de la Cour municipale de la cité de Jonquière.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icellcs apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce deuxième jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la dix-huitième année.Par ordre, I* sous-secrétaire de la province, 28805-o Raymond Douville.of submitting the territory of this municipality to the jurisdiction of the Municipal Court of the city of Jonquière; Whereas the Municipal Council of the city of Jonquière, by its by-law number i717 agreed to the terms of the said by-law adopted by the Municipal Council of the Village of Saint-Am-broise; Whereas under the authority of section 7 of the Municipal Courts Act (Revised Statutes, 1964, chapter 24), the Lieutenant-Governor in Council has given his approval to these by-laws.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 691, dated March 12, 1969, and pursuant to the provisions of sections 693 to 697 of the Cities and Towns Act (Revised Statutes, 1964, chapter 193), and to sections 3 to 7 of the Municipal Court Act (Revised Statutes, 1964, chapter 24), We have decreed and do decree that from and after thirty-one days following the publication of the present proclamation in the Québec Official Gazette, the territory of the municipality of the village of Saint-Am¦ broise will be submitted to the jurisdiction of the Municipal Court of the city of Jonquière.Of all of which Our loving subjects and all others whom the presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and I he Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.C.,Q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given in Our Parliament Buildings, in Our city of Quéliec, in Our Province of Québec, this second day of April, in the Year of Our Lord one thousand nine hundred and sixty-nine and in the eighteenth year of Our Reign.By command, Raymond Douville, 28805 Assistant Secretary of the Province.Changement de nom \u2014 Loi du John Shemanashen Avis est donné que John Shemanashen, souscripteur de risques, domicilié et résidant au 6935, 35e avenue Rosemont, dans les cité et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de John Sherman.Montréal, ce 7e jour d'avril 1969.Les procureurs du requérant, O'Brien, Home, Hall, Nolan, Saunders, 28770-15-2-o O'Brien & Smyth.Mendel Bluczyc Avis est par les présentes donné que Mendel Bluczyc, commis de banque, aussi connu sous le nom de Martin Blutchitz, domicilié à 82 Roxton Crescent, Montréal Ouest, district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur de la Province de Québec la permission de changer son nom en celui de Martin Bloom.Montréal, le 3 avril 1969.Le procureur du requérant, 28789-16-2-0 David A.Schwartz.Change of name \u2014 Act John Shemanashen Notice is given that John Shemanashen, underwriter, domiciled and residing at 6935, 35th ave.Rosemont, in the city and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to that of John Sherman.Montreal, this 7th day of April 1969.O'Brien, Home, Hall, Nolan, Saunders O'Brien & Smyth, 28770-15-2-o Attorneys for petitioner.Mendel Bluczyc Notice is hereby given that Mendel Bluczyc, bank clerk, also known under the name of Marl in Blutchitz, domiciled at 82 Roxton Crescent, Montreal West, district of Montreal, will ask the Lieutenant-Governor of the Province of Québec for the permission to change his name to that of Martin Bloom.Montreal, April 3, 1969.David A.Schwartz.28789-16-2-o Attorney for A pplicant. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2371 Madeline Agnes Pipher Avis est, par les présentes, donné que Madeline Agnes Pipher domiciliée à 12251, Laconic, t.'artiervillc, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Madeline Agnes l'ipher Cutts, celui-ci devant servir à toutes fins légales.Montréal, 13 mars 1969.Les procureurs de la requérante, Baker, Woloshen, 28693-15-2 Beaupré & Baker.Claude Bonsaint Avis est donné que Claude Bonsaint, plombier, domicilié à 1422 William David à Montréal, fera demande au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour un décret changeant son nom en celui de Claude Caron.Son épouse née Agathe Savoie et son fils mineur non émancipé Alain, tous de la même adresse, bénéficieront du dit changement de nom.Ix procureur du requérant, 2S750-15-2-o Gaétan Lagarde, avocat Joseph Georges Roger D'Amour Avis est par les présentes donné que Joseph ( ieorges Roger D'Amour époux de Vernice Hajaly, des ville et district de Montréal, province de Québec, conformément au Bill 31, s'adressera au secrétaire de la Province de Québec pour obtenir l'autorisation de changer son nom en celui de Roger Dubé.Montréal.Les procureurs du requérant, 28790-16-2 Liverman & Kaufman.Ernest Avis est pur la présente donné que le procureur .soussigné transmettra au secrétaire de la province une requête au nom de son client pour que ce dernier domicilié à-Montréal et actuellement désigné à son acte de naissance sous l'unique prénom de Ernest soit dorénavant et à toutes fins que de droit juridiquement reconnu sous les nom et prénom de Marcel Robert, le tout en vertu de la Loi du Changement de nom, 13-14 Elizabeth II, Ch.77.Montréal, ce 11 mars 1969.Le procureur du requérant, 2,S830-16-2-o Charles Coderhe, ch.Nathan Joseph Ferstenfcld et al Avis est par les présentes donné que Nathan Joseph Ferstenfcld, manufacturier, domicilié et résidant au 1062, 100c Avenue, dans la cité de Laval, district of Montréal, s'adressera au secrétaire de la province pour changer son nom en celui de Nat Joseph Fersten, ledit changement devant s'appliquer aussi à son épouse, née Elaine Frances Agatston, ménagère, et à ses enfants mineurs non émancipés: Marc Stuart et Caren Audrey, tous domiciliée au même endroit.Les procureurs du requérant, 2881946-2 Halpehin & Morris.Madeline Agnes Pipher Notice is hereby given that Madeline Agnes Pipher residing at 12251 Lacorne, Cartierville, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for adoption of an order changing her name to that of Madeline Agnes Pipher Cutts the same to avail for all legal purposes.Montreal, March 13, 1989.Baker, Woloshen, Beaupré & Baker, 28693-15-2-o Attorneys for Applicant.Claude Bonsaint Notice is hereby given that Claude Bonsaint, plumber, domiciled at 1422 William David, in Montreal, will apply to the LieutenantGovernor in Council of the Province of Québec for leave to change his name to that of Claude Caron.His wife, née Agathe Savoie, and his minor unemancipated son, Alain, all of the same address, will benefit from the said change of name.Gaétan Lagarde, Advocate, 28750-15-2 Attorney for the Petitioner.Joseph Georges Roger D'Amour Notice is hereby given that Joseph Georges Roger D'Amour husband of Vernice Hajaly, of the city and district of Montreal, province of Québec, in conformity with Bill 31 will petition the secretary of the Province of Québec in order to obtain the change of his name to Roger Dubé.Montreal.Liverman & Kaufman, 28790-16-2-o Attorneys for Applicant.Ernest Notice is hereby given that the undersigned attorney will apply to the Provincial Secretary, in the name of his client, so that the latter, domiciled in Montreal and presently designated on his birth certificate under the given name of Ernest, be, henceforth and for all purposes, legally known under the name and given name of Marcel Robert, the whole pursuant to the Change of Name Act, 13-14 Elizabeth II, chapter 77.Montreal, March 11, 1969.Charles Coderre, q.c, 2S830-16-2 Attorney for the petitioner.Nathan Joseph Ferstenfcld et al Notice is hereby given that Nathan Joseph Ferstenfeld, manufacturer, domiciled and residing at 1062, 100th Ave., in the City of Laval, District of Montreal, will apply to the Provincial Secretary to change his name to Nat Joseph Fersten and to benefit his wife, née Elaine Frances Agatston, housewife, and his unemancipated minor children; Marc Stuart and Caren Audrey, all domiciled at the same place.Halperin & Morris, 27819-16-2-0 Attorneys for Petitioner. 2372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, m0 16 Paul Singler Avis est par la présente donné que Paul Singler, opérateur, domicilié et résidant au 1640 rue Ville-Marie, district de Montréal, demandera au Secrétaire de la province de changer son nom en celui de Paul Bernard de même que celui de sa femme née Germaine Lord, ménagère de la même adresse et celui de son fils René demeurant au 6241 Boulevard Roi-René, ville d'Anjou district de Montréal, ainsi que celui de sa femme née Loranza Robert, ménagère.28791-16-2-0 Jack Baranovsky Avis est par les présentes donné que Jack Baranovsky, vendeur (époux de Barbara Bara-novsky, née Gasco) résidant au 18 rue Lesage, Dollard des Ormeaux, Province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, pour un décret changeant son nom de Jack Baranovsky à Jack Baron.Montréal, ce 8 avril 1969.Les procureurs du requérant, 28822-16-2-0 Mes Kravitz & Kravitz.Joseph-Edouard Tanguay Prenez avis que Joseph-Edouard Tanguay, né le 23 avril 1937, à Ste-Sabine, comté de Belle-chasse, et actuellement résidant à ville de Lac Etchemin, comté de Dorchester, s'adressera au secrétaire de la province afin qu'aux prénoms de Joseph-Edouard, soit ajouté celui de Denis.Québec, lc 15 avril 1969.Les procureurs des requérants, Bon.y, Henry, Boulianne & Pouliot.28868-16-2-0 Paul Singler Notice is hereby given that Paul Singler, operator, domiciled in Montreal, residing at 1640 Ville Marie Street, is petitioning the Provincial Secretary that his name be changed to Paul Bernard, also that of his wife, born Germaine Lord, housewife, domiciled at the same address, also including his son, René, domiciled at 6241 Roi René Boulevard, Ville d'Anjou, district of Montreal and his wife, born Lorenza Robert, housewife.28791-16-2-0 Jack Baranovsky Notice is hereby given that Jack Baranovsky, salesman (husband of Barbara Baranovsky, maiden name Gasco) residing at 18 Lesage street, Dollard des Ormeaux, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, his adopting of an order changing his name of Jack Baranovsky to Jack Baron.Montreal, April 8, 1969.Mtres Kravitz & Kravitz, 28822-16-2-0 Attorneys for the Petitioner.Joseph-Edouard Tanguay Notice is hereby given that Joseph-Edouard Tanguay, born on April 23, 1937, at Ste-Sabine, county of Bcllechassc, ami presently residing in the town of Lac Etchemin, county of Dorchester, will apply to the Provincial Secretary in order to add Denis to the first names of Joseph-Edouard.Québec, April 15, 1969.Boily, Henry, Boulianne & Pouliot, Attorneys for the petitioner.28868-16-2 Demandes à la Législature Ville de Laval Avis est par les présentes donné que la « Ville de Laval » s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec à sa présente session, pour l'adoption d'une loi sur les matières suivantes: 1° Obtenir le pouvoir d'organiser, de maintenir et d'exploiter un système de transport en commun et de créer à ces fins, une Commission de Transport.2° Obtenir l'autorisation d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation des immeubles pour fins de réaménagement urbain; 3° Obtenir le pouvoir de créer un fonds industriel pour fins de développement domiciliaire et commercial.4° Déclarer valides, à toutes fins que de droit, les ventes effectuées par la Corporation Interurbaine de l'Ile Jésus avant l'incorporation de la Ville de Laval.5° Obtenir lc pouvoir de revendre pour des fins particulières, des résidus de terrains acquis par suite d'expropriation.Et pour toute autre fin qui lors de l'étude et de la présentation des amendements à la charte de la ville de Laval, pourrait être dons l'intérêt de la ville et de ses contribuables.Ville de Laval, ce onzième jour de mors 1969.Le procureur de la Ville de Laval, 28520-13-4-o Roger Savard, c.r.Applications to Legislature City of Laval Notice is hereby given that the \"City of Laval\" will apply to the National Assembly of Québec at its present session, for the adoption of an act, the objects thereof are the following: 1.To obtain the power to organize, maintain and operate a public passenger transport network and to constitute a Transport Commission for these purposes.2° To obtain the authorization to acquire by agreement or expropriation, the immovables for the urban rc-devclopment.3.To obtain the power to establish an industrial fund for the purposes of a domiciliary and commercial development.4.Ratify for all legal purposes, the sales executed by the Corporation Interurbaine de l'île Jésus before the incorporation of the City of Laval.5.To obtain the power to sell for particular purposes, some residues of land acquired by expropriation.Ana for all other purposes which during the studying and presentation of amendments to the charter of the City of Laval could be in the interest of the city and its taxpayers.City of Laval, this eleventh day of March 1969.Roger Savahd, q.c, 28520-13-4-o Attorney for the City of Laval. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2373 Ville de Candiac Avis public est par les présentes donné que la Ville de Candiac s'adressera à la Législature de la province de Québec à sa présente session pour demander l'adoption d'une loi en vue de sanctionner une entente intervenue entre elle et Candiac Development Corporation et destinée à mettre fin à la convention intervenue entre les parties le 16 mars 1961 devant Me Herbert Uayne McLean sous le numéro 22356 de ses minutes, sanctionnée par la Loi 9-10 Elizabeth II, chapitre 129 et relative à .l'installation des services publics dans la municipalité.Le procureur de la pétitionnaire, '28584-13-4-0 Gaston Pouliot, c.r.Fabrique de la paroisse de Ste-Sophic Avis public est par les présentes donné que la < Fabrique de la paroisse de Ste-Sophie » s'adressera à la Législature de Québec lors de la présente session, pour l'adoption d'une loi: 1° Annulant la prohibition d'aliéner contenue dans les actes du 20 juillet 1948 ainsi que dans celui du 6 novembre 1871; 2° Autorisant votre requérante à vendre lesdits lots; 3° À ce que lesdits baux emphytéotiques déjà signés entre l'emphytéotc et le bailleur équivail-lent à vente; 4° Et pour toutes autres fins.Fabrique de la paroisse de Ste-Sophic, ce 14 mars 1969.Iajs procureurs de la requérante, André Foroet, Guérin, 28521-13-4-0 Taillefer & Brunet.Corporation municipale de Saint-Jean-dcs-Piles Avis public est par les présentes donne que la corporation municipale de Saint-Jean-des-Piles, dans le comté de Champlain, s'adressera à la Législature du Québec lors de la présente session l>our l'adaption d'une loi lui permettant d'annexer le territoire de la Pointc-à-Comeau ainsi que le territoire du Lac des Piles, lesdits territoires à être détachés de la municipalité de la paroisse de Sainte-Flore, dans le comté de Suint-Maurice, et toutes autres fins qui pourraient être dans l'intérêt de la municipalité.Shawinigan, le 5 avril 1969.Le procureur de la requérante, 28651-14-4-0 Guy Germain.Église Baptiste de Marieville Avis est par les présentes donné que « Église Baptiste de Marieville , une congrégation bap-tiste ayant sa place des offices au 762 rue Claude de Ramesny, en la ville de Marieville, Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil I>our être incorporé sous le nom de « Église Baptiste de Marieville» conformément aux dispositions du chapitre 305, S.R.Q.1964.28652-14-4-0 Église Baptiste Française de Québec Avis est par les présentes donné que « Église Baptiste Française de Québec », une congrégation baptistc ayant sa place des offices au 1198, 3e avenue, en la ville de Québec, Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'être incorporée sous le nom de « Église Baptistc Française de Québec » conformément aux dispositions du chapitre 305, S.R.Q.1964.28658-14-2-0 Town of Candiac Public notice is hereby given that the Town of Candiac will apply to the Legislature of the Province of Québec at its present session for the passing of an Act ratifying an agreement between the Town and Candiac Development Corporation, such agreement being designed to tcrmi te a certain contract signed between the parties on March 16, 1961, before Herbert Bayne c-Lean, Notary, under number 22356 of his minutes, ratified by the Act 9-10 Elizabeth II, chapter 129 and pertaining to the installation of public services in the municipality.Gaston Pouliot, q.c, 28584-13-4-0 Attorney for Petitioner.Fabrique de la paroisse de Ste-Sophie Public notice is hereby given that the \"Fabrique de la paroisse de Ste-Sophie\" will apply to the Québec Legislature at its present session, for the adoption of an Act: 1.To annul the prohibition to alienate contained in the act of July, the 20th 1948 and in the other one of November, the 6th 1871; 2.To authorize the petitioner to sell the said lots; 3.And the emphyteutic leases signed between the lessee and the lessor be considered as sale.4.And for all other purposes.Fabrique de la paroisse de Ste-Sophic, this March 14, 1969.André Foroet, Guérin, Taillefer & Brunet, 28521-13-4-0 Attorneys for the petitioner.Municipal Corporation of Saint-Jean-des-Piles Public notice is hereby given that the municipal' Corporation of Saint-Jean-des-Piles, in the county of Champlain, will apply to the Québec Legislature during its present session to request the adoption of an Act permitting it to annex the territory of Pointc-à-Comcnu as well as the territory of Lac des Piles, the said territories to be detached from the municipality of Saintc-Flore, in the county of Saint-Maurice, and for all other purposes which could be in the interest of the municipality.Shawinigan, April 5, 1969.Guy Germain, 28651-14-4 Attorney for the Petitioner.Église Baptistc de Marieville Notice is hereby given that \"Église Baptistc dc Marieville\", a Baptist Congregation having its place of worship at 762 Claude de Ramcsay, in the town of Marieville, Province of Québec, shall apply to the Lieutenant Governor in Council for incorporation under the name of \"Église Baptistc de Marieville\", in conformity with the provisions of chapter 305, R.S.Q.1964.28652-14-2-0 Église Baptistc Française de Québec Notice is hereby given that \"Église Baptistc Française de Québec\", a Baptist Congregation having its place of worship at 1198, 3rd Avenue, in the city of Québec, Quebec, shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for incorporation under the name of \"Église Baptiste Française de Québec\" in conformitv with the provisions of Chapter 305, R.S.Q.1964.28653-14-4-0 2374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 Cité de Verdun Avis public est, par les présentes, donné que la cité de Verdun s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la loi 7 Edouard VII, chapitre 73 et ses amendements, sur les matières suivantes: \u2014 pour remplacer de nouveau l'article 2 de la loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 72, déjà remplacé par l'article 3 de la loi 15-16 Elizabeth II, chapitre 93; \u2014 pour que le contrat passé le 28 avril 1966 devant le notaire Jean-Luc Trempe, sous le No 5172 de ses minutes, entre la ville de Montréal et la cité de Verdun, soit continué pour 3 ans à compter du 19 mars 1969; \u2014 pour faire amender pour la cité l'article 539 de la Loi des cités et villes; \u2014 pour faire abroger le dernier paragraphe de l'article 9 de la loi 9-10 Elizabeth II, chapitre 54; et pour toutes les autres fins.Montréal, ce 2 avril 1969.Les \"procureurs, Lacroix, Viau, Bélanger, 28823-16-4-0 Page, Hébert & Mailloux.Cité des Trois-Rivicrcs Avis public est par les présentes donné que la corporation de la « Cité des Trois-Rivières » s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi spéciale afin de modifier son nom, modifier les procédures à suivre au cas d'infractions aux règlements relatifs à la circulation et au stationnement, modifier la pension des conseillers, modifier la procédure pour la perception des taxes, abroger la loi autorisant la création d'un fonds de réserve, ainsi que pour autoriser l'amendement du règlement no 239-A aux fins de pouvoir évaluer tous terrains ou terres suivant la loi.Trois-Rivières, 15 avril 1969.Le procureur de la pétitionnaire, 28867-16-4-0 Jean Méthot, en.City of Verdun Public notice is hereby given that the city of Verdun will apply to the Legislature of the Province of Québec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 7, Edward VII, chapter 73 and its amendments, on the following matters: \u2014 to replace article 2 of Act 5-6 Elizabeth If, chapter 72, as amended by article 3 of Act 15-10 Elizabeth II, chapter 93; \u2014 to have the contract entered into on Aprii 28th 1966, before Notary Jean-Luc Trempe, under No.5172 of his minutes, between the city of Montreal and the city of Verdun, continued for three years, since March 19, 1969; \u2014 to amend for the city of Verdun, article 539 of the Cities and Towns Act; \u2014 to abrogate the last paragraph of article 9 of Act 9-10 Elizabeth II, chapter 54; and for all other purposes.Montreal, April 2, 1969.Lacroix, Viau, Bélanger, Page, Hébert & Mailloux, 28823-16-4-0 Attorneys.City of Trois-Rivicrcs Public notice is hereby given that the corporation of the \"City of Trois-Rivières\" will apply to the Legislature of the province of Québec, at its present session, for the adoption of a special act in order to change its name, the procedures to follow in case of infractions to the by-laws relating to traffic and parking, the pension of councillors, the procedure for the collection of taxes; the abrogation of the act authorizing the creation of reserve funds, as well as the authorization of the amendment of by-law No.239-A in order to valuate all lands or farms according to the act Trois-Rivières, April 15, 1969.Jean Méthot, q.c, 28867-16-4 Attorney for the peliliner.Compagnies autorisées Companies Licensed à faire des affaires to do Business Cit Travel Service, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Cit Travel Service, Inc.», a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Italo Fato, 12504, rue Francis, Pierrefonds.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 2055, rue Peel, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 1-69 \u20141475/81 Lithium Corporation of America Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Lithium Corporation of America » a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite Cit Travel Service, Inc.Notice is given that under the Extra-Provincial Companies Act, \"Cit Travel Service, Inc.\".has been authorized to carry on business in tin' Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Italo Fato, 12504 Francis Street, Pierrefonds.The principal office of the company in the Province is at 2055 Peel Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institulions, Companies and Cooperatives.28785-o 1-69 \u20141475/SI Lithium Corporation of America Notice is given that, under the Extra-Provin cial Companies Act, \"Lithium Corporation of America\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2375 compagnie, est MM.Bucbanan, McAllister, Blakcly & Ham, avocats, suite 1230, place du Canada, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à suite 1230, place du Canada, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 12-69 \u20141475/85 Cities Service Minerais Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Cities Service Minerais Corporation > a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Kenneth H.Brown, conseil en Loi de la reine, «le Montréal.Le bureau principal de la compagnie «lans la province est établi à suite 720,800, place Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Lc sous-ministre des institulions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28785 18-19 \u2014 1476/105 Plymouth Golf Bail Soles Company Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Plymouth Golf Bail Sales Company» a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est C.T.Corporation System (Canada), Ltd., of Québec.Lc bureau principal de la compagnie dans la province est établi à suite 42, 81, rue St-Picrrc, Québec, district judiciaire «le Quél>cc.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2S785 14-69\u20141476/41 Messrs.Buchanan, McAllister, Blakely & Ham, advocates, Suite 1230, Place du Canada, Montreal.The principal office of the company in the Province is at Suite 1230, Place du Canada, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 12-69 \u20141475/85 Cities Service Minerals Corporation Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Cities Service Minerals Corporation\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Kenneth H.Brown, Queen's Counsel, of Montreal.The principal office of the company in the Province is at Suite 720, 800 Victoria Square, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28785-0 18-69 \u20141746/105 Plymouth Golf Ball Sales Company Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Plymouth Golf Ball Sales Company\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is C.T.Cor|>oration System (Canada), Ltd., of Quebec.The principal office of the company in the Province is at Room 42, 81 rue St-Pierre, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institulions, Companies and Cooperatives.28785-0 14-69 \u20141476/41 Liquidation \u2014 Avis dc Société coopérative agricole dc beurrerie de St-Elzéar (Loi des sociétés coopératives agricoles) Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des membres «le la « Société coopérative agricole de beurrerie de St-Elzéar», tenue ù St-Elzéar, le 24 janvier 1967, il n été-résolu dc liquider la coopérative, conformément aux dispositions «le l'article 33 de la Loi des sociétés coopératives agricoles, statuts refondus 1964, chapitre 124, et que MM.Roch Biais, Clément L'aplanie et Joseph Marcoux ont été nommés liquidateurs.Québec, lc 22 octobre 1968.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 28785-0 Ls-Philippe Bouchard.I.c Téléphone Rural de St-Gédéon Avis est donné «pie, lors d'une assemblée générale spéciale «les actionnaires de la compagnie Le Téléphone Rural dc St-Gédéon », tenue à Winding up Notices Société coopérative agricole dc beurrerie dc St-Elzéar (Agricultural Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that, at a special general meeting of the members of the \"Société coopérative agricole de beurrerie de St-Elzéar\", held in St-Elzéar on January 24, 1967, a resolution was adopted to liquidate the cooperative, pursuant to the provisions of section 33 of the Agricultural Cooperative Associations Act, Revised Statutes, 1964, chapter 124, and that Messrs.Roch Biais, Clément Laplante and Joseph Marcoux have been appointed lkiuidalors.Quelle, October 22, 1968.Ls-Piiilippe Bouchard, Depuly Minister of Financial Institutions, 28785 Companies and Cooperatives.Le Téléphone Rural dc St-Gcdcon Notice is hereby given that al a special general meeting of the shareholders of \"Le Téléphone Rural «le St-Gédéon\", held at Saint-Gédéon, on 2370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 19G9, 101' année, n\" 16 Saint-Gédéon, le 11 février 1968, il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Laurent Petit, c.a.a été nommé liquidateur.Lc sous-minislre des institulions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.28871-0 65509-45 February 11, 1968, a resolution was passed stating that the affairs of the said company be wound-up, and that they be dissolved, pursuant to the Winding-Up Act, and that Mr.Laurent Petit, c.a., was appointed liquidator.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.28871 6509-15 Assemblée La Compagnie du chemin dc fer Alma & Jonquibrcs Les actionnaires dc « La Compagnie du chemin de fer Aima & .Tonquières » sont convoqués en assemblée générale annuelle lc mardi, vingt-deux avril 1969, il trois heures dc l'après-midi, au numéro 1, de l'immeuble Place Ville-Marie, ù Montréal, pour recevoir les comptes de l'exercice 1968, procéder à l'élection des administrateurs et à la nomination des vérificateurs pour lc prochain terme d'office et pour délibérer sur toute autre question du ressort de l'assemblée.Le secrétaire, 28694-15-2-0 J.R.Turgeon.Meeting The Aima & Jonquibrcs Ruitwuy Company The Annual Meeting of the Shareholders of \"The Alma & Jonquières Railway Company\" to receive the 1968 financial statements of the company, to elect directors and appoint auditors for the ensuing year, and to transact such other business as may properly come before the meeting, will be held in the 31st floor board room, 1, Place Ville Marie, Montreal, on Tuesday, April 22, 1969, at three o'clock in the afternoon.J.R.Turgeox, 28694-15-2-o Secretary.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Assurances The British Canadian Insurance Company La Compagnie d'Assurance Canadienne Britannique (constituée en corporation en vertu des Lois de la province de Québec) Avis est donné, par les présentes, que « The British Canadian Insurance Company \u2014 La Compagnie d'Assurance Canadienne Britannique», constituée en corporation en vertu des lois de la province de Québec, a réassuré tous ses contrats en vigueur dans la province dc Québec avec « The Western Assurance Com-pony», constituée en corporation en vertu des Lois du Canada, dont le siège social est situé il Toronto, province d'Ontario, enregistrée dans la province de Québec et laquelle a assumé les réclamations produites ou il être produites à ladite «The British Canadian Insurance Company \u2014 La Compagnie d'Assurance Canadienne Britannique », s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil le 14c jour de juillet 1969 pour obtenir la remise de ses valeurs déposées chez le ministre des finances de la province de Québec.Avis est de plus donné que tous les réclamants actuels ou éventuels s'opposant à la remise des valeurs de « The British Canadian Insurance Company \u2014 La Compagnie d'Assurance Canadienne Britannique», constituée en corporation en vertu des Lois de la province dc Québec, doivent produire leur opposition à l'Inspecteur des assurances, Services des assurances, Hôtel «lu Gouvernement, Québec, lc ou avant le 14e jour «le juillet 1969.Donné à Montréal, ce 26e jour de mars 1969.Le secrétaire, 28752-15-2-0 Walter Geoffrey Chapman.Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Insurance The British Canadian Insurance Company La Compagnie d'Assurance Canadienne Britannique (incorporated under the laws of the Province of Québec) Notice is hereby given that \"The British Canadian Insurance Company \u2014 La Compagnie d'Assuranw Canadienne Britannique \", incorporated under the laws of the Province of Québec, has reinsured all its contracts in force in the said Province with \"The Western Assurance Company\", incorporated under the laws of Canada, whose head office is situated in Toronto, province of Ontario, registered in the Province of Québec, and which assumed the liability for reported and unreported claims of \"The British Canadian Insurance Company \u2014 La Compagnie «l'Assurance Canadienne Britannique\", will apply to the Lieutenant-Governor in Council on the 14th of July 1969, for the release of its securities deposited with the Minister of Finance of the Province of Québec.Notice is hereby further given that all claimants, actual or eventual, opposing the release of the securities of \"The British Canadian Insurance Company \u2014 La Compagnie d'Assurance Canadienne Britannique\", incorporated umlcr the laws of the Province of Québec, must file their opposition with the Inspector of Insurance, Department of Insurance, Government House, Québec, on or before the 14th day of July 1969.Dated at Montreal, this 26th day of March 1969.Walter Geoffrey Chapman, 28752-15-2-0 Secretary. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2377 The United Provinces Insurance Company La Compagnie d'Assurances Provinces-Unies Avis est donné, par les présentes, que « The United Provinces Insurance Company \u2014 La Compagnie d'Assurances Provinces-Unies » a adopté le règlement suivant que ses membres ont approuvé ù l'unanimité à une assemblée générale spéciale tenue le 28 mars 1969: Que l'article III, Section 1, des règlements généraux de la compagnie est annulé ét remplacé par le texte qui suit: Que les affaires dc la compagnie seront administrées par un bureau de direction composé dc pas moins dc six (10) ou plus de onze (11) membres.Donné à Montréal, ce 31c jour dc mars 1969, conformément aux dispositions de l'article 170 de la Loi des assurances de Québec (chapitre 295, S.R.Q.1964).Le secrétaire, 28865-0 Louis Pons.The United Provinces Insurance Company La Compagnie d'Assurances Provinces-Unies Notice is hereby given that \"The United Provinces Insurance Company \u2014 La Compagnie d'Assurances Provinces-Unies\" has adopted the following by-law which its members have unanimously approved at a special general meeting held on the 28th of March 1969; That article III, Section 1, of general by-laws of the company is cancelled and replaced by the following text: The affairs ofthc company shall be managed by a board of not less than ten (10) or more than eleven (11) directors.Given at Montreal, this 31st day of March 1969, pursuant to the provisions of section 170 of the Quebec Insurance Act (chapter 295, R.S.Q.1964).Louis Pons, 28865-0 Secretary.Avis divers Cité de Thetford Mines Avis public est, par les présentes, donné que le conseil de la cité de Thetford Mines adressera, après les délais exigés à l'article 2 dc la Loi des Cités et Villes (S.R.Q.1964, ch.193 et ses amendements), une requête au lieutenant-gouverneur en conseil en vue d'obtenir des lettres patentes modifiant la charte de la Cité de Thetford Mines, en remplaçant les articles 6 et 10 de la loi 12 Geo VI, ch.59, l'article 526c édicté pour la Cité par l'article 7 dc la loi 13 Geo.VI, 85, l'article 68d édicté pour la Cité par l'article 3 de la loi 5-6 Elizabeth II, ch.81 et l'article 7 de la loi 8-9 Elizabeth II, ch.118 par les dispositions correspondantes dc ladite loi des Cités et Villes.Donné à Thetford Mines, ce dixième jour du mois d'avril, mil neuf cent soixante-neuf.(Sceau) Le greffier de la Cité, 28821-0 Armand Gagnon.Conseil Mgr.Gaspard Forest, P.D., No 2793 des Chevaliers de Colomb de Val d'Or inc.Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 31 mars 1969, approuvé les règlements généraux dc la corporation « Conseil Mgr Gaspard Forest, P.D., No 2793 des Chevaliers de Colomb de Val d'Or inc.», et ce, en vertu dc l'article 9 de la Loi concernant les Chevaliers dc Colomb dc la province de Québec et de l'article 225 de la Loi des compagnies.Lc sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.28799-0 22-68 Conseil Stc-Gcrmaiiic No 2988 des Chevaliers de Colomb dc Stc-Gcrmaine inc.Avis est donné que lc secrétaire dc la province a, lc 27 mars 1969, approuvé les règlements généraux de la corporation « Conseil Ste-Gcr-inaine No.2988 des Chevaliers dc Colomb dc Stc-Germaine inc.», et ce, en vertu dc l'article 9 de la Loi concernant les Chevaliers dc Colomb de la province de Québec et dc l'article 225 dc la Loi des compagnies.Le sous-secrétaire dc la province, Raymond Douvii.i.e.28786-0 19-68 Miscellaneous Notices City of Thetford Mines Public notice is, hereby, given that the City Council of Thetford Mines will apply, after the delays required by article 2 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1964, h.193 and its amendments) by petition to the Lieutenant-Governor in Council, in order to obtain letters patent amending the charter of the City of Thetford Mines then replacing articles 6 and 10 of Act 12 Geo.VI, ch.59, article 526c added for the city by article 7 of Act 13 Geo.VI, ch.85, article 68d added for the city by article 3 of Act 5-6 Elizabeth II, ch.81 and article 7 of Act 8-9 Elizabeth II, ch.118 by the correspondent provisions of the said Cities and Towns Act.Given under my band at Thetford Mines, this tenth day of the month of april in the year one thousand nine hundred and sixty-nine.(Seal) Armand Gagnon, 28821 City Clerk.Council Mgr.Gaspard Forest, P.D., No.2793 of the Knights of Columbus of Val d'Or Inc.Notice is given that the Secretary of the Province approved, on March 31, 1969, the general by-laws of the corporation \"Council Mgr Gaspard Forest, P.D., No.2793 of the Knights of Columbus of Val d'Or Inc.\", and such, pursuant to section 9 of the Act respecting the Knights of Columbus of the province of Québec and section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.28799 22-68 Council Sle-Gcrmaine No.2988 of the Knights of Columbus of Ste-Gcrmainc Inc.Notice is given that the Secretary of the Province approved, on March 27, 1969, the general by-laws of \"Council Ste-Germaine No.2988 of the Knights of Columbus of Ste-Germaine Inc.\", and such, pursuant to section 9 of the Act respecting the Knights of Columbus of the province of Québec and section 225 of the Companies Act.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.28786 19-68 2378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 Cité dc Longueuil Cité dc Jacques-Cartier Avis est pur les présentes donné, suivant l'article 6 de la Loi de la fusion volontaire des municipalités (13-14 Eliz.II, chapitre 56), que la cité dc Jacques-Cartier a adopté, le 1er avril 1969, un règlement qui porte lc No 733, et que la Cité de Longueuil a adopté, le 8 avril 1969, un règlement qui porte lc No 1043, et tels règlements autorisent la présentation d'une rcquôtre conjointe au lieutenant-gouverneur en conseil, lc priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces deux municipalités et créant une nouvelle municipalité dc ville, le tout aux conditions ci-après qu'expose la requête annexée duns chaque cas audit règlement; et qu'aussitôt que possible après les publications du présent avis, cette requête sera transmise au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale dc Québec.Cette requête expose, outre les lois qui régissent la constitution dc chacune des deux municipalités, la contiguïté dc leurs territoires, leur désir de se fusionner conformément ù la Loi de la fusion volontaire des municipalités, l'adoption des règlements ci-dessus mentionnés, et l'approbation par la Commission Municipale dc Québec du règlement No 733 dc la cité de Jacques-Cartier, ce qui suit: 1° Lc nom de la nouvelle municipalité sera la « Ville dc Longueuil » \u2014 en anglais the « City of I-Ollgueuil » ; 2° Lc territoire dc la nouvelle municipalité sera fait du territoire actuel des deux municipalités fusionnées tel que défini à la description technique et montré au plan tous deux préparés par William-Patrick Laltochc et Louis Langlois, arpenteurs-géomètres, et datés 31 mars 1969, lesquels description et plan sont annexés aux présentes après avoir été signés par lc maire et pur lc greffier (annexes 3 et 4); 3° La Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitré 193) régira la nouvelle municipalité sous réserve des conditions de la fusion telles qu'énoncées aux présentes; 4° Les dispositions législatives spéciales qui réagissaient les deux municipalités avant leur fusion, savoir, la charte dc la cité dc Longueuil, (7 Edouard VII, (1907), chapitre 71) et la charte dc la cité «le Jacques-Cartier (11 George VI, chapitre 102 (1947) et leurs umendements cesseront dc régir le territoire dc la nouvelle municipalité, sous réserve des dispositions suivantes: a) Dispositions conservées dc la charte dc la cité de Longueuil (annexe 5): 7 Edouard VII (1907), chapitre 71, article 52.3 George V (1912), chapitre 64, articles 7 et 10.8 George V (1918), chapitre 90, article 10.13 George V (1922), chapitre 96, article 3.20 George V (1930),'chapitre 115, articles 1 et2.25-26 George V (1935), chapitre 126.article 6.5 George VI (1941), chapitre 78, articles 1,2,3 et 4.9 George VI (1915), chapitre 82, articles 1, 2, 5, 6, 7 et 8.12 George VI (1948), chapitre 60, articles 1, 3 et 4.14 George VI (1950), chapitre !>7, article 1.14-15 George VI (1951), chapitre 82, article 1.City of Longueuil City of Jacques-Cartier Notice is hereby given under section 6 of The Voluntary Amalgamation of Municipalities Act, (13-14 Eliz.II, chapter 56), that the City or Jacques-Cartier has adopted, on April 1st, 1969, a by-law bearing No.733, and that the City of Longueuil has adopted, on the April 8, 1969, a by-law bearing No.1043, and that such bylaws uuthorizc the presentation of a joint petition to the Lieutenant-Governor in council praying for the granting of letters patent amalgamating these two municipalities, the whole under the hereinafter conditions as stated in the petition annexed in each case to the said by-law; and that, as soon as possible after the publications of the present notice, that petition shall be forwarded to the Minister of Municipal Affairs and to the M iinieipal Commission of Québec.That petition states, further to the statutes constituting each of the two (2) municipalities, the fact that their territory is contiguous, their wish to amalgamate according to the Voluntary Amalgamation of Municipalities Act, the adoption of the bcreinaforc-mcntioncd by-laws and the approval by the Municipal Commission of Quél>cc of by-law No.733 of the City of Jncqucs-Carticr, the following: 1.The name of the new municipality shall be \"Ville de Longueuil\" \u2014 in English \u2014 \"City of Longueuil\"; 2.The territory of the new municipality shall be made of the actual territories of the two (2) amalgamated municipalities as defined in the technical description and shown on the plan, both of which have been prepared jointly by William-Patrick LaRochc and l.ouis Langlois, Québec Land Surveyors, and dated March 31, 1969, which said description and plan are annexed to these presents after having been signed by the mayor and by the clerk (annex 3 and 4) ; 3.The Cities and Towns Act (S.R.Q.1961.Ch.193) will govern the new municipality under reserve of the conditions of the amalgamation as stated in these presents; 4.The legislative provisions governing the two (2) municipalities before their amalgamation, namely the charter of the City of Longueuil.(7 Edward VII, (1907) ch.71), ami the charter of the City of Jacques-Cartier, (11 George VI.(1947), ch.102), and their amendments shall cease to apply to the territory of the new municipality under the reserve of the following provisions! (a) Legislative provisions which arc retained from the charter of the City of Longueuil (annex 5): 7 Edward VII (1907), chapter 71, section 52._ 3 George V (1912), chapter 64, sections 7 and 10.8 George V (1918), chapter 90, section 10.13 George V (1922), chapter 96, section 3.20 George V (1930), chapter 115, sections 1 and 2.25-26 George V (1935), chapter 126, section 6.5 George VI (1941), ch.78, sections 1, 2, 3 and 4.9 George VI (1945), chapter 82, sections I, 2, 5, 6, 7 and 8.12 George VI (1948), chapter 60, sections I.3 and 4.II George VI (1950).ch.97.section 1.14-15 George VI (1951), chapter 82, section I. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2.379 2-3 Eliz.II (1954), chapitre 79, articles 5,6 et 7.5-0 Eliz.II (1957), chapitre 85, articles 2 et 4.7-8 Eliz.II (1959), chapitre 65, articles 1 ct 6.8-9 Eliz.II (1900), chapitre 120, articles 1,2, 3 ct 5.11-12 Eliz.II (1963), chapitre 83, article 7.12-13 Eliz.II (1964), chapitre 84, articles 3, 1 ct 5.13-14 Eliz.II (1965), chapitre.100, article 1.15-16 Eliz.II (1966-67), chapitre 106.b) Dispositions conservées de la charte dc la cité de Jacques-Cartier (annexe 6) : 11 George VI (1947), chapitre 102, article 12.12 George VI (1948), chapitre 74, articles4ct 6.14 George VI (1950), chapitre 102, articles 12, 13, 14 et 16.14-15 George VI (1950-51), chapitre 19.15-16 George VI (1951-52), chapitre 81, articles 2 ct 3.4-5 Eliz.II (1955-56), chapitre 77, articles 9 et 12.6-7 Eliz.II (1957-58), chapitre 60, article 7.14-15 Eliz.II (1966), chapitre 22.15-16 Eliz.II (1966-67), chapitre 100, articles 5ct 10.5° La premiere élection générale tic la nouvelle municipalité aura lieu le premier dimanche de novembre 1970; 6° Jusqu'à la première élection générale, lc conseil qui a lc pouvoir d'administrer la nouvelle municipalité est un conseil provisoire composé dc 12 personnes, soit un maire ct onze conseillers; 7° Lc muirc de la cité dc Jacques-Cartier en fonction à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes est lc maire de la nouvelle municipalité ct lc demeure jusqu'au premier jour de novembre 1969; 8° Lc maire dc la cité dc Longueuil en fonction à la date dc l'entrée en vigueur des lettres patentes est le maire suppléant; à ce titre, il possède tous les pouvoirs du maire quand il doit le remplacer en cas d'absence ou d'incapacité; ct il assume la charge dc maire uu premier novembre 1969 ou avant cette date s'il y a vacance dc la charge; par la suite, le conseil nomme un maire suppléant tous les trois mois; 9° Cinq conseillers sont nommés au conseil provisoire par le conseil de la cité dc Jacques-Cartier et cinq par le conseil dc la cité dc Longueuil; Ces nominations se font par résolution avant la date dc l'entrée en vigueur tics lettres patentes ct à une séance du conseil que le maire seul peut et doit présitler; Si les nominations au conseil provisoire n'ont pas été ainsi faites, le ministre des Affaires Municipales les fait; 10° Toute vacance dans le conseil entre la date cdagogical\".3.By replacing the fifth paragraph of section 28.05 by the following: \"He approves or modifies the budget of each department, prepares the budget of his fuculty and presents it to the rector; he participates in its discussion with the officers of the university.\" 4.By striking out in first paragraph of section 28.13 the word \"pedagogical\".Makc Biiièue, 28801-o Attorney for the Université de Montréal.Ventes d'effets non-réclames La Cic des Messageries Canadien Pacifique Avis est par les présentes donné que tous les effets reçus avant le 1er jour de mai 1968, et non réclamés nux bureaux des Messageries Canadien Pacifique, à divers endroits de la province de Québec, seront vendus aux enchères publiques nu plus haut enchérisseur par Frank Waddington, encanteur, 189 est, rue Queen, Toronto, Ontario, à onze heures du matin, le 8e jour de mai 1969, à moins que lesdits effets ne soient réclamés ct tous les frais payés avant cette date.La Cie des Messageries Canadien Pacifique.Le vice-président & gérant général, 28647-14-5-0 W.1.Bowers.Sales of Unclaimed Baggage Canadian Pacific Express Company Notice is hereby given that all goods received previous to the first day of May 1968, and still remaining unclaimed in the office of the Canadian Pacific Express Company, at different points hi the Province of Québec, will be sold at public auction to the highest bidder by Frank Waddington, Auctioneer, at 189 Queen Street East, Toronto, Ontario, at 11.00 o'clock in the forenoon, on the 8th day of May, 1969, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.Canadian Pacific Express Company.W.J.Bowers, 28647-15-5 Vice President «t- Genera/ Manager. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2385 Syndicats professionnels Professional Syndicates L'Association des Travailleurs de Fonderie dc Montréal .Avis est donné que lc secrétaire de la province a, le 26 février 1969, décrété la fin de l'existence corporative de « L'Association des Travailleurs de Fonderie de Montréal », dont la constitution, a été autorisée lc 21 septembre 1965, ct dont lc siège social est situé a Montréal, et ce, en vertu dc l'article 25 de la Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Québec, lc 27 février 1969.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.28805-o 92-65 Fraternité des Travailleurs en Fabrication d'Autobus (Loi des syndicats professionnels) La constitution d'un syndicat professionnel, sous lc nom dc « Fraternité des Travailleurs en Fabrication d'Autobus», a été autorisée par le Secrétaire de la province lc 3 avril 1969.Lc siège social dudit syndicat professionnel est situé ù Saint-Line, district judiciaire dc Jolictte.Québec, le 10 avril 1969.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.28861-0 15-69 Association des Camionneurs Artisans du Comté dc Matane (Loi des syndicats professionnels) Lu constitution d'un syndicat professionnel, sous lc nom dc « Association des Camionneurs Artisans du Comté dc Matane », a été autorisée par le Secrétaire «le la province le 11 avril 1969.Lc siège social dudit syndicat professionnel est situé ù Saint-Luc, district judiciaire de Rimouski.Quebec, le 15 avril 1969.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.28862-a 24-69 Association des Camionneurs Artisans du Comté dc Matapédia (Loi des syndicats professionnels) La constitution d'un syndicat professionnel, sous lc nom dc - Association des Camionneurs Artisans du Comté dc Matapédia», a été autorisée par lc Secrétaire de la province le 14 avril 1969.Lc siège social dudit syndicat professionnel est situé ù Causapscul, district judiciaire dc Rimouski.Québec, le 15 avril 1969.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.28863-0 23-69 Syndicat National des Travailleurs Unis dc St-Basile (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que le secrétaire de la province n, lc 5 mars 1969, autorisé lc changement dc nom du « Syndicat National Catholique des Travail- L'Association des Travailleurs de Fonderie de Montréal Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on February 26, 1969, decreed the end of the corporate existence of \"L'Association des Travailleurs de Fonderie dc Montréal\", the incorporation of which was authorized on September 21, 1965, and the head office of which is situated in Montreal, and such, pursuant to section 25 of the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, chapter 146.Québec, February 27, 1969.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.28805 92-65 Fraternité des Travailleurs en Fabrication d'Autobus (Professional Syndicales Act) The incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Fraternité des Travailleurs en Fabrication d'Autobus\", has been authorized by the Provincial Secretary on April 3, 1969.The head office of the said professional syndicate is situated at Saint-Lin, judicial district of Joliette.Québec, April 10, 1969.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.28861 15-69 Association des Camionneurs Artisans du Comté de Matane (Professional Syndicales Act) The incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Association des Camionneurs Artisans du Comté de Matane\", has been authorized by the Provincial Secretary on April 11, 1969.The head office of the said professional syndicate is situated at Saint-Luc, judicial district of Rimouski.Québec, April 15,1969.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.28862 24-69 Association des Camionneurs Artisans du Comté de Matapédia (Professional Syndicates Act) The incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Association des Camionneurs Artisans du Comté de Matapédia\", has been authorized by the Provincial Secretary on April 14,1969.The head office of the said professional syndicate is situated at Causapscal, judicial district of Rimouski.Québec.April 15,1969.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.28863 23-69 Syndicat National des Travailleurs Unis de St-Basile (Professional Syndicales Act) Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on March 5, 1969, approved the change of name of \"Syndicat National Catholique 2386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 leurs Unis de St-Basile », dont lu constitution a été uutorisée le 25 murs 1052, ct dont lc siège social est situé il Saint-Basile, en celui dc « Syndicat National tics Travailleurs Unis de St-Basile », et ce, en vertu dc la Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Québec, le 10 mars 1969.Le sous-secrélaire de la province, Raymond Douville.28864-e 079-52 des Travailleurs Unis de St-Busilc\", the incorporation of which was authorized on March 25, 1952, and the head office of which is situutcd in Saint-Basilc, to that of \"Syndicat Nationul des Travailleurs Unis dc St-Basilc\", and such, pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, chapter 146.Québec, March 10,1969.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.28864 679-52 Ministère de l'Éducation Department of Education Des Chenaux Demande est faite de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires de Ste-Gcnc-vièvc-dc-Bntiscan, St-Luc, St-Narcisse, St-Pros-per ct St -Stanislas, dans lc comté de Champlain, et de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom « des Chenaux », dans lc comté de Champlain.Québec, le 3 avril 1969.Le ministre de l'Éducation, 28751-15-2-0 Jean-Guy Cardinal.Ville d'East-Angus (Cath.) Demande est faite d'annexer, pour les catholiques seulement, le territoire actuel des municipalités scolaires dc Bury (Cath.), St-Camillc-de-Cookshirc (Cath.), St-Paul-dc-Scotstown (Cath.) ct Sawycrvillc (Cath), dans lc comté de Compton, à la municipalité scolaire dc la ville d'East-Angus (Cath.), dans lc comté dc Compton.Québec, le 3 avril 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.28769-15-2-0 165-06 Argcnteuil (Prot.) Il u plu uu lieutenunt-gouvcrneur, pur arrêté en conseil no 1056, en date du 2 avril 1969, dc fusionner le territoire actuel îles municipalités scolaires de Town of I.achutc (Prot.), dans les comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes et Vau-drcuil-Soulanges; dc Brownsburg (Prot.), duns le comté d'Argenteuil, ct dc l'ériger, pour les protestunts seulement, sous lc nom de Argcnteuil (Prot.), dans les comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes et Vaudreuil.Lc nombre des commissaires d'écoles pour cette nouvelle municipalité est fixé il sept (7).Pour les fins d'élection, son territoire est divisé en deux quartiers, numérotés, représentés ct délimités comme suit: Le quartier numéro 1, représenté par quatre commissaires, comprend lc territoire actuel de la municipalité scolaire dc Town of I.achutc (Prot.).Lc quartier numéro 2, représenté par trois commissaires, comprend le territoire actuel dc la municipalité scolaire dc Brownsburg (Prot.).Ces changements prennent effet pour fins «l'élection, le 1er juin 1969 ct pour toutes autres fins, lc 1er juillet 1969.Quéliec, le 10 avril 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.28854-0 950-01 Aylmcr-Rapides-dcs-Chêncs Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil no 1056, en dutc du 2 avril 1969, dc Des Chenaux A request is made to amalgamate the actual territory of the school municipalities of Stc-Gcnevièvc-dc-Botiscan, St-Luc, St-Narcisse, St-Prosper and St-Stanislas, in the comity of Champlain, and to erect it into a new school municipality under the name of \"des Chenaux\", in the county of Champlain.Québec, April 3,1969.Jean-Guy Cardinal, 28751-15-2 Minister of Education.Town of East-Angus (Cath.) A petition is made to annex, for Catholics only, the actual territory of the school municipalities of Bury (Cath.),St-Camille-de-Cookshire (Cath.), St-Paul-dc-Scotstown (Cath.) and Sawycrvillc (Cath.), in the county of Compton, to the school municipality of the town of East-Angus (Cath.), in the county of Compton.Québec, April 3, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28769-15-2 165-06 Argcnteuil (Prot.) The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1056 dated April 2, 1969, to amalgamate the present territory of tin-school municipalities of Town of I.achutc (Prot.I, in the counties of Argcnteuil, Deux-Montagnes and Vaudrcuil-Soulanges; of Brownsburg (Prot.) in the county of Argentcuil, and to erect it into a new municipality, for Protestants only, under the name of Argentcuil (Prot.), in the counties of Argentcuil, Deux-Montagnes and Vaudreuil.The number of school commissioners for the new municipality shall lie fixed at seven (7).For election purposes, its territory shall be divided into two wards numbered, represented and limited as follows: Ward Number 1, represented by four commissioners, covers the present territory of tin-school municipality of the Town of I.uchute (Prot.).Ward Number 2, represented by three commissioners, covers the present territory of the school municipality of Brownsburg (Prot.).These changes shall take effect from and after June 1, 1969 for election purposes and July I, 1969 for all other purposes.Québec, April 10, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28854 950-01 Aylmcr-Rapidcs-dcs-Chciics The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1056 dated April 2, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 detacher de la municipalité scolaire de St-Êtiennc-dc-Chelsea, dans le comté de Gatincau, les lots 19 à 28 inclusivement du rang VII et 22 à 28 inclusivement du rang VIII du cadastre officiel du canton de Hull, ct de les annexer, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire d'Aylmer-Rapides-tlcs-Chênes, dans le comté de (îatineau.Ce changement prend effet pour fins d'élection, le 1er juin 1969 ct pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, lc 10 avril 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.28854-o 610-02 Chaudifcrc-Etchcmin 11 a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1056, en date du 2 avril 1969, de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires de Charny, Ste-Hélène-de-Breakeyville, St-Lambert, St-Romuald-d'Etchemin ct Très-St-Uédcmptcur, dans le comté de Levis, ct de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de Chaudière-Etchcmin, dans le comté dc Lévis.Lc nombre des commissaires d'écoles |>our cette nouvelle municipalité est fixé à sept (7).Pour fins d'élection, sont territoire est divisé en cinq quartiers, nommés, délimités ct représentés comme suit, savoir: Le quartier St-Romuald, représenté par deux commissaires et comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Romuald-d'Etchemin.Le quartier Charny, représenté par deux commissaires ct comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire dc Charny.Lc quartier Breakeyville, représenté par un commissaire et comprenant le territoire actuel «le la municipalité scolaire dc Ste-Hélène-de-Brcakcy ville; Le quartier St-Lambert, représenté par un commissaire et comprenant le territoire actuel île la municipalité scolaire de St-Lambert.Lc quartier St-Rédempteur, représenté par un commissaire et comprenant lc territoire actuel de la municipalité scolaire de Très-St-Rédcmp-leur.Ces changements prennent effet pour fins d'élection, le 1er juin 1969 et pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, le 9 avril 1969.Le ministre dc l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.28854-0 750-04 Cowansville 11 a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté conseil No 1056, en date du 2 avril 1969, dc changer le nom de la municipalité scolaire de Stc-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, dans les comtés de Brome et Missisquoi, en celui dc Cowansville, dans les comtés dc Brome ct Missisquoi.Ce changement prend effet 8 jours après la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec.Québec, le 10 avril 1969.Le ministre dc l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.2S854-0 580-01 2387 1969, to detach from the school municipality of St-Étienne-dc-Chelsea, in the county of Gatineau, lots 19 to 28 inclusively of Range VII and 22 to 88 inclusively of Range VIII on the official cadastre of the township of Hull, and to annex them, for the Catholics only, to the school municipality of Aylmcr-Rapides-des-Chênes, in the county of Gatineau.This change shall take effect for election purposes on June 1, 1969, and on July 1, 1969 for all other purposes.Québec, April 10, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28854 610-02 Chaudicrc-Elchcniin The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1056 dated April 2, 1969, to amalgamate the present territory of the school municipalities of Charny, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Lambert, Saint-Romuald-d'Etchcmin and Très-Saint-Rédempteur, in the county of Levis, and to erect it into a new school municipality under the name of Chaudière-Etchcmin, in the county of Levis.The number of the school commissioners for this new municipality shall be fixed at seven (7).For election purposes, its territory shall be divided into five wards, named, delimited and represented as follows, to wit: Saint-Romuald Ward, represented by two commissioners and covering the present territory of the school municipality of Saint-Romuahl-d'Etchemin.Charny Ward, represented by two commissioners and covering the present territory of the school municipality of Charny.Breakeyville Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Sainte-Hélènc-de-Breakeyvillc.Saint-Lambert Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Lambert.Saint-Rédempteur Ward, represented by one commissioner antl covering the present territory of the school municipality of Très-St-Rédem-teur.These changes shall take effect on June 1, 1969 for election purposes antl on July 1, 1969 for all other purposes.Québec, April 9, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28865 750-04 Cowansville The Licutenunt-Govcrnor has been pleased! by Order in Council No.1056 dated April 2, 1969, to change the name of the school municipality of Sainte-Tliérèse-de-1'Enfant-Jésus, in the counties of Brome antl Missisquoi, into that of Cowansville, in the counties of Brome antl Missisquoi.This change shall take effect eight days from and after the publication of this notice in the Québec Official Gazette.Québec, April 10, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28854 5S0-01 2388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, »\u2022 16 Dolbeau Il a pju au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil no 1056, en date du 2 avril 1969, de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires dc la ville de Dolbeau, Notre-Damc-dc-Lorette, St-Eugènc et St-Stanislas, dons le comté dc Roberval, et dc l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom dc Dolbeau, dans lc comté de Roberval.Le nombre des commissaires d'écoles pour cette nouvelle municipalité est fixé à sept (7).Pour fins «l'élection, son territoire est divisé en quatre quartiers, nommés, délimités et représentés comme suit, savoir: Le quartier Dolbeau, représenté par quatre commissaires et comprenant le territoire actuel île la municipalité scolaire dc la ville dc Dolbeau.Le quartier St-Stanislas, représenté par un commissaire ct comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire dc St-Stanislas; Le quartier St-Eugône, représenté par un commissaire et comprenant le territoire actuel dc la municipalité scolaire dc St-Eugène; Le qunrtier Notrc-Damc-dc-Lorcttc, représenté par un commissaire et comprenant lc territoire actuel de la municipalité scolaire de Notre-Dame-dc-Lorette.Ces changements prennent effet pour fins d'élection, lc 1er juin 1969 et pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, le 9 avril 1969.Le ministre de l'Education, Jean-Guy Cardinal.28854-0 495-03 Doniiacona Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil no 1056, en date du 2 avril 1969, d'annexer lc territoire actuel dc la municipalité scolaire de Les Êcureils, dans le comté de Port-neuf, à la municipalité scolaire de Donnacona, dans le comté dc Portncuf.Ce changement prend effet pour fins d'élection, lc 1er juin 1969 ct pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, le 9 avril 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.28854-0 740-02 Farnhani Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1056, en date du 2 avril 1969, d'annexer, pour les protestants seulement, le territoire actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles pour la municipalité de Stc-Brigide, dans le comté d'Iberville, au territoire sous la juridiction des syndics d'écoles pour la municipalité de Farnhani, dans les comtés d'Iberville ct Missisquoi.Ce changement prend effet le 1er juillet 1969.Québec, le 10 april 1969.Le ministre dc l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.28854-u 900-01 La Tuque (Prot.) 11 a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1056, en date du 2 avril 1969, d'ériger en une nouvelle municipalité scolaire, pour les protestants seulement, le territorc ci-dessous décrit, qui comprend le territoire actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles Dolbeau The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1056 dated April 2, 1969, to amalgamate the present territory of the school municipalities of the town of Dolbeau, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Eugène and Saint-Stanislas, in the county of Roberval, and to erect it into a new school municipality under the name of Dolbeau, in the county of Roberval.The number of the school commissioners for this new municipality shall be fixed at seven For election purposes, its territory shall be divided into four wards, named, delimited and represented as follows, to wit: Dolbeau Ward, represented by four commissioners and covering the present territory of the school municipality of the town of Dolbeau.Saint-Stanislas Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Stanislas.Saint-Eugène Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Eugène.Notre-Damc-de-Lorette Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Nolrc-Dame-dc-Lorette.These changes shall take effect on June 1, 1969 for election purposes, and on July 1, 1969 for all other purposes.Québec, April 9, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28854 495-03 Doiiiiucona The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1056, dated April 2, 1969, to annex the present territory of the school municipality of Les Écureuils, in the county of Porlneuf, to the school municipality of Donnacona, in the county of Portncuf.This change shall take effect on June 1, 1969 for election purposes and on July 1, 1969 for all other purposes.Québec, April 9, 1969.Jean Guy Cardinal, Minister of Education.28854 740-02 Farnhani The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council dated April 2, 1969, to annex, for Protestants only, the territory now under the jurisdiction of the school trustees for the municipality of Sainte-Brigidc, in the county of Iberville, to the territory now under the jurisdiction of the school trustees for the municipality of Farnham, in the counties of Iberville and Missisquoi.This change shall take effect on July 1, 1960.Québec, April 10, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28854 900-01 La Tuque (Prot.) The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1056 dated April 2, 1900.to erect into a new school municipality, for Protestants only, the territory described hereunder, covering the territory now under the jurisdiction of the school trustees for the municipality i.QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2389 pour la municipalité de la ville de La Tuque, dans le comté de Laviolette, sous le nom de La Tuque, dans le comté de Laviolette.I Les cantons Lamy, Dandurand, Lctondal, Lnvignc, Hamcl, Dessane, Lavallée, Chouinard, Wcymontachinguc, Albani, Ingall, Rhéaumc, ('adieux, Clouticr, Payment, Adams, Langelier, Dumoulin, Tourouvre, Bourgeoys, Mailhot, Turcotte, Vallières, Charcst, Laurier, Pothier, Cari-gnan, Polctte, Lapcyrcrc ct Boucher; 2° Les rangs VI à IX inclusivement du canton Hackctt; 3° Toute cette partie de la seigneurie de Batis-can comprenant les rangs ouest, Il est et tous les lots du rang est limité au sud-est à la rivière Caribou.Ce ebangment prend effet pour fins d'élection, le 1er juin 1969 et pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, lc 10 avril 1969.Lé ministre dc l'Education, Jean-Guy Cardinal.28854-0 510-01 La Vallièrc II a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil no 1056, en date du 2 avril 1969, de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires dc Rivière-au-Doré, St-Félicien ct St-Méthode, dans le comté dc Roberval, ct de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous lc nom dc La Vallièrc, dans le comté dc Roberval.Lc nombre des commissaires d'écoles pour cette nouvelle municipalité est fixé à sept (7).Pour fins «l'élection, son territoire est divisé en trois quartiers, numérotés, délimités ct représentés comme suit, savoir: Le quartier Xo 1, représenté par un commissaire et comprenant le territoire actuel dc la municipalité scolaire de St-Méthode.Lc quartier Xo 2, représenté par deux commissaires et comprenant lc territoire actuel de la municipalité scolaire dc Rivière-au-Doré.Le quartier Xo 3, représenté par quatre commissaires et comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Félicien.Ces changements prennent effet pour fins d'élection, lc 1er juin 1969 ct pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, le 9 avril 1969.Le ministre de l'Education, Jean-Guy Cardinal.28854-o 495-02 Lennoxville Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil no 1056, en date du 2 avril 1969, d'annexer, pour les protestants seulement, le territoire actuel dc la municipalité scolaire de Compton-Watervillc (Prot.), dans le comté de Compton, à la municipalité scolaire de Lcmiox-ville, dans lc comté de Sherbrooke.Ce changement prend effet pour fins d'élection, le 1er juin 1969 et pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, lc 10 avril 1969.Le ministre de l'Education, 28854-0 Jean-Guy Cardinal.L'Érahlicrc Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil Xo 1056, en date du 2 avril 1969, de fusionner lc territoire actuel des municipalités of the town of La Tuque, in the county of Laviolette, under the name of La Tuque, in the county of Laviolette.1.The townships of Lamy, Dandurand, Le-tondal, Lavigne, Hamel, Dessane, Lavallée, Chouinard, Weymontachinguc, Albani, Ingall, Rhéaume, Cadieux, Cloutier, Payment, Adams, Langelier, Dumoulin, Tourouvre, Bourgeoys, Mailhot, Turcotte, Vallières, Charcst, Laurier, Pothier, Carignan, Polette, Lapcyrere and Boucher; 2.Ranges VI to IX inclusively of the township of Hackctt; 3.The whole part of the Seigneurie de Batiscan covering west, II east ranges and all the lots of range east limited on the southeast by the Caribou River.This change shall take effect for election purposes on June 1, 1969, and for all other purposes on July 1,1969.Québec, April 10, 1969.Jean-Guy Cardinal, M initier of Education.28854 510-01 La Vallièrc The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council Xo.1056 dated April 2, 1969.to amalgamate the present territory of the school municipalities of Rivière-au-Doré, Saint-Félicien and Saint-Méthode, in the county of Roberval, and to erect it into a new school municipality under the name of La Vallièrc, in the county of Roberval.The number of the school municipalities for this new municipality shall be fixed at seven (7).For election purposes, its territory shall be divided into three wards, numbered, delimited and represented as follows, to wit: Ward Number 1, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Méthode.Ward Number 2, represented by two commissioners and covering the present territory of the school municipality of Rivière-au-Doré.Ward Number 3, represented by four commissioners, and covering the present territory of the school municipality of Saint-Félicien.These changes shall take effect on June 1, 1969 for election purposes and on July 1, 1969 for all other purposes.Québec, April 9, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.2885-1 495-02 Lennoxville The Lieutenant-Governor bus been pleased, by Order in Council Xo.1056 dated April 2, 1969, to annex, for Protestants only, the present territory of the school municipality of Compton-Watcrville (Prot.), in the county of Compton, to the school municipality of Lennoxville, in the county of Sherbrooke.This change shall take effect on June 1.1969 for election purposes, and on July I, I960 for all other purposes.Québec, April 10, 1969.Jean-Guy Cardinal, 28854 Minister of Education.L'Erablicrc The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council number 1056 dated April 2,1969.to amalgamate the present territory of the school 2390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 scoluircs dc Notre-Dame-de-Lourdcs, Stc-Béa-trix, Slc-Eliznbcth, Stc-Émélic-dc-rÉnergie, St-Félix-dc-Volois et St-Jcan-de-Matha, dans le comte dc Joliette, et St-Zénon, dons le comté de Bcrthicr, ct dc l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de L\" Erablière, dans les comtés dc Berliner ct Joliette.Lc nombre des commissaires d'écoles pour cette nouvelle municipalité est fixé ù neuf (9).Pour fins d'élection, son territoire est divisé en sept quartiers, numérotés, délimités ct représentés comme suit, savoir: Lc quartier No 1, représenté pur un commissaire ct comprenant lc terrilire actuel de la municipalité scolaire de Notro-Damc-dc-Lourdcs; Lc quartier No 2, représenté par un commissaire ct comprenant lc territoire actuel de la municipalité scolaire de Stc-Elizabctb; Lc quartier No 3, représenté par deux commissaires et comprenant lc territoire actuel de la municipalité scolaire dc St-Félix-dc-Valois; Le quartier No 4, représenté par un commissaire ct comprenant lc territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Jean-de-Matha; Lc quartier No 5, représenté par un commissaire et comprenant lc territoire actuel dc la municipalité scolaire dc Stc-Béatrix; Lc quartier No 0, représenté par un commissaire ct comprenant le territoire actuel dc la municipalité scolaire de Stc-Émélic-dc-rÉnergie; Lc quartier No 7, représenté par deux commissaires ct comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire dc St-Zénon.Ces changements prennent effet pour fins d'élection, lc 1er juin 1969 ct pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, lc 9 avril 1969.Le ministre de i Éducation, Jean-Guy Cardinal.28854-0 340-07 Monseigneur Vuchon 11 a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1056, en date du 2 avril 1969, de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires dc St-Bcrnardin, Ste-Cbristinc, St-1 .énnard ct St-Raymond dans le comté de Port-neuf, ct île l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de Monseigneur Vacbon, dans le comté dc Portncuf.Lc territoire ci-dessus décrit, non encore organisé1 uu jioint de vue scolaire, est annexé à cette nouvelle municipalité scolaire: Lc territoire des cantons Roqucmont, Tonti, l.asalle ainsi que la partie nord ar un commissaire ct comprenant lc territoire actuel dc la municipalié scolaire de Girardvillc; Lc quartier St-Edmond, représenté pur un commissaire ct comprenant lc territoire actuel de lu municipalité scolaire de St-Edmond-les-Plaincs; Lc quartier St-Thomas, représenté par un commissaire et comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Thomas-Didymc; Lc quartier Alhaucl-Girardville, représenté par un commissaire ct comprenant cette partie de territoire située au nord du village d'Albàncl et limitée par les rangs VI et VII du canton Albancl «l'une part et V ct VI du canton Girard d'autre part.Ces changements prennent effet pour fins d'élection, lc 1er juin 1969 et pour toutes autres lins, le 1er juillet 1969.Québec, le 9 avril 1969.Le ministre Je l'Education, Jkan-Guy Cardinal.2S854-o 495-03 Nouvclle-Acadic Il a plu uu lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1056, en date du 2 avril 1969, dc fusionner lc territoire actuel des municipalities scolaires de St-Alexis, St-Jacques.St-Liguori ct Ste-Maric-Snlomé, dans le comté de Montcalm, ct St-Gérard-Magellu, dans lc comté dc l'Assomption, ct dc l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous lc nom dc Nouvclle-Acadic, duns les comtés dc l'Assomption ct Montcalm.Lc nombre îles commissaires d'écoles pour cette nouvelle municipalité est fixé ù sept (7).Pour fins d'élection, son territoire est divisé en cinq quartiers, nommés, délimités et représentés comme suit, savoir: Le quartier St-Jucques, représenté pur deux commissaires ct comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Jucques;\u2022 Le quartier St-Alexis, représenté |wr deux commissaires et comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Alexis; Le quartier St-Gérard, représenté par un commissaire ct comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Gérard-Magella; Lc quartier St-Liguori, représenté par un commissaire ct comprenant lc territoire actuel dc la municipalité scolaire de St-Liguori; l/c quartier Stc-Marie, représenté par un commissaire et comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire de Ste-Marie-Salonié.val, and to erect it into a new school municipality under the name of Normandin, in the county of Roberval.The number of the school commissioners for this new municipality shall be fixed at seven (7).For election purposes, its territory shall be divided into six wards, named, delimited and represented as follows, to wit: Normandin Ward, represented by two commissioners and covering the present territory of the school municipality of Normandin; Albancl Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Sainte-Lucie-d'Albancl ; Girardvillc Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Girardvillc; Saint-Edmond Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Edmond-Ics-Plaines; Saint-Thomas Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Thomns-Di-dymc; Albanel-Girardvillc Ward, represented by one commissioner and covering that part of territory situated on the north of the village of Albancl and limited by Ranges VI and VII of the township of Albancl on the one hand and by Ranges V and VI of the township of Girard on the other hand.These changes shall take effect on June 1, 1969 for election purposes, and on July 1, 1969 for nil other purposes.Québec, April 9, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28864 495-03 Nouvclle-Acadie The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council number 1056 dated April 1, 1969, to amalgamate the present territory of the school municipalities of Saint-Alexis, Saint-Jacques, Saint-l.iguori and Snintc-Maric-Sulomé, in the county of Montcalm, and Saint-Gérard-Magclla, in the county of L'Assomption, and to erect it into a new school municipality undur the name of Nouvellc-Acadie, in the counties of L'Assomption and Montcalm.The number of the school commissioners for this new municipality shall be fixed at seven (7).Por election purposes, its territory shall he divided into five wards, named, delimited and represented as follows, to wit: Saint-.laïques Ward, represented by two commissioners and covering the present territory of the school municipality of Saint-Jacques; Saint-Alexis Ward, represented by two commissioners and covering the present territory of the school municipality of Saint-Alexis; Saint-Gérard Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Gérnrd-Magclla; Saint- l.iguori Ward, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Liguori; Saintc-Mnric Ward, represented by'one commissioner and covering the present territory of the school mimicipalily of Sniiitc-Murie-Saloiné. 2394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 Ces changements prennent effet pour fins d'élection, le 1er juin 1969 ct pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, le 9 avril 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.28S54-c> 340-07 Princeville 11 a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1056, en date du 2 avril 1969, d'annexer lc territoire actuel des municipalités scolaires de Saint-Norbert-d'Artbabaska ct Sain t -Louis-dc-Blnndford, dans le comté d'Arthabaska, à la municipalité scolaire de Princeville, dans le comté d'Arthabaska.Lc nombre des commissaires d'écoles pour la municipalité de Princeville, dans le comte d'Arthabaska, est porté ù sept (7).Pour fins d'élection, son territoire est divisé en trois quurtiers, numérotés,- délimités et représentés comme suit, savoir: Lc quartier numéro 1, représenté par cinq commissaires ct comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire de Princeville; Lc quartier numéro 2, représenté par un commissaire ct comprenant le territoire actuel dc la municipalité scolaire dc Saint-Louis-de-Blondford; Le quartier numéro 3, représenté par un commissaire et comprenant le territoire actuel dc la municipalité scolaire de Snint-Norbcrt-d'Arthu-baska.Ces changements prennent effet pour fins d'élection, le 1er juin 1969 ct pour toutes autres fins, lc 1er juillet 1969.Québec, le 9 avril 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.28b54-o 010-03 Ristigouclie Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1056, en date du 2 avril 1969, de fusionner lc territoire actuel des municipalités scolaires dc Cross-Point (Cath.), L'Alvcrnc, Pata-pédia, St-André-dc-Ristigouchc, St-Alcxis-de-Ma-tnpédia, St-Fidèle-dc-Ristigoucbc.St-François-d'Assisc, St-Laurent-de-Matapé(lia ct Shoolbrcd diss., dans le comté dc Bonaventure, et de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de Ristigouclie, dans le comté de Bonaventure.lie nombre des commissaires d'écoles pour cette nouvelle municipalité est fixé à neuf (9).Pour fins d'élection, son territoire est divisé en cinq quartiers, numérotés, délimités et représentés comme suit, savoir: Lc quartier No 1, représenté par un commissaire ct comprenant lc territoire actuel dc la municipalité scolaire de Patapédia; Le quartier No 2, représenté par deux commissaires ct comprenant le territoire actuel de la municipalité scolaire dc St-François-d'Assisc; Lc quartier No 3, représenté par un commissaire et comprenant lc territoire actuel dc la municipalité scolaire dc St-Alexis-dc-Matapédia; Lc quartier No 4, représenté par un commissaire ct comprenant le territoire actuel des municipalités scolaires de St-Laurcnt-de-Matapédia ct St-André-dc-Ristigouche; Lc quartier No 5, représenté par quatre commissaires ct comprenant le territoire actuel des municipalités scolaires de St-FidcIc-dc-Ristigou-clic, L'Alvcrnc, Cross-Point (Cath.) ct Shoolbrcd diss.These changes shall take effect on June 1, I960 for election purposes and on July 1, 1969 for nil other purposes.Québec, April 9, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28854 340-07 Princeville The Lieutenant-Governor bus been pleased, by Order in Couucil number 1056 dated April 2.1969, to annex the present territory of the school municipalities of Saint-Norbert-d'Arthabaska and Saint-Louis-dc-Blanford, in the county of Artha-baska, to the school municipality of Princeville.in the county of Arthabaska.The number of the school commissioners for the municipality of Princeville, in the county of Arthabaska, shall be increased to seven (7).For election purposes, its territory shall he divided into three wards, numbered, delimited and represented as follows, to wit: Ward number 1, represented by five commissioners and covering the present territory of the school municipality of Princeville; Ward number 2, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Louis-de-Blandford: Ward number 3, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Norbert-d'Arthabaska.These changes shall take effect on June 1.1969 for election purposes, and on July 1, 1900 for all other purposes.Québec, April 9, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.28854 010-08 Ristigouclie The Licutcnunt-Governor has been pleased, by Order in Council No.1056, dated April 2, 1960, to amalgamate the present territory of the school municipalities of Cross-Point (Cath.), L'Alvcrnc.Patapédia, Saint-André-dc-Ristigouchc, Sain I-Alcxis-dc-Mntapédia, Saint-Fidèlc-de-Ristigoii-ebe, Saint-François-d'Assise, Saint-Laiircnt-dc-Matapédia and Shoolbrcd diss., in the county of Bonaventure, and to erect it into a new school municipality under the name of Ristigouclie, in the county of Bonaventure The number of the school commissioners for this new municipality shall be fixed at nine (9).For election purposes, its territory shall be divided into five wards, numbered, delimited and represented as follows, to wit: Ward No.1, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Patapédia; Ward No.2, represented by two commissioners and covering the present territory of the school municipality of Saint-François-d'Assise; Ward No.3, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipality of Saint-Alcxis-de-Matapédia; Ward No.4, represented by one commissioner and covering the present territory of the school municipalities of Saint-Laurent-dc-Mnlapédia and Saint-André-dc-Ristigouchc; Ward No.5, represented by four commissioners and covering the present territory of the school municipalities of Siiint-Fidèlc-dc-Ristigouclie.L Alverne, Cross-Point (Cath.) and Shoolbrcd diss. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 Ces changements prennent effet pour fins d'élection, lc 1er juin 1969 et pour toutes autres fins, lc 1er juillet 1969.Québec, lc 9 avril 1969./our obligations » seront reçues par lc soussigné loland Royal, secrétaire-trésorier, jusqu'il 8 heures du soir, Bureau dc la Corporation, 1200, rue Principale, case postale 150, Village de Saint-Zotiquc, comté dc Soulanges, P.Q., ct par après jusqu'il 8 heures 30 du soir.Salle des Réunions du Conseil, village dc St-Zotique, comté de Soulanges, P.Q., mardi, le 6 mai 1969, pour l'achat de $250,000 d'obligations du village dc Snint-Zoti-que, comté de Soulanges, datées du 1er mai 1969 et remboursables par séries du 1er mai 1970 au 1er mai 1989 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable scmi-nnnucllcment les 1er mai ct 1er novembre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou «les amortissements annuels entiers, tels «juc montrés aux tableaux «l'amortissement dans lc présent avis.Règlement no: 162 \u2014 $250,000 \u2014 aqueduc, égoûts.Pour fins l'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1969.Tableau d'amortissement \u2014 $200,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1970.$ 2,500 1er mai 1971.2,500 1er mai 1972.3,000 1er mai 1973 .3,000 1er mai 1974 .3,000 1er mai 1975.3,500 1er mai 1976.3,500 1er mai 1977.4,000 1er mai 1978.4,500 1er mui 1979.4,500 1er mai 1980 .5,000 1er mai 1981.5,500 1er mai 1982 .6,000 1er mai 1983.6,000 1er mai 1984.6,500 1er mai 1985-.7,000 1er mai 1986 .7,500 1er mai 1987.8,000 1er mai 1988 .9,000 1er mail 989.155,500 Dc plus, «les soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 10 ans ou à courte échéance 15 ans.Également, des soumissions seront reçues ct considérées pour des obligations en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans, pourvu toutefois que cette dernière partir ne soit pus pour un montant inférieur a $19,500, ct si supérieur à ce dernier montant cette partie devra compremlrc qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans lc présent avis, et en commençant par les dernière années d'échéances «le la partie renouvelable ci-après mentionnée.Cependant, les soumissions ne «levront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter (]u'un seul des termes sauf dans lc cas dc l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément à la loi.Village dc Saint-Zotiquc County of Soulanges Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Roland Royal, Secretary-Treasurer, until 8:00 o'clock p.m.Office of the Corporation, 1200 Main Street.P.O.Box 150, Village of St-Zotiquc, county of Soulanges, P.Q., and afterwards, until 8:30 o'clock p.m.Council Meeting Hall, Village of St-Zotique, county of Soulanges P.Q., Tuesday.May 6, 1969, for the purchase of an issue of 8250,000 of bonds for the Village of Saint-Zotiquc, county of Soulungcs, dated May 1, 1969, and redeemable serially from May 1, 1970 to May 1.1989 inclusively, with interest at a rate not less than 7% nor more than 8% payable semiannually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue.However, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or more entire annual amortizations, such ns shown on the tables of redemption in the present notice.By-law No: 162 \u2014 $250,000 \u2014 aqueduct, sewers.For adjudication only, interest will be calculated as from May 1, 1969.Table of redemption \u2014 $250,000 \u2014 20 years Year Capital May 1, 1970.$ 2,500 May 1,1971.2,500 May 1, 1972 .3,000 May 1,1973 .3,000 May 1, 1974 .3,000 May 1, 1975.3,500 May 1, 1976 .3,500 May 1,1977 .4,000 May 1, 1978 .4.500 May 1,1979 .4,500 May 1, 1980 .5,000 May 1, 1981.5,500 May 1,1982 .6,000 May 1,1983 .6,000 May 1, 1984 .6,500 May 1, 1985 .7,000 May 1, 1986.7,500 May 1,1987 .8,000 May 1, 1988 .9,000 May 1,1989.155,500 Moreover, tenders may be sent and shall be considered for ten-year short-term of fifteen-year short-term serial bonds.Also, tenders will be received and considered for ten-year serial bond- with the baluncc being partly for ten-year short-term and portly for twenty-year fixed-term bonds, provided, however, that this latter part be for an amount not less than $19,500.and if higher than this latter amount, this part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and staring by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of t lie terms, save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 19G9, Vol.101, No.16 2399 L'échéance du 1er mai 1989 au montant dc 8155,500 comprend un solde de $146,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, ct échéant comme suit: Année Capilal 1er mai 1990.$10,500 1er mai 1991.11,000 1er mai 1992.12,000 1er mai 1993.13,000 1er mai 1994.13,500 1er mai 1995.15,000 1er mai 1996.16,000 1er mai 1997.17,000 1er mai 1998.18,500 1er mai 1999.19,500 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Côtcau-Landing.Le capital ct les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dent le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesditcs obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre de $155,500.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $155,500, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, nu pair, lc 1er mai dc chaque année pour lc montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances dc l'émission apparaissant dans lc présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes ct considérées ù une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le 6 mai 1969, ù 8 heures 30 du soir, Salle des Réunions du Conseil, village dc Saint-Zotique, comté de Soulanges, P.Q.Lc conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Zotiquc (Comté dc Soulanges), ce 26 mars 1969.Le secrétaire-trésorier, Roland Royal.Bureau de la Corporation, 1200, rue Principale, Case postale 150, Village de Saint-Zotiquc (Soulanges), P.Q.Téléphone : 267-3535, code 514.28859-0 Ville dc Chibougamau Comté d'Abitibi-Est Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées ct endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Germain-M.Julien, greffier, Hôtel de ville, 650, 3ième rue, case postale 876, Chibougamau, comté d'Abitibi-Est, P.Q., jusqu'à 7.30 heures du soir, mardi, le 6 mai 1969, pour l'achat dc $250,000 d'obligations de la ville de Chibougamau, comté d'Abitibi-Est, datées du 1er mai 1969, ct remboursables par séries du 1er mai 1970 au 1er mai 1989 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable scmi-annucllcmcnt les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant The May 1, 1989 maturity in the amount of $155,500 comprises a balance of $146,000 renewable for an additional ten-year period maturing as follows: Year Capital May 1, 1990.$10,500 May 1,1991.11,000 May 1,1992.12,000 May 1,1993.13,000 May 1, 1994.13,500 May 1, 1995.15,000 May 1,1996.16,000 May 1,1997.17,000 May 1,1998.18,500 May 1, 1999.19,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued' interest, if any, by certified cheque payable at par at Coteau Landing.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation when issued serially or serially and as twenty-year fixed-term bonds, for an amount equal to or less than $155,500.However, if they are issued partly as twenty-year fixed-term bonds for an amount higher than $155,500, the bonds so issued shall be redeemable by anticipation at par, on Moy 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of maturity of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.Tenders will be opened at a meeting of the council to be held on Tuesday, May 6, 1969, at 8:30 o'clock p.m., Council Meeting Hall, Village of St-Zotique, county of Soulanges, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Zotique (County of Soulanges), March 26, 1969.Roland Royal, Secretary- Treasurer.Office of the Corporation, 1200 Main Street, P.O.Box 150, Village of Saint-Zotique (Soulanges), P.Q.Telephone: 267-3535, code 514.28859 Town of Chibougamau County of Abitibi-East Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Germain-M.Julien, Town _Clerk, Town Hall, 650, 3rd Street, P.O.Box 876, Chibougamau, county of Abitibi-East, P.Q., until 7:30 o'clock p.m., Tuesday, May 6, 1969, for the purchase of an issue of $250,000 of bonds for the town of Chicougamau, county of Abitibi-East, dated May 1, 1969 and redeemable serially from May 1, 1970 to May 1, 19S9 inclusively, with interest at a rate not less than 7%, nor more than 8%, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must 2400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n' 16 émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlement No: 135 \u2014 $250,000 \u2014 aqueduc, égoûts.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé ù compter du 1er mai 1969.Tableau d'amortissement \u2014 $250,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1970.$ 6,000 1er mai 1971.6,000 1er mai 1972 .6,500 1er mai 1973 .7,000 1er mai 1974 .7,500 1er mai 1975 .8,000 1er mai 1976.9,000 1er mai 1977 .9,500 1er mai 1978.10,500 1er mai 1979.11,000 1er mai 1980.12,000 1er mai 1981.13,000 1er mai 1982.13,500 1er mai 1983.15,000 1er mai 1984.16,000 1er mai 1985.17,000 1er mai 1986.18,500 1er mai 1987 .20,000 1er mai 1988 .21,000 1er mai 1989.23,000 Dc plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations en séries a courte échéance 10 ans ou a courte échéance 15 ans.Également, des soumissions seront reçues et considérées pour des obligations en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie ct l'autre partie ù terme fixe 20 ans pourvu toutefois que cette dernière partie ne soit pas pour un montant inférieur à $23,000, ct si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut ct ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le cas tic l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément ù la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital ct intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair a Chibougamau.Lc capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lcsdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal à $23,000.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans j>our un montant supérieur à $23,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, lc 1er mai de chaque année pour lc montant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émis-mission apparaissant dans lc présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal a 1% du montant de l'emprunt ct devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.cover one or more entire annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.By-law No: 135 \u2014 $250,000 \u2014 aqueduct, sewers.For adjudication only, interest will be calculated as from May 1, 1969.Table of redemption \u2014 $250,000 \u2014 20 years Year Capital May 1, 1970.$ 6,000 May 1, 1971.6,000 May 1, 1972 .6,500 May 1, 1973.7,000 May 1, 1974 .7,500 May 1,1975.8,000 May 1, 1976 .9,000 May 1, 1977.9,500 May 1, 1978.10,500 May 1, 1979.11,000 May 1,1980.12,000 May 1,1981.13,000 May 1,1982.13,500 May 1, 1983.15,000 May 1, 1984.16,000 Moy 1,1985.17,000 May 1,1986.18,500 May 1, 1987 .20,000 May 1,1988 .21,000 May 1,1989 .23,000 Moreover, tenders may be sent and shall be considered for ten-year short-term or fifteen-year short-term serial bonds.Also, tenders will be received and considered for ten-year serial bonds with the balance being partly for ten-year short-term and partly for twenty-year fixed-term bonds, provided, however, that this latter part be for an amount not less than $23,000, and, if higher than this latter amount, this part must comprise one or more annual amortizations, bearing in mind the tabic of maturities of the issue appearing in this notice, and starting by the last years of maturities.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Chibougamau.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially ami for twenty-year fixed-term for an amount equal to $23,000.However, if they arc issued partly for twenty-year fixed-term for an amount higher than $23,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual tftnount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be nccompunied by u certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender. QUÉBEC OFFICIAT, GAZETTE, April 19, lâG9, Vol.101, No.1G 2401 Les soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le (i mai 1069, a 7.30 heures du soir, Hôtel dc ville, t >-¦>(>, 3ièmc rue, case postale 876, Chibougamau, comté d'Abitibi-Est, P.Q.Le conseil se réserve lc droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Chibougamau (Comté d'Abitibi-Est), ce 2 avril 1969.Le greffier, Gekmain-M.Julien*.Hôtel dc ville, 650, 3ième rue, Case postale 876, Chibougamau, Comté d'Abitibi-Est, P.Q.Téléphone: 276-2688, code 819.28856-0 Ville de Nicolct Comté de Nicolet Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées ct endossées « Soumissions jxnir obligations » seront reçues par lc soussigné (icorges H iron, secrétaire-trésorier.Hôtel dc Ville, Place 21 Mars, case postale 670, Nicolet, comté dc Nicolet, P.Q., jusqu'à 8.15 heures du .soir, lundi, lc 5 mai 1969, pour l'achat de $254,500 d'obligations dc la ville dc Nicolet, comté dc Nicolet, datées du 1er mai 1969 et remboursables par séries du 1er mai 1970 au 1er mai 1989 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur il 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellcmcnt les 1er mai et 1er novembre dc chuque année Lc taux d'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans lc présent avis.Règlements Nos: 266 \u2014 $106,000 \u2014 aqueduc, égouts; 271 \u2014 $148,500 \u2014 aqueduc, égouts, voirie Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1969.Tableau d'umorti.i.iemeiit \u2014 $264,600 \u2014 20 ans Annie Capital 1er mai 1970.$ 6,000 1er mai 1971.7,000 1er mai 1972.7,000 1er mai 1973 .7,500 1er mai 1974 .8,500 1er mai 1975 .8,500 1er mai 1976.9,500 1er mai 1977.10,000 1er mai 1978.11,000 1er mai 1979.11,500 1er mai 1980.12,000 1er mai 1981.13.000 1er mai 1982.14,000 1er mai 1983.14,500 1er mai 1984.16,000 1er mai 1985.17,000 1er mai 1986.18,000 1er mai 1987.19,500 1er mai 1988 .21,500 1er mai 1989.22,500 Dc plus, des soumissions pourront être envoyées ct elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 10 ans ou à courte échéance 15 ans.Également, des soumissions seront reçues et considérées pour des obligations en séries 10 ans avec lc solde à courte échéance 10 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans pourvu toutefois que celte dernière partie ne soit pas pour un montant The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, May 6, 1969, at 7:30 o'clock p.m., in the Town Hall, 650, 3rd Street, P.O.Box 876, Chibougamau, county of Abitibi-East, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Chicougamau (County of Abitibi-East), April 2, 1969.Gehmain-M.Julien, Town Clerk.Town Hall, 650, 3rd Street, P.O.Box 876, Chibougamau, County of Abitibi-East, P.Q.Telephone: 276-2688, code 819.28856 Town of Nicolet County of Nicolet Public notice is hereby given that sealed tenders endorseil \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Georges Biron, Secretary-1 rcasurcr, Town Hall, Place 21 Mars, Post Office Box 670, Nicolet, county of Nicolet, Québec, until 8:15 o'clock in the evening, Monday, May 5, 1969, for the purchase of $254,500 of bonds for the town of Nicolet, county of Nicolet, dated May 1, 1969 and redeemable serially from May 1, 1970 to May 1, 1989 inclusively, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable semi annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate l>c used, the amount so issued at each different rate-must cover one or several complete annual amortizations, such as shown on the table of redemption of this notice By-laws numbers 266 \u2014 $106.000 \u2014 aqueduct, sewers; 271 \u2014 $148,500 \u2014 aqueduct, sewers, roads.For adjudication only, interest shall be calculated as from May 1, 1969.Table of redemption \u2014 $254,500 \u2014 20 years Year Capital May 1, 1970.$ 6.0(H) May 1, 1971.7,000 May 1, 1972 .7.000 Mav 1, 1973 .7,500 May 1, 1974.8.500 Mav 1, 1975.S.500 Mav 1, 1976 .9,500 May 1, 1977.10,000 May 1, 1978.11,000 Mav 1, 1979.11.5(H) May 1, 1980.12.0(H) Mav 1, 1981.13,000 Mav 1, 1982.14,000 May 1, 1983.14.500 Mav 1, 1984.16.000 May 1, 1985.17,000 Mav 1, 1986.18,000 Mav 1, 1987.19.500 May 1, 1988.21.5(H) May 1, 1989.22.5(H) Moreover, tenders may be sent and they .shall be considered for ten-year short-term or fifteen-year short-term serial bonds.Also, tenders will be received and considered for ten-year serial bond- with the balance being ten-year short-term bonds for one part, and twenty-year fixed-term bonds for the other |>art, provided however that the latter part be for an amount of not less than $22,500, and if greater than the latter amount, 2-102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 19G9, 101' année, 7i° 16 inférieur ù $22,500, et si supérieur ù ce dernier montant cette partie devra comprendre qu'un ou îles amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, ct en commençant par les dernières années d'échéances.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut ct ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans lc cas dc l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital ct intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Nicolet.Lc capital ct les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque à Toronto, Ontario.Lcsdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal à $22,500.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $22,500, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, lc 1er mai dc chaque année pour lc montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances dc l'émission apparaissant dans lc présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil, qui sera tenue, lundi, lc 5 mai 1969, à 8.15 heures du soir, Hôtel de Ville, Place 21 Mars, case postale 670, Nicolet, comté de Nicolet, P.Q.Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Nicolet (Comté dc Nicolet), ce 26 mars 1969.Le secrétaire-trésorier, Georges Bison, Hotel de Ville, Place 21 Mars, Case postale 670, Nicolet, Comté de Nicolet, P.Q.Téléphone: 293-4401, code 819.28857-o Paroisse dc Ste-Annc-dcs-Plaiiics Comté de Terrebonne Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues pur le soussigné Maurice Roy, secrétaire-trésorier, jusqu'il 5 heures du soir.Bureau de la Corporation, 154-A, boulevard Sainte-Anne, case postale 119, Sainte-Anne-des-Plaines, comté de Terrebonne, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir, École Saint-François, 3ième avenue, Saintc-Annc-des-Plaines, comté de Terrebonne, P.Q., lundi, le 5 mai 1969, pour l'achat de $275,500 d'obligations de la paroisse de Sainte-Anne-des-Phùnes, comté de Terrebonne, datées du 1er mai 1969 et remboursables par séries du 1er mai 1970 au 1er mai 1989 inclusivement, avec intérêt à lin taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellcment les 1er mai ct 1er novembre de chaque année.Lc taux d'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant said part should include one or several entire annual amortizations only, taking into account the table of redemption appearing in this notice, beginning with the last years of maturity.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall include one only of the terms save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Nicolet.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank whose name is mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds shall not be redeemable by anticipation when issued serially, or serially ami as twenty-year fixed-term bonds, for an amount equal to $22,500.However, should they be issued partly as twenty-year fixed-term bonds for an amount greater than $22,500, the bonds so issued shall be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of redemption of the issue appearing in this notice Each tender must be accompanied by u certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds at the date of their delivery is included or not in the price of the tender.Tenders will be opened und considered at a meeting of the council to be held Monday, May 5, 1969, at 8:15 o'clock in the evening, at the Town Hall, Place 21 Mars, Post Office Box 670, Nicolet, county of Nicolet, Québec.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Nicolet (County of Nicolet), March 26, 1969.Geo no es Binox, Secretary-Treasurer.Town Hall, Place 21 Mars, Post Office Box 670, Nicolet, County of Nicolet, P.Q.Telephone: 293-4401, code 819.28857 Parish of Ste-Aniie-des-PIuincs County of Terrebonne Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Maurice Roy, Secretary-Treusurer, until 5:00 o'clock p.m.in the office of the Corporation, 154-A Sainte-Annc Boulevard, P.O.Box 119, Ste-Annc-des-Plaincs.county of Terrebonne, P.Q.and afterwards until 8:00 o'clock p.m., Saint-François School.3rd Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, county of Terrebonne, P.Q., for the purchase of an issue of $275,500 of bonds for the parish of Saint'-Anne-des-Plaincs, county of Terrebonne, P.Q., Monday, May 5, 1969, dated May 1.1969.and redeemable serially from May 1, 1970 lo May 1, 1989 inclusively, with interest al a rale not'less than 7%, nor more than 8%, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each dil- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 ¦2m émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés aux tableaux d'amortissement dans lc présent avis.Règlements nos: 210 \u2014 $40,000 \u2014 aqueduc, égouts; 220 \u2014 $8,500 \u2014 aqueduc, égouts; 222 \u2014 $11,500 \u2014 aqueduc, égouts; 223 \u2014 SI 12,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1969.Tableau d'amortissement \u2014 $275,500 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1970.$ 3,500 1er mai 1971.4,000 1er mai 1972 .4,000 1er mai 1973 .4,000 1er mai 1974 .4,000 1er mai 1975 .4,000 1er mai 1976.5,000 1er mai 1977.5,000 1er mai 1978.5,000 1er mai 1979 .6,000 1er mai 1980 .7,000 1er mai 1981.7,000 1er mai 1982 .8,000 1er mai 1983.8,000 1er mai 1984 .8,000 1er mai 1985.9,000 1er mai 1986.10,000 1er mai 1987.11,000 1er mai 1988.11,000 1er mai 1989.152,000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 10 ans OÙ à courte échéance 15 ans.Également, des soumissions seront reçues ct considérées pour des obligations en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à tenue fixe 20 ans, pourvu toutefois que cette dernière partie ne soit pas pour un montant inférieur à $19,000, ct si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans lc présent avis, ct en commençant par les dernières années d'échéances de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Cependant les soumissions ne devront être transmises que pour un seid des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans lc cas de l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er mai 19S9 au montant dc 8152,000 comprend un solde dc $140,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, ct échéant comme suit: Année Capital 1er mai 1990.$10,000 1er mai 1991.11,000 1er mai 1992.12,000 1er mai 1993.13,000 1er mai 1994.13,000 1er mai 1995.14,000 1er mai 1996.15,000 1er mai 1997.16,000 1er mai 1998.17,000 1er mai 1999.19,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital cl intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair n Saintc-Annc-dcs-Plaincs.ferent rate must cover one or more entire annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.By-laws Nos: 210 \u2014 $40,000 \u2014 aqueduct, sewers; 220 \u2014 $8,500 \u2014 aqueduct, sewers; 222 \u2014 $11,500 \u2014 aqueduct, sewers; 223 \u2014 $112,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads.For adjudication only, interest will be calculated as from May 1, 1969.Table of redemption \u2014 $275,600 \u2014 20 years Year Capital May 1,1970 .8 3,500 May 1,1971.4,000 May 1,1972.4,000 May 1,1973 .4,000 May 1, 1974 .4,000 May 1,1975 .4,000 May 1,1976.5,000 May 1,1977.5,000 May 1,1978 .5,000 May 1,1979.6,000 May 1,1980.7,000 May 1,1981.7,000 May 1,1982.8,000 May 1,1983 .8,000 May 1,1984 .8,000 May 1,1985.9,000 May 1, 1986.10,000 May 1,1987.11,000 May 1,1988.11,000 May 1,1989.152,000 Moreover, tenders may be sent and shall be considered for ten-year or fifteen-year short-term serial bonds.Also, tenders will be received and considered for ten-year serial bonds with the balance being partly for ten-year short-term and partly for twenty-year fixed-term bonds, provided, however, that this latter part be for an amount not less than $19,000, and if higher than this latter amount, this part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starling by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The May 1, 1989 maturity in the amount of $152,000 comprises a balance of $140,000 renewable for an additional ten-year period and maturing as follows: Year Capital May 1, 1990.$10,000' May 1, 1991.11,000 May 1,1992.12,000 May 1,1993.13,000 May 1, 1994.13,000 May 1, 1995.14,000 May 1,1996.15,000 May 1,1997.16,000 May 1, 1998.17,000 May 1, 1999.19,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Sainlc-Anne-des-Plaincs. 2-104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, n° 16 Le capital ct les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dont lc nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lcsdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre dc $152,000.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $152,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, lc 1er mai dc chaque année pour lc montant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt ct devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le 5 mai 1969, à 8 heures du soir, École Saint-François, 3ièmc avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, comté dc Terrebonne, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Stc-Annc-dcs-Plaincs (Comté dc Terrebonne), ce 25 mars 1969.Le secrétaire-trésorier, Mauhice Roy.Bureau de la Corporation, 154-A, boul.Sainte-Anne, Case postale 119, Saintc-Anne-dcs-Plaincs (Terrebonne), P.Q.Téléphone: 525-6311 (bureau), code 514 435-7781 (resilience) 28858-o Ville d'Orsainville Comté dc Cbauvcau Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées ct endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par lc soussigné Armand Létourneau, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 4215, ave des Sauges, Orsainvillc, comté de Cbauvcau, P.Q., jusqu'à S heures du soir, mercredi, le 7 mai 1969, pour l'achat de $314,500 d'obligations dc la ville d'Orsainville, comté dc Cbauvcau, datées du 1er mai 1969 et remboursables par séries du 1er mai 1970 au 1er mai 1989 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable scmi-annuellement les 1er mai ct 1er novembre dc chaque année Lc taux d'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Règlements Nos: 335 \u2014 $53,200 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, etc.; 339 \u2014 $53,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 344 \u2014 $38,300 \u2014 aqueduc ct égouts; 351 \u2014 $22,900 \u2014 voirie; 354 \u2014 $49,500 \u2014 aqueduc et égouts; 355 \u2014 $47,600 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, etc.; 356 \u2014 $18,500 \u2014 aqueduc et égouts; 361 \u2014 $31,500 \u2014 achat d'une soudeuse à neige.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1969.Tableau d'amortissement \u2014 $314,500 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1970.$ 3,500 1er mai 1971.4,000 Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for twenty-year fixed-term bonds for an amount equal to or less than $152,000.However, if they are issued partly for twenty-year fixed-term for an amount higher than $152,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tabic of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interesl accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, May 5, 1969, at 8:00 o'clock p.m.Saint-François School, 3rd Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, county of Terrebonne, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Ste-Annc-dcs-Plaines (County of Terrebonne ).March 25, 1969.Mauiuce Roy, Secretary-Treasurer.Office of the Cor'wration, 154-A Saintc-Annc Boulevard, P.O.Box 1 lit.Saintc-Annc-dcs-Plaincs (Terrebonne), P.Q.Telephone: 525-6311 (Office), code 514.435-7781 (Residence) 2885s Town of Orsainvillc County of Cbauvcau Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Armand Létourneau, Secretary-Treasurer, Town Hall, 4215 des Sauges Avenue, Orsainvillc, county of Cbauvcau, P.Q., until 8:00 o'clock, p.m., Wednesday.May 7, 1969, for the purchase of an issue of $314,500 of bonds for the town of Orsainvillc, county of Cbauvcau, dated May 1, 1969 and redeemable serially from May 1, 1970 to May 1.1989 inclusively, with interest at a rate not less than 7%, nor superior to 8%, payable semiannually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rale is used, the amount issued at each different rale must cover one or several whole annual amortizations, such as shown on the tables of redemption in the present notice By-law Nos.: 335 \u2014 $53,200 \u2014 aqueduct, sewers, roads, etc.; 339 \u2014 $53,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 344 \u2014 $38,300 \u2014 aqueducl and sewers; 351 \u2014 $22,900 \u2014 roads; 354 $49,500 - aqueduct and sewers; 355 \u2014 $47,60(1 aqueduct, sewers, roads, etc.; 356 \u2014 $18,500 aqueduct and sewers; 361 \u2014 $31,500 \u2014 purchasing of a snowblowcr.For adjudication only, interest will be calculated us from May 1, 1969.Table of redemption \u2014 $31.',,500 - 20 years Year Capital May I, 1970.8 3,500 May 1, 1971.4,000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2405 1er mai 1972.S 4,000 1er mai 1973 .4,500 1er mai 1974.4,500 1er mai 1975.4,500 1er mai 1976 .5,500 1er mai 1977.5,500 1er mai 1978 .6,000 1er mai 1979.6,500 1er mai 1980 .2,500 1er mai 1981.3,000 1er mai 1982.3,000 1er mai 1983.-3,000 1er mai 1984.3,500 1er mai 1985.3,500 1er mai 1986 .4,000 1er mai 1987 .4,500 1er mai 1988 .4,500 1er mai 1989 .234,500 De plus, des soumissions pourront être envoyées ct elles seront prises en considération |K)iir des obligations en séries à courte échéance 10 ans ou à courte échéance 15 ans.Également, des soumissions seront reçues ct considérées pour des obligations en séries 10 ans avec lc solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans, pourvu toutefois que cette dernière partie ne soit pas pour un montant inférieur à $21,000, ct si supérieur a, ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant, compte des tableaux d'échéances apparaissant dans lc présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Cependant, ' les soumissions ne devront être transmises que |H>ur un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans lc cas de l'exception notée.L'adjudication sera fnitc conformément à la loi.L'échéance du 1er mai 1989 au montant dc $234,500 comprend un solde de $229,500 renouvelable pour une période additionnelle dc 20 ans, et échéant comme suit: May 1, 1972.$ 4,000 May 1,1973 .4,500 May 1, 1974 .4,500 May 1, 1975 .4,500 May 1,1976 .5,500 May 1,1977.5,500 May 1,1978.6,000 May 1, 1979.6,500 May 1, 1980 .2,500 May 1, 1981.3,000 May 1,1982 .3,000 May 1, 1983 .3,000 May 1,1984.3,500 May 1, 1985 .3,500 \"May 1,1986 .4,000 May 1,1987 .4,500 May 1, 1988.4,500 May 1,1989 .234,500 Moreover, tenders may be sent and shall be considered for 10-year short-term or 15-year short-term serial bonds.Also, tenders will be received and considered for 10-year serial bonds, with the balance being partly for 10-year short-term and partly for 20-year fixed-term bonds, provided, however, that this latter part be for an amount not less than $21,000, and if higher than this latter amount, this part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starting by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The May 1, 1989 maturity iu the amount of 8234,500 includes a balance of $229,500 renewable for an additional 20-year period, and maturing as follows: Année Capital 1er mai 1990.$ 5,000 1er mai 1991.6,000 1er mai 1992 .6,000 1er mai 1993.6,500 1er mai 1994.7,000 1er mai 1995.7,500 1er mai 1996 .8,000 1er mai 1997 .8,500 1er mai 1998 .9,500 1er mai 1999.10,000 1er mai 2000.11,000 1er mai 2001.12,000 1er mai 2002.13,000 1er mai 2003.13,500 1er mai 2004.14,500 1er mai 2005.15,500 1er mai 2006.17,000 1er mai 2007.18,500 1er mai 2008.19,500 1er mai 2009.21,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Orsainvillc.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dont le nom est mentionné dans ln procédure d'emprunt ninsi qu'au bureau principal dc ladite banque A Toronto, Ontario.Year Capital May 1, 1990.$ 5,000 May 1, 1991.6,000 May 1, 1992 .6,000 May 1, 1993.6,500 May 1, 1994.7,000 May 1,1995.7,500 May 1, 1996.8,000 May 1,1997 .8,500 May 1, 1998 .9,500 May 1,1999.10,000 May 1,2000.11,000 May 1, 2001.12,000 May 1,2002.13,000 May 1.2003.13,500 May 1,2004.14,500 Mav 1, 2005.15,500 May 1,2006.17,000 May 1,2007.18,500 May 1,2008.19,500 May 1,2009 .21,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Orsainvillc.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the bend office of the said bank in Toronto, Ontario. 2406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101* année, n° 16 Lcsditcs obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre dc $234,500.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur i\\ $234,500, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er mai de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances dc l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt ct devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mercredi, le 7 mai 1969, à 8 heures du soir, Hôtel dc Ville, 4215, ave des Sauges, Orsainvillc, comté de Cbauvcau, P.Q.Le conseil se réserve lc droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Orsainville ( Comté de Chauvcau), ce 9 avril 1969.Le secrétaire-trésorier, Armand Létourneau.Hôtel our obligations » seront reçues par lc soussigné Henri Brabant, secrétaire-trésorier.Hôtel de Ville, 801, Chemin Oka, Cité des Deux-Montagnes, comté des Deux-Montagnes, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, jeudi, lc 8 mai 1969, pour l'achat dc $457,000 d'obligations dc la cité des Deux-Montagnes, comté des Deux-Montagnes, datées du 1er mai 1969 ct remboursables par séries du 1er mai 1970 au 1er mai 1989 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à S%, payable schii-annuellement les 1er mai et 1er novembre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Règlements nos: T-127 \u2014 $15,000 \u2014bâtisses et terrains; T-151 \u2014 $3,000 \u2014 aqueduc égouts; T-152 \u2014 $198,000 \u2014 voirie; T-153 \u2014 $3,800 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; T-161 \u2014 $8,700 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; T-163 \u2014 $2,700 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; T-165 \u2014 $65,000 \u2014 aqueduc, égouts; T-168 \u2014 $160,800 \u2014 aqueduc, égouts.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1969.Tableau d'amortissement \u2014 $457,000 \u2014 S0 ans Année Capital 1er mai 1970.$ 5,000 1er mai 1971.5,000 1er mai 1972 .5,000 1er mai 1973.6,000 1er mai 1974 .6,000 1er mai 1975.7,000 1er mai 1976.7,000 1er mai 1977.7,000 The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for 20-year fixed-term for an amount equal to or less than $234,500.However, if they are issued partly for 20-year fixed-terra for an amount greater than $234,500, the bonds so issued will be redeemable, by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by u certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Wednesday, May 7, 1969, at 8:00 o'clock, p.m., at the Town Hall, 4215 des Sauges Avenue, Orsainvillc.county of Chauveau, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Orsainville (County of Chauveau), April 0, 1969.Armand Létourneau, Secretary-Treasurer.Town Hall, 4215 des Sauges Avenue, Orsainville (Chauveau), P.Q.Telephone: 623-5431, code 418.28860 City of Two-Mountains County of Two-Mountains Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Henri Brabant, Secretary-Treasurer, Town Hall, 801 Oka Road, City of Two-Mountains, county of Two-Mountains, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Thursday.May 8, 1969, for the purchase of an issue of $457,000 of bonds for the city of Two-Mountains, county of Two-Mountains, dated May 1, 1969 and redeemable serially from May 1, 1970 to May 1, 1989 inclusively, with interest ut a rate not less than 7%, nor more than 8%, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue, however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, such as shown on the tables of redemption in the present notice.By-laws Nos: T-127 \u2014 $15,000 \u2014 buildings and lots of land; T-151 \u2014 $3,000 \u2014 aqueduct, sewers; T-152 \u2014 $198,000 \u2014 roads; T-153 -$3,800 \u2014 aqueduct, sewers, roads: T-161 \u2014 $8,700 \u2014 aqueduct, sewers, roads: T-163 \u2014 $2,700 \u2014 aqueduct, sewers, roads; T-165 $65,000 \u2014 aqueduct, sewers; T-168 \u2014 $160,800 \u2014 aqueduct, sewers.For adjudication only, interest will he calculated as from May 1, 1969.Table of redemption \u2014 $457,000 \u2014 20 years Year Capital May 1, 1970.$ 5,000 May 1,1971.5,000 May 1,1972 .5,000 May 1,1973 .6,000 May 1,1974 .6,000 May 1, 1975 .7,000 May 1, 1976.7,000 May 1,1977 .7,000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 19G9, Vol.101, No.16 1er mai 1978.$ 8,000 1er mai 1979.11,000 1er mai 1980.12,000 1er mai 1981.11,000 1er mai 1982.12,000 1er mai 1983.14,000 1er mai 1984.15,000 1er mai 1985.17,000 1er mai 1986.18,000 1er mai 1987.18,000 1er mai 1988.18,000 1er mai 1989.:.255,000 De plus, des soumissions pourront être envoyées ct elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 10 ans ou à courte échéance 15 ans.Également, des soumissions seront reçues et considérées pour des obligations en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans, pourvu toutefois que cette dernière partie ne soit pas pour un montant inférieur à 312,000, et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, ct en commençant par les dernières années d'échéances dc la partie renou-velable ci-après mentionnée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le cas de l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er mui 1989 au montant dc 5255,000 comprend un solde dc $234,000 renouvelable pour une période additionnelle dc 20 ans, et échéant comme suit: Année Capital 1er mai 1990.$13,000 1er mai 1991.13,000 1er mai 1992.13,000 1er mai 1993.12,000 1er mai 1994.15,000 1er mai 1995.15,000 1er mai 1996.15,000 1er mai 1997.17,000 1er mai 1998.\u2022.17,000 1er mai 1999.18,000 1er mai 2000 .6,000 1er mai 2001.6,000 1er mai 2002 .7,000 1er mai 2003.7,000 1er mai 2004 .8,001) 1er mai 2005.9,000 1er mai 2006.10,000 1er mai 2007.10,000 1er mai 2008.11,000 1er mai 2009.12,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair il Deux-Montagnes.Le capital cl les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque ù Toronto, Ontario.Lesditcs obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égul ou moindre dc $255,000.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur A $255,000 les obligations 2407 May 1, 1978.$ 8,000 May 1,1979.11,000 May 1, 1980.12,000 May 1,1981.11,000 May 1, 1982.12,000 May 1,1983.14,000 May 1, 1984.15,000 May 1, 1985.17,000 May 1, 1986.18,000 May 1,1987.18,000 May 1, 1988.18,000 May 1,1989.255,000 Moreover, tenders may be sent and shall be considered for ten-year short-term or fifteen-year short-term serial bonds.Also, tenders will be received and considered for ten-year serial bonds with the balance being partly for ten-year short-term and partly for twenty-year fixed-term bonds, provided, however, that this latter part be for an amount not less than $12,000 and, if higher than this latter amount, this part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starting by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The May 1st, 1989 maturity in the amount of $255,000 comprises a balance of $234,000, renewable for an additional twenty-year period and maturing as follows: Year Capital May 1, 1990.$13,000 May 1,1991.13,000 May 1,1992.13,000 May 1, 1993.12,000 May 1, 1994.:.15,000 May 1, 1995.15,000 May 1, 1996.15,000 May 1,1997.17,000 May 1,1998.17,000 May 1,1999.18,000 May 1,2000 .6,000 May 1, 2001.6,000 May 1,2002.7,000 May 1,2003.7,000 May 1,2004 .8,000 May 1,2005.9,000 May 1,2006.10,000 May 1, 2007.10,000 May 1, 2008.11,000 May 1,2009.12,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Two-Mountains.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the bead office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for twenty-year fixed-term bonds for an amount equal to or less than $255,000.However, if they arc issued partly for twenty-year fixed-term for an amount higher than $255,000, the 2408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 19G9, 101' année, n\" 16 ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er mai de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement, dc l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt cl devra specifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, jeudi, le 8 mai I960, à 8 heures du soir.Hôtel dc Ville, 801, Chemin Oka, Cité îles Deux-Montagnes, comté des Deux-Montagnes, P.Q.Lc conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Deux-Montagnes (Comté dc Deux-Montagnes), ce 11 avril 1969.Le secrétaire-trésorier, Henri Brabant.Hôtel de Ville, 801, Chemin Oka, Cité de Deux-Montagnes, Comté des Deux-Montagnes, P.Q.Téléphone: 473-2796, code 514.28889-4) Ville de Dollard-des-Ormcaiix Comté de Robert Baldwin Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par la soussignée Mme Lillian G.Lamarchc, greffier, Hôtel de ville, 4139, Boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux, comté dc Robert Baldwin, P.Q., jusqu'à S heures du soir, mardi, le 6 mai 1969, pour l'achat dc 81,204,500 d'obligations de la ville de Dollard-des-Ormeaux, comté «le Robert Baldwin, datées du 1er juin 1969 et remboursables par séries du 1er juin 1970 au 1er juin 1989 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-nnnucllcmcnt les 1er juin ct 1er décembre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Règlements nos: 216 (284) \u2014 8125,000 \u2014 aqueduc ct égouts; 230 \u2014 8140,000 \u2014 aqueduc et égouts; 232 \u2014 $13,500 \u2014 voirie et éclairage; 242 \u2014 $30,000 \u2014 aqueduc ct égouts; 243 \u2014 $16,000 \u2014 aqueduc et égouts; 247 \u2014 $37,000 \u2014 voirie; 263 \u2014 $15,000 \u2014 bâtisses et terrains; 265 \u2014 $130,000 \u2014 aqueduc ct égouts; 271 \u2014 $22,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 272 \u2014 8220.000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 276 \u2014 S304.000 \u2014 aqueduc, égouts ct voirie; 298 \u2014 848,000 \u2014 aqueduc et égouts; 313 \u2014 $78,500 \u2014 services récréatifs ct communautaires; 319 \u2014 $25,500 \u2014 voirie.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1969.Tableau d'amortissement \u2014 SI,204,500 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1970.$ 19,500 1er juin 1971.21,000 1er juin 1972 .22,000 1er juin 1973.23,000 1er juin 1974.25,000 1er juin 1975 .27,000 1er juin 1976.29,000 1er juin 1977 .31,000 bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on May 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Thursday, May 8, 1969, at 8:00 o'clock p.m., Town Hall, 801 Oka Road, city of Two-Mountains, county of Two-Mountains, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Two-Mountains (County of Two-Mountains).April 11, 1969.Henri Brabant, Secretary-Treasurer.Town Hall, 801 Oka Road, City of Two-Mountains, County of Two-Mountains, P.Q., Telephone: 473-2796, code 514.28869 Town of Dollard-dcs-Ormeaiix County of Robert Baldwin Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Airs.Lillian G.Lamarchc, Town Clerk, Town Hall, 4139 Des Sources Boulevard, Dollard-des-Onneaux, county of Robert Baldwin, Québec, until 8 o'clock in the evening, Tuesday, May 6, 1969, for the purchase of an issue of $1,204,500 of bonds of the town of Dollard-des-Ormeaux, county of Robert Baldwin, dated June 1, 1969 and redeemable serially from June 1, 1970 to June 1, 1989 inclusively, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable semiannually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount so issued ut each different rate must cover one or several complete annual amortizations, such as shown on the tables of redemption of this notice.By-laws numbers 216 (284) \u2014 $125,000 aqueduct and sewers: 230 \u2014 $140,000 \u2014 aqueduct and sewers; 232 \u2014 $13,500 \u2014 roads and lighting: 242 \u2014 $30,000 \u2014 aqueduct and sewers; 243 $16,000 \u2014 aqueduct and sewers; 247 \u2014 $37,000 \u2014 roads; 263 \u2014 $15,000 \u2014 huldings and lands: 265 \u2014 $130,000 \u2014 aqueduct and sewers; 271 $22,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 272 8220,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 276 $304,000 \u2014 aqueduct, sewers und roads; 298 $48,000 \u2014 aqueduct and sewers; 313 \u2014 $78,5011 \u2014\u2022 recreational and community services; 319 $25,500\u2014 roads.For adjudication only, interesl shall I»' calculated us from June 1, 1969.Table of redemption \u2014 SI,204,500 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1970.$ 19,500 June 1,1971.21,000 June 1,1972.22,000 June 1, 1973.23,000 June 1, 1974 .25,000 June 1, 1975.27,000 June 1, 1976.29,000 June 1, 1977 .31,000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 19G9, Vol.101, No.16 2409 1er juin 1978.$ 33,000 1er juin 1979.35,000 1er juin 1980 .37,000 1er juin 1981.41,000 1er juin 1982.43,000 1er juin 1983.46,000 1er juin 1984.50,000 1er juin 1985.53,000 1er juin 1986 .57,000 1er juin 1987 .60,000 1er juin 1988.-.65,000 1er juin 1989.487,000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 10 ans ou à courte échéance 15 ans.Également, des soumissions seront reçues et considérées pour des obligations en séries 10 ans avec lc solde à courte échéance 10 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans, pourvu toutefois que cette dernière partie ne soit pas pour un montant inférieur à 857,000, et si supérieur ù ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut ct ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le cas île l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er juin 1989 au montant de 8487,000 comprend un solde île $417,000 renouvelable pour une période additonnelle de 10 ans et échéant comme suit: Année Capital 1er juin 1990.$30,000 1er juin 1991.32,000 1er juin 1992.34,000 1er juin 1994 .37,000 1er juin 1995 .40,000 1er juin 1996.42,000 1er juin 1997.45,000 1er juin 1998 .48,000 1er juin 1999.52,000 1er juin 2000 .57,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Dollard-des-Ormeaux.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lcsdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou eu séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre de $487,000.Toutefois si elles sont émises en partie ù terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $487,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement dc l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt ct devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus June 1, 1978.$ 33,000 June 1, 1979 .35,000 June 1, 1980 .37,000 June 1, 1981.41,000 June 1, 1982 .43,000 June 1,1983.46,000 June 1, 1984 .50,000 June 1, 1985 .53,000 June 1, 1986 .57,000 June 1, 1987 .60,000 June 1, 1988.65,000 June 1, 1989 .487,000 Moreover, tenders may be sent and they shall be considered for tcn-ycar short-term or fifteen-year short-term serial bonds.Also, tenders will be received and considered for ten-year serial bonds with the balance being ten-year short-term for one part, and twenty-year fixed-term bonds for the other part, provided however that the latter part be for an amount of not less than $57,000, and if greater than the latter amount, said part should include one or several entire annual amortizations only, taking into account the tabic of redemption appearing in this notice, beginning with the last years of maturity of the renewable part hereinafter mentioned.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall include one only of the terms save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The June 1, 1989 maturity in the amount of $487,000 includes a balance of $417,000 renewable for an additional ten-year period and maturing as follows: Year Capital June 1, 1990.$30,000 June 1, 1991.32,000 June 1,1992.34,000 June 1, 1994 .37,000 June 1, 1995.40,000 June 1, 1990.42,000 June 1,1997 .45,000 June 1, 1998.48,000 June 1, 1999 .52,000 June 1,2000 .57,000 The successful tenderer agrees to |>ay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Dollard-des-Ormcaux.Capital and interest arc payable at all branches in the province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds shall not be redeemable by anticipation when issued serially, or serially and as twenty-year fixed-term bonds, for an amount equal to or less than $487,000.However, should they be issued partly as twenty-year fixed-term bonds for an amount greater than 8487,000, the bonds so issued shall be redeemable by anticipation, at par, on June 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of redemption of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds at the date of their delivery is 2410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 19G9, 101' année, ii° lb sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, lc 0 mai 1969, à 8 heures du soir, Hôtel dc ville, 4139, Boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux, comté de Robert Baldwin, P.Q.Lc conseil se réserve lc droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Dollard-des-Ormeaux (Comté dc Robert Baldwin), ce 11 avril 1969.Le greffier, Lillian G.Lamarche.Hôtel dc ville, 4139, Boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux (Robert Baldwin), P.Q.Téléphone: 6S4-1010, code 514.28870-o included or not in the price of the tender.Tenders will be opened and considered at n meeting of the council to be held on Tuesday, May 6, 1969, at 8 o'clock in the evening, at the Town Hall, 4139 Des Sources Boulevard, Dollard-des-Ormeaux, county of Robert Baldwin, Québec.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Dollard-des-Ormeaux (County of Robert Baldwin), April 11, 1969.Mus.Lillian G.Lamarche, Town Clerk.Town Hall, 4139 Des Sources Boulevard, Dollard-des-Ornicnux (Robert Baldwin), P.Q.Telephone: 684-1010, code 514.28870 Vente - Loi de faillite Sale - Bankruptcy Act Canada, province de Québec, district de Bcauce, Cour Supérieure, (en matière dc faillite), No 431-F.Dans l'affaire de la faillite dc: Paul Monty, contremaître.East Broughton, comté dc Beancc.débiteur.Avis de vente Avis est par les présentes donné comme suit: Mardi lc 13 mai 1969 à 2 heures dc l'après-midi, scru vendu pur encan public, au Palais de Justice dc St-Joseph de Bcaucc, l'immeuble suivant: « l'n emplacement composé des lots soixante-dix ct soixante et onze (70-71) rang B, canton d'Adstock, avec les bâtisses dessus construites, circonstances cl dépendances.» à usage dc chalet.Mise à prix minimum.82,500 Les titres peuvent être consultés en s'uilrcssant au bureau des syndics soussignés.Cet item sera offert en vente au plus haut ct dernier enchérisseur.Cette vente seru fuite avec les formalités donnant les mêmes effets qu'une vente par le Shérif articles 716, 717 ct 719-A du Code dc Procédures Civiles ct de l'article 55 de la Loi de Fuillitc ct ce conformément à l'ordonnance rendue par la Cour Supérieure à cet effet.Cet immeuble est visible sur demande en s'adressant à Me Robert Marchand, 179, Notre-Dame Sud, Thctford-Mincs.Conditions de paiement: urgent comptant.Québec, 9 avril 1969.Iœs syndics, René Lefaivre & Albert Yerhoeulst.56, rue St-Pierrc, Québec.28824-o Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES ct HÉRITAGES sous-mentioiinés ont été saisis ct seront vendus aux temps cl lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.GASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province dc Québec District de Gaspé Division Iles de la Madeleine Cour Provinciale, ( TRYING OIL COMPANY No 60.i 1 LIMITED, corporation ' légalement constituée, avec siège d'affaires ù Saint-John, dans lu province du Cunndu, Province of Québec, district of Bcaucc, Superior Court, (In matter of bankruptcy), No.431-F.In the matter of the bankruptcy of Paul Monty, foreman.East Broughton.county of Bcaucc, debtor.Notice of sale Notice is hereby given as follows: On Tuesday.May 13, 1969, at 2-00 o'clock in the afternoon, the following immovable shall be sold by publie auction in the Court House, at Saint-Joseph dc Bcauce: \"An emplacement comprising lots seventy and seventy-one (70-71) range B, township of Adstock, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" with the use of the summer house.Minimum price.82,501) The titles may be consulted nt the office of the undersigned trustees.This item shall be sold to the highest and last bidder.The procedure used in the said sale shall have the same force as a Sheriff's sale, sections 716, 717 nnd 719-A of the Code of Civil Procedure and section 55 of the Bankruptcy Act and such, in conformity with the Order rendered by the Superior Court in this matter.The said immovable may be visited on request to Me Robert Marchand, 179 Notre-Dame Sud.Thetford-Mines.Conditions of payment: Cash.Québec, April 9, 1969.René Lefaivre & Albert Verroeulst, Trustees.56 Saint-Pierre Street, Québec.2882-1 Sheriffs' Sales PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, nnd will be sold at the respective times and places mentioned below.GASPÉ Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Gaspc Iles de la Madeleine Division Provincial Court, ( TRVING OIL COMPANY No.60.-v *¦ LIMITED, a corporation v legally constituted, with a bend office in Saint-John, in the Province of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 10, 10(10, Vol.101, No.16 2411 Nouvcau-Brunswick, demanderesse; es LES HÉRITIERS DE PIERRE POIRIER, de L'endroit ap|)cl6 Les Caps, Iles de la Madeleine, district île Gaspé, Province de Québec, défendeurs.Comme appartenant aux défendeurs: Un certain lopin de terre situé dans la municipalité dc Fatimu, comté des Iles dc la Madeleine, plus explicitement connu ct désigné aux plan ct livre dc renvoi revisés de l'Ile dc Cup-aux-Mculcs, division d'enregistrement des Iles dc lu Madeleine, comme suit: I .i- lot No G57 (six cent cinquunte-scpt) tel que cadastré, d'une superficie dc 746,000 (sept cent i|iinrnntc-six mille pieds currés).Un certain lopin dc terre situé duns lu municipalité de Fatima, comté des Iles de la Madeleine, plus explicitement connu ct désigné aux plun ct livre de renvoi revisés de l'Ile de Cup-aux-Mculcs, division d'enregistrement des Iles dc la Madeleine, comme suit: Lc lot No 669 (six cent soixante-neuf), tel que cadastré, d'une superficie de 231,330 p.c.(deux cent trente et un mille trois cent trente pieds currés, avec maison dessus construite, circonstances et dépendances.Pour être vendu uu bureau du Shérif, puluis de justice, HAvre-Aubert, Iles de lu Mudclcinc le VINGT ET UNIÈME jour de MAI, 1969, A ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif-adjoint.Le shérif-adjoint, Puluis de Justice, napoléon Briand.IIuvre-Aubcrt, Iles île lu Madeleine 28872-o JOLIETTE bien Facias de Bonis et dc Terris Canndu \u2014 Province de Québec District de Jolictte Cour Supérieure, l T) OMULUS COMTOIS.No 23,288.S -*-N.commercent, dc lu mu-' nicipulité dc St-Guhricl-de-Kraudoii, district de Jolictte, demandeur, rs MARCEL LAVERDIÈRE, gentilhomme de la municipalité de St-Gahriel-dc-Rrundon, district de Jolictte, et Dame LUCILLE BOUCHER, épouse légitime dudit Marcel Laverdièrc, des mêmes lieux, défendeurs.« Une parcelle de terrain situé en la municipalité de la paroisse dc St-Gabricl-de-Brandon, prise le long de l'ancien chemin des lots, aujourd'hui le chemin menant A lu propriété Ernest l.acoursc.et au nord-est du nouveau chemin qui A cet endroit, coupe l'équcrrc que formait autrefois le chemin des lots, connue et désignée cette parcelle de terrain comme étnnt une parla- du lot cinq cent trente-trois (Plie 533) nu cadastre de la paroisse «le St-Gabriel-dc-Brandon, partant en pointe uu sud-ouest, là ou le nouveau chemin commence, A partir «le l'ancien chemin, se prolongeant ainsi le long dc lu ligne sud-est dc l'aïu-icii chemin des lots, pour aller aboutir uu nord-est à cette autre partie du chemin «les lots, face A la propriété Lacourse, après l'éipicrrc formée par cet ancien chemin, mesurant environ quntre-vingt-cinq pieds de largeur (85') dans cette ligne nord-est, cl lu ligne sud-est étant parallèle A l'ancien chemin des lots, sur la profondeur qu'il y u depuis le nouveau chemin, A aller A la propriété l.acoursc ou partie de l'ancien chemin, bornée uu nord-ouest par l'ancien chemin, au sud-est, pur le vendeur, au nord-est par l'ancien New Brunswick, plaintiff; M THE HEIRS OF PIERRE POIRIER, of the place called Les Caps, Iles dc la Madeleine, district of < iuspé, Province of Québec, defendants.As belonging to the defendants: A certain piece of lund situuted in the municipality of Fat una, county of Iles «le la Madeleine, more explicitly known and designated on the revised plun und book of reference for the Isle of Cup-nux-Meulcs, registration division of lies dc la Madeleine, as follows: The lot No.657 (six hundred und fifty-seven us registered in the cadastre, of an area of 746,000 (seven hundred and forty-six thousand square feet).A certain piece of lund situuted in the municipality of Fatima, county of Iles de la Madeleine, more cxplicitcly known and designated on the revised plan and book of reference for the Isle of Cap-aiix-Meulcs, registration division of lies dc la Madeleine, as follows: The lot No.669 (six hundred and sixty-nine), as registered in the cadastre, of an area of 231,330 sip ft.(two hundred thirty-one thousand three hundred and thirty square feet), and a house thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the Sheriff's Office Court House, Hûvre-Auliert, Iles de la Madeleine, the TWENTY-FIRST day of MAY, 1969, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Associate Sheriff's Office, Napoléon Briand,.Court House, Associate Sheriff.Havre-Aubcrt, Iles dc la Madeleine 28872.JOLIE T T E Fitri Facias dc Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Jolictte Superior Court, I T> OMULUS COMTOIS.No.23,288.< AN- trader of the munici-v pality of St-Gabricl-de-Brandon, district of Jolictte, plaintiff, rs MARCEL LAVERDIERE, gentleman, of the municipality of St-Gabriel-dc-ilrandon, district of Jolictte, and Mrs.LUCILLE BOUCHER, legal wife of said Marcel Laverdièrc, of the same place, defendants.\"A parcel of land situated in the municipality of the parish of St-Gabricl-de-Brandon, taken along the former road of the lots, now the road leading to the property of Ernest La course, and on the northeast of the new road which, at this place, cuts the squure which was formerly part of the road of the lots, this part of lund known and designated as being u part of lot five hundred and thirty-three (Pt.533) of the cadastre of the parish of St-Gabricl-de-Brandon, starting in a point on the .southwest, where the new road starts, from the former road, thus prolongating itself ulong the southeast line of the former road of the lots, to end on the northeast on this other part of the road of the lots, facing Lacourse's property, after the square formed by this former road, measuring approximately eighty-five feet in width (85') on this northeast line, and the southeast line being parallel to the former road of the lots, by the depth existing from the new road, to the property of Lacourse or part of the former road, bounded on the northwest by the former road, on the southeast, by the vendor on the northeast by the former road, facing Lacourse, 2412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, u\" 16 chemin, face à Lacourse, ct au sud-ouest lc nouveau chemin.Avec les bâtisses qui s'y trouvent.> Pour être vendue à la division d'enregistrement de Bcrthicr i\\ Bcrthicrville, district dc Joliette, MARDI, lc VINGT-SEPTIÈME jour du mois dc MAI, 1969, i\\ ONZE heures dc l'avant-midi.Le shérif.Bureau du shérif, Chaules Élément.Joliette, ce 11 avril 1969.28873-0 K A M O U R A S K A Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province dc Québec District dc Kamouraska Cour Provinciale,Y T-JECTOR BOURGOIN, Kamouraska, commerçant dc Riviè- No 1759.j rc-Vertc, (St-Antonin), com-l té de Rivière-du-Loup, dc-mandeur, m LÉO MICHAUD, h of St-François, county of Montmagny, in the second concession on the south of Rivièrc-du-Sud, containing two arpents in front by 40 arpents in depth, known and designated under number three hundred and fifty-five (355) on the official plan and book of reference of the cadastre- of the said parish of St-François, in the county of Montmagny, with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, Montmagny, on the TWENTY-SIXTH day of MAY, 1969, at THREE o'clock in the afternoon.Jean-Paul Themblav, Sheriff's Office, Sheriff.Montmagny, April 11, 1969.28875 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2413 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Cour Supérieure Québec, à savoir: ( T\\AME LEOPOLD SI -No 152-686.< J-/ MARD, domiciliée au l 2322, rue Maufils, en les cité et district George Muir, Notre-Dumc des Lnurcntidcs, district de Québec.» Pour être vendu nu bureau d'enregistrement de Québec, à Québec, lc VINGT-TROISIÈME jour de MAI prochain à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif-adjoint, Bureau du shérif, Raymond Hains.Québec, lc 15 avril 1969.\u2022 28877-u Fieri Facias de Terris Québec, à savoir:/TE PRÊT HYPOTHÉ-Cour Supérieure,) CAIRE, corporation lé-No 155-142.\\ gaiement constituée, ayant ' son siège social en la cité dc Quél>ec, contre ANDRÉ FALARDEAU, aviculteur dc Loretteville, comté de Québec, et LE RÊGISTRATEUR pour lu division d'enregistrement de Québec, mis-en-cuse.a) la subdivision 1 de la subdivision S du lot 1046 (1046-8-1), au cadastre dc lu paroisse de Saint-Ambroisc dc lu Jcune-Lorette, cité de Loretteville; * QUÉBEC Fieri Facias dc Terris Superior Court Québec, to wit : ( T^AME LEOPOLD SI - No.152-686.< J-' MARD, domiciled at 12322 Maufils Street, in the city and district of Québec, vs LEOPOLD SIMARD, domiciled at 2326 Maufils Street, in the city and district of Québec.\"A piece of land being at the southwest cud of lots four hundred and fifty-six and four hundred and fifty-seven (S.W.pt.456 and S.W.pt.457) on the cadastre for the parish of Charlesbourg, measuring about two hundred and ninety feet (290') in width by a length of about one thousand four hundred and forty feet (1440'), on the northwest and one thousand two hundred and fifty feet (1250') on the southeast, and bounded as follows: towards the northeast by the service road of Laurentian Boulevard, towards the southeast by lot four hundred and fifty-five (455) on the cadastre of Charlesbourg, towards the southwest by lot ninety-nine (99) of the sixth concession and at last towards the northwest by the lot four hundred nnd fifty-eight (458) on the aforesaid cadastre, without buildings.A piece of land crossed by the electrical transmission line of Shawinigan Water & Power\".To be sold at the Registry Office of Québec, in Québec, the TWENTY-THIRD day of MAY next at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office.Associate Sheriff.Québec, April 15, 1969.28876 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: f JULIEN LECLERC, grocer.Provincial Court,1) J domiciled and residing at No.32-843.' Pont-Rougc, county of Portncuf, district of Québec, against MARC ANDRÉ BLOUIN, domiciled at 56H (ieorges Muir, Notre-Dame des Laurcntidcs, district of Québec.\"A part of lot 449 on the cadastre for the parish of Charlesbourg, measuring 75 feet from north to south, and 100 feet in its cast-west lines, bounded on the north by Antonio Portier, on the west by Roméo Williamson, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Being nlso known as a property situated at 56}4 (îeorges Muir, Notre-Dame des Lauren-tides, district of Québec.\" To be sold at the Registry Office of Québec, in Québec, the TWENTY-THIRD day of MAY next at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Ollicc, Associate Sheriff.Québec, April 15, 1969.28877 Fieri Facias de Terris Québec, to wit:?J E PRÊT II YPOTHÉ-Supèrïor Court, ) CAIRE, a corporation No.155-142.1 legally constituted, having its V head office in the city of Québec, against ANDRÉ FALARDEAU, breeder of fowls from Loretteville, county of Québec, and THE REGISTRAR for the Québec Registration division, mis-cn-causc.(a) subdivision 1 of subdivision S of lot 1046 (1046-8-1), on the cadastre for the parish of Saint-Ambroisc de lu Jeune-Lorette, city of Loretteville 2414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 19G9, 101' année, n° 1G b) la sulxlivision 4 de la subdivision 3 du lot 1047 (1047-3-4) au même cadastre; c) la subdivision 3 dc la subdivision 1 dc la subdivision 3 du lot 1047 (1047-3-1-3), au même cadastre; d) lu subdivision 8 dc la subdivision 1 dc lu subdivision 3 du lot 1047 (1047-3-1-8), au même cadastre; c) la subdivision 0 dc lu subdivision 1 dc la subdivision 3 du lot 1047 (1047-3-1-9), au même cadastre; /) lu subdivision 10 dc la subdivision 1 dc lu sulxlivision 3 du lot 1047 (1047-3-1-10), nu même cadastre; g) une partie du lot 1040, uu cadustre dc lu paroisse de Snint-Ambroisc de lu Jcunc-Lorcttc, ville de Ncufchutcl, de figure triangulaire, bornée au nord-ouest par lu ligue limitative dc la cité de Loretteville ct dc la ville de Ncufchutcl, uu nord-est par lc lot 1047, ct au sud-ouest pur lc lot 1046-35, mesurant 68 pieds au nord-ouest; h) une partie du lot 1047, uu même cadastre; bornée uu nord-ouest pur la ligne limitative de lu cité de Loretteville ct dc lu ville dc Ncufchutcl, uu nord-est pur lc lot 1048, au sud-est par la purtic vendue du lot 1047 duns l'acte enregistré sous le numéro 578 579, et uu sud-ouest pur les lots 1046 cl 1047-7; mesurant 299 pieds et deux dixièmes; au nord-ouest, environ 785 pieds au nord-est, ct 338 pieds et neuf dixièmes au sud-est; Avec bâtisses ct sujet à la servitude dc drainage en faveur dc la ville dc Loretteville enregistrée sous le numéro 357 S31.Pour être vendu nu bureau d'enregistrement de Québec, n Québec, le VINGT-DEUXIÈME jour dc MAI prochain à DIX heures dc l'avant-midi.Le shérif-adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 15 avril 1969.28878-o S A G U E N A Y De Terris Canada \u2014 Province de Québec District dc Suguenay Cour Supérieure, ( T UCIEN HARBOUR, in-No 25,748.{ ^ dustriel de La Malbaic.' district dc Soguenny, demandeur, rs ARMANI) GAGNON, journalier dc I«es Eboulemcnts, district de Sagucnay, défendeur.« Une terre située en la paroisse des Eboulemcnts, rang Ste-Cathcrinc-Est, contenant trois arpents de largeur sur quarante arpents de profondeur, plus ou moins, bornée au nord par le trait carré du rang Stc-Eulnlie, au sud par le trait carré du deuxième rang, à l'est par Paul-Émilc Tremblay, et à l'ouest par lc donateur, étant ct formant le lot numéro sept cent quarante-sept (747) et la moitié est du lot sept cent qunrantc-six (746) plan et livre de renvoi du cadastre officiel dc la paroisse des Eboulemcnts.Une terre située en la paroisse des Eboulemcnts, rang Ste-Cathcrinc-Est contenant un arpent de largeur sur quurantc arpents de profondeur, plus ou moins, bornée au nord par le trait carré du rang Stc-Eulalie, au sud par lc trait carré du deuxième rang, à l'est par l'acheteur el ù l'ouest pa r le vendeur étant et formant purtic ouest du lot sept cent quarante-six (Ptie O.746) (b) subdivision 4 of subdivision 3 of lot 1017 (1047-3-4) on the same cadastre.(c) subdivision 3 of subdivision 1 of subdivision 3 of lot 1047 (1047-3-1-3) on the same cadastre.(il) subdivision 8 of subdivision 1 of subdivision 3 of lot 1047 (1047-3-1-8), on the same cadaslre.(e) subdivision 9 of subdivison 1 of subdivision 3 of lot 1047 (1047-3-1-9), on the same cadustre.(f) subdivision 10 of subdivision 1 of subdivision 3 of lot 1047 (1047-3-1-10), on the same cadastre.(g) A part of lot 1046, on the cadaslre for the parish of Sainl-Ambroisc de la Jeune-Lorcllc, town of Ncufchutcl, of u triangular figure, bounded on the northwest by the boundary line of the city of Loretteville und of the town of Ncufchutcl, on the northeast by lot 1047, und on the southwest by lot 1046-35, measuring 68 feet on the northwest.(h) A part of lot 1047 on the same cadastre, bounded on the northwest by the boundary line of the city of Loretteville and of the town of Ncufchatcl, on the northeast by lot 1048, on the southeast by the part sold from lot 1047 in the deed registered under the number 578 579, and on the southwest by lots 1046 and 1047-7; measuring 299 feet nnd two tenths on the northwest, about 785 feet on the northeast, and 338 feel and nine tenths on the southeast.With the buildings and subject to the drainage servitude in favour of the town of Loretteville registered under the number 357 831.To be sold at the Registry Office of Québec, in Québec, the TWENTY-SECOND day of MAY next at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Associate Sheriff.Québec, April 15, 1969.2887S S A G U K N A Y De Terris Canada ¦\u2014 Province of Québec District of Sagucnay Superior Court, I T UCIEN HARBOUR, in-No.25,748.\\ *f dustrialist of La Malbaie, v districl of Sagucnay, plaintiff, M ARMANI) GAGNON, labourer of Les Ebou-lemcnts, district of Snguenuy, defendant.\"A farm situuted in the parish of Les Eboule-ments, Ste-Cuthcrinc East Range, containing three arpents in width by forty nments in depth, more or less, bounded on the north by the \"trail carré\" of Stc-Eulnlic Range, on the south by the \"trait carré\" of the second range, on the cast by Paul-Emile Tremblay, on the west by the donor, being nnd forming lot number seven hundred and forty-seven (747) and the east half of lot seven hundred and forty-six (7461 on the plan and book of reference of the official cadastre for the parish of Les Eboulemcnts.A farm situated in the parish of Les Eboulemcnts, Stc-Cntherinc East Range containing one arpent in width by forty arpents in depth, more or less, bounded on the north by the \"trail carré\" of Stc-Eulalic Range, on the south by the \"trait carré\" of the second Range, on the cast by the purchuscr and on the west by the vendor being and forming tlie west part of lot QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1909, Vol.101, No.10 2415 plan et livre de renvoi du cadaslre officiel de lu paroisse «les Eboulemcnts.Une terre contenant un arpent et demi dc front sur la profondeur qu'il peut y avoir à partir du trait carré séparant les terres «lu rang Stc-Cathcrine Est a aller au trait carré du rang St-Pascal Nord ou la route St-Nicolas, bornée au nord par la route dc St-Nicolas, au sud par Arthur Gagnon, ù l'est par Joseph Tremblay Hcrmel, ct à l'ouest par Raoul Bouchard, étant et formant la juste moitié est du lot numéro neuf cent «lix-huit (918) plan et livre «le renvoi du cadastre officiel de la paroisse des Eboulemcnts.Une terre située en la paroisse des Eboulemcnts, rang Ste-Catherinc Est, contenant deux arpents de front sur environ trente nrpents dc profondeur étant le lot numéro sept cent quarante-cinq (745) plan ct livre «le renvoi du cadastre officiel de la paroisse «les Eboulemcnts, avec bâtisses dessus construites.Pour être vendu au bureau du régistratcur, «le la première division d'enregistrement du comté de Charlevoix, à Baie St-Paul.JEUDI, le VINGT-DEUXIÈME jour du mois «le MAI 1969, à ONZE heures dc l'avant-midi.Lc shérif.Bureau «lu shérif, Sylvio Thkmblay.La Malbaic.le 11 avril 1969.28879-o seven hundred nnd forty-six (W.pt.746) on the plan and book of reference of the official cadastre for the parish of Les Éboulements.A farm containing one arpent and a half in front by the depth that can exist from the \"trait carré\" dividing the farms of Stc-Catherinc cast Range to the \"trait carré\" of St-Pascal north Range or St-Nicolas Route, bounded on the north by St-Nicolas Route, on the south by Arthur Gagnon, on the cast by Joseph Tremblay Hcrmcl, and on the west by Raoul Bouchard, being and forming the exact cast half of lot number nine hundred and eighteen (918) on the plan and book of reference of the official cadastre for the parish of Les Éboulements.A farm situated in the parish of Les Éboulements, Stc-Catherine East Range, containing two arpents in front by about thirty arpents in depth being the lot number seven hundred and forty-five (745) on the plan and hook of reference of the official cadastre for the pari-h of Les Éboulements, with the buildings thereon erected.To be sold at the Registrar's Office, of the first registry division of the county of Charlevoix, in Baie St-Paul.THURSDAY the TWENTY-SECOND day of the month of MAY 1969, ut ELEVEN o'clock in the forenoon.Sylvio Tremblay, Sheriff's Office, Sheriff.La Malbaic, April II, 1969.28879 INDEX No 10 ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 1019 \u2014 Manutentionnaires du Havre de Montréal navigation intérieure et côtière.2355 1019 \u2014 Freight Handlers \u2014 Inland and coastal navigation, Montreal Harbour.2355 1027 \u2014 Métallurgie, Québec.2355 1027 \u2014 Metal Trades, Québec.;.2355 1049 \u2014 Transport du poisson pris dans certaines réserves.2359 1049 \u2014 Transportation of fish taken within certain reserves.2359 1050 \u2014 Classement et la vente des produits de l'érable (règlements).2359 1050 - Classification and sale of maple products (regulations).2359 ASSEMBLÉE MEETING Alma & Jonquières Railway Company (The).2376 Compagnie du chemin de fer Alma & Jonquières (La).2376 AVIS divers MISCELLANEOUS Notices Chevaliers de Colomb de Ste-Gcnnaine inc., Conseil Sic-Germaine No 2988 (Régi.).2377 Chevaliers de Colomb de Vnl d'Or inc.Conseil Mgr.Gnspart Forest, p.o., No 2793 (Rrgl.).2377 Fabrique dc la desserte dc Saint-Mare de Latour (La) (Nom-Naine ch.).2384 Fabrique dc la paroisse dc St-Michcl dc Sillery (I.a) (Nom-Naine ch.).2384 Jacques-Cartier, cité-city (Requête-Petit ion).2378 Knights of Columbus of Ste-Germaine inc., Council Ste-Germaine No.29SS (By-lairs).2377 Knights of Columbus of Val d'Or inc., Council Mgr.Gaspard Forest, p.i>., No.2793 (By-laws).2377 Longueuil, cité-city (Requête-Pétition).2378 St-l)omini(pic, pur.(Requête-Pétition).2381 St-Dominiquc, village (Requête-Pétition).2382 Thetford Mine, cité-city (Requête-Pétition).2377 Université dc Montréal (Mod.statuts).2384 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME \u2014 Avt Baranovsky, Jack (Dem.-Appl.).2372 Bluczyc, Mendel (Dem.-Appl.).2370 Bonsaint, Claude (Dem.-Appl.).2371 D'Amour, Joseph (îcorges Roger (Dem.-.ippl.).2371 Brnest (Dem.-Appl.).2371 Ferstcnfelil, Nathan Joseph (Dem.-Appl.).2371 Pipher, Madeline Agnes (Dem.-Appl.).2371 Shemanashen, John (Dem.-Appl.).2370 Singler, Paul (Dem.-Appl.).2372 Tanguay, Joseph Edouard (Dem.-Appl.).2372 2416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 19 avril 1969, 101' année, «\u2022 16 CAISSES SAVINGS d'épargne cl de crédit on»/ credit unions Caisse d'économie du personnel dc l'institut Albert Prévost (Formation)____ 2362 Caisse populaire de Notre-Dame dc Ham (Ext.terr.).2362 COM PAGNIES COMPANIES Avis relatifs Notices relative à la loi des to the Act of Autorisées Licensed u fuirc des affaires to do Business Cit Travel Service, Inc.*.2374 Cities Service Minerais Corporation.2375 Lithium Corporation of America.2374 Plymouth Golf Bail Sales Company.2375 Chartes \u2014 Charters \u2014 demandes Application for d'abandon dc Surrender of Atlas Trimmings Ltd.2360 Dionne, (Luc) inc.2361 Institut classique père Albert L'Heureux (L').2361 Institut des Oblates Bénédictines dc Ville Marie (L').2361 .lover Corporation.2361 Lapinière Realties Inc.2361 Perjac Construction Ltd.2362 Quebec limitée.2360 Services Roger Garon ltée (Les).2361 Sun Valley Investment Corporation.2362 Dissoutes Dissolved Burnett Co.2337 Cangesco inc.2337 Compagnie dc Fabrication dc Meubles.233S Compagnie des Silicones du Commonwealth ltée (La).2341 Condi Realties Inc.2337 Confection Stc-Marie Cie ltée.233K Dimet Realty Corp.2338 Dimock Construction inc.'.2338 Drummond-McGregor Corporation.2338 Édifice Hethrington inc.2338 Furniture Manufacturing Company.2338 Gignac (R.M.) limitée.2339 Globe Shippers Ltd.2339 Guérard (Alphonse) inc.2339 Haïmes Schneider Sports of Canada Limited.2339 Immeubles Célestin inc.2339 Intercontinental Investment Inc.2339 Interfair Associates Ltd.2340 Kuhl (Martin) Inc.2340 Montreal Die Works Limited.2340 National Tavern Incorporated.2342 O'SuUivan (E.) (Canada) Ltd.2340 Pavillon Champlain inc.(La).2340 Perron Gold Mines Limited.2340 Placements Lucas inc.2341 Planned Homes Inc.2341 Reed (Chester) Co.Ltd.2341 Réserve des Chcneux inc.(La).2341 Rhodack Realty Coq).2341 Stc-Marie Mfg.Co.Ltd.233S Sic.Thérèse Holding Ltd.2342 Silicone Commonwealth ( 'ori>oration Ltd.2341 Standard Investment Corporation.2342 Sunbeam Realty Co.2342 Taverne Nationale, incorporée.2342 Threeway Holding Corp.2342 Town & Country Wear (1964) Co.Ltd.2342 Val-Kar inc.2343 Valmount Mining Exploration Ltd.2343 Victor Angelillo inc.2337 Voyages Transatlantiques & Internationaux inc.2343 Divers Miscellaneous A.B.E.G.Camping inc.(Dir.).2367 Adams Motel Inc.(Annul.).2307 Blier Inc.(Dir.).2360 Bolton, Tremblay & Compagnie (Dir.) 2368 Bolton, Tremblay & Company (Dir.).2368 C.G.M.Enterprises Ltd.(Dir.).2366 CAblovision inc.(Dir.).2367 Cic de Fabrication tic brosses Su|>érior (Dir.).2308 Kute-Knit Mfg.Corp.(Dir.).2367 Landex Realties Inc.(Dir.).2367 Lignes Tcmis liée (Les) (Dir.).2367 S.R.Maçonnerie inc.(Dir.).2367 S.R.Masonry Inc.(Dir.).2367 St, Johns Paper Products Co.Ltd.(Dir.) 2367 Shirley K.Maternité inc.(Dir.).2368 Shirley K.Maternity Inc.(Dir.).2368 Silver « K » Aluminum Products Ltd.(Dir.).2367 Superior Brush Mfg.Co.(Dir.).2368 Thibault (L.P.) inc.(Dir.).2367 Williams and Esber Co.(Dir.).2368 Wolfgang ltée (Nom-Name ch.).2368 Lettres pntcntcs Letters patent A.G.Radiator Service Inc.2328 A à Z surplus ltée.2288 Agences de publicité Succès ltée (Les).22S8 Aliments de Santé du Québec ltée.2289 Alliance des Professeurs de Danse du Québec inc.2280 Artisanat en bois Metro ltée.2318 Artisan Jewellers Inc.2280 Barbeau (Pierre) & Associates Inc.2290 Barbeau (Pierre) & associés inc.2290 Barrina Market Inc.2310 Beaubien Bar-B-Q Ltd.2290 Beaumont Distributors Inc.2200 Bertremo inc.2200 Bijouterie Suisse G.W.inc.- 2331 Bijoutiers Artisan inc.2280 Biais (René P.) automobile inc.2201 Boraje Investments Inc.2321 Boutique Napoléon inc.(La).2291 Breuvages Fiesta inc.2291 Brossard Printing Ltd.2310 Buffet Rizzo inc.2292 Bureau d'esthétique appliquée dc Qué- lwc inc.2292 Camille Val d'Or inc.2292 Canadian Hellenic Athletic Club.2293 Cantine Ti-Coq Mobile inc.2293 Cavcrsham Securities Ltd.2203 Centre Administratif de Sorel inc (Correction).2360 Centre d'information spécialisé inc.2291 Chaudière Ready Mix Inc.2291 Chomedey Sweater Company Ltd.2294 Clôtures Gibraltar inc.2295 Club des Lions dc Stc-Thérèse.2295 Club Du-Va-Les inc.2205 ( 'lub Lusimvic inc.(Le).2299 Club social Robidoux inc.2290 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 19, 1969, Vol.101, No.16 2417 Lettres patentes tetters Patent (suite) (continued) Comité des Loisirs de Rivière Trois-Pistoles.2290 Compagnie d'Optique Provinciale.2297 Compagnie du Chandail Chomedey ltée 2294 Corgesid inc.____ 2297 Corporation des Loisirs de St-Louis-dc- Francc (La).2297 Courtiers Interprovinciaux ltée.2298 Debclco inc.'.2298 Deca Laboratory Ltd.2312 Delta Automobiles Inc.2298 Dionne International Ltd.2299 Distributions Beaumont inc.2299 Distributeurs Frontenac inc.(Les).2305 Domaine d'Upton ltée.2299 Domaine Terrebonne inc.2300 Duplac inc.2300 Éditions Maintenant inc.(Les).2300 Edutec inc._.2301 Entreprises A.Bisson inc.(Les).2301 Entreprises Du-El inc.(Les).2301 Entreprises G.II.D.ltée (Les).2302 Fabre Building Inc.2302 Fédération d'Éducation physique du Québec.2302 Ferme du Lac Aylmcr ltée (La).2313 Ferme St-Urbain inc.(La).2303 Ferme Thibaudeau ltée.2303 Fer Ornemental dc Sherbrooke inc.(Lc) 2303 Fiesta Beverages Inc.2291 Fleury automobile inc.2304 Fonds S.L.B.inc.(Les).2304 Fortin (Germaine) inc.2304 Frigard Inc.2305 Frontenac Distributors Inc.2305 (îaleric du meuble Loiselle ltée (La).2305 Garage R.F.Dc Roose & fils inc.230G Cîary Cnpc Agency Inc.2306 Glcn Mountain Inc.2306 Gougcon's (Helen) Belle Cuisine Inc.2307 Grand Prix Moto-neige St-Jovitc Mont-Tremblant inc.2307 G.S.M.Inc.2307 Harrington Harbour Sports Inc.2308 Hébert (Gérard) limitée.230.8 Hcnmar Construction Inc.2309 Ideal Dry Wall Inc.2309 Immeuble Fabre inc.2302 Immeubles Léger inc.2310 Imprimerie Brossard ltée.2310 Industries de disques multicolores inc.(Les).2310 Input Trends Inc.2311 Interprovincial Brokers Ltd.2298 Jeanson avicole inc.2311 .lobert construction inc.2311 L.S.R.Construction ltée.2316 Labellc (Antonio) ltée.2312 Laboratoire Deca ltée.2312 Lacollc électronique inc.2312 Lac St-.Ican Oxygène inc.2313 Lake Aylmcr Farm Ltd.(The).2313 Lamontagnc auto électrique ltée.2313 Landreville (Orner) & fils inc.2314 Lane Sportswear Inc.2314 Lange (F.X.) inc.2314 Lasha Investments Ltd.2315 Léger Realties Inc.2310 Ligue dc Hockey Intermédiaire « C >\u2022 Rurale inc.'\u2022 ¦ ¦ 2315 Ligue dc Hockey Intermédiaire « C » dc Sept-Iles inc.2315 M.Humidité inc.2309 Marché Barrina inc.2316 Mazot inc.(Lc).2317 Ménard (M.C.) inc.2317 Metro Catering Service of Montreal Ltd.2317 Metro Woodcraft Ltd.2318 Modern Poultry Inc.2318 Montreal Home Renovation Associates Ltd.2318 Mont Stc-Adèle Lodge Inc.2319 Moussaillons de Cité Jacques-Cartier (Les).2319 Oeuvre des Terrains dc Jeux de St- Malachie inc.(L').2319 Optimist Club \u2014 L'Assomption.2320 P.A.& F.métal inc.2320 Paré inc.2320 Peck (Marcel) inc.2321 Placements Boraje inc.2321 Placements J.J.Ducharme ltée (Les).2321 Plein Jour inc.(I*).2322 Polymos inc.2322 Posd Investment Inc.2322 Posomar inc.2323 Pour L'Instant Designs Inc.2323 Pour L'Instant Dessins inc.2323 Prodcv Corporation Inc.2329 Produits Trouvcx inc.2323 Provincial Optical Company.2397 Québec Dance Teachers Alliance Inc.2289 Racine Auto Lave inc.2324 Reach Corporation.2324 Rcn-ManCorp.2324 Restaurant du Paradis Terrestre ltée.2325 Restaurant Pouformond inc.2325 Rockbottom Discount Ltd.2325 Roscl construction inc.2326 Salaison Gascogne inc.2326 Salon Carlain (1969) inc.2326 Sanrcmo Compagnie ltée.2327 St-Cvr Moto ct Vélo inc.2327 St-Jcan dactylo inc.2327 St-Michcl radio taxi limitée.2328 Service de Radiateurs A.G.inc.2328 Service des Ondes limitée.2328 Société de gestion Richelieu inc.2329 Société d'investissement industriel Betisa inc.(La).2329 Société Prodcv inc.(La).2329 Stadcon Limited.2330 Steve Stecko Transport Ltd.2330 Surprenant (Jean E.) & associés ltée.2330 Surprenant (Jean E.) & Associates Ltd.2330 Swiss Jewellery G.W.Inc.2331 Tapis Casimir inc.2331 Taverne Champlain inc.2331 Textiles Mondor inc.(Les).2332 Trouvcx Products Inc.2323 Tuatara Holdings Inc.2332 Unité île réadaptation (Domrémy) Accueil Rouyn-Noranda inc.2332 Vador inc.2333 Vanpro Ltd.2333 VE 2 RM Inc.2333 Westridge Construction Inc.2334 Sièges sociaux Head Office» Andc Construction LUI.2363 Appartements Lacordaire inc.(l«cs)- 2365 2418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 1969, 101' année, ;t° 16 Sieges sociaux 7/ead Offices (suite) (contitiued) Carbonneau (Germain) cl fils inc.23C4 Carslev (Jean) Interiors Inc.2304 Chrysta Pizza Inc.2364 Construction Ande ltée.2363 Designers Three inc.2365 Dévclopiiements Lac-dés-Monts inc.2363 Dieco Inc.2362 Frederic Viau Transport limitée.2366 Globelmi Inc.2363 Jeminosy Inc.2363 Kerr Automobiles Ltd.2365 Landex Realties Inc.2363 Lido inc.(Le).2364 Lido Inc.(The).2364 Lignes Ternis ltée (Les).2364 lagging Development Cor|>oration.2365 Nadon Sport Inc.2365 Produits Trouvex inc.2366 Rivard (Z.) inc.2363 Société de placement Triangle inc.2366 Société immobilière La flèche inc.(La).2366 Tcmis Pole Line Ltd.2364 Triangle Investment Corp.2366 Trouvex Products Inc.2366 Viau (Frederic) Transport ltée.2366 DEMANDES APPLICATIONS u la Législature to Legislature Candiac, villc-town.2373 Église .Baptiste dc Marieville.2373 Église française dc Québec.2373 Fabrique de la paroisse de Ste-Sophic.2373 Laval, ville-city.2372 St-.Ican-dcs-Pilcs, munie.2373 Trois-Rivières, cité-city.2374 Verdun, cité-city.2374 LIQUIDATION WINDING avis dc up Notices Société coopérative agricole de beurrerie de St-Elzéar.2375 Téléphone Rural de St-Gédéon (Lc).2375 MIN1STÈRES DEPARTMENTS Education Education Municipalité scolaire dc: School Municipality of: Argcnteuil (Prot.) (Acc.-Grant.).2386 Aylmcr-Rnpidc-des-Chênes, (Acc.-Grant.).2386 CInudièrc-Etchemin (Acc.-Grant.).2387 Cowansville, (Acc.-Grant.).2387 Des Chenaux (Dem.-Appl.).2386 Dolbeau (Acc.-Grant.).2388 Donnacona (Acc.-Grant.).2388 East-Angus, villc-town (Cath.) (Dem.-Appl.).2386 Farnhani (Acc.-Grant.).2388 La Tuque (Prot.) (Acc.-Grant.).2388 Ln Vallièrc (Acc.-Grant.).2389 lennoxville (Acc.-Grant.).2389 L'Érablière (Acc.-Grant.).23S9 Monseigneur Vachon (Acc.-Grant.).2390 Montcalm (Acc.-Grant.).2391 Normandie (Acc.-Grant.).2392 Normandin (Acc.-Grant.).2392 Nouvclle-Acadic (Acc.-Grant.).2393 Princeville (Acc.-Grant.).2391 Ristigouclie (Acc.-Grant.).2394 Roberval (Acc.-Grant.).2395 Rouyn (Dem.-Appl.).2397 Stc-Martine (Acc.-Grant.).2395 Shawinigan-Sud (Acc.-Grant.).2396 Sherbrooke (Cath.) (Acc.-Grant.).2395 Soulanges (Acc.-Grant.).2395 Valléc-dc-Mistassini (Acc.-Grant.).2396 Vaudreuil (Acc.-Grant.).2397 Institutions Financial financières, Institutions.compagnies Companies ct coopératives nnd Cooperatives Assurances: Insurance: British Canadian Insurance Company (The) (Petition).2376 Compagnie d'Assurance Canadienne Britannique (La) (Requête).2376 Compagnie d'assurance Provinces-Unies (La) (Dir.).2377 United Provinces Insurance Company (The) (Dir.).2377 Terres et Forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Charlesbourg, pur.2331 I
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.