Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
lundi 4 (no 1)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1965-01-04, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" 97e ANNÉI vol.97 OFF ¦in ES I1 ' N\" 1 officielle de (Mec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE J A N1965 Québec, lundi 1 janvier 196.\"» Règlements l3 Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine.Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte «le l'annonce «lans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais «les intéressés, d'après le tarif officiel.3* Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent ôtre publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur n'-ception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits «le l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.J>° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chè«iue ou mandat à l'ordre «lu Ministre des Finances.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retanler la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions «le l'article 7.9\" Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont pri«*s d'en aviser l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et «l'autre des frais onéreux de reprise.Quebec, Monday, January t.I%.\"> Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer.Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the two official languages.When copy is supplied in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Pay cash and before publication for advertising copy according to the rates set forth below, exception when the copy is to be published several times.In that event, the interested party shall pay upon receipt of his accoin t and before the second insertion: otherwise this insertion will be suspended without further notice an«l without prejudice to the Queen's Printer who will refund any overpayment.5.Subscriptions, price of documents, etc., arc payable strictly in advance.G.Remittance must be made to the order of the Department of Finance, by cheque or money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the r 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: Si per 100 words.Singh- copies: 40 «\u2022ents each.Slips: $1.50 per dozen.Subscriptions: 110 per year.X.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition «»f the Gazette for the first insertion; the third to the number of insertion, and the letter \"«>\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.Ro«ii Lbfbbvrb, Queen's Printer.Parliament Buihlings, Quebec, May 5, 1902.8903 \u2014 l-52-o Letters Patent Artro Inc.Notice is hereby given that limier Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Louis Orenstein, Queen's Counsel.5054 MacDonald, Hampstead, Jason Ruby, 2800 Ekers, Montreal, ami John Michelin, 5200 Prince of Wales, Montreal, all three advocates, for the following purposes : To deal in jewellery, costume jewellery, precious metals, rhinestones, pearls, jewels, gems ami stories of all kinds, umler.the name \"Artro Inc.\", with a total Capital stock «>f $40,000, divided into 2,000 common shares f Quebec, incorporating: Leonard Bélanger.G«''.\\ the Lieutenant-Governor of tin- Province of Quebec, incorporating: Stanley St inman, advocate, 480 Arlington, Claude N deau, advocate, 1989 Gait St.West, and Lise I tube, student, fille majeure, I 10 Terril, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on the bus iuess dealing in motor vehicles of all kinds, ami their rental, their accessories and parts ami to carry on as garagemen, under the name of \"Brouillard Rental Inc.Location Brouillard inc.\".with a total capital stock «>f 675,000 divided into 750 common shares of $100 eat h.The bead office of the company will !>f St-Francis.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of November, 1964.Raymond Don vii.i.k, Assistant Secretary of the Province.8902 6237-64 Ace Mortgage Corp.Notice is hereby given that under l'art I of the QucIk'c Companies Act.letters patent, bearing «late the Oth day of November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Mitchell Klein.188 Wexford Crescent.Ilampstead, Daniel Miller.5714 Edgemore Road, (Yite-St-Luc.and Alan Golden, 1067 Vendôme Avenue, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a finance company, under the name «;f \"Ace Mortgage Corp.\", with a total capital stock «>f 840,000, divided into 20.000 common shares of $1 each an«l 2.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will l>e at 4770 Kent Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the ollice of the Provincial Secretary, this 0th day «*f November, 1904.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.S902-o 4998-64 Agence immobilière Astra inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of Noveml>er, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Hervé Lafortune, real estate broker, 570 côte Ste-Catherine, Outremont, Gertrude Richard, 10000 Tolhurst St., and Marcelle Coupai, 10577 St-Denis St., the latter two secretaries, of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 4, 19tif>, Vol.97, So.I 7 Faire alfaires eoniine compagnie «l'immeuble et de roust met ion, sous le nom de « Agence immobilière Astra inc.», avec un capitul «livisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 350 actions privilégiées «l'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de .Montreal.Donné au bureau du secretaire «le la province, ce '24e jour «le novembre 1904.#> Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillb.8902-o 5304-04 Allied Crane Services Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie f the company will be at St-Alexandre, judicial district of Iberville.Given at the office of the provincial Secretary, this 18th day «)f November.1964.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.S902 4714-64 L'Aqueduc de St-Dunstan inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the ,24th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Louis E.Frechette, commercial traveller, Paul M.Boutet.garageman, ami André Mackay.insurance broker, all three of St- Dunstan-du-Lac-Bcauport.for the following purposes: To operate a private system «tf acpieduct.under the name «>f \"L'Aqueduc «le St-Dunstan inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares «»f $10 each an«l into 3,900 preferretl shares «>f $10 each.The head office of the company will be at St-Dunstan-rt.judicial «listrict of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of November, 1904.Raymond Douville.Assistant Secretary tf the Province.8902 5314-64 G.Archanibault contr.ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of November, 1964, have ben issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gertrude QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, January i, 196», Vol, 97, So.1 I corporation: Gertrude Bourdcau, .secrétaire, fille majeure, 1430, St-Mare, Marguerite Villeneuve, secrétaire, épouse séparée «le biens «le René Villeneuve, 0203, Ma/.arin, toutes deux de Montréal, et Maurice Martel, ch., avocat, 1301, St-Viateur, ouest, Outreinont.pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en «-oustruction, sous le nom de « G.Archambault contr.ltée », avec un capital total «le $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 3.0(H) actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnies sera à St-Louis-«ie-Terreljonne, «listrict jiuliciaire de Terre-lionne.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 25e jour «le novembre 1064.I.e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillb.8902-ç 5880-64 Armature A.C.E.P.inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 24e jour «le novembre 1904, constituant en corporation: (Juy Desroches, entrepreneur, 5551, lie avenue, Montréal, Eugène-Oéranl Plaide, marchand, 254.rue Macaulay, St-Lambert, et Albert Carpentier, surintendant à l'Hydro- Québec, 10240, rue Verville.Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « Armature A.C.E.P.inc.», avec un capital total «le $3(5,000, divisé en 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 24e jour de novembre 1904.IjC Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.8902-e ' 5026-64 < 'abri ni's Coffee Shop Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a «\u2022té accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu ISe jour de novembre 1804, constituant en «\u2022«irporation: Peter Di Florio.propriétaire «le restaurant, Jeannette Bonetto, ménagère, épouse séparée de biens dudit Peter Di Florio, et Joseph Di Florio, vendeur, tous tr«>is de 6622, Châtelain.Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce de restaurateurs, sous le nom de « Cahrini's Coffee Shop Inc.».avec un «\u2022apital total «le $40.000.divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie se ni 5055, St-Zotkjtie, est, Montréal, «listrict jiuliciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 18e jour «le novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.8902 4846-64 Hourdeau, secretary, fille majeure, 1430 St-Marc, Marguerite Villeneuve, secretary, wife separate as to property «»f René Villeneuve, 0203 Ma/.arin, both of Montreal, ami Maurice Martel, «;.f $10 each and Into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will lie at St-Louis-«le-Terreb«)iine, judicial «listrict of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of November, 1904.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8808 5259-64 Armature A.C.E.P.inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 24th day of November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, in«'orporating: Guy Desroches.contractor, 5551, 11th Ave., Montreal, Eugène-Gérard Plante, merchant.254 Macaulay St., St-Lanibert, ami Albert Carpcn-tier, superintendent et Hy«lro-Quebec, 10240 Verville St., Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Armature A.C.E.P.inc.\", with a total capital stock of 836,000, divided into 000 common shares of a nominal value of $10 each and 300 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of November, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902 5026-64 Cahrini's Coffee Shop Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent.bearing «late the 18th day of November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Peter Di Florio.restaurant owner, Jeannette Bonetto, housewife, wife separate as t«> pn perty of the said Peter Di Florio.ami Joseph Di rkmo, salesman, all three of 0022 Châtelain.Montreal, for the following purposes: To carry on the business «if restaurateurs, under the name «>f \"Cahrini's Coffee Shop Inc.\".with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office «>f the company will lie at 5055 St-Zotiquc East.Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this INth day «)f November.1904.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.X902-o 4846-64 10 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 4 janvier 1996, 97' année.So 1 Canadian Dinette Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par !«\u2022 lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu lOejourde février 1964, constituant en corporation: Charles Brownstein, avocat, 6612, chemin Nice, Côte-St-Luc, Mary Goldwater, secrétaire, épouse séparé»- f Sydney L.Goldwater, 36 Avon-dale Street, wlmrd-des-Ormeaux, Isidore Green* baum, advocate, 615 Westluke, Cote-St-Luc, ami Harm h Pollack, advocate, 6085 De Vimy Avenue, Montreal, for the following purposes: To deal in display fixture.-, ami furniture of all kinds, under the name f \"Canadian Dinette < '\u2022>.\".with a total capital stock of $ 10.000.divided into 2.000 common shares of the par value «>f $10 each and 2.000 preferred shares «>f the par value of 810 each.The head office «>f the company will In- at Montreal, jmlicial district of Montreal.(îiven at the ollice of the Pr«»vincial Secretary, this 10th day of December, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.S902-o 557-64 Canadian General Distributors Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 26th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Armand Thibodeau, industrialist, Jean-Guy Thibodeau, tradesman, ami Guihnette St-Amant, housekeeper, wife contractually separate as to property «>f the said Jean-Guy Thibodeau, all three of St-John's, for the following purposes: To carry on a business dealing ironware and hardware products, sports articles, ami huiMings materials, under Lhe name of \"Canadian General Distributors Inc.\", with a total capital stock of $40,090, divided into 1,000 common shares of $10 each, and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at St-John's, jmlicial «listrict «)f Iberville.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5074-64 Cel-Air plastique It«'«-Cel-Air Plastic Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1964, have lu-en issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: René Auger, technician, 7415, Chambord, Montreal, Gérar«l Auger, administrator, 1746 Bédard, Vi-mont, and Richard Lalonde, administrator, 15601 Fernand, Picrrefonds, for the following purposes: To carry on a business dealing in insulation, under the name of \"Cel-Air plastique ltée \u2014 Cel-Air Plastic Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 100 common shares of $100 each ami into 900 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, January lOtiô.l'ol.!)7.No.I Le siège H«>oial «le la compagnie sera 8402.9e avenue, St-Michel, district jiuliciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 23e jour «le novembre 1004.Is Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.8902-0 498144 Cie i m mobilière de Contrecoeur inc.Contrecoeur Real Estate Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu «le In première partie «le la Loi «les compagnies which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hohl is to be limited, is «1Û0.0C0.The head office «>f the corporation will be at Lake-Sergeant, county of Portneuf.jmlicial «listrict Of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of November.1904.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.8902 5228-64 Commission de boxe amateur du Bas St-Laurent inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 19th «lay of November.1964.have been issued by the LieutenanteGovernor of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January i960, Vol.97, No.1 13 \u2022 in I0e jour de novembre 1064, constituent en corporation sans capital-actions: Roland Sylvain, instructeur physique, I bald Bnvard, gérant du stade de la ouville.S002-o 4832-64 the Province «>f Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Roland Sylvain, physical education instructor.Ibald Bavard, manager of the stadium in tin* young people's city, and Antoine Rioux, manager of the bowling alley in the Poyer Patro, «II three of Rivière-du- Loup, for the following purposes: To promote sports and physical culture in general, under the name of S I 'oininission de boxe amateur du Has St-Lntuvut inc.\".The amount to which the vnlue of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is 840.000.The head office «»f the corporation will be at Riviorc-du-Loup.judicial (list ret of Kainouraska.Given at the office of the Provincial Secretary, this imi, day of November, 1964.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.8902 4832-64 Compagnie de prêts J.N.limitée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 25e jour «le novembre 1964.constituant en corporation, Hélène(ïélinas, avocat, fille majeure, 177, chemin Dulferin.Ilampstead.Georges-Charles Clermont, avocat, 455, Beverley.Mont-Royal, René Cousincau, avocat, 3620, Limoges.St-Laurent.et Monique Brousseau, secrétaire, épouse COntractueUement séparée «le biens de Paul Brousseau.3708.Verdun, Verdun, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le prêts, sous le nom «le « Compagnie «le prêts J.X.limitée », avec un capital total «le $40,000, divisé en 4,000 act ions ordinaires «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Jacques-Cartier, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du Secrétaire «le la province, ce 25e jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire Je la prorince, Raymond Dor ville.8902-o 5087-04 La Compagnie de publicité Trans-Public ltée The TraiiH-Publie Advertising Com pan v Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 27e jour «le novembre 1904, constituant en corporation: Maurice Trudeau, publiciste.3932.Mentana, Montréal, Henri Dutil.avocat, 452, route de l'Eglise, Ste-Foy, et Monique Lacroix, secrétaire, 322, «le la Reine.Québec, pour les objets suivants: Exercer les activités d'entrepreneurs et «le conseillers en publicité.SOUS le nom «le « La Compagnie de publicité Trans-Public ltée \u2014 The Trans-Public Advertising Company Lt«l.».avec un capital total de $25.000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 50 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, «listrict judiciaire «le Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.89t)2-o 5383-04 Compagnie de prêts J.N.limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 25th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Hélène (îélinus.advocate, fille majeure, 177 Dufferin Road, Ilampstead.Georges-Charles Clermont, advocate, 455 Beverley.Mount Royal, René Cousineau, advocate, 3020 Limoges, St-Laurent, and Monique Brousseau.secretary, wife contractually separate as to property of Paul Brousseau, 3708 Verdun, Verdun, for the following purposes: To carry on business as a loan company, under the name of \"Compagnie «le prêts J.X.limitée\", with a total capital stock of 840.000, divided into 4.000 common shares of $10 each.The head office «>f the company will be at Jacques-Cartier, jmlicial «listrict of Montreal.(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of November, 1904.Raymond CoovtLLE, Assistant Secretari/ of the Province.8902 5087-64 La Compagnie de publicité Trans-Public ltée The Trans-Public Advertising Company Ltd.Notice is heregy given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the 27th «lay of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec incorporating: Maurice Trudeau, publicist.3932 Mentana, Montreal, Henri Dutil.advocate.452 Route «le l'Eglise, Ste-Foy.and Monique Lacroix, secretary, 322 de la Reine, Quebec, for the following purposes: To carry on t lie operations of contractors and counsellors in publicity, under the name of \"La Compagnie de publicité Trans-Public ltée \u2014 The Trans-Public Advertising Company Ltd.\".with a total capital stock of $25.000, divided into 200 common shares of $100 each and into 50 preferretl shares of $100 each.The head office.of the company will be at Quebec, jmlicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of November, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902 5383-64 GAZETTE OFFICIEILE DE QVÊIIEC, J, janvier M5, 97' année.No I It Continental Shipping Company l-tf the Provincial Secretary, this 19th day of November.1904.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.8902 5226-64 Creative Press Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day «f November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating:Stephen Garber, executive.5761 cote St-Luc Road, Côte-St-Luc, Donald W.Seal.5790 Northmount, Philip Shaposnick.6486 Coolbrook, both of M°ntreal, and Gary Moscowits, 200 St.Aubin, St-Laurent, the latter three attorneys, for the fallowing purpose's: To carry on business as printers ami publishers, umler the name of \"Creative Press Ltd.\", with a total capital stock «>f 640.000, divided into 2.000 common shares of $10 each and 21000 preferred slum's of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 4 janvier 1066, 071 année.Xo 1 16 Donné au bureau du secrétaire «le la province, cea23e jour de novembre L064.I.e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillb.8902 5280-64 ( i edilae inc.VA vil ett ilonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, pur l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du Te Jour d'août 1064, constituant en corporation: Edouard Meunier, commis de bureau, boulevard des Mille lies, St-Franeois-de-Sales, .lack Schneider, dessinateur, 0525, Wilderton, #400, Montréal, et Pernand Noiseux, ingénieur conseil, 1409, boulevard Laird, St-Laurent, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'achats de créances, sous le nom de « (redifac inc.».avec-un capital total de 640,000, divisé en 4.0t)l> actions ordinaires de §10 chacune.1/e siège social «le la oempagnic sera à Montréal, district jiuliciaire de Montréal.Donne au bureau «lu secrétaire de la province, ce- 14e jour «le décembre 1004.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.8902-o 3502-04 Dale Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accortlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Quebec, «les lettres patentes, en «late du 20e jour de novembre 1904, constituant en corporation: Theodore IL 1'oli-.uk, 144, chemin Piochley, Ilampstead, lrwin S.Brodie, 7521, chemin Mountbattcn.Côte-St-Luc, Cyril E.Schwisberg, 4915, avenue Fulton, Montréal, tous trois avocats, et Fran«;ois Renaud, étudiant en droit, 133, rue Beauce, Beauharnois.pour les objets suivants: Agir comme agents et courtiers à des fins d'achat et de vente d'immeubles, soas le nom de a Dale Realties Ltd.», avec mi capital total de $10,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune.* Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donne au bureau «lu secrétaire |>.97' année, A'o / Donné nu bureau du secrétaire de la province, «\u2022c 1 le jour «le novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond DOUVILLB.8902 5071-04 Le* Kntreprises D.I*.R.liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi dee compagnie! «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 20c jour «le novembre 1904, constituant en corporation: Claude Paquette, 05.rue St-Pierre, Terrebonne.Paul Reeves, 252, Victoria, Longueuil, et Monique Coupai, 3014, Van Horne.Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le transport et «l'entreposage, sous le nom «le « Les Knt reprises 1).P.R.ltée », avec un capital total de $75,000.divisé en 250 actions ordinaires «le $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à St-François, district jiuliciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire-de la province, CÇ 20e jour «le novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond DorjViLLB.80O2-o 6062-04 Les Entreprises Mario inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 17e jour «le novembre 1904.constituant en corporation: Pierre Chèvrefils, Ste-Martine, Yves Ampleman, Beauharnois, tous deux avocats, et Marcel Laguë, comptable agréé, Châteauguay, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, motels, auberges et restaurants, sous le nom de « Les Entreprises Mario inc.», avec un capital total de $75,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune, 1,503 actions privilégiées classe «A» «le $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées classe « B » de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Beauharnois, district judiciaire «le Beauharnois.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 17e jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dolvillk.8902-o 5174-64 Given at the office of the Provincial Secretary, this 11th day of November, 1904.Raymond Dou vi m.k.Assistant Secretary of the Province, 8902-o 5071-64 Les Entreprises I).P.It.ltée Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 20lh day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Paquette, 05 St-Pierre St., Terrebonne.Paul Reeves, 252 Victoria, Longueuil, ami Monique Coupai, 3014 Van Horne, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a tansportation and storage company, umler the name of \"Les Entreprises p.P.R.ltée\", with a total capital stock of $75.000.divided into 250 common shares of 8100 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at St-Francois, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of November.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5002-04 Les Entreprises Mario inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the 17th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Chèvrefils, Ste-Martine, Yves Ampleman, Beauharnois, both advocates, and Marcel Laguë, chartered accountant, Châteauguay, for the following purposes: To operate hotels, taverns, motels, inns ami restaurants, under the name of \"Les Entreprises Mario inc.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 4,000 common shares of $10 each, 1,500 preferred class \"A\" shares of $10 each and 2,000 preferred class \"B\" shares of $10 each.The head office of the company will l>e at Beauharnois, judicial district of Beauharnois.Given at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.S902 5174-64 Excavation Lery Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été aircordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Quélicc, des lettres patentes, en «late du 25e jour de novembre 1964, constituant en corporation: Gordon N.Rutledge, entrepreneur, 72, Hudson, Mont Royal, Lan ri u Lapointe, 4028, Harvard, et J.-Clovis Dagenais, 3549, Northclifîe, ces deux derniers avocats et conseils en loi de la Reine, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de « Excavation Lery Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Ste-Philomène, district judiciaire de Beauharnois.Excavation Lery Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gordon N.Rutledge, contractor, 72 Hudson, Mount Royal, Lauriu Lapointe, 4028 Harvard, and J.-Clovis Dagenais, 3549 Northclifîe, the latter two advocates and Queen's Counsels, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Excavation Lery Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Ste-Philomène, judicial district of Beauharnois. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January i960, Vol.97.No.I 21 Donné un bureau du secrétaire de la province.00 25e jour de DOVembra 10(54.Le Sous-secrétaire' de la province, Raymond Douvillk.8902 5207-04 Les Fermes Relcan inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour de novembre 19(54.constituant en corporation: Jacques Yerdonek, Jean Yerdonck et Georges Verdonck, industriels, de Ste-Marthe, comte «le Yaudreuil, pour les objets suivants: Faire le commerce «le four rages verts, sous le nom de « Les Fermes Bclcan inc.», avec un capital total «le $40.000, divisé en 1.000 actions onlinaircs «le 810 chacune et en 800 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Ste-Marthe, «listrict jiuliciaire de Beauharnois.Donné au bureau du secrétaire «le la province, «\u2022e 23c jour «le novembre 1904.Le 8omê secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902-o 4340-64 Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of November, 19(51 Raymond Douvillk, Aeeiitant Secretary of the Province.8902-.» 6207-64 I/CH Fermes lb ban inc.Notice is hereby given that Under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 23rd day of November, 19(54, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jac«pics Verdonck, Jean Verdonck and Georges Yer«lonck, industrialists, of Ste-Marthe, county of Vau-drcuil.for the following purposes: To carry on a business dealing in green fodders, umler the name of \"L«\\s Fermes Belcan inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 1,000 common shares of $10 each ami into 300 prefered shares of $100 each.The bead office of the company will be at Ste-Marthe.judicial «listrict of Beauharnois.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day uvcrneiir de la province «le Québec, des lettres patentes, «-n date «lu 24e jour f a par value of 810 each.The head office of the company will be at 5350 Ferrier Street.Montreal, jmlicial «listrict of Montreal.(iiven at the ollice «>f the Provincial Secretary.this 2ml day of November; 1904.Raymond Dim villi-:.Assistant Secretary >>f the Province.8902-.6187-64 Fondation Charles Le.Moyne Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act.letters patent.bearing date the 24th day of November.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province f the Provincial Secretary, this 24th day of November.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5308-64 La Fondation de la brusseric Dow Dow Brewery Foundation Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi «l«-s compagnies «le Québec, il a été BCCOrdé, par le licutonant-geuverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour «l'août 1901.constituant en corporation sans capital-actions* David Henry Holland, avocat.St-Lambert, William Patrick Creagh.commis en loi, Mont Royal, Ernest William Mockridge, gérant.St-Lambert, Clifford George Meek, teneur de livre-.Montréal, Guy Ambrose Miller, gérant.St-Bruno-«le-Montar-ville, et Donald Harry Bunker, commis en comptabilité, St-Lambert, pour les objets suivants: Recevoir f an investment company, under the name of \"Futura Investment Corporation\", with s total capital stock of 640,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and 2.000 preferred shares «>f a par value of $10 each.The head office «>f the company will be at 500Ô Queen Mary Road.Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of November, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902-0 5185-04 Curage Graeicn Béluug«'r liée Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Graeicn Bélanger, garageman, Lucienne Galhenne, housekeeper, wife «>f the said Grecian B langer, ami Normand Paradis, mechanic, all three Of Sept-lles.for the following purposes: To carry on a business dealing in motor vehicles, their accessories and parts and to operate as garagemen, under the name «>f \"Garage Graeicn Bélanger ltée\", with a total capital stock of 830,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Sept-Res, judicial «listrict of Hauterive.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 27th day «>f November.1904.Raymond Doi;ville.Assistant Secretary of the Province.8902 5244-04 21 QAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 4 janvier I960, 07' année.No 1 Garage liiopel inc.Avis est donné qu'on vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec.«I«'s lettres patentes, en date «lu 30c jour de novembre 1004.constituant en corporation: Réal Kiopcl.gérant de la mécanique, 157, 21e Avenue.Marcel Riopel, gérant «le service, 159.21e Avenue, et René Riopel, gérant «le ventes, 335, 43e Avenue, tous trois de l.achine.pew les objets suivants: Exercer le commerce de véhicules automobiles, leurs accessoires et parties et faire affaires comme garagistes, sous l«> nom «!«¦ « Garage Kiopcl inc.».avec un capotai total de 340,000, divisé en 3.000 actions ordinaires «l'une valeur nominale de SI chacune et en 370 actions privilégiées d'une valeur nominale «le 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 2125.rue Notre-Dame.Larhinc.district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 30e jour «le novembre 1064.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville:.8002-c 5313-04 Claude Ccndron inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Quebec, il a été accoidé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 9e jour «le novembre 1904, constituant en corporation: Claude Gendron, épicier, 80, Bien-ville.Longueuil.Lucien Bouthillier.boucher, 702, Fort St-Louis, Boucherville, et Denis Lanctot, avocat.48.rue Cicot, Boucherville, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers, sous le nom «le « Claude Gendron inc.», avec un capital total «le $40,000, «livisé en 1.250 actions onlinaires «le $10 chacune et en 275 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Jacques-Cartier, «listrict jiuliciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 9e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillb.8902-o 4948-04 Garage Riopel inc.Notice is hereby given that under l'art I of of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 30th day «>f November, 1904, have been Issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Real Kiopcl, manager of mechanics, 157, 21st Ave., Marcel Riopel, service manager, 159, 21st Ave., ami Kené Kiopcl, sales manager, 335, 43rd avenue, all three of Lachlne, for the following purposes : To carry on the business «laaling in motor vehicles, their accessorial and parts an«l to carry as garagemen.umler the name of \"Garage Riopel inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of a nominal value of 81 each and into 370 preferred shares of a nominal value «>f 8100 each.The head office of the company will be at 2125 Notre-Dame St., Luchinc, judicial district of Montreal.(iiven at the ollice of the Provincial Secretary, this 30th day of November, 1904.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8002 5313-04 Claude Gendron inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 9th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Gendron, grocer, 80 Bienville, Longueuil, Lucien Bouthillier, butcher.702 Fort St-Louis, Boucherville, ami Denis Lanctot, advocate, 48 Cicot St.Bou«4ierville, ft>r the following purposes: To carry on business as grovers, umler the name of \"(lande (îemlron inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,250 common shares of $10 each and into 275 preferred shares of $100 each.The head oflice of the company will be at \u2022lacques-( 'artier, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of November, 1904.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902 4948-04 General Automotive Kngine Rebuilders Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 20e jour de novembre 1904, constituant en «corporation: Charles-Joseph Gélinas, C.B., 515, Champagneur, Outremont, Pierre Bourquc, 48, Chartres, et François Bélanger, 14 A.-Lavigne, ces deux derniers «le Dollard-des-Ormcaux, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer un commerce «le mécaniciens, sous le nom «le « General Automotive Engine Kebuilders Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $50 chacune et 500 actions privilégiées «le $50 chacune.l.e siège social de la compagnie sera à Montréal, district jiuliciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province.Ce 20e jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dot-ville.S902 5167-04 General Automotive Engine Rebuilders Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, tearing «late the 20th day of November.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Charles-Joseph Gélinas.Q.C., 515 Champagneur, Outremont, Pierre Bourque, 48 Chartres, and François Bélanger, 14 A.-Lavigne, the latter two of Dol-lard-des-Ormeaux, all three lawyers, for the following purposes: To carry on business as mecanicians, under the name of \"General Automotive Engine Rebuilders Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $50 each and 500 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of November, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902-o 5167-64 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January J,, 1965, Vol.07, A'o./ 2ft Goldman Pant Contractors Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de novembre 1904, constituant en corporation: Irving Halpcrin, avocat, 5609, chemin de la reine Marie, Ilampstead, Daniel Morris, avocat, 4502, Lacombe, Montréal, et Georgette Lavoie, réceptionniste, fille majeure, 217, rue Georges-Yunicr, Pont-Viau, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tailleurs, sous le nom de « Goldman Pant Contractors Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires «le $10 chacune et 3,500 actions privilégiées «le SU) chacune.Le siège social «le la compagnie sera 427, ( 'hamplain, Joliette, district judiciaire «le J«>liette.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de novembre 19G4.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.8902 5332-04 Goycttc armature inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 25e jour «le novembre 1904, constituant en corporation: Paul-Emile Lapointe, gérant, 1771, rue Guimond, Fernand Goycttc, entrepreneur, tous deux de Trois-Rivières, et Donatien Goyotte.entrepreneur, 120.rue Heauchemin, Cap-dc-la-Ma«leleine.pour les objets suivants: Faire le commerce «le métaux «le toutes sortes, leurs produits et sous-prtxluits, sous le nom de r the following purposes: To carry on business as general building contractors, umler the mime of Lee Habitations Tremblay inc.\".with a total capital stock «>f 810.000, divided into loo common shares «>f $100 each.The head office f the company will be at Montreal, judicial district < f Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secret an/ of the Province.8902 4984-64 L'Harmonie monseigneur Dumas Notice is hereby given that under Part III f November, 1904.have been issued by the Licutcuant-(i«>vemor of the Province «»f Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Noël Moisan, professor, 139 de l'Hôpital, Loretteville, Emile Beaupré, employee, Château-d'Eau, ami Orville J.Bourque, technical officer, 27 de NL'.pital.Lorett«'vill«'.for the following purposes: To group into an association persons interested in music, under the name of \"L'Harmonie monseigneur Dumas\".The amount to which the value «>f the immoveable property which the corporation may scquire and hold is to be limited, is 8100.000.The head office of the corporation will be at Loretteville, judicial «listri«-t of Quebec.(iiven at the office «»f the Provincial Secretary, this 20th day of November.1964.It ay.m on d Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 4786-64 Les Immeubles du Bassin de ( '.bam hi y inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 20th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Luc Geoffroy, 821 Briand Blvd., Chainbly, Guy Bissonnette, 4351 Oxford St., Montreal, both advocates, ami Jeannette Brodeur, secretary, fille majeure in use of her rights, 3450 Du rocher St.Apt.31, Montreal, for the following purposes: To carry on business as real estate and investment company, umler the name of \"Les Immeubles «lu Bassin de Chainbly inc.\".with a total QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Janaury 1006, Vol.07, No.I 27 de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1080, Bourgogne, Cham My, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de novembre 10(54.Le Sous-secretaire de la province, Raymond Douville.890*2-0 8645-64 les Immeubles Loyal limitée I »¦> ii I Realties Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour «le novembre 1904.constituant en corporation: William Carrière, courtier en immeuble, [rêne Ouimet, ménagère, épouse commune en biens «ludit William Carrière, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes) tous deux «le 72.McLaren, et Clement Bcaudiu.commerçant, 53, Dion, tous trois «le Salaberry-de-Valley-fielfl, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et «le construction, sous le man de « Les Immeubles Loyal limitée Loyal Realties Limited ».avec un capital total de 640,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 300 actions privilégiées de s 100 chacune.Le si«'*ge social «le la compagnie sera à Salaber-ry-«le-Yall«\\vfi«4d, district judiciaire de Beauharnois.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de novembre 19(54.Le Sous-secrétaire de la prorince, Bavmono Douville.8902-o 5291-64 Les Immeubles Monaco inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province f the Quebec Companies Act, letters patent.bearing date the 20th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Fran-cois-Hermaise Vanier, manufacturing agent.429 Church St.Beaconsfield, Claude Leblanc 1610 Henri-Bourasss Blvd.and Marie-Claire Lefeb- 28 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.t janvier lin;;,, 07* année.No i et Marie-Claire Lefebvre, 10882.rue Grande- Alice, ces deiM derniers avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une OU dei \u2022Voles privées et y donner des cours de formation ou d'éducation général»-, scientifique, commerciale ou autre, sous le nom de « Institut Frontenac inc.».avec un capital divisé en 1.000 BCtioni ordinaires sans valeur nominale et en 3.600 actions privilégiées d'une valeur nominale île 610 chacune.Le sièfie social de la compagnie sera à Mont réal.district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 20e jour de novembre 1064.Le Sous-secrctairc de lu province.Raymond Douvillb.8902-e 1058-04 vre.10832 Grande-Allée St.the latter two advocates, of Montreal, for the following pur-posts: To operate one or several private schools and to give therein courses in character formation or general education, scientific, commercial or other courses, under the name of \"Institut Frontenac inc.\", Wth a capital Stock divided into 1.000 common shares of no nominal value and 3,500 preferred shares of a nominal value of SI0 each.The head office if the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven a.t the office of the Provincial Secretary, this 20th day of November, 1964.Raymond Do* ville, .Isainiant Secretary of tin 1'rovince.8002 4058-64 Conrad Jut ras inc.Avis est ilonué qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de novembre 1004.constituant en corporation: Conrad Jut ras, manufacturier.Nrotre-Dame-du-Bon-i lonseil, Normand Viens, agent d'assurances, et Lucien M.Déchène.comptable, ces deux derniers «le Coaticook, pour les objets suivants: Faire le commerce du ciment et de ses BOUS* produits, sous le nom de «< Conrad Jutras inc.», avec un capital total de $40.000.divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera rang 10.Notre-Dame-du-Hon-(lonseil, district judiciaire de Drummomi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 2ôe jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douville.S902-o 5261-64 kuyurr Associates Limited Avis est donné qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 18e jour de novembre 1901, constituait en corporation: Keith Monsarrat Laidley, avocat, John Penhale, étudiant en droit.Kleanor Robertson, secrétaire, célibataire, et Barbara Ann Pearson, secrétaire, célibataire, tous cpiatre de chambre 3411, Place Ville Marie.Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'annonce, publicité et organisation, sous le nom de « K'avarr Associates Limited ».avec un capital total de 840,000, divisé en 40.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 30.chemin North Ridge, Ile-Bi/.ard, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 18e jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douville, 8902 5144-64 Kosy Kornor Tu\\i Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il u été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des letties patentes, en date du 20e jour de novembre 1904, constituant en Conrad J ut rus inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 25th day of November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Conrad Jutras.manufacturier.Not re-Daine-du-Bon-Conseil.Normand Viens, insurance agent, and Lucien M.Déchène, accountant, the latter two of Coaticook.for the following purposes: To carry on a business dealing in cement and its by-products, under the name of \"Conrad Jutras inc.\".with a total capital stock of 640,000.divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will he at range 10.Notre-Dainc-du-Bon-Conseil.judicial district of Drunnnond.(iiven at the ollice of the Provincial Secretary, this 25th day of November.1904.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of tin Province.8902 5201-04 Kayarr Associates Limited Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 18th day of November, 19(54, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quelle, incorporating: Keith Monsarrat Laidley, advocate, John Penhale, law-student, Kleanor Robertson, secretary, spin-ter, and Barbara Ann Pearson, secretary, spinster, all four of Suite 3411, Place ville Marie.Montréal, for the following purposes: To carry on a general advertising, publicity and promotion business, tinder the name of \"Kayarr Associates Limited\", with a total capital stock of 640,000, divided into 40,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company wdll he at 30 North Ridge Road, Ue-Bisard, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the ollice of the Provincial Secretary, this 19th day of November, 1904.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902-0 5144-04 Kosy horn or Taxi .Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean- QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, January 4.t$06, Vol, 97, No.1 29 corporation: Jean-Paul Duplantic.3707, 12e avenue, Laval ouest, Donut Vian, 1140, terrasse Sauvé, Laval ouest, tous deux hommes d'affaires, et Jean A.Vian, comptable, 8040, boulevard Lasalle, LaSalle, pour les objets suivants: Exploiter 'les postes de taxi, sous le nom de « Kosy Komer Taxi Co.Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $10 chacune et 3.800 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la Compagnie sera à Laval ouest, district jiuliciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, Ce 20e jour «le novembre 1004.Le Sous-secrêtaire Je la province, Raymond Douville.8002 5240-64 Laiterie G.IL inc.G.IL Dairy Inc.Avis est donné qu'en vercu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour «le janvier 1004.constituant en corporation: Georges B.Siinard.commerçant, 203, rue Mellon.Arvida, Claude Simard, commis, 278.rue Tremblay.Arvida, et Gérard Claveau, journalier, rang 3.8t-Charles-Borromée, pour les objets suivants: Exploiter une laiterie dans toutes ses spécialités, sous le nom «le «Laiterie (i.IL inc.-G.IL Dairy Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 263, rue Mellon, Arvida.«listrict judiciaire «le Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province, «\u2022e 10e jour de décembre 1904.Le Sons-secrétaire de la province, Raymond Douvillb.8902-0 485-64 Langworthy Sign Studio inc.Avis est donné qu'en vertu dè la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «h* la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 20V jour «h- novembre 19(54.constituant en corporation: Seymour Maehl«>viteh.avocat.3495.rue Mountain, app.70S.Montréal, Gisèle Le-BhtttC, secrétaire, épouse Réparée «le biens «!«\u2022 Marcel LeBlanc, 1815.«le Boucherville.St-Bruno-de-Montarville, et Mary Bavachol, secrétaire, épouse séparée «le biens de Charles Ravocnol, 3590.Dé/.éry, app.15.Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'annonces «l'étalage, sous le nom de a Langworthy Sign Studio Inc.».avec un capital total «le 810.000.divisé en 10,000 actions ordinaires «1< $1 chacune el 30.000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social «le lu compagnie sera à Beau repaire, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, «\u2022e 26e jour «le novembre 19(54.Le Souê-secrétaire de la province, Raymond Douville.8902 5012-01 Latin Watch Case C«>.Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a «\u2022té accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la Paid Duplantic.3707, 12th Avenue, Laval West, Douât Viau, 1140 Sauve Tenace, Laval West, both businessmen, and Jean A.Viau, accountant, 8549 Lasalle Boulevard, LaSalle, for the following purposes' To operate taxi stands, umler the name of \"Kosy (Corner Taxi Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of 810 each and .3.800 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Laval West, judicial «listrict of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary.this 201 h day «»f November, 1964, Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902-0 5240(54 Laiterie C.II.inc.G.II.Dairy Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 31st day of January, 19(54.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, ine«>rporating: Georges E.Simard.trader.2(53 Mellon St.Arvida.Claude Simard, clerk, 278 Tremblay St., Arvida.ami Gérard Claveau, labourer, range 3, St-Charles Borromce, for the following purposes: To operate a dairy with all its specialties, under the name of \"Laiterie G.IL inc.- G.H.Dairy Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 203 Mellon St., Arvida, judicial district of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of December.19(54.Raymond DOUVILLB, Assistant Secretary of the Province.8902 485-04 Langworthy Sign Studio Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters, patent, bearing «late the 20th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Seymour Maehlovitch.advocate, 3495 Mountain Street, Apt.708, Montreal.Gisèle LeBlanc.secretary, wife separate as to property of Marcel LeBlanc.1815 «le Boucherville, St-Bruno-de-Montarville, and Mary Ravachol, secretary, wife separate as t«> property of Charles Ravachol, 35(H) Dézéry, Apt.15.Montreal, for the following purposes: To deal in display signs, under the name of ''Langworthy Sign Studio Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10.000 common shares «>f $1 each and 30.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Beaurcpairc.judicial «listrict of Montreal.(iiven at the ollice of the Provincial Secretary, this 20th day of November.1904.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.8902-o 5012-04 Latin Watch Case Co.Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 25th day of November, 1904, 80 GAZETTE OFFICIEL LE DE QUE province f November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor «»I the Province of Quebec, incorporating: Menashe Broder, advocate, 4750 Plamondon, C.Joshua Borenstein, advocate, 5891 Decelles, and (iloria la-vine, secretary, wife separate as to property of Harry Preedman, \u2022'{'270 Ellendale, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business «d a real estate ami construction company, umler the name of \"Libby Investment Corp.\", with a total capital stock of $20.000.divided into 10.(MM) common shares «»f $1 each ami 10.(MM) pr«'fene«l shares of $1 each, The head office of the company will be at Montreal, jmlicial district of Montreal.'iiven at the ollice of the Provincial Secretary, this 25th «lay of November, 1904.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.S902-o 5325-04 Librairie & Papeterie Ste-Catherine inc.Avis est donné qu'en vertu «le la premiers partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant -gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 20e jour «le novembre 1904.constituant en corporation: André Ducharme, avocat et conseil en loi de la Reine.401, avenue Stuart.Outremont, Claire Morin, secrétaire, fille majeure, et Denise Bélanger, secrétaire, fille majeure, ces deux dernières «le 1119.Mont-Royal, est, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme papetiers et libraires, sous le nom «l«> « Librairie & Papeterie Ste-Catherine inc.».avec un capital total de $30.000.divisé en 1,500 actions ordinuires «le $10 chacune et «-il 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4140.rue Ste-Catherine, est.Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu .secrétaire «le la province, «\u2022e 26e jour «le novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.8902-o 5315-04 Librairie & Papeterie Ste-Catherine inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 20th day of November, 1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: André Ducharme, advocate and Queen's Counsel, 401, Stuart Ave., Outreniount, Claire Morin, secretary, fille u ajeure, and Denise Bélanger, secretary, fille majeure, the latter two of 1119 Mount-Royal.East, Montreal, for the following purposes: To carry on business as stationers ami librai-rians, umler the name of \"Librairie & Papeterie Ste-Catherine inc.\", with a total capital stock of $30.009.divided into 1,500 common shares of $10 each ami into 150 preferred shares of $100 «'ach.The head office of the company will be at 4140 Ste-Catherine St., Fast.Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of November.1964.Raymond Dot .ville.Assistant Scciefury of the Province.8902 5315-04 Limoilou transmissions automati«|iies inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été acconlé, par ! lieutem nt-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu 26e jour «le novembre 1964, constituant en corporation: Régent Bouffard, industriel, 8285, 3e avenue, est, Charleshourg.Roméo Drolct.industriel, 2035.«les Quatre-Bourgeois, Ste-Foy, et Jean-Pierre (îiguère.comptable agréé.2915.Coin des Caps, Ste-Poy, pour les objets suivants: Limoilou transmissions automatiques inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of November.1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Régent Bouffard, industrialist, 8285, 3rd Ave.Fast.Charleshourg.Roméo Drolct.industrailist, 2035 des Quatre-Bourgeois, Ste-Foy, and Jean-Pierre (îiguère, chartered accountant, 2915 Coin «les Caps, Ste-Foy, for the follow ing purposes: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 janvier 1966, 97' année, No I 32 Faire le commerce «le transmissions automatiques, de véhicules automobiles, leurs accessoires et parties et f lire affaires comme garagiste-., sous le nom de « Limoilou transmissions automatiques inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 aidions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, «listrict judiciaire «le Québec.Donné au bureau du secrétaire «!«\u2022 la province, ce 20e jour de novembre 1964.Le Sonx-svcrétairc de la proline,.It \\ym«>n n Dot ville.8902-o 5299-64 Linton Pastry A Delicatessen Inc.A\\i> «ist donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le licutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patente s.en date du 23e jour de novembre 1964, constituant en corporation: Irving L.A«le>-ky, 5789, avenue Melling.Dionysia Zerbisias, 5525, avenue West-bourne, tous «Unix de Côte-St-Luc, et Rrahm L.Campbell, 5500, avenue Bnowdon, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Fxereer un commerce de boulangerie, de boucherie et de friandise, sous le nom de « Linton Pastry & Delicatessen [ne.».avec un capital total de S 10,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de 810 chacune et .'{.000 actions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 0098, côte- des-Neiges, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province.OC 23e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond douville.S902 5277-64 Roger foras ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 20e jour de novembre 1904, constituant en corporation: Roger Locas, homme «l'affairés.Mariette Bertrand, ménagère, épouse contrac-tueliement séparée de biens «ludit Roger Locas, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous «leux de 4154, boulcvanl Cléroux, Chomedey, et Jean-Claude Benoit, mécanicien, 10945, Lausanne, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Faire le commerce des huiles, graisses, pétroles, tous leurs produits, et «lu gaz naturel, sous le nom de « Roger Locas ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires «le 8100 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4154, boulevard Cléroux, Chomedey, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902-o 5202-04 Les Loisirs de St-Gervais inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date To carry on business dealing in automatic transmissions, automobiles, their accessories ami parts and to act as garugemcn.umler the name of \"Limoilou transmissions automatiques Inc.\", with a total capital stock of $ 10.000.divided into l.ooo common shares «)f $io each and 3.ooo preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district f Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th .lay «»f November, 1964, Raymond douvillb, Assistant Seen Ian/ of the Prorinee.8902 5299-61 Linton Pastry «X Delicatessen Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd «lay «if November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Coventor of the Province of Quebec, incorporating: Irving L.Adessky, 5789 Melling Avenue, Dionysia Zerhisias.5525 Wcsthoiirne Awiine, h«ith «f Cote- St-Luc, and Brahm L.Campbell, 550QSnowdon Avenue, Montreal, all three advocates, for the following purpo es: To carry on a bakery, butchery ami delicatessen business, umler the name of \"Linton Pastry & Delicatessen Inc.\".with a total capital stock of 840.000, divided into I 000 common shares of $10 each and 3.0! \u2022() preferred shares of $10 each.The head office «»f the company will Ik at 009s côte «les Neige.s Road.Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of November, 1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.8902-O 5277-04 Roger Locas ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 20th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roger Locas, businessman, Mariette Bertrand, housewife, wife contractually separate as to property of the said Roger Locas, ami duly authorized by him for these presents, both of 4154 Cléroux Blvd., Chomedey, ami Jean-Claude Benoit, mechanic, 10045 Lausanne, Montreal-North, for the following purposes: To carry on business dealing in oil, grease, petroleum, all their products and in natural gas, under the name of \"Roger Locas ltée**, with a total capital stock of $40.000, divided into 100 common shares of $100 each ami 300 preferred shares of $100 each.The head oflice of the company will he at 4154 Cléroux Blvd., Chomedey, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of November, 1901.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5202-04 I>es Loisirs de St-Gervais inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 24th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, January J,, 1995, Vol.97, No, l 88 du 24c jour de novembre 1004, constituant en corporation sans capital-actions: Joachim Carrier, instituteur, Adélard Nadeau, cultivateur, et Roland I,«flamme, caissier, tous trois de St-Gervais, comté de Bellechasse, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Les Loisir^ de St-Gervais inc.».Ia> montant auquel est limitée lu valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $35,000.le at Rawdon, judicial «listrict of Joliette.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 25th «lay of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5273-64 Modpap Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, beaiing date the 20th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jack Lighstone, u.c., 2170 Fulton Road.Mount Royal.Marvin Rihack, Q.c., 5021 Fulton Road, Côte-St-Luc.ami Barry Biberman, 2296 Fulton Road, Mount Royal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Modpap Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2.000 common shares of $10 each and 2.000 prefcrre*! shares of $10 each. 30 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, h janvier 1966, 97* année, \\o J Le siège social een issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: All>ert Morin.contractor in masonery, Maric-Paule Gagnon, housekeeper, wife separate as to pro- perty of the said Albert Morin, both «>f 010 ( 'hahaiicl.ami Yvon Tremblay, accountant, 37 Villeneuve St., all three of Chicoutimi.for the following purposes: To carry on business as contractors in masonery.under the name of \"Albert Morin ltée\", with a total capital stock of $20.000.divided into 100 common shares «>f $100 each and into 100 preferred shares «>f $100 each.The head office of the company will lie at 010 ( 'habituel.Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.S902 3090-64 Pierre Naud inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 25e jour de novembre 1904.constituant en corporation: Laurent Naud.industriel, Madeleine Lafrance, ménagère, épouse séparée de biens dudit Laurent Naud, et Pierre Naud, étudiant, tous trois de Ste-Thècle, pour les objets suivants: Industrie et commerce «lu bois, sous le nom «le « Pierre Naud inc.», avec un capital total «le 375,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 500 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Ste-Thècle.district judiciaire de St-Maurice.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 25e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dokvillk.8902-o 5321-64 Pierre Naud inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, hearing date the 25th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Laurent Naud, industrialist, Madeleine Lafrance.housekeeper, wife separate as to property of the said Laurent Naud, and Pierre Naud, student, all three of Ste-Thècle, for the following purposes: To operate an industry an«l business dealing in lumber, under the name of \"Pierre Naud inc.\", with a total capital stock of $75.000, divided into 250 common shares of a nominal value of $100 each and into 500 prcferrcer, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Abraham Nozetz, chartered accountant, Shirley Nozetz.housewife, wife separate as to property of the sai«l Abraham Nozetz.both of 705 Abbott.Street.St-Laurent.Saul Greenfield, chattered accountant, and Dorothy Greenfield, housewife, wife separate as to property of the said Saul Greenfield, the latter two of 6562 Mountain Sights.Montreal, for the following purposes: To carry on the business of consultants in the operation of all kinds of busincssess, operations and undertakings, under the name of \"Nozetz.Greenfield Associates Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each, 2.000 class \"A\" preferred shares of a par value of $1 each and 3,700 class \"R\" preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 901 Bleury Street, Suite 340, Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902-o 5250-64 Nniiiisnia inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 23e jour «le novembre 1904, constituant en corporation: Charles J.Gélinas, C.B., 515, Cham-pagneur, Outremont, Pierre Bourque, 48.rue Chartres, Dollard-des-Ormeaux.et Claude Benoit, 1758, Jacques-Lemaistre, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Industrie et commerce «le pièces commémora - fives, «le médailles et «le médaillons «le toutes sortes, sous le nom «le « Numisma inc.».avec un capital total de $40.000.divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ne 23c jour «le novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.S902-O 5218-64 Numisma inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 23rd day of November, 1964.have Iwen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Charles .L Gélinas, q.c, 515 Champagneur, Outremont.Pierre Bourque.48 Chartres St., Dollard-dcs-Ormeaux.and Claude Benoit, 1758 Jacques-Lcinaistre.Montreal, all three advocates, for the following purposes: The industry and business «lealing in commemorative pieces, medals ami medallions of all kinds, umler the name of \"Numisma inc.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of November, 1964.Raymond Douvillk, .issistant Secretary of the Province.8902 5212-01 O & S Bronze & Metal Fabricators Ltd.O & S Bronze & Metal Fabricators Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that umler Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quelle Companies Act.letters patent. GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, k janvier 1066, 97' année, A'o 1 38 été ICOOrdéi par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 38e Jour «le novembre 1964, constituant en corporation: Michael Garber.en., 4838* avenue Montrose, Westmount, Jacob Harold Blumens- tein, us trois avoeats, pour l«'s objets suivants: Faire le commerce «!«\u2022 métaux, aoue le nom «!«\u2022 « O «Si S Bronae & Metal Fabricators Ltd.».avec un capital total «le ?10.000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune «'t 2.000 actions privilégiées «le $10 chacune.lie siège social de la compagnie sera à Montreal, district judiciaire «!«' Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902-o 4849-04 bearing «late the 23r«l «lay of November, 1904, have been Issued by the Lieutenant \u2022Governor of the Province of Quebec, incorporating: Michael Garber, o.c, 4338 Montrose Avenue, Westmount, Jacob Harold Biumenstein, u.c., 4815 Queen Mary Road, Montreal, and Harry Yohalem Garber, 3238 Ridgewood Avenue, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To deal in metals, under the name of \"O & s Bronae & Metal Fabricators Ltd.**, with a total capital stock «>f $40.000.«li\\i«lf .81 ca«h and 2.000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district «»f Montreal, (Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of November, 1964.Raymond Dou ville, Assistant Secretary f the Province.8902-O 5279-04 Océanu limitée Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 20th «lay of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, incorporating: Ghislaine Caron, secretary, fille majeure, 017 «les Erables.Ghislain Marcoux.broker, 313a Walberg Blvd., and André Blanchet.advocate, 80 Walberg, all three of Dolbeau, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and reatau-rants, umler the name of \"Océana limitée\", with a total capital st«x-k of $40.000, divided into 500 common shares of $10 each ami into 35,000 preferred shares «>f $1 each.The head office of the company will he at 541 Walberg Blvd., Dolbeau, judicial district of Roberval.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 26th «lay of November.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5363-04 L'Oeuvre des bourses du Collège de Montréal Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 27th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Lionel Leroux, 32 Roskihlc Ave., Outremont.Marc Leroux.378 Carlyle, Mount-Royal, ami René Leroux, 5040 Decelles Ave., Montreal, all three notaries, for the following purposes: To encourage and promote, by material means, the formation of pupils and professors at Collège «le Montreal, umler the name of \"L'Oeuvre des bourses du Collège de Montréal\".The amount to wduch the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to he limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th «lay of November, 19G4.Raymond Douvillk, A.s.iinfant Secretary of the Province.8902 4849-04 QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, January 1966, Vol.97.No, I 39 La Pâtisserie Superbe ine.Avis est ill mm'- qu'en veitu f November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Hervé Duval, manager, 1595 Père-Manpiette, Jean-Claude Duval, pastry-maker, 1595 Père-Mar-guette, and Pierre Marcotte, paslry-inak«'r, 719 Bureau St.all three of Trois-Rivières.for the following purposes: To carry on business dealing in bread, cake, pastry, and other articles, umler the name of \"La Pâtisserie Superbe inc.\", with u total capital Stock of $40.000.divided into 200 c -mm >n shares of a n iminal value >f $100 each and 20) preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at 005 Bureau St.Trois-Rivières, judicial «listrict of Trois-Rivières.(iiven at the office of the Pr >vincial Secretary, this 25th day of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5320-64 Pember Realties Limited Notice is hereby given that umler Part I «»f the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 20th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor Of the Province of Quebec, incorporating: Paul Frederick Dingle.Frederick William Benn and Herbert Birkett McNally.advocates, of 507 Place d'Armes, Montreal, for the following purposes : To carry on the business of a real estate company, umler the name of \"Pember Realties Limited\", with a capital stock divided into 1.000 common shares having no par value and 3,500 pre«lerref Quebec incorporating: Georges A.Pouliot.2266 Sénécs Road.Mount Royal.Pierre M.Verdy, 540 Bl tomfield, and Serge Desroehers, 732 Wilder St., the two latter of Outremont, all three advocates, for the following purposes: To carry «m business dealing in Berated and mineral water, under the name «>f \"Nil Picard & fils inc.- Nil Picard & Sons Inc.\", with a total capital st«>ck of $101.000, divided into 100 common shares of $10 each and 10.000 preferred shares of $10 each.The head office «>f the company will be at 56 Bennett St.North, Thetfonl Mines, judicial «listrict of Megan tic.(iiven at the office «>f the Provincial Secretary, this 25th «lay of November.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5205-04 40 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, J, janvier J966, 97' année.No J J.II.Pothicr & fils inc.Avis est donné qu'on vertu de- I» première partie cie la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, pur le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patente^, «ni date du L'iie jour de novembre 1064, constituant eu corporation : Jean-Baptiste Pothicr, rentier, Lévis Pothier, industriel, et Estelle Cossette, ménagère.épouse séparée de bien-, «ludit Lévis Pothier, et dûment autorisée par lui aux fins «les présentes.tous trois de St-Tite.comté de Laviolêtte, pour les objets suivants: Faire le commerce de scies mécaniques «d de véhicules autoinobih-s.leurs accessoires et parties et faire affaires comme garagistes, bou8 le nom «le « J.IL Pothier & fils inc.».avec un capital total «le 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège s«>cial de la compagnie sera à St-Tite.«listrict judiciaire «le St-Maurioe.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 2veinber, 1904.have l>een issue*! by the Lieutenant-Governor of the Province f Quebec, incorporating: Jean- Baptiste Pothier, annuitant.Levis Pothicr.industrialist, and Estelle Cossette.housewife, wife separate as to property of the said Levis Pothier, ami duly authorised by him for these présenta, all three of St-Tite.county of Laviolette, for the following purposes: To carry on business dealing in mechanical saw s and automobiles, their accessories and parts, and to ad as garagemeii.under the name of *'.L IL Pothier & fils inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 610 each and 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at St-Tite.judicial «listrict of St-Mauri«e.Given at the oflicc of the Provincial Secretary.this 26th day of November, 1904.Raymond douvillb, Assistant Secretary of tin Province.8002 0231-04 Prêts Quebeco inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu Lie jour «le novembre 1904, constituant en corporation: Robert Dubrcuil.entrepreneur électricien, 12301.rue Victoria, Daniel Marteau, gérant.721.17e avenue, tous «leux «le Pointc-aux-Trembles.et René Lungelier.courtier en assurance, 4400.rue Migneault, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et «le prêts, SOUS le nom «le « Prêts Quebeco inc.», avec un capital total «le 8600*000, divisé en 10.000 actions ordinaires de $25 chacune et en 1.000 actions privilégiées «le 61UU chacune.Le siège social «le la compagnie sera 5910.rue Hochclaga.Montréal, district jiuliciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 13c jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la prarince.Raymond Dol ville.S902-o 4231 -04 Prêts Quebeco inc.Notice is hereby given that under Part I «d the Quebec Companies Act.letters patent, hearing «late the 13th «lay 16,000 common shares of $25 each ami into 1.000 preferred shares of $1C0 each.The head office «>f the company will be at 5910 Hochelaga St.Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of November, 1964.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.8902 4231-64 Quincaillerie Taillon ltée Avis est donm' epi'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 27e jour «le novembre 1904.constituant en corporation: Rimai Gagné, comptable-vérificateur, 1545, Sauriol, Marcel Gagné, comptable.57, St-.Iac«pies.ouest, et Mouiipie Grégoire, secrétaire, épouse séparée de biens d'André Germain, 57, St-Jacques, ouest, tous trois «le Montréal, pour les «>bjets suivants: Faire affaires comme cpiincailleliers.sous le nom «le «Quincaillerie Tailk n ltée S, avec un capital total «le $40.000, divisé en 200 actions ordinaires «le $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 57.rue St-Jacques, ouest.Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Quincaillerie Taillon ltée Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, hearing «late the 27th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: RhéaI Gagné, accountant-assessor, 1545 Sauriol, Marcel Gagné, accountant.57 St-James St.West, ami Monique Grégoire, secretary, wife séparât» as to property «>f André Germain, 57 St-James, West, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as hardware dealers, under the name of \"Quincaillerie Taillon ltée\", with a total capital stock of $40.000 divided into 200 common shares «>f $100 each and into 200 prr-ferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 57 St-James St.West.Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.January 4.1966, Vol.97, No.I 11 Donné au bureau du secret «ire «h- la province, ce 27e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire Je la province.Raymond Douvillk.S902-o 5302-64 Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of November, 1904.Raymond Dor villk.Assistant Secretary of the Province.8902 5302-64 Radisson Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 12e jour de novembre 1904.constituant en corporation: Demetre Panagopoulos, propriétaire de restaurant, 1300, rue Sherbrooke, est, Julius Rosenblum.avocat, et Susan Webster, secrétaire, fille majeure, ces deux derniers de 159.rue ('raig.ouest, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce «le restaurateurs, sous le nom de « Radisson Restaurant Inc.», avec un capital total «le $30.000.divisé en 700 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 2.300 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montr«:al.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, «\u2022e 12e jour «le novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902 5091-04 Radisson Restaurant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies -Act, letters patent, bearing date the 12th day of November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Demetre Panagopoulos, restaurant proprietor, 1306 Sherbrooke Street Kast, Julius Rosenblum, advocate, ami Susan Webster, secretary, fille majeure, the latter two of 159 Craig Street West, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Radisson Restaurant Inc.\", with a total capital stock of $30.000, divided into 700 common shares of a par value of $10 each ami 2,300 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 12th «lay of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902-o .5091-04 Roger de Paris coiffure inc.Avis est donné qu'en vertu «le la premièie partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec, des lettres patentes, en date «lu 25e jour de novembre 19G4, constituant en corporation: Claude Thivierge, avocat, 105, rue Thackeray, Reaconsficld, Jacqueline Matte, 8390, Drolet, Montréal, et Renée Auger.534, rue Tru-«leau, LaSalle, ces deux dernières secrétaires, filles majeures et usant de leurs droits, pour les objets suivants: Exploiter un salon de beauté et de coiffure pour «lames dans toutes ses spécialités, sous le nom de « Roger de Paris coiffure inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1333, chemin Canora, Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de novembre 1904.Ia Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902-o 5264-64 Roger de Paris coiffure inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Thivierge, af 410 St.Nicholas Street.Room 415.Mon real, f«>r the following purposes: To carry on the business of a development ami investment company, umler the name of \"Sheldon Development Corp.\", with a total capital stock of $20.000, divided into 2.000 common shares of $10 each.The head office of the company will Ik* at 037 Craig Street West, Montreal, (c/o Cecil April.c.a.), jmlicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th «lay of November.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Protince.8902-o 5227-04 Skybolt General Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day «>f November, 1904.have Imhmi issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Nathaniel II.Salomon.4300 Western Avenue.Nahum Gelber.4115 .lean-Brillant.and Robert S.Litvack.5217 Ponsard Avenue, all throe advocates, «>f Montreal, for the foll«>wing purposes: QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, January ',.1995, Vol, 97.No.i 13 Excnrr le cominerce d'une compagnie d'immeubles, «le construction et «le placements, sous le nom «le « Skyholt (îcneral Construction Co.Lt«i.», avec un capital total de $5,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 20-10, avenue Belgrave, St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province! ce 26c jour «le novembre 1064.Le Sous-secrétaire de, la province, Raymond Douville.8902 5011-«il To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under tin-name of \"Skybolt Genera] Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head uverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 18e jour de novembre 1904.constituant en corporation: Lise Dumontet.secrétaire, fille majeure.0601, Bordeaux, Montréal, Annette Caron, secrétaire, fille majeure.7045, rue Fabre.app.5, Montréal, et Guy G.Malo.comptable.6001, De la Loire.Anjou, pour les objets suivants: Exercer les opérations «l'une c«>mpagnie de portefeuille (« holding »), sous le nom «le « Société financière d'Amérique ltée ».avec un capital total de $500.000, divisé en 50,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 18e jour de novembre 1964.Le Sous-sccrétaire de la province, Raymond Dou villk.8902-c 4784-64 Société canadienne Progressive inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1964, have been issue«J by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claurle Leblanc, advocate, 1610 Henri-Bourassa, East, Montreal, Pierre Lalande, advocate, and Pierre Berthelets, insurance agent, the latter two of 3000 St-Rose Blvd., Laval-West, for the following purposes: To offer against remuneration any kind of promotion and economical orientation, commercial and social, under the name of \"Société canadienne Progressive inc.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 1.600 common shares of $25 each, The head office of the company will be at S060 Chamboid St.Montreal, jmlicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd «lay of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 4969-64 Société financière d'Amérique ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 18th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lise Dumontet, secretary, fille majeure, 6601 Bor-deaux, Monti eal, Annette Caron, secretary, fille majeure, 7045 Fabre St., Apt.5, Montreal, and Guy (i.Malo.accountant.0001 De la Loire, Anjour, for the following purposes: To carry on the operations of a holding company, under the name of \"Société financière d'Amérique ltée\".with a total capital stock of $500,000, divided into 50,000 common shares of $10 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 4784-64 Le Sommet Suisse, ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il u été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 18e jour «le novembre 1964.constituant en corporation: Maurice Martel, avocat et conseil en loi «le la Reine, 1301, St-Viateur.ouest.Outremont, Gertrude Bourdeau.secrétaire, fille majeure.1420, St-Marc, Montréal, et Margue- Le Sommet Suisse, ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 18th «lay of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Maurice Martel, advocate and Queen's Counsel, 1301 St-Yialeur, West.Outremount.Gcrtnnle Bour-deau, secretary, fille majeure, 1420 St-Marc, Montreal, and Marguerite Bissonnette, secretary. Il GAZETTE OFFICIELLE DE QVÉ1IEC, 4 janvier 1905.97' année.No 1 rite Bissonnctte, secrétaire, épouse séparée de biens de René Villeneuve, 0203, Mazarin.Montréal, pour les objets suivants: \u2022 Faire affaires comme compagnies d'immeuble et de construction, sous le nom de « Le Sommet Suisse, ltée », avec un capital total de $100.(KX), divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 9,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 757, rue Davaar.Outremont, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 18e jour de novembre 1064.Le Sous-secrftaire de la prorincr.Raymond Douvillk.8902-o 5143-64 South Shore Marine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant -gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de novemher 1904.constituant en corporation: .lames Edward Drody, 2150, rue Sherbrooke ouest.Montréal.William Patrick Keating.552.rue Berwick.Mont Royal, tous deux avocats, et Jennifer Fila Anstead.secrétaire, célibataire.1516, avenue des Pins, ouest.Montréal, pour les objets suivants.Exercer le commerce d'industries et opérations marines, sous le nom de « South Shore Marine Inc.».avec un capital total de $40.000.divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 150 acti-ms privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social rie la compagnie sera 213.rue Prince Arthur, St-Lambert.district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.8902 5233-64 wifw sepaiate as to property of René Villeneuve.6263 Mazarin.Montieal, for the following pur- poese: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Le Sommet Suisse, lté*'**, with a total capital stock of $100.000.divided into 1,000 common shaies of $10 each ami into 9,000 preferred shares of $10 each.The head office of the e«>mpany will be at 757 Davaar, Out remount, judicial district of Montreal.(iiven at the ollice of the Provincial S««crctary.this 18th day of Novenlx-r, 1904.Raymond Do u v i llk , Assista n I Secretary of the Province.8902 5143-04 South Shore Marine Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 25th «lay of Novemher, 1964.have been issue«l by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: James Edward Dro«ly.2150 Sherbrooke Street West.Montreal.William Patrick Keating, 552 Berwick Street.Mount Royal, both advocates, and Jennifer Ella Anstead, secretary spinter, 1516 Pine Avenue West.Montreal, for the following purposes : To carry on business connected with marine industries and operations, under the name of \"South Shore Marine Inc.\", with a total capital stock of $40,000 divided into 250 common shares of a par value of $100 each and 150 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will he at 213 Prince Arthur Street.St-Lambert, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of November, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902-n 5233-64 Spécialités Ma-Ga cie ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour de novembre 1964, constituant en corporation: Michel Nardella.marchand, Albert Nardella et Armand Nardella, vendeurs, tous trois de 122, rue Robinson, nord.Granhy, pour les objets suivants: Faire le commerce d'épicerie, sous le nom «le « Spécialités Ma-Ga cie ltée », avec un capital total de $40,000.divisé en 2.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 9, rue Êvangéline, G ran by.district judiciaire de Bc«l-ford.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902-o 5222-04 La Suisse de F Ksi ère I ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date Spécialités Ma-Ga cie ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letteis patent, liearing date the 19th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Michel Nardella, merchant, Albert Nardella and Armand Nardella, salesmen, all three of 122 Robinson St.north, (iranby, for the following purposes: To carry on business as grocers, under the name of \"Spécialités Ma-Ga cie ltée\", with a total capital stock of $40.000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferre«l shares of $10 each.The head office of the company will be at 9 Êvangéline St.(iranby, judicial «listrict of Bedford.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th «lay of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5222-64 la Suisse de PEstérel ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of November, 1964.have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor o. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.January 4.1966, Vol, 97, No.I 15 du 20e jour de novembre 1964, constituant en corporation: Maurice Martel, 1301, St-Yiateur, Outremont, Yves Laurier, 152, Notre-Dame, est, Montréal, tous deux avocats et conseils en loi de la Reine, et Gertrude Bourdeau, secrétaire, fille majeure, 1420, St-Maic, Montréal, pour les objets suivants : L'exploitation de centres de ski, «le monte-pentes, d'écoles «le ski, d'iu'itcllerics et autres commerces semblables, sous le nom de « La Suisse «le l'Estérel ltée », avec un capital total «le $40.000, divisé en 400 actions onlinaires «le $10 chacune et en 3,600 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie 'sera à Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, «listrict jiuliciaire «le Terrebonne.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 20e jour «le novembre 1904.Le Sous-secrétaire Je la province, Raymond Douvillk.8902-o 5170-04 Swiss Cleaners (St.Laurent) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour «le novembre 1904.constituant en corporation: Samuel Godinsky, c.b., avocat, 731, Upper Belmont, Montréal.Aniceta O'Grady, secrétaire, célibataire, 4012, avenue Hampton.Montréal, et Paul Reindler, gérant, 4454, avenue Madison, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'établissements de nettoyage et de buanderie, sous le nom «le « Swiss Cleaners (St.Laurent) Ltd.», avec un capital total de $40,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902 5220-04 L.Tanguay & fils inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu 27e jour de novembre 1904, constituant en corporation : Leopold Tanguay, machiniste, Jeanne d'Arc Richard, ménagère, épouse commune en biens dudit Leopold Tanguay, et Clermont Tanguay, vendeur, tous trois de 422, rue Mont Plaisant, Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles, leurs parties et accessoires, sous le nom de « L.Tanguay & fils inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902-o 4903-64 Edward Thomas inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Province of Quebec, incorporating: Maurice Martel, 1301 St-Viateur, Outremont, Yves Laurier, 152 Notre-Dame East, Montreal, both advocates ami Queen's Counsel, and Gertrude Bourdeau, secretary, fille majeure, 1420St-Marc.Montreal, for the following purposes: To operate ski centers, ski-tows, ski schools, hotels and other similar business, under the name of \"La Suisse «le l'Estérel ltée\", with a total capital stock of 140,000, divided into 400 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head ollice of the company will be at Sle-Margiicritc-ilu-Lac-Masson, judicial «listrict of Terrebonne.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th «lay of November, 1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.8902 5170-04 Swiss Cleaners (St.Laurent) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 19th day of November, 1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Samuel Godinsky, q.c, advocate, 731 Upper Bclmomt.Montreal, Aniceta O'Grady, secretary, spinster.4012 Hampton Avenue, Montreal, ami Paul Reindler, manager, 4454 Madison Avenue.Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dry cleaning and laundering establishments, under the name of \"Swiss Cleaners (St.Laurent) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and 300 preferre«l shares of a par value of $100 each.The hca«l office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of November, 1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.8902-o 5220-64 L.Tanguay us le nom de « Timothy & Murray inc.».avec un capital total de $40.000.divisé en 300 actions ordinaires «le $100 chacune et eu 100 actions privilégiées «le 8100 chscune.Le sièg»* social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.I)'»niié au bureau du secrétaire carry on business as oil mcrchnnds, under name of \"Timothy & Murray inc.\", with a total capita] stock «>f $4o.u00.divided into 300common shares of $100 each ami into 100 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th day «>f November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Produce.8902 5147-64 Trans-Ile inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 24th «lay of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating' Eric Claus, solicitor, 19,1 ôth St.Roxboro, Gérard, Cor-beil, advocate, 304 Hawthorne Ave., Longueuil, Laurence Ostiguy.6250, 44th Ave., and Huguette Curadeau.2112 Plessis St.the latter two secretary's, spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Trans-Ile inc., with a total capital stock of 840,000, divided into 4.000 common shares «>f $10 each.The head oflice of the company will he at Montreal, jmlicial district of Montréal.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 24th day of November.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary i f the Produce.8902 5303-04 A.Triggs Appraiser Inc.Évaliiateur A.Triggs inc.Notice is hereby given that under Part I of the Queliec Companies Act.letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January I 1966, Vol.97, No.i été accordé! par 1«' lieutenant-gouverneur f Qimhec, incorporating : Jac«|ues Duquette, ll St-Paul St.West, Guy Godard, 7A Tour du Lac, both advocates, and Liliane Piché, secretary, fill** majeure, 65 St Joseph St.all three of Ste-Agathe-des-Monts, for the following purposes: To operate as adjusters, appraisers, inspectors, investigators, inquirer in insurance or otherwise, under the name of \"A.Triggs Appaiser Inc.\u2014 Evaluateur A.Triggs inc.\", with a total capital stock of $1.000.divided into l.OOO common shares of 81 each.The head office of the company will l>e at Pont-Viau, judicial district « f Montreal.(Jiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 25th day of November.1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary if the Province.8902 5331-64 Universal Electronics Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 16th «lay «f November, 1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Joseph Lerncr.1456 Peel Street.Samuel Gradinger, 6383 Trans Island, both men bants, and Leonard Simcoe, advocate, 423 Mayor Street.Suite 2, all three of Montreal, for the following purposes: To «Ical in electronic and electric equipment, electronic components, ra«lar, aircraft, electric machinery, apparatus, electric appliances and supplies, under the name of \"Universal Electronics Inc.\", with a total capital stock of $200.000.divided into 5.000 common shares of $10 each and 1,500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial «listrict of Montreal.(Jiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 16th «lay of November.1904.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902-O 5235-64 Fernando Veilleux inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 19th «lay «)f November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Marguerite Leinieux.merchant, unremarried widow of Fernando Veilleux, La Guadeloupe, Valérien Cloutier, accountant, Vallée-Junction, ami Guy Couture, chartered accountant, St-Georges, for the following purposes: To carry 00 a business dealing in food products, umler the name of \"Fernamlo Veilleux inc.\", with a total capital stock of 140,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 150 preferred shares of $1C0 each.The head office «>f the company will he at Vallée-Junction, jmlicial «listrict of Reauce.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of November, 1904.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902 5224-64 18 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 4 janvier 1066, 97' année.Xo 1 J.C.Véstaa ltée Avis est donné qu'eil vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu 20e jour de novembre 191)4.constituant en corporation: Jacques Collard, avocat.Paul Martel, comptable agréé, et Jean-Yves Guy, comptable, to is trois de 218, Sacré-( 'oeur.Aima, pour les objets suivants: Faire le conuneiee de machines, moteurs, outils, instruments et quincuillcrie de toutes sortes, sous le nom de « J.('.Yézinn ltée», avec un capital total «le $40.000.divisé en 400 actions ordinaires «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera Notre* Dame-d'llébertvillc, «listrict jiuliciaire «le Ro-herval.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 20e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillb.8902-o 5152-04 The Villager Shoe Shoppe (Place Victoria) Inc.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 24e jour de novembre 1904.constituant en corporation: Joseph Roy Hoffman, ch., 4918, Mayfair, Oscar Respitz.4945, (îlencairn, tous deux de Montréal, et Max S.Kaufman, ch., 574.Claremont, Westmount, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce de chaussures, souliers, vêtements, articles vestimentaires et accessoires de toutes sortes, sous le nom «le « The Villager Shoe Shoppe (Place Victoria) Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 24e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902 5293-64 Vogue Sportswear Mfg.Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 19e jour «le novembre 1904, constituant en corporation: Albert H.Malouf, ch., 1100, Marlboro Drive, Mont Royal.Bruno.Pateras.11818, rue Frigon, Y van Macerola.2090, Place Êtienne-IIi filé, et C.James Galileo.6959, rue Stuart, ces trois derniers de Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Kxercer le commerce «le vêtements, sous le nom de « Vogue Sportswear Mfg.Go.», avec un capital total de $40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune et 3,000 actions pi ivi-légiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 7080, rue Hutchison, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de novembre 1964.Le Sous-sccrétaire de la province, Raymond Douville.8902 5182-64 J.C.\\ é/ina ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 20th day of November, 1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Collard, advocate, Paul Martel, chartered accountant, and Jean-Yves Guy, accountant, all three of 215 Sacré-Coeur, Alma, for the following purposes: To carry on business dealing in machines, motors, tools, instruments and hardware of all kimls, under the name of \"J.C.Vé/.ina ltée\", with a total capital stock of 840.000.«livhled into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Notre-Dame-d'Hébert ville, judicial district of Roberval.(iiven at the office of the Provincial Secretary, rhis 20th «lay of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 5152-64 The Villager Shoe Shoppe (Place Victoria) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 24th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Joseph Roy Hoffman, q.c, 4918 Mayfair, Oscar Respitz, 4945 (ilencairn, both of Montreal, and Max S.Kaufman, q.c, 574 Clarcmont, West-mount, all three advocates, for the following purposes: To deal in shoes, footwear, clothing, wearing apparel and accessories of all kinds, under the name of \"The Villager Shoe Shoppe (Place Victoria) Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of November, 1904.R aymon d DOU villk, Assistant Secretary of the Province.8902-o 5293-04 Vogue Sportswear Mfg.Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 19th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Albert H.Malouf, q.c, 1100 Marlboro Drive, Mount Royal, Bruno Pateras, 11818 Frigon Street.Y van Macerola, 2090 Êticnne-Brûlé Place, and C.James Galileo.6959 Stuart Street, the latter three of Montreal, all four advocates, for the following purposes : To «leal in wearing apparel, under the name of \"Vogue Sportswear Mfg.Co.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will he at 7080 Hutchison Street, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of November, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902-o 5182-64 QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, January ton».Vol.97, No.l 49 Les 18-30 inn.Avis est «lonné qu'en vertu «le lu troisième partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été aceor«lé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 25e jour «ie novembre 1004, constituant en corporation sans capital-actions: Norbert Brouillard, vendeur, 7490 A, Chateaubriand.Montréal, Jean-Claude l'âgé, «lessinateur industriel, 8498.St-André, app.409.Montréal, et Pierre Alix, imprimeur, 10042.boulevard d'Auteuil.Montival.pour les objets suivants: Ktablir et diriger un club social, sous le nom «le « Les 18 30 inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir cl posséder, est de $20,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor villk.8902-o 4514-04 Les 18-30 inc.Notice is hereby given that umler Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, healing «late the 25th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Norbert Brouillard, salesman, 7499A, Chateaubriand, Montreal.Jean-Claude Page, industrialist designer, 8498 St-André.Apt.409.Montreal, and Pierre Alix, printer, 10042 d'Auteuil Blvd., Montreal, for the following purposes: To establish ami direct a social club, umler the name of \"Les 18-30 inc.\".The amount to which the Value of the immoveable property wdiich the corporation may acquire and hol«l is to he limited, is $20.000.The head ollice of the corporation will he at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 4514-64 Lettres patentes supplémentaires African Business Corporation for Development (Quebec) Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 17e jour «le novembre 1964, à la compignie « African Business Corporation for Development (Quebec) Ltd.».augmentant son capital «le $10.000 à 1165,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 12.500 actions privilégiées «le $10 chacune.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 17c jour «le novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.8902 911-64 1246/112 Agence générale de Hull Inc.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 17e jour «le novembre 1964, à la compagnie « Agence générale «le Hull inc.».augmentant son capital «le 820,000 à $200.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 1,800 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $100 chacune.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce|17e jour «le novembre 1904.Le Sous-sccrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902-o 2968-64 1247/101 Arco Stone Co.Limited Cie de Pierre Arco limitée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, pir le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late du 18e Jour «le novembre 1904.à la compagnie « Arco Stone Co.Limited ».constitués par lettres patentes en «late «lu Ile Supplementary Letters Patent African Business Corporation for Development (Quebec) Ltd.Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent.!>earing «late the 17th «lay of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"African Business Corporation for Development (Quebec) Ltd.\", increasing its capital from $40,000 to 8165,000, the additional capital stock being divided into 12,500 preferred shares of $10 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 17th «lay of November, 1901.Raymond Dor villk.Assistant Secretary of the Province.N902-o 911-64 1246/112 Agence générale de Hull Inc.Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 17th «lay of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Agence générale «le Hull inc.\".increasing its capital stock from $20.000 t«> $200,000.the additional capital stock being divided into 1.800 preferred shares of a par value of $100 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 17th «lay of November, 1904.Raymond Dor villk.Assistant Secretary of the Province.8902 2968-64 1247/101 Arco Stone Co.Limited Cie dc Pierre Arco limitée Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing «latc the ISth «lay of November.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, t«> \"Arco Stone Co.Limited\", incorporated by letters patent dated the 11th «lay «>f April.1928. .-.Il GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 4 janvier Mr>.97' année.No i jour d'avril 1928, changeant son nom en relui de « Arco Stone Co.Limited Cie de Pierre Arco limitée ».Donné au bureau du secrétaire de la province.ce ISe jour de novembre 1964, Le SoUM secrétaire de !a province.Raymond Douvillk.8902m 693-28 1247/7 Cultex construction inc.Avis est donné qu'en vertu «le lu première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late du 23e jour «le novembre 191)4, à la compagnie « Caltex construction inc.».augmentant son capital de $40,000 à $100,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 000 actions privilégiées «le $100 chacune.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 23e jour de novembre 1904.Le Sous-sccrétaire de la province, Raymon d Douvillb.8902-o 14041-00\u2014 1248/134 Canadian Commercial Union Co.Inc.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 27e jour «le novembre 1904, à la compagnie «Webster Realties Co.Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 20e jour «l'octobre 1959, 10 changeant son nom en celui «le « Canadian Commercial Union Co.Inc.»; 2' modifiant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour «le novembre 1904.Le Sous-sccrétaire de la province, Raymond Douville.8902 15820-59 1248/83 changing its nana- t«> that «d \"Arco St«>nc C«>.Limited Cie «le Pierre Arco limitée\".(îiven at the office ot the Provincial Secretary, this 18th «lay of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary if the Province.8902 ' 668-28 1247/7 Cultex construction inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 23rd November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Caltex Construction inc.\", increasing its capital stock of $40,000 t $100,000, the additional capital stock being divided into 600 preferred shares of $100 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretan/ of the Province.8902 14041-60 1248/134 Canadian Commercial Union Co.Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 27th «lay of November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Webster Realties Co.Inc.\", incorporated by letters patent dated the 20th day of October, 1959, 1.changing its name to that of \"Canadian Commercial Union Co.Inc.\"; 2.modifying its powers.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th «lay of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902-o 15826-59 \u2014 1248/83 La Compagnie de construction des boulevards du Québec Quebec Boulevards Construction Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date «lu 27e jour de novembre 1964, à « La Compagnie «le construction des boulevards du Québec - Quebec Roulevards Construction Company », étendant ses pouvoirs.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 27c jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.8902-o 6698-45 \u2014 1248/135 Compagnie immobilière & industrielle (limitée) Industrial & Real Estate Co.Limited Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date «lu 18e jour de novembre 1964, à la « Compagnie immobilière & industrielle (limitée) \u2014 Industrial & Real Estate Co.Limited ».augmentant son capital «le $50,000 à 8150,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 10.000 actions privilégiées de $10 chacune.La Compagnie de construction des boulevards du Québec Quebec Boulevards Construction Company Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 27th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"La Compagnie de construction des boulevards du Québec \u2014 Quebec Boulevards Construction Company\", extending its powers.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of November, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.8902 6698-45 \u2014 1248/135 Compagnie immobilière & industrielle (limitée) Industrial & Real Estate Co.Limited Notice is hereby given that, under Part I of of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Compagnie immobilière & industrielle (limitée) \u2014 Industrial & Real Estate Co.Limited\", increasing its capital stock from 850,000 to 8150,000, the additional capital stock being divided into 10,000 prefered shares of $10 each. QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, January !,.ff0e\\ l'ai.07, Ao./ ft] Donné Ml bureau du secrétaire de la province, «\u2022e 18e jour de novembre 1064, Ia: Sous-sccrétaire Je la province, Raymond Douvillb.8902-o 3108-44 1247/123 La Corporation Foncière «le Montréal Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Quéliee, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date «lu 27e jour de novembre I964i à « La Corporation Foncière de Montréal augmentant son capital «le 8020.000 à 8060,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 40.000 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le Si chacune.Donné au bureau «lu secrétaire f November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 13382-00 1247/18 Ferrosteel Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 24e lourde novembre 1904.à la compagnie « Domsteel Corporation ».constituée par lettres patentes en date «lu 13e jour de 1964, changeant son nom en celui «le « Ferrosteel Corporation ».Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 24e jour de novembre 1964.I*e Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.8902 3174-04 \u2014 1248/43 Ferrosteel Corporation Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 24th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Domsteel Corporation\", incorporated by letters patent dated the 13th day of duly, 1904, changing its name to that of \"Ferrosteel Corporation\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.S902-o 3174-04 \u2014 1248/43 Friendly Enterprises Ltd.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date «lu 18e jour «le novembre 1904, à la compagnie « Friendly Investments Ltd.», constituée par lettres patentes en «late du 4e jour de décembre 1957, changeant son nom en celui de « Friendly Enterprises Ltd.».Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 18e jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.8902 13860-57 \u2014 1248/44 Charles E.Frosst & Co.Charles E.Frosst et Cie Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 25e jour de novembre 1904 à la compagnie « Charles E.Frosst & Co.», Friendly Enterprises Ltd.Notice is hereby given that, under Part I of the Quel>ec Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 18th day of November, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Friendly Investments Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 4th day of December, 1957, changing its name to that of \"Friendly Enterprises Ltd.\", Given at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.S902-o 13800-57 \u2014 1248/44 Charles E.Frosst & Co.Charles E.Frosst et Cie Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Charles E.Frosst & Co.\", incorporated by QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 1966, Vol.97, A'o./ 58 constituée par lettres patentes en date «lu 25e jour «le mars 1081, changeant son nom en celui «le «Charles K.Frosst & Co.-Charles ES.Frosst et Cie ».Donné au bureau «lu sconHuire «le la province, «\u2022«\u2022 25e jour «le novembre 1964.Le Sou.*-,secreluire de la province, Raympnd Douvillb.8902 604-31 1248/45 Cugnon frères nouveautés (I)olheau) ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Queliee, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late du 19e jour «le novembre 1964, à la compagnie « Cagnon frères nouveautés (Dolbeau) ltée », augmentant son capital «le 810,000 à $12.000, le capital-aeti«>ns additionnel étant divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune, 2,000 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 2,001) actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 19c jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillb.8902-o 10946-56 1247 70 letters patent dated the 25th «lay of March, 1931, changing its lyune to that «>f \"Charles K.Frosst &\u2022 Co.¦\u2014 Charles E.Frosst et Cie\".-(iiven at the ollice of the Provincial Secretary, this 26th «lay of November, 1964.raymond Douvillk.Assistant Secretary of the.Province.8902-o \" 00-1-31 - 1248/45 Cagnon frères nouveautés (Dolbeau) ltée Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 19th «lay of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Gagnon frères nouveautés (Dolbeau) ltée\", increasing its capital stock from $10,000 to $12,000, the additional share capital being divided into 1.000 common shares of $10 each.2,000 preferred class \"A\" shares of $10 each and 2.000 preferred class \"11\" shares of $1 each.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 19th «lay of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902 10946-56 - 1247/76 Heather Curling Club In:-.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnes de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 2e jour «le juillet 1964, à !a compagnie « Heather Curling Club Inc.», I ° augmentant le montant «le la propriété immobilière que la corporation peut posséder ou détenir, de $100,000 à $509.000; 2° modifiant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire «le la provûice, ce 7e jour «le décembre 1904.Le Sous-sccrétaire de la province, Raymond Douvillk.4902 2129-22 - 1244/12 J.L.International Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date «lu 13e jour «le novembre 1904.à la compagnie « Jaymor Enterprises Inc.», constituée par lettres patentes en «late «lu 10e jour d'août 1959, changeant son nom en celui \" L L.International Ltd.s.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 13e jour de novembre 1904.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.8902 14638-59 - 1246/124 Heather Curling Club Inc.Notice is hereby given that, under the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2ml «lay of .Lily, 1964, have l>cen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Heather Curling Club Inc.\", 1.increasing the amount of immoveable property which may be owned or held by the corporation from $100,000 to $500,000; 2° modifiying its powers.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 7th «lay «>f December, 1964.Raymond Douvillk, 1 Assistant Secretary of the Province.S902-o 2129-22\u2014 1244/12 J.L.International Ltd.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, heraing date the 13th day of November.1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Jaymor Enterprises Inc.\", incorporated by letters patent dated the 10th day of August, 1959, changing its name to that of \"J.L.International Ltd.\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902-d 14638-59 - 1246/124 Kanco Industrial Sales Ltd.Les Ventes industrielles Kanco liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 10e jour «le novembre 1964.à la compagnie \"Les Équipements Rolland ltée », constituée par lettres patentes en «late «lu 80e jour de juillet 1963, 1° changeant son nom Kanco Industrial Sales Ltd.Les Ventes industrielles Kanco ltée Notice is hereby given that, un«ler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of November, 1964, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Les Équipements Rolland ltée\", incorporated by letters patent dated the 30th day of July, 1963, 1.changing its name to that of \"Kenco Industrial at GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 4 janvier I960, 97* année, A'o / en celui de « Keneo Industrial Sales Ltd.\u2014- Les Ventes industrielles Kanco liée »; 2° modifiant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 10e jour de novembre 1904.Ia 8cMS-sécrétaire de la province.Raymond Douvillb.8902-o 800443- 1240 22 Le Laboratoire Audio-Visuel de Langues inc.The Audio-Visuel Language Laboratory Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 30e jour «le novembre 1904, à la compagnie « Le Lal>oratoire Audio-Visuel de langues inc.The Audio-Visuel Language Laboratory inc.» modifiant les privilèges et restrictions attachés à del actions privilégiée*.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 30e jour de novembre 1904.Ia Sous-sécrétaire de la province, Raymond Douvillk.8903-0 4010-64 \u2014 1249.79 The Laurentian Forest Protective Association, Limited L'Association Protectrice des Forêt*.Lauren tn-nne*.limitée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur that of \"Laurentide Ski-Tows Limited Les Monte-Pentes Laurentide ltée\".(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 12th day of November.1964.Raymond Dou villk.Assistant Secretary of the Province.8902 2482-38 1246/125 J.Mashal & Co.Ltd.Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary let- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 4.1905, Vol.97, No.1 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 20e jour d'octobre 1904, à la compagnie « J.Mashal & Co.Ltd.», 1° désignant ses 000 actions privilégiées de Si00 chacune en 000 actions privilégiées catégorie « A » de $100 chacune; 2° augmentant sou capital de $100 000 a $101.000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000 actions privilégiées catégorie « H » de $1 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour d'octobre 1064.Le Sous-sccrétaire Je la produce, Raymond DOUVILLB.8902 13351-58 ' 1245/113 M a-La électrique, limitée Maska Electric, Limited Avis «¦\u2022\"\u2022' donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé-, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 24e jour de novembre 1904.à la compagnie « Maska Electric Company Limited La Compagnie d'électricité Maska limitée S, constituée par lettres patentes en date du 8e jour d'avril 1900, 1 changeant son nom en celui île « Maska électrique, limitée Maska Electric, Limited »: 2~ augmentant son capital de $49,000 à $00.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 10 actions privilégiées de $100 chacune et en KM! actions ordinaires de $10\" chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 24e jour de novembre 1964.Le Sous-sccrétaire Je la province, Raymond Douvillk.8902^ 11281-60 1248 121 Me.ham.al Appliance Limited Appareils mécaniques limitée A vu est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 20e jour de novembre 1904, à la compagnie « Mechanical Appliance Company Limited », constituée par lettres patentes en date du 28e jour de février 1903.changeant son nom en celui de « Mechanical Appliance Limited Appareils mécaniques limitée ».Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de novembre 1904.Le Sous-sccrétaire Je la province.Raymond Douvillk.8902 894-63 1247/113 J.Meloche inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late du 23e jour «le novembre 1964.à la compagnie « .T.Meloche inc.», 10 modifiant les dispositions «le ses lettres patentes; 28 augmentant son capital de $38,010 à $50,000, lec capital-actions additionnel étant «livi.se en 199 actions ordinaires «le $10 chacune et en 10,000 actions privilégiées classe « R » de $1 chacune.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 23e jour de novembre 1964.Le Sous-sccrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.8902-«) * 4277-49 1248 3 ters patent, bearing «late the 20th day of October, 1901.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"J.Mashal & C«j.Ltd.\".1.«Icsignating its 600 preferred shares of $100 each into 000 class \"A\" pndcrr«-«l shares of $100 each; 2.increasing its capital from 8100.000 to $101.000.thea«l«liti«>nalcapital stix-k being divided into 1.000 class \"B\" prefer-re«l shares of $1 each.(iiven at the office of the Provincial Si'eretary.this 20th «lay of October.1964.R avmon i) I )«>u vi l.l.l , Assistant Secretari/ of the Province.X902-o 13351-58 1215/113 Masku electri«|u«*.limitée Masku Electric, Limited Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplenumtary letters patent, bearing «late the 21th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Maska Electric Company Limited \u2014La Compagnie d'électricité Maska limitée\", incorporated by letters patent dated the 8th «lay «>f April, 1960.1.changing its name to that of \"Maska électrique, limitée \u2014 Maska Electric.Limited\"; 2.increasing its capital stock from $49,000 to §60.000.t he additional share capital being divided into 10 preferred shares of 8100 each and 100 common shares of $100 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.8902 11*281-60 1248 121 Mechanical Appliance Limited Appartdls mécaniques limitée Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 20th day of November.1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Mechanical Appliance Company Limited\", incorporated by letters patent dated the 28th day of February.1903, changing its name to that «>f \"Mechanical Appliance Limited \u2014 Appareils mécaniques limitée\".(iiven at the ollice of the Provincial Secretary, this 20th «lay of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902-o 894-63\u20141247/113 J.Meloche inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rtl «lay of November.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \".L Meloche inc.\", 1.amending the provisions of its letters patent; 2.increasing its capital stock from $38.010 to $50.000.the a«l«litional capital stock being divided into 199 common shares of $10 each ami into 10,000 preferred shares class \"B\" of $1 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd «lay of November.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Prorince.8902 ' 4277-49 - - 1248 3 56 GAZETTE OFFICIELLE 01.QUEBEC, -} janvier 1966, 97' année, No l Morgan, Ostiguy rgan, Ostiguy & 11 ni ii u i inc.».Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ee 27e jour «le novembre 1664.Le Sous-sccrétaire ra Morrow lue.»; 2° étendant ses pouvoirs; 3° augmentant s«m capital de $20,000 à $200,000, le capital-actions a.hlitionnel étant divisé en 101,(KM) actio'is privilégiées de $1 chacune, les classant « pari passu », en tous points avec les actions privilégiées déjà existantes de la compagnie, lesdites actions privilégit-es devant être désigné»-* comme étant «les actions privilégiées catégorie f Quebec, to \"Morgan & Co.Ltd.\", incorporute«l by letters patent dated the August 1st, 1957, changing its name to that of \"Morgan, Ostiguy & lludon inc.\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of November, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.8902 124X5-57 - 1249/82 Dora Morrow Inc.Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 18th «lay of November, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"M.IL Normand Ltd.\", incorporate«l by letters patent dated the 18th «lay of July, 1961.1.changing its name to that of \"Dt>ra Morrow Inc.\"; 2.extending its powers; 3.increasing its capital from $20,000 to $200,000, the additional capital stock being divided into 101,000 preferred shares of $1 each, ranking pari passu in ull respects with the existing preferretl shares of the company, the sai«l preferre«l shares t«> be «lesignatetl as class \"A\" preferetl shares, and into 19,000 class \"B\" prcfcml shares of $1 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902-0 13304-64 - - 1247/25 Normandie Handbags Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieUtenunt-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 10e jour de novembre 1964, à la compagnie « Normandie Bag & Novelty Co.», constituée par lettres patentes en date du 22e jour de mai 1953, changeant son nom en celui «le « Normandie Handbags Limited ».Donné au bureau du secrétaire de la province, «x?10e jour de novembre 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8902 10343-53 \u2014 1246/80 Normandie Handbags Limited Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of November, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Normandie Bag & Novelty Co.\", incorporated by letters patent dated the 22nd day of May, 1953, changing its name to that of \"Normandie Handbags Limited\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of November, 196-1.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.8902-o 10343-53 \u2014 1246/80 Pascal-Dawson Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late du 18e jour «le novembre 1904.à la ci impugn le « Dawson Auto Parts Limited », Constituée par lettres patentes en date «lu 30e jour «le septembre 1933.changeant son nom en Celui «le f November, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.8902-d 1704-33- 1247/117 QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, January {.1965, Vol.97.No, I 57 Place Bonaveiiturc Ino, Avis est donné qu'on vertu «le la première partie «le la Loi dei compagnies de Québec, il a été accordé, par l«- lieutenant-gouverneur de i» province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «lat«- «lu 26e jour d'août 1064, à la compagnie « Place Bona venture inc.».convertissant ses 160,000 actions privilégiées de $10 chacune en 00,000 actions privilégiées premières «le Ski chacune «-t en 60,000 actions privilégiées secondes de $10 «4iaeune.Donné au bureau «lu secrétaire
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.