Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 septembre 1963, samedi 14 (no 37)
[" Tome 95, No 37 4285 Vol.95, No.37 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Quebec i (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUÉBEC Quebec, samedi 14 septembre 1963 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, September 14, 1963 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the.two official languages.When same is supplied in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over .ay ment, if any 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.L'Imprimeur de la Reine, roch lefebvre, Quten'i Printer \u2014 Québec 4286 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 96, So 37 6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le mercredi à condition que ce jour de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans un tel cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la Eublication de certains documents, à cause de ur longueur ou pour des raisons d'ordre admi-\u2022 nistratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces 1 Abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $1 des 100 mots.Exemplaire séparé: 40 cents chacun.Feuilles volantes: $1.50 la douzaine.Abonnement: $10 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre loi signifie 3ne la matière n'est ni de notre composition ni e notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, Roch Lefebvhk.Hôtel du Gouvernement, Québec, 5 mai 1962.1515 \u2014 l-52-o 6.Remittance must be made' to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Wednesday, providing that this day of the week is not a holiday.In such case, the ultimate delay expires at noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $1.per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: $1.50 per dozen.Subscriptions: $10.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: \u2022 The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette tor the first insertion; the third to the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.Roch Lefebvke, Queen's Printer.Parliament Buildings, Quebec, May 5, 1962.1515\u20141 -52-o Lettres patentes Les Agences Decary Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 3e jour de juillet 1963, constituant en corporation : Gilles Hébert, avocat, 22, de Barcelone, Candiac, Claude Thivierge, avocat, 105, chemin Tac ke ray, Beaconsfield, et Jacqueline Matte, secrétaire, 8390, Droiet, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires dans le domaine de l'assurance, sous le nom de « Les Agences Decary Ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et en 360 actions privilégiées de $100 chacune.\u2014 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Letters Patent Les Agences Decary Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Gilles Hébert,, advocate, 22 de Barcelone, Candiac, Claude Thivierge, advocate, 105 Tac ke ray road, Beaconsfield, and Jacqueline Matte, secretary, 8390 Droiet, Montreal, for the following purposes: To carry on business in the field of insurance, under the name of \"Les Agences Decary Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, IMS, Vol.96, No.S7 4287 Donné au bureau du secrétaire de la province, es 3e jour de juillet 1063.Le Sous-secrétaire de la ¦province, Raymond Douville.3992-o 2702-63\u2014 1179/114 Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of July.1963.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.3992 2702-63\u2014 1179/114 Les Ajusteurs Associée du Québec Inc.Quebec Associated Adjusters Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Pierre Masson, commerçant, 6105, 21e avenue, Montréal, Suzanne Masson Chaussé, secrétaire, épouse séparée de biens d'André Chaussé, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, 519, rue Desaulniers, St-Lambert, et J.-Éloi Gcrvais, avocat et conseiller en loi de la Reine, 61, rue St-Charles, est, l/ongueuil, pour les objets suivants : Exercer le commerce d'ajusteurs en assurance, sous le nom de « Les Ajusteurs Associés du Québec Inc.\u2014 Quebec Associated Adjusters Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Lambert, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 2929-63 \u2014 1180/19 Les Ajusteurs Associés du Québec Inc.Quebec Associated Adjusters Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Masson, merchant, 6105, 21st Avenue, Montreal, Suzanne Masson Chaussé, secretary, wife separate as to property of André Chaussé, and duly authorized by him for the purpose of these presents, 519 Desaulniers St., St-Lambert, and J.-Éloi Gervais, advocate and Queen's Counsel, 61 St-Charles St., East.Longueuil, for the following purposes: To carry on business as insurance adjusters, under the name of \"Les Ajusteurs Associés du Québec Inc.\u2014 Quebec Associated Adjusters Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at St-Lambert, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2929-63\u20141180/19 Anjou Gardens Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du-15e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Neil Franklin Phillips, 634, ave.Clarke, Westmount, Ivan Edward Phillips, 48,-Place Belvédère, Westmount, Mitchell Klein, 188 Wexford Cresc., Hampstead, Daniel Miller, 5714, ave.Edgemore, Côte-St-Luc, tous quatre avocats, et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, 4650, ave.Madison, Montréal, pour les objets suivants: Exercer des affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Anjou Gardens Ltd.», avec un capital total de $510,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 50,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992 3058-63 \u2014 1180/20 Anjou Gardens Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Neil Franklin Phillips, 634 Clarke Ave., West-mount, Ivan Edward Phillips, 48 Belvédère Place, Westmount, Mitchell Klein, 188 Wexford Cres., Hampstead, Daniel Miller, 5714 Edge-more Ave., Côte-St-Luc, all four advocates, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, 4650 Madison Ave., Montreal, for the following purposes: To do business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Anjou Gardens Ltd.\", with a total capital stock of $510,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 50,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992-0 3058-63\u20141180/20 Art-Tec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Hélène Langlois, ménagère, veuve de Jacques Lauzier, 1158, St-Viateur, Outremont, Thomas Langlois, agent, 725, rue Wiseman, Montréal, et Aimé Bertrand, marchand de matériel d'artiste, 178, rue Querbes, Montréal, pour les objets suivants: Art-Tec Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Hélène Langlois, housewife, widow of Jacques Lauzier, 1158 St-Viateur, Outremont, Thomas Langlois, agent, 725 Wiseman St., Montreal, and Aimé Bertrand, dealer in artists' materials, 178 Querbes St., Montreal, for the following purposes: 428S GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 95.No 37 Faire le commerce de tout genre de matériel d'artiste, de peinture ou de sculpteur, sous le nom de « Art-Tec Inc.».avec un capital total de $20,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 278, rue Sherbrooke, ouest.Montreal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 2843-63 \u2014 1181/183 Arvida Pistol Club To carry on business dealing in all kinds of material for artists, painters and sculptors, under the name of \"Art-Tec Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 278 Sherbrooke St.West, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of July, 1963.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 2843-63 \u2014 1181/132 Arvida Pistol Club Avis est donné qu'en vertu de la troisième Notice is hereby given that under Part III of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent, été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la bearing date the 30th day of July, 1963, have province de Quebec, des lettres patentes, en date been issued by the Lieutenant-Governor of the du 30e jour de juillet 1963.constituant en eorpo- Province of Quebec, to incorporate as a corporation suns capital-actions: Hugh Joseph Gailey, ration without share capital: Hugh Joseph Gailey, 236.rue GayLussac, John Herman Braams, 840, 236 GayLussac, John Herman Braams, 840 Lor-rue Lorraine, Marc Hans Bruhacher, 894.rue raine St., Marc Hans Brubacher, 894 Lavoisier Lavoisier, Raphaël Victor Baker, Manoir du St., Raphaël Victor Baker, Manoir du Saguenay.Saguenay, Gordon Harvey Sabiston.8?6, rue Lor- Gordon Harvey Sabiston, 826 Lorraine St., Ray-rainc, Raymond-Jean-Marie Barbeau.880, rue mond-Jean-Marie Barbeau, 886 Lavoisier, Alfred Lavoisier, Alfred Victor Richards.844, rue Wake, Victor Richards, 844 Wake St., Arthur Harvey Arthur Harvey Topham, 325.rue Racine, Fre- Topham.325 Racine St., Frederick Stephen Oli-derick Stephen Oliver, 824.rue Hoopes.tous ver, 824 Hoopes St., all nine engineers, Stewart neuf ingénieurs, Stewart Millar Barrington, 308, Millar Barrington, 308 Dickie St., Bohdan Jozef rue Dickie, Bohdan Jozef Francki.822, rue Francki, 822 Hoopes, and Geoffrey Walter Hut-Hoopes, et Geoffrey Walter Hutchin, 826, rue chin, 826 Montgomery St., the last three Montgomery, ces trois derniers dessinateurs, draughtsmen, all twelve of Arvida, for the tous douze d Arvida, pour les objets .suivants: following purposes: Établir et administrer un club de tir au pistolet To establish and administrate a shooting club ou avec d'autres armes à feu dans le municipalité for pistols or other firearms in the municipality d'Arvida.sous le nom de « Arvida Pistol Club ».of Arvida, under the name of \"Arvida Pistol Club\".Le montant auquel est limitée la valeur des The amount to which the value of the immo- biens immobiliers que peut acquérir et posséder veable property which the corporation may la corporation, est de $5,000.may hold is to be limited, is $5,000.Le siège social de la corporation sera 844.rue The head office of the corporation will be at Wake, Arvida.district judiciaire de Chicoutimi.844 Wake St., Arvida, judicial district of Chi- coutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province.Given at the office of the Provincial Secretary, ce 30e jour de juillet 1963.this 30th day of July, 1963.1* Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk, Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992-0 3088-63\u2014 1182/1 3992 3088-63\u2014 1182/1 L'Association des Cités et Villes du District de Saint-François The St.Francis District Cities and Towns Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour «le juillet 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Léger Cameron, pharmacien, Romuald Dumont, secrétaire, trésorier, tous deux de Coaticook, et Marcel Roy, avocat, Richmond, pour les objets suivants: Étudier les problèmes municipaux propres au district ou à la région, sous le nom de « L'Association des Cités et Villes du District de Saint-François \u2014 The St.Francis District Cities and Towns Association ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $1,000,000.Le siège social de la corporation sera à Richmond, district judiciaire de St-François.L'Association des Cités et Villes du District de Saint-François The St.Francis District Cities and Towns Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Léger Cameron, pharmacist, Romuald Dumont, secretary-treasurer, both of Coaticook, and Marcel Roy, advocate, Richmond, for the following purposes: To study municipal problems particular to a district or region, under the name of \"L'Association des Cités et Villes du District de Saint-François \u2014 The St.Francis District Cities and Towns Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $1,000,000.The head office of the corporation will be at Richmond, judicial district of St.Francis. QLEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol.95, So.37 42S9 Donné au bureau du secrétaire de lu province, ce 29e jour de juillet 1963.1* Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3902*0 3056-63 \u2014 1181/104 Association des Propriétaires de la Ville de I.a Petite-Rivière Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu troisième partie de la Loi des eompugnies de Québec, il u été uccordé, pur l'administrateur du gouvernement «le la province «le Québec, des lettres putentes, en dute du 23e jour de juillet 1963, constituant en corporation suns capital-actions: Lucien Clout ici-, fonctionnaire provincial, 2051, St-Vincent-Ferrier.Joffre Powell, fonctionnaire provincial, 2064.Careau.et Orner Tardif, entrepreneur plâtrier, 2023, Laroche, tous trois de La Petite-Rivière, pour les objets suivants: Veiller à la conservation, la défense et la promotion «les intérêts des personnnes ayant la qualité de propriétaire suivant le rôle d'évaluation en vigueur dans la ville «le La Petite-Rivière, sous le nom de « Association des Propriétaires de la ville «le La Petite-Rivière Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur «les biens immobiliers que peut acquérir et possétler la corporation, est «le $50,000.Le siège social de la corporation sera à La Petite-Rivière, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de juillet 1963.Ije Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3064-63 \u2014 1181/34 Association des Soudeurs du Québec Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour de juillet 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Dollard Flamand, 676, La Fayette, Jonquière, Robert Simard, 30, St-Mathieu, Jonquière, et Roméo Lab rie, 616, Vol ta.Arvida, tous trois soudeurs, pour les objets suivants : Promouvoir, défendre et protéger les intérêts moraux, sociaux, culturels et économiques de ses membres, soudeurs, apprentis-soudeurs et artisans, sous le nom de « Association des Soudeurs du Québec Inc.».Le montant des biens immobiliers que pourra acquérir et posséder la corporation est limité à $40,000.Le siège social de la corporation sera case postale 651, Jonquière, district judiciaire «le Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3902-o 2420-63 \u2014 1180/136 Atlas Roof Truss Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a «:té acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de juillet 1963, constituant en corpora tien : Pierre Dagenais, commerçant, Templet on, Rhéar Archambault, technicienne, fille majeure, et Marcel Beaudry, avocat, ces deux derniers de Hull, poi r les objets suivants: (îiven at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary/ of the Province.3992 3050-03- 1181/104 Association des Propriétaires de la Ville de La Petite-Rivière Inc.Notice is hereby given that un«ler Purt III of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing f July, 1963.have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec.t«> incorporate as a corporation without share capital: Lucien Clou-tier, provincial civil servant, 2051 St-Vincent-Ferrier, Joffre Powell, provincial civil servant, 2064 Careau, and Orner Tardif, contractor-plasterer, 2023 Laroche, all three of La Petite-Rivière, for the following purposes: To watch over the conservation, «lefence and promotion of the interests of persons in their capacity as proprietors according to the rôle of evaluation in force in the Town of La Petite-Rivière, under the name of \"Association «les Propriétaires de la ville «le La Petite-Rivière Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire ami hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at La Petite-Rivière, judicial district bf Quebec.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3064-63 \u2014 1181/34 Association des Soudeurs du Québec Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of July.1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Dollard Flamand, 676 La Fayette, Jonquière, Robert Simard, 30 St-Mathieu, Jonquière, et Roméo Labrie, 616 Volt a, Arvida, all three welders, for the following purposes: To promote, secure and support the economical cultural, social and moral interests of its members, welder-apprentices and handicrafts-men, under the name of \"Association des Soudeurs du Québec Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $40.000.The head office of the corporation will be at Post Office Box 651, Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2420-63 \u2014 1180/136 Atlas Roof Truss Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant -Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Dagenais, trader, Templeton, Rhéa Archambault, technician, spinster of the full age of majority, and Marcel Beaudry, advocate, the two latter of Hull, for the following purposes: 4290 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, H septembre 1963, Tome 95, So 37 Faire affaires dans les domaines de l'immeuble et de la const met ion, sous le nom de « Atlas Roof Truss Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions'ordinaires d'une valeur au pair de $\"> chacune et en 380 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Temple-ton, district judiciaire de Hull.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 29e jour de juillet 1963.I^e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3145-63\u2014 1181/50 Auberge de Jeunesse Vive la Vie Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1963, constituant en corporation sans capital-°.ctions: Georges Malouin, 1820, Lavérendrye, Gérard Bourassa, 2026, Laviolette, et Paul Laurin, 3255, de Franche-ville, tous trois étudiants, de Trois-Rivières, pour les objets suivants: Favoriser les loisirs sains de toute la jeunesse au point de vue social, cultured et sportif, sous le nom de « Auberge de Jeunesse Vive la Vie ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation pent acquérir et posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de juillet 1963./> Snus-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 2902-63 \u2014 1181/105 To carry on business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Atlas Roof Truss Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $5 each and 380 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Templeton, judicial district of Hull.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Proviivce.3992 3145-63 \u2014 1181/50 Auberge de Jeunesse Vive la Vie Notice is hereby given that under Part III of the Quel>ec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Georges Malouin, 1820 Lavérandrye, Gérard Bourassa, 2026 Laviolette, and Paul Laurin, 3255 de Francheville.all three students, of Trois-Rivières, for the following purposes : To favor healthy recreations for all young folk from a social, cultural and sports point of view, under the name of \"Auberge de Jeunesse Vive la Vie\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3Qth day of July.1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2902-63\u20141181/105 Le Baron Hôtel Motel (Sherbrooke) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Paul M.Gervais, André Langlais, tous deux de Sherbrooke, et A.-René Monty, Lennox ville, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, motels et restaurants, sous le nom de « Le Baron Hôtel Motel (Sherbrooke) Inc.», avec un capital total de $55,000, divisé en 50 actions ordinaires de $100 chacune et en 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 2914-63\u2014 1181/20 Julien Beaudoin Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par.l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Julien Beaudoin, manufacturier, Marie-Paule Richard Beaudoin, ménagère, épouse contractuellement commune en biens dudit Julien Beaudoin, et dûment Le Baron Hôtel Motel (Sherbrooke) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Paul M.Gervais, André Langlais, both of Sherbrooke, and A.-René Monty, Lennoxville, all three advocates, for the following purposes: To operate hotels, motels and restaurants, under the name of \"Le Baron Hôtel Motel (Sherbrooke) Inc.\", with a total capital stock of $55,000, divided into 50 common shares of $100 each and 5,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of July, 1963.- Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2914-63 \u2014 1181/20 Julien Beaudoin Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of July, 1983, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Julien Beaudoin, manufacturer, Marie-Paule Richard Beaudoin, housewife, wife common as to property of the said Julien Beaudoin, and duly authorized by him for these presents, both of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September IL, 1968, Vol.95, So.37 4291 autoruée par lui aux fins des présentes, tous deux de Daveluyville, et Gaston Morel, journalier, 2794, rue ChAteauguay, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises et articles en aluminium, fer é mai lié, fer-blanc, granit, métal galvanisé, tôle\" et autres articles fabriqués totalement ou en partie de métaux ou bout, sous le nom de « Julien Beaudoin Ltée », avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et en 4,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Daveluyville, district judiciaire d'Arthabaska.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3215-63 \u2014 1181/106 Daveluyville, and Gaston Morel, day-labourer, 2794 ChAteauguay St., Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in merchandise and articles made of aluminum, enamelled iron, tin, granite, galvanized metal, sheet metal and other articles made wholly or partially of metals or wood, under the name of \"Julien Beaudoin Ltée\", with a total capital stock of $50,000.divided into 500 common shares of $10 each and 4,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Daveluyville, judicial district of Arthabaska.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3215-63 \u2014 1181/106 Paul Bédard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 17e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Léo-Paul Bédard, vendeur, Thérèse Côté Bédard, ménagère, épouse dudit Léo-Paul Bédard, tous deux de 391, rue Hou (fard, et Louis-Philippe Bédard, chauffeur, 387, rue Bouffard, tous trois de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises sèches et de lingerie dans toutes leurs formes et dérivés, sous le nom de « Paul Bédard Inc.», avec, un capital total de $50.000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 17e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la proviivce, Raymond .Douville.3992-o 3104-63 \u2014 1181/24 Paul Bédard Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Léo-Paul Bédard, salesman, Thérèse Côté Bédard, housewife, wife of the said Léo-Paul Bédard, both of 391 Bouffard, and Louis-Philippe Bédard, chauffeur, 387 Bouffard, all three of Quebec, for the following purposes : To carry on business dealing in dry good s and lingerie in all forms and dirivatives, under the name of \"Paul Bédard Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of July, 1963.Raymond Douville, » Assistant Secretary of the Province.3992 3104-63 \u2014 1181/24 Roland Bédard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Luc Geoffroy, 821, boul.Briand, Chambly, Yvan Mercure, 2099, Bellevue, St-Bruno, et Robert Dulude, 90, Galt, est, Dorion, tous trois avocats, pour les objets suivants : < Exercer le commerce de courtiers en assurance, sous le nom de « Roland Bédard Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 8, rue Bennet, Fort-Chambly, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 3143-63 \u2014 1181/37 Berdesmol Ltée Roland Bédard Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government, of the Province of Quebec, incorporating: Luc Geoffroy, 821 Briand Blvd., Chambly, Yvan Mercure, 2099, Bellevue, St-Bruno, and Robert Dulude, 90 Gait.East, Dorion, all three advocates, for the following purposes: To carry on a business as insurance brokers, under the name of \"Roland Bédard Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 8 Bennet St., Fort Chambly, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3143-63\u20141181/37 Berdesmol Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a 4292 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 96, No 87 été accorde', par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 3le jour de juillet 19(53, constituant en corporation: Errol Klock McDougall, Walter Austin Johnson, William Tinling Stewart, tous trois avocats et conseils en loi de la Reine, et James Turner, Lumsdeii, gérant de bureau, tous quatre «le 507, Place D'Armes, Montréal, pur les objets suivants: Faire le commerce «le propriétés immobilières, sous le nom «le « Herdesmol Ltée », avec un capital total de $1,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 31e jour «le juillet 1963.IjC Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992 3126-63\u2014 1182/2 bearing date the 31st day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Krrol Klock McDougall, Walter Austin Johnson, William Tinling Stewart, all three advocates and Queen's Counsels, and James Turner Lumsden, of I ice manager,%)l four of 507 Place D'Armes, Montréal, for the following purposes : To .(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of July.1963.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.3092-o 3126-63 \u2014 1182/2 Bernard Excavation Inc.Avis est donné «m'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date du lie jour de juillet 1963, constituant en corporation: 1/on id a s Bernard, technicien, La Reine, comté d'Abitibi, Roch Bernard, opérateur, La Reine, comté d'Abitibi, Florent Létourneau, technicien, Marina Mor-rissette, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Florent Létourneau, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, ces deux derniers d'Iroquois Falls, province d'Ontario, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de « Bernard Excavation Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La Reine, district judiciaire d'Abitibi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1 le jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 2959-63 \u2014 1179/117 Bernard Excavation Inc.Notifie is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Léonidas Bernard, technician, La Reine, County of Abitibi, Roch Bernard, operator.La Reine, County of Abitibi, Florent Létourneau, technician, Marina Morrissette, housewife, wife contractually separate as to property of the said Florent Létourneau, and duly authorized by him for the purpose of these presents, the latter two of Iroquois Falls, province of Ontario, for the following pruposes: To deal in wood industry and commerce, under the name of \"Bernard Excavation Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at La Reine, judicial district of Abitibi.(liven at the office of the Provincial Secretary, this 11th day of July,-1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 s 2959-63\u2014 1179/117 P.-A.Bérubé.Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 26e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Paul-Auguste Bérubé, marchand, Mme Huguette F.Bérubé, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Paul-Auguste Bérubé, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Rivière-Bleue, et Renaud Robichaud, comptable, St-Dav id-d'Est court, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de construction, sous le nom de « P.-A.Bérubé, Limitée », avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $50 chacune et en 700 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rivière-Bleue, district judiciaire de Kamouraska.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 26e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 3076-63\u2014 1181/133 P.-A.Bérubé, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of July, 1963.have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Paul-Auguste Bérubé, merchant, Mrs.Huguette F.Bérubé, housewife, wife contractually, separate as to property of the said Paul-Auguste Bérubé, and duly authorized by him for these presents, both of Rivière-Bleue, and Renaud Robichaud, accountant, St-David-d'Estcourt, for the following purposes: To carry on business as a construction company, under the name of \"P.-A.Bérubé, Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $50 each and 700 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Rivière-Bleue, judicial district of Kamouraska.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3076-63 - 1181/133 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14.IMS.Vd, 96, No.S7 4293 Bibo, Transport Muritimc Ltéc Bibo Maritime Transport Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la 'première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 21e jour «le juin 1903, constituant en corpora-tion: André Trottier, 1074, rue Belmont, Sillery, Guy Letarte, 2753, rue Valcourt, et Henri Lame, 2000, rue «les Forges, ces deux derniers «le Ste-Foy, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exploiter une compagnie de navigation, sous le nom «le « Bibo.Trans|>ort Maritime Ltée \u2014 Bibo Maritime Transport Ltd.», avec un capital total de $100,000, divisé en 3.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,500 actions privilégiées «le $20 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Clermont, district judiciaire de Saguenay.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 21e jour de juin 1963.I* Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.3992-o 2741-63 1178/42 Bi*.*onncttc Auto (Rouyn) Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Marcel Cinq-Mars, avocat, 144, rue Saguenay, Alfred Leclerc, comptable, 165, 15e rue, tous deux de Noranda, et Julienne Pilon, secrétaire, fille majeure, 169, rue Latulipe, ouest, Rouyn, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles, leurs accessoires et parties et faire affaires comme garagistes, sous le nom de « Bissonnette Auto (Rouyn) Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Norahda.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 2703-63- 1182/3 Blumer'* (St.Jean) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Seymour Blumer, marchand, Roslyn Faber Blumer, ménagère, épouse séparée de biens dudit Seymour Blumer, et dûment autorisée par ce dernier aux 6ns des présentes, tous deux de 5051, chemin Glencairn, et Stanley Kan-«lestin, avocat, 4590, Michel-Bibaud, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le «commerce de vêtements pour hommes, femmes et enfants, nouveautés, bottines et .souliers, produits de la ferme et marchandise générale et exploiter des magasins généraux, sous le nom de « Blumer's (St.Jean) Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune._ Le siège social de la compagnie sera à St-Jean, district judiciaire d'Ibefville.Bibo, Transport Maritime Ltée Bibo Maritime Transport Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of June, 19(53, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: André Trottier, 1074 Belmont St.Sillery.Guy Letarte, 2753 Valcourt,St., ami Henri Larue, 2660 des Forges, St., the latter two of Ste-Foy, all three advocates, for the following purposes: To operate a shipping company, un«ler the name of \"Bibo, Transport Maritime Ltée \u2014 Bibo Maritime Transport Ltd.*'.with a total capital stock of $100,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $20 each.The head office of the company will be at Clermont, judicial district of Saguenay.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of June.1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2741-63 - 1178/42 Bissonnette Auto (Rouyn) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Cinq-: Mars, advocate.144 Saguenay, Alfred Leclerc, accountant, 165, 15th St., both of Noranda, and Julienne Pilon, secretary, fille majeure, 169 Latulipe St., West, Rouyn, for the following purposes : To carry on a business dealing in automobiles, their accessories and parts and to operate as garagemen, under the name of \"Bissonnette Auto (Rouyn) Inc.\", with a total capital stock of $40,000,*divided into 4,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda.Given at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2703-63 - 1182/3 Blumer's (St.Jean) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 25th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Seymour Blumer, merchant, Roslyn Faber Blumer, housewife, wife separate as to property of the said Seymour Blumer, and duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 5051 Glencairn Rd., and Stanley Kandestin, advocate, 4590 Michel-Bibaud, all three of Montreal, for the following purposes: To deal in men's, women's and children's clothing, dry goods, boots and shoes, farm produce and general merchandise and to operate general stores, under the name of \"Blumer's (St.Jean) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3.000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at St-Jean, judicial district of Iberville. 4294 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Toms 95, No 37 Donné au bureau du .secrétaire de la province, ce 25e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3210-63 -1182/52 Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-o 3120-63 \u2014 1182/52 Ilarold-G.Boisseau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouverne-ment de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Louis Fortin, avocat, Claudette Pallass et Pauline Gobeil, secrétaires, tous trois de 585, boulevard (\"barest, est, Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de fenêtres, moustiquaires, treillis métalliques, panneaux translucides, murs-écrans, incinérateurs, cheminées et toutes autres spécialités en construction, sous le nom de « Harold-G.Boisseau Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de juillet 1963.IjC Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 2944-63 \u2014 1181/38 Harold-G.Boisseau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Louis Fortin, advocate, Claudette Pallass and Pauline Gobeil.secretaries, all three of 585 Cbarest Blvd., East, Quebec, for the following purposes: To deal in windows, screens, wire netting, translucent panels, screenwalls, incinerators, chimneys and all other specialties in construction, under the name of \"Ilarold-G.Boisseau Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2944-63\u20141181/38 Jordi Bonet Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23c jour de juillet 1963, constituant en corporation: Marcel Belleville, avocat, Robert Benoit, avocat, tous deux de 204, Notre-Dame, ouest, et Monique Léonard, secrétaire, fille majeure, 3971, St-Hubert, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Commerce d'articles de céramique et autres produits fabriqués de toutes substances provenant du sol ou du sous-sol, sous le nom de « Jordi Bonet Inc.», avec un capital total de $40,000.divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 3097-63\u20141181/27 Jordi Bonet Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of July, 1963, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Belleville, advocate, Robert Benoit, advocate, both of 204 Notre-Dame West, and Monique Léonard, secretary, fille majeure, 3971 St-Hubert, all three of Montreal, for the following purposes : To deal in articles of ceramic and other products made of any substance coming from the soil or sub-soil, under the name of \"Jordi Bonet Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3097-63\u2014 1181/27 Boulangerie Gadoua & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Claude Béland, 2870, rue Glencoe, Montréal, Louis A.Toupin, 352, nie Me loche, St-Laurent, et Jean Bad eaux, 197, rue Dufferin, Hampstead, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce du pain, de gâteaux, pâtisseries et autres articles d'alimentation produits par .la cuisson, sous le nom de « Boulangerie Boulangerie Gadoua & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Claude Béland, 2870 Glencoe St., Montreal, Louis A.Toupin, 352 Meloche St., St-Laurent, and Jean Badeaux, 197 Dufferin St., Hampstead, all three advocates, for the following purposes: To deal in bread, cakes, pastries and other food articles produced by cooking, under the name of \"Boulangerie Gadoua & Fils Ltée\", with QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol.95, So.37 4295 < iadoua & Fil* Ltée », avec un capital total de $60,000, divisé en 200 action* ordinaire* de $100 chacune et en 400 action* privilégiée* de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Napier-ville, district judiciaire d'IberviUe.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de juillet 1963.Le Sous-secrHaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 2896-63 \u2014 1181/l Bourgeois & Frère Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Rémi Bourgeois, 307, rue York, Léonide Bourgeois, 165, rue Elgin, et Ernest Bourgeois, 60, St-Charles, tous trois manufacturiers, de Granby, pour les objets suivants: Exercer le commerce de toute* sortes de portes, fenêtres et autres ouvertures, ainsi que de* matériaux de construction, sous le nom de « Bourgeois & Frère Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et en 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de juillet 1963.IjC Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3174-63 \u2014 1181/80 a total capital stock of $60,000.divided into 200 common shares of $100 each and 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will he at N'apiei ville, judicial district of Iberville., Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2896-63\u2014 1181/1 Bourgeois & Frère Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of July, 1963, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Rémi Bourgeois, 307 York St., Léonide Bourgeois, 165 Elgin St., and Ernest Bourgeois, 60 St-Charles, all three manufacturers, of Granby, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of doors, windows and other openings, as well as in construction materials, under the name of \"Bourgeois & Frère Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $10 each and 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3174-63 -1181/80 La Boutique Madelon Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 8e jour d'août 1963, constituant en corporation: Jacques La marche, avocat stagiaire, 5506, Bellingham, Montréal, Claire Vaillancourt, secrétaire, 24, Brise du Lac, Valois, et André Gauthier, avocat, 4990, bout, des Ormes, St-Bruno-de-Montarville, pour les objets suivants : Faire le commerce de vêtements, sous le nom de \u2022 La Boutique Madelon Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 10732, rue Millen, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 8e jonr d'août 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3378-63\u2014 1182/109 Brake & Electric Service, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Pierre Legrand, 415, Place d'Amiens, 1 >u vernay.Michel A.Gagnon, 3769, avenue Grey, Montréal, tous deux avocats, et André Guertin, commis, 5635, avenue Wellington.Verdun, pour les objets suivants: La Boutique Madelon Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letter* patent, bearing date the 8th day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Lain arche, Taw student, 5506 Bellingham, Montreal, Claire Vaillancourt, secretary, 24 Brise du Lac, Valois, and André Gauthier, advocate, 1990 des Ormes Blvd., St-Bruno-de-Montarville, for the following purposes: To carry on business dealing in wearing apparel, under the name of \"La Boutique Madelon Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10.each.* The head office of the company will be at 10732 Millen St., Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of August, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3378-63\u2014 1182/109 Brake & Electric Service, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 30th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Legrand, 415 Place d'Amiens, I )uvernay, Michel A.Gagnon, 3769 Grey Ave., Montreal, both advocates, and André Guertin, clerk, 6635 Wellington Ave., Verdun, for the following purposes: 4296 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, H septembre 1963, Tome 96, So 37 Commerce e siège social «le la compagnie sera à St-Mi-chel, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 30e jour «le juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doit ville.3902-o 3074-63\u2014 1181/134 To carry on business dealing in vehicles, carnages, motors and apparatus of all kinds as well as their spare parts and accessories and to carry on business in the field of real estate, uuder the name of \"Brake & Electric Service, Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at St-Michel, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30 day of July.1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3074-63\u20141181/134 Bureau d'Ajustement Bics Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 22e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Louis Vaillancourt.4519, Oxford, Roma Cousineau, 5652.Drake, tous deux avocats, de Montréal, et Claude Pou lin.étudiant, 3716, Evelyn, Verdun, pour les objets suivants: Faire l'évaluation, l'estimation et l'appréciation de toutes sortes de biens, propriétés et exploitations, sous le nom de « Bureau d'Ajustement Bics Inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la conpagnie sera 5977, boulevard Monk, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 3146-63 - 1181/51 Bureau de Traduction Raymond-Kelly-Noël Inc.Raymond-Kelly-Noël Translation Bureau Inc.Avis est donné qu'en vertu ,bjets suivants: Exercer le commerce «le louage de tous véhicules, automobiles, camions, bateaux, bicyclettes, tracteurs, aéroplanes, autobus et autres moyens de transport, sous le nom de « Château Leasing Lt«l.», avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions ordinaires de $50 chacune et en 200 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour de juillet 1963.Lê Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-e 3144-63 \u2014 1182/80 Chaudière Chipping Center Inc.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: A J mas Brassard, 121 Racine St., East, René levesque, said Brassard, 121 Racine St., East, Orner Tremblay, 333.Raciue St., East, all three of Chicoutimi, Roland Landry, 705 Jacques-Cartier, Jonquière, and Xavier Angers, 10 Moreau St., Alma, all five brokers, for the following purposes: To unite in association the persons interested in the business of real estate or to immoveable operations, under the name of \"La Chambre d'Immeuble du Royaume du Saguenay Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of August, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2935-63 \u2014 1182/111 ' Charlebois & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 20th «lay of July, 1963, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Jude* Charlebois, François Charlebois and Claude Charlebois, manufacturers, of Lachute, for the following purposes: To carry on business as lumber merchants, under the name of \"Charlebois & Fib Ltée\", with a total capital stock of $49,000, divided into 200 common shares of $100 each and 290 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Lachute, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3046-63\u2014 1182/53 Château Leasing Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: François Boisclair, 336 Hall St., St-Lambert, Jean-Louis Lamoureux, 10485 Jeanne-Mance, Montreal, and Yyon Brizard, 6538 Louis-Hébert, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on a business in the rental of any vehicle, automobiles, trucks, boats, bicycle, tractors, aéroplanes, autobuses, and other means of transportation under the name of \"Château Leasing Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of $50 each and into 200 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of July, 1963.Raymond Douvillk, f Assistant Secretary of the Province.3992 3144-63 \u2014 1182/80 Chaudière Chipping Center Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Notice is hereby given that under Part I of.the Quebec Companies Act, letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol.96, So.37 4301 été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 12e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Jacques (iodhout, industriel, Marc-André I.al>l>é, gérant, I,éonanl Lessard, commis, tous trois de St-Georges, et Georges Poulin, inspecteur, St-Georges-Ouest, pour les objets suivants: Exploiter des moulins à !>ois «le Unîtes sortes pour convertir le Ixris en produits finis ou partiellement finis et plus spécialement faire la conversion «le résidus «le moulins à scie en copeaux, sous le nom de « Chaudière Chipping Center Inc.», avec un capital total de $40,0U0, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 510 chacune et en 3,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-( ieorges, district judiciaire de H eau ce.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 12e jour de juillet 1963.Ije Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3998-0 2934-63-1180/55 La Cie de Démolition Ltée Avis est donné qu'eu vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, eir \u2022late du 29e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Êlie A Hard, promoteur, 2146, Darling, Montréal, J.-Éloi Gervais, avocat, 61, St-Charles, est, Longueuil, et Horacia Cassidy, ménagère, épouse ert Cassidy, et dûment autorisée par lui aux fins «les présentes, 311, boul.St-Joseph.est, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le «commerce de démolisseurs, sous le nom de « La Cie de Démolition Ltée », avec un capital total de $15,000, divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au vureau du secrétaire «le la province, ce 29e jour de juillet 1963, Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3069-63 \u2014 1181/111 bearing date the 12th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Godlmut, industrialist, Marc-André Labi >é, manager, Léonard Lessard, clerk, all three of St-( ieorges, and Georges Poulin, inspector, St-Georges-West, for the following purposes: To operate wood mills of all kinds to transform wood into finished or partly finished products and more particularly to convert sawmill residues into chipping, under the name of \"Chaudière Chipping Outer Inc.\", with a total capital stock of $40.000.divide! into 1.000 com mon shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will he at St-Georges, judicial district of Beauce.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2934-63 \u2014 1180/45 La Cie de Démolition Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Êlie Allan!, promoter, 2140 Darling, Montreal, J.-Éloi Gervais, advocate, 01 St-Charles, East, Longueuil, and Horacia Cassidy, housewife, wife of Robert Cassidy, and duly authorized by him for these presents, 311 St-Joseph Blvd., East, Montreal, for the following purposes: To carry on a business as deinolishers, under the name of \"La Cie «le Démolition Ltée\", with a total capital stock of $15,000, divided into 50 common shares of a par value of $100 each and into 100 preferretl shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3009-63 \u2014 1181/111 J.B.Cloutier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 10e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Jean-Baptiste Cloutier, épicier, Mme Alice B.Cloutier, ménagère, épouse dudit Jean-Baptiste Cloutier, tous deux de 142, rue Racine, Loretteville, et Jean-Nicol Cloutier, commis, 76, Des Bouleaux, Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'épiciers, sous le nom de « J.B.Cloutier Inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 140, rue Racine, Loretteville, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 10e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 2979-63 \u20141180/84 J.B.Cloutier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Jean-Baptiste Cloutiej, grocer, Mrs.Alice B.Cloutier, housewife, wife of the said Jean-Baptiste Cloutier, both of 142 Racine, Loretteville, and Jean-Nicol Cloutier, clerk, 70 des Bouleaux, Quebec, for the following purposes: To carry on a business as grocers, under the name of \"J.B.Cloutier Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided in 400 common shares of $100 each and into 100 preferred shares of of $100 each.The head office of the company will be at 140 Racine, Loretteville, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2979-63\u20141180/84 4302 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 95, So 37 Club de Curling de Baie-Comeau Limitée Baie-Comeau Curling Club Limited Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 26e jour de juin 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Bruce Megill, 10, avenue Mouchette, John Jennings, 15, avenue Père-Carnier, et John Thompson, avenue Low, tous trois industriels, de Baie-Comeau, pour les objets suivants: Établir et diriger un club social et sportif, sous le nom de « Club de Curling de Baie-Comeau Limitée \u2014 Baie-Comeau Curling Club Limited\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $500,000.Le siège social de la corporation sera à Baie-Comeau, district judiciaire de Saguenay.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 26e jour de juin 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 2769-63\u20141181/81 Club des Pins Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 2e jour d'août 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Ernest Heu miette, entrepreneur, St-Élie-d'Orford, Avila Laliberté, camionneur, 1927, King, ouest, Sherbrooke, et Romuald Dumas, gérant de ventes, 1727, Mardi, Sherbrooke, pour les objets si u van t.s: Établir et administrer un club social, sous le nom de « Club des Pins Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera à St-Élie-d'Orford, district judiciaire de St-François.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 2e jour d'août 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-u 3207-63 \u2014 1182/113 Le Club Dom Est Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour de juillet 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Gabriel M.Pelletier, avocat, Odile T.Pelletier, secrétaire, épouse dudit Gabriel M.Pelletier, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 2004, chemin St-Louis, et Claude Trottier, industriel, 1418, Dubuisson, tous trois de Sillery.pour les objets suivants : Établir et administrer un club familial, sous le nom de « Le Club Dom Est Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.* Le siège social de la corporation sera à Sillery, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-q 3140-63\u20141181/136 Club de Curling de Baie-Comeau Limitée Baie-Comeau Curling Club Limited Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of June, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Bruce Megill, 10 Bouche ttc Ave., John Jennings, 15 Père Gamier Ave., and John Thompson, Low Ave., all three industrialists, of Baie-Comeau, for the following purposes: To establish and direct a social and sports club, under the name of \"Club dc Curling de Baie-Comeau Limitée \u2014 Baie-Comeau Curling Club Limited\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $500,000.The head office of the corporation will be at Baie-Comeau, judicial district of Saguenay.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of June.1963.raymon d dou ville, Assistant Secretary of the Province.3992 2769-03\u2014 1181/81 Club des Pins Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Ernest Beaudette, contractor, St-Élie-d'Orford, Avila Laliberté, trucker, 1927 King West, Sherbrooke, and Romuald Dumas, sales manager, 1727 Marcil, Sherbrooke, for the following purposes: To establish and administrate a social club, under the name of \"Club des Pins Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at St-Élie-d'Orford, judicial district of St.Francis.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of August, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3207-03\u2014 1182/113 Le Club Dom Est Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Québec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of July, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Gabriel M.Pelletier, advocate, Odile T.Pelletier, secretary, wife of the said Gabriel M.Pelletier, and duly authorized by him for these presents, both of 2004 St-Louis Road, and Claude Trottier, industrialist, 1418 Dubuisson, all three of Sillery, for the following purposes: To establish and manage a family club, under the name of \"Le Club Dom Est Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Sillery, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3140-63 \u2014 1181/136 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol.95, No.37 4303 I a- Club Nautique de St-Félicien Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouverne-ment de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 2e jour de juillet 1963, .(instituant en corporation sans capital-actions: l'a u I ( iu il Jaunie.industriel, Robert Lamontagne, notaire, Philippe Pilote, Real Payette, Aurélien Talbot, Oswald Verreault, tous quatre commerçants, Robert Coté*, avocat, Paul-Emile Jacques, commis, Y von Castonguay, agent de police, Paul Lepage, camionneur, Paul Lizotte, Guy Moreau, tous deux gérants, tous douze de St-Félicien, et Léonce Tremblay, commerçant, Xotre-Dame-de-la-Doré, pour les objets suivants: Grouper en association les personnes intéressées au sport nautique, sous le nom «le « le Club N'autique de St-Félicien Inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de «50,000.Le siège social de la corporation sera à St-Félicien, district judiciaire de Roberval.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 2e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 2097-03\u2014 1181/77 Le Club Nautique de St-Félicien Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of July, 1903, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Paul Guillaume, industrialist, Robert Lamontagne, notary, Philippe Pilote, Real Payette, Aurélien Talbot, Oswald Verreault, all four traders, Robert Côté, advocate, Paul-Emile Jacques, clerk, Y von Castonguay, policeman.Paul Lepage, trucker, Paul Lizotte, Guy Moreau.both managers, all twelve of St-Félicien, and Léonce Tremblay, trader.Notre-Dame-de-la-Doré, for the following purposes : To group together into an association the persons interested in water sports, under the name of 'Te Club Nautique «le St-Félicien Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at St-Félicien.judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2nd «lay of July.1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2097-63 \u2014 1181/77 Club Privé du Lac Laurel Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été i.-corde\", par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 17e jour de juillet 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Warren Hale, entrepreneur électricien, 605, O'Connell, Robert Burgess, machiniste, 5902, boul.Monk, Ronald St-Germain, peintre, 7257, Henri-Julien, Walter Spooner, assistant-contremaître, 4548, Bour-bonnière, René Landry, contremaître, 733, rue St-Denis, Jean-Paul Gagnon, artisan, 2079, Dézéry, tous six de Montréal, Louis Baribeault, graisseur, rue Chaumont, Anjou, Léonce Gosse-lin, menuisier, Laurel, comté d'Argenteuil, Eugène Laplante, menuisier, 442, rue Décarie, St -Laurent, Henri I lamelin, pompier, 427, Décarie, St-Laurent, et Real Deniers, artisan, Browns-burg, pour les objets suivants: Établir et administrer un club social et sportif, sous le nom de « Club Privé du Lac Laurel », Le revenu annuel des propriétés immobilières «tue la corporation pourra acquérir et posséder pour ses fins ne devra pas excéder $50,000.Le siège social de la corporation sera Lac Laurel, canton de Wentworth, district judiciaire de Terrebonne.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 17e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 2719-63 \u2014 1181/82 Club Sportif Mont-Eskimo Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour d'août 1963, constituant en corporation: Y von Per ras, avocat, 5335, Place d'Argenteuil, Cartierville, Gilles Cossette, avocat, 702, Club Privé du Lac Laurel Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Warren Hale, contractor-electrician, 605 O'Connell, Robert Burgess, machinist, 5902 Monk Blvd., Ronald St-Germain, painter, 7257 Henri-Julien, Walter Spooner, assistant-foreman, 4548 Bourbonnière, René Landry, foreman, 733 St-Denis St., Jean-Paul Gagnon, craftsman, 2079 Dézéry, all six of Montreal, Louis Baribeault, greaser, Chaumont St., Anjou, Léonce Gosselin,, joiner, Laurel, county of Argenteuil, Eugène Laplante, joiner, 442 Décarie St., St-Laurent, Henri Hamelin fireman, 427 Décarie St-Laurent, and Real Deniers, craftsman.Brownsburg, for the following purposes: To establish and administrate a social and sports club under the name of \"Club Privé du Lac Laurel\".The annual revenue of the immoveable properties which the corporation may acquire and own for its purposes shall not exceed $50,000 The head office of the corporation will be at Lac Laurel, township of Wentworth, judicial district of Terrel>onne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of July, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2719-63 \u2014 1181/28 Club Sportif Mont-Eskimo Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Yvon Perras, advocate, 5335, Place d'Argenteuil, Cartierville, Gilles Cossette, advocate, 702 Davaar, Outre- 4304 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, IL septembre 1968, Tome 95, No 87 Davuar, Outremont, et René Plouffe, homme d'affaire», 4000, Pierre-Chevrier, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste a fournir de l'amusement au public et exploiter le commerce de golf, du tennis, du ski et autres formes d'amusement, sous le nom de « Club Sportif Mont-Eski-mo Ltée », avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair, et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses opération! sera «le $5,000.Le siège social de la compagnie sera à'Lac-Paré, comté «le Montcalm, district judiciaire «le Joliette.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 1er jour d'août 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3190-03\u2014 1182/82 Collège Champlain Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du lie jour de juillet 1963.constituant en corporation : Rosaire Beauté, avocat.10580, Grande-A lié, Montréal, René Beau lac, étudiant en droit, 0290, Louis-Hé mon.Montréal, et Paule Lamontagne, secrétaire.veuve dé François Gobeil.2015, Beaubien.Montréal, pour les objets suivants: Établir et diriger une ou «les écoles privées et y donner des cours de formation ou d'éducation générale, scientifique, commerciale, s'adressant à des élèves du cours primaire ou secondaire, sous le nom de « Collège Champlain Inc.», avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $5 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Duver-nay, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1 le jour de juillet 1903.Ia' Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3902-o 3001-03\u20141180/5 mount, and René Plouffe, businessman, 4060 Pierre-Chevrier, Montreal, for the following purposes: To carry on a business which will supply amusement to the public and operate a business dealing with golf, tennis, skiing and other forms of amusement, under the name of \"Club Sportif Mont-Eskimo Ltée\", with a capital stock divided into 1,000 common shares of no par value, and the amount of'the capital stock with which the company shall start its operations shall be $5,000.The head office of the company will be at take Paré, county of Montcalm, judicial «lis trict of Joliette.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of August, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3190-03- 1182/82 Collège Champlain Ine.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of July, 1903, have been issued by the A«lministrator of the Govern meut of the Province of Quebec, incorporating.Rosaire Beaulé, advocate, 10580 Grande-Allée.Montreal, René Beaulac, student at law, 029b Louis-Hémon, Montreal, and Paule Lamontagne.secretary, widow of François Gobeil, 201\") Beaubien, Montreal, for the following purposes: To establish and manage private school or schools and to dispense therein scientific, commercial courses of general formation or education convenient for pupils of primary or secondary grade, under the name of \"Collège Champlain Inc.\", with a total capital stock of $20,000.divided into 1,000 common shares of $5 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Duvernay, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 11th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3001-03\u20141180/5 Le Comité des Citoyens du Lac Grégoire Avis est donné qu'en vertu «le la troisième par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Quél>ec, «les lettres patentes, en date du 15e jour de juillet 1903, constituant en corporation sans capital-actions: Roch Léves-que, opérateur, 0735, 21e avenue, Montréal, Philias La plan te.journalier, 1583.St-Christophe, Montréal, Raymond Perrier, homme de service.3084.Desautels, Montreal.Wilfrid Chartier, inspecteur, 4451.Bordeaux, Montréal, Damien Messier, machiniste, 3892, Allen.Verdun, Jean (iagné, avocat.10285.Jeanne-Mance, Montréal, Jean-Charles Lafleur, industriel, 9153, Iberville.Montréal, Alcide Hébert, mouleur, 7839, Lajeu-nesse.Montréal.Denis Poirier, directeur des incendies, 8, chemin Chambly, Longueil, Paul-Emile Caron, inspecteur.3410, Bedford, Mourrai, et Hennas Perreault, opérateur, 1117, 27e avenue, St-Autoine-des-Laiirentides, pour les objets suivants: Grouper en association tous les résidants du territoire connu sous le nom de projet du Lac-Grégoire, de Ste-Julienne, comté de Montcalm, sous le nom de « Le Comité des Citoyens du Lac Grégoire ».Le Comité des Citoyens du Lac Grégoire Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Roch Lc-vesque, operator, 6735, 21st Avenue, Montreal.Philias Lap I an te, labourer, 1583 St-Christophe.Montreal, Raymod Perrier, serviceman, 3084 Desautels, Montreal, Wilfrid Chartier, inspector.4451 Bordeaux, Montreal, Damien Messier, machinist, 3892 Allen, Verdun, Jean Gagné, advocate, 10285 Jeanne-Mance, Montreal.Jean-Charles Lafleur, industrialist, 9153 Iberville.Montreal, Alcide Hébert, moulder, 7839 Lajeu-nesse, Montreal, Denis Poirier, fire-chief, S Chambly Bd.Longueuil, Paul-Emile Caron.inspector, 3410 Bedford, Montreal, and Hennas Perreault, operator, 1117, 27th Avenue, St-An-toine-des-Laurentides, for the following purposes: To unite into association all the residents of the territory known under the name of project of Lac-Grégoire, of Ste-Julienne, county of Montcalm, under the name of \"Le Comité des Citoyens du Lac Grégoire\". QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, IMS, Vol.i des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du Uze jour de juillet 1903, constituant en corporation: Claude Barbeau, ingénieur professionnel, Pierrette Fournier, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Claude Barbeau, tous «leux de 497, rue Del ma r, app.11, Pointe-Claire, et Jacqueline Fournier, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens de Jean-Paul L'Archevêque, 8145, rue St-André, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le barbiers et de coiffeurs, sous le nom de « Coromoto Ltd.», avec un capital total de $40.000, divisé en 2.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour de juillet 1903./>e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o .3156-63 \u20141181/78 La Corporation Desruisseaux Desrtiisseaux Corporation Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur «lu gouvernement «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 18e jour de juillet 1903, constituant en corporation : F.Edmund Barnard, 624, rue Vimy, nord, Sherbrooke, Charles Leblanc, 659, rue London, Sherbrooke, et Pierre C.Fournier, 159, boul.Queen, nord, Sherbrooke, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de lithographes, imprimeurs, éditeurs, imprimeurs de plaques de métal The head office of the corporation will he at Gaspé, judicial district of Gaspé.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3142-63 -1181/5 Const ruction Bouchard Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 5th «lay of September, 1962.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating : Joseph Bouchard, Fernand Bouchard, contractors, Pierre Belzile and André Belzile, merchants, all four of Luceville.for the following purposes: To carry on a business as constructors and general building contractors, under the name of \"Construction Bouchard Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Luceville, judicial district of Rimouski.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of August, 1903.Raymond Douvii.i.k, Assistant Secretary of the Province.3992 13420-02- 1139/108 Coromoto Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters' patent, bearing date the 22nd day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Claude Barbeau, professional engineer, Pierrette Fournier, housewife, wife contractually separate as to property of the said Claude Barbeau, both of 497 Dclmar, Apt.11, Pointe-Claire, an«l Jacqueline Fournier, housewife, wife contractually separate as to property of Jean-Paul L'Archevêque, 8145 St-André St., Montreal, for the following purposes: To carry on a business as barl>er.s and hairdressers, tinder the name of \"Coromoto Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2 000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3150-03 -1181/78 La Corporation Desruisseaux Desruisseaux Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of July, 19(53, have been issued by the A«lministrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: F.Edmund Barnard, 024, Vimy St., North, Sherbrooke, Charles Leblanc, 659 London St., Sherbrooke, and Pierre C.Fournier, 159 Queen Blvd., North, Sherbrooke, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of lithographers, printers, publishers, printers of metal and tin 4308 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 96, So 37 et d'étui h.nous le nom de « La Corporation Desruisseaux \u2014 Desruisseaux Corporation », avec un capital total de $500,000, divisé en 50,000 actions spéciales d'une valeur au pair de $1 chacune, 300,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 150,000, actions privilégiées «l'une valeur au pair de $1 chacune.le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire «le St-Fran«^>is.' Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 18e jour «le juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3078-63 \u2014 1181/41 Crémerie Lemaire Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouverne-, ment de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 25e jour «le juillet 1903, constituant en corporation: Félicien lemaire, fromagier, Roger Lemaire.fromagier.et Jean-Paul lemaire, journalier, tous trois de Ste-Per-pétue, pour les objets suivants: Commerce du lait et de ses sous-produits, sous le nom de « Crémerie Lemaire Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ste-Perpétue, district judiciaire de Nicolet.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour «le juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 3216-63\u20141181/85 filâtes, under the name of \"La Corporation )esruisseaux \u2014 Desruisseaux C«>rporation\".with a total capital stock of $500.000, divided into 50,000 special shares of a par value of $1 each, 300,000 common shares of a par value of $1 each and 150,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of July, 1903.Raymond IKhjvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 307S-63 1181/41 Crémerie Lemaire Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 25th day of July, 1903, have been issued by the (Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Félicien Lemaire, cheese-maker, Roger Lemaire, cheese-maker, and Jean-Paul lemaire, day-labourer, all three of Ste-Perpétuc.for the following purposes: To deal in milk ami its by-products, under the name of \"Crémerie Lemaire Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each am! 3.000 preferral shares of $10 each.The head office of the company will l>e at Ste-Perpétue, judicial district of Nicolet.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July.1963.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3210-63 \u2014 1181/85 Crète & Guimond Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1903.constituant en corporation: Georges Crète, entrepreneur, St-Séverin de Proulxville, Fernand Boucher, comptable agréé, 440, boni, des Laurentides, Shawinigan-Nord, et Raymond Landry, avocat, St-Êtienne-des-Grès, pour les objets suivants: Industrie et commerce de bois, sous le nom de « Crète & Guimond Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.I-e siège social de la compagnie sera 082, 5e rue, Shawinigan, district judiciaire de Trois-Rivières.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour «le juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3202-63\u20141182'114 Cricket & Rugger Times Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Alastair Richmond Pryde.agent d'immeubles, 5260, avenue Mariette, Vincent-Joseph Gagnon, 5324, avenue Plamondon, Dennis Brian Gustard, 6666, avenue Fielding, app.308, tous deux représentants de Crête «& Guimond Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Georges Crete, contractor, St-Séverin de Proulxville, Fernand Boucher, chartered accountant, 440 des Laurentides Blvd., Shawinigan-North.and Raymond Landry, advocate, St-Êtienne-des-Grès, for the following purposes: The industry and business dealing in wood, under the name of \"Crète & Guimond Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 682, 5th St.Shawinigan.judicial district of Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of July, 1903.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3262-03 \u2014 1182/114 Cricket & Rugger Times Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Alastair Richmond Pryde, real estate agent, 5260 Mariette Ave., Vincent-Joseph Gagnon, 5324 Plamondon Ave., Dennis Brian Gustard, 6666 Fielding Ave., Apt.308, both sales representatives, all three of Montreal.James Albert QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, IMS, Vol.95, No.37 4309 ventes, tous trois rt amateur et organiser des parties, voyages et compétitions de toute nature, sous le nom de « Cricket & Rugger Times Ltd.», avec un capital total de $2,000, divisé en 750 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, 10 actions privilégiées catégorie « A » d'une valeur au pair de $50 chacune et 75 actions privilégiées catégorie « H » d'une valeur au pair de $10 chacune.le siège social de la compagnie sera à St-Chrysostome, district judiciaire de Beauharnois.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de juillet 1903.Le Soux-xecrêtaire de la province, Raymond Douvillk.3992 2920-03- 1181/138 Maurice Cuillerier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 9e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Raymond Crevier, avocat, 245, avenue Outremont, Outremont, Michel A.Gagnon, avocat, 3709, Grey, Mont real, et André Guertin, commis, 5635, avenue Wellington, Verdun, pour les objets suivants: Maintenir et exploiter des salons de beauté et de coiffures, sous le nom de « Maurice Cuillerier Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cartier-ville, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 9e jour de juillet 1963.Le Sont-secrétaire de la province, Raymond Douville.1992-0 2970-63- 1179/94 Les Cuisines G.Miller Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Robert Y.Lanthier, avocat, 237, boni.Ste-Rose, J.-Robert Archambault, quincaillier.39, boni.Ste-Rose, et Alexandre Marcotte, rembourreur.199, boni.Ste-Rose, tous trois de Ste-Rose.pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de « Les Cuisines G.Miller Inc.».avec un capital total de $10,000, divisé en 10.000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 101.rue Vanier, Ste-Rose, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de juillet 1903.Ije Sous-xecrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 3227-63 \u2014 1181/139 Dell-Franco Inc.Reid, accountant.40 Woodcraft.Robin John Rugg, secretary treasurer, 36 (Villon, both of Dollanl -des-Ormeaux, and Paul Michael Keeley, senior clerk, 99A Circle Rd., île Bigras.for the following purposes: To promote amateur sport and to arrange matches, tours and competitions of any nature, under the name of \"Cricket & Rugger Times Ltd.\", with a total capital stock of $2.000.divided into 750 common shares of a par value of $1 each, 10 class \"A*' preferred shares of a par value of $50 each and 75 class \"B\" preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will Ik* at St-Chrysostome, judicial district of Beauharnois.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assist(int Secretary of the Province.3992-0 2920-03\u2014 1181/138 Maurice Cuillerier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating Raymond Crevier, advocate, 245 Outremont Avenue, Outremont, Michel A.Gagnon, advocate, 3709 Grey, Montreal, and André Guertin, clerk, 5635 Wellington Avenue, Verdun, for the following purposes: To maintain and operate beauty and hair-dressing parlours, under the name of \"Maurice Cuillerier Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Cartierville, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2970-63\u2014 1179/94 Les Cuisines G.Miller Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Robert Y.Lanthier, advocate, 237 Ste-Rose Blvd., J.-Robert Archambault, hardware dealer, 39 Ste-Rose Blvd., and Alexandre Marcotte, upholsterer, 199 Ste-Rose Blvd., all three of Ste-Rose, for the following purposes: To carry on business as restaurant-owners, under the name of \"Les Cuisines G.Miller Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10.000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at 161 Vanier St.Ste-Rose, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of July, 1963.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3227-63\u2014 1181/139 Dell-Franco Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent. 4310 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 14 septembre 1068, Tome 05, So 37 été accordé, pur l'administrateur du gouvernement «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de juillet 19(>3, constituant en corporation: Bruno l'ut eras, avocat, 11818, Frigon, Montreal.Y van Macerola, avocat.2090, Place Etienne-Brûlé, Montréal, et Carmen Galileo, étudiant.9252, Clark, Montreal, pour les objets suivants: Fain* le commerce d'articles «le céramique, tuile, marbre, bronze, vitre et autres produits fabriqués de toute substance provenant du sol ou du sous-sol, sous le nom de « Dell-Pranco Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégii'-es de $100 chacune.le siège social de la compagnie sera ù Montreal, district judiciaire «le Montreal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 25e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-een issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Bruno Pateras, advocate.11818 Frigon, Montreal.Yvan Macerola, advocate, 2090 Place Étienne-Brùlc.Montreal, ami Carmen (ialileo, student, 9252 Clark.Montreal, for the following purposes To carry on business dealing in articles of ceramic, tile, marble, bronze, glass and other products made of all substances coming from the soil or sub-soil, under the name of \"Dell-Franco Inc.\".with a total capital stock of $40,000.divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July.1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Prwince.3992 3213-63\u20141181/7» I .es Développements Argent eu il Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Geoffroy Birtz.170, rue Highfield.Mont-Royal, Michel Dagenais, 20, Bord du Lac, Dorval, tous deux avocats, et Gabrielle Lahaie, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, 7806, rue Berri, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Les Développements Argenteuil Inc.».avec un capital total de 820.000, divisé en 2.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 0879, boul.St-Laurent, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secretaire de la province, ce 25c jour «le juillet 19(>3.Ia' Sous-secrétaire de la_ province, Raymond Douvillk.3992-0 3114-63\u2014 1181/114 Distribution Fiesta Ltée Fiesta Distribution Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Paul-Henri Côté, industriel.(5655, 28e avenue, Hervé Côté, industriel.3701, Bélanger, est, et Jean Duclos, vendeur, 11897, James Morrice, tous trois de Montréal, pour les objets suivants : Commerce de tous produits, articles et marchandises faits, en tout ou en partie, de cuir, caoutchouc, métal, métalloïde, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, verre et leurs sou s-produit.s; de merceries, produits comestibles, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et périodiques, peintures, travaux d'art, produits chimiques, produits de la terre, de la mer et des forêts, produits de beauté, articles de toilette et parfums, sous le nom de \u2022 Distribution Fiesta Ltée \u2014 Fiesta Distribution Ltd.».avec un capital total de $40,000, divisé en 900 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,100 actions privilégiées de $10 chacune.Les Développements Argenteuil Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 25th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating : Geoffroy Birtz, 170 Highfield St., Mount Royal.Michel Dagenais, 20 Bord du Lac, Dorval, both advocates, and Gabrielle Lahaie, secretary, lilie majeure in use of her rights, 7800 Berri St.Montreal, for the following purposes To carry on a business in the field of real estate and construction under the name of \"Les Développements Argenteuil Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2.000 common shares of $10 each.The head office of the company will be al 0879 St-Laurent Blvd.Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 1983.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3114-63 \u2014 1181/114 Distribution Fiesta Ltée Fiesta Distribution Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Paul-Henri Côté, industrialist.6655, 28th Avenue, Hervé Coté, industrialist, 3701 Bélanger.Fast, and Jean Duclos.salesman, 11897 James Morrice, all three of Montreal, for the following purposes: To deal in all products, articles and merchandise made in whole or in part of leather, rubber, metal, metalloide, wood, paper, nylon, plastic, fur, textile, glass and by-products of same; in haberdashery, edible products, animals, minerals precious stones, soft beverages, books and periodicals, paints, works of art, chemical products, land, sea and forest products, cosmetics, toilet articles and perfumes, under the name of \"Distribution Fiesta Ltée \u2014 Fiesta Distribution Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 900 common shares of $10 each and 3,100 preferred shares of $10 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September I/,, 1963, Vol.9».So.37 4311 Le siège M>e at 6145 Jarry St., Bait, St-Ieonard-de-Port-Mau-rice, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of July.190.3.Raymond Douvillk, Axxixtaut Secretary of the Province.3992 3102-03 1180/80 Le Domaine des Lacs Raymond Ltée Le Domaine de- Laes Raymond Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 10e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Raymond Séguin, administrateur, 3355, Beaubien, est.Montréal, Claude Barrette, gérant de vente, et Madeleine Gagnon Barrette, ménagère, épouse séparée de biens dudit Claude Barrette, ces deux derniers de 11601.1.amoureux.Montréal-Nord, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de Elacements, sous le nom «le « Le Domaine «les acs Raymond Ltée », avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3355.rue Beaubien, est.suite 7.Montreal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 10e jour «le juillet 1903./«* Soux-xecrétaire de lu province, Raymond Douvillk.3992-o 2651-63\u20141180/7 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 10th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Raymond Séguin, executive.3355 Beaubien, East, Montreal, Claude Barrette, sales manager, and Madeleine Gagnon Barrette, houdewifc.wife separate as to property of the said Claude Barrette, the latter two of 11601 Lamoureux.Montreal North, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, un«ler the name of \"Le Domaine des Lacs Raymond Ltée\".with a total capital stock of $20,000.divided into 2.000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 3355 Beaubien St.East.apt.7.Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of July.1903.Raymond Douvillk.Axxixtaut Secretary of the Province.3992 2651-63\u20141180/7 Domaine des Tilleuls Inc.Domaine des Tilleuls lue.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 17e jour «le juin 1963, constituant en corporation: Jules Pépin, industriel, Mme Mance Pépin, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Jules Pépin, et dûment autorisés par lui aux fins des présentes, et Madame Françoise Demers, industrielle, veuve en première noces et non remariée «le Jean Deniers, tous trois de ( ïentilly, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Domaine des Tilleuls Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à (ïentilly.district judiciaire de Nicolet.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 17e jour «le juin 1903.Ia' Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 2032-03\u2014 11X0 00 Do/ois & Montpetit Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Berthe Montpetit Goupil, marchande, veuve d'Albert Goupil, 1014, rue Joliette, Gabriel Dozois, marchand, 0910, 9e avenue, Réjeanne Gauthier, secrétaire, 8052, Raoul, tous trois de Montréal, et Julien Plouffe.avocat, 11605, Lépine, Pierrefonds, pour les objets suivants: Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 17th day of June, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec incorporating: Jules Pépin, industrialist, Mrs.Mance Pépin, housewife, wife separate as to property of sai«l Jules Pépin, and duly authorized by him for the purpose of these presents, an«l Mrs.Françoise Demers.industrialist, unremarried widow of Jean Demers, of-tient illy, for the following purposes: To carry on business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Domaine des Tilleuls Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will Im* at Gentilly, judicial district of Nicolet.Given at the office of the Provincial Secretary, this 17th «lay of June.1903.Raymond Douvillk, Axxixtaut Secretary of the Province.3992 2632-63 \u2014 1180/00 Dozois & Montpetit Ine.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of July, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Berthe Montpetit Goupil, merchant, widow of Albert (ioupil, 1014 Joliette St., Gabriel Dozois, merchant, 6910, 9th Ave., Réjeanne Gauthier, secretary, 8052 Raoul, all three of Montreal, and Julien Plouffe, advocate, 11605 Lépine, Pierre-Fonds, for the following purposes : 4312 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 95.No 37 Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom «le « Do/ois & Montpetit Inc.», avec un capital tt>tal «le $300,000, divise en 150 actions ordinaires de $100 chacune et en 2.850 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 181, rue St-Charles, Longueuil, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, «\u2022e 31e jour «le juillet 1988.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.3992-0 3283-03 \u2014 1181/110 Édifiées Ste-Marie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accortlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Evans St-Celais, architecte, 112, Maison-neuve, Rosaire Dumais, marchand, 484, St-Bernard, Dr Y van Lambert, médecin, 459, St-Dominique, Louis Lemieux, ingénieur, 314, Ste-Marie, Dr Maurice Gagnon, dentiste, Pierre D.Bouchard, comptable, 550, St-Bernard, et Roger Chouinard, avocat, 440, Ste-Ursule, tous sept de Jonquière, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Édifices Ste-Marie Ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.3992-0 2930-03 \u2014 1181/80 Les Éditions Européennes Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Léon Hoffman, libraire, Joséphine Mignot Hoffman, commis, épouse dudit Léon Hoffman, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 460, rue Crépin, et Lina Magar Mignot, commis, épouse d'Alfred Mignot, et dûment autorisée par lui aux 6ns des présentes, tous trois de Québec, pour les objets suivants : Exercer le commerce de libraires, éditeurs, imprimeurs, relieurs, papetiers, lithographes et graveurs, sous le nom de « Les Éditions Européennes Limitée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 55, boulevard Charest, est Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.3992-0 3184-63\u2014 1181/52 Electro Ltée To operate hotels, taverns inns and restaurants, under the name of \"Dozois & Montpetit Inc.\", with a total capital stock of $300.000, divided into 150 common shares of $100 each and 2,850 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 181 St-< diaries St., Longueuil.judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 31st «lay of July, 1903.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3283-63-1181/110 Édifices Ste-Marie Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th ec.incorporating: Evans St-Gelais.architect.112 Maison neuve.Rosaire Dumais, merchant, 484 St-Bernard, Dr.Yvan Lambert, physician, 459 St-Doininique, Louis Lemieux, engineer.314 Ste-Marie, Dr.Maurice Gagnon, dentist, Pierre D.Bouchard, accountant, 550 St-Bernard, and Roger Chouinard, advocate, 440 Ste-LVsule, all seven of Jonquière.for the following purposes: To carry on business in the fields of real estates and construction, under the name of Edifices Ste-Marie Ltée\".with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of July.1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2930-03 \u2014 1181/80 Les Éditions Européennes Limitée Notice is hereby gjven that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Léon Hoffman, librairian, Joséphine Mignot Hoffman, clerk, wife of the said Léon Hoffman, and duly authorized by him for these presents, both of 460 Crépin St., and Lina Magar Mignot, clerk, wife of Alfred Mignot, and duly authorized by him for these purposes, all three of Quebec, for4he following purposes: To carry on business as librarians, editors, printers, binders, stationers, lithographers, and engravers, under the name of \"Les Editions Européennes Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 55 Charest Blvd., East.Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3184-63.-1181/52 Electro Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September //,.1963, VeL 95, No.37 4313 été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres pu ten t.es, en date du 22e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Gilbert A mint, homme d'affaires, Mme Thérèse Canucl Amiot, ménagère, épouse contractuellement séj>arée de biens dudit Gilbert Amiot, et dûment autorisée par lui aux 6ns des présentes, tous deux cie 445, St-Germain, est, Paul-E.DesRosiers, homme d'affaires, Mme Monique l.evcsque DesRosiers, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Paul-K.DesRosiers.et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 109, 13e rue, tous quatre de Rimouski, et Rodrigue bavoie, électricien, 433, rue Roy, Notre-Dame-du-Sacré-Couer, pour les objets suivants: Kxerccr le commerce d'électriciens, sous le nom de « Electro Ltée », avec un capital total de $90,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 600 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 40, rue de la Cathédrale, Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour de juillet 1963.Le Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 3168-63 \u2014 1181/87 bearing date the 22nd day of July, 1963, have lieen issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Gilbert Amiot,businessman, Mrs.Thérèse Canuel Amiot, housewife, wife contractually separate as to property of the said Gilbert Amiot, and duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 445 St-Gemmm East.Paul-K.DesRosiers, businessman, Mrs.Monique Leves-que DesRosiers, housewife, wife contractually separate as to property of the said Paul-K.DesRosiers, and duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 109.13th Street, all four of Rimouski, and Rodrigue I a-voie, electrician, 433 Roy St., Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, for the following purposes: To carry on business as electricians, under the name of \"Electro Ltée\", with a total capital stock of $90,000, divided into 300 common shares of $100 each and 000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 40 Cathedral St.Rimouski, judicial district of Rimouski.(¦iven at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of July, 1963.Raymond Douville, Axxixtaut Secretary of the Province.3992 3168-63\u2014 1181/87 Charles Elliott Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1903.constituant en corporation: Charles Elliott, entrepreneur, 10235, boul.St-Vital, Réjean Lafrance, agent d'immeubles, 3377, rue Monselet, tous deux de Montréal-Nord, et Jean A.Hébert, comptable agréé, 2345, rue Bélanger, est, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Charles Elliott Construction Inc.» avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 10235.boul.St-Vital, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de juillet 1903.L§ Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 3067-63\u20141181/140 Les Employeurs Forestiers de la Rouge, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du lie jour de juillet 1963, constituant en corporation sans capital-actions: François Lajoie, avocat et conseil en loi de la Reine, Isabelle Vigneau et Lucette Vigneau, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Trois-Rivières, pour les objets suivants: (trouper en association les employeurs forestiers engagés dans l'exécution d'opérations forestières dans les concessions forestières et dans les forêts privées de Canadian International Paper Company, situées dans les bassins des rivières respectives Rouge.La Lièvre, Mat- Charles Elliott Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 30th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Charles Elliott, contractor, 10235 St-Vital Blvd., Réjean Lafrance, real estate agent, 3377 Monselet St., both of Montreal-North, and Jean A.Hébert, chartered accountant, 2345 Bélanger St.East.Montreal, for the following purposes : To carry on business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Charles Elliott Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 10235 St-Vital Blvd., Montreal-North, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of July.1903.Raymond Douville.Axxixtant Secretary of the Province.3992 .3007-03 \u2014 1181 /140 Les Employeurs Forestiers de la Rouge, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of July, 1963, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: François Lajoie.advocate and Queen's Counsel.Isabelle Vigneau and Lucette Vigneau, the two latter secretaries, spinsters of the full age of majority, all three of Trois-Rivières.for the following purposes : To group together into an association the forestry employers engaged in the carrying out of forestry operations in the forestry concessions and in private forests of the Canadian International Paper Company, situated in the basins of the respective Rouge, La Lièvre, Mattawin, 4314 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1968, Tome 96, No 87 ta win, Du Nord, Ouareau, K'inonge et Petite Nation, sous le nom de « Les Employeurs Forestiers de lu Rouge.Inc.» Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $25.000.Le siège social de la corporation sera à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce I le jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3013-03\u2014 1182/4 Les Entreprises Itrouillette Inc.Brouilletle Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 14e jour de juin 1903, constituant en corporation: Georges-Henri Brouillette, bijoutier, 523, rue Principale, Jeanne-d'Arc Couture Brouillette.ménagère, épouse séparée de biens dudit Georges-Henri Brouillette, 35, rue (iouin, et Georges Savoie, avocat, 433, rue Principale, tous trois de Richmond, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de portefeuille (holding), le commerce de bijoutiers, le commerce de quincailliers et le commerce «le nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « Les Entreprises Brouillette Inc.\u2014 Brouillette Enterprises Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Richmond, district judiciaire de St-François.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 14e jour de juin 1903.l^e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 2432-03 \u2014 1177/10 Les Entreprises Cavelier Inc.Cavelier Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Marcel Gauthier, contremaître, 173, avenue Lasalle, Bourlamaque, Ovide Jette, entrepreneur, 483, avenue Larivière, Rouyn, et Benoît St-Laurent, gérant, 117, Chadbourne, Noranda, pour les objets suivants : Industrie et commerce du bois, sous le nom de « Les Entreprises Cavelier Inc.\u2014 Cavelier Enterprises Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mata-gami, district judiciaire d'Abitibi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 2990-63 \u2014 1182/89 Les Entreprises J.P.F.Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 4e jour de juillet 1963, Du Nord, Oiiareau, Kinonge and Petite Nation Rivers, under the name of \"Les Employeurs Forestiers de la Rouge.Inc.\" The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire ami hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretary, this 11th day of July.1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3013-03 \u2014 1182/4 f l.«'s Entreprises Brouillette Inc.Brouillette Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of June, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: (ieorges-Henri Brouillette.jeweller, 523 Main St., Jeanne-d'Arc Couture Brouillette, housewife, wife separate as to property of the said (ieorges-Henri Brouillette, 35 (iouin St., and Georges Savoie, advocate, 433 Main St., all three of Richmond, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, of jewellers, of hardware merchants and of novelties of all kinds, under the name of \"Les Entreprises Brouillette Inc.\u2014 Brouillette Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head of the company will be at Richmond, judicial district of St.Francis.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of June, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2432-63 \u2014 1177/10 Les Entreprises Cavelier Inc.Cavelier Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Gauthier, foreman, 173 Lasalle Avenue, Bourlamaque, Ovide Jette, contractor, 483, Larivière Ave., Rouyn, and Benott St-Laurent, manager, 117 Chadbourne, Noranda, for the following purposes: Trade and business of wood, under the name of \"Les Entreprises Cavelier Inc.\u2014 Cavelier Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Matagami, judicial district of Abitibi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of July, 1963.Raymond Douville, Assistuiit Secretary of the Province.3992 2990-03 \u2014 1182/89 Les Entreprises J.P.F.Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September IL, 1963, Vol.96, No.37 4315 constituant en corporation : Henri Choinière, 54, St-Jacques, Claude Lauzon, 54, St-Jacques, tous deux avocats, et Jeannine Rém il lard, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, 212, St-(,ennain, tous trois de St-Jean.pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de transport, sous le nom de « Les Entreprises J.P.F.Ltée », avec un capital total de $40,000.divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.I^e siège social de la compagnie sera à St-Jean.district judiciaire d'II>erville.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4e jour de juillet 1063.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.:ec Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of July, 1963, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Rhéal Gagné, 1545 Sauriol St., Marcel Gagné, 7344 Boyer, both accountants, and Ghislaine Gignac, secretary, 6760, 25th Ave., all three of Montreal, for the following purposes: To deal in fruits, vegetables and all kinds of manufactured food products, as well as in all products of the land, the vineyard and the trees, under the name of \"Fruiterie Ahuntsic Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common snares of $100 each.The head office of the company will be at 57 St.James St.West, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 19th day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2892-63 \u2014 1182/7 Galerie Martin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 3rd day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Frank George, controller, 11800 Guertin, René Boutet, executive, 12225 Guertin, and Robert Senecal, accountant, 10597 Chambord, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of objects of art and more particularly pertaining to paintings and sculpture, under the name of \"Galerie Martin Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 3rd day of July, 1963.' Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2618-63 \u2014 1181/4 Guy Gagné Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a 4320 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 96, No 37 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, de» lettres patentes, en date du 1er août 1903, constituant en corporation: Pierre Cou tu.avocat, 4K90, rue Lacombe, Montréal, Claude (îrignon, avocat, 252, Dubeau, St-Laurent, et Françoise Savard, secrétaire, fille majeure, 4219.houl.Décarie, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtiers en assurance, sous le nom de « Guy Gagné Inc.», avec un capital total de $10,000.divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Laval-dès-Rapides, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour d'août 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3250-03 \u2014 1182/93 bearing date the 1st day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Cou tu, advocate, 4890 Lacombe St., Montreal, Claude (îrignon, advocate, 252 Dubeau, St-Laurent, and Françoise Savard, secretary, fille majeure, 4219 Décarie Blvd., Montreal, for the following purposes : To carry on a business dealing as insurance brokers, under the name of \"Guy Gagné Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head oil ice of the company will be at Laval-des-Rapides, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of August, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3250-63 \u2014 1182/93 Garage F.Paul Gagnon Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour de juillet 1903.constituant en corporation: F.-Paul Gagnon, garagiste, Mme Fernande Sigouin Gagnon.ménagère, épouse dudit F.-Paul Gagnon.tous deux de 88, Ile de Mai, Ste-Thérèse-Ouest, et Dollard Dame, garagiste, 2258.(îirouard, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles, leurs accessoires et parties, et faire affaires comme garagistes, sous le nom «le « Garage F.Paul Gagnon Inc.».avec un capital total de $10,000, divise en 100 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5390, rue Sherbrooke, ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de juillet 1903.l.e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3137-63\u2014 1181/0 Garage F.Paul Gagnon Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 19th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: F.-Paul Gagnon, garage keeper, Mrs.Fernande Sigouin Gagnon.housewife, wife of the said F.-Paul Gagnon, both of 88 Ile de Mai, Ste-Thérèse-West, and Dollard Dame, garage keeper.2258 Girouard, Montreal, for the following purposes: To deal in motor vehicles, parts and accessories thereof, and to do business as garage keepers, under the name of \"Garage F.Paul Gagnon Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 5390 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 19th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3137-63\u20141181/6 Geco (Quebec) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Errol Klock McDougall, Walter Austin Johnson, William Tinling Stewart, tous trois conseils en loi de la Reine, Paul Frederick Dingle et Herbert Birkett McNally, tous cinq avocats, de 507, Place d'Armes, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de dessin, construction et surveillance de travaux électriques, mécaniques, structuraux, résidentiels, industriels et commerciaux et d'édifices, et entreprendre l'estimation, l'ajustement et l'évaluation, l'étude et l'inspection des bâtisses, sous le nom de « Geco (Quebec) Limited », avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31 e jour de juillet 1963.Le Sous-secretaire de la province, Raymond Douville.3992 3139-63\u20141182/9 Geco (Quebec) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Errol Klock McDougall, Walter Austin Johnson, William Tinling Stewart, all three Queen's Counsels, Paul Frederick Dingle and Herbert Birkett McNally, all five advocates, of 507 Place d'Armes, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of designing, constructing and supervising electrical, mechanical, structural, residential, industrial and commercial works and buildings, and to carry on and engage in appraisals, adjustments and valuations, building surveys and inspections, under the name of \"Geco (Quebec) Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-0 3139-63\u20141182/9 Ql EBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14.1963, Vol.96, No.37 4321 C.E.Coyer & Flls Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 10e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Michel A.Gagnon, avocat, 3709, avenue Grey, Montréal, Pierre Legrand, avocat, 415, Place d'Amiens, Duver-na.v, et André Guertin, commis.5035, avenue Wellington, Verdun, pour les objets suivants: Poursuivre les activités et les affaires d'une compagnie transigeant en valeurs, droits et biens immobiliers de toutes sortes, pour son compte et comme courtiers ou à quelque autre titre que ce soit, sous le nom «le « C.E.Goyer & Fils Inc.», avec un capital total de $400,000, divisé en 5,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $10 chacune et en 35,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Bruno, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 2973-03 \u2014 1179/98 C E.Goyer & Fila Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 10th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quel>ec, incorporating: Michel A.Gagnon, advocate.3769 Grey Avenue, Montreal, Pierre Ix>graud, advocate, 415 d'Amiens Place, Duvernay, ami Amlré (inertin, clerk, 5635 Wellington Ave.Verdun, for the following purposes : To carry on the operations and business of a company transacting with stocks, rights and real estate of all kinds, for its own profit or as brokers or any other purpose whatsoever, under the name of \"C.E.Goyer & Fils Inc.\", with a total capital stock of $400.000, divided into 5,000 common shares of a par value of $10 each and 35,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at St-Bruno, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of July, 1963.Raymond Dor ville.Assistant Secretary of the Province.3992 2973-63\u2014 1179/98 Gravel Location d'Automobiles Ltée Gravel Car Leasing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 5e jour d'août 1963, constituant en corporation: Arthur Derek Guthrie, 3066, ave Lacombe, Michel A.Gagnon, 3769, ave Grey, tous deux avocats, de Montréal, et Ernest William Mock-ridge, gérant, 324, ave Mercille, St-Lambert, pour les objets suivants: Faire le commerce de locations de véhicules automobiles, sous le nom de « Gravel Location d'Automobiles Ltée\u2014 Gravel Car Leasing Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 450 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Lambert, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 5e jour d'août 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-c 3260-63 \u2014 1182/119 Gravel Location d'Automobiles Ltée Gravel Car Leasing Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Arthur Derek Guthrie, 3066 Lacombe Ave., Michel A.Gagnon.3769 Grey Ave:, both advocates, of Montreal, and Ernest William Mockridge, manager, 324 Mercille Ave., St-Lambert, for the following purposes: To carry on a business leasing motor vehicles, under the name of \"Gravel Location d'Automobiles Ltée \u2014 Gravel Car Leasing Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 50 common shares of a par value of $100 each and into 450 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at St-Lambert, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of August, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3260-63- 1182/119 Grégoire Auto Parts Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour d'août 1963, constituant en corporation: Armand Maltais, avocat, 2219, Monsei-gneur-Gosselin, Marguerite Tremblay, 1335, François 1er, et Micheline For gués, 1111, 1ère avenue, ces deux dernières secrétaires, tous trois de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles et faire affaires comme garagistes, sous le nom de « Grégoire Auto Parts Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1345, rue William, Sillery, district judiciaire de Québec.Grégoire Auto Parts Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Armand Maltais, advocate, 2219, Monseigneur-Gosselin, Marguerite Tremblay, 1335 François 1er, and Micheline Forgues, 1111, 1st Ave., the two latter secretaries, all three of Quebec, for the following purposes : To carry on business dealing in automobiles and to act as garagemen, under the name of \"Grégoire Auto Parts Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10'each.The head office of the company will be at 1345 William St., Sillery, judicial district of Quebec. 4322 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1968, Tome 95, So 87 Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour d'août 1903.I.i Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3105-03-1182/12 Marcel Guertin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 10e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Marcel Guertin, Henriette St-Germain, ménagère, éjMHise séparée de biens dudit Marcel ( inert in, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 1027, route Marie-Victorin, Tracy, et Paul-A.Bélanger, avocat.70.rue du Roi.Sorel, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits alimentaires, épicerie, viandes, volailles, vivres d'éleveurs de toutes sortes, sous le nom de « Marcel (îuertin Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1111, route Marie-Victorin, Tracy, district judiciaire de Richelieu.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 10e jour «le juillet 1903.1* Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 2841-63 \u2014 1179/128 Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of August, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3105-03 - 1182/12 Marcel Guertin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Guertin, merchant, Henriette St-Germain, housewife, wife separate as to property of the said Marcel Guertin, and duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 1027 Marie-Victorin Road, Tracy, and Paul-A.Bélanger, advocate, 70 du Roi St., Sorel, for the following purposes: To deal in food products, groceries, meats, fowl, breeder's food of all kinds, under the name of \"Marcel Guertin Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1.000 common snares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1111 Marie-Victorin Road, Tracy, judicial district of Richelieu.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2841-63 \u2014 1179/128 Berthold Hamelin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 15e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Jacques Richard, avocat, 12272, Beauséjour, Claudette Lacroix, secrétaire, fille majeure, 5229, 6e avenue, tous deux de Montréal, et Jean-Charles Tétreault, ingénieur professionnel, 3106, Marcel St-Laurent, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Berthold Hamelin Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 000 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour de juillet 1963.I.r Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3047-63\u20141181/118 Hôtel Interprovincial Ltée Interprovincial Hotel Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour «le juillet 1963, constituant en corporation: Roger Boucher, technicien, Kingsmere, comté de Gatineau, Pierre Lamont, gérant, 128, rue St-Raymond, J.-Aimé Desjardins, ingénieur, 192, rue Amherst, Fernand Dion, agent d'immeuble, 34, rue St-François, tous trois de Hull, Marc Cayer, entrepreneur, et Charles Munn, notaire, chemin D'Amour, ces deux derniers de Hull-Sud, pour les objets suivants: Berthold Hamelin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Richard, advocate, 12272 Beauséjour, Claudette Lacroix, secretary, fille majeure, 5229 6th Ave., both of Montreal, and Jean-Charles Tétreault, professional engineer, 3100 Marcel, St-Laurent, for the following purposes: To carry on a business as builders and building contractors, under the name of \"Berthold Hamelin Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares of $10 each and into 600 preferred shares of $50 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of July, 1963.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3047-63 - 1181/118 Hôtel Interprovincial Ltée Interprovincial Hotel Ltd.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roger Boucher, technician, Kingsmere, county of Gatineau, Pierre Lamont, manager.128 St-Raymond St., J.-Aimé Desjardins, engineer, 192 Amherst St., Fernand Dion, real estate agent, 34 St.François St., all three of Hull, Marc Cayer, contractor, and Charles Munn, notary, D'Amour Bd., (he latter two of Hull-South, for the following purposes: 4323 Exploiter (les hotels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Hôtel Interprovincial Ltée \u2014 Interprovincial Hotel Ltd.», avec un capital total de $45,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 7, rue Maillot.Hull, district judiciaire de Hull.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-q 2847-03 \u2014 1181/119 To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Hôtel Interprovincial Ltée \u2014 Interprovincial Hotel Ltd.\", with a total capital stock of $45,000, divided into 150 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the companv will be at 7 Maillot St.Hull, judicial district of Hull.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2847-63 \u2014 1181/119 The House of Bombay Impex Inc.The House of Bombay Impex Inc.La Maison de Bombay Impex Inc.Lu Maison de Bombay Impex Inc.Avis est donné qu'en vertu cie la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour d'août 1903, constituant en corporation: Joseph Beauchemin, vendeur, 5317, Ban-nantyne, Verdun, Sylviane Thérien Beauchemin, ménagère, épouse contractuellement sé|>arée de biens dudit Joseph Beauchemin, 249, De Cour-celles, Montréal, et Gaston Beauchemin, restaurateur, 5879, Jeanne-Mance, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce des vins domestiques et importés et de liqueurs alcooliques de toutes sortes, sous le nom de « The House of Bombay Impex Inc.\u2014 La Maison de Bombay Impex Inc.», avec un capital total de $130,000, divisé en 18,000 actions ordinaires de $5 chacune et en \u2022*,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour d'août 1903.Ijt Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 2801-03\u2014 1182/90 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of August, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Joseph Beauchemin, salesman, 5317 Bannantyne, Verdun.Sylviane Thérien Beauchemin, housewife, wife contractually separate as to property of the said Joseph Beauchemin, 249 De Courcelles, Montreal, and Gaston Beauchemin, restaurateur, 5879 Jeanne-Mance, Montreal, for the following purposes : To carry on a business dealing in domestic and imported wines and alcoholic liquor of all kinds, under the name of \"The House of Bombay Impex Inc.\u2014 La Maison de Bombay Impex Inc.\", with a total capital stock of $130,000, divided into 18,000 common shares of $5 each and into 8.000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Mount-Royal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of August, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2801-63\u2014 1182/90 Howell Insurance Agency Co.Ltd.Howell Insurance Agency Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Claire Laurin, 6785, rue Hadley, Adrienne Lafrenière, 7647, St-André, toutes deux sténographes, de Montréal, et Yvonne Bourbonnais, dactylo, 1465 ouest, rue Bernard, Outremont, toutes trois célibataires, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtiers en assurance, sous le nom de « Howell Insurance Agency Co.Ltd.», avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3901 ouest, rue Jean-Talon, Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymodn Douvillk.3992 3005-63 \u2014 1182/13 Les Immeubles Bérubé Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres paten- Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Claire Laurin, 6785 Hadley St., Adrienne Lafrenière, 7647 St-André, both stenographers, of Montreal, and Yvonne Bourbonnais, typist, 1465 Bernard St.West, Outremont, all three spinsters, for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers, under the name of \"Howell Insurance Agency Co.Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 3901 Jean-Talon Street West, Mount Royal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992-o 3005-03 \u2014 1182/13 Les Immeubles Bérubé Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Govern- 4324 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, //, septembre 1963, Tome 95, So 37 tes, en date du 15e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Rodolphe Morin, comptable, Raymond Bilodeau, gérant, et Lorenzo Marceau, journalier, tous trois de Québec, pour les objets suivants: Paire affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Les Immeubles Bérubé Inc.», avec un capital total de $150,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $50 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.3992-o 3053-03- 1180/123 Les Immeubles de Luçon Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 10e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Y von Perras, 5335, Place d'Argenteuil, Cartierville, Gilles Cossette, 702, rue Davaar, Outremont, tous deux avocats, et Oswald Fontaine, entrepreneur, 4007, de Carignan, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Les Immeubles de Luçon Ltée », avec un capital total de $50,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 8,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 10e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.3992-o 2995-63 \u2014 1179/129 ment of the Province of Quebec, incorporating: Rodolphe Morin, accountant, Raymond Bilodeau, manager, and Lorenzo Marceau, laborer, all three of Quebec, for the following purposes: To carry on business in the fields of real estates and construction, under the name of \"Les Immeubles Bérubé Inc.\", with a total capital stock of $150,000, divided into 1,000 common shares of $50 each and 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretarv, this 15th day of July, 1963.Raymon d Dou ville, Assistant Secretary of the Province.3992 3053-63 -1180/123 Les Immeubles de Luçon Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Y von Perras, 5335 d'Argenteuil Place, Cartierville, (idles Cassette, 702 Davaar St., Outre-mont, both advocates, and Oswald Fontaine, contractor, 4007 de Carignan.Montreal, for the following purposes: To carry on business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Les Immeubles de Luçon Ltée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 8,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2995-63 \u2014 1179/129 Les Immeubles Piuze f Quebec, incorporating: André Gauthier, adoveate.1990 «les Ormes.St-Bruno.Jacques Lamarche, law student.5500 Bellingham.Montreal, ami Claire \\ 'ail Ian -court, secretary.24 Brisc-du-Lac.Valois, for the following purposes: To carry on a business dealing as plumbing, heating und refrigerating contractors, under the name «>f \"Georges Longpré Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shar«'.s of $10 each ami into 1.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 19(53.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3149-63 \u2014 1181/91 Magnetic Window Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of July.1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Joseph-Armand Tremblay, industrialist, 10498 Tanguay.Montreal, Raymond Tremblay, salesman, 3404 Hutchison, Montreal, and Raoul Chainey.contractor, 22 René-Philippe, LeMoyne, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of doors, windows and other openings, under the name of \"Magnetic Window Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 5.000 common shares of $1 each and 1,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of July, 1963.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3229-63 \u2014 1182/19 La Maison du Palmarès Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Vic Bergeron, marchand, Thérèse Audet Bergeron, ménagère, épouse dudit Vie Bergeron, et Guy Cloutier, marchand, tous trois d'Alma, pour les objets suivants : Faire le commerce du disque en général, sous le nom de « La Maison du Palmarès Inc.», avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Aima, district judiciaire de Roberval.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-c 3052-63 \u2014 1181/60 Les Majorettes Rouge et Or d'Alma Inc.La Maison du Palmarès Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, lettres patent, bearing date the 29th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Vic Bergeron, merchant, Thérèse Audet Bergeron, housewife, wife of the said Vic Bergeron, and Guy Cloutier, merchant, all three of Alma, for the following purposes: To carry on business dealing in records in general, under the name of \"La Maison du Palmares Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of $10 each.The head of the company will be at Alma, judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3052-63 \u2014 1181/60 Les Majorettes Rouge et Or d'Alma Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent. 4334 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 95, So 37 été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Quebec, des lettres patentes, en date du 17e jour de juillet 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Jacques Lamy, négociant, 581, St-Joseph, Laval Maltais, commis, 222, boul.Cimon, et Adrien Martin, employé d'hotel, 59, Francoeiir, tous trois d'Alma, pour les objets suivants: Établir, former et diriger un corps de majorettes pour promouvoir la détente «le l'esprit et du corps «le ses membres, sous le nom de « Les Majorettes Rouge et Or d'Alma Inc.».I^e montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséiler, est «le $5,000.Le siège social «le la corporation sera à Aima, district judiciaire «le Roberval.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 17e jour «le juillet 19(53.Le Sous-secrétaire de la prorince, R a ymon u DoU ville.3992-o 3090-03\u2014 1182/20 bearing date the 17th day of July, 19(53, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Jacques Lamy, trader, 581 St-Joseph, Laval Maltais, clerk, 222 Cimon Blvd., and Adrien Martin, hotel employee, 59 Francoeur, all three of Alma, for the following purposes: To establish, form and direct a majorette corps t«> promote the relaxation of the mind and body «>f its members, under the name of \"Les Majorettes Rouge et Or d'Alma Inc.\" The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire hold is to be limited, is $5,000.The head office of the corjioration will be at Alma, judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 17th day of July, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3090-03- 1182/20 Marlboro Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Harry Blank.4625, avenue Miller, Irving Adcssky, 5789, avenue Melling, tous deux avocats, et Rhoda Cohen, secrétaire, fille majeure, 6427, avenue Mac-Donald, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et «le construction, sous le nom de « Malboro Construction Ltd.», avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 450 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 25e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992 3214-03\u2014 1181/92 Marlboro Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Harry Blank, 4625 Miller Avenue, Irving Adessky, 5789 Melling Avenue, both advocates, and Rhoda Cohen, secretary, spinster of the full age of majority, 6427 MacDonald Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To do business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Malboro Construction Ltd.\".with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of $10 each and 450 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992-o 3214-63\u2014 1181/92 Maxwell Lumber Supplies Co.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur «lu gouvernement de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 18e jour «le juillet 1963, constituant en corporation: Robert Thibodeau, commerçant, 4(581.«le la Roche.Montréal, Luc S.Levac, commerçant, 1090, boul.Tachereau, LeMoyne, et Léger St-Pierre, entrepreneur général, 2344.rue Coursol, Montréal, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de « Maxwell Lumber Supplies Co.».avec un capital total de $40,000, divisé en 2,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1090, boul.Tachereau, LeMoyne, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 18e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 3121-63\u2014 1180/125 Maxwell Lumber Supplies Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 18th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Robert Thibodeau.merchant, 4681 «le la Roche, Montreal.Luc S.Levac, merchant, 1090 Tachereau Blvd., LeMoyne, and Léger St-Pierre, general contractor, 2344 Coursol St.Montreal, for the following purposes: To deal in the wood industry am! commerce, untler the name of \"Maxwel Lumber Supplies Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,500 common shares of $10 each and 150 preferre«l shares of $100 each.The head office of the company will be at 1090 Tachereau Blvd., judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of July.1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3121-63 \u2014 1180/126 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14.IMS.Foi M, S'a.S7 4335 Media Advertising Ltd.Media Advertising Ltd.Agenee Media de Publicité Lté» Agence Media de Publicité Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 25e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Lorraine Turcot t«», avocate, 105, rue Drummond, Denise Ménard, 9, rue Paré, et Pierrette Desjardins, 157-D, rue Paré, cvs deux «lernières secrétaires, toutes trois filles majeures, «le Granby, pour les objets suivants: Exercer les activités d'entrepreneurs «le publicité et «le conseillers en publicité, s«>us le nom «le « Media Ailvertising Ltd.\u2014 Agence Media de Publicité Ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1460, rue Union, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 3218-63\u2014 1181/93 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the 25th f advertising contractors and counsellors, under the name of \"Media Advertising Ltd.\u2014 Agence Media de Publicité Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 1400 Union St., Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3218-G3\u20141181/93 Metro Electronic Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Henri Laurin, industriel, 9984, 30e avenue, Rivière-des-Prairies, Paul Mombleau, technicien, et Jeanne Laurin Momhleau, ménagère, épouse dudit Paul Mombleau, ces deux derniers de 3780, boulevard Monselet, Montréal-Nord, pour les objets suivants : Faire le commerce de tout appareil électroni-«|ue, sous le nom de « Metro Electronic Inc.», avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacume.Le siège social de la compagnie sera 3780, boulevard Monselet, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de juillet 1903.Lé Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 3012-63 \u2014 1181/123 Metro Electronic Inc.Notice is hereby given that un«ler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Henri Laurin, industrialist, 9984, 30th Ave., Rivière-«les-Prairies, Paul Mombleau, technician, and Jeanne Laurin Momhleau, housewife, wife of the said Paul Momhleau, the last two of 3780 Monselet, Montreal North, for the following purposes: To carry on a business dealing in any electronic apparatus, under the name of \"Metro Electronic Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 250 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 3780 Monselet Blvd., Montreal North, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of July, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3012-63 \u2014 1181/123 Metropolitan Auto Parts, Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Pierre Lcgrand, avocat, 415, Place d'Amiens, Duvernay, Michel A.Gagnon, avocat, 3769, avenue Grey, Montréal, et André Guertin, commis, 5635, avenue Wellington, Verdun, pour les objets suivants: Faire le commerce d'accessoires et pièces de véhicules et voitures de toutes sortes, de machines, instruments, outils, appareils, accessoires et produits liés à la fabrication, l'entretien et le fonctionnement de voitures et véhicules de toutes sortes, sous le nom de « Metropolitan Auto Parts, Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Metropolitan Auto Parts, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 30th day of July, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Le-grand, advocate, 415 Place «l'Amiens, Duvernay, Michel A.Gagnon, advocate, 3709 Grey Ave., Montreal, ami André Guertin, clerk, 5635 Wellington Ave., Verdun, for the following purposes: To carry on business dealing in accessories and parts for vehicles of all kinds, for machines, instruments, tools, apparatus, acessories and products linked to the production, maintenance and functioning of all types of vehicles, under the name of \"Metropolitan Auto Parts, Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $10 each. 4336 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.14 septembre 1.968, Tome 96, No 87 Le siège social «le la compagnie sera ù St-Micliel, district judiciaire de Mont mil.Donné au bureau du secrétaire «le la pr«>vince.ce 30e jour «le juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3073-03 \u2014 1181/94 The head ofiice of the company will be at St-Michel, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3073-03- 1181/94 Metropolitan Food Services Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur «lu gouvernement «le la province «le Québec, des lettres patentes, en «late «lu 20e jour «le juillet 1903 constituant en corporation: Harry Blank.4025, avenue Miller.Irving Adessky, 5789, avenue Melling.Daniel Kingstone, 4985, avenue Iona.tous trois avocats.Rhoda Cohen, 0427, avenue MacDonaM, et Shirlee Simon, 1780, rue St-Louis, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous cinq «le Montréal.|k>ur les objets suivants: Exercer le commerce «le restaurateurs, sous le nom de « Metropolitan Foo«l Services Inc.».avec un capital total «le $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et 900 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la provint*, ce 20e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992 3241-03\u2014 1181/01 Metropolitan Food Services Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the 20th «lay of July, 1963, have been issued by the A«iministrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Harry Blank, 4(525 Miller Avenue, Irving Adessky, 5789 Moiling Avenue, Daniel Kingstone, 4985 Iona Avenu-, all three advocates, Rhoda Cohen, 6427 MacDonald Avenue, and Shirlee Simon, 1780 St-Lou is Street, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, all five of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Metropolitan Food Services Inc.\", with a total capital stock of $10,000.divided into 100 common shares of $10 each and 900 preferre«l shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 20th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-0 3241-63\u20141181/01 Meunerie Sylvio Brochu Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu 31e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Sylvio Brochu, St-Isidore, André Brochu et Donald Brochu, ces deux derniers de St-St-Henri, tous trois commerçants, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meuniers et faire le commerce «le grains et céréales, des produits de la terre et leurs sous-produits, sous le nom de « Meunerie Sylvio Brochu Ltée », avec un capital total de $00,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Isidore, district judiciaire de Beauce.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3018-03 \u2014 1182/102 Meunerie Sylvio Brochu Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 31st day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Sylvio Brochu, St-Isidore, André Brochu et Donald Brochu, the latter two of St.Henri, all three merchants, for the following purposes: To carry on business as millers and dealing in cereals and grains farm products and their by-products, under the name of \"Meunerie Sylvio Brochu Ltée\", with a total capital stock of $60,000, divided into 400 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The office of the company will be at St-Isidore, judicial district of Beauce.Given at the office of the Provincial Secretarv.this 31st day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3018-63 \u2014 1182/102 Mobilier Moderne (1963) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Roger Beaulieu, avocat et conseil en loi de la Reine, 4125, Blue-ridge Crescent, Renée Mignault, secrétaire, 2185, Sauriol, et Germaine Lamothe, récep-tioniste, 2145, Fleury, ces deux dernières filles majeures, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Mobilier Moderne (1963) Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government, of the Province of Quebec, incorporating: Roger Beaulieu, advocate, and Queen's Counsel, 4125 Bleuridge Crescent, Renée Mignault, secretary, 2185 Sauriol, and Germaine Lamothe, receptionist, 2145 Fleury, the latter two filles majeures, all three of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, IMS, Vol.05, So.37 4337 Commerce d'effets mobiliers de toutes sortes, et particulièrement des meubles de ménage ou de bureau, sous le nom de « Mobilier Moderne (1063) Ltée », avec un capital total de S10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.I.e siège social de la compagnie sera at St-Michel, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secretaire de la province, «\u2022e 23e jour de juillet 1903.£# Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3993-0 3182-03- 1181/62 To carry on business by dealing in furniture of all kinds and especially household or office furniture under the name of \"Mobilier Moderne (1963) Ltée\".with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will l>e at St-Michel, judicial district of Montreal.(liven at the office of the Provincial Secretarv, this 23rd day of July.1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3182-03 \u20141181/62 Mon tor Landscape «X Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20e jour «le juillet 1903.constituant en corporation: Nick Rizzuto, contremaître, 7820, De Lorimier, Vincenzo Cam-marclli, entrepreneur, 7818, De Lorimier, et Charles Campo, vendeur, 1901, Jacqucs-Hertel.tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de la pierre, de la chaux, du ciment, du sable, des minerais, minéraux et matériaux de construction «le toutes sortes, sous le nom de « M on tor Landscape & Construction Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 7820, rue De Lorimier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 20e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3232-63- 1181/63 Motel Évangéline Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Bernard Corriveau.notaire, 592, Monseigneur-Taché, Ste-Foy, Monique Royer, 735, rue d'Aiguillon, Québec, et Micheline Côté, 57, des Vosges, Ste-Foy, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, motels, auberges et restaurants, sous le nom de « Motel Evangéline Inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Si-méon, comté de Charlevoix, district judiciaire de Saguenay.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3129-63\u20141181/11 O'Brien Motors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Robert Learmont Jamieson, 15, West-wood Drive, Pointe-Claire, John Maria Cerini, Montor Landscupe & Construction Inc.Notice is hereby given that under Fart I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Nick Riz/uto.foreman.7820 De Lorimier, Vincenzo l'a m ma rell i.contractor, 7818 De lorimier, and Charles Campo, salesman, 19(51 -lacqties-Hertcl, all three of Montreal, for the following purposes: To curry on business dealing in stone, lime, cement, sand, ores, minerals and construction materials of all kinds, under the name of \"Montor Landscape & Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will he at 7820 De Lorimier St., Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv', this 26th day of July, 1963.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3232-63 -1181/63 Motel Evangeline Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Queliee Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of July, 1963, have been issued by the A«lministrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Bernard Corriveau, notary, 592 Monseigneur-Taché, Ste-Foy, Monique Royer, 735 d'Aiguillon St., Quebec, and Micheline Côté, 57 des Vosges, Ste-Foy, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes: To operate hotels, motels, inns and restaurants, under the name of \"Motel Evangeline Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at St-Siméon, county of Charlevoix, judicial district of Saguenay.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3129-63 \u2014 1181/11 O'Brien Motors Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31 st day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Robert Learmont Jamieson, 15 Westwood Drive, Pointe-Claire, John Maria Cerini, 4628 Kensington 4338 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1908, Tome 05, So 37 4628, avenue Kensington, Montréal, tous deux avocats et Conseils en Lof de la Reine, et Barrie Hincliclitfc Brown, avocat, 4335, Broadway, Lad line, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles de toutes sortes, de leurs pièces et accessoires et exercer le commerce de garagistes, sous le nom de « O'Brien Motors Ltd.», avec un capital total «le $10,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 302, avenue Inglewood, Pointe-Claire district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992 3116-63 \u2014 1182/22 Avenue, Montreal, both advocates and Queen's Counsels, and Barrie Iliuchclilfe Brown, advocate, 4335, Broadway, Lacbine, for the following purposes: To deal in motor vehicles of all kinds, their parts and accessories and to carry on the business of garage-keepers, under the name of \"O'Brien Motors Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 common shares of $1 each.The head office of the company will he at 302 Inglewood Avenue, Pointe-Claire, judicial district of Montreal.(Jiven at the of lice of the Provincial Secretarv, this 31st day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-«» 3116-63 \u2014 1182/22 Pannier Céramiques Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du lie jour de juillet 19(53, constituant en corporation: Paul Pannier, céramiste, 8317, rue de l'Êpée, Montréal, Adone Scattolin, entrepreneur, 10555, boul.St-Laurent, Montréal, Georges Lauda, décorateur, 3009, Maplewood, Montréal, et Raymond Globensky, entrepreneur, 10095, boul.d'Auteuil, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles «le céramique, mosaïque, tuile et autres produits fabriqués de toute substance provenant du sol ou du sous-sol, sous le nom de « Pannier Céramiques Ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 10024, rue London, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1 le jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.3992-o 2998-63 \u2014 1180/127 Pannier Céramiques Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Paul Pannier, ceramist, 8317 de l'Épée St., Montreal, Adone Scattolin, contractor, 10555 St-Laurent Blvd., Montreal, Georges Lauda, decorator, 3009 Maplewood, Montreal, and Raymond Globensky, contractor, 10095 d'Auteuil Blvd., Montreal, for the following purposes : To deal in ceramic, mosaic and tile articles, and other products manufactured with substances coming from the ground or underground, under the name of \"Pannier Céramiques Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 prefer red shares of $100 each.The head office of the company will be at 10024 London St., Montreal North, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 11th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2998-03 \u2014 1180/127 Parc Laurier Service Ine.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Claude Poirier Defoy, Gilles Audet, tous deux avocats, de 1224, Ste-Catherine.ouest, et Lyse Paradis, secrétaire, célibataire majeure, 7741, Cartier, app.4, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles, leurs accessoires et parties et faire affaires comme garagistes, sous le nom de « Parc Laurier Service Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1103, rue St-Grégoire, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3222-63 \u2014 1182/23 Parc Laurier Service Inc.Notice is hereby given that under Past I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Poirier Defoy, Gilles Audet, both advocates, of 1224 St.Catherine West, and Lyse Paradis, secretary, spinster of the full age of majority, 7741 Cartier.Apt.4.all three of Montreal, for the following purposes : To carry on business dealing in automobiles, their accessories and parts, and to act as gara-gemen, under the name of \"Parc Laurier Service Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 1103 St-Grégoire St., Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of July.1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3222-63\u2014 1182/23 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, lot.95, So.37 4339 Maurice Parent Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accurdé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Quebec, ties lettres patentes, en date du 15e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Maurice Parent, industriel, Mme Mariette Tangua y Parent, ménagère, épouse tludit Maurice Parent, et dûment autorisée par lui aux fins ties présentes, tous deux tie 15, rue Martel, Loretteville, et Jean-Marie Paquet, comptable, 7X25, ('uré-l)oucet, Charlesbourg, pour les objets suivants: Faire le commerce des huiles, graisses, pétroles et tous leurs produits, et tlu gaz naturel, sous le nom de « Maurice Parent Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 15, rue Martel, Loretteville, district judiciaire tie Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour tie juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3100-03 \u2014 1181/13 Le Patro Sainte-Anne Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, ties lettres patentes, en date du 19c jour de juillet 1903, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard C.Gagnon, marchant!, Benoit Jean, directeur de l'École des Métiers, Ovide Gamier, travailleur social, Gérard Lepage, Jean-Marc Chenel, industriels, André-Albert Fournier, fonctionnaire, et Régis Garon, instituteur, tous sept de Ste-Anne-des-Monts, pour les objets suivants: Maintenir et diriger un foyer pour étudiants, sous le nom tie « Le Patro Sainte-Anne Inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Ste-Anne-des-Monts, district judiciaire de Gaspé.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-t» 2908-03 \u2014 1180/128 Paul & Sons Window Cleaning Inc.Avis est tlonné qu'en vertu tie la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en tlate du 23e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Jacques Le Blanc, administrateur, 525, rue Gohier, St-Laurent, Georges Brosseau, gérant, 12335, St-Êvariste, Montréal, et Paul-Emile Létourneau, courtier en assurances, 1537, boul.Graham, Mont-Royal, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs pour le lavage, le nettoyage, le posage de vitres, fenêtres, portes dans toutes les catégories d'immeubles, sous le nom de « Paul & Sons Window Cleaning Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Maurice Parent Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing tlate the 15th day of July.1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Maurice Parent.industriuIi.sH, Mrs.Mariette Tanguay Parent, housewife, wife of the sait! Maurice Parent, ami duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 15 Martel St., Loretteville, ami Jean-Marie Paquet, accountant, 7825 ( 'uré-Doucet, Charlesbourg, for the following purposes: To deal in oils, grease, petrol ami all products thereof, ami in natural gas.untler the name of \"Maurice Parent Inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each antl 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 15 Martel St., Loretteville, judicial district of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretarv.this 15th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3100-03 \u2014 1181/13 Le Patro Sainte-Anne Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quel>ec, to incorporate as a corporation without share capital: Gérard C.Gagnon.merchant.Benoit Jean, director of a trade school, Ovide Gamier, social worker, Gérard Lepage.lean-Marc Chenel, industrialists, André-Albert Fournier, civil servant, and Régis Garon, teacher, all seven of Ste-Anne-des-Monts, for the following purposes: To maintain and direct a home for students, under the name of \"Le Patro Sainte-Anne Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Ste-Anne-des-Monts, judicial district of Gaspé.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2908-63 \u2014 1180/128 Paul & Sons Window Cleaning Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of July, 1903, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Le-Blanc, administrator, 525 Gohier St., St-Laurent, Georges Brosseau, manager, 12335 St-Êvariste.Montreal, and Paul-Emile Létourneau, insurance broker, 1537 Graham Blvd., Mount Royal, for the following purposes: To act as contractors in washing, cleaning, placing of glass, windows, doors in all types of immoveables, under the name of \"Paul & Sons Window Cleaning Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each. 4340 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 95, So 37 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montreal.Donné au bureau du secrétaire de la province.cate, 400 Champagneur, Outre-mount, Paul-Eugène Hélanger, advocate.2755 Louis-1 )ant in.Montreal, and Albéric Deschamps, 289, 63rd Ave., Chomedey.for the following purposes : To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Placements Dansereau Inc.\", with a-total capital stock of $250,-000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2.300 preferral shares of $100 each.The head office of the company will be at 455 Mitchell.Mount-Royal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Axxixtaut Secretary of the Province.3992 3226-63 -1182/26 Placements Gilman Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 26e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Jean-Marie Tremblay, courtier en assurances, Hector David, entrepreneur peintre, Patrick Boutin, pharmacien, Isachar Ix^clerc, garagiste, Dr Robert Morel, médecin, Martin Gauvin, ingénieur, tous six de Chibou-gamau, et Jean-Baptiste Latlamme, industriel, Chapais, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Placements Gilman Inc.», avec un capital total «le $150,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ( ' hibou-gamau, district judiciaire d'Abitibi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 26e jour de juillet 1963.Le Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3045-63 1182/27 Plastic Services & Dies Ltd.Placements Gilman Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of July, 1963, have been issued by the Government Administrator of of the Province of Quebec, incorporating: Jean-Marie Tremblay, insurance broker.Hector David, painting contractor, Pat rick Boutin, pharmacist, Isachar Leclerc, garageman.Dr.Robert Morel, physician, Martin Gauvin, engineer, all six of Chibougamau, and Jean-Baptiste Latlamme.industrialist, Chapais, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Placements Gilman Inc.\", with a total capital stock of $150.000, divided into 1,500 common shares of $100 each.The head office of the company will l>e at Chibougamau, judicial district of Abitibi.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Axxixtaut Secretary of the Province.3992 3045-03 1182/27 Plastic Services & Dies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companise Act, letters patent, 4342 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 95, No 37 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de lu province de Québec, des lettres patentes, en date du 2e jour d'août 1903, constituant en corporation: Maurice Marcotte, avocat, 285, Duinoucliel, Dor val, Bernard l'aquin, avocat, I, rue Crépin.ChAteauguay.et André Pelletier, avocat.1910.boul.I )orchester, ouest.Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de moteurs, machines, leurs parties et accessoires, et autres instruments et appareils, sous le nom de « Flastic Services & Dies Ltd.».avec un capital total de $20,000.divisé eu 400 actions ordinaires de $10 chacune et en 160 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2540, rue St-Antoine.Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 2e jour d'août 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3311-03 \u2014 1182/126 bearing «late the 2nd day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province t>f Quebec, incorporating: Maurice Marcotte, advoeate, 285 Dumouchel, Dorval, Bernard Paquin, advocate, 1 Crépin St, ChAteauguay, and André Pelletier, advocate, 1916 Dor Chester Blvd., West, Montreal, for the following purposes : To carry on a business dealing in motors, ma-chines, their parts and accessories and other instruments and apparatus, under the name of \"Plastic Services & Dies Ltd.\", with a total capital stock of $20.000.divided into 400 common shares of $10 each and into Kit) preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 2540 St-Antoine St., Montreal, judicial district of Montreal.(¦iven at the office of the Provincial Secretarv.this 2nd day of August, 1903.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3311-03 - 1182/120 Playboy Men's Wear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i «les compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 22e jour «le juillet 1903, constituant en corporation: Leon Barakett, marchand, 2425, rue Laviolette, Nick Mallick, marchand, 1970, rue Lajoie, et Edmond Barakett, marchand, 2425.rue Laviolette, tous trois de Trois-Rivières.pour les objets suivants: Exercer le commerce de mercerie pour hommes, sous le nom de « Playboy Men's Wear Inc.», avec un capital total de $49,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 2,900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Trois-Rivières.district judiciaire de Trois-Rivières.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour «le juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 2089-63 -1182/28 Playboy Men's Wear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 22nd day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Leon Barakett, merchant, 2425 Laviolette St., Mick Mallick, merchant, 1970 Lajoie St., and Edmond Barakett, merchant, 2425 Laviolette St., all three of Trois-Rivières, for the following purposes: To deal in haberdeshery, under the name of \"Playboy Men's Wear Inc.\", with a total capital stock of $49,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and 2,900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretarv.this 22nd day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Provincte 3992 2689-63 \u2014 1182/28 Plomberie Papineau Ltée Papineau Plumbing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 9e jour de juillet 1963, constituant en corporation: René Lacelle, plombier, Mme Agathe Gagnon Lacelle.ménagère, épouse commune en biens dudit René Lacelle, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 469, rue Millar, Gatineau, et Jean-Claude Daoust.homme d'affaires, Masson, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'entrepreneurs en plomberie, chauffage et réfrigération, sous le nom «le « Plomberie Papineau Ltée \u2014 Papineau Plumbing Ltd.».avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Temple-ton, district judiciaire de Hull.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 9e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-o 2828-63 \u2014 1181/124 Plomberie Papineau Ltée Papineau Plumbing Ltd.Notice is hereby given that untler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: René Lacelle, plumber, Mme Agathe Gagnon Lacelle, housewife, wife common as to property of said René Lacelle, and duly authorized by him for these presents, both of 469 Millar St., Gatineau, and Jean-Claude Daoust, businessman, Masson, for the following purposes: To carry on the business of plumbing, heating and refrigeration contractors, under the name of \"Plomberie Papineau Ltée \u2014 Papineau Plumbing Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Templeton, judicial district of Hull.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 2828-63\u20141181/124 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 198$, Vol.98, So.37 4343 \\a-h Pneus J.Grenier Liée J.Grenier Tires Lid.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Quéliec, il a été accordé, par l'administrateur du gou\\ernc-inent cie la province de Québec, «les lettres pa ten -tes, en «late «lu lie jour «le juillet 10(53, constituant en corporation: J.-lacque.s Beauchemin, avocat, 355, avenue Bloom field, Outretnont, André Vali«|uette, avocat, 3340, Beauséjour, St-Laurent, Madeleine Kiel, 0020, Hamilton, Montréal, et Jeannette Desjardins, 3880, boulevard St-Joseph, est, app.0, Montréal, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les oh jets suivants: Faire Je commerce «le toutes parties et accessoires «le véhicules, automobiles, «le pneus, «le pneus, de même que toutes espèces «le moteurs, machines, instruments, appareils et accessoires dont on se sert dans la fabrication ou l'usage «l'au-tomobiles, sous le nom de « \\ajs Pneus J.Grenier Ltée \u2014 J.Grenier Tires Ltd.», avec un capital total de $30.000, «livisé en 30,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 3550, Jarry, est, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 1 le jour «le juillet 1903.Le Soux-xecrétaire de la produce, Raymond Douvillk.3993-0 2972-03- 1182/104 Les Pneus J.Grenier Liée J.Grenier Tires Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies A«t, letters patent, hearing «late the 11th «lay of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: J.-Jacques Beauchemin, 355 Bloomfield Ave., Outremout, Amlré YaJiqllctte, advocate.3340 Beauséjour, St-I.aurent, Madeleine Rich 0920 Hamilton.Montreal, and Jeannette Desjardins, 3880 St-Joseph Blvd., Fast, Apt.0, Montreal, the last two secretaries, filles majeures, for the following purposes : To carry on a business dealing in all kinds of parts and accessories of vehicles, automobiles, tires as well as all types of motors, machines instruments, apparatus and accessories used in the manufacture or for the use of automobiles, under the name of \"Lea Pneus J.Grenier Ltée \u2014 J.Grenier Tires Ltd.\", with a total capital stock of $30,000 divided into 30,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at 3550 Jarry Fast, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this llth day of July, 1903.Raymond Douvillk, Axxixtaut Secretary of the Province.3992 2972-03 \u2014 1182/104 Poly placemen Is Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres pa ten t es, en date du 21e jour de juin 1903, constituant en corporation: Geoffroy Birtz, 170, High field.Mont-Royal, Jacques Leduc, 54, Beloeil, Outremont, Jean-Yves Durand, 5540, Gatineau, Montréal, tous trois avocats, Suzanne Dupujs, 4043, Vendôme, Montréal, et Grabrielle Lahaie, 7800.rue Berri, Montréal, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants : Exercer le commerce «l'une compagnie «le placements, sous le nom de « Polyplacements Inc.», avec un capital total de $75,000, divisé en 50 actions classe « A » de $50 chacune et en 1,450 actions classe « B » de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 21e jour «le juin 19G3.Le Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 2501 -03 \u2014 1180/73 Pratte «& Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, «les lettres patentes, eu date du 25e jour de juillet 1903, constituant en corporation: (biles Pratte, 150, 12 avenue, Gilles Rose, tous «leux commerçants, et Gilberte Pratte Rose, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Gilles Rose, ces deux derniers de 38, St-Laurent, tous trois de Drummondville, pour les objets suivants: Faire le commerce de vêtements pour hommes et femmes, sous le nom de « Pratte et Fils Inc.», avec un capital total de $150.000, divisé en 2,500 Polyplacements Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 21st day of June, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Geoffroy Birtz, 170 High field, Mont-Royal, Jacques Leduc, 54 Beloeil, Outremont, Jean-Yves Durand, 5540 Gatineau, Montreal, all three advocates, Suzanne Dupuis, 4043 Vendôme, Montreal, antl Gabriel le Lahaie, 7800 Berri St., Montreal, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes : To carry on the business of an investment company, under the name of \"Polyplacements Inc.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 50 class \"A\" shares of $50 each an«l 1,450 class \"B\" shares of $50 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of June, 1903.Raymond Douvillk, Axxixtaut Secretary of the Province.3992 2561-63 \u2014 1180/73 Pratte & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Gilles Pratte, 156, 12th Avenue, Gilles Rose, both merchants, ami Gilberte Pratte Rose, housewife, wife contractually separate as to property of said Gilles Rose, the latter two of 38 St-Laurent, all three of Drummondville, for the following purposes: To deal in wearing apparels for men and women, under the name of \"Pratte et Fils Inc.\", with a total capital stock of $150.000.divided 4344 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.14 septembre 19$$, Tome 95, So 37 actions ordinaires d'une valeur au pair (le $10 chacune.12,400 actions privilégiées classe « A » «l'une valeur au pair «le $10 chacune et en 100 actions privilégiées classe « H » «l'une valeur au pair «le S 1.0 chacune.liC siège social «le la compagnie sera à Drum-mondvillc, district judiciaire d'Arthahaska.Donné au bureau du secrétaire «le la province, «\u2022e 25e jour «le juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-.) 3125-63 \u2014 1182/127 Précision Automati«|iie J.R.N.Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été acconlé.par l'administrateur «lu gouvernement de la province «le Québec, «les let ties patentes, en date du 25e jour «le juillet 1903.constituant en corporation: Pierre Gaston, avocat.Maryse Gaston, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Pierre Gaston, tous «leux «le 29S.35e avenue.Marcel ( aroii, gérant de bureau, 11S, 7e avenue, Monitjue St-Pierre, secrétaire, fille majeure, 377, 15e avenue, et Robert Des-forges, comptable agréé.050.ISe avenue, tous cinq «le l.achine, pour les objets suivants: Faire le commerce «le métaux «le toutes sortes, leurs produits et sous-produits, sous le nom de « Précision Automatique J.R.N'.Ltée ».avec un capital total «le $40.000.divisé en 2.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 25e jour «le juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.3092-o 3017-03 \u2014 1181 /9G into 2,500 common shares of a par value of $10 each, 12,400 class \"A\" preferre«l shares of a par value of $10 ea«'h and 100 class \"H\" preferreo shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Drummondville, judicial district of Arthaba.sk».Given ut the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 19(53.Raymond Douville, Assistant Secretari/ of the Province.3992 3*125-03 \u2014 1183/127 Précision Automati«|iie J.R.N.Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the 25th day of July.1903, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Gaston, advocate.Maryse Gaston, housewife, wife separate as to property of the said Pierre Gaston, both of 298, 35th Ave.Marcel Caron, office manager, US.7th Ave.Monique St-Pierre.secretary, fille majeure.377, 15th Ave., ami Robert Desforges.chartered accountant.050, 18th Ave., all five of l.achine.for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of metals, their products and by-products, under the name of \"Précision Automatique J.R.N Ltée\", with a total capital stock of $40,000.divided into 2.000 common shares of $10 each an«l 200 preferre«l shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 1963.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3017-03 \u2014 1181/9(1 Les Prêts Richelieu Inc.Richelieu Loans Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu 25e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Lorraine Turcotte, avocate, 105 rue Drummond, Denise Ménard, 9, rue Paré, et Pierrette Desjardins, 157-D, rue Paré, ces deux dernières secrétaires, toutes trois célibataires, «le Granby.pour les objets suivants : Exercer le commerce «l'une compagnie de financement, sous le nom de « Les Prêts Richelieu Inc.\u2014 Richelieu Loans Inc.», avec un capital total «le $250,000, divisé en 2,500 actions ordinaires «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 54, rue St-(ieorges.St-Jean.district judiciaire d'Iberville.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour «le juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3217-63\u20141181/126 Produits d'Érables Tuque Rouge Ltée Tuque Rouge Maple Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date Les Prêts Richelieu Inc.Richelieu Loans Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of July, 1903 have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Lorraine Turcotte, advocate, 105 Drummond St.Denise Ménard.9 Paré St., and Pierrette Des-jardins, 157-D Paré St.the two latter secretaries, all three spinsters, of Granby, for the following purposes: To carry on business as a finance company, under the name of \"Les Prêts Richelieu Inc.\u2014 Richelieu Loans Inc.\", with a total capital stock of $250,000, divided into 2,500 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 54 St-Georges St., St.John, judicial district of Iberville.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of July, 196S.Raymond Douvillk, Assistant Secretray of the Province.3992 3217-63 1181/126 Produits d'Krables Tuque Rouge Ltée Tuque Rouge Maple Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 1/,.1968.Vet.95.So.37 4345 du 29e jour de juillet 19113, constituant en corporation: Thomas Chasney Camp, avocat, 133 avenue Ballantyne, Montréal-Ouest, Richard Joseph Kiendeau, avocat, 4(58, boulevard Graham, Mont Royal, William Ewart Stavert, avocat, .'5250, avenue des Cèdres, Montréal, Haie James l'Iant, avocat, 377, Redfern, Westmount, et Roy Lacaud Ileenan, uvocat, 439, avenue Victoria, Westmount, pour les objets suivants: Faire le commerce des produits de l'érable sous toutes ses formes et procédés de fabrication, sous le nom de « Produits d'Erables Tuque Bouge Ltée - Tuque Rouge Maple Products Ltd.», avec un capital total de $100.000, divisé en 20.000 actions d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Émile-«I.-Montcalm, district judiciaire «le Joliette.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992 3005-03- 1181/97 Le* Produits Dromoco Inc.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par l'administrateur «lu gouvernement «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date.du 23e jour de juillet 1903, constituant en corporation: J.-Gaston Drouin, 1946, rue Méthot.Jean-Jacques Côté, 3045, Monseigneur-Gauthier, tous «leux vendeurs, de Gitlard, et Michel Moisan, gérant, 19, «le Gaula-, Orsainville, pour les objets suivants: Faire le commerce «le tous genres «le tuyaux de drainage, conduits de drainage ou d'aqueduc ou d'égout, de rampes ou garde-fous en métal ou autres produits, et autres marchandises semblables, sous le nom de « Les Produits Dromoco Inc.», avec un capital total de $15,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 19, rue de Gaulle, Orsainville, district judiciaire «le Québec.l'onné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3008-03 \u2014 1180/129 Les Publications Carillon Inc.The Carillon Publications Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouverne-ni'-ut «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 18e jour «le juillet 1903, constituant en corporation: J.-Vincent O'Donnel fils.20, «le Bretagne, Préville, Marc Beauregard, 5217, ave Bessborough, Montréal, Eric L.('lark, 4954, Fulton, Montréal, Paul Hurtubise, 10492, d'Auteuil, Montréal, tous quatre avocats, et l'Iiilippe-Robert de Massy, étudiant, 709, Upper Koslyn, Westmount, pour les objets suivants: Kxercer le commerce d'imprimeurs, éditeurs, papetiers, lithographes, graveurs, relieurs, libraires fondeurs typographes et autres commerces semblables, sous le nom de « Les Publications Carillon Inc.\u2014 The Carillon Publications Inc.», avec un capital divisé en 100 actions ordinaires sans valeur au pair et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera d'au moins $500.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Province of Queliec, incorporating : Thomas ( 'lias-ney Camp, advocate, 133 Ballantyne Avenue, Montreal West, Richard Joseph Kiendeau, advocate, 4(58 Graham I bin le van I, Mount Royal, William Ewart Stavert, advocate.3250 Cedar Avenue, Montreal, Rafe James Plant, advocate, 377 Redfern, Westmount, ami Roy Lacaud Heenan, advocate.439 Victoria Avenue.West-mount, for the following purposes: To deal in maple tree products in all forms and processes of manufacture, under the name of 'Produite d'Erables Tuque Rouge Ltée - Tuque Rouge Maple Products Ltd.\", with a total capital stock «>f $100,000, divided into 20,000 shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at St-Emile-de-Montcahn, judicial district of Joliette.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 29th «lay of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-o 30(55-63 1181/97 Les Produits Dromoco Inc.Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies Act.letters patent, hearing date the 23rd day of July, 19(53, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: .1.-Caston Drouin, 1946 Méthot St., Jean-Jacques C6té, 3045 Monseigneur-Gauthier, l>oth salesmen, of (iitlard, and Michel Moisan, manager, 19 de Gaulle, Orsainville, for the following purposes: To deal in drainage pipes of all kinds, drainage, aqueduct or sewer systems, railings and hand-railings in metal or in other products, and other similar merchandise, under the name of \"Les Protluits Dromoco Inc.\", with a total capital stock of $15,000, divided into 150 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 19 de (iaulle St., Orsainville, judicial district of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretarv, this 23rd day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3008-63 \u2014 1180/129 Les Publications Carillon Inc.The Carillon Publications Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of July 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quel>ec, incorporating: J.-Vincent O'Donnel Jr., 26 de Bretagne, Pré-villc.Marc Beauregard, 5217 Bessl>orough Ave., Montreal, Eric L.Clark, 4954 Fulton, Montreal.Paul Hurtubise, 10492 d'Auteuil, Montreal, all four advocates, and Philippe-Robert de Massy, student, 709 Upper Roslyn, Westmount, for the following purposes: To carry business as printers, publishers, paper-makers, lithographers, engravers, booksellers, type-founders and other similar businesses, under the name of \"Les Publications Carillon Inc.\u2014 The Carillon Publications Inc.\", with a total capital stock divided into 100 common shares without par value and the amount with which the company will commence its operations will be at least $500.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 4340 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 95, So 37 Donné au bureau «lu secrétaire de la province, «\u2022e 18e jour «le juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-d 3105-03 \u2014 1180/130 Qucbee Industrial Gas Ltd.(No Personal Liability) Gaz Industriel du Québec Ltée (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu «les dispositions «le la Loi «les compagnies minières de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement «le la province de Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 23e jour «le juillet 1903, constituant en corporation: William Edgar Bronstet-ter, Morgan Carlyle Johnston, avocats, et Carman Curtis, secrétaire, tous trois «le 3411, Place Ville-Marie, Montréal, pour les objets suivants: Faire «les recherches et explorations pour découvrir des mines et minerais, sous le nom «le « Que-bec Industrial Gas Lt«l.)) (No Personal Liability)\u2014 «Gai Industriel «lu Québec Ltée» (Libre «le Responsabilité Personnelle), avec un capital total «le $40,000.divisé en 40,000 actions, «l'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront paye ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 23e jour «le juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992 3100-63\u2014 1181/67 (îiven at the office of the Provincial Secretarv, this 18th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3105-03 - 1180/130 Quebec Industrial Gas Ltd.(No Personal Liability) Gax Industriel du Québec Ltée (Libre de responsabilité personnelle) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of July, 1903, have l>een issued by the Administrator of the Government f the Province e paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3092-o 8166-63 \u2014 1181 ,'07 Le Ranch des Sportifs Inc.Le Ranch des Sportifs Inc.Sportsmen's Ranch Inc.Sportsmen's Ranch Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a «:té accordé, par l'administrateur «lu gouvernement «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 23e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Jerry Sima.nl, machiniste, 425, rue Bellechns.se, est, Claude Picard, avocat, 168, Notre-Dame, est, c\\ Roger Picard, comptable, 4563, Dumas, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fournir «le l'amusement au public et faire le commerce «le location de chevaux «l'«5quitation, de « Go-Karts » et «le « Ski-Doos », sous le nom de « Le Ranch des Sportifs Inc.\u2014 Sportsmen's Ranch Inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 4.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 425, rue Belled Hisse, est.Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 3009-03 \u2014 1182/32 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 23r«l day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Jerry Simard, machinist, 425 Bcllcchasse, East.Claude Picanl, advocate, 168 Notre-Dame, East, and RogerPici r«l, accountant, 4563 Dumas, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on a business of supplying amusement to the public and to carry on a business for the rental of horses for horseback riding, for \"Go-Karts\" and for \"Ski-Doos\" under the name of \"Le Ranch des Sportifs Inc.\u2014 Sportsmen's Ranch Inc.\" with a total capital scock of $50,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will he at 425 Bcllcchasse St.East, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office «)f the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3009-63 \u20141182/32 Le Restaurant Baronet Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du lie jour de mars 1963, Le Restaurant Baronet Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of March, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September /.',, 1963, loi.95, So.37 4347 -mist it liant en corporation: Madeleine Cloutier Raymond, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens de I,on is-Albert Raymond, 1480.de Repcntigny, Suzanne Houdreault, secrétaire, fille majeure, 8, rue Hrébeuf, et Pierre Bienjo-netti, avocat, 580, Grande-Allée, est, tous trois de Québec, pour les objets suivants: Kxercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de « Le Restaurant Raronet Inc.», avee un capital total de $20,04)0, divisé eu 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire «le Québec.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 14e jour tl'aoiH 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.;W2-o 1081-03 \u2014 1181/43 Madeleine Cloutier Raymond, housewife, wife contractually sepurate as to property of Louis-Albert Raymond, 1480 «le Repcntigny, Suzanne Houdreault, secretary, fille majeure, 9 Hrébeuf St., and Pierre Bienjonetti.advocate, 580 Grande-Allée, bast, all three of Quebec, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Le Restaurant Haronet Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of $100 each ami 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will he at Quebec, judicial district of Quebec.(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of August, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 1081-03 1181/43 Restaurant « La Fiesta Inc.» Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province «le Québec, des lettres patentes, en date du l()e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Laurent P.Bolduc, avocat, 2050, chemin Ste-Foy, Ste-Foy, Arthur Hussicres, comptable, 135, St-Olivier, Québec, et Gaston Desjardins, avocat, 3190, Marsolet, Ste-Foy, pour les objets suivants: Kxercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de « Restaurant « La Fiesta Inc.» », avec un capital total de $15,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2291, rue Maufils, Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 10e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 2908-03 \u2014 1182/128 Restaurant \"La Fiesta Inc.\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 10th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorjiorating: Laurent P.Bolduc, advocate, 2050 Ste-Foy Road, Ste-Foy, Arthur Bussières, accountant, 135 St-Olivier St., Quebec, ami Gaston f ) es j aril ins.advocate, 3190 Marsolet, Ste-Foy, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Restaurant \"La Fiesta Inc.\" \", with a total capital stock of $15.000.divided into 150 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 2291 Maufils, Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2908-03 \u2014 1182/128 La Revue Parti Pris, Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour «le juillet 1903, constituant en corporation sans capital-actions: André Brochu, professeur, An«lré Major, journaliste, Jean-Marc Piotte, professeur, tous trois de 3026, Dorlet, app.I.Montréal, Paul (\"lia m her land, étudiant, 1487, De Lorimier, No 5, Montréal, et Pierre Vfaheu, professeur, 790-B, ( 'hampagneur, Outre-mont, pour les objets suivants: R«:diger, imprimer et distribuer une publication qui portera le nom «le « Parti Pris », sous le nom île « I^a Revue Parti Pris, Incorporée ».Le montant auquel sont limités les biens immo-biliers que la corporation peut actjuérir et posséder, est de $20,000.l>e siège social de la corporation sera 790, rue (hampagneur, Outremont, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 29e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8992* 3118-03\u20141181/98 La Revue Parti Pris, Incorporée Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of July, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: André Broehu, professor, André Major, journalist.Jean-Marc Piotte, professor, all three of 3020 Dorlet, Apt.1, Montreal, Paul Chamberlain!, student, 4487 De Lorimier, No 5, Montreal, and Pierre Maheu, professor, 790-B Champagneur, Outremont, for the following purposes: To edit, print and distribute a publication which will hear the name \"Parti Pris\", under the name of \"La Revue Parti Pris, Incorporée\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will be at 790 Champagneur St., Outremont, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistnat Secretary of the Province.3992 3118-83 \u2014 1181/98 Roma's Steel Works Inc.Roma's Steel Works Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie dé la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent, 4348 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 95, No 37 été accordé, par la lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 5e jour d'août 1963.constituant eu corporation: Claude Simard, 7255, Des Érables, Gaston Boudreault, 3448, Iberville, tous deux avocats, et Benjamin S.Stock, gaent, 431.Lagauchetière, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Kxercer le «'ommerce «le constructeurs et d'en» trepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « Roma's Steel Works Inc.», avec un capital total de $40.000.divisé en 4.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le sièg«> social de la compagnie sera à Charlemagne, district judiciaire «le Joliette.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 5e jour d'août 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.3092-o 3190-03 1182/129 hearing date the \">t 11 day of August, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Simard.7255 Des Érables, (laston Houdreault.3448 Iberville, both advocates, and Benjamin S.Stock, agent, 431 Lagauchetière, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Roma's Steel Works Inc.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 4.000 common shares of $10 each.The hcaf the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 23rd day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government f the Province of Quebec, incorporating: Wilfrid Samson, Maurice Samson and Marcel Samson, we 11-diggers, of St-Pierre, county of Montmagny.for the following purposes: To operate a business as drillers, well-digger^ an«l mine searchers, under the name of \"Samson & Frères Inc.\", with a total capital stock of $100,000.divided into 1.200 common shares of $25 each and into 700 preferred shares of $100 each.The head office t>f the company will be at St-Pierre, county of Montmagny, judicial district of Montmagny.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 '3177-03\u2014 1181 99 Service Immobilier de Montréal Inc.Montreal Real Estate Service Inc.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement «le la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 22e jour «le juillet 1903, constituant en corporation: Adrien R.Raquette, avocat.212, Bloom fie Id, Outremont, Marcel Paquctte, avocat.1320.Chanteclerc, St-Bruno, et Franchie Thibault, secrétaire, 2404, rue Théo-«lore, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de l'immeuble et «le la construction, sous le nom de « Service Immobilier «le Montréal Inc.\u2014 Montreal Real Estate Service Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 10.000 actions ordinaires «le $1 chacune.he siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour «le juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 2700-63\u2014 1181/69 Service Immobilier de Montréal Inc.Montreal Real Estate Service Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the 22n«l day of July, 1963, have Wen issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Adrien R.Paqucttc, advocate, 212 Bloom fie Id.Outremont.Marcel Paqucttc, advocate, 1320 Chanteclerc.St-Bruno, ami Francine Thibault, secretary.2404 Théodore St., Montreal, for the following purposes: To carry on business in the fields of real estate ami construction, under the name of \"Service Immobilier «le Montréal Inc.\u2014 Montreal Real Estate Service Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 '2700-03\u2014 1181/09 Silibéton Ltée Silibeton Ltd.Silibéton Ltée Silibeton Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bea- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol.96, No.37 4349 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 14e jour de juin 1963, constituant en corporation: Claude Heaucheiniii, avocat, Mme Claude l'epin Beauchemin, ménagère, épouse dudit ( lande Beauchemin, tous deux de 851, rue Boissy, St-Lambert, et André Beauchemin, ingénieur, 3784, Vendôme, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce du ciment, béton, chaux, argile et de leurs sous-produits, sous le nom de « Silibéton Ltée \u2014 Silil>eton Ltd.», avec un capital de $200,000, divisé en 20.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 507, Place d'Armes, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 14e jour de juin 1903.Le Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douvillk.:t992-o 2021-03 \u2014 1180/43 The Sir George Williams University Faculty Club Avis est «lonné qu'en vertu de la troisième partie de la Ix>i des compagnies «le Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 26e jour de juillet 1963, consti-t uant en corporation sans capital-actions: Fred W.Bedford, 1, Village Suisse, St-Jean, Wynne Francis, 49 sud, avenue Ballantyne, tous deux professeurs associés, Keith Crouch, libraire d'université, 4376, avenue Western, Fred Sauer, surintendant des comptes, 747, avenue Allard, Jack Bordan, professeur, 2085, rue Vincent, Robert Curnew, 2945, chemin Bedford, tous les cinq de Montréal, Magnus Flynn, 494, Murray, tous deux assistants doyens, Donald Ayre, directeur des admissions, 39, rue Burton, tous deux de Greenfield Park, et David A.Schwartz, avocat, 90 avenue Elgin, Valois, pour les objets suivants: Établir, entretenir et gérer un club pour l'acco-inodation, la récréation et l'agrément des membres de la corporation et autres personnes, sous le nom de « The Sir George Williams University Faculty Club ».Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est de $100,000.Le siège social de la corporation sera 2015, rue Drummond, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 26e jour de juillet 1963.Le Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992 2799-63\u20141181/70 Skyline Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 17e jour de juin 1963, constituant en corporation: George Rosenberg, avocat, 1000 McGregor, Montréal, Beatrice Steer, 10, Marsolais, Outremont, et Laura Frishling, 4870, Bourret, Montréal, ces deux-dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Exercer des affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Skyline Construction Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.ring date the 14th day of June, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Beauchemin, advocate, Mrs.Claude Pepin Beauchemin, housewife, wife of the said Claude Beauchemin, both of 851 Boissy St., St-Lambert, and André Beauchemin, ingeneer, 3784 VemlAme, Montreal, for the following purposes: To deal in cement, concrete, lime, clay argile and their by-products, under the name of \"Silibéton Ltée - Silibéton Ltd.\", with a total capital stock of $200,000.divided into 20,000 common shares of $10 each.The head office of the company will l>e at 507 Place d'Armes, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 14th dayof June 1963.Raymond Douvillk, Axxixtaut Secretary of the Province.3992 2621-63 \u2014 1180/43 The Sir George Williams University Faculty Club Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Fred W.Bedford, 1 Swiss Village, St-Jean, Wynne Francis, 49 Ballantyne Avenue South, both associates professors, Keith Crouch, university librarian, 4376 Western Avenue, Fred Sauer, supervisor of accounts, 747 Allard Avenue, Jack Bordan, professor, 2085 Vincent Street, Robert Curnew, 2945 Bedford Road, all five of Montreal, Magnus Flynn, 494 Murray, both assistants deans, Donald Ayre, director of admissions, 39 Burton Street, both of Greenfield Park, and David A.Schwartz, lawyer, 90 Elgin Avenue, Valois, for the following purposes: To establish, maintain and conduct a club for the accomodation, recreation and convenience of the membres of the corporation and others, under the name of \"The Sir George Williams University Faculty Club\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited to $100,000.The head office of the corporation will be at 2015 Drummond Street, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-0 2799-63 \u2014 1181/70 Skyline Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of June, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: George Rosenberg, advocate, 1000 McGregor, Montreal, Beatrice Steer, 10 Marsolais, Outremont, and Laura Frishling, 4870 Bourret, Montreal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To do business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Skyline Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each. 4350 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 96, No 37 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 17e jour de juin 1963.L«?Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992 2636-63\u2014 1177/109 Société America Europa Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quéliec, des lettres patentes, en date du 31e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Ghylaine De Samayoa, agent «le relations extérieures, épouse séparée de biens «le Salvador Samavoa Mhlenee, 06(55, rue Sherbrooke, ouest, Victor-Paul-Emile Auhut, avocat, 10055, De Martigny, et J.-Ernest Savard, financier, 3495, Mountain, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants : Commerce de tous produits, articles et marchandises faits, en tout ou en partie, de cuir, caoutchouc, métal, métalloïde, bois, papier, nylon, plasticine, fourrure, textile, verre et leurs sous-produits; «le merceries, produits comestibles, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, boissons alcooliques, livres et pério«li«iues, peintures, travaux d'art, produits chimiques, produits de la terre, de la mer et des forêts, produits de beauté, articles de toilette et parfums, sous le nom de « Société America Europa Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 60, rue St-Jacques, ouest, chambre 401, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour de juillet 1903.ht Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3284-63 \u20141182/36 La Société Delbro Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en «late «lu 26e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Gérard Desjardins, arpenteur géomètre, 15, rue Dalla ire.Pierre Lemieux, notaire, 56, rue Fraser, Armand No-reau, gérant de ventes, 64, rue St-Georges, et Charles H.Guay, gérant, 15, Biais, tous quatre de Levis, pour les objets suivants : Faires affairés dans les domaines «le l'immeuble et de la construction, sous le nom «le « La Société Delbro Inc.».avec un capital total «le $200,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 15, rue Dallaire, Levis, district judiciaire «le Québec.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 26e jour «le juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3235-63\u2014 1181/71 Sofino Inc.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of June, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-o 2636-63 - 1177/109 Société America Europa Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 31st day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Ghylaine De Samayoa, foreign relations agent, wife separate as to property of Salvador Sani \u2022-villi M id en ce.6665 Sherbrooke St.West, Victor-Paul-Êmile Aubut, advocate, 10055 De Martigny, and J.Ernest Savard, financier, 3495 Mountain, all three of Montreal, for the following purposes : A business dealing in all products, articles and merchandise made wholly or in part of leather, rubber, metal, métalloïde, wood, paper, nylon, plastic, fur, textile, glass and their by-products; of merchandise, food products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, alcoholic liquors, books and periodicals, paintings, works of art, chemical products, products of the land, sea and forests, beauty products, toilet articles and perfumes, under the name of \"Société America Europa Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at'60 St-James St., West, room 401, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the olfice of the Provincial Secretary, this 31st day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3284-63 \u2014 1182/30 La Société Delbro Inc.' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Gérard Desjardins, surveyor, 15 Dallaire St-Pierre Lemieux.notary, 50 Fraser, Armand Noreau, sales manager, 04 St-Gcorges St., and Charles H.Guay, manager, 15 Biais, all four of Levis, for the following purposes : To carry on business in the field of real estate and construction, under the name of \"La Société Delhro Inc.\".with a total capital stock of $200,000.divided into 1,500 common shares of $100 each and into 500 preferre«l shares of $100 each.The head office of the company will he at 15 Dallaire St., Levis, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3235-03 \u2014 1181/71 Sofino Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of July.1963, have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1063, loi.06, So.37 4351 province «le Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1903, constituant en corporation: Roland Milette, 579, Fleury, est, Roger Comtois, 4840, O'Bryan, Jean-Guy Cardinal, 1517, avenue Mariette, Francois Hogue, 10217, Verville, Guy Rivet, 0222, rue Lemay, l/onard H.Wisse, 1120, Elgin Terrace, tous six de Montréal, et André Labonté, 8001, Des Vendéens, Anjou, tous sept notaires, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de i Sofino Inc.».avec un capital divisé en 2,000 actions classe « A » sans valeur au pair, 500 actions classe « H » sans valeur au pair et sans droit de vote et en 5,000 actions privilégiées classe a C » d'une valeur au pair de $5 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera «le S15,000.Ix?siège social «le la «'ompagnic sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de juillet 1963.L$ Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3Q024) 918-63\u2014 1182/37 been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roland Milette, 579, Fleury St.East, Roger Comtois, 4840O'liryan, .lean-Guy Cardinal, 4517 Mariette Ave., François Hogue, 10217 Verville, Guy Rivet.0222 Lemay St., Léonard H.Wisse, 1120 Elgin Terrace, all six of Montreal, and André Labonté.8001 Des Vendéens, Anjou, all seven notaries, for the following purposes: To carry on a business as an investment and holding company under the name of \"Sofino Inc.\", with a capital stock divided into 2,000 class \"A\" of no par value.500 class \"B\"' shares of no par value and without right of vote and into 5,000 preferred class \"C\" shares of a par value of $5 each, and the amount with/which the company shall start its operations shall he $15,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of July, 1963.Raymond Douvillk, Am i étant Secretary of the Province.3992 918-63\u2014 1182/37 Sogestion Ltée Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 9e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Pierre Legrand, avocat, 415, Place d'Amiens, Duvernay, L.-Yves Fortier, avocat, 40, avenue Arlington, Westmount, et André Guertin, commis, 5635, rue Wellington, Verdun, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de gestion, sous le nom de « Sogestion Ltée », avec un capital total de $50,000, divisé en 10,000 actions classe « A » d'une valeur au pair de $3 chacune et en 20,000 actions classe « B » d'une valeur au pair de $1 chacune.I^e siège social de la compagnie sera à Mont-réal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 9e jour «le juillet 1963.L» Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.5992-0 / 2758-03\u2014 1179/85 Sogestion Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Legrand, advocate, 415 Place d'Amiens, Duvernay, L.-Yves Fortier, advocate, 40 Arlington Ave., Westmount, and André Guertin, clerk, 5035 Wellington, Verdun, for the following purposes: To operate a company dealing in the administration of affairs, under the name of \"Sogestion Ltée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 10,000 class \"A\" shares of a par value of $3 each and into 20,000 class \"B\" shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2758-03\u20141179/85 Sonny's Service Station Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrât eur du gouvernement de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 22e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Y von Lespérance, garagiste, 1465, Paintre Circle, app.6, St-Laurent, Kdward Sebastienski, garagiste, et Yolande Se-bastienski, ménagère, épouse dudit Edward Sebastienski, ces deux derniers de 11138, avenue Rome, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines~et tous leurs accessoires et parties et faire affaires comme garagistes, sous le nom de « Sonny's Service Station Inc.», avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1520, rue Poirier, St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Sonny's Service Station Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 22n«l day of July, 1963, have been issued by the Government Administrator of the Province of Quebec, incorporating: Yvon Lespérance, garageman, 1465 Painter Circle, Apt.0, St-Laurent.Edward Sebastienski, garageman, and Yolande Sebastienski, housewife, wife of the said Edward Sebastienski, the two latter of 11138 Rome Ave., Montreal-North, for the following purposes : To carry on business dealing in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, and to act as garagemen, under the name of \"Sonny's Service Station Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 1520 Poirier St., St-Laurent, judicial district of Montreal. 4352 GAZETTE OFFICIELLE DE QIÊBEC, 14 septembre 1963, Tome 96, So 37 Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-o 3086-63 \u2014 1181/33 À 1 .a Soupe Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 6e jour d'août 1963, constituant en corporation: Luc Geoffroy, 821, boni.Kriand, Chambly, Y van Mercure.2099.ave Bellevue.St-Bruno, et Rhéal Chevrier, 2785, Maplewood, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le restaurateurs, sous le nom de « A La Soupe Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la coin pagine sera 9715.boulevard St-Laurent, Montréal, «listrict judiciaire «le Montreal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 0e jour d'août 1963.Le Sous-secniaire de la prorince, Raymond Douvillk.3992-0 3302-03 \u2014 1182/108 (îiven at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of July, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3086-63\u2014U81./3:< À La Soupe Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, incorporating : Luc Geoff row 821 Briand Blvd., Chambly, Y van Mercure, 209!) Bellevue Ave., St-Bruno, and Rhéal Chevrier.2785 Maplewood, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"A La Soupe Inc.\", with a total capital stock of $40,000 divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 9715 St-Laurent Blvd.Montreal, judicial district of Montreal.(îiven at the oftice of the Provincial Secretarv.this 0th day of August.1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 3302-63 \u2014 1182/108 Frank Spenard (Immeubles) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Quéhec, «les lettres patentes, en «late «lu 22e jour «le juillet 1963, constituant en corporation : Al fini Vigeant, avocat, 1871.rue «le la Jonquière, Trois-Rivières, Jean Girouard, avocat, 2575, nie Marie le Neuf, Trois-Rivières, et Hélène BarhVau, secrétaire, fille majeure usant «le ses droits, 110, rue Beau-chemin, Cap-ec Companies Act, letters patent, hearing date the 22nd day of July, 1963, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: J.-Arthur Deschamps, chartered accountant.Kathleen Deschamps, secretary, spinster, both of 5606 Phillips Ave., and Lucien Grothé, advo cate, 3520, Maplewood Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: .To carry on business as decorative artists, under the name of \"Studio de Meubles d'Art Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol.95, No.37 4353 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 22e jour «le juillet 1963.£# Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992-0 2738-63\u2014 1181/15 Tétreault & Frère Ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ec, il a été accordé, par l'administrateur «lu gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 18e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Marcel Tétreault, Roger Tétreault, tous deux épiciers, de Danville, et Elphè-ge Paillé, cultivateur, St-V'dère, pour les objets Clivants: Exercer le commerce «l'épiciers, sous le nom «le « Tétreault & Frère Ltée », avec un capital total de $60,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et en 450 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Danville, district judiciaire de S^-François.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 18e jour «le juillet 1963.IjC Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.39034) 2855-63\u2014 1181/72 Les Transports A.Larouche Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a dé accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 7e jour d'août 1963, constituant en corporation: Roger Chouinard, 446, Ste-Ursule, François Lamarre, 140, St-Dominique, tous deux avocats, et Adrien Larouche, voiture public, 174, St-Pierre, tous trois de Jonquière, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de transport, sous le nom de « Les Transports A.Larouche Inc.», avec un capital de $40,000.divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 174, rue St-Pierre, Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour d'août 1963.tê Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 2986-63 \u2014 1183/25 Trutone Cleaners & Tailors Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par l'.odministrrteur du gouvernement do la province de Québec, des lettres patentes, en date du 24c jour de juillet 1963, constituant en corporation: Martin Cross, 1105, Ridgewood Drive, Chomedey, Donald Haha-movitch, 5754, avenue Smr.rt, et Joseph Mendel-son, 5622, Jelliccc, ces deux derniers de Côte-St-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de nettoyeurs, presscurs, teinturiers, buandiere et répareurs de vêtements, tissus, marchandises et fournitures de maison, sous le nom de « Trutone Cleaners & Tailors Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 22nd «lay of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2738-68- 1181/15 Tétreault & Frère Liée Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 18th day of July, 1963.have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Tétreault, Roger Tétreault, both groecrs, of Danville, ami Elphège Paillé, farmer, St-Valère for the following purposes: To carry on business as grocers, under the name of \"Tétreault & Frère Ltée\", with a total capital stock of $60,000.divided into 150 common shares of $100 each and 450 preferred shares of $100 each.The head office of the company will lie at Danville, judicial district of St.Francis.Given at the office of the Provincial Secretary, this 18th dayof July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2855-63\u2014 1181/72 Les Transports A.Larouche Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, hearing date the 7th day of August.1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roger Chouinard, 446 Ste-Ursulc, François Lamarre, 140 St-Dominique, both advocates, and Adrien Larouche, public carrier, 174 St-Pierre, all three of Jonquière, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Les Transports A.Larouche Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 174 St-Pierre St., Jonquière, judicial district of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of August, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 2986-63\u20141183/25 Trutone Cleaners & Tailors Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of J ly.1063, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: Martin Gross, 1105 Ridgewood Drive, Chomedey, Donald Hahamovitch, 5754 Smart Avenue, and Joseph Mendelson, 5622 Jcllicoc, the latter two of Côtc-St-Luc, all three advocates, for the following purposes: _ To carry on the business of cleaners, pressera, dyers, launderers and repairers of clothing, fabrics, goods and household furnishings, under the name of \"Trutone Cleaners & Tailors Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30.000 preferred shares of $1 each. 4354 GAZETTE OFFICIELLE DE QIÊBEC, 14 septembre*1963, Tonus 95, So 37 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 24e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992 3197-63 \u2014 1181,73 Vard Incorporated Yard Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéliec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 2e jour d'août 1963, constituant en corporation: Maurice R.Marcotte.285, rue Dumouchel.Dorval, Rernard Faquin, 1, rue Crépin, C liât eau -guay, et André Pelletier.1916.boul.Dorchester, ouest, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie «le portefeuille (holding), sous le nom «le « Var«l Incorporated \u2014 Yar«l Incorporée », avec un capital total «le $100,000, divisé en 2.000 actions or«li-naires de $10 chacune et en 800 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2540, rue St-Antoine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 2e jour d'août 1963.L$ Sous-secrétaiie Je la province, ' raymoni) douviu.k.3992-d 3310-03 - 1182/135 Vorlnge Ski and Recreation Area Limited Avis est donné qu'en vertu «le la premier partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 31e jour de juillet 1963, constituant en corporation: Ellen Warren, secrétaire, célibataire, 198 boul.Macy, Rernard Pearl, 131, rue Cooper, et Kenneth Radnoif, 87, chemin Skead, ces «leux derniers avocats, tous trois d'Ottawa, province d'Ontario, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un centre de ski et de tous articles connexes, et exploiter des monte-pentes, vendre et louer des ensembles pour la pratique du ski et entretenir un club de golf, sous le nom de « Vorlage Ski and Recreation Area Limited », avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Wakefield, district ju liciaire de Hull.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 31e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire Je la province, Raymond Douvillk, 3992 3287-63 \u2014 1182/38 Voyageur Provincial Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Auébec, des lettres patentes, en date du 7e jour d'août 1963, constituant en corporation: Pierre Legraml, 415, Place d'Amiens, Du-vernay, Pierre Cimon.2049, Maplewood, Montréal, et Yves Fortier, 85, Windsor, Westmount, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Voyageur Provincial Inc.», avec The head «»ffi«e of the company will Ik* at Montreal, judicial district of Montreal.(viven at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of .Lily.1968.Raymond Douvillk.Assistant Secretari/ of the Province.3992-0 3197-63\u2014 1181 7:< Vard Incorporated Vard Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Qucliec Comptines Act, letters patent, bearing «late the 2nd day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «;f Quebec, incorporating: Maurice R.Marcotte, 285 Dumouchel St., Dorval.Bernard Paquin.1.Crépin St., Chftteauguay, and André Pelletier, 1916 Dorchester Blvd., West.Montreal, all time advocates, for the following purposes: To carry on business as a holding (company, under the name of \"Vard Incorporated -Vard Incorporée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 2.00() common shares of $10 each ami S00 preferred shares of $100 each.The head office «>f the company will l>e at 2540 St.Antoine St., Montreal, judicial «listrict of Montreal.GiVen at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day «>f August, 1903.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.3992 3310-63 \u2014 1182/135 Vorlage Ski and Recreation Area Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, date the 31st day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Ellen Warren, secretary, spinster, 198 Macy Blvd., Bernard Pearl, 131 Cooper Street, and Kenneth Radnoff, 87 Skead Road, the latter two barristers, all three of Ottawa, province of Ontario, for the following purposes: To carry on the business of a ski resort and all matters ancillary thereto and to operate ski tows, rental and sale of ski equipment and to maintain a golf club, under the name of \"Vorlage Ski and Recreation Area Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Wakefield, judicial district of Hull.Given at the office of the Provincial Secretarv.this 31st day of July, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-0 3287-63 \u2014 1182/38 Voyageur Provincial Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, 'letters patent, bearing date the 7th day of August, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Le-grand, 415 Place d'Amiens, Duvernay, Pierre Cimon, 2049 Maplewood, Montreal, and Yves Fortier, 85 Windsor, Westmount, all three advocates, for the following purposse: To carry on business as a transportation company, under the name of \"Voyageur Provincial QliEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol.95, So.37 4356 un capital divisé en 800 actions ordinaires sans valeur au pair ou nominale, et le montant du capital avec lequel la compagnie exercera ses affaires sera d'au moins $4,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour d'août 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-d 3347-63 \u2014 1182/140 Westminster Service Station Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été acordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Quél>ec, des lettres patentes, en date du 2(>e jour de juillet 1903, constituant en corporation: (iodfroy Marin, avocat, 78, Chester, Pointe-Claire, Francine Tremblay, 2379, Bercy, et Kathleen Higgins, 3025 ouest, Sherbrooke, ces deux dernières secrétaires, célibataires, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de véhicules-automobiles de toutes sortes, leurs pièces et accessoires, et agir comme garagistes, sous le nom de « Westminster Service Station Inc.».avec un capital total de $20,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Côte-St-Luc, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de juillet 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992 3242-03 - 1181/101 Westmount Plumbing & Roofing (1963) Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des- compagnies de Québec, il a été accordé, par l'administrateur du gouvernement de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour de juillet 1963, constituant en corporation: René Beaudry, avocat, 235, boni.Desaulniers, St-Lambert, Louis-Claude Trudel, avocat, 237, Bloomfield, Outremont, et Raymonde Vary, secrétaire, fille majeure, 3490, rue Joliette, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs en plomberie, chauffage, réfrigération, climatisation de l'air et confection de toitures, sous le nom de « Westmount Plumbing & Roofing (1903) Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 360 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Westmount, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 3051-63 \u2014 1180/134 Inc.\", with a capital stock divided into 800 common shares without nominal or par value, and the amount of the capital stock with which the company shall carry on its affairs shall be of at least $4,000.The head office of the company will he at Montreal, ju licial «listrict of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of August, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3347-63 \u2014 1182/140 Westminster Service Station Inc.Notice is hereby given that under Fart I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 20th day of July, 1963, have been issued by the A«lministrator t>f the Government of the Province of Quebec, incorporating: Godfrey Marin, advocate, 78 Chester, Pointe-Claire,* Francine Tremblay, 2379 Bercy, and Kathleen Higgins, 3025 Sherbrooke West, the latter two secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To deal in motor vehicles of all kinds, their parts and accessories and to carry on the business of garage-keepers, under the name of \"Westminster Service Station Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 10,000 common snares of $1 each and 1,000 preferre«l shares of $10 each.The hea«l office of the company will be at Côte-St-Luc, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th «lay of July, 1903.Raymond Douville.Assistant Secretari/ of the Province.3992-0 3242-63\u2014 1181/101 Westmount Plumbing & Roofing (1963) Ltd.Notice is hereby given that,under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of July, 1903, have been issued by the Administrator of the Government of the Province of Quebec, incorporating: René Beaudry, advocate, 235 Desaulniers Blvd.St-Lambert, Louis-Claude Trudel, advocate, 237 Bloomfield, Outremont, and Raymonde Vary, secretary, fille majeure, 3490 Joliette St., Montreal, for the following purposes: To carry on business as contractors in plumbing, heating, refrigeration, air conditioning and roof-making, under the name of \"Westmount Plumbing & Roofing (1963) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of a par value of $100 each an«l 360 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Westmount, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of July, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.3992 3051-63 \u2014 1180/134 Lettres patentes supplémentaires Association Sportive de Laval-Ouest Laval-West Sports Association Supplementary Letters Patent Association Sportive de Laval-Ouest Laval-West Sports Association Notice is hereby given that, under the provisions of the Quebec Companies Act, supplemen- Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été 4356 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1063, Tome 05, No 37 accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 17 juillet 1963, à la compagnie « Plage Laval Sports Association \u2014- Association Sportive de Plage Laval », constituée par lettres paient*-s en date du 27 octobre 1948, changeant son nom en celui de « Association S|M>r-tive de Laval-Ouest Laval-West Sports Association ».Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 17 juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.3992 6859-48\u2014 1184/46 The City Bag Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnie de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 29 mai 1963, à la compagnie « The City Bag Co.Ltd.», 1° réduisant son capital-actions de $400,000 à $300,000, le capital-actions annulé étant divisé en 1.000 actions privilégiées de $100 chacune; 2° si bdivisant et convertissant ses 7,500 actions ordinaires de $10 chacune en 742,500 actions catégorie « A » de $0.10 chacune et 7,500 actions ordinaires de $0.10 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29 mai 1963.Le Soux-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992 42529-53\u2014 1176/101 Club Seigneurie de Grand-Pré Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 9 août 1963, à la corporation « Associated Textile Social Club », constituée par lettres patentes en date du 19 octobre 1938, 1° changeant son nom en celui de « Club Seigneurie de Grand-Pré » ; 2° étendant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 9 août 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3992-0 2294-38 \u2014 1184/56 Salem Exploration Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières du Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 20 mars 1903, à la compagnie « Quebec Labrador Development Company Limited » (No Personal Liability), constituée en corporation par lettres patentes datées du 17e jour de janvier 1947, 1° changeant son nom en celui de « Salem Exploration Limited » (No Personal Liability); 2° diminuant son capital de $10,000,000 à $3,389,500, le capital-actions annulé étant divisé en 6,610,500 actions de $1 chacune; 3° augmentant son capital de $3,389,500 à $5,000,000, le capital-actions étant divisé en 1.610,500 actions de $1 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 3 septembre 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.-3992 1608-47\u2014 1173/37 tary letters patent, bearing date the 17th day of July, 1963, nave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to « Plage Laval Sports Association Association Sportive «le Plage Laval\", incorporate*! by letters patent dated the 27th day of October, 1948, changing its name to that of \"Association Sportive «le Laval-Ouest \u2014 Laval-West Sports Association\".(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of July, 1903.Raymond Dou villi;.Assistant Secretary of the Province, 3992-d 0859-48- 1184/4G The City Bag Co.Ltd.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of May, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"The City Bag Co.Ltd.\", 1.reducing its capital from $400,000 to $300,000, the capital stock annulled being divided into 1,000 preferred shares of $100 each; 2.subdividing and converting its 7,500 common shares of $10 each into 742,500 class \"A\" shares of $0.10 each an«l into 7,500 common shares of $0.10 each.(iiven at the office of the Provincial Secretarv, this 29th day of May, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-0 42529-53 \u2014 1176/101 Club Seigneurie de Grand-Pré Notice is given that under the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated August 9, 1963, to \"Associated Textile Social Club\", incorporated by letters patent dated October 19.1938, 1.changing its name to that of \"Club Seigneurie de Grand-Pré\"; 2.extending its powers.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of August, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992 m 2294-38 \u2014 1184/56 Salem Exploration Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that, under the provisions of the Quebec Mining Companies Act and of Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of March, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Quebec Labrador Development Company Limited\" (No Personal Liability), incorporated by letters patent dated the 17th day of January, 1947, 1.changing its name to that of \"Salem Exploration Limited\" (No Personal Liability); 2.reducing its capital from $10,000,000 to $3,389,500, the capital stock annulled being divided into 6,610,500 shares of $1 each; 3.increasing its capital from $3,389,500 to $5,000,-000, the additional capital stock being divided into 1,610,500 shares of $1 each.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 3rd day of September, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.3992-0 1608-47 - 1173/37 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, IMS, Vol.05.No.37 4357 Vista Investments Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi dss compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la lirovince de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 30 mai 1903, à la compagnie f Vista Investments Corporation», 1° diminuant son capital de $1.000,000 à $18,050.le capital-actions annulé étant divisé en 1,954 actions privilégiées catégorie « B » d'une valeur an pair de $500 chacune et en 4,950 actions catégorie « C » d'une valeur au pair de $1 chacune; 2° augmentant son capital de $18,050 à $218,050, le capital-actions additionnel étant divisé en 400 aetions privilégiées, catégorie « B » .l'une valeur au pair de $500 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, eeu raised against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of La hour: That the said decree, number 383, he amended as follows : Y.Paragraph \"it\" of article is I deleted.2.The first sub-paragraph of paragraph \"a\" of article II is replaced by the following: \"II.Jurisdiction: a) Professional jurisdiction: Those governed by the provisions of the «lecree shall he the employers; professional employers, artisans and wage-earners in garages, gasoline stations, service stations, scrapping yards, machine shops, vulcanizing and retreading shops.\" D.Tanguay, 4030-o Acting Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1481 Quebec, August 28.1963.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the approval of a by-law with regard to compensation for sick leave in the case of the departure or superannuation of a functionary.It is ordered, upon the recommendation of the Prime Minister: That the by-law of the Civil Service Commission, relative to compensation for sick leave, on the departure or superannuation of an employee, adopted on August 19, 1963, true copy of which is annexed to the present order in council, he approved in accordance with section 14 of the Civil Service Act; That the said regulations enter into force on the first day of the month which shall follow its publication in the Quebec Official Gazette.Jacques Premont, Associate Clerk of the Executive Chamber.The Civil Service Commission of the Province of Queliec, under the authority of sections 14 and 58 of the Civil Service Act, establishes the following by-law: Art.1 \u2014 The present by-law may be cite«l under the title of: lly-laic concerning sick leave.This applies, except for the reserves mentioned in article 17 to permanent and temporary functionaries whose work or functions are under the supervision of the Civil Service of the Province.Art.2 \u2014 In the present by-law, unless otherwise implied in the text, the won! : o) \"act\" means the Civil Service Act; 6) \"commission\" means the Civil Service Commission of the Province of Quebec; c) \"department\" includes the Department of Education, the Secretariat, of the Province, as well as any Commission, Board, Bureau, Office or any Organism whose personnel comes under the supervision of the Civil Service of the Province of Quebec; d) \"fiscal period\" means a period of twelve months included between April first of one year and March 31 of the following year during which the financial transactions of the Provincial Government are registered; 4302 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 96, No 37 e) « fonctionnaire permanent » désigne un titulaire qui occupe ses fonctions à service continu et pour une période indéterminée; /) « fonctionnaire temporaire » désigne un titulaire qui occupe ses fonctions à service continu ou limité et pour une période déterminée; g) « emploi à temps partiel » signifie un emploi n'exigeant du titulaire qu'un service a temps discontinu pour l'accomplissement de ses devoirs: .h) « emploi saisonnier » signifie un emploi dont la nature «lu service est telle qu'il ne dure pas toute l'année mais se ré|>ète chaque année; i) « emploi rémunéré à taux quotkjien » signifie un emploi dont la nature du service est telle «lu'il convient «le le rémunérer sur une base quotidienne; j) « emploi pour travaux st'ssionnels » signifie un emploi dont la nature «lu service est telle qu'il ne tlure que pendant les sessions de la Législature et se rattache directement à celles-ci; Art.3 \u2014 Tout fonctionnaire incapable de travailler pour cause «le maladie liénéficie d'un congé aux conditions ci-après mentionnées.Art.4 \u2014 Il est accordé à tout fonctionnaire un crédit d'une journée et quart (1M) par mois de service soit un nombre correspondant à quinze (15) jour de travail pour chaque exercice financier, et ce, à compter «le la «late «l'entrée en vigueur du pèsent règlement.Ces jours de maladie sont cumulatifs.Art.5 \u2014 H est accordé à tout fonctionnaire en service à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, et ce, pour faire un point de départ, les cré«lils «le jours «le maladie suivants: 1.Dans les ministères où il existe des records précis, ceux-ci serviront de base comme point de départ pour le nombre de jours à porter au crédit en congés de maladie à tel fonctionnaire; 2.Dans tous les autres cas, le fonctionnaire concerné devra faire la preuve des crédits qu'il réclame à la satisfaction de la Commission et du Conseil de la Trésorerie.Art.6 \u2014 Le congé de maladie ne sera accordé au fonctionnaire que sur production d'une preuve suffisante, démontrant qu'il lui est impossible de travailler.On acceptera une «léclaration écrite lorsque cette absence n'aura pas dépassé trois (3) jours consécutifs.Pour toute absence de plus de trois (3) jours consécutifs, le fonctionnaire devra produire un certificat médical.Le sous-chef pourra toutefois exiger un certificat médical pour toute absence d'une durée inférieure à trois (3) jours consécutifs s'il le juge nécessaire.Tout certificat médical devra être soumis dans les 7 jours qui suivront la première journée d'absence.Art.7 \u2014 Si la maladie se prolonge au-delà de la réserve accumulée au bénéfice «lu fonctionnaire, la Commission, sur une demande qui devra lui être pésentée par le sous-chef pourra accortler à tel fonctionnaire, aux conditions qu'elle déterminera, un congé sans traitement; toutefois, dans les cas spéciaux, le sous-chef pourra soumettre à la Commission une demande pour un congé avec traitement «lont ce fonctionnaire pourra bénéfùuer pourvu que ce congé soit chargé au compte des crédits à venir et n'excède pas soixante-six (66) jours «le travail ou trois (3) mois de calendrier.Art.8 \u2014 Il sera également loisible à un sous-chef de permettre à un fonctionnaire, et ce, à sa propre demande, d'utiliser, en tout ou en partie, des vacances auxquelles il a droit pour compenser ses absences pour cause de maladie dépassant les congés avec traitement prévus à cette fin.e) \"permanent functionary\" means a person who is on «luty continously ami for an indefinite period; /) \"temporary functi«>nary\" means a person who is on «luty for a continued or limited time and within a determined period ; g) \"part-time functionary\" means a person working for a certain period «>f time only; h) \"seasonal employ\" means employment which docs not last throughout the year because of its nature, but which occurs each year; t) \"daily paid employment\" means employment the nature of which is such as to put it on a daily basis; j) \"sessional employment\" means employment for the duration of the session only and deals directly with work pertaining thereto.Art.3 \u2014 Any functionary unable to work because of illness may obtain a leave of absence on the conditions mentioned below: Art.4 \u2014 All employees are credited with one day and one/quarter sick leave each month, i.e., fifteen (15) working days for each fiscal period.This starts from the entry into force of the present by-law.This sick-leave is cumulative.Art.5 \u2014 Any employee in service on the date of the entry into force of the present by-law is granted cre«lit for sick-leave, as follows: 1.In departments where proper records are kept, such records shall be used as a basis for the number of days to he place«l to the credit of sick-leave for such an employee; 2.In all other cases, the employee concerned shall prove to the satisfaction of the Commission and the Treasury Council the validity of the credits claimed; Art.6 \u2014 Sick leave shall he granted to an employee only upon production of sufficient proof attesting that he Is unable to work.A written «léclaration will l>e accepted in the case of three (3) successive days of absence.Any absence over three (3) consecutive days will require a medical certificate.The deputy-head may, however, require a medical certificate for any absence less than three (3) consecutive days, should he deem it necessary.Any medical certificate shall he submitted within the seven (7) days following the first day of absence.Art.7 \u2014 Should an illness be prolonged beyond the accumulated reserve of a functionary, the Commission, upon request to be made by the deputy-head, may grant such a functionary, on certain conditions to be tletermined, sick-leave without pay: however, in special cases, the fro y Marin.Secretary.401 l-o 10989-50 La Cie Univex (Que) Ltée La Cie Univex (Que) Ltée Avis est donné que « La Cie Univex (Que) Ltée », constituée en corporation par lettres r patentes le 1er jour de décembre 1960, ayant son une social établi à Hull, district de Hull, au No 25, rue St-Hyacinthe, a transporté son bureau à Aylmer, district de Hull, au No 90, Parker.À compter de la date de cet avis, ledit bureau M-ra considéré comme étant le siège social de la compagnie.Daté à Hull, district de Hull, ce 12e jour de juin 1962.Le Président, e established in Hull, district of Hull, at No.25 St.Hyacinthe Street, has moved it to Aylmcr, district of Hull, at No.90 Parker.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Hull, district of Hull, this 12th day of June, 1952.Maurick Ladouceur, 4012-o President.A.«X G.Fabrics Ltd.Notice is hereby given that \"A.& G.Fabrics Ltd.\", incorporated by letters patent under Part I of the Quebec Companies Act dated the eighteenth day of January, 1961, has changed the location of its head office to 195 Lou vain Street West, in the City of Montreal, P.Q.Dated this 31st day of May, 1963.Josef Glashot.4013-o President.Motel Lasalle Incorporée Avis est donné que la compagnie « Motel Lasalle Incorporée », constituée en corporation pur lettres patentes en date du 7 août 1963, et uyant son bureau principal dans la ville de Ri-vière-du-Loup a établi son bureau au numéro 262, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup.À compter de la date du présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Québec, ce 12ème jour d'août 1963.Motel Lasalle Incorporée Notice is hereby given that \"Motel Lasalle Incorporée\", incorporated by letters patent dated August 7, 1963, and having its head office in the town of Rivière-du-Loup, has established its office at number 262, Témiscouata St., Rivière-du-Loup.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Quebec this 12th day of August.1963.Leopold Levesque, 4019 President.J Le Président, 4019-o Leopold Levesque. 4374 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, H septembre 196S, Tome 95, fié 37 Abaca Inc.Règlement changeant le siège social de la Compagnie §) Qu'il soit et il est résolu unanimement que le siège social de la compagnie soit changé de Montréal à 962, rue Chaumont à Chambly, comté de Chambly.Copie certifiée du règlement adopté par les directeurs le 2 juillet 1963 et approuvé unamine-ment par les actionnaires à une assemblée spéciale convoquée à cette fin le 2 juillet 1963.La Secrétaire, Mme J.Conway.4020 233-63 Abaca Inc.By-law changing the head office of the Company Be it and it is hereby unanimously resolved that the head office of the company be changed from Montreal to 962, Chaumont St.in Chambly, county of Chambly.Certified copy of the by-law adopted by the directors on July, 2 1963, and unanimous I approved by the shareholders at a special meeting convoked for this purpose on July 2, 1963.Mus J.Conway, Secretary.4020-o 233-bM Savoie Frères Inc.Avis est donné que la compagnie « Savoie \" Frères Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 3 juillet 1963, a établi son bureau principal à Manseau, P.Québec. compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Manseau, ce 20e jour d'août 1963.Le Président, 4021-o J.Aldrbd Savoie.Savoie Frères Inc.Notice is given that \"Savoie Frères Inc.\", incorporated by letters patent dated July 3.1963 has established its head office in Manseau, P.Québec.From and after the date of this notice, Unsaid office is considered by the company as being its head office.Given at Manseau, this 20th day of August 1963.J.Alfred Savoie, 402 l-o President.Weather-Proofing Limited Règlement No 55 pourvoyant à un changement de situation du siège social « Attendu que le siège social de la compagnie, conformément au règlement No 53, était jusqu'à ce jour, situé à Montréal, P.Q.Attendu que la compagnie l'a transporté à 140, rue Deslauriers, St-Laurent, P.Q.En conséquence, qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de la compagnie ce qui suit: «Que le règlement No 53 soit et il est, par les Erésentes, révoqué et remplacé par le règlement Fo 55, selon lequel le siège social de la compagnie sera situé à 140, rue Deslauriers, St-Laurent, P.Q.» Copie conforme certifiée du règlement No 55, tel qu'adopté par une assemblée des directeurs tenue le 10 juillet 1963, et approuvé, ratifié et confirmé par le vote d'au moins les deux-tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée spéciale de « Weather-Proofing Limited », convoquée aux fins de considérer le règlement et tenue le 10 juillet 1963.Le Secrétaire, Arthur H.Patenaude.4022-o 4998-43 Canadian Bookclub Centre Ltd Avis est donné que f Canadian Bookclub Centre Ltd.», constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 17e jour de juillet 1963, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 2845, chemin Bates, en ladite cité. compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré comme étant le siège social de la compagnie.Daté à la cité de Montréal, ce 30e jour de juillet 1963.La Secrétaire, 4023 - Irene V.Spilka.Weather-Proofing Limited By-law No.65 providing for a change in location of the head office \"Whereas the head office of the company according to by-law No.53 was situated up until today at Montreal, P.Q.Whereas the company has moved to 140 Deslauriers Street St.Laurent, P.Q.Now then fore, be.it enacted and it is hereby enacted as a by-law of the company as follows: \"That by-law No 53 be and the same is hereby repealed and replaced by by-law No.55 by which the head office of the company shall be situated at 140 Deslauriers Street, St.Laurent, P.Q\" Certified a true copy of by-law No.55 as adopted by a meeting of directors held on July 10, 1963 and approved, ratified and confirme* 1 by the vote of at least two-thirds in value of the shares represented by the shareholders present at a special meeting of \"Weather-Proofim' Limited\", called for considering the by-law and held on July 10, 1963.Arthur H.Patenaude, Secretary.4022 4998-43 Canadian Bookclub Centre Ltd Notice is hereby given that \"Canadian Bookclub Centre Ltd\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies Act on the 17th day of July, 1963, and having its head office in the city of Montreal, in the said province, has established its office at 2845, Bates Road, in the said city.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at the city of Montreal, this 30th day of July, 1963.Irene V.Spilka, 4023-o Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, im.Vol.95, So.37 4375 La Corporation Desruisseaux \" Avis est donné que la compagnie « 1.11 Corporation Desruisseaux », constituée en corporation par lettres patentes sous la Loi des compagnies de Québec en date du 18e jour de juillet 1963, et ayant son bureau principal dans la cité de Sherbrooke, a établi son bureau au No 221, de la rue Dufferin.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Sherbrooke, ce 5e jour de Septembre 1963.Ia Secrétaire, 4024-o F.Edmund Barnakd.Lazare Investment Corp.Avis est donné que « Lazare Investment Corp.», constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec le 2e jour de juillet 1963, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 5430, Place Grove Hill, en ladite cité. compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré comme étant le siège social de la compagnie.Daté à la cité de Montréal, ce 7e jour d'août 1963.Le Secrétaire, 4031 Jack L.Lazakk.Leigh Investments (Montreal) Ltd.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « Leigh Investments (Montreal) Ltd.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 26e jour de juillet 1963, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en la province de Québec, a établi son bureau à 1155 ouest, boulevard Dorchester, Montréal, Québec.À compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal.Québec, ce fie jour de septembre 1963.(Sceau) Le Président, 4032 L.M.Bloom field, c.r.Made to Fit Garment Limited Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « Made to Fit Garment Limited », dûment constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, le 22 août 1951, a transporté son siège social à 9050, avenue du Parc, cité de Montréal.À compter de Is date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal, 6 septembre 1963.Le Procureur de la compagnie, 4033 Albert H.Malouf, c.r.Junior Deb Mfg.Ltd.Avis est donné que « Junior Deb Mfg.Ltd.», dûment constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, le 1er décembre 1951, a changé son siège social à 9050, avenue du Parc, cité de Montréal.À compter du présent avis ledit bureau sera considéré comme étant le siège social de la compagnie.Montréal, 6 septembre 1963.Le Procureur de la compagnie, 4034 Albert H.Malouf, c.r.Desruisseaux Corporation Notice is hereby given that \"Desruisseaux Corporation\", company incorporated by letters Eat eut.on the |18th day of July, 1963, and aving its head office in the city of Sherbrooke, has established its office at No.221, Dufferin Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Sherbrooke, this 5th day of September, 1963.F.Edmund Barnard, 4024-o Secretary.Lazare Investment Corp.Notice is hereby given that \"Lazare Investment Corp.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies Act on the 2nd day of July, 1963, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 5430 Grove Hill Place, in the said city.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by Uie company as being the head office of the company.Dated at the city of Montreal, this 7th day of August, 1963.Jack L.Lazare, 403l-o Secretary.Leigh Investments (Montreal) Ltd.Notice is hereby given that \"Leigh Investments (Montreal) Ltd.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act, on the 26th day of July, 1963 and having its head office in the city of Montreal, in the Province of Quebec, has established its office at 1155, Dorchester Boulevard West, Montreal, Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, Quebec, this 6th day of September, 1963.(Seal) L.M.Bloomfikld, q.c, 4032-o.President.Made to Fit Garment Limited Notice is hereby given that \"Made to Fit Garment Limited\", a body duly incorporated under the Quebec Companies Act on August 22, 1951, has changed its head office to 9050, Park Avenue, city of Montreal.From the date of the present notice the said office will be considered as the head office of the company.Montreal, September 6, 1963.Albert H.Malouf, q.c, 4033-o Attorney for the company.Junior Deb Mfg.Ltd.Notice is hereby given that \"Junior Deb Mfg.Ltd.\", a body duly incorporated under the Quebec Companies Act on December 1, 1951, has changed its head office to 9050, Park Avenue, city of Montreal.From the date of the present notice the said office will be considered as the head office of the company.Montreal.September 6, 1963.Albert H.Malouf, q.c, 4034-o Attorney for the company. 4376 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.14 septembre 1903, Tome 96, No 37 .Anjou Gardens Ltd Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « Anjou Gardens Ltd », constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 15e jour de juillet 1963, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 6999, Côte des Neiges.À compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par lu compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ee 13e jour d'août 1963.(Sceau) Le Secrétaire, 4035 P.F.Vineber.;.Anjou Gardens Ltd Notice is hereby given that \"Anjou Gardens Ltd\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies Act, on the 15th day of July, 1903, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 0999, Cote «les Neiges.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 13th day of August, 1903.P.F.VlNEBERG, 4035-o Secretary.Parino Inc.Avis est donné que la compagnie « Parino Inc.», constituée en corporation en vertu de la première partie «le la Ix>i des compagnies «le Québec, par lettres patentes en date du 13e jour «le juin 1963, a établi son siège social au numéro 9455, de la rue Dirval, en la cité «le Montréal, province de Québec.À compter «le la «late «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montreal, ce 17e jour «le juin 1963.Le Secrétaire-trésorier, 4055-o ANDRÉ GlBEAULT.René Duchesne Inc.Avis est donné que « René Duchesne Inc.», * été constituée en corporation dans la province de Québec par lettres patentes en «late du 14 mai 1963.Le siège social de la compagnie est situé à 575, 99e Avenue, à Pointe-aux-Trembles, district de Montréal, et constitue «'gaiement son principal bureau.Montréal, ce 5 septembre 1963.Bernard M.Desciiênes, 405K-o 40000*.Parino Inc.Notice is hereby given that \"Parino Inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act by letters patent dated the 13th day of June 1903.has established its head officefat 9455.Dirval Street, in the city of Montreal, provint* of Quebec.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Dated at Montreal, this 17th day of June 1903.Andre Gibeault, 4055-o Secretary-Treasurer.René Duchesne Inc.Notice is hereby given that \"René Duchesne Inc.\", incorporated in the Province of Quebec, by letters patent dated May 14, 1963.The head office of the company is situated at 575, 99th Avenue, at Pointe-aux-Trembles, district of Montreal, and which constitutes as its head office.Montreal.September 5, 1963.Bernard M.Deschenes, 4058 Attorney.Bedeeo Inc.Avis est donné que la compagnie « Bedeeo Inc.», a été constituée en corporation dans la province de Québec par lettres patentes en date du 14 mai 1903.Le siège social «le la compagnie est situé à 575.99e Avenue, Pointe-aux-Trembles, «listrict de Montréal, et constitue également son principal bureau.Montréal, ce 5 septembre 1963.Bernard M.Dkhchênes, 4059-o Avocat.Bedeco Inc.Notice is hereby given that \"Betleco Inc.\", incorporated in the Province of Quebec, by letters patent dated May 14, 1963.The head office of the company is situated at 575, 99th Avenue, at Pointe-aux-Trembles, district cf Montreal, and which constitutes its bead office.Montreal, September 5, 1963.Bkhnard M.Demchênkh, 4059 Attorney.La Petite Marquise Inc.Avis est donné que hi compagnie « La Petite Marquise Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date «lu 31 juillet 1963, et ayant son bureau principal dans la ville de Québec, a établi son bureau su numéro 1100.rue St-Jean, Québec.À compter de la date «lu présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Québec, ee Se jour d'août 1963.Le Président, 4060-o Rodrigue Bédard.La Petite Marquise Inc.Notice is given that \"La Petite Marquise Inc.\".incorporated by letters patent dated July 31, 1963, and having its head office in the city of Quebec, has established its office at number 1100, St-John Street.Quebec.From ami after the «late of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Quebec, this 5th day of August.1963.Rodrigue Bédard, 4060 President. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September I/,, 1968, Vol.95, So.87 4377 Lort Realty Corp « Avis est donné que la compagnie « Lort Realty Corp.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 14 novembre 1957 et ayant son bureau principal au numéro 1440, de la rue Towers à Montréal, a établi son bureau au uuméro 1405, de la rue Peel, à la chambre 300, à Montréal.» Extrait des minutes d'une assemblée des directeurs de la compagnie « Lort Realty Corp.», tenue à Montréal, le 20 août 1068.Copie conforme.(Sceau) Le Secrétaire, 4005-o Pau.Emile Hlain.Lort Realty Corp \"Notice is given that \"Lort Realty Corp.\", incorporated by letters patent dated November 14, 1957, and having its head office in the town of Montreal, 1440, Towers Street, has established its office at number 1405.Peel Street, Room 300, in the town of Montreal.\" Extract of the minutes of a meeting of directors of \"Lort Realty Corp.\", held in Montreal, on August 20, 1903.True copy.(Seal) Pail Emile Hlain, 4065-o Secretari/.Demandes à la Législature Martin Frederick Juister Avis est par les présentes donné que « Martin Frederick Juister », gérant, de la cité et district de Montréal, s'adressera à la Législature de la Province de Québec, au cours de sa procliaine session, pour l'adoption d'une loi changeant son nom de Martin Frederick Juister à Martin Frederick Jus ter.Montréal, le 19 août, 1903.Le Procureur du requérant, 385A-34-4-0 Frank M.Godine, c.r.Le Club de Golf Larrimac Inc.Avis est par les présentes donné que « Le Club de Golf Larrimac Inc.», du district de Hull (bureau de poste de Kirk's Ferry) s'adressera à l'Assemblée législative de la Province de Québec, au cours de la présente session, afin de faire adopter une loi qui accordera à cette corporation des pouvoirs spéciaux et l'incluera dans la partie LT de la Loi des Sociétés du Québec au lieu de la partie I de cette loi.Hull, P.Q., ce 26e jour d'août 1963.Le Club de Golf Larrimac Inc.Le Secrétaire, 3929-35-4-0 L.F.Mundt.Liquidation \u2014 Avis de Applications to Legislature Martin Frederick Juister Notice is hereby given that \"Martin Frederick Juister\", executive, of the city and district of Montreal in the Province of Quebec, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its next session for the passing of an act to change his name from Martin Frederick Juister to Martin Frederick duster.Montreal, August 19, 1903.Frank M.Gooink, q.c 3854-34-4-0 Solicitor for the petitioner.The Larrimac Golf Club Inc.Notice is hereby given that \"The Larrimac Golf Club Inc.\", of the district of Hull (Kirk's Ferry Post Office) .will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act granting the Corporation special powers and providing that it be governed by Part II of the Quebec Companies Act instead of by Part I of the Act.Hull, P.Q., this 26th day of August, 1963.The Larrimac Golf Club Inc.L.F.Mundy, 3929-35-4-o Secretary.Winding up Notice Les Entreprises Nadon Ltée Avis est donné que la compagnie « Les Entreprises Nadon Ltée », constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes, en date du 23 décembre 1958, et dont le siège social était situé à Fabrevflle, a été dissoute le 3 septembre 1963, conformément aux dispositions de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 278).Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 6 septembre 1963.Le Sou*-#ecrétaire[de la province, Raymond Douville.4028-o 11674-58 Les Entreprises Nadon Ltée Notice is hereby given that \"Les Entreprises Nadon Ltée\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act by letters patent dated December 23, 1958, and the head office of which is situated in Fabreville, was dissolved on September 3, 1963, pursuant to the provisions of the Winding-up Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 278).Given at the office of the Provincial Secretary, on September 6.1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.4028 11674-58 4378 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 14 septembre 1963, Tome 95, So 37 Ministère des Finances Assurances La Protection Universelle, Compagnie d*Assurances Universal Protection Insurance Company Avis est donné qu'en vertu de la Loi des assurances de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29ème jour de juillet 1963, constituant en corporation: messieurs André Bédard, homme d'affaires, des cité et district de Québec, Amédée Demers fils, industriel, de la cité de Sillery, district de Québec, Jean-H.Gagné, conseiller en loi de la Reine, de la cité de Ste-Foy, «listrict de Québec, Charles La-gueux, industriel, «le la cité «le Sillery, district de Québec, Conrad Leblanc, homme d'affaires, de la cité de Sillery, district de Québec, Clément Renaud, évaluateur conseil, de la cité de Sillery, district de Québec, et Guy Renaud, comptable général licendié, de la cité de Ste-Foy, district de Québec, tous de la province de Québec, dans le but d'exercer le commerse «l'assuramxs générale, sauf l'assurance et la réassurance sur la vie, et de réaliser «les opérations d'assurance et de réassurance relatives aux catégories suivantes: accidents du travail, automobile, aviation, bétail, bris de glace, cautionnement, chaudière à vapeur, crédit, cylone, défectuosité de gicleurs automatiques, dommages aux biens, explosion, faux, fidélité, garantie, grêle, incendie, industrielle, intempéries et autres forces de la nature, loyer, machinerie, maladie, maritime océanique, navigation intérieure, outillage, responsabilité, transport intérieur, vol, sous le nom de « La Protection Universelle, Compagnie d'Assurances \u2014 Universal Protection Insurance Company », avec un capital total d'un million de dollars ($1,000,000.00) divisé en dix mille (10,000) actions d'une valeur au pair de cent «lollars ($100.00) chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29ème jour de juillet 1963.Le Sous-secrétaire de la province, 3992-o Raymond Douville.The Canada Accident and Fire Assurance Company La Compagnie d'Assurance contre les Accidents et l'Incendie du Canada Avis de changement de nom Avis est donné, par les présentes, que «The Canada Accident and Fire Assurance Company », constituée en corporation le 23 juin 1887, par la Loi 50-51 Victoria, chapitre 106, et ses amendements, et enregistrée dans la Province sous le numéro 8, peut faire affaires soit sous le nom de « The Canada Accident and Fire Assurance Company » ou sous le nom de « La Compagnie d'Assurance contre les Accidents et l'Incendie du Canada », tel qu'il est prévu à l'article I du Bill S-33 du Parlement du Canada, sanctionné le 2 août 1963.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 28 août 1963.Pour le Ministre des finances, de la Province, Le surintendant des assurances, 3994-0 Gustave-E.Tremblay, ca.Department of Finance Insurance Universal Protection Insurance Company La Protection Universelle, Compagnie d'Assurances Notice is hereby given that under the Quebec Insurance Act, letters patent, dated the 29th day of July, 1963, have been issued by the Lieutenant-Govenor in Council of the Province of Quebec, incorporating: André Bédard, business man, of the city and district of Quebec, Amédée Demers junior industrialist, of the city of Sillery, district of Quebec, Jean-H.Gagné, Queen's counsel, of the city of Ste.Foy, «listrict of Quebec, Charles Lagueux, industrialist, of the city of Sillery, district of Quebec, Conrad Leblanc, business man, of the city of Sillery, district of Quebec, Clément Renaud, consulting appraiser, of the city of Sillery, district of Quebec, and Guy Renaud, certified general accountant, of the city of Ste.Foy, district of Quebec, all domiciled in the Province of Quebec, for the purpose of carrying on the business of general insurance, except life insurance and reinsurance, and for the object of carrying on operations of insurance and reinsurance of the following classes:'accident, automobile, aviation, livestock, plate glass, suretyship, steam boiler, credit, tornado, sprinkler leakage, damage to property, explosion, forgery, fidelity, guarantee, hail, fire, industrial, weather, rent, machinery, sickness, marine, ocean marine, inland marine, equipment, liability, inland transportation, house-breaking our burglary, under the name of \"Universal Protection Insurance Company \u2014 La Protection Universelle, Compagnie d'Assurances\", with a total capital of one million dollars ($1,000,000.) divided into ten thousand (10,000) shares of a par value of one hundred «lollars ($100) each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of July, 1963.Raymond Douville, 3992-o Assistant Secretary of the Province.The Canada Accident and Fire Assurance Company La Compagnie d'Assurance contre les Accidents et l'Incendie du Canada Soticc of change of name Notice is hereby given that \"The Canada Accident and Fire Assurance Company\", incorporated the 23rd of June 1887, Act 50-51 Victoria, chapter 106, and its amendments, and registered in the Province under number 8, may use, in the transaction of its business, either the name of \"The Canada Accident and Fire Assurance Company\" or the name of \"La Compagnie d'Assurance contre les Accidents et l'Incendie du Canada\", pursuant to the provisions of section I of Bill S-33 of the Parliament of Canada assented to on the 2nd of August, 1963.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 28th of August 1963.For the Minister of Finance, of the Province, Gustave-E.Tremblay, ca., 3994-0 Superintendent of Insurance, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1968, Vol.95, So.87 4379 Département de l'Instruction publique Paspébiac « Prot.» et Cox « Dûs.» Demande est faite de fusionner le territoire actuellement sous la juridiction des commissaires d écoles pour la municipalité de Cox, dans le comté de Bonaventure, et des syndics d'écoles pour la municipalité de Paspébiac, dans le même comté, pour l'ériger en municipalité scolaire distincte, pour les protestants seulement, sous le nom de « Chaleur Bay », dans le comté de Bonaventure.Le territoire de cette nouvelle municipalité scolaire protestante comprend: tout le canton Hope, les municipalités de Paspébiac, Paspébiac -Ouest, New-Carhsle et cette partie de la paroisse de St-Bonaventure-de-Hamilton située au sud d'une ligne divisant les rang VU et VIII ouest du canton Cox et à l'est de la rivière Bonaventure, moins le rang sud-est de la rivière Bonaventu- Québec, le 28 août 1963.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.-J.Desaulniebb.3948-36-2-0 484-63 Amtfield Demande est faite d'annexer à la municipalité scolaire de Arntfield, dans le comté de Rouyn-Noranda, le territoire du canton Desserat, non encore organisé au poin t de vue scolaire.Québec, le 29 août 1963.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.-J.Desaulniers.3967-36-2-0 791-63 Canton Cartier Demande est faite d'annexer à la municipalité scolaire de St-Côme, dans le comté de Joliette, les rangs HI et XI inclusivement du canton Cartier, territoire non encore organisé au point de vue scolaire.Québec, le 30 août 1963.Le Surintendant de l'InstrueHn publique, O.-J.Desaulniers.3972-36-2-0 932-63 Ville de Beloeil Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil numéro 1501, en date du 4 septembre 1903, d'annexer le territoire actuel de la commission scolaire de la « Paroisse de Beloeil, dans le comté de Verchères » à la municipalité scolaire de la « Ville de Beloeil, dans le même comté ».Ce changement prendra effet pour fins d'élection le premier juin 1964 et pout toutes autres fins le premier juillet 1964.Québec, le 10 septembre 1963.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.-J.Desaulniers.4056-o 746-63 Leclerc ville Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil numéro 1501, en date du 4 septembre 1963, d'annexer le territoire actuel de la commission scolaire de « Ste-Emmelie, dans le comté de Lotbinière » à la municipalité scolaire de « Leclercville, dans le même comté ».Department of Education Paspébiac \"Prot.\" and Cox \"Diss/* Application is made to amalgamate the territory presently under the juriciction of the school commissioners for the municiaplity of Cox, in the county of Bonaventure, and the school trustees for the municipality of Paspébiac, in the same county, to erect it into a separate school municipality, for Protestants only, under the name of \"Chaleur Bay\", in the county of Bonaventure.The territory of this new Protestant school municipality includes: all the township of Hope, the municipalities of Paspébiac, Paspebiac-West, New-Carlisle and that part of the parish of St-Bonaventure-de-Hamilton situated on the south of a line dividing the ranges VII and VIH west of the township of Cox and on the east of the Bonaventure River, less the southeast range of the Bonaventure River.Quebec, August 28,1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.3948-36-2 484-63 Arntfield Application is made to annex to the school municipality of Amtfield, in the county of Rouyn-Noranda, the territory of the township of Desserat, not as yet organ wed from an educational point of view.Quebec, August 29, 1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.3967-36-2 791-63 Township of Cartier Application is made to annex to the school municipality of St-Côme, in the County of Joliette, Ranges III and XI inclusively in the Township of Cartier, a territory not yet organized from a school point of view.Quebec, August 30,1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.3972-36-2 932-63 Town of Beloeil The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council number 1501, dated September 4, 1963, to annex the present territory of the school commission of the \"Parish of Beloeil, in the county of Verchères\" to the school municipality of the \"Town of Beloeil, in the same county\".This change will take effect for election purposes on the first of June, 1964, and for all other purposes on the first of July, 1964.Quebec, September 10, 1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.4056 746-63 Leclercville The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council number 1501, dated September 4, 1963, to annex the present territory of the school commission of \"Ste-Emmelie, in the county of Lotbinière\" to the school municipality of \"Leclercville, in the same county\". 4380 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1968, Tome 95, No 87 Ce changement a pris effet le 4 septembre 1903.Québec, le 9 septembre 1963.Le Surintendant de l'Instruction publique, o.-J.Desaulniers.405(5-0 111 03 Ville de Candiac « Prot » Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1482, en date «lu 28 août 1903, «le détacher de la municipalité scolaire protestante de (ireater Laprairie.dans le comté «le Napier-ville-Laprairie, le territoire «le la ville «le Candiac, dans le comté de Napierville-Laprairie, tel que décrit dans la section 2 du chapitre 100 «le la loi 7-8 Elizabeth II et l'ériger en municipalité scolaire distincte, pour les protestants seulement, sous le nom «le « Ville de Candiac »», «lans le comté de Napierville-Laprairie.Ce changement a pris effet le 28 août 1903.Québec, le 10 septembre 1963.Le Surintendant de V Instruction publique, O.-J.Desaulniers.4050-o 547-03 This change took effect on September 4, 1063.Quebec, September 9, 1068.O.-J.Desaulniehs, Superintendent of Education.4056 111-03 Town of Candiac \"Prot\" The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1482, dated August 28, 1963, to detach from the Protestant school municipality of (ireater Laprairie, in the county of Napierville-Laprairie, the territory of the town of Candiac, in the county of Napierville-Laprairie, as described in article 2 of chapter 106 of the Act 7-8 Elizabeth II and to erect it into a distinct school municipality, for the Protestants only, under the name of \"Ville de Candiac\", in the county of Napierville-Laprairie.This change took effect on August 28, 1963.Quebec, September 10, 1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.4056 547-63 Ville St-François Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil numéro 1500, en date «lu 4 septembre 1963, de changer le nom de la municipalité scolaire de St-François-de-Sales, dans le comté de Laval, en celui «le « Ville St-François, dans le comté de Laval ».Ce changement prendra effet le 22 septembre 1963.$M Québec, le 9 septembre 1963.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.-J.Desaulniers.4050-o 899-63 Town St-François The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council number 1500, dated September 4, 1963, to change the name of the school municipality of St-François-de-Sales, in the county of Laval, to that of \"Town of St-François, in the county of Laval\".This change will take effect on September 22.1963.Quebec, September 9, 1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.4050 899-6.5 St-Noël Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil numéro 1501.en date du 4 septembre 1903, de changer le nom de la municipalité scolaire du village de St-Noël, dans le comté de Matapédia, en celui de « St-Noël, dans le même comté ».Ce changement prendra effet le 22 septembre 1903.Québec, le 10 septembre 1903.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.-l.Desaulniers.405G-o 911-03 Clarendon Demantle est faite de détacher de la municipalité scolaire de Claremlon, dans le comté de Pontine, les lots 276 et 286 du rang IV, 28a et 286 du rang V, tous du canton Litchfield, pour les annexer, pour les protestants seulement, à la municipalité scolaire protestante de Campbell's Bay, dans le même comté.Québec, le 4 septembre 1903.Le Surintendant de V Instruction publique, O.-J.desaulnier8.4027-2-o 397-63 St-Noël The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council number 1501, dated September 4, 1963, to change the name of the school municipality of the village of St-Noël, in the county of Matapédia, to that of \"St-Noël, in the same county\".This change will take effect on September 22.1963.Quebec, September 10, 1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.4050 911-63 Clarendon Application is made to detach from the school municipality of Clarendon, in the county of Pontiac, lots 276 and 286 on range IV, 28a ami 286 on range V, all in the township of Litchfield, in order to annex them, for Protestants only, to the Protestant school municipality of Campbell Bay, in the same county.Quebec, September 4, 1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.4027-2 397-0* He Bonaventure Avis est par la présente donné, que je me propose, en vertu des dispositions de l'article 71-B de la loi de l'Instruction publique, de soumettre au lieutenant-gouverneur enjeonseil, l'annexion Ile Bonavnture Notice is hereby given that I intend to submit, pursuant to the provisions of section 71-B of the Education Act, to the Lieutenant-Governor in Council, the annexation of the present territory QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1983, Vol.96, So.37 4381 du territoire actuel de la commission scolaire de l'Ile Bonaventure, dans le comté de Gaspé-Sud, à celle de Percé, dans le même comté.Québec, le 9 septembre 19(13.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.-J.Dk.hai i.niekh.4041-2-o 908-68 of the school commission of Ile Bonaventure, in the county of Gaspé-South, to Percé, in the same county.Quel>ec.September 9.1963.O.-J.Dehaulniers, Superintendent of Education.4041-2 998.(53 Ministère des Terres et Forêts Cadastre Village d'Amos ( :l( last re officie I du village d'Amos, municipalité de la ville d'Amos, division «l'enregistrement d'Abitibi.Avis est par la présente donné que les lots 1 à 24 Bloc 42-a, 1 à 24 Bloc 42, 1 à 24 Bloc 44, 1 à 24 Bloc 44-a, 1 à 24 Bloc 47-a et 1 à 24 Bloc 52-a sont annulés et les lots 26 à 35 Bloc 42, 26 à 35 Bloc 42-a, 26 à 35 Bloc 44, 26 à 35 Bloc 44-a, 26 à 35 Bloc 47-a, 26 a 35 Bloc 52-a sont ajoutés en vertu de l'article 2174A, du Code civil.Quélxc le 19 août 1963.Le Sous-ministre, 3093-o Fernand Boutin.Paroisse de Boucherville Cadastre officiel «le la paroisse de Boucherville.municipalité de la ville de Boucherville, division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 27-1 et la partie restante du lot 27_-l-2 sont annulées en vertu de l'article 2174A, du Code civil.Québec, le 29 août 1963.Le Sous-ministre, 3993-o Fkrnand Boutin.Paroise de Charlesbourg Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, municipalité de cité de Charlesbourg, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 793-8 à 793-16 sont annulés en vertu de l'article 2174A, du Code civil.Québec, le 26 août 1963.Le Sous-ministre, 3993-u Fkrnand Boutin.Paroisse de Sault-au-Bécollet Cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet, municipalité de cité de St-Michel, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 348-74 à 348-146, 349-55 à 349-95, 355-71 à 355-102, 348-1-154 à 348-1-293, 349-1-131 à 349-1-201, 355-1-174 à 355-1-227 sont annulés en vertu «le l'article 2174A, du Code civil.Québec, le 3 septembre 1963.Le Sous-ministre, 3993-o Fern and Boutin.Paroisse de Ste-Agathe-des-Monts Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Agathe-des-Monts, municipalité de ville de Ste-Agathe-des-Monts, division d'enregistrement de Terrebonne., Department of Lands and Forests Cadastre Village of Amos Official cadastre of village of Amos, municipality of ville of Amos, registration division of Abitibi.Notice is hereby given that lots 1 to 24 Block 42-a, 1 to 24 Block 42, 1 to 24 Block 44.1 to 24 Block 44-a, 1 to 24 Block 47-a and 1 to 24 Block 52-a are cancelled and lots 26 to 35 Block 42, 26 to 35 Block 42-a, 26 to 35 Block 44, 26 to 35 Block 44-a, 26 to 35 Block 47-a, 26 to 35 Block 52-a are a«lded in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec.August 19, 1963.Fern and Boutin, 3993-o Deputy-minister.Parish of Boucherville Official cadastre of the parish of Boucherville, municipality of the town of Boucherville, registration division of Chambly.Notice is hereby given that a part of lot 27-1 and the remaining part of lot 27-1-2 are cancelled in virtue of Article 2174A, of the Civil Cotle.Quel>ec August 29, 196?.Fern and Boutin, 3993 -o Deputy-m in ister.Parish of Charlesbourg Official cadastre of the parish of Charlesbourg, municipality of city of Charlesbourg, registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 793-8 to 793-16 are cancelled in virtue of article 2174A, of the Civil Cec et «le Levis et le territoire compris dans un rayon de cinquante (50) milles de leurs limites, lui ont présenté une requête à l'effet «le soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: Section I 1° l'article 13 sera remplacé par le suivant: « 13.Ix' terme « commis vendeur » désigne tout salarié préposé principalement à la vente des marchandises, soit au comptoir, soit dans l'entrepôt, soit au téléphone 11 comprend également les techniciens en alimentation (merchandiser), dessinateurs, publicistes, etc., s'occupant «le la promotion «tes ventes «le produits «l'alimentation «lans les épiceries.» 2° L'article 18 sera biffé.3° L'article 23 sera remplacé par le suivant: « 23.Le terme « homme général » désigne le salarié qui exécute un travail de manoeuvre ou tout autre travail non»aut renient classifié.» 4° L'article 29 sera remplacé par le suivant: « 29.Le terme « salarié assujetti au travail de nuit» désigne le saline dont la majorité des heures de travail s'exécute en dehors «les heures normales prévues par le présent décret pour la journée régulière de travail «lans les établissements assujettis et qui, en outre, ne fait pas partie «les équipes de jour.La durée «les heures normales de travail d'un salarié assujetti au travail «le nuit ne pourra excéder 10 heures.Au-delà «le telle limite, le salarié sera rémunéré au taux de salaire et demi basé sur son salaire régulier.» 5° L'article 38 sera remplacé par le suivant: « 38.Le terme « personnel de maîtrise » désigne les salariés de l'établissement ayant un rang supérieur à celui «le contre-mattre et de comptable et recevant un salaire régulier de $100.00 ou plus par semaine.Ce terme désigne et comprend, en particulier le gérant de la production, le gérant des ventes, le gérant des achats, le contrôleur, le chimiste, le chef comptable et le chef de bureau.Cependant, il ne peut y avoir plus d'un salarié pour chacune de ces catégories dans un même établissement.» 6° L'article 47 sera remplacé par le suivant: « 47.Exceptions: Sont exclus de la juridiction commerciale de la présente section du présent décret, les établissements suivants: i.Les laiteries, les !>eurrerics et fromageries, c'est-à-dire les établissements dont l'occupation principale est la transformation du lait en beurre ou en fromage.ii.Les couvoirs et les postes de mirage dont les produits sont distribués principalement (75%) aux établissements commerciaux de gros ou demi-gros de l'alimentation.iii.Les établissements faisant le commerce des animaux vivants et les boucheries dont les ventes s'effectuent en dehors des établissements commerciaux.iv.Les établissements dont le commerce principal est le commerce en gros ou en demi-gros de poissons, fruits et légumes.» 7° Les mots « quarante-deux (42) heures » apparaissant au deuxième alinéa du paragraphe f a » de l'article 49 seront remplacés par les mots 1 quarante-cinq (45) heures ».(R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree number 2347 of June 27, 1944 and amendments, relating to the food prcducts manufacturing and wholesale trade in the cities of Quebec and Levis and a radius of fifty (50) miles from their limits, have petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said «lecree: Section I 1.Article 13 will be replaced by the following : \"13.The words \"sales clerk\" mean any employee whose work consists mainly in selling goods, at the counter, by telephone or in the warehouse, and also include merchandisers, draftsmen, publicists, etc., doing food products safe promotion in groceries.\" 2.Article 18 will be deleted.3.Article 23 will be replaced by the following : \"23.The words \"general hand\" designate a person doing labourer's work, or any work not otherwise classified.\" 4.Article 29 will be replaced by the following: \"29.The term \"employee doing night work\" means an employee whose hours are worked mostly beyond the standard hours established in the decree for the standard work day in the establishments governed by the said «lecree and who is not included in the day shifts.The regular hours of work of such employee doing night work shall not exceed 10 hours.Beyond that limit, the employee shall be paid at the rate of time and one half based on his regular rate of pay.\" 5.Article 38 will be replaced by the following: \"38.The words \"administration personnel\" mean the employees of an establishment occupying positions above the rank of foreman and accountant and earning a regular salary of $100.00 or more per week.These words specially include the production manager, the sales manager, the purchasing department manager, the controller, the chemist, the chief accountant and the office chief clerk.However, there shall not he more than one employee for each one of these catégories in the same establishment.\" 6.Article 47 will be replaced by the following : \"47.Exceptions: The following establishments are excluded from the commercial jurisdiction of the present section of this decree : i.Dairies, butter-dairies, cheese-dairies, i.e.all establishments where the main occupation is to turn milk into butter or cheese.ii.Incubating and candling establishments the products of which are distributed mainly (75%) to the food products wholesale or part wholesale commercial establishments.iii.Establishments dealing in live stock and slaughterhouses selling mostly to other than commercial establishments.iv.Establishments engaged mainly in the wholesale or part wholesale trade of fish, fruits and vegetables.\" 7.The words \"forty-two (42) hours\" appearing in the second sub-paragtaph of paragraph \"a\" of article 49 will be replaced by the words \"forty-five (45) hours.\" \u2022 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol 96, So.37 48SS s.L'article 52 sera remplacé par le suivant: « 52.Salarié» du personnel de maîtrise: Seuls les s-ilariés du personnel de maîtrise d'un établissement répondant aux exigences de l'article 38 .sont exclus de la juridiction du décret.» 9° L'article 58 sera biffé.10° Les mots « Vendredi-Saint après-midi » apparaissant à l'article M) seront remplacés par les mots « une demi journée le Vendredi-Su hit ».11° L'article 64 sera remplacé par le suivant: « 64.a) Dans le cas d'un salarié qui a moins d'un an de service au 30 avril de chaque année, celui-ci aura droit à des v.'icances équivalentes à une demi-journée par mois de service qui doivent lui être accordées entre le 15 mai et le 15 octobre de la même année et lui être rémunérées à 2% du salaire gagné.b) Dans le cas du départ d'un salarié, l'employeur doit payer les vacances dues sur la base de 2% du salaire gagné.» 12° L'article 67 sera remplacé par le suivant: « 67.Toute entente constituant une renonciation par le salarié à ses vacances sera nulle et n'aura nul effet,- et le salarié nonobstant telle entente devra recevoir le double de la rémunération de ses vacances en plus de la rémunération déjà reçues.» 13° L'article 68 sera remplacé par le suivant: « 68.Toute entente aux fins d'octroyer audit salarié des vacances à une période autre que celle prévue au présent décret, sauf dans le cas du mariage de l'employé, sera nulle et sans effet et nonobstant telle entente, le salarié devra recevoir la rémunération de ses vacances en double.» 14° L'article 71 sera remplacé par le suivant: « 71.Les taux de salaires minima suivants doivent être payés aux salariés des catégories ci-après mentionnées pour la semaine régulière du travail : Par semaine Per week 1 II III 1.Abatteur-désosseur \u2014 Slaughterer-boner.$59.50 $52.85 $50.65 2.Boucher-désosseur \u2014 Butcher-boner: Apprenti \u2014 Apprentice: 1er semestre \u2014 1st six months.46.00 41.40 43.05 2e semestre \u2014 2nd six months.50.00 44.80 43.05 2e année \u2014 2nd year.54 00 48.20 46.25 Durant et après la 3e année \u2014 During and after 3rd year.60.00 53.30 51.05 Qualifié (avec certificat) \u2014 Competent (certificated).65 00 57.55 45.05 Contremaître \u2014 Foreman.69.00 60.95 58.25 3.Charcutier \u2014 Pork-butcher: Apprenti \u2014 Apprentice: 1er semestre \u2014 1st six months.46.00 41.40 39.85 2e semestre \u2014 2nd six months.50.00 44.80 43.05 2e année \u2014 2nd year.54.00 48.20 46.25 Durant et après la 3e année \u2014 During and after 3rd year.60.00 53.30 51.05 Qualifié (avec certificat) \u2014 Competent (certificated).65.00 57.55 55.05 Assistant-contremaître \u2014 Assistant-foreman.67.00 59.25 56.65 Contremaître \u2014 Foreman.69.00 60.95 58.25 4.Chef de département dans les maisons de salaison et les charcuteries \u2014 Departmental manager in packing houses and pork-butcheries.79.00 69.45 66.25 5.Chef de département dans les maisons de salaison et les charcuteries - (département des petites marchandises) \u2014 Departmental manager in packing houses and pork-butcheries (small goods department).72.00 63.50 60.65 6.Cuiseur et presseur des aliments du bétail \u2014 Feeding meat cook and presser.61.50 54.55 52.25 7.Homme préposé à la salaison \u2014 Dry-curer: Apprenti \u2014 Apprentice: 1er semestre \u2014 1st six months.46.00 41.40 39.85 2e semestre \u2014 2nd six months.50.00 44 80 43.05 2e année \u2014 2nd year.54.00 48.20 46.25 Durant et après la 3e année \u2014 During and after 3rd year.60.00 53.30 51.05 Qualifié (avec certificat) \u2014 Competent (certificated).65.00 57 55 55 05 Contremattre \u2014 Foreman.69.00 60.95 58.25 8.Article 52 will l>e replaced by the following: \"52.Administration personnel: The employees of the administration personnel alone, as defined in article 38, shall be excluded from the jurisdiction of the decree.\" 9.Article 58 will be deleted.10.The words \"Cood Friday afternoon\" appearing in article 60 will be replaced by the words \"a half day off on Cood Friday\".11.Article 64 will be replaced by the following : \"64.a) Regular employees having less than one year of service on April 30 of one year shall be tnt it led to a vacation period of one half day (Vi) per month of service; such vacation-shall be granted to the employee between May 15 ami Octol>er 15 of the same year and remunerated at the rate of 2% of the wages earned.b) Should employees leave their employer, the latter shall pay their vacation on the basis of 2% of the wages earned.\" 12.Article 07 will lie replaced by the following: \"07.Any agreement by which an employee waves his rights to the vacation shall be null and void and the employee, notwithstanding such agreement, shall be paid double his vacation pay in excess of the remuneration already received.\" 13.Article 68 will be replaced by the following: \"68.Any agreement entered into for the purpose of granting vacation at a period other than that determined in the decree, except in the event of the marriage of the employee, shall be null and void and, notwithstanding such agreement, the employee shall receive double his vacation pay.\" 14.Article 71 will be replaced by the following: \"71.The following minimum wage rates shall be paid to the employee of the categories hereafter mentioned, for the regular work week: 4380 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1968, Tome 95, No 37 Par semaine Per week 8.Chef tir département (à l'exception des maison» de salaison et des / // /// charcuteries) \u2014 Department manager (excepting packing houses aud pork-butcheries.101.50 $54.55 152.25 9.a) Classificalcur d'oeufs; salarié du sexe masculin ou féminin manipu- lant ou transportant à la fois des marchandises pesant plus de 35 livres \u2014 Kgg grader: Male employee or female employee handling goods weighing more than 35 pounds: Premiere année - First year.52.00 40.50 44 05 1 )euxicme année \u2014 Second year.54.00 48.20 40.25 Troisième et quatrièmes années \u2014 Third and fourth years.50.00 49.90 47.85 Cinquième année et plus \u2014 Fifth year and thereafter.00 00 53 30 51.05 In Classificatcur d'oeufs: salariée du sexe féminin ne manipulant ou ne transportant à la fois aucune marchandise pesant plus de 35 livres Kgg grader: Female employee not handling goods weighing more than 35 pounds : Première année \u2014 First year.44.00 39.70 38.25 I )euxième année \u2014 Second year.*.46.00 41.40 39.85 Troisième et quatrième années \u2014 Third and fourth years.49.00 43.95 42.25 Cinquième année et plus \u2014 Fifth year and thereafter.52.00 40.50 44.05 10.Conditionneur de beurre et fromage \u2014 Butter and cheese conditioner.62.00 55.00 52.05 11.Conducteur de camion et autres véhicules automobiles \u2014 Motor vehicles driver.59.50 52.85 50.05 12.Contremaître premier expéditeur \u2014 Foreman - head shipper .63.50 50.25 53.85 13.Assistant-contremaître, assistant-premier expéditeur \u2014 Assistant-fore- man, assistant-head shipper.61.50 54.55 52.25 14.Coupeur de »>eurre \u2014 Butter cutter.54.00 48.20 40 25 15.Enveloppeur et empaqueteur de beurre \u2014 Butter wrapper and packer.49.00 43.95 42.25 10.Gardien de.nuit, (minimum pur semaine) \u2014 Night watchman (minimum per week).51.00 45.65 43.85 (Par heure) \u2014 (Per hour).1.00 0.90 0.80 17.Garçon junior \u2014 Junior employee.44.00 39.70 38.25 18.Homme général, autre que celui des maisons de salaison et les charcu- teries \u2014 General hand, not in packing houses and pork-butcheries: Moins de 17 ans, 1er trimestre \u2014 Under 17 years of age, first three months.40.00 41.40 39.85 Après trois mois de service \u2014 After three months of service.49.00 43.95 42.25 17 ans révolus \u2014 17 years of age.51.00 45.65 43.85 18 ans révolus \u2014 18 years of age.54.00 47.50 46.25 19 ans révolus \u2014 19 years or older.57.50 51.15 49 05 19.Homme général, maisons de salaison et les charcuteries \u2014 General hand, packing houses and pork-butcheries.60.00 53.30 51.05 20.Homme préposé aux commandes, homme de plancher \u2014 Order em- ployee, receiving clerk.59.50 52.85 50.65 21.Meunier ou homme en charge des malaxeurs \u2014 Miller or mixer operator.61.50 54.55 52.25 22.Personnel féminin d'entrepôt ne faisant pas partie du personnel de bureau (à l'exception des maisons de salaison et des charcuteries) \u2014 Warehouse female personnel not included in the office staff (excepting packing houses and pork-butcheries) : 1ère année \u2014 First year.43.00 38.85 37.45 Durant et après la 2e année \u2014 During and after second year.45.00 40.55 39.05 23.Personnel féminin d'entrepôt (ne faisant pas partie du personnel de bureau) dans les maisons de salaison et les charcuteries \u2014 Warehouse \u2022 female personnel (not included in the office staff) in packing houses and pork-butcheries: 1ère année \u2014 First year.43.00 38.85 37.45 2ème année \u2014 Second year.45.00 40.55 39.05 Durant et après la 3e année \u2014 During and after third year.47.00 42.25 40.65 24.Surnuméraire d'entrepôt masculin - Warehouse occasional hand, male (Par heure) \u2014 (Per hour) .1.31 1.17 1.13 Surnuméraire d'entrepôt féminin \u2014 Warehouse occasional hand, female (Par heure) - (Per hour).0.95 0.86 0.83 25.Comptable \u2014 Accountant.66.75 59.00 56.40 26.Assistant-comptable \u2014 Assistant-accountant.64.25 56.85 54.40 27.Comptable-caissier \u2014 Accountant-cashier.62.25 54.15 52.80 28.Commis-vendeur \u2014 Sales clerk: 1ère année \u2014 First year.48.00 43.10 41.45 2ème année \u2014 Second year.50.00 44.80 43.05 3ème année \u2014 Third year.56.00 49.90 47.85 Durant et après la 4e année \u2014 During and after 4th year.61.00 54.05 51.85 29.Commis junior \u2014 Junior clerk.____ 38.75 35.20 34.00 30.Messager de bureau \u2014 Office messenger.40.75 36.90 35.60 31.Personnel féminin de bureau (excepté les sténographes) \u2014Office female staff (excepting stenographers) : 1ère année \u2014 1st year.36.00 32.00 31.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol.95, So.37 4387 Par se nun iw Per week I II III 2ème aimée - 2nd year.$39.50 $35.50 $34.50 Durant et après la 3e année \u2014 During and after 3rd year.43.00 39.00 38.00 32.Personnel de maîtrise \u2014 Administration |>crsonnel.73.75 04.95 02.00 33.Sténo-dactylo \u2014 Stenographer: 1ère année\u20141st y ear.39.00 35.00 34.00 2ème année \u2014 2nd year.42.50 38.50 37.50 Durant et après la 3e année \u2014 During and after 3rd year.47.00 43.00 42.00 34.Surnuméraire de bureau \u2014 Office occasional hand (Par heure) \u2014 (Per hour).1 18 1.00 1.02 35.Teneur de livres ou commis de bureau \u2014 Book-keeper or office clerk : 1 ère année \u2014 1st year.42.75 37.45 37.00 2ème année \u2014 2nd year.45.25 40.05 39.10 3ème année \u2014 3rd year.47.75 42.85 41.20 4ème année \u2014 4th year.50.75 45.40 43.60 5ème année \u2014 5th year.53.75 47.95 40.00 6ème année \u2014 Gth year.55.75 49.75 47.(50 7ème année \u2014 7th year.'.57.75 51.35 49.20 Durant et après la 8e année \u2014 During and after 8th year.60.75 53.80 51.60» 15.L'article 72 sera remplacé par le suivant: 15.Article 72 will he replaced by the following: «72.Les item 1 à 35 de l'article 71 seront \"72.From May 1, 1904.items 1 to 35 of article augmentés à compter du 1er mai 1904 de $2.00 71 shall he increased by $2.00 for the weekly pour les taux de salaires hebdomadaires et de rates and by $0.04 for the hourly rates with 0.04 pour les taux de salaires horaires à l'excep- the exception of items 31, 33 and 35 where the tion des item 31, 33 et 35, dont les taux seront rates shall he increased by $1.00 the 1st year, augmentés de $1.00 la première année, $1.50 la $1.50 the second year and $2.00 the following deuxième et $2.00 les années subséquentes.» years.\" 16° L'article 73 sera remplace par le suivant: 16.Article 73 will be replaced by the following: « 73.Tout salarié doit recevoir avec sa paie \"73.Every employee shall he given with his un bulletin contenant les renseignements sui- pay, a slip of paper on which the following van t.s : particulars sha11 mentioned : i.ses noms, prénoms et occupations i.his name in full and occupation ii.les heures de travail régulières ii.the regular hours of work iii.les heures de travail supplémentaires iii.the overtime hours iv.le salaire régulier iv.the regular pay v.le salaire supplémentaire v.overtime pay vi.la période de paie vi.the prdiod of pay vii.le salaire gagné vii.the wages earned viii.le montant des déductions v iii.the amount of deductions ix.le montant à lui remettre.» ix.the amount remitted.\" 17° L'article 76 sera remplacé par le suivant: 17.Article 76 will he replaced by the following: « 76.L'expérience acquise ailleurs que dans les \"76.In classifying bookkeepers, experience établissements régis par le présent décret doit acquired outside the jurisdiction of the decree être considérée en vue de la classification des shall be taken into account.\" teneurs de livres.» 18° L'article 79 sera biffé.18.Article 79 will Ik- deleted.Section III 19° Les articles 6 et 7 seront remplacés par les suivants : « 6.La présente section régit tous les employeurs et les salariés des commerces et des entreprises ci-après décrits: 7.Les établissements dont le commerce principal est le commerce en gros ou en demi-gros du foin, de la farine, des grains ou des aliments du bétail, ainsi que des suppléments et des moulées de viande pour les renards, et autres produits d'alimentation animale; Les établissements dont le commerce principal est le commerce au détail des produits d'alimentation animale et, en particulier, des produits décrits à l'alinéa ci-dessus.» 20° L'article 13 sera remplacé par le suivant: « 13.Tout salarié régulier dont les services sont requis dans les établissements assujettis au ftrésent décret les jours chômés mentionnés à 'article 12, à l'exception toutefois des catégories de salariés mentionnées aux paragraphes « d » et « e » de la section I, doit être rémunéré au taux de temps et demi de son salaire régulier Sur tout travail exécuté pendant ces jours de es chômés.» Section III 19.Articles 6 and 7 will be replaced by the following: \"6.The present section applies to all employers and employees of the trades or concerns hereafter mentioned.7.Establishments engaged mainly in the wholesale or part wholesale trade of hay, flour, grain, feedstuff's, including \"supplements\" and meat mashes for foxes and other animal food products; Establishments engaged mainly in the retail trade of animal food products and, particularly, of products described in the foregoing paragraph.\" 20.Article 13 will l>e replaced by the following: \"13.Regular employees whose services are required in the establishments governed by the present decree on the feast days mentioned in article 12, excepting the categories of employees mentioned in paragraphs \"rf\" and \"e\" of Section I shall be paid at the rate of time and one half for all work performed on such feast days.\" 4388 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 14 septembre 1968, Tome 96, So 37 Section V Section V 21.Lch articles 39 et 40 seront remplacés par 21.Articles 39 and 40 will be replaced by the les suivants: following: « 39.Toute entente constituant une renon- \"39.Any agreement by which an employee ciation par le salarié à ses vacances sera nulle et waves his rights to the vacation shall he null n'aura nul effet, et le salarié nonobstant telle and void and the employee, notwithstanding entente devra recevoir le double de la rémunéra- such agreement, shall be paid double his vacation tion de ses vacances en plus de la rémunération pay in excess of the remuneration already recei-déjà reçue.ved.« 40.Toute entente aux fins d'octroyer audit \"40.Any agreement entered into for the pur-salarié des vacances à une période autre que celle pose of granting vacation at a period other than prévue au présent décret, sauf le cas du mariage that determined in the decree, except in the event de l'employé, sera nulle et sans effet et nonobs- of the marriage of the employee, shall be null and tant telle entente, le salarié devra recevoir la void and, notwithstanding such agreement, the rémunération de ses vacances en double.» employee shall receive double his vacation pay.\" 22° L'article 43 sera remplacé par les suivants: 22.Article 43 will he replaced by the following : « 43.u) Les taux de salaires minima suivants 43.a) The following minimum wage rates doivent être payés aux salariés des catégories shall be paid to the employees of the categories ci-après mentionnées, pour la semaine régulière hereafter mentioned, for the standard work de travail: week: Zones I 11 1.Personnel masculin \u2014 Male personnel: Par heure Homme d'ouvrage général \u2014 ( J encrai hand: Per hour 20 ans et plus, 1ère année \u2014 20 years or older, 1st year.$ 1.08 S 1.06 1 an et plus \u2014 One year and over.1.15 1.13 2.(îarçon junior \u2014 Junior employee.0.95 0.93 3.Mécanicien de machines fixes, 4ème classe \u2014 Stationary engiman, fourth class.1.20 1.18 4.Chauffeur \u2014 Fireman.1.10 1.08 5.Préposé aux machines\u2014 Millwright.1.24 1.22 6.Confiseur \u2014 Confectioner.1.24 1.22 7.Rôtisseur \u2014 Toaster____.1.22 1.20 8.Assistant-confiseur \u2014 Assistant-confectioner.1.18 1.16 9.Conducteur de véhicule (camionneur) \u2014 Truck-driver.1.20 1.18 10.Contremaître \u2014 Foreman.1.32 1.30 11.A s8 is tant-contremaître \u2014 Assistant-foreman.1.29 1.27 12.Expéditeur \u2014 Shipper.1.22 1.20 13.Personnel de maîtrise \u2014 Administration personnel (Par semaine) \u2014 (Per week).75.00 71.00 14.Surnéraire \u2014 Occasional hand: a) Garçon, pas plus de 20% du total des surnuméraires \u2014 Junior employee not more than 20% of the total number of occasional hands.0.77 0 73 b) Homme \u2014Man.0.86 T)82 15.Personnel féminin \u2014 Female personnel: Femme d'ouvrage général \u2014 General hand : 1ère année \u2014 1st year.0.77 0.73 2ème année \u2014 2nd year.0.82 0.78 Surnuméraire \u2014 Occasional hand.0.77 0.73 Par semaine 16.Personnel de bureau \u2014 Office personnel: Per week Comptable \u2014 Accountant.65.00 63-00 Sténo-dactylo \u2014 Stenographer: 1ère année \u2014 1st year.,.4 .36.00 34.00 2ème année \u2014 2nd year.42.50 38.50 3ème année \u2014 3rd year.46.00 42.00 4ème année \u2014 4th year.50.00 46.00 Ouvrage général \u2014 General work: 1ère année\u20141st year.33.00 31.00 2ème année \u2014 2nd year.36 50 34.50 3ème année \u2014 3rd year.40.00 38.00 17.Gardien \u2014 Watchman.51.00 49.00 18.Voyageur de commerce \u2014 Travelling salesman: 1er semestre de vente \u2014 First six months of sales work.38.75 36.75 2e semestre de la 1ère année \u2014 Second six months of the first year.42.25 40.25 Pendant la 2ème année \u2014 During the second year.45.25 43.25 Pendant la 3ème année \u2014 During the third year.49.75 47.75 Pendant et après la 4e année \u2014 During and after the 4th year.54.75 52.75 Par heure Per hour 19.Salariés travaillant aux produits de l'érable \u2014 Maple products employees.S 1.16 S 1.12 20.Salariés affectés aux opérations suivantes:\u2014 Employees engaged in the following operations: Lavage des barils \u2014 Barrel washing.&.1.09 1.05 Barils vides \u2014 Empty barrels.1.09 1.05 Échantillons \u2014 Samples.1.09 1.05 Réception-expédition \u2014 Receiving-shipping.1.00 1.05 Journalier permanent \u2014 Permanent common worker.1.09 1.05 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1.903, lot.96, So.87 4889 43.b) À compter du 1er mai 1964, les taux de salaires de base minima apparaissant aux item 1 à 20 inclusivement seront augmentés de $0.04, à l'exception des item 16, (comptable) et 17, (gardien) dont les taux de salaires de base seront augmentés de $2.00.À l'item 10 de nouveau, sous sténo-dactylo et ouvrage général de même que l'item 18 dont les taux de salaires de hase seront augmentés de $1.00 pour la première année, $1.50 pour la deuxième et $2.00 pour les années subséquentes.» 23° Le paragraphe intitulé « Durée du décret » sera remplacé par le suivant: « Durée du décret I -c présent décret demeure en vigueur jusqu'au premier mai 1965.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) jours ni de moins de trente (30) jours avant le premier mai de chaque année Un tel avis doit également être adressé au ministre du Travail.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, Gerard Tremblay.Ministère du Travail, Québec, le 14 septembre 1963.4030-o Avis de modification Industrie de la construction St-Jean et Iberville L'honorable Carrier Fortin, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans les districts électoraux de St-Jean et d'Iberville, rendue obligatoire par le décret numéro 784 du 21 juillet 1955 et amendements, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1° Le dernier alinéa du paragraphe « a » de l'article V sera remplacé par le suivant: « Les majorations suivantes seront apportées aux taux ci-dessus aux dates ci-après mentionnées: Entrée en vigueur: $0.10 l'heure.1er janvier 1964: $0.12 l'heure.1er juillet 1964: $0.13 l'heure.1er janvier 1965: $0.10 l'heure.1er juillet 1965: $0.10 l'heure.» 2° Le paragraphe « a » de l'article VI sera remplacé par le suivant : « VI.Durée du travail: a) À compter du 1er janvier 1964, les heures de travail des ouvriers qualifiés seront de huit heures et demie (H'-j) Car jour du lundi au jeudi inclusivement, et de uit (8) heures le vendredi, le tout constituant une_ durée de travail de quarante-deux (42) heures par semaine.43.b) From May 1, 1964, the minimum rates of wages appearing in items 1 to 20 inclusively shall he increased by $0.04 per hour with the exception of items 10 (accountant) and 17 (watchman) where the basic rates of wages shall lie increased by $2.00.Again in item 10, the rates for the following occupations: stenographer, general work, shall Ik* increased by $1.00 for the 1st year, by $1.50 for the 2nd year and by $2.00 for the subsequent years.\" 23.The paragraph entitled \"Duration of the decree\" will be replaced by the following: \"Duration of the decree The present «lecree remains in forec until May 1, 1905.It then renews itself automatically from year to year unless either contracting party notifies the «»ther party, in writing, to the contrary within the period extending from the sixtieth (00th) to the thirtieth (30th) day before May 1st of each year.Such a notice must also he forwarded to the Minister of Labour.\" The publication of the present notice «lots not rentier obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which comes into force on the date of its publication in the Queltec Official Gazette.During the thirty cent per pint, 3 cents per quart, 6 cents per half gallon, 9 cents per measure of three quarts and 12 cents per gallon, in the case of milk with l,ly2% butterfat.8.The present Order repeals Order No.2-63 and shall come into force on the first day of October, 1963.Signed: Nolahque April, President, Jean-Marie Bon in, Vice-President, \\ Aimé Boisvert, Member, Paul Charette, Member, Jean Godbouti Member, Maurice Halle, Member, Jean-Baptiste Lemoine, Member.Certified: Gilles Préoent, Executive Secretary.4064-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1968, Vol.96, No.S7 4395 Proclamation Proclamation Canada Province de PAUL CONTOIS Québec./ (L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icellea pourront concerner, Salut: VAssistant-procureur C A TTENDU qu'en ver-général, 1 tu du chapitre 19 C.-E.Cantin.\\ de la Loi 11 George VI, v les jours fériés dans la province ont été établis et que le pouvoir a été donné au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer, par proclamation, tout jour d'actions de grâces; Attendu que notre province est fermement attachée à ses traditions religieuses; Attendu qu'il convient de remercier le Bon Dieu d'une manière publique et solennelle; Attendu qu'il est à popos de déclarer jour férié et jour d'actions de graces le 14 octobre 1963, À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans l'arrêté en conseil numéro 1395, en date du 20 août 1963, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que le 14 octobre 1963 soit, pour la province de Québec, jour férié et jour d'actions de graces.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très 6dèle et bien-aimé l'honorable PAUL COMTOIS, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre Hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Quél>ec, ce troisième jour de septembre en l'année mil neuf cent soixante-trois de l'ère chrétienne et de Notre Règne la douzième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la province, 3992-o Raymond Douville.Proclamation Proclamation Canada Province of PAUL ( OMTOIS Quebec.(L.S.) ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada, and Her other Realms and Territories, Queen, Head of Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting.C.-E.Cantin, t \\\\/HEREAS in virtue of Deputy Attorney) VV Chapter 19 of Act 11, General.\\ George VI, holidays were es-v tablished in Our Province and that the power was conferred on the Lieutenant-Governor in Council to 6x, by proclamation, any Thanksgiving Day: Whereas Our Province is firmly bound to its religious traditions; Whereas it is proper to thank Almighty God in a public and solemn manner; Whereas it is expedient to declare October 14,1963, a holiday and day of thanksgiving.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in an Order in Council number 1395, dated August 20, 1963, We have enacted and ordained, and do hereby enact and ordain that October 14, 1963, be for the Province of Quebec, a holiday and day of thanksgiving.Of all of which Our loving subjects and all other whom these presents may concern, are hereby reqaired to take notice and to govern themselves accordingly, In testimony whereof.We have caused these Our letters to be made patent, and the Great Seal of Our province of Quebec to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable PAUL COMTOIS, p.o., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Parliament Buildings, in Our city of Quebec, in Our Province of Quebec, this third day of September, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and sixty-three and in the twelfth year of Our Reign.By command, Raymond Douville, 3992 Assistant Secretary of the Province.Soumissions Tenders Ville de Villeneuve Town of Villeneuve Comté de Québec County of Quebec Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées 1 Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné G.¦ Latouche, secrétaire-ttésorier, jusqu'à 7.30 heures p.m., 1042, Boulevard des Chutes, Villeneuve, ou jusqu'à 8 heures p.m., Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned G.Latouche, secretary-treasurer, until 7:30 o'clock p.m., 1042 Boulevard des Chutes, Villeneuve, or until 8:00 o'clock p.m., in the municipal hall, 5 Tan- 4390 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1968, Tome 96, No 37 en la salle municipale, 5 rue Tanguay, Villeneuve, lundi, le 30 septembre 1903, pour l'achat de $72,000 d'obligations de la ville de Villeneuve, comté de Québec, datées du 1er novembre 1903, et remboursables par séries du 1er novembre 1904 au 1er novembre 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 0%, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements Nos 123 \u2014 1ère tranche de $51,300 sur un montant total de $165,000 aqueduc, égouts, voirie et pavage; 135 - $20,700 \u2014 capitalisation «le dépenses capitales.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt aera calculé à compter du 1er novembre 1903.Tableau d'amortissement \u2014 $72,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1964.$ 3.000 1 er novembre 1965 .3.000 1 er novembre 1966.3,500 1 er novembre 1967.3,500 1er novembre 1968 .3,500 1 er novembre 1969 .3,500 * 1er novembre 1970.3,500 1er novembre 1971.4,000 1 er novembre 1972 .4,000 1 er novembre 1973.4,000 1er novembre 1974.2,000 1 er novembre 1975 .2,000 1er novembre 1976 .2,000 1er novembre 1977 .2,000 1 er novembre 1978 .2,000 1er novembre 1979 .2,000 1er novembre 1980.2,000 1er novembre 1981.2,500 1er novembre 1982 .2,500 1 er novembre 1983.17,500 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Beauport.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 30 septembre 1963, à 8 heures du soir, en la salle municipale, 5, rue Tanguay, Villeneuve, comté de Québec.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Villeneuve, (Comté de Québec), 6 septembre 1963.Le Secrétaire4résorier, Georges Latouche.1042, Boulevard des Chutes, Villeneuve, (Québec), P.Q.Téléphone: MO-3-9767 résidence MO-3-6987 bureau 4050-o guay Street, Villeneuve, Monday, September 30, 1903, for the purchase of an issue of $72,000 of bonds for the town of Villeneuve, county of Quel tec, dated Novemlwr 1, 1963, and redeemable serially from November 1, 1904 to November I.1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semiannually on May 1 ami November 1 of each year.The rate of interest may he the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos.123 \u2014 1st block of $51,300 of a total amount of $105,000 \u2014 aqueduct, sewers, roadwork and paving; 135 \u2014 $20,700 \u2014 capitalization of capital expenditures.For adjudication purposes only, interest shall l>e calculated as from November 1, 1903.Table of redemption \u2014 $72,000 \u2014 20 years Year Capital November 1, 1964.$ 3,000 November 1, 1965 .3,000 November 1, 1900.3,500 November 1, 1967 .3,500 November 1.1908.3,500 Noveml)er 1, 1909.3,500 November 1.1970.3,500 November 1, 1971 .4,000 November 1, 1972 .4,000 November 1, 1973.4,000 November 1, 1974 .2,000 November 1.1975.2,000 November 1, 1970.2,000 November 1, 1977 .2,000 November 1, 1978 .2,000 November 1, 1979 .2,000 November 1.1980 .2,000 November 1, 1981.2,500 November 1.1982.2,500 November 1, 1983.17,500 Moreover, tenders may be forwarded and shall he considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall l>e considered for one of the three terms only.Adjudication shall he made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Beauport.Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council, to be held on Monday, September 30, 1963, at 800 o'clock p.m., in the municipal hall, 5 Tanguay Street, Villeneuve, county of Quebec.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Villeneuve, (County of Quebec), September 6.1963.Georges Latouche, Secretary- Treasurer.1042 Boulevard des Chutes, Villeneuve, (Quebec), P.Q.Telephone: MO-3-9767 residence MO-3-6987 office 4050 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September //,, 1968, Vol.96, No.87 4397 Village de Laurierville Comté de Mégantie Avis publie est |»ar les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Cailles Mercier, secrétaire-trésorier, buurierville, comté de Mégantie, jusqu'à 8 heures p.m., mardi, le 1er octobre 1963, pour l'achat de $100,000 d'obligations du village de Lauriervillc, comté de Mégantie, datées du 1er novembre 1963 et remboursables par séries du 1er novembre 1964 au 1er novembre 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 6%, payable semi-annuelle-ineuf les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement No 159 \u2014 $100,000 \u2014 acquisition de terrains et bâtisses pour fins industrielles.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt, sera calculé à compter du 1er novembre 1963.Tableau d'amortissement $100,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1964.$2,500 1er novembre 1905.3,000 1er novembre 1966 .3,000 1er novembre 1907 .3,000 1er novembre 1968.3,500 1er novembre 1909 .3,500 1er novembre 1970 .4,000 1er novembre 1971.4,000 1er novembre 1972.*,500 1er novembre 1973.4,500 1er novembre 1974 .5,000 1er novembre 1975.5,000 1er novembre 1976.5,500 1er novembre 1977 .0,000 1er novembre 1978 .0,000 1er novembre 1979 .6,500 1er novembre 1980.7,000 1er novembre 1981.7,500 1er novembre 1982 .8,000 1er novembre 1983 .8,000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Lauriervillc.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courrus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 1er octobre 1963 à 8 heures du soir, en la salle paroissiale, Laurierville, comté de Mégantie.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Village of Laurierville County of Mégantie Publie notice is hereby given that sealed tenders, endorsed 'Tenders for Bonds\" will l>e recefVed by the undersigned (idles Mercier, secretary-treasurer, Laurierville, county of Mégantie, until 8.-00 o'clock p.m.on Tuesday, October 1.1963, for the purchase of an issue of $100,000 of bonds for the Village of Laurierville, county «f Mcgantic, dated November 1, 1903, and redeemable serially from November 1, 1904 to November 1.1983 inclusively, with interest at a rate not leas than 5%, nor more than 0%, payable semi-annually on May 1 ami November 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.159 \u2014$100.000 purchase of lands ami buildings for industrial purposes.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from November 1, 1963.Table of rédemption \u2014 $100,000 \u2014 20 years Year Capital November 1, 1964.*.$2,500 November 1, 1965 .3.000 November 1, 1900 .3,000 November 1, 1967 .3,000 November 1, 1908 .3,500 November 1, 1969 .3,500 November 1, 1970.4,000 November 1, 1971.4,000 November 1, 1972 .4,500 November 1, 1973.4,500 November 1, 1974 .5,000 November 1, 1975 .5.000 November 1, 1976.5.500 November 1, 1977.6.000 November 1, 1978 .0,000 November 1, 1979 .6,500 November 1, 1980.7,000 November 1, 1981.7,500 November 1, 1982 .8,000 November 1, 1983.8.000 Moreover, tenders may be forwarded and shall he considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall l»e made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal ami accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Laurierville.Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto.The said bonds will not l>e redeemable any anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, October 1, 1963, at 8:00 o'clock p.m., at the Parish Hall, Laurierville, county of Mégantie.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders. 4398 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 96, Xo 37 Laurier vil If.(Comté île Mégantie), ee 6 septembre 19(13.Le Secrétaire-trésorier, Gilles Mercier.C.I».20.Laurie r ville, (Mégantie), P.Q.Téléphone: 365-4040.4051-o Laurierville, (Countv of Mégantie), Septcml>er 6, 1963.GlLLES MERCIER, Secretari/- Treasurer.P.O.B.26, Laurierville, (Mégantie) P.Q.Telephone: 365-4646.4051 Municipalité de Douville Comté de St-Hyacinthe Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Georges Blanchard, secrétaire-trésorier, 3935, rue Lemoyne, Douville.comté de St-Hyacinthe, jusqu'à 4 heures p.m., lundi, le 30 septembre 1963, pour l'achat de $95,500.d'obligations de la municipalité de Douville, comté de St-Hyacinthe, datées du 1er novembre 1963 et remboursables par séries du 1er novembre 1964 au 1er novembre 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5% ,ni supérieur à 6%, payable semi-annuel lenient les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement No.40 \u2014 $95,500 \u2014 usine d'épuration.Pour 6ns d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1963 Tableau d'amortissement \u2014 $95,500 \u2014 20 ans Annie Capital 1er novembre 1964.$ 500 1er novembre 1965 .500 1er novembre 1966 .500 1er novembre 1967 .500 1er novembre 1908 .500 1er novembre 1969 .500 1er novembre 1970 ____'.500 1er novembre 1971 .400 1er novembre 1972 .500 1er novembre 1973 .500 1er novembre 1974 .500 1er novembre 1975 .1,000 1er novembre 1976 .1,000 1er novembre 1977 .1,000 1er novembre 1978 .1,000 1 er novembre 1979 .1,500 1er novembre 1980 .1,500 1er novembre 1981 .1,500 1er novembre 1982 .1,500 1er novembre 1983 .80,000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage a payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Hyacinthe.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert com- Erend ou ne comprend pas les intérêts courus sur \u2022s obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 30 Municipality of Douville County of St.Hyacinthe Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Georges Blanchard, secretary-treasurer, 3935, Lemoyne St., Douville, county of St.Hyacinthe, until 4:00 o'clock p.m.on Monday, September 30,1963, for the purchase of an issue of $95,500 of bonds for the municipality of Douville, county of St.Hy linthe, dated November 1, 1963, and redeemable serially from November 1, 1964 to November 1.1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semi-annually on May 1 and November 1 of each year.The rate of interest may be the s»me for the whole issue or it may vary according to maturities.By-law No 40, \u2014 $95,500 \u2014 water purifying plant.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from November 1, 1963.Table of redemption \u2014 $95,500 \u2014 20 years Year Capital November 1, 1964.$ 500 November 1, 1965.500 November 1, 1966.500 November 1, 1967.500 November 1, 1968.500 November 1, 1909.500 November 1, 1970 .500 November 1.1971.500 November 1, 1972 .500 November 1, 1973 .500 November 1, 1974 .500 November 1, 1975.1,000 November 1, 1976.1,000 November 1, 1977.1.000 November 1, 1978.1.000 November 1, 1979.1.500 November 1, 1980.1.500 November 1.1081.1.500 November 1.1982.1.500 November 1, 1983 .80.000 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The succesful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at St.Hyacinthe.Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the hank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1968, Vol.96, No.87 4399 septembre 1963 à 4 heures de l'après-midi, 3935, rue lemoyne, Douville, comté de St-Hyacinthe.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Douville, (Comté de St-Hyacinthe), ce 6 septembre 1903.Le Secrétaire-trésorier, GKJSGM Blanoiiahd.3935, rue Lemoyne, Douville, (St-Hyacinthe).Téléphone: PRovince 4-8642 4052-o Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Pointe-au-Pic Comté de Charlevoix Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Sam Warren, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, Pointe-au-Pic, comté de Charlevoix, jusqu'à 9 heures p.m., mardi, le 1er octobre 1963, pour l'achat de $235,000 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité- de Pointeau-Pic, comté de Charlevoix, datées du 1er novembre 1963, et remboursables par series du 1er novembre 1964 au 1er novembre 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 6%, payable semi-annuelle-ment les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution en date du 19 mars 1963 \u2014 $235,000.\u2014 telle que modifiée \u2014 construction d'une école de 12 classes.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1963.Tableau d'amortissement \u2014 $235,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1964.x $54,500 1er novembre 1965.x 60,000 1er novembre 1966 .2,500 1er novembre 1967.2,500 1er novembre 1968 .3,000 1er novembre 1969 .3,000 1er novembre 1970.3,000 1er novembre 1971.3,500 1er novembre 1972.3,500 1er novembre 1973 .4,000 1er novembre 1974 .4,000 1er novembre 1975 .4,500 1er novembre 1976.4,500 1er novembre 1977 .5,000 1er novembre 1978 .5,000 1er novembre 1979.5,500 1er novembre 1980.6,000 1er novembre 1981.6,000 1er novembre 1982.6,500 1er novembre 1983 .48,500 Les « x » indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $130,000, accordé par le gouvernement provincial et payable en deux versements de $65,000 chacun, en 1904 et 1905, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à La Malbaie.September 30, 1903, at 4:00 o'clock p.m., at 3935 Ixunoyne St., Douville, County of St.Hyacinthe.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Douville, (County of St.Hyacinthe), September 0.1903.GaOBGBt Blanchahd, Secretary-Treasurer.3935.Lemoyne St.Douville, (St.Hyacinthe).Telephone: PBovince 4-SG42 4052 The school commissioners for the municipality of Pointe-au-Pic County of Charlevoix Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Sam Warren, secretary-treasurer, City Hall, Pointe-au-Pic, county of Charlevoix, until 9:00 o'clock p.m., Tuesday, October 1, 1963, for the purchase of an issue of $235,000 of bonds for the school commissioners for the municipality of Pointe-au-Pic, county of Charlevoix, dated November 1, 1963, and redeemable serially from November 1, 1964 to November 1, 1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5% nor more than 6%, payable semi-annually on May 1 and November 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Resolution dated March 19, 1963 \u2014 $235,-000.\u2014 as modified \u2014 construction of a 12 class school.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from November 1, 1963.Table of redemption \u2014 $285,000 \u2014 20 Years Year Capital November 1, 1964.x $54,500 November 1, 1965.x 60,000 November 1, 1900 .2,500 November 1, 1967 .2,500 November 1, 1968 .3,000 November 1, 1969.3,000 November 1, 1970 .3,000 November 1, 1971.3,500 November 1, 1972 .3,500 November 1, 1973.4,000 November 1, 1974 .4,000 November 1, 1975.4,500 November 1, 1970.4,500 November 1, 1977.5,000 November 1, 1978 .5,000 November 1, 1979.5,500 November 1, 1980 .6,000 November 1, 1981.6,000 November 1, 1982 .6,500 November 1.1983.48,500 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $130,000, granted by the Provincial Government and payable in two instalments of $05,000 each, from 1904 to 1905 inclusively, will he received and applied to the service of the said loan.Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at La Malbaie. 4400 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 11)63, Tome .93, No 37 Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas (achetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra Specifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance «les commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 1er octobre 1903 à 9 heures du soir, Hôtel de Ville, Pointe-au-Pic, comté de Charlevoix.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Pointe-au-Pic, (Comté de Charlevoix), ce (J septembre 1903.Le Secrétaire-trésorier, Sam Warren.Hôtel de Ville, ('.P.507, Pointe-au-Pic, (Charlevoix), P.Q.Téléphone: MOntcahn-5-3207 4053-o Paroisse de Ste-Cécile Comté de Beauharnois Avis public est par les présentes donne qu* des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Robert Sauvé, secrétaire-trésorier, 57, rue Nicholson, Ste-Cécile.comté de Beauharnois, jusqu'à 8 heures p.m., lundi, le 30 septembre 1903, pour l'achat de $41,500 d'obligations «le la paroisse «le Ste-Cécile, comté «le Beauharnois, datées du 1er novembre 1903 et remboursables par séries du 1er novembre 1964 au 1er novembre 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 6%.payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement No 61 \u2014 $41,500\u2014 travaux d'égouts.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1903.Tableau d'amortissement \u2014 341,500 \u2014 SO ans Année Capital 1er novembre 1964.$1,000 1er novembre 1905.1,000 1er novembre 19G6.1,500 1er novembre 1967.1,500 1er novembre 1968.1,500 1er novembre 1969.1,500 1er novembre 1970.1,500 1er novembre 1971.1,500 1er novembre 1972 .2,000 1er novembre 1973.* 2,000 1er novembre 1974 .2,000 1er novembre 1975 .2,000 1er novembre 1976.2,500 1er novembre 1977 .2,500 1er novembre 1978 .2,500 1er novembre 1979.2,500 1er novembre 1980 .3,000 1er novembre 1981.3,000 1er novembre 1982 .3,000 1er novembre 1983 .3,500 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte'échéance dix ans Capital an'cl«jck p.m., at the City Hall, Pointe-au-Pic.county of Charlevoix.The school commissioners do not hind tem-sclves to accept the highest or any of the tenders.Pointe-au-Pic, (County «»f Charlevoix), September 6, 1963.Sam Waiiren, Secretary-Treasurer.City Hall, P.O.Box 507, Pointe-au-Pic, (Charlevoix), P.Q.Telephone: MOntcalm-5-3207 4053 Parish of Ste-Cécile County of Beauharnois Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Robert Sauvé, secretary-treasurer, 57 Nicholson St., Ste-Cécile, county of Beauharnois, until 800 o'clock p.m., Monday, September 30, 1963, for the purchase of an issue of $41,500 of bonds for the parish of Ste-Cécile, county of Beauharnois, dated November 1, 1963, and redeemable serially from November 1, 1964 to November 1, 1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semi-annually on May 1 and November 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-law No.61 \u2014 $41,500 \u2014 sewer works.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from November 1, 1963.Table of redemption \u2014 $41,500 \u2014 20 Years Year Capital November 1, 1964.$1,000 November 1, 1965.1,000 November 1, 1966.1,500 November 1, 1967.1,500 November 1, 1968.1,500 November 1, 1969.1,500 November 1, 1970.1,500 November 1, 1971.1,500 November 1, 1972.2,000 November 1, 1973 .2,000 November 1, 1974 .2,000 November 1, 1975.2,000 November 1, 1976.2,500 November 1, 1977 .2,500 November 1, 1978 .2,500 November 1, 1979.2,500 November 1, 1980.3,000 November 1, 1981.3,000 November 1, 1982.3,000 November 1, 1983.3,500 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall QUEBEC OFFICIAL BABETTE, September 14, 1M8, loi.M, So.S7 4401 ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par ehèqtie visé, payable au pair à Valleyfield.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas radietaides par anticipation.Chaque soumission devra être accompagné-c d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront-ouverles et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 30 septembre 1903 à H heures du soir, en l'École Dominique Savio.Chemin Larocque, Ste-Cécile, comté de Hcauharnois.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Cécile, (Comté de Beauharnois), ce 9 septembre 1903.Le SecrHaire-trhorier, RoBKHT SaUVÊ.57.rue Nicholson.Ste-Cécile, (Beauharnois).P.Q.Téléphone: 373-1280 4054-o Cité de Laflèche Comté tie Chambly Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Gérard Maurice, greffier, Hôtel de Ville, 3350, Grande-Allée, Laflèche, comté de Chambly, jusqu'à 8 heures p.m., mardi, le 1er octobre 1963, pour l'achat de $420.000 d'obligations de la cité de Laflèche.comté de Chambly, datées du 1er novembre 1963 et rcmlioursables par séries du 1er novembre 1904 au 1er novembre 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 0%, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour, toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements Nos: 120 \u2014 $329,000 \u2014 travaux de pavage; 124 \u2014 $41,000 \u2014 travaux de pavage; 131 \u2014 $56,000 \u2014 travaux d'aqueduc et d'égouts.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1903.Tableau d'amortissement \u2014 $426,000 \u2014- 20 ans Année Capital 1er novembre 1904.$10,500 1er novembre 1905.11,000 1er novembre 1966.12,000 1 er novembre 1967.13,000 1 er novembre 1968.14,000 1er novembre 1969.14.500 1 er novembre 1970.15.000 1er novembre 1971.16.000 1er novembre 1972.17,500 1 er no membre 1973.18,000 1er novembre 1974.19,500 1 er novembre 1975 .20,500 1er novembre 1976 .22,000 1 er novembre 1977.23,000 1er novembre 1978 .24.000 1 er novembre 1979 .25,500 be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if uny, by certified cheque pavable at pur at Vallev-field.I* Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the hank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must he accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue ami must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, September 30, 1963, at 8:00 o'clock p.m., at the Dominique Savio School.Chemin Larocque, Ste-Cécile, county of Beauharnois.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Ste-Cécile, (County of Beauharnois), September 9, 1903.Robert Sauve, Secretary-Treasurer.57 Nicholson St., Ste-Cécile, (Beauharnois).P.Q.Telephone : 373-1280 4054 City of Laflèche County of Chambly Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received bv the undersigned Gérard Maurice, city clerk, City Hall, 3350 Grande-Allée, Laflèche, county of Chambly, until 8 KM) o'clock p.m., for the purchase of an issue of $426.000 of bonds for city of Laflèche, county of Chambly, dated November 1, 1963, and redeemable serially from November 1, 1964 to November 1, 1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semi-annually on May 1 and November 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos.: 120 \u2014 $329,000 \u2014 work on pavements; 124 ~ $41,000 \u2014 work on pavement; 131 \u2014 $56,000 \u2014 work on aqueduct and sewers.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from November 1, 1963.Table of redemption \u2014 $426,000 \u2014 20 years Year Capital November 1, 1964.$10,500 November 1, 1965.11,000 November 1, 1966.12,000 November 1, 1967.13,000 November 1, 1908.14,000 November 1, 1969.14,500 November 1, 1970.15,000 November 1, 1971.10,000 November 1, 1972.17,500 November 1, 1973.18,000 November 1, 1974.19,500 November 1, 1975 .20,500 November 1.1970 .22,000 November 1, 1977.23,000 November 1, 1978 .24,000 November 1, 1979 .25,500 4402 GAZETTE OFFICIELLE DF QUEBEC, 14 septembre IMS, Tome .95, So 37 1er novembre 1980.«28,000 1er novembre 1981.29,000 1er novembre 1982.30,500 1er novembre 1983 .02,500 De plus, «les soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour «les obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront «.\"«importer «|u'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, pur chèque vue.payable au pair à Laflèche.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, «lans la province «le Québec, «le la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladile banque à Toron t»>.Lesdites obligations ne seront pas rachetahles par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% «lu montant «le l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pus les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance «lu conseil qui sera tenue mardi, le 1er octobre 1903 à 8 heures «lu soir.Hôtel «le Ville, 3350.Grande-Allée, Laflèche.comté «le Chambly.Le conseil se réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Laflèche.(Comté «le Chambly), ce 11 septembre 1068.Le Greffier, (\u2022huano Maurice.Hôtel «le Ville, 3350, Grande-Allée.Laflèche, (Chamblv), P.Q.Téléphone: OR-0-1800.4070-o November 1.1980.$28,000 November 1.1981.29.000 November 1, 1982.30,500 November 1, 1983.02,500 Moreover, tenders may be forwarded an«l shall he considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall lie considered for one of the three terms only.Adjudication shall he made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Laflèche.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the hank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said hank at Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must, be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the temler.The tenders will be opened ami considered at a meeting of the council to he held on Tuesday, October 1, 1903, at 8:00 o'clock p.m., at the City Hall, 3350 Grande-Allée, Laflèche, county of Chambly.The council does not hind itself to accept the highest or any of the tenders.Laflèche, (County of Chambly), September 11, 1903.Gérard Maurice, City Clerk.Citv Hall, 3350 Grande-Allée, Laflèche.(Chambly), P.Q.Telephone: OR-0-1806.4070 Village de Lavaltrie Comté «le Hcrthier Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Charles Martineau, secrétaire-trésorier, Lavaltrie, comté «le Berthicr, jusqu'à 8 heures p.m., mercredi, le 2 octobre 1963, pour l'achat de $352,000 d'obligations du village de Lavaltrie, comté «le Berthier, datées «lu 1er novembre 1903 et remboursables par séries «lu 1er novembre 1904 au 1er novembre 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 6%, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut-être le même pour toute l'émission ou il peur varier suivant les échéances.Règlement No 70 \u2014 $352,000 \u2014 travaux d'aqueduc, d'égouts et usine d'épuration des eaux.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1963.Tableau d'amortissement \u2014 $352,000 \u2014 20 ans Annie Capital 1er novembre 1964.$ 4,500 1er novembre 1965.4,500 1 er novembre 1966.5,000 1er novembre 1967.5,500 1er novembre 1968.5,500 1 er novembre 1969.6,000 1er novembre 1970 .0,500 1er novembre 1971.6,500 1 er novembre 1972 .7,500 1 er novembre 1973 .7,500 Village of Lavaltrie County of Berthier Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Temlers for Bonds\" will be received by the undersigned Charles Martineau, secretary-treasurer, Lavaltrie county of Berthier, until 8:00 o'clock p.m.Wednesday, October 2, 1903, for the purchase of an issue of $352,000 ôf bonds for the village of Lavaltrie, county of county of Berthier, dated Navember 1, 1903, and redeemable serially from Noveml>er 1, 1964, to November 1, 1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%.payable semi-annually on May 1 and November 1 of each year.The rate of interest may he the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-law No.70 \u2014 $352,000 work on aqueduct, sewers and water purifying plant.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from November 1, 1963.Table of redemption \u2014 $352,000 \u2014 20 years Year Capital November 1, 1964.$ 4,500 November 1, 1965.4,500 November 1, 1966.5,000 November 1, 1967 .5,500 November 1, 1968.5,500 November 1, 1969 .6,000 November 1, 1970 .6,500 November 1, 1971.6,500 November 1, 1972 .7,500 November 1.1973 .7,500 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 1/,, 1063, Vol.96, So.37 4403 1er novembre 1974.$ 8,000 1er novembre 1975 .8,500 1er novembre 1976 .8,500 1er novembre 1977.9,500 1er novembre 1978.10,000 1 er novembre 1979.10,500 1er novembre 1980.11,500 1er novembre 1981.12,000 1er novembre 1982.13,000 1 er novembre 1983.201,500 De plus, éeifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 2 octobre 1963 à 8 jeu res du soir, au collège J.-C.Chaussé, Lavaltrie.comté de Berthier.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Lavaltrie.(Comté de Berthier).ce 11 septembre 1063.Le Secrétaire-trésorier, Charles Martineau.Lavaltrie, (Berthier), P.Q.Téléphone : 837-4677 4071 -o November 1, 1974.* 8.000 November 1, 1975 .8.5(H) November 1, 1970.8.500 November 1, 1977 .0,600 November 1, 1978.10,000 November 1, 1979.10.5(H) November 1.1980.11.500 November 1, 1981.12,000 November 1, 1982.13,000 November 1, 1983 .201,500 Moreover, tenders may he forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tendered agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Lavaltrie.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the hank mentioned in the loan procédure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must he accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery Is included or not in the price of the tender.The tenders will he opened and considered at a meeting of the council, to be held on Wednesday, October 2, 1963, at 8:00 o'clock p.m., at the J.-C.Chaussé.Lavaltrie, county of Berthier.The council does not hind itself to accept the highest or any of the tenders.Lavaltrie, (County of Berthier).September 11.1963.Charles Martin eat, Secretary-Treasurer.Lavaltrie, (Berthier), P.Q.Telephone: 837-4677 4071 Municipalité de Lac Lemoine Comté d'Abitibi Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées a Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné J.-P.Bouleau, secrétaire-trésorier.R.R.No 2.Val d'Or, comté d'Abitibi, jusqu'à 7.30 heures p.m., mercredi, le 2 octobre 1963, pour l'achat de $250,000 d'obligations de la municipalité de Lac Lemoine, comté d'Abitibi, datées du 1er novembre 1963 et remboursables par séries du 1er novembre 1964 au 1er novembre 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%.ni supérieur à 6%, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements Nos: 18 \u2014 $137,000.\u2014 travaux d'aqueduc et de protection contre l'incendie; 24 \u2014 $113,000 \u2014 travaux d'égouts.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1963.Tableau d'amortissement \u2014 3250,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1964.$ 1,000 1er novembre 1965.1,500 1er novembre 1966 .2,000 1er novembre 1967.2,500 1er novembre 1968.3,000 Municipality of Lac Lemoine County of Abitibi Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned J.-P.Rouleau, secretary-treasurer, R.R.No.2, Val d'Or, county of Abitibi, until 7:30 o'clock p.m., Wednesday, October 2.1963, for the purchase of an issue of $250,000 of bonds for the municipality of Lake Lemoine, county of Abitibi, dated November 1, 1963, and redeemable serially from November 1, 1964 to November 1, 1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semi-annually on May 1 and November 1 of each year.The rate of interest may be the same or the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos: 18 \u2014 $137,000.- works in aqueduct and protection against fire; 24 \u2014 $113,000.\u2014 works in sewers.For adjudication purposes only, interests hall be calculated as from November 1, 1963.Table of redemption - 9250,000 \u2014 20 Years Year Capital November 1, 1964.$ 1.000 November 1, 1905.1,500 November 1, 1966.2,000 November 1, 1967.2,500 November 1, 1968 .3.000 4*04 CAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1968, Tome 95, No 37 1er novembre 1969.$ 3,500 - 1er novembre 1970.4.000 1er novembre 1971.4,500 1er novembre 1972 .5,000 1er novembre 1973.5,500 1er novembre 1974.0,000 .er novembre 1975 .0,500 1 er novembre 1976 .7,000 1er novembre 1977 .7.500 1er novembre 197S.8,000 1er novembre 1979.8,500 1er novembre 1980 .9,000 1er novembre 1981.9,500 1er novembre 1982.10,000 I er novembre 1983.145.500 De plus, «les soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul «les trois termes.L'adjudication sera faite conformément ù la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair ù Val «l'Or.Le capital et les intérêts sont payables à toutes* les succursales, dans la province «le Québec, «le la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pus rachetables par anticipation.Chaque soumission devra «Hre accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant «le l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance «lu conseil qui sera tenue mercredi, le 2 octobre 1963, à 7.30 heures du soir, en l'École Ste-Marie, Lac Lemoine, comté d'Abitibi.Le conseil se réserve le «Iroit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Lac Ixmioine, (Comté d'Abitibi).ce 11 septembre 1963.Le Secrétaire-trésorier, J.-P.Rouleau.R.R.No 2, Val d'Or, (Abitibi), P.Q.Téléphone: 824-4275 4072-o Ville de Coaticook Comté de Stanstead Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Romuald Du mont, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 150, rue Child, Coaticook, comté de Stanstead, jusqu'à 7.30 heures p.m., mardi, le 1er octobre 1963, pour l'achat de $127,000 d'obligations de la ville de Coaticook, comté de Stanstead, datées du 1er novembre 1963 et remboursables par séries du 1er novembre 1964 au 1er novembre 1980 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 6%, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements Nos: 593 \u2014 $99,000 \u2014 construction de bâtisses pour fins industrielles; 596 \u2014 $28,000 \u2014 travaux de pavage.November 1.1969.$ 3,500 November I, 1970 .4,000 November 1, 1971.4,500 November 1, 1972.5,000 November 1, 1073 .5,500 November 1, 1974 .0,000 November I.1975 .0,500 November 1.1976 .7.000 November 1, 1977 .7,500 November 1, 1978 .8.000 November 1, 1979 .8,500 November 1, 1980 .9,000 November 1, 1981.9,500 November 1, 1982.10,000 November 1.1983.145.500 Moreover, tenders may be forwardetl and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be consi«lere«l for one of the three terms only.Adjudication shall he made according to law.The successful tenderer agrees t«) pay f«>r the bonds, principal an«l accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Val «l'Or.Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the hank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must he accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will he opened and considered at a meeting of the council, to be held on Wednesday, October 2, 1963, at 7:30 o'clock p.m., in Ste-Marie School, Lake Lemoine, county of Abitibi.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Lake Lemoine, (Countv of Abitibi), September 11, 1963.J.-P.Rouleau, Secretary- Treasurer.R.R.No.2, Val d'Or, (Aitibi), P.Q.Telephone: 824-4275 4072 Town of Coaticook County of Stansteatl Public notice is hereby given that sealed temlcrs, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned RomoeJd Dumont, secretary-treasurer.Town Hall, 150 Child St.Ccaticook.county of Stanstead, until 7:30 o'clock p.m., Tuesday, October 1, 1903, for the purchase of an issue of $127,000 cf bonds for the town cf Coaticook, county of Stanstead, dated November 1.1963, and redeemable serially from November 1.1964 to November 1, 1980 inclusively, with interest at a rate mit less than b°7c, nor more than 6%, payable semi-annually on May 1 ami November 1 cf each year.The rate of interest may bo the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos: 593 \u2014 $99,000 \u2014 construction of buildings for industrial purposes; 590 \u2014 $28,000 \u2014 paving.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1963.For adjudication purposes only, int< rest shall be calculated as from November 1.1968. QUEBEC CEE ICI AL GAZETTE, September 14, l.%3, Vol.96, So.37 4405 Tableau d'amortissement \u2014 $127,000 \u2014 17 aim Année Capital 1er novembre 1904.$ 0,000 1 er novembre 1905.0,000 1 er novembre 1900 .0,000 1er novembre 1907.0,000 1er novembre 1908 .,.8.000 1er novembre 1909 .8,000 1 er novembre 1970 .8.000 1er novembre 1971.8.000 1 er novembre 1972.10.000 1er novembre 1973.10,000 1 er novembre 1974 .0,000 1er novembre 1975.7,000 1er novembre 1970 .7,000 1er novembre 1977 .7,000 1 er novembre 1978 .8,000 1 er novembre 1979 .8,000 1er novembre 1980 .8,000 On est prié de noter «pie les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Coaticook.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 1er octobre 1903 à 7.30 heures du soir, Hôtel de Ville, 150, rue Child, Coaticook, comté de Stanstead.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Coaticook, (Comté de Stanstead), ce 11 septembre 1963.Le Secrétaire4résorier, romuald Dl'MONT.Hôtel de Ville, 150, rue Child.CP.250, Coaticook, (Stanstead), P.Q.Téléphone: 849-2721.4073-o Ville de Hauterive Comté de Saguenay Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Gilbert Moffatt, secrétaire-trésorier, Hauterive, comté de Saguenay, jusqu'à 7.30 heures p.m., lundi, le 30 septembre 1903, pour l'achat de $729.030 d'obligations de la ville de Hauterive.comté de Saguenay.dat:*es du 1er novembre 1983, et remboursables par séries du 1er novembre 1964 au 1er novembre 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 6%, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement No 102 \u2014 $300,000 \u2014 travaux d'égouts; 104 \u2014 $426,000 \u2014 travaux d'égouts.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1963.Table of rédemption \u2014 $127,000 \u2014 17 yearn Year Capital November 1.1904.$ 0,000 November I.1905.0.000 November I, 1966 .0.000 November 1,1067.6,000 November 1, 1908.8,000 November 1, 1969 .8,000 November 1, 1970 .8.0(H) November 1, 1971.8.000 November 1.1972.10.000 November 1,1978.10.0(H) November 1.1974.6,000 November 1, 1975 .7,000 November 1, 1976 .7.0(H) November 1, 1977.7.0(H) November 1.1978 .8,000 November 1, 1979 .8,000 November 1, 1980 .8,000 Please?note that tenders are called for bonds redeemable according to the above table only, and that offers for short term bonds shall not be taken into consideration.The lUOCesiful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par ;'.t Coaticook.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office' of said hank in Toronto.The laid bonds will not Ik- re-dee niable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council, to he held on Tuesday, October 1, 1963, at 7:30 o'clock p.m., in the Town Hall, 150 Child St., Coaticook, county of Stanstead.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Coaticook, (County of Stanstead), September 11, 1963.RoMl'ali) Dl'mont, Secretary- Treasurer.Town Hall, 150 Child St., P.O.Box 250.Coaticook, (Stanstead), P.Q.Telephone: 849-2721.4073 Town of Hauterive County of Saguenay Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Gilbert Moffatt, secretary-treasurer, Hauterive, county of Saguenay, until 7:30 o'clock p.m., Monday, September 30,\" 1903, for the purchase of an issue of $726,000 of bonds for the town of Hauterive, county of Saguenay, dated November 1, 1963, ami redeemable serially from Noveml>er 1.1964 to November 1, 1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semiannually on May 1 and November 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole or it may vary according to maturities.By-law No.102 \u2014 $300,000 - work on sewers; 104 \u2014 $426,000 \u2014 work on sewers.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from November 1, 1963. 4406 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre IMS, Tome 96, No 37 Tableau d'amortissement 3729,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1064.$ 0,500 tor novembre* 1005 .9,500 1er novembre 1900.10,500 1er novembre 1007.11,000 1er novembre 190S.12,000 1er novembre 1009.12,000 1er novembre 1970.13,000 1er novembre 1971.13,500 1er novembre 1972.14,500 1er novembre 1973.15,500 1er novembre 1974.10,500 1er novembre 1975.17,000 1er novembre 1976.18,500 1er novembre 1977.19,500 1er novembre 1978.20,500 1er novembre 1979.22.000 1er novembre 1980.23,000 1er novembre 1981.24,500 1er novembre 1982.26.500 1er novembre 19S3.417,000 De plus, des .soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations ù courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.('c|>endunt, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément ù lu loi.L'adjudicataire s'engage ù payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Hauterive.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné duns la procédure d'emprunt.\" Lesdites obligations ne seront pas raehetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra specifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 30 septembre 1963, à 7.30 heures du soir, à l'endroit habituel des séances, Hauterive, comté de Saguenay.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Hauterive, (Comté de Saguenay), ce 11 septembre 1963.Le Secrétaire-trésorier, Gilbert Moffatt.CP.1150, Hauterive, (Saguenay), P.Q.Téléphone : 589-2071.4074-o Table of redemption $729,01)0 \u2014 20 years Year Capital November 1.1064.$ 9,500 November 1, 1905.9,500 November 1, 1900.10,500 November 1, 1907.11,000 November 1, 1968.12,000 November 1, 1909.12,000 November 1, 1970.13,000 November 1, 1971.13,500 November 1, 1972.14,500 November 1, 1973.15.500 November 1, 1974.10,500 November 1.1975.17,000 Novemlier 1.1976.18,500 November I, 1977.19,500 November I, 1978 .20,500 November 1, 1979.22.000 November 1, 1980 .23.000 November 1, 1981.24.500 Novemlier 1, 1982 .20.500 November I, 1068.417,000 Moreover, tenders may he forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall he made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Hauterive.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the hank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not lie redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will lie opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, Septemlier 30, 1903, at 7:30 o'clock p.m., at the usual place for meetings, Hauterive, county of Saguenay.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Hauterive, (County of Saguenay), September 11.1963.Gilbert Moffatt, Secretari/-Treasurer.P.O.B.1150, Hauterive, (Saguenay), P.Q.Telephone : 589-2071.4074 Syndicat professionnel Le Syndicat des Producteurs de Bleuets de Tchitagama (U.C.C.) (Loi des syndicats professionnels) La constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « Ijc Syndicat des Producteurs de Bleuets de Tchitagama (U.C.C.) », a été autorisée par le Secrétaire de la province le 8 août 1963.Le siège social dudit syndicat professionnel est situé à Notre-Dame-du-Rosaire, district judiciaire de Chicoutimi.Québec, le 13 août 1963.Le Sous-sercétaire de la province, 4014-o Ratmonu Douville.Professional Syndicate Le Syndicat des Producteurs de Bleuets de Tchitagama (U.C.C.) (Professional Syndicates' Act) The incorporation af a professional syndicate, under the name of \"Le Syndicat des Producteurs de Bleuets de Tchitagama (U.C.C.)\", has lieen authorized by the Provincial Secretary on August 8, 1963.The head office of the said professional syndicate is situated at Notre-Dame-du-Rosaire, judicial district of Chicoutimi.Quebec.August 13, 1963.Raymond Douville, 4014 Assistant Secretary of the province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14.1666, l'ol.96, So.37 4407 Ventes par licitation St - Arnaud r.s St-Arnuud et al Canada, Province de Quebec, district de Trois-Rivières, Cour Supérieure, No: 26-021.André St-Arnaud, demandeur, vu Joseph St.Arnaud et al., défendeurs.Avis de licitation Avis public est par le présent donné que par et en vertu «l'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à Trois-Rivières, dans le district de Trois-Rivières, le 20 juillet 1963, dans une cause dans laquelle André St-Arnaud, comptable agréé, résidant et domicilié dans les cité et district de Trois-Rivières est demandeur, et Joseph St-Arnaud, résident à Vancouver, dans la province de la Colombie Britannique, Camille St Arnaud, résidant et domicilié au No 1174, Dchuilion, cité et district de Montréal, Émilien St-Aruaud, résidant et domicilié au No 2357, Notre-Dame, cité et district «le Montréal, Dame Bernadette St Arnaud, é|K>use «le Pierre Hamel, résidant tous deux «lans les cité et «listrict de Montréal, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes si besoin est, Jeanne St-Arnaud, Anna St-Arnaud, Kusèbe St-Arnaud, Armand St-Arnaud, tous quatre de lieux inconuus sont défendeurs, ordonnant la licitation de certains immeubles désignés comme suit, savoir: a) « Un emplacement situé dans le village de la dite paroissse de Ste-Geneviève, portant le numéro quatre-vingt-neuf (89), «lu cadastre officiel de la dite paroisse de Ste-Geneviève, avec la maison et autres bâtisses dessus construites.» b) « Un lopin de terrain pris sur la terre de la Fabrique susdite, terre connue sous le numéro soixante-neuf (P.69) des plan et livre de renvoi officiels de la dite paroisse «le Ste-Geneviève, et lopin contenant trente-huit pieds anglais de largeur par cent f Montreal ami composed of the northeast h.'lf « f lot number sixty-four of the origin-1 lot number one hundred ami twenty (120-N.E.]/2 64) on the official plan and book of reference of the incorporated village of Ced, they will be foreclose*! from so doing.A deposit cf two thousand dollars must be made by each bidder with every bid for such emplacement.Montreal, September 9, 1963.GaKONCK & ScilNAIBKReJ, Attorneys for Phintiff.Garonce & Schnaibcrg, Advocates, Attorneys for Plaintiff, 400 Ontario Street West, Montreal, Telephone: Victor 4-1083.4040-37-2-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, VMS, Vol.05, So.97 4409 Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sou«-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ARTHABASKA Fieri Facias de Bonis et de terris District d'Artliaha.ska Cause i A LBERT TELLIER, employé No 17918.orné en front au sud-est par la rue dogues, au sud-ouest par le lot 139-665, au nord-ouest par le résidu des mêmes lots appartenant à la Commission Scolaire, et au nord-est par le résidu du lot 139-Ptie 663.» Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Simon de Drummondville-Sud, SAMEDI, le DIX-NEUVIÈME jour d'OCTOBRE 1963.\" à UNE heure de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Léo Faucher.Le 9 septembre 1963.4042-37-2-0 Sheriffs* Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ARTHABASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris District of Arthahaska Case./ A LBERT TELLIER, factory No.17918.\"S ** employee of the city and ' district of Trois-Rivières, in his capacity as testamentary executor of the estate of Laura Tellier, in her lifetime of Drummond-ville.district of Arthahaska, plaintiff, vs EL-PHÈGE FAVREAU, of Drummondville-South, district of Arthahaska, defendant.\"A lot of land with buildings thereon constructed, measuring eighty feet in width by one hundred feet in depth, English measure, more or less, known and designated in the official'plan and hook of reference for the cadaster of the township of Grantham, county of Drummond.as being part of lot number six hundred and sixty-four and the 30 southwest feet of lot six hundred and sixty-three of the official subdivisions of lot one hundred and thirty-nine (139 P.664 and P.663), bounded in front, on the southeast by dogues St., on the southwest by lot 139-665, on the northwest by the remainder of the same lots belonging to the School Commission, and on the northeast by the remainder of lot 139-P.663.\" To be sold at the parochial church door of St-Simon in Drummondville-South, on SATURDAY, the NINETEENTH day of OCTOBER, 1963, at ONE o'clock in the afternoon.Leo Faucher, Sheriff's Office, Sheriff.September 9, 1963.4042-37-2 BEAUCE Fieri Facias de Terris District de Beauce Cour Supérieure, ( T> OLAND CARON, indus- No 121-881.\"J -1-Mriel, domicilié sur la Rou-' te Rurale No 1, St-Henri, comté de Levis, contre GERARD MARQUIS, St-A use line, comté de Dorchester, à savoir: « Un immeuble situé sur la route 53 à St-Anselme, comté de Dorchester, P.Q., comprenant lot P-52-1 et lot P-57-1 avec bâtisses.» Pour être vendus « en bloc » à la porte de l'église paroissiale, de la paroisse de St-Ànselme, Dorchester, le DIX-SEPTIÈME jour du mois d'OCTOBRE 1963, à ONZE heures de Pavant-midi.Le Député-Shérif, Adolphe Rexy.Bureau du Shérif, St-Joseph de Beauce, 9 septembre 1963.4043-37-2-o BEAUCE Fieri Facias de Terris District of Beauce Superior Court, i \"D OLAND CARON, indus-No.121-881.\\ trialist, domiciled on Ru-' ral Route No.1, St-Henri, County of Levis, versus GÉRARD MARQUIS St-Anselme, county of Dorchester, to wit: \"An immoveable situated on Route 53 in St-Anselme, county of Dorchester, P.Q., comprising lot P-52-1 and lot P-57-1 with buildings.To be sold \"en bloc\" at the parochial church door in the parish of St-Anselme, Dorchester, on the SEVENTEENTH day of the month of OCTOBER, 1963.at ELEVEN o'clock in the forenoon.Adolphe Reny, Deputy-Sheriff.Sheriff's Office, St-Joseph de Beauce, September 9, 1963.4043-37-2 CHICOUTIMI Fieri Facias District de Chicoutimi Cour Supérieure, f THE WESTERN SAV-No 33,382.{ A INGS AND LOAN AS-l SOCIATION, corporation lé- CHICOUTIMI Fieri Facias District of Chicoutimi Superior Court, I T»HE WESTERN SAV-No.33,382.< INGS AND LOAN AS-' SOCIATION, a corporation 4410 V.AZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 1J, septembre 1963, Tome 96, No 37 gaiement constituée ayant son siège social en la legally incorporated, having its head office in cité de Winnipeg, dans la province du Manitoba, the city of Winni|>eg, in the province of Manitoba, et faisant affaires dans la province de Québec, et and carrying on business in the province of Que- ayant élu domicile pour les fins des présentes bee, and having elected domicile for the purposes dans la cité d'Arvida, district de Chicoutimi, of the these presents in the city of Arvida, district demanderesse M JEAN-EUDES TREMBLAY, of Chicoutimi, plaintiff, vs JEAN-EUDES résidant à 321.rue Ross, Arvida.district de TREMBLAY, residing at 321 Ross; St., Arvida, Chicoutimi, défendeur.district of Chicoutimi, defendant.Tout ce lot de terre connu et désigné aux plan This whole lot of laud known and designated et livre de renvoi officiels de la cité d'Arvida, sous on the official plan and book of reference of the le numéro cent quatre-vingt-dix-huit de la sub- city of Arvida, under number one hundred and division du lot numéro vingt-quatre (24-198) situé ninety-eight of the subdivision of lot number sur le coté nord de la vingt-deuxième rue en la twenty-four (24-198) situated on the north side cité d'Arvida, de forme irrégulière, mesurant of the twenty-second street in the city of Arvida, cinq pieds et soixante-dix centièmes (5.70') sur of irregular form, measuring five feet and seventy une partie et trente-neuf pieds et soixante-six hundredths (5.70') on one part and thirty-nine centièmes (39.66') sur l'autre partie du côté feet and sixty-six hundredths (39.66') on the nord, quatre-vingt-seize pieds et cinquante con- other part at the north side, ninety-six feet and tièmes (96.50') au côté est, cinquante (50) pieds fifty hundredths (90.50') at the east side, fifty de long de la courbe formée par la rue au côté sud (50) feet long from the curve formed by the street et quatre-vingt-quinze pieds et cinquante et un to the south side and ninety-five feet and fifty-one centièmes (95.51 ) au côté ouest et contenant en hundredths (95.51') at the west side and contain- superficie quatre mille cinq cent cinquante (4550) ing in superficial area four thousand five hundred pieds carrés, plus ou moins, mesure anglaise.and fifty (4550) square feet, more or less, English measure.Avec ensemble toutes les bâtisses dessus cons- Together with all the buildings thereon erected, truites, circonstances et dépendances.circumstances and dependencies.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale To be sold at the parochial church door of de St-Jacques, à Arvida.le VINGT-SIXIÈME St-Jacques, at Arvida, on the TWENTY-SIXTH jour du mois de SEPTEMBRE 1963, à TROIS day of SEPTEMBER.1963.at THREE o'clock heures de l'après-midi.in the afternoon.Le Shérif, René Dblihlb, Bureau du Shérif, René Delisle.Sheriff's Office, Sheriff.Chicoutimi, le 16 août 1963.3849-34-2-o Chicoutimi, August 16, 1963.3849-34-2 G ASPÊ Canada \u2014 Province de Québec District de Gaspé Cour Supérieure.( fi ERM AINE ST-LAU-No 26,714.< vJ RENT, marchande pu-' blique, épouse contractuellement séparée de biens de Gabriel Maloney, huissier, de l'endroit appelé St-Joachim de Tourelle, district de Gaspé, et y faisant affaires seule sous la raison sociale de MAGASIN DU CHIC et ledit Gabriel Maloney comparaissant aux fins d'autoriser son épouse, demanderesse, es ERNEST LABRIE, de l'endroit appelé Petite Tourelle, district de Gaspé, défendeur.« Une maison, circonstances et dépendances, sise sur subdivision numéro neuf du lot numéro vingt (20-9) au cadastre revisé du premier rang, Canton Tourelle.» Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Joachim de Tourelle, comté et district de Gaspé, LUNDI, le SEPTIÈME jour d'OCTOBRE 1963, à ONZE heures de l'avant-midi.L» Shérif, Bureau du Shérif, Percy Biard.Percé, ce 19 août 1963.3870-34-2-o HULL Canada \u2014 Province de Québec District de Hull Cour de Magistrat, i T ES HÉRITIERS DE No 7164 { FEU J.C.ROSSI-' GNOL, de son vivant médecin de la ville d'Ottawa, Ontario, demandeurs, vs EARL McCONNERY, de Kazabazua, P.Q.défendeur.GASPÉ Canada \u2014 Province of Quebec District of Gaspe Superior Court, { /GERMAINE ST-LAU-No.26,714.< RENT, public mer.' chant, wife contractually separate as to property of Gabriel Maloney, bailiff, of the place called St-Joachim de Tourelle, district of Gaspé, and carrying on business alone under the style and name of MAGASIN DU CHIC and the said Gabriel Maloney appearing for the purpose of authorizing his wife, plaintiff, vs ERNEST LABRIE, of a place called Petite Tourelle, district of (Jaspé, defendant.\"A house, circumstances and dependencies, situated on subdivision number nine of lot number twenty (20-9) on the revised cadaster of the first range, township of Tourelle.\" To be sold at the parochial church door of St-Joachim de Tourelle, cohty and «listrict of Gaspé, MONDAY, the SEVENTH day of OCTOBER, 1963, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Percy Biaru, Sheriff's office, Sheriff.Percé, August 19, 1963.x 3870-34-2 HULL Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Magistrate's Court, i THE HEIRS OF THE No.7164 < A LATE J.C.ROSSI-' GNOL, during his lifetime physician of the City of Ottawa, Ontario, plaintiffs, vs EARL McCONNERY, of Kazabazua, P.Q., defendant. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1903, Vol 96.So.37 4411 Une partie du lot numéro 17, rang 10, canton d'Aylwin, décrite plus particulièrement comme suit: Commençant à une certain point situé sur la limite sud du chemin conduisant de Kazabazua Station au Lac Dan ford; ledit point étant à 125 pieds ù l'ouest d'un point près de l'intersection d'un autre chemin conduisant au Petit Lac Danford; dudit point vers l'ouest et suivant la limite sud dutlit chemin conduisant de Kazabazua au Lac Danford, une distance de 400 pieds, plus ou moins; de là, vers le sud à un certain point situé sur la rive du lac Shea dans une ligne parallèle de et à une distance de 275 pieds de la limite ouest de lu propriété Forestier; de là vers l'est, suivant la rive nord du lac Shea à un point; de là vers le nord le long de la clôture de limite de la propriété de M.Begley, ladite clôture étant sur une ligne parallèle à la limite Est de la propriété Begley, une distance de 125 pieds au point «le départ; ladite parcelle de terrain étant bornée comme suit: Au nord par le chemin ci-dessus conduisant de Kazabazua au Lac Danford, au sud par le Lac Shea; à l'Est par la propriété «le David Begley, à l'ouest par la propriété de Mme, C.Forester.Avec tous les membres et dépendances y appartenant, et avec toutes les scrvitud«>s y attachées ou s'y rapportant.Pour être vendu à la porte de la Chapelle Notre-Dame du Mont Carmel, dans le Village de Kazabazua, district de Hull, le VINGT-HUITIÈME jour de SEPTEMBRE, 1963, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.St-Pierre.ce 13 août, 1963.3871-34-2-o Canada \u2014 Province de Québec District de Hull Cour Supérieure, [CCONO HEATING No 4509.'S ^ OTTAWA LTD., corps ' pol i tique et incorporé ayant sa principale place d'affaires dans la cité- d'Ottawa, province d'Ontario, demanderesse, te L.W.NOËL (QUÉBEC) LTÉE., corps politique et incorporé, ayant sa principale place d'affaires à Pointe-Gatineau, district de Hull, défenderesse, et OMER MASSE, des cité et district de Hull, en sa qualité de registrateur de la division d'enregistrement de Hull, dit district, mis-en-cause.« Les lots 570-17, 570-18, 570-19, 570-35 et 570-30, aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de Pointe-Gatineau, avec bâtisses dessus érigées, circonstances et «lépendances ».Pour être vendus à la porte de l'église St-François de Sales, en la ville de Pointe-Gatineau, le DIX-SEPTIEME jour d'OCTOBRE, 1903, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.St-Pierre.ce 10 septembre.1903.4062-37-2-o Part of lot number 17, range 10, township of Aylwin, described more particularly as follows: Commencing at a certain point situated on the south limit of the road leading from Kazabazua Station to Danford Lake; the said point being at 125 feet to the west from a point near the intersection of another road leading to Petit Lac Danford; from the said point toward the west and following the south limit of the said roa«l leading from Kazabazua to Danford Lake, a distance of 400 feet, more or less; thence, toward the south to a certain point situated on the shore of Shea Lake in a parallel line from und at a distance of 275 feet from the west limit of the Forester property; thence toward the east, following the north shore of Shea Lake at a point; thence toward the north along the limiting fence of Mr.Begley's property, the said fence being on a parallel line to the East limit of Begley's property, a distance of 125 feet to the starting point; the said piece of land being hounded as follows: on the north by the road above-mentioned leading from Kazabazua to Danford Lake, on the south by Shea Lake; on the east by David Begley's property, on the west by Mrs.C.Forester's property.With all the members and dependencies belonging thereto, and with all the servitudes attached or pertaining thereto.To he sold at the Chapel «loor of Notre-Dame du Mont Carmel, in the Village of Kazabazua, district of Hull, the TWENTY-EIGHTH day of SEPTEMBER, 1963.at THREE o'clock in the afternoon.R.St-Pierre, Sheriff's office, Sheriff.August 13, 1963.3871-34-2 Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Superior Court, ftfCONO HEATING No.4509.\\ J-» OTTAWA LTD., body ' politic and corporate having its principal place of business in the city of Ottawa, province of Ontario, plaintiff vs L.W.NOËL (QUEBEC) LTÉE, body politic and corporate, having its principal place of business in Pointe-Gatineau, district of Hull, defendant and OMER MASSE, of the city and district of Hull, in his capacity of registar of the registration division of Hull, said district, mis-en-cause.\"Lots 570-17, 570-18, 570-19, 570-35 and 570-30, on the official plan and in the book of reference of the cadaster of Pointe-Gatineau, with building thereon erected, circumstances and dependencies\".To be sold at the church door of St.François «le Sales, in the city of Pointe-Gatineau, the SEVENTEENTH dav of OCTOBER, 1963, at THREE o'clock in the afternoon.R.St-Pierre, Sheriff's Office, Sheriff.September 10, 1963.4062-37-2 KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Rimouski et Kamouraska Cour Supérieure, ( BENEFICIAL FINANCE «le Rimouski )£> COMPANY OF CA-No 25,269 \\ NADA, demanderesse, vs (MARTIN PELLETIER et JEANNE SOUCY, défendeurs.KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Rimouski and Kamouraska Superior Court I BENEFICIAL FINANCE of Rimouski )D COMPANY OF CA-No.25,269.\\ NADA, plaintiff, vs MARTIN (PELLETIER and JEANNE SOUCY.defendants _ 4412 Il A Z ET TE OFFICIELLE DE QUEBEC, 14 septembre 1063, Tome 05, So 37 « I.es lots 2(1 et 27 «lu rang 0, canton Robinson, St .Iran de la Lande, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendus à lu porte de l'église de St-Jean de la Lande, comté de Témiscouata, le VTNGT-TROISIEMK (23) jour d'CXTOBRE 1903.ù TROIS (3) heures de l'après-midi.U Shérif, Maurice Mkin.Kureuu du Shérif, Rivière-dii-IiOtip.le 10 septembre 1003 40()3-37-2-o \"Lots 20 and 27 of range 0, township of Robinson, St-Jean de la Lande, with buildings thereon erected, circumstances ami dependencies.\" To be sold at the church door of St-Jean de lu Lande, county of Témiscouata, the TWENTY-THIRD (23rd) .lay of OCTOBER, 1988, at THREE (3) o'clock in the afternoon.Maihick Mokin, Sheriff.Sheriff's office, Rivière-du-Loup.September 10.1903.4003-37-2 M É G A N T I C Fieri Facias de Bonis et de Terris District de Mégantie Cour Supérieure, J pORANO LIMITEE, com-No 2812.\\ * pagnie à fonds social ' constituée en corporation, ayant son siège social à Plessisville, demanderesse, vs ARMAND ROY, industriel de St-Ferdinand, défendeur.Avis de vente « Les lots 327-4, 327-20, 330-3 et 331-8 du 'cadastre officiel revisé de la paroisse de St-Fer-dinand, canton d'Halifax pour la municipalité du village de Bernierville.» Pour être vendus séparément à la porte de l'église paroissiale de St-Ferdinand, comté de Mégantie, le VINGT-HUITIÈME jour de SEPTEMBRE 1963, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, 3864-34-2-0 Denis Guenette.M Ê G A N T I C Fieri Facias de Bonis et de Terris District of Mégantie Superior Court, f pORANO LIMITÉE, joint No.2812.\\ stock company incorporated, having its head office at Plessisville, plaintiff, m ARMAND ROY, industrialist of St-Ferdinand, defendant.Notice of sale \"Lots 327-4, 327-20, 330-3 and 331-8 of the revised official cadastre of the parish of St-Ferdinand, township of Halifax for the municipality of the village of Bernierville.\" To be sold separately at the parochial church door of St-Ferdinand, county of Mégantie, on the TWENTY-EIGHTH day of SEPTEMBER, 1963, at TEN o'clock in the forenoon.Denis Guenette, 3864-34-2 Sheriff.QUEBEC Fieri Facias Québec, à savoir: ( T OFFICE DU CRÉDIT No 123-211.\\ AGRICOLE DU QUÉ-l BEC, corps politique et Incorporé, ayant son siège social à Québec, contre THOMAS BÉLANGER, cultivateur de La T uque.Rivière Croche, comté d:* Laviolette.« Lot no 43 rang ouest du canton Langelier, borné à l'ouest par le No 93, à l'est par la Rivière Croche; au sud par le No 42 et au nord par le No 44, mesurant treize chaînes (13) de largeur, sur une profondeur moyenne de cent cinquante-quatre chaînes (154); contenant en superficie deux cent un acres (201 -0) Lot No 44 rang ouest du canton Langelier borné à l'ouest par le No 93, à l'est par la Rivière Croche; au sud par le No 43 et au nord par le No 45, mesurant treize chaînes (13) de largeur sur une profondeur moyenne de cent cinquante-cinq chaînes (155), contenant en superficie deux cent deux acres (202-0) circonstances et dépendances, avec maison dessus construite.» Pour être vendu à la porte de l'Église de Saint-Hippolyte, Comté de Champlain le VINGT-SEPTIÈME jour de SEPTEMBRE prochain à DIX heures de l'avant midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Antoine Bouroet, c.r., Québec, 21 Août 1963.3878-34-2-o QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit: ( /QUEBEC FARM CREDIT No.123-211.< BUREAU, body politic ' and corporate, having its head office at Quebec, agamst THOMAS BÉLANGER farmer, of La Tuque, Rivière Croche, County of Laviolette.\"Lot No.43, west range of the township of Langelier, bounded on the west by No.93, on the west by the Rivière Croche; on the south by No.42 and on the north by No.44, measuring thirteen chains (13) in width by a medium depth of one hundred and fifty-four chains (154); containing in superficial area two hundred and one acres (201-0) Lot No.44, west range of the township of Langelier bounded on the west by lot No.93, on the east by the Rivière Croche; on the south by No.43 on the north by No.45, measuring thirteen chains (13) in width by a medium depth of one hundred and fifty-five chains (155), containing in superficial area two hundred and two acres (202-0), circumstances and dependencies, with house thereon erected.\" To be sold at the church door of Saint-Hippo- , lyte, county of Champlain, on the TWENTY-SEVENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o'clock in the forenoon.Antoine Bourget, q.c, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, August 21, 1963.3878-34-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, 1963, Vol.96, So.37 4413 RIMOUSKI Fieri Facias de Bonis et de Tetris Canada \u2014 Province de Québec District de Rimouski Cour Supérieure, ( pvAME MARIE BLAN- No 21-698.< LJ CHE PARADIS, épou-v se séparée de corps de Leopold St-Laurent, domiciliée à Rimouski, dit district, demanderesse, vs LEOPOLD ST-LAURENT, marchand, de St-Benoit Joseph Labre d'Amqui, district de Rimouski, défendeur.Un terrain situé en la paroisse de St-Pierre du Lac, contenant cent vingt-quatre (124) pieds de largeur au terrain restant au bailleur, allant en rétrécissant au Lac Matapédia sur cent quatre-vingt-dix (190) pieds de profondeur, faisant partie du lot connu et désigné sous le numéro un (P.1) du cadastre officiel de la paroisse de St-Pierre du Lac, premier rang, de la Seigneurie du Lac Matapédia, avec droit de passage dans le chemin actuel, à pied ou en automobile, par le preneur des ayants droits ou représentant légaux, ledit terrain est borné d'un côté au terrain de Georges Larouche, d'un côté au terrain du bailleur d'un côté au Lac et de l'autre au terrain du bailleur, c'est un bail emphythéotique, de douze dollars par année payable à Pierre Beaulicu, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église de la Karoisse de Val-Brillant, le VINGT-CINQUIÈ-IE jour de SEPTEMBRE 1963, à DEUX heures de l'après-midi.U Député-Shérif, Jacques Martin.Bureau du Député-Shérif, Rimouski, 20 août 1963.3873-34-2-o Fieri Fadas de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Rimouski Cour Supérieure, ( T AURETTE LEPAGE, No 28-800.\\ *-* épouse contractuellement ' séparée de biens de Raynald Landry, domiciliée à 4 rue Champlain à Nazareth, district de Rimouski, demanderesse vs RAYNALD LANDRY, vétéran, domicilié à 30 rue St-Pierre, en la cité de Rimouski, défendeur.De figure irrégulière, borné au nord-ouest par les lots 26-19 et 26-20, au nord-est par le lot 26-59, au sud-est par le lot 26-30 (rue), au sud-ouest par le lot 26-23, mesurant 193.6' au nord-ouest, 87.5' au nord-est, 164 au sud-est, 130 au sud-ouest, contenant en superficie (22,242 p.c), mesure anglaise, étant le lot No 26-24 au cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame du Sacré-Coeur, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y en a.Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Notre-Dame du Sacré-Coeur, le DIX-SEPTIÈME jour d'OCTOBRE, 1963, à DEUX heures de l'après-midi.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, Jacques Martin.Rimouski, 9 septembre 1963.4044-37-2 Fieri Facisa de Terris Canada \u2014Province de Québec District de Rimouski.Cour Supérieure f T UDGER DUMAIS, domi-No 28-901 \\ cilié à Matane, district ' de Rimouski, demandeur vs PAUL MARIE BERNIER, demeurant à Les Méchins, district de Rimouski, défendeur.RIMOUSKI Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Rimouski Superior Court, { \"TvAME MARIE BLANCHE No.21-098.{ U PARADIS, wife separate ' as bed and hoard of Leopold St-Laurent, domiciled at Rimouski, said district plaintiff.M LEOPOLD ST-LAURENT, merchant, of St-Benoit Joseph Labre d'Amqui, district of Rimouski, defendant.A piece of land situate in the parish of St-Pierre du Lac, containing one hundred and twenty-four (124)' feet in width to the land lessor's remaining property, narrowing to lake Matapédia by one hundred and ninety feet (190) in depth, being part of the lot known and designated under number one (P.1) of the official cadaster of the parish of St-Pierre du Lac, first range, of the Seigniory of Matapédia Lake, with right of wuy in the present road, on foot or car, by the lesser of whoever have the rights or legal representatives, the said piece of land is hounded on a side by Georges Larouche's land, on a side by the lessor's land, on a side by the lake and on the other side by the lessor's land, it is an emphyteutic lease, of twelve dollars a year payable to Pierre Beaulieu, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of the parish of Val-Brillant, on the TWENTY-FIFTH day of SEPTEMBER, 1903, at TWO o'clock in the afternoon.Jacques Martin, Deputy-Sheriff.Office of the Deputy-Sheriff, Rimouski, August 20, 1963.3873-34-2 Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Rimouski Superior Court, 1 T AURETTE LEPAGE, No.28-800.\\ J-' wife contractually sepa-l rate as to property of Raynald Landry, domiciled at 4 Champlain St., at Nazareth, district of Rimouski, plaintiff, vs RAYNALD LANDRY, veteran, domiciled at 30 St.Peter St., in the city of Rimouski, defendant.Of irregular form, bounded on the northwest by lots 26-19 and 26-20, on the northeast by lot 26-59, on the southeast by lot 26-30 (street), on the southwest by lot 26-23, measuring 193.6' at the northwest, 87.5' at the northeast, 164 at the southeast, 130 at the southwest, containing in superficial area (22,242 s.L), English measure, being lot No.26-24 on the official cadaster of the parish of Notre-Dame du Sacré-Coeur, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, if any.To be sold at the church door of the parish of Notre-Dame du Sacré-Coeur, on the SEVENTEENTH day of OCTOBER, 1963, at TWO o'clock in the afternoon.Jacques Martin, Sheriff's Office, Deputy-Sheriff.Rimouski, September 9, 1963.4044-37-2-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Rimouski Superior Court, ( T UDGER DUMAIS, donri-No 28-001 < \u2022L'ciled at Matane, district of t Rimouski, plaintiff vs PAUL MARIE BERNIER, residing at Les Méchins, district of Rimouski, defendant. 4414 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1968, Tome 95, So 87 Le lot No 25-A-7, rang 1, Village des Méchins, au cadastre officiel de la paroisse de St-Édouard des Méchius, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de St-Êdouard des Méchins, le SEIZIÈME jour d'OCTOBRE, 19(53.à TROIS heures et DEMIE de l'après-midi, (heure de l'Atlantique).Le Député-Shérif.Bureau du Shérif.Jacques Martin.Rimouski.9 septembre 1963.4045-37-2-o Fieri Facia* de Terris Canada \u2014 Province de Quéln-c District de Rimouski Cour Supérieure, i /CHARLES GOSSELIN.No 27-097 \\ ^ marchand, domicilié à l Petite-Matanc, district de Rimouski, demandeur M LÉONARD LANGLOIS, demeurant à Grosses-Roches, district de Rimouski, défendeur.Les lots Nos (43-45-46), rang 3, canton Cherbourg, situés en la paroisse de Grosses-Roches, les impences, améliorations et les défrichements et tous les droits de préemption que le défendeur a ou peut avoir sur lesdits lots, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de Grosses-Roches, le SEIZIÈME jour d'OCTOBRE 1963, à DEUX heures de l'après-midi, (heure de l'Atlantique).Le Député Shérif, Bureau du Shérif, Jacques Martin.Rimouski.9 septembre 1963.4046-37-2-o SAGUENAY Canada \u2014 Province de Québec District de Saguenay Cour Supérieure, ( CEPT ILES READY MIX No 21-758.< O & EQUIPMENT INC., 'corporation légalement constituée ayant une place d'affaires à Sept-Iles, district de Saguenay, demanderesse, vs LES DÉVELOPPEMENTS DU SAGUENAY LTÉE., corps politique et incorporé ayant sa principale place d'affaires à Sept-Iles, district de Saguenay, demanderesse.a Les subdivisions du lot 9 du rang 1, du canton Letellier du cadastre de Sept-Iles, soit: 9-1 à 9-27 inclusivement.Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Et en plus, le résidu du lot 9 du rang 1 canton Letellier non subdivisé, à distraire les parties déjà vendues et enregistrées sous les numéro 720, 721, 722, 723, 724, 725, 727, 728, 729.730, 731, 732, 757, 758 et 1014.s Pour être vendu à l'Hôtel de Ville de la cité de Sept-Iles, le VINGT-CINQUIÈME jour de SEPTEMBRE 1963 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Elzear Villeneuve.La Malbaie, le 15 août 1963.3850-34-2-o Canada \u2014 Province de Québec District de Saguenay Cour Supérieure, f MERCANTILE No 22-048.\\ A BANK OF CANADA, ' corps politique et incorporé ayant son siège social et principale place d'affaires poor la province de Québec en les cité et district Lot No.25-A-7, range 1.Village of Les Méchins on the official cadaster of the parish of St.Edouard des Méchins, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of the parish of St.Edouard des Méchins, on the SIXTEENTH day of October.1963, at THREE THIRTY o'clock in the afternoon, (Atlantic time) Jacques Martin, Deputy-Sheriff Office, Deputy-Sheriff.Rimouski, September 9, 1963.4045-37-2 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Rimouski Superior Court, fp H ARLES GOSSELIN.No.27-097 \\ ^ merchant, domiciled at ' Petite-Matanc, district of Ri.mouski, plaintiff, vs LÉONARD LANGLOIS.living at Grosses-Roches, district of Rimouski, defendant.Lots Nos.(43-45-46), range 3, township of Cherbourg, situated in the parish of Grosses-Roches, upkeep and improvements and clearings and all the preempt ion rights which the defendant has or may have on said lots, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of the parish of Grosses-Roches, the SIXTEENTH day of OCTOBER, 1963, at TWO o'clock in the afternoon, (Atlantic time).Jacques Martin, Deputy Sheriff's Office, Deputy Sheriff.Rimouski, September 9, 1963.4046-37-2 SAGUENAY Canada \u2014 Province of Quebec District of Saguenay Superior Court, I CEPT ILES READY MIX No.21-758.\\ & & EQUIPMENT INC., ' corporation legally incorporated, having a place of business at Sept-IIes, district of Saguenay, plaintiff, vs LES DÉVELOPPEMENTS DU SAGUENAY LTÉE, body politic and incorporated, having its principal place of business at Sept-IIes, district of Saguenay, defendant.\"Subdivisions of lot 9 in range 1, township of Letellier on the cadaster of Sept-IIes, namely: 9-1 to 9-27 inclusively.With buildings thereon erected, circumstances and dependencies.And furthermore, the residue of lot 9, of range 1, township of Letellier unsuhdivided, to withdraw the parts already sold and registered under numbers 720, 721.722, 723, 724, 275.727, 728, 729, 730, 731, 732, 757.758 and 1014.\" To be sold at the City Hall of the city of Sept-IIes, on the TWENTY-FIFTH day of SEPTEMBER, 1963, at TEN o'clock in the forenoon.Elzéar Villeneuve, Sheriff .s Office, Sheriff.La Malbaie, August 15, 1963.3850-34-2 Canada \u2014 Province of Quebec District of Saguenay Superior Court, ( rT%HE MERCANTILE No.22-048.\\ *¦ BANK OF CANADA, ' a body politic and corporate having its head office and principal place of business for the Province of Quebec in the city and QUEBEC OFFIVlAL GAZETTE, September 14.1963, Vol.95, No.37 4415 de Montréal, demanderesse, w NAPOLÉON GAGNON, du district de Saguenay, y résidant à Port Neuf sur Mer, P.Q., défendeur.f Un terrain situé aur la Seigneurie Mille Vaches, dans le village de Port Neuf sur Mer, d'une grandeur d'environ cent soixante (160') au chemin et de cent soixante dix pieds (1700 »u bord de la grève, et borné comme suit: au sud-est par la grève, au sud-ouest par la succession de Dame Léandre Bouchard, au nord-ouest par le chemin du Roi, et au nord-est par Lucien Tremblay; maison et dépendances, le tout tel que clôturé actuellement, sous réserve des droits fonciers.» Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Port Neuf sur Mer, le VINGT-SEPTIÈME jour de SEPTEMBRE 1063, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Elzéar Villeveuve.La Malbaie, le 16 août 1963.3856-34-2-o district of Montreal, plaintiff, vs NAPOLONÊ GAGNON, of the district of Saguenay, therein residing at Port Neuf sur Mer, P.Q., defendant.\"A piece of land situated on the Seingeurie Mille Vaches, in the village of Port Neuf sur Mer, measuring about one hundred and sixty feet (1600 to the road and one hundred and seventy feet (170') to the edge of the beach, and bounded as follows: on the south-east by the beach, on the south-west by the estate of Dame Léandre Bouchard, on the north-west by the King's highway, and on the north-east by Lucien Tremblay; house and dependencies, the whole as fenced presently, under reserve of landed rights.\" To be sold at the church door of the parish of Port Neuf sur Mer.the TWENTY-SEVENTH day of SEPTEMBER.1963, at TWO o'clock in the afternoon.Elzéar Villeneuve, Sheriff's Office, Sheriff.La Malbaie, August 16, 1963.3S56-34-2 Canada \u2014 Province de Québec District de Saguenay Cour Supérieure, ( THE MERCANTILE No 21-504.< j- BANK OF CANADA, ' un corps politique et incorporé, ayant sa principale place d'affaires pour la province de Québec, en les cité et district de Montréal, demanderesse, vs ARISTIDE HO-VINGTON, du district de Saguenay, et y résidant à Ruisseau Vert, défendeur.« Une maison d'environ 20 x 20 pieds sise et située sur une partie du lot No 40 du rang 2 du canton Ragueneau.Lot en location du Ministère de la Colonisation et dont le locataire actuel est M.Elzéar Êmond.Sous réserve des droits du propriétaire du terrain.\u2022 Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Raguenau, comté de Saguenay, le VINGT-SEPTIEME jour de SEPTEMBRE 1963 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Elséar Villeneuve.La Malbaie, le 16 août 1963.3857-34-2-o \\ SAINT-FRANÇOIS Fieri Farias de Boni» et de Terri» District de St-François Cour Supérieure.( \\/f ORRIS LUMBER LI-No 21 967.{ 1VA MITED, corps politi-' que et incorporé, ayant son principal bureau dans les cité et district de Montréal, demandeur, vs HENRI LOUIS MARTEL, de Lac Mégantie, dans le district de St-François, défendeur.s Les lots de terre numéros deux mille trois cent soixante-quinze-quinze et deux mille trois cent soixante-quinze-seize (Nos.2375-15 et 2375V16) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la ville de Mégantie, sans bâtisse, » propriété de Henri Louis Martel, suivant contrat enregistré au bureau d'enregistrement de Lac Mégantie le 22 janvier 1955, sous le numéro 64534.» Pour être vendus en bloc à la porte de l'église paroissiale de Ste-Agnès, Lac Mégantie, le VINGT-QUATRIÈME jour de SEPTEMBRE 1963, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Don at Jacques.Sherbrooke, ce 16 août 1963.3858-34-2-o [Première insertion le 24 août 1963] Canada \u2014 Province of Québec District of Saguenay Superior Court, l THE MERCANTILE No.21-504.{ A BANK OF CANADA, a body politic and corporate, having its principal place of business for the Province of Quebec in the city and district of Montreal vs ARISTIDE HOVINGTON, of the district of Saguenay, therein residing at Ruisseau Vert, defendant.A house measuring about 20 x 20 feet lying and situate on a part of lot No.40 of range 2, township of Ragueneau.Lot rented from the Department of Colonisation and whose actual tenant is Mr.Elzéar Êmond.Under reserve of landlord rights.\" To be sold at the parochial church door of Ragueneau, county of Saguenay, on the TWENTY-SEVENTH day of SEPTEMBER, 1963, at TEN o'clock in the forenoon.Elzéar Villeneuve, Sheriff's office, Sheriff.La Malbaie, August 16.1963.3857-34-2 SAINT-FRANCIS Fieri Facias de Bonis et de Terris District of St-Francis Superior Court.( \\/f ORRIS LUMBER LI-No.21 967.{ JVl MITED.body politic - and corporate, having its head office in the city and district of Montreal, plaintiff, vs HENRY LOUIS MARTEL, of Lac Mégantie, in the district of St-Francis, defendant.\"The lots of land numbers two thousand three hundred seventy-five-6fteen and two thousand three hundred seventy-6ve-sixteen (Nos.2375-16 and 2375-16) upon the official cadastral plan and book of reference of the town of Mégantie, without building,\" property of Henri Louis Martel, according to deed registered at the registry office of Lac Mégantie the 22nd of January 1955, under number 64534.\" To be sold \"en bloc\" at the door of the parochial church of Ste-Agnès.Lac Mégantie, the TWENTY-FOURTH day of SEPTEMBER 1963, at TEN o'clock, in the forenoon.Don at Jacques, Sheriff's Office, Sheriff.Sherbrooke, August 16, 1963.3858-34-2-0 [First insertion August 24.1963] 4416 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1968, Tome 96, Sp 37 Fieri Facias de Terris District de Saint-François Cour Supérieure.( npHE WESTERN SAV -No 25.601.\\ L INGS & LOAN ASSO-' CIATION, corps politique et incorporé, dûment incorporé, ayant son bureau chef et principale place d'affaire dans la ville de Winnipeg, province du Manitoba, demandeur, es H.J.GIRARD, marchand, autrefois de la ville de Richmond, district de Saint-François et résidant présentement à 150 rue Ontario, Sherbrooke, défendeur.f Ce certain emplacement situé dans la ville de Richmond, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de ladite ville comme le lot cadastral numéro deux cent cinquante et un (251), ensemble avec les bâtisses, améliorations, dépendances et accessoires ci-dessus érigés et y appartenant.» Pour être vendu au Bureau d'enregistrement, à Richmond, le VINGT-CINQUIÈME jour de SEPTEMBRE 1963, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Don at Jacques.Sherbrooke, ce 16 août 1963.3859-34-2-o [Première insertion le 24 août 1963] Fieri Facias de Bonis et de Terris District de St-François Cour Supérieure, ( BENEFICIAL FINANCE No 25 867.\\ U CO.OF CANADA, corps ' politique et incorporé, ayant une place d'affaires dans l'Édifice Continental, à Sherbrooke, district de Saint-François, demanderesse, te LIONEL BEAUREGARD, domicilié et résidant à Bishopton, district de Saint-François, défendeur.« Le lot No 30 B, rang 11 canton Bury.Faisant partie du lot No 30 du lie rang de la subdivision primitive de Bury, borné vers le nord-ouest par le numéro 30 A, vers le nord-est par le numéro 30C, vers le sud-est par un chemin public et vers le sud-ouest par le numéro 29; mesurant dix chaînes en front par cinquante chaînes de profondeur, contenant cinquante acres en superficie.Avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.» « Le lot numéro 30 C, rang 11, canton Bury.Faisant partie du lot numéro 30 du lie rang de la subdivision primitive de Bury, borné vers le nord-ouest par le numéro 30 A, vers le nord-est par le numéro 31 C, vers le sud-est par un chemin public et vers le sud-ouest par le numéro 30 B; mesurant dix chaînes en front par cinquante chaînes de profondeur, contenant cinquante acres en superficie.Avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.» Pour être vendus en bloc à la porte de l'église paroissiale du Saint-Clément, Bishopton, le SEIZIÈME jour d'OCTOBRE 1963, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Don at Jacques.Sherbrooke, ce 4 septembre 1963.4047-37-2-o SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province de Québec District de St-Hyacinthe Cour Supérieure, f A UGUSTE LAPORTE.No 14,838.\\ demandeur, bourgeois vde St-Dominique, district de St-Hyacinthe, vs LES HÉRITIERS DE FEU BERTRAND FONTAINE, de St-Dominique, district de St-Hyacinthe.Fieri Facias de Terris District of St-Francis Superior Court, ( THE WESTERN SAV -No.25,601.\\ A INGS & LOAN ASSO-) CIATION, a body politic and corporate, duly incorporated having its head office and principal place of business in the city of Winnipeg, in the province of Manitoba, plaintiff, vs H.J.GIRARD, merchant, formerly of the town of Richmond, district of St-Francis, and presently residing at 150 Ontario St., Sherbrooke, defendant.\"That certain emplacement situate in the town of Richmond, known and designated upon the official plan and book of reference for the said town as cadastral lot number two hundred and fifty-one (251) together with buildings and improvements, dependencies and accessories thereon found and thereto belonging.\" To be sold at the registrv office, Richmond, on the TWENTY-FIFTH day of SEPTEMBER 1963.at TEN o'clock in the forenoon.Don at Jacques, Sheriff's Office, Sheriff.Sherbrooke, August 16, 1963.3859-34-2-o [First insertion: August 24, 1963] Fieri Facias de Bonis et de Terras District of St-Francis Superior Court, I BENEFICIAL FINANCE No.25,867.{ D CO.OF CANADA, body I politic and corporate, having a place of business in the Continental Building at Sherbrooke, district of St-Francis, plaintiff, vs LIONEL BEAUREGARD, domiciled and residing at Bishopton, district of St-Francis, defendant.\"Lot No.30 B, range 11 township of Bury.Forming part of lot No 30 of the 11th range of the promitive subdivision of Bury, bounded towards the North West by No.30 A, towards the North East by No.30 C, towards the South East by a public road and towards the South West by No.29; measuring ten chains in front by fifty chains in depth, containing fifty sacres in superficies.With buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" \"Lot No.30 C, range 11 township of Bury.Forming part of lot No.30 of the Uth range of the primitive subdvission of Bury, bounded towards the North West by No.30 A, towards the North East by No.31 C, towards the South East by a public road and twards the South West by No.30 B; measuring ten chains in front by fifty chains in depth, containing fifty acres in superficies.With buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold \"en bloc\", at the door of the parochial church of St-Clément, Bishopton, the SIXTEENTH day of OCTOBER 1963, at TEN o'clock in the forenoon.Donat Jacques, Sheriff's office, Sheriff.Sherbrooke.September 4, 1963.4047-37-2-o SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province of Quebec District of St-Hyacinthe Superior Court, i A UGUSTE LAPORTE, No.14,838.\\ gentlemen, of the city land district of St-Hyacinthe plaintiff «s LES HÉRITIERS DE FEU BERTRAND FONTAINE, of St-Dominique, district of St-Hyacinthe. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14, IMS, Vei.96, So.37 4417 1° Un emplacement situé au village de St-Dominique, faisant partie du lot no deux cent soixante-trois (Ptie 263) au cadastre de ladite paroisse, contenant soixante-deux pieds (62') anglais de front sur environ cent cinquante (150') pieds anglais de profondeur plus ou moins, borné en front au chemin du rang St-Dominique nord-est, du côté nord-ouest au terrain de Armand Beaudry, du côté sud-est au terrain ci-après désigné appartenant au débiteur et à la profondeur au terrain d'Émilien Deslandes.Avec une maison et autre bâtisses dessus érigées.2° Un immeuble situé au village de St-Dominique comprenant: a) un terrain de soixante douze pieds de largeur (72'), sur une profondeur de cent quatre pieds (104') «lans la ligne sud-est et de cent dix pieds (110') dans la ligne nord-ouest; b) un terrain situé à l'arrière de celui ci-dessus en a) dont la ligne nord-ouest est le prolongement de la ligne nord-ouest du terrain ci-haut décrit en a) mesurant trente-huit pieds (38') de profondeur par quatre-vingt-quatre pieds (84') de largeur.Ces deux terrains (2) sont connus et désignés au cadastre de ladite paroisse comme faisant partie du lot no deux cent soixante-trois (Ptie 263) et sont bornés comme suit: en front par le chemin public, en profondeur par partie du même lot appartenant à Émilien Deslandcs, du côté nord-ouest au terrain ci-dessus désigné en lot appartenant au débiteur et du côté sud-est au terrain de Albert Boy, le tout mesure anglaise et plus ou moins.Avec une remise en blocs de ciment dessus érigée.Ainsi que le tout se trouve présentement, avec les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, attachées audits immeubles.Pour être vendus à la porte de l'Église paroissiale de St-Dominique, district de St-Hyacinthe, le VINGT-QUATRIÈME jour de SEPTEMBRE 1963, à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif.Gérard Beaudet.St-Hyacinthe, le 19 août 1963.3874-34-2-o 1.An emplacement situated in the village of St-Dominique, being part of lot no.two hundred and sixty-three (Ptie 263) at the cadaster of the said parish, containing sixty-two English feet (62') in front on about one hundred and fifty feet (150') in depth more or less, bounded to the front by the north-east public road of St-Dominique, on north-west by the land of Armand Beaudry, on south-east side to the land hereafter described owned by retailler, and to the depth of Émilien Deslandes' land, With a house ami others buildings thereon erected.2.A property situated in the village of St-Dominique consisting; a) a piece of land of seventy-two feet in width (72'), by one hundred and four feet (104') in the south-east line and of one hundred and ten feet (11 0*)on the north-west lien; b) a piece of land situated on the rear of the one mentioned above in a) which the north-west is the extent ion line of north-west line of the ground described above in a) measuring thirty-eight feet (38') in depth by eighty-four feet (84') in width.These two (2) lands are knowned and designated at the cadaster of the said parish as being part of lot no.two hundred and sixty-three (263 Ptie) and are bounded as follow: On front by the public road, in depth by a part of same lot owned by Émilien Deslandes, on north-west side to the ground above designed in lot owned debitor and on south-seat side to the ground of Albert Roy, the whole in English mesaure and less or more.With a ciment block shed thereon erected.Thus as the whole is presently, with actives servitudes and passives, appearing or ocular, thereon attached to the said buildings.To he sold at the parochial church door of St-Dominique, citv and district of St-Hyacinthe, the TWENTY-FOURTH day of SEPTEMBER, 1963 at ELEVEN o'clock a.m.gérard beaudet, Sheriff's Office.Sheriff.St-Hyacinthe.August 19.1963.3874-34-2-o TERREBONNE Canada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne Cour Supérieure, I \\/fAURICE LAMARCHE, No 50 933.< *?* cultivateur de St-Eus-l tache, district de Terrebonne, demandeur va OVILA BOISVERT, peintre, de St-Eustache, district de Terrebonne, et DAME MADELEINE JAUVIN, épouse judiciairement séparée de biens de Roger Bolduc, suivant un jugement rendu par la Cour Supérieure du district de Montréal, dans la cause No 260355, et ledit ROGER BOLDUC pour autoriser et assister son épouse aux fins des présentes, tous deux de St-Eustache, district de Terrebonne et AUGUSTIN GRÉGOIRE de Montréal, district de Montréal, défendeurs et PETER SPANIER, de St-Eustache, district de Terrebonne, BERNARD LABERGE, de St-Eustache, district de Terre-bonne et LE R ÊGISTRATEUR DU BUREAU D'ENREGISTREMENT du comté des Deux Montagnes, mis-en-cause.Avis de vente TERREBONNE Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, [ \"VyfAURICE LAMARCHE, No.50 933.\\ 1VA farmer of St-Eustache, ' district of Terrebonne, plaintiff, va OVILA BOISVERT, painter, of St-Eustache, district of Terrebonne, and DAME MADELEINE JAUVIN, wife judicially separate as to property of Roger Bolduc, according to a judgment rendered by the Superior Court for the district of Montreal, in case No.260355, and the said ROGER BOLDUC, to authorize and assist his wife in these presents, both of St-Eustache, district of Terrebonne, and AUGUSTIN GRÉGOIRE, of Montreal, district of Montreal, defendants and PETER SPANIER, of St-Eustache, district of Terrebonne, BERNARD LABERGE, of St-Eustache, district of Terrebonne, and THE REGISTRAR FOR THE REGISTRY OFFICE of the county of Two Mountains, mis-en-cause.Sotice of sole L'immeuble ci-après désigné et en la possession du défendeur Augustin Grégoire.The immoveable hereinafter designated, and in the possession of the defendant, Augustin Grégoire. 4418 GAZETTE OFFICIELLE DE QCEJiEC, 14 septembre 1963, Tome 96, So 37 « Un emplacement connu et désigné sous partie du numéro deux cent trente-six (1*.236) «les plan 11 livre de renvei officiels de la pumis.se de St-Eustache avec une maison et remise y érigées, contenant une largeur de quatre-vingt-dix puds par une pn fondeur d'environ trois cent cinquante pieds, mesure anglaise, borné devant par le terrain du Chemin de fer tie The Canadian Northern Ontario Railway d'un côté par le No 237, d'autre côté et en arrière par le reste du No 230 appartenant à la vendere.sse.» Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale catholique de St-Eustachc, (rue St-Louis) JEUDI le DIX-SEPTIEME jour d'OCTOBRE 1963 à DEUX heures de l'après-midi.Conditions; comptant.Le Shérif, Bureau du Shérii.Villknkuve Huot.St-Jérôme, le 9 septembre 1963.4048-37-2-o \"An emplacement known and designated as part of number two hundred and thirty-six (P.236) in the official plan and book of reference for the parish of St-Eustache with a house and shed thereon erected, measuring ninety feet in width by a depth of approximately three hundred and fifty feet, English measure, bounded in front by the land belonging to The Canadian Northern Ontario Railway, on one side by No.237, on the other side and in the rear by the remainder of No.236 belonging to the vendor.\" To he sold at the Catholic parochial church door of St-Eustache (St.Louis St.), on THURSDAY, the SEVENTEENTH .lay of OCTOBER, 1963, at TWO o'clock in the afternoon.Conditions: Cash.Viixeneuce Huot, Sheriff's Office.Sheriff.St-Jérôme.September 9.1963.4048-37 2 TR OIS RI VIE RES TROIS-RIVIÈRES ( 'anada Province de Québec District de Trois-Rivières Cour Supérieure, I T3 ALSTON PURINA CO.No 26734 < LTD., corporation lé-gaiement const it née.ayant son siège social à Woodstock, Ontario, et une place d'affaires à St-Romuald, district de Québec, demanderesse, vs ROBERT LAFRANCE, St-Sévérin de Proulxville, district de Trois-Rivières, défendeur.« Un terrain situé dans le rang de la Côte St-Louis «lans la paroisse de Saint-Sévérin de Proulxville, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro cent cinquante-six (ptie 150) sur le plan et dans le livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Stanislas, mesurant deux arpents trois perches et six pieds, mesure française dé largeur, plus ou moins, par une profondeur de deux cent soixante-dix pieds, mesure anglaise; borné en front vers le nord-est par le chemin public, en profondeur vers le sud-ouest par Edwidge Cossette, joignant du côté nord-ouest Jean-Louis E.Cossette et du côté sud-est Sandy Massicotte.avec une porcherie y dessus construite.» Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Saint-Sévérin de Proulxville, MERCREDI, le SEIZIÈME jour du mois d'OCTOBRE, mil neuf cent soixante-trois, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du shérif, Guy Mercier.Trois-Rivières, le 6 septembre 1963.4049-37-2-o Canada \u2014 Province of Quebec District of Trois-Rivières -n ALSTON PURINA CO.LTD., body legally in- Superior Court, i No.26734 < M'orporated, having its head office in Woodstock, Ontario, and a place of business in St-Romuald, district of Quebec, plaintiff, vs ROBERT LAFRANCE, St-Sévérin de Proulyville, district of Trois-Rivières, defendant.\"A lot of land situated on Côte St-Louis Range in the parish of Saint-Sévérin de Proulxville, known and designated as being part of lot number one hundred and fifty-six (P.156) on the plan and in the official book of reference for the parish of Saint-Stanislas, measuring tow arpents, three rods and six feet, French measure, in width, more or less, by a depth of two hundred and seventy feet, English measure, hounded in front, on the north-east, by the public road, in depth, on the south-west, by Edwidge Cossette, joining, on the north-west side, the land of Jean-Lou is E, Cossette, and on the south-east side, the land of Sandy Massicotte, with a pigsty thereon constructed.\" To be sold at the parochial church door of Saint-Sévérin de Proulxville, on WEDNESDAY, the SIXTEENTH day of the month of OCTOBER, one thousand nine hundred and sixty-three, at THREE o'clock in the afternoon.Gut Mercier, Sheriff's Office, Sheriff.Trois-Rivières, September 6, 1963.4049-37-2 INDEX !¥o 37 ACTION ACTIOS en séparation de biens for Separation as to Property Gagnon vs Gagnon.4357 ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 1270-A - Construction, Montreal (Erratum).4357 1481 - Compensation de congés de maladie, lors du départ ou de la mise à la retraite d'un fonctionnaire.4361 1481 - Compensation for sick leave in the case of the departure or superannuation of a functionary.4361 1487 - Règlements relatifs aux manoeuvres tendant à favoriser la vente de la bière.4364 1487 - By-laws relative to the manoeuvres tending to favor the sale of beer.4364 1522 - Commission d'Apprentissage des Métiers du Bâtiment, Terrebonne et Labelle.4358 1522 - Apprenticeship Commission of the Building Construction, Terrebonne ; no Labelle.4358 1523-A - Imprimerie, Montréal.4356 1523-A - Printing, Montreal.4359 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 14.IMS, Vol.1)6, No.37 4419 ARRÊTÉS en Conseil {suite) ORDERS in Council (continued) 1523-H - Imprimerie, Montréal et «listrict.4358 1523-B Printing, Montreal and district.4358 1521-A - Fer et bronze d'ornementation, Montréal.4359 1521-A - Ornemental iron and bronze, Montreal.4359 1524-B - Barbiers et coiffeurs, St-Hyacinthe.4359 1524-B - Barbers and hairdressers, St-Hyacinthe.4359 1524-C - Oarage.Joliette.4360 ASSEMBLÉE Nationwide Food Service (Quebec) Ltd.MEETING 4365 COOPERATIVE Associations ASSOCIATIONS Coopératives Association coopérative d'investissement (Form.).4866 Association coopérative des camionneurs de Girardville (Form.).4366 Association coopérative industrielle de Beauceville (Form.).4366 Association coopérative de Grande Baleine (Form.).4366 COMPAGNIES Avis relatifs à la loi des Chartes -Abandon de COMPANIES Notices relative to the Act of Charters \u2014¦ Surrender of Clément Construction Ltée.4368 Gagnon Frères Nouveautés Aima Inc.4367 Giguère & Laplante Li i itée.4368 Joron & Cie Inc.4368 Magasin Parisien Inc.(Le).4367 Majorettes Ste Thérèse de Thetford Mines Inc.4367 Octad Limited.4368 Prince Chesterfield Inc.4367 Quebec Metallurgical Company Inc.4367 St.Elzear Land & Housing Corp.4366 Wexler Investments Corp.4368 Dissoute Ebco Administration Inc.Divers Dissolved .4368 Miscellaneous Atlantic Lumber Company (The) (Agent).4370 Bermont Mines Ltd.(Dir.).4369 Centre Paroissial de St-Jean Port-Joli (Le) (Règl.- By-laws).4370 Club de Golf Laurentide Inc.(Règl- By-laws).4370 Club de Golf Laurentide Inc.(Dir.).4371 Franklin Glass & Paint Company (Règl.- By-laws) (Dir.).4370 Glomus Inc.(Dir.).4369 Sogestion Ltée (Dir.).4369 Lettres patentes Letters Patent Agences Decary Ltée «Les).4286 Agence Media de Publicité Ltée.4335 Ajusteurs Associés du Québec Inc.,Les) 4287 Anjou Gardens Ltd.,.4287 Art-Tec Inc.4287 Arvida Pistol Club.4288 Association des Cités et Villes du District de Saint-François (L').4288 Association des Propriétaires de la Ville de la Petite-Rivière Inc.4289 Association des Soudeurs du Québec Inc.4289 Atlas Roof Truss Ltd.4289 Auberge de Jeunesse Vive la Vie.4290 Baie-Comeau Curling Chib Limited.4302 Baron Hôtel Motel (Sherbrooke) Inc.(Le).4290 Beaudoin (Julien) Ltée.4290 Bédard (Paul) Inc.4291 Bédard (Roland) Inc.4291 Bcrdesmol Ltée.Bernard Excavation Inc.Bérubé (P.-A.), Limitée.Bibo Maritime Transport Ltd.Bibo, Transport Maritime Ltée.Bissonnette Auto (Rouyn) Inc.Blumer's (St.Jean) Ltd.Boisseau (Harold-G.) Inc.Bonet (Jordi) Inc.Boulangerie Gadoun & Fils Ltée.Bourgeois & Frère Inc.Boutique Madelcn Inc.(La).Brak.» & Electric Service, Inc.Brouillette Enterprises Inc.Bureau d'Ajustement Bics Inc.Bureau de Traduction Raymond-Kelly-Noël Inc.Café Giardino d'Italia Inc.Calcaires Canadiens Ltée (Les) .Camionneurs de Joliette & Région.Inc.(Les).Carillon Publications Inc.(The).Carli Transport Inc.Caron (Marcel) Excavation Inc.Cavelier Enterprises Inc.Cedar Park Enterprises Inc.Centre «le la Roulotte Inc.(Le).Centre Médical de Rouyn Inc.Chambre d'Immeuble du Royaume du Saguenay Inc.(La).Charlebois & Fils Ltée.Chateau Leasing Ltd.Chaudière Chipping Center Inc.Cie de Démolition Ltée (La).Cloutier (J.B.) Inc.Club de Curling de Baie-C« meau Limitée .Club des Pins Inc.Club Dom Est Inc.(Le).Club Nautique de St-Félicien Inc.(Le).Club Privé «lu Lac Laurel.Club Sportif Mont-Eskimo Ltée.Collège Champlain Inc.Comité des Citoyens du Lac Grégoire (Le).Commission des Loisirs d'Iberville Inc.Commission du lOième Anniversaire de Tracy Inc.Compagnie de Locations Trans-Canada Ltée (La).Compagnie Générale d'Immeubles «le Valleyfield.Conseil Régional d'Expansion Économique de la Gaspésie et «les Iles-de-la-Madeleine .Construction Bouchard Inc.Coromoto Ltd.4291 4292 4292 4293 4293 4293 4293 4294 4294 4294 4295 4295 4295 4314 4290 4296 4297 4297 4297 4345 4298 4298 4314 4298 4299 4299 4299 4300 4300 4300 4301 4301 4302 4302 4302 4303 4303 4303 4304 4304 4305 4305 4305 4306 4306 4307 4307 4420 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963.Tome 96.No 37 lettres patentes letters Patent (suite) (contitued) Corporation Desruisscuux (La).4307 Couvent des Servantes du Saint CtttUV de Marie de Waterville.4371 Crémerie Lemaire Inc.4308 Crête & Guimond lue.4308 Cricket & Rugger Times Ltd.4308 Cuillerier (Maurice) Inc.4309 Cuisines G.Miller Inc.(Les).4309 Dcll-Francolnc.4309 Desruisseaux Corporation.4307 Développements Argenteuil Inc.(Les).4310 Distribution Fiesta Ltée.4310 Domaine des Lacs Raymond Ltée (Le) 4311 Domaine des Tilleuls Inc.4311 Do/ois & Montpetit Inc.4311 Edifices Ste-Marie Ltée.4312 Editions Européennes Limitée (Lee).4312 Electro Ltée.4312 Elliott (Charles) Construction Inc.4313 Emplovcurs Forestiers de la Rouge.Inc.(Les).4313 Entreprises Brouillette Inc.(Les).4314 Entreprises Cavelier Inc.(Les).4314 Entreprises I.P.F.Ltée (Les).4314 Entreprises Marcal Inc.(Les).4315 Entreprises Premont Inc.(Les).4315 Entreprises Théodore Beaudoin Ltée (Us).4310 Épicerie Traversy Inc.4316 Équipements «le Téléphone Laurentiens Inc.(Les).4316 Équipements Rolland Ltée (Les).4317 Erie Service & Equipment Ltd.4317 Évêque Catholique Romain de Hull (L*).4371 Ferme Wilson Inc.(La).4317 Fiesta Distribution Ltd.4310 Finesse of Quebec Ltd.4318 Flamo Inc.4318 Fleuriste Notre-Dame de Grâce Inc.4318 Fruiterie Ahuntsic Inc.4319 (îalerie Martin Inc.4319 Gagné (Guy) Inc.4319 Garage F.Paul Gagnon Inc.4320 Gaz Industriel du Québec Ltée.4346 Geco (Quebec) Limited.4320 Goyer (C.E.) & Fils Inc.4321 Gravel Car Leasing Ltd.4321 Gravel Location d'Automobiles Ltée.4321 Grégoire Auto Parts Inc.4321 Grenier (J.) Tires Ltd.4343 Guertin (Marcel) Inc.4322 Hamelin (Berthold) Inc.4322 Hôtel Interprovincial Ltée.4322 House of Bombay Impex Inc.(The) .4323 Howell Insurance Agency Co.Ltd.4323 Immeubles Bérubé Inc.(Les).4323 Immeubles de Luçon Ltée (Les).4324 Immeubles Piuze & Harvey Inc.(Les).4324 Infra Red Heating Ltd.4324 Interprovincial Hotel Ltd.4322 Institut de Beauté Maridelis Inc.4325 International Plumbing & Heating Supplies Limited.4325 Italo I.C.Fruit Co.Ltd.4326 J M Co.Ltd.4326 J.P.Inc.4326 J.R.S.Ltd.4327 Jacko Publicité Ltée.4327 Jardins Ste-Dorothée Inc.4327 Lalonde Electric Inc.4328 Lalonde Électrique Inc.4328 Lamarche Frères Limitée.4328 Laniel Automat Inc.4328 Larivière (André) Inc.4329 Laurentide Press Ltd.4329 Laurentide Service Station Inc.4330 Lemieux (Patrick) Ltée.4330 l.cssunI & Caron Inc.4330 L'Heureux (Pierre) & Cie (1963) Limitée.4331 Liessens (Gaétan) Inc.4331 Location Universelle Inc.4331 Loisirs de Ste-Gertrude Inc.(Les).4332 London Waste Mfg.Co.Ltd.4332 Longpré (Georges) Ltée.4333 Magnetic Window Inc.4333 Maison de Bombay I mpex Inc.(La).4323 Maison du Palmarès Inc.(I^a).4333 Majorettes Rouge et Or d'Alma Inc.(Les).4333 Marcal Enterprises Inc.4315 Marlboro Construction Ltd.4334 Maxwel Lumber Supplies Co.4334 Media Advertising Ltd.4335 Metro Electronic Inc.4335 Metropolitan Auto Parts, Inc.4335 Metropolitan Food Services Inc.4336 Meunerie Svlvio Brochu Ltée.4336 Mobilier Moderne (1963) Ltée.4336 Montor Landscape & Construction Inc.4337 \u2022Montreal Real Estate Service Inc.4348 Motel Évangéline Inc.4337 Notre-Dame de Grâce Florist Ine.4318 O'Brien Motors Ltd.4337 Oeuvre Diocésaine des Vocations de Saint-Jean (L').4371 Pannier Céramiques Ltée.4338 Papineau Plumbing Ltd.4342 Parc Laurier Service Inc.4338 Parent (Maurice) Inc.4339 Patro Sainte-Anne Inc.(Le).4339 Paul & Sons Window Cleaning Inc.4339 Perle du Lac Inc.(La).4340 Pierre Construction Ltée.4340 Placements Coderre Inc.(Les).4340 Placements Dansereau Inc.(Les).4341 Placements Gilman Inc.4341 Plastic Services & Dies Ltd.4341 Playboy Men's Wear Inc.4342 Plomberie Papineau Ltée.4342 Pneus J.Grenier Ltée (Les).4343 Polyplacements Inc.4343 Pratte et Fils Inc.4343 Précision Automatique J.R.N.Ltée.4344 Prêts Richelieu Inc.(Les).4344 Produits d'Érables Tuque Rouge Ltée.4344 Produits Dromoco Inc.(Les).4345 Protection Universelle, Compagnie d'Assurance (La).4378 Publications Carillon Inc.(Les).4345 Quebec Associated Adjusters Inc.4287 Quebec Industrial Gas Ltd.4346 Ranch des Sportifs Inc.(Le).4346 Raymond-Kelly-Noël Translation Bureau Inc.4296 Restaurant Baronet Inc.(Le).4346 Restaurant « La Fiesta Inc.».4347 Revue Parti Pris, Incorporée (La).4347 Richelieu Loans Inc.4344 Roman Catholic Bishop of Hull (The).4371 Roma's Steel Works Inc.4347 Rouyn Medical Centre Inc.4299 St.Francis District Cities and Towns Association (The).4288 Samson & Frères Inc.4348 Service Immobilier de Montréal Inc.4348 Silibéton Ltd.4348 Silibéton Ltée.4348 Sir George Williams University Faculty Club (The).4349 Skyline Construction Inc.:.4349 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 1J,, 1963, Vol.96, No.37 4421 Lettres patentes Letters Patent suite continued Société America Europa Inc.4350 Société Delbro Inc.(La).4350 Sofino Inc.4350 Sogostion Ltée.4351 Sonny's Service Station Inc.4351 Soupe Inc.(Ak).4352 Spenard (Frank) (Immeubles) Ltée.4352 Sportmen's Ranch Inc.4346 Studio de Meubles d'Art Inc.4352 Tétreault & Frère Ltée.4353 Trans-Canada Leasing Co.Ltd.4305 Transports A.Larouche Inc.(Les).4353 Trutone Cleaners & Tailors Inc.4353 Tuque Rouge Maple Products Ltd.4344 Universal Leasing Inc.4331 Universal Protection Insurance Company.,.4378 Valleyfield General Realties Company.4300 Vard Incorporated.4354 Vard Incorporée.4354 Vorlage Ski and Recreation Area Limited.4354 Voyageur Provincial Inc.4354 Westminster Service Station Inc.4355 Westmount Plumbing & Roofing (1963) Ltd.4355 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Association Sportive de Lqval-Ouest.4355 City Bag Co.Ltd.(The).4356 Club Seigneurie de Grand-Pré.4356 Hôpital Ste-Croix.4372 Laval-West Sports Association.4355 Salem Exploration Limited.4356 Vista Investments Corporation.4357 Vista Investments Corporation.4357 Sièges sociaux Head Offices Abaca Inc.4374 A.& G.Fabrics Ltd.4373 Anjou Gardens Ltd.4376 Bateaux de Service Sorel Ltée.4372 Bedeco Inc.4376 Canadian Bookclub Centre Ltd.4374 Cie Univex (Que) Ltée (La).4373 Col-Mer Construction Company.4373 Corporation Desruisseaux (La).4375 Duchesne (René) Inc.4376 Équipement R.Lague Ltée.4372 Girard & Girard Inc.4372 Junior Deb Mfg.Ltd.4375 Lazare Investment Corp.4375 Leigh Investments (Montreal) Ltd.4375 Lort Realty Corp.4377 Made to Fit Garment Limited.4375 Motel Lasalle Inc.4373 Parino Inc.4376 Petite Marquise Inc.(La).4376 Savoie Frères Inc.4374 Sogestion Ltée.4372 Sorel Working Boats Ltd.4372 Weather-Proofing Limited.4374 DEMANDES APPLICATIONS à la Legislature to Legislature Club de Golf Larrimac Inc.(Le).4377 Juister, Martin Frederick.4377 Larrimac Golf Club Inc.(The).4377 LIQUIDATION WINDING MINISTÈRES DEPARTMENTAL Finances Finance Assurances: Insurance: Canada Accident and Fire Assurance Company (The).4378 Compagnie d'Assurance contre les Accidents et l'Incendie du Canada (La).4378 Instruction publique Etlucation Municipalité scolaire de: School Municipality of: Arntfield (Dent.- Appt.).4379 Beloeil, ville - town (Ace- Grant.).4379 Candiac « Prot », ville - town (Acc- Grant.).4380 Cartier, Canton-Township (Dem.- ^4p- pL).4379 Clarendon (Dem-Appt.).4380 Ile Bonaventure (Dem- Appt.).4380 Leclerville, (Acc.- Grant.).4379 Paspébiac « Prot.» et-and Cox « Diss.» (Dem.- Appt.).4379 St-François, ville-town (Acc- Grant.) 4380 St-Noël (Acc- Grant.).4380 Terres et Forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Amos, village.4381 Boucherville, par.4381 Charlesbourg, par.4381 Sault-au-Récollet, par.4381 Ste-Agathe-des-Monts, par.4381 Ste-Foye, par.4382 St-Philippe-de-Laprairie, par.4382 Travail Labour Industrie ou métiers de: Industry or Trades of: Building, Drummondville, (App.).4382 Building, Eastern Townships (Levy).4391 Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses, Saint-François (App.).4382 Barbers and Hairdressers, St Francis (App.).4382 Construction, Cantons de l'Est (Pre*!.).4391 Construction, Drummondville (App.).4382 Construction, St-Jean et R>erville (Mod.).4389 Construction, St-John and Iberville, (Amend.).4389 Alimentation, Québec et al (Mod.).4383 Food, Quebec et al (Amend.).4383 Fourrure - Gros, Montréal (Mod.).4383 Fur - Wholesale, Montreal (Amen'.).4383 RÉGIE QUEBEC des marchés agricoles Agricultural du Québec Marketing Board Industrie Laitière: Dairy Industry: Ord.2-63-A (Québec).4392 PROCLAMATION PROCLAMATION Jour d'actions de grâces.4395 Thanksgiving day.4395 SOUMISSIONS TENDERS Coaticook, ville - town.4404 Douville, munie.4408 Hauterive, ville - town.4405 Lac Lemoine, munie.4403 Laflèche, cité-city.4401 Laurierville, village.4407 Entreprises Nadon Ltée (Les).4377 4422 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 14 septembre 1963, Tome 96, No 37 SOUMISSIONS TENDERS mite continued Lavaltrie, village.4402 Pointe-au-Pic, munie, c.a.- s.c.4409 Ste-Cécile, par.4400 Villeneuve, ville - town.4405 SYNDICAT SYNDICATE professionnel Professional Syndicat des Producteurs de Bleuets de Tchitagama (U.C.C.) (Form.).4406 VENTES SALES Licitation Licitation Shapiro vs Shapiro et al.4407 St-Arnaud vs St-Arnaud et al .4407 SHÉRIFS SHERIFFS Arthahaska Artliabaska Tellier vs Favreau.4409 Beauce \u201e Beauce Caron vs Marquis.4409 Chicoutimi Chicoutimi Western Savings and Loan Association «Tremblay.4409 Gaspé Gaspé Maloney vs La h rie.4410 Hull Hull Econo Heating Ottawa Ltd vs L.W.Noël (Quebec) Ltée et al.4411 Rossignol (Héritiers-Heira) w McCon- nery.4410 Kamouraska Kamouraska Beneficial Finance Company of Canada vs Pelletier et al.4411 Mégantie Mégantie Forano Limitée vu Roy.4412 Québec Québec Office du Crédit Agricole du Québec (L') vs Bélanger.4412 Quebec Farm Credit Bureau (The) W Bélanger.4412 Rimouski Rimouski Dumais vs Bernier.4413 Gosselin vs Langlois.4414 Lepage vs Landry.4413 Paradis vs St-Laurent.4413 Saguenay Saguenay Mercantile Bank of Canada (The) vs Gagnon.4414 Mercantile Bank of Canada vs Hoving- ton.4415 Sept Iles Ready Mix & Equipment Inc.vs Les Développements du Saguenay Ltée.4414 Saint-François Saint Francis Benificial Finance Co.of Canada vs Beauregard.4416 Morris Lumber Limited vs Martel.4415 Western Savings & Loan Association (The) vs Girard.4416 Saint-Hyacinthe Saint Hyacinthe Laporte vs Hétiers - Heirs Fontaine.4416 Terrebonne Terrebonne Lamarche vs Boisvert et al.4417 Trois-Rivières Troie-Rivièree Ralston Purina Co.Ltd.es Lafrance.4418 L« Ministère dee Poètes, à Ottawa, a autorisé l'affranchissement en numéraire si l'envoi comme objst ., de deuxième classe de la présente publication.Authorised as second clam mail by the Poet Office Department, Ottawa, and for payment of postage in cash."]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.