Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 31 mars 1962, samedi 31 (no 13)
[" Tom 94, No 13 1729 Vol.94, No.13 ! \u2022 i pea h de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Hag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Quebec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Quebec, samedi 31 mars 1962 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1 1 Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Hotel du Gouvernement, Québec; 2a Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue, la traduction en est fuite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.43 Payer comptant et avant publication le \u2022dût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis \u2022 ( sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de i'imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, March 31, 1962 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec., 2.Supply advertising copy in the two official languages.When same is supplied in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions, 4.('ash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hercinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.I.c Ministère dos Postés, à Ottawa, a autorisé l'affranchissement en numéraire et l'envoi comme objet de deuxième classe de la présente publication.Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, and for payment of postage in cash. 1730 UAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 31 mari, 1962, Tome 94, No 13 7° La (hutte officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le mercredi à condition que ce jour de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans un tel cas, l'ultime délai expire ù midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annoncest Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: Il la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, Roch Lefebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec, 5 décembre 1960.59870 \u2014 l-52-o Lettres patentes L.Abramowicz Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 16e jour de janvier 1962, constituant en corporation: Clarence Reuben Gross, avocat, ch., 790, avenue Lexington, Montréal, Joel Arnold Pinsky, avocat, 4910, avenue Maple wood, Montréal, et Lawrence Fligel, étudiant en droit, 4865, chemin Ste-Catherine, Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce de bouchers, .sous le nom de « L.Abramowicz Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI 00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Wvù-nesday, providing that this day of the week is not a holiday.In such case, the ultimate delay expires at noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subseqm u edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain docu.ments, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any renu: tances of money are subject to the provisions -if article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.- Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate lino, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation : 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1 per dozen.Subscriptions: $7 per year.N.B.- The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette tor the first insertion ; the third to the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are follow id only by our document number.Roch Lefebvre, Queen's Printer.Parliament Buildings, Quebec, December 5, 1960.59870 \u2014 1-52 -o Letters Patent L.Abramowicz Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of January, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Clarence Reuben Gross, advocate, Q.c, 790, Lexington Avenue, Montreal, Joel Arnold Pinsky, advocate, 4910, Maplewood Avenue, Montreal, and Lawrence Fligel, student-at-law, 4865, St.Catherine Road, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of butchers, under the name of \"L.Abramowicz Inc.\", with a total capita] stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each and 300 preferred shares of the par value of $100 each The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 31, 1968, Vol.94, Sû.13 1731 Donné au bureau du secrétaire de la province, , < 16e jour de janvier 1962.Cf Soux-srcrétaire de la province, Raymond Dou ville.60801 10216-62\u2014 1111/91 Lett Agences du Nord Ltée Avitt est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la provinefl de Québec, des lettres patentes, en date .et « Hoechst Industries Limited », constituée en corporation en vertu des dispositions de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes datées du 22e jour de février 1952, pour les objtes suivants: Faire le commerce de toutes sortes d'articles et marchandises fabriqués en tout ou en partie de métal, plastique, substance chimique, bois, papier, textile, cuir, caoutchouc, nylon, fourrure, verre, et celui d'animaux, minéraux, pierres précieuses, boissons gazeuses, livres et périodiques, oeuvres d'art, produits de beauté, produits de la mer, de la terre et de la forêt, sous le nom de « Canadian Hoechst Ltd », avec un capital total de $450,000, divisé en 150.C00 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $100 chacune.be nom de la nouvelle compagnie est « Canadian Hoechst Ltd ».Le siège social de la compagnie sera en les cité et district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ee 5e jour de mars 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.00808 10446-62 \u2014 1115/105 Canadian Metal Fashions Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des Jet très patentes, en date du 28e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Abraham Sinister, avocat, 5470, Hcssborough, Montréal, Nathaniel Liebman, notaire, 5215, Kensington, Montréal, et Dorothy L (in h s ton.secrétaire, fille majeure, 1240, rue du Fort, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises-, menus objets, effets et articles de quincaillerie fabriqués d'aluminium, émail, étain, granit, tôle galvanisée et métal en feuille, sous le nom de « Canadian 'létal Fashions Inc.», avec un capital total de 910,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.be siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Canadian Hocchxt Ltd Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of January, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, authorizing the amalgamation of \"Canadian Hoechst Limited\", incorporated in virtue of the provisions of Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated the 22nd day of July, 1953, and \"Hoechst Industries Limited\", incorporated in virtue of the provisions of the said Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated the 22nd day of February, 1952, for the following purposes: To deal in all kinds of articles and merchandise made, in whole or in part, of metal, plastic, chemical, wood, paper, textile, leather, rubber, nylon, fur, glass, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, works of art, beauty products, land, sea and forest products, under the name of \"Canadian Hoechst Ltd\", with a total capital stock of $450,000, divided into 150,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $100 each.The name of the new Company is \"Canadian Hoechst Ltd\".The head office of the company will be in the city and in the judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of March, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.OO8O8-0 10446-62 \u2014 1115/105 Canadian Metal Fashions Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Abraham Shuster, advocate, 5470 Bessborough, Montreal, Nathaniel Liebman, notary, 5215, Kensington, Montreal, and Dorothy K.Gunston, secretary, fille majeure, 1240, Fort St.Montreal, for the following purposes: To deal in goods, wares and merchandise manufactured from and articles made of aluminum ware, enamel ware, tin ware, granite ware, galvanised ware and sheet metal ware, under the name of \"Canadian Metal Fashions Inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 3,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 1738 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI mm 1962, Tome 94.So 13 Donné nu bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de décembre 1061.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 16266-61 -1110/98 Canadian Yorkshire & Manchester Club Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 12e jour de janvier 1962, constituant en corporation sans capital-actions: Henry Melling, Kréposé à l'entretien, 4848, avenue du Parc, 1 ont real.Albert Gardner, vendeur, 312, 9e Avenue, LaSalle, Alfred McPherson, concierge, 2636, rue Reading, Point c-St-('liaries, Henry Barrette, concierge, 2642, rue Heading, Pointe-St-Charles, et Kennett Harder, camionneur, 2155, rue Tupper, Montréal, patir les objets suivants: Grouper les habitants du Lancashire qui vivent présentement au Canada par des liens d'amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle, sous le nom de « Canadian Yorkshire & Manchester Club ».Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est $20,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 12e j.nir de janvier 1962.l.r Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 15134-61 \u2014 1110/8 Given at the office of the Provincial Secretin-, this 28th day of December, 1961.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.60808-o 16265-61 - 1110/98 Canadian Yorkshire & Manchester Club Notice is hereby given that under Part III of the Quelrec Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Henry Melliiv.maintenance man, 4848, Park Avenue, Montr* I, Albert Gardner, salesman, 312, 9th Avenue, LaSalle, Alfred McPherson, caretaker, 2630, Reading Street, Pointc-St-Charles, Henry Barrette, janitor, 2642, Reading Street, Pointe Si Charles, and Kennett Barber, truckdriver, 2155, Tupper Street, Montreal, for the following purposes: To unite Lancashire people now living in Canada in the bonds of friendship, good fellowship and mutual understanding, under- the name uf \"Canadian Yorkshire & Manchester Club\".The amount to which the value of the iram \u2022 veable property which the corporation may possess, is to be limited, is $20,000.' The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00808-o 15134-61 \u2014 1110/8 Chalvignac Céramiques Exclusives Inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 6e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Pierre M.Verdy, avocat, 2100, Van Horne, app.10, Montréal, Geoffroy Birtz, avocat, 176, avenue High field.Mont-Royal, et sSerge Desrochers, avocat, 732, avenue Wilder, Outremont, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles en céramique, d'objets artistiques et de nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « Chalvignac Céramiques Exclusives Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 6e jour de décembre 1961.IjC Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808-o 15887-61 \u2014 1107/127 Chalvignac Céramiques Exclusives Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date thé 6th day of December, 1901.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre M.Verdy, advocate, 2100, Van Horne, apt.10, Montreal, Geoffroy Biitz, advocate, 176, High field Avenue, Mount-Royal, and Serge Desro-chers, advocate, 732, Wilder Avenue, Outre-mount, for the following purposes: To carry on a business dealing in articles made of ceramic, artistic articles and in novelties of all kinds, under the name of \"Chalvignac Cera-miques Exclusives Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be «I Saint-Michel, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Sécrétai y.this 6th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 15887-61 \u2014-1107/127 Châteauguay Automobile Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Gaston Tessier, comptable, 131, rue Bienville, Longueuil, Jeannine Chabot, secrétaire, majeure, 8117, avenue Querbes, Montréal, et Thérèse Hamelin, secrétaire, majeure, 7989, rue St-Denis, Montréal, pour les objets suivants: Châteauguay Automobile Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act letters paten', bearing date the 29th day of December, 190 b have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gaste-i Tessier, accountant, 131, Bienville Street, Lon gueuil, Jeannine Chabot, secretary, of full ae .8117, Querbes Avenue, Montreal, and There-\" Hamelin, secretary' of full age, 7989, St-Dei.-Street, Montreal, for the.following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 81.1969.Vol 94.No.13 1739 Faire le commerce d'automobiles et faire affaire.s comme garagistes, sous le nom de « Château-.¦¦!.iv Automobile Inc.», avec un capital divisé en 2.000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 2,500 actions privilégiées de $20 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $20,000.fie siège social de la compagnie sera à Châteauguay, district judiciaire de Beauharnois.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de décembre 1961.Le Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville.6080&a 10065-62 \u2014 1111/114 Chez Real Men's Wear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 22e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Fernand Richard, opérateur, Val-d'Or, Adonaî Richard, marchand retraité, Malar-tic, et Real Richard, marchand, Malartic, pour les objets suivants: Faire le commerce de vêtements, sous le nom rie « Chez Real Men's Wear Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Ix,' siège social de la compagnie sera à Aylnier-Est, district judiciaire de Hull.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour de décembre 1961.ts Sous-eecrêtaire de la province, Raymond Douville.6080S* 16171-61 \u2014 1111/95 La Cité des Jeunes de Vaudreuil Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date \u2022lu 13e jour de décembre 1961, constituant en corporation sans capital-actions: J.-E.-André bernardin, courtier d'assurances agréé, Vaudreuil-Mir-le-Lac, Florian Bleau, administrateur, 84, rue Saga la, lle-Perrot, Robert Caron, comptable agréé, 44, rue Hôtel-dc-Ville, Dorion, Oscar tendron, médecin, 6, rue St-Anselme, Rigaud, Leopold Pharand, notaire, St-Polycarpe, J.Gibb Stewart, avocat, Main Road, Como, et Clovis Tougas, médecin-vétérinaire, 224, rue St-Charles, Dorion, pour les objets suivants: F.tablir à Vaudreuil ou dans les environs un centre d'éducation, de culture et de sport, sous le nom de « La Cité des Jeunes de Vaudreuil ».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $1,000,000.Le siège social de la corporation sera à Vaudreuil, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, \u2022 13e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.W8O8-0 15973-61 \u20141104/109 To carry on a business dealing in automobiles and to operate as garage-keepers under the name of \"Châteauguay Automobile Inc.\", with a capital stock divided into 2.000 shares without nominal or par value and into 2,500 preferred shares of $20 each, and the amount with which the company shall start its operations is $20,000.Tire head office of the company will be at Châteauguay, judicial district of Beauharnois.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of Dei-ember, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.liOKOK 10065-62 - 1111/114 Chez Real Men's Wear Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the (Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of December, 1961, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Que!>ec, incorporating: Fernand Richard, operator, Val-d'Or, Adonaî Richard, retired, merchant, Malartic, and Real Richard, merchant.Malartic, for the following purposes: To carry on business dealing in clothing, under the * name of \"Chez Real Men's Wear Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Aylmer-East, judicial district of Hull.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00808 16171-61 \u2014 1111/95 La Cité des Jeunes de Vaudreuil Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: J.-E.-André Bernardin, certified insurance broker, Vaudreuil-sur-le-Lac, Florian Blcau, administrator, 84, Sagala Street, lle-Perrot.Robert Caron, chartered accountant, 44, HAtel-de-Ville Street, Dorion, Oscar Gendron, physician, 6, St-Anselme Street, Rigaud, Leopold Pharand, notary, St-Polycarpe, J.Gibb Stewart, advocate, Main Road, Como, and Clovis Tougas, veterinary surgeon, 224, St-Charles Street, Dorion, for the following purposes: To establish in Vaudreuil or in the surrounding district an educational, cultural and sports, center, under the name of \"La Cité des Jeunes de Vaudreuil\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $1,000,000.The head office of the corporation will be at Vaudreuil, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.6080S 15973-61 \u2014 1104/109 M.Clark Realties Ltd.M.Clark Realties Ltd.- Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1962, Avis est donné qu'en verte de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Mé accordé, par le lieutenant-gouverneur de la 1740 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI mars 1962, Tome 94, No 1S province de Québec, «les lettres patentes, en date du 4e jour de janvier 1962, constituant en corporation: Paul Galt Michaud, avocat, 3495, rue Mountain, Montréal, Gilles-André Denis, avocat, 571, rue Champagneur, Montréal, et Gilles-Ivan Beaupré, avocat, 5938, rue Louis-Hémon, Montréal, pour les objets suivants: Exercer des affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de s M.Clark Realties Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la en m pagine sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4e jour de janvier 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 14858-61 - 1109/2 Club des 21 Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15e jour de janvier 1962, constituant en corporation sans capital-actions: Joseph Murray, papetier, 186, 7ième Avenue, Port-Alferd, Fer-nand Perron, machiniste.180, 5ième Avenue, Port-Alfred, et Gérald Aubin, avocat, 364, boulevard Ste-Geneviève, Chicoutimi-Nord, pour les objets suivants: Établir et diriger un club social, sous le nom de « Club des 21 Inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera 186, 7ième Avenue, Port-Alfred, district judiciaire de Chicoutimi.Donné au bureau du serrétaire de la province, ce 15e jour de janvier 1962.Lé Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.60K08-o 16039-61 - 1111 /42 have been issued by the Lieutenant-Governor .f the Province of Quebec, incorporating: Paul Gait Michaud, advocate, 3495, Mountain Str, et, Montreal, Gilles-André Denis, advocate, 571.Champagneur Street, Montreal, and Gilles-Ivau Beaupré, advocate, 5938, Louis-Hémon Street Montreal, for the following purposes: To do business in the fields of real estate and construction, under the name of \"M.Clark Realties Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will bt at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Seeretar.this 4th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00808-0 14858-61 \u2014 1109/2 Club des 21 Inc.Notice is hereby given that under Part III f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of January, 1 lid-have been issued by the Lieu tenant-Govern ¦ ¦ of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Joseph Murray, stationer, 186, 7th Avenue, Port-Alfred.Fernand Perron, machinist, 180, 5th Avenue.Port-Alfred, and Gérald Aubin, advocate, 864 Ste-Geneviève Boulevard, Chicoutimi-North.foi the following purposes: To establish and direct a social club, under the name of \"Club des 21 Inc.\".The amount to which the value of the imuio veable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at 186, 7th Avenue, Port-Alfred, judicial district of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 16039-61 \u2014 1111/42 Chez Clairette Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies tie Québec, il a été accoidé, par le lieutenant gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 14e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Dame Magda Gross Simon, marchande publique, 2075.Mountain, Montréal, John Simon, restaurateur, 2075.Mountain.Montréal, et Dame Clairette Oddera, gérant.1230, McGregor, Montréal, pour les objets stti vanta: Exercer le commerce «le restaurateurs, sous le nom «le « Chez Clairette Inc.», avec un capital total «le $30,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valoir au pair «le $10 chacune et 250 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, distiict judiciaire de Sf ont real.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, «e 14e jour «le décembie 1961.Le Sous secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 16032 61 1109/55 Club Optimiste de Longueuil Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi des compagnies «le Quéltcc, il a Chez Clairette Inc.Notice is heieby given that under Part Ifpf the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 14th day of December, 1961, have l>een issued by the Lieutenant-Goverooi of the Province of Quebec, incorporating: Danu Magda Gross Simon, marchande publique, 207ô.Mountain, Montreal, John Simon, restaurateur.2075, Mount; in, Montreal, ami Dame Clairette Otldera, manager, 1230, McGregor, Montreal, for the following purposes: To do business as restaurateurs, under the name of \"Chez Clairette Inc.\", with a t«jtal capital stock of $30,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and 250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office uf the company will Ik- at Montreal, judicial district of Montreal.(îiven at the office of the Provincial Secretary this 14th day of December, 1961.Raymond Dur ville.Assistant Secretary of tht t'nmnce.00808-o 16032-til 1109/5.'.Club Optinjistc de Longueuil lne.Notice is hereby given that under Part III ol the Quebec Companies Act, letters patent. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 81, 1962, Vol.94, No.13 1741 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettre» patentes, en date du 18e jour de décembre 1961, constituant en eorporation sans capital-actions: Roland Dai-gucault, tégistrateur, 124, rue St-Thomas, Longueuil, J.-Hervé Couture, employé de la Commission de Transport de Montréal, 135, rue I,a-hoiité, Longueuil, et Jean-Marie Laçasse, courtier ru assurances, 298, rue Gardenville, Longueuil, pour les objets suivants: Travailler à prévenir la délinquence juvénile, en soutenant de leurs propres deniers et du fruit de leur organisation les oeuvres de loisirs éduca-tioimels, sous le nom de «Club Optimiste de Dmgueuil Inc.».I.e montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $iootoou.I.e siège social de la corporation sera 130, chemin de Chambly, Longueuil, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce IV jour de décembre 1961.Le Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville.61 BQf* 15373-61 \u2014 1109/56 Club Sportif Amiante Indépendant Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Iroisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 26 janvier 1962, constituant en corporation sans car ital-aetions, sous le nom de « Club Sportif Amiante Indépendant Inc.», la corporation « Club Spcrtif Amiante », déjà constituée en avril 1956, en vertu des dispositions de la Loi des clubs de récréation (S.K.Q.1941, chapitre 304), et que les objets de la nouvelle corporation sont: Former et diriger un club social, sous le nom de \" ( lub Sportif Amiante Indépendant Inc.».' I.e siège social de ladite corporation est situé à Tlictford Mines, district judiciaire de Mégantic.I.e montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $200,080.Donné an-bureau du secrétaire de la province, ce 26 janvier 1962.Le Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville.(30808* 15670-61 \u2014 1113/113 Cohen's Children's Wear Inc.Avis est donné qu'en verbi de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu 29e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Bernard Gardner, avocat, 412, chemin Northcote, Roscmère, Gabriel Glazer, avocat, 5850, avenue Souart, Montréal, et Mlle Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, 4840, avenue Bourret, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles vestimentaires, sons le nom de « Cohen's Children's Wear Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.I.e siège social de la compagnie sera 4387, boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.bearing date the 18th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Roland Dai-gneault, registrar, 124, St-Thomas Street, Longueuil, J.-Hervé Couture, employee of the Montreal Transportation Commission, 135, La-bonté Street, Longueuil, and Jean-Marie Laçasse, insurance agent, 298, Gardenville Street, Longueuil, for the following purposes: To work for the prevention of juvenile delinquency by supporting with their own moneys and the fruits of their organization the words of educational recreations, under the name of \"Club Optimiste de Longueuil Inc.\".The amount to which the value of the immoveable propert v which the corporation may hold is to be limited.is $100,000.The head office of the corporal ion will l>e at 130, Chambly Road, Longueuil, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of December.1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province, 60808 15373-61 \u2014 1109/56 Club Sportif Amiante Indépendant Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of January, Hi62, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital under the name of \"Club Sportif Amiante Indépendant Inc.\", the corporation \"Club Sportif Amiante\", previously incorporated in April, 1956, under the provisions of tire Amusements Clubs Act, (R.S.Q.1941, chapter 304), and that the purposes of the new corporation are: To form and direct a social club under the name of \"Club Sportif Amiante Indépendant Inc.\".The head office of the corporation will be at Thetford Mines, judicial district of Megar.tic.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $200,000.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 15670-61 \u2014 1113/113 Cohen's Children's Wear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Bernard Gardner, advocate, 412, Northcote Road, Rose-mère, Gabriel Glazer, advocate, 5850, Souart Avenue, Montreal, and Miss Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, 4840, Bourret Avenue, Montreal, for the following purposes: To deal in wearing apparel, under the name of \"Cohen's Children's Wear Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 4387, St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal. 1742 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI mars 1962, Tome 94, A'o 1S Donné au bureau du secrétaire (le la province, ce 29e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.«0808 10061-62 - 1110/113 La Compagnie Quim Limitée Quim Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Louis Orenstein, conseil en loi de la Reine, 65, avenue McNider, Outremont, Jason Ruby, avocat, 2860.rue Ëkers, Montréal, Marc Beaudoin, avocat, 2668, rue Beaubien, est, Montréal, et Huguette St-Marseille.secrétaire, fille majeure, 533, boulevard Duhamel, Ile-Perrot,.pour les objets suivants: Agir comme courtiers et agents d'immeubles, sous le nom de « La Compagnie Quim Limitée \u2014 Quim Company Limited », avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, c«28e jour de décembre 1961.Le Soue-eeerétaire de la province, Raymond Douville.60808-o 16262-61 \u2014 1110/84 Congregation B'Nai Y'Chezkel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 22e jour de décembre 1961, constituant en corporation sans capital-actions: Dr Morton R.Lang, dentiste, 1742, chemin Lucerne, Mont Royal, Dr Hyman Wit ko v, médecin, 2051, chemin Athlone, Mont Royal, Ben Stein, marchand, 2225, chemin Eden, Mont Royal, Lester B.Lazarus, marchand, 115, avenue Cornwall, Mont Royal, et George Pervin, marchand, 8175, rue At her ton, Montréal, pour les objets suivants: Établir, entretenir et administrer une synagogue et exercer l'enseignement du judaïsme, sous le nom de « Congregation B'Nai Y'Chezkel Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Chome-dey, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour de décembre 1961.Ije Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 16177-61 \u2014 1111/116 Corporation de Développement du Nord Inc.Northern Development Corporation Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieu tenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Pierrette Trottier, secrétaire, célibataire, 610, La vigueur, Québec, Albert in e Chouinard, comptable, célibataire, 160, 10e Rue, Québec, Denise Vachon, secrétaire, célibataire, Given at the office of the Provincial Secretary this 29th day of December, 1961.Raymond Douville, Aeeietant Secretary of the Provituje.00808-o 10061-62 \u2014 1110/113 La Compagnie Quim Limitée Quim Company Limited Notice is hereby given that under Part i of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Louis Orenstein, Queen's Counsel, 65, McNider Avenue, Outremont, Jason Ruby, advocate, 2860, Ekers Street, Montreal, Marc Beaudoin, advocate, 2668, Beaubien Street, East, Montreal, and Huguette St-MarseH1e, secretary, spinster, 533, Duhamel Boulevard Ile-Perrot, for the fol.lowing purposes: To operate as real estate brokers and agents under the name of \"La Compagnie Quim Limi.tee \u2014 Quim Company Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and ito 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(riven at the office of the Provincial Secretar .this 28th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 16262-61 \u2014 1110/S4 Congregation B'Nai Y'Chezkel Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd'day of December, 1901, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a cor- Cration without share capital: Dr.Morton II.ng, dentist, 1742, Lucerne Road, Mount Royal, Dr.Hyman Witkov, physician, 2051, Atholne Road, Mount Royal, Ben Stein, merchant, 222r>, Eden Road, Mount Royal, Lester B.Lazarus, merchant, 115, Cornwall Avenue, Mout Royal, and George Pervin, merchant, 8175, Atherton Street, Montreal, for the following purposes To establish, maintain and conduct a synagogue and to carry on the teaching of Judaism, under the name of \"Congregation B'Nai Y'Chezkel Inc.\".~ The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Chomedey, judicia) district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00808-o 16177-61\u20141111/116 Corporation de Développement du Nord Inc.Northern Development Corporation Ine.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patci I, bearing date the 29th day of December, 1901, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierrette Trottier, secretary, unmarried, 610, Lavigueur, Quebec, Albert ine Chouinard, accountant un-married, 160, 10th Street, Quebec, Denise Vachon, secretary, unmarried, 1516, Vitré Street, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March SI, 1962.Vol.94.So.IS 1743 1510, rue Vitré, Quoi) ce, Solange Le tu rte, secrétaire, célibataire, 2079, Desrochers, Québec, et ( ! nstiane Sengstag, secrétaire, célibataire, 832, Si l-'.i i s tache, app.203, Québec, pour les objets suivants: ' \\créer le commerce d'une compagnie de placement*, sous le nom de « Corporation de I )é\\ eloppement du Nord Inc.\u2014 Northern Deve-I.pillent Corporation Inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune et 500 actions privilégiées de 1100 chacune.I.e siège social de la compagnie sera à Montréal, dis! riet judiciaire de Montréal.\u201e I >nnné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de décembre 1961.Le Soue-secrétaire de la produce, Raymond Douville.60808 10021-62\u2014 1111/83 Corso Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 9e jour de janvier 1962, constituant en corporation: Israel Gepner, marchand, 1655, rue Grenat, Saint-Laurent, Jacob Rot h m an, avocat, 6434 ouest, avenue Clanranald, Montréal, et Martha Bent, secrétaire, fille majeure, 6452 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, pour les objets suivants: Kxercer les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de «Corso Holdings Ltd.», avec un capital total de $10,000, divisé en 5.1 '1)0 actions ordinaires d'une valeur au pair de Si chacune et 5,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Ia?siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.I >onné au bureau du secrétaire de la province, ce 9e jour de janvier 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 10118-62\u20141111/3 Courchesne Vending Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1961, constituant en corporation : Wilfrid Courchesne, mécanicien, 911, Rivard, Tracy, Raymond St-Hilaire, gérant, 21, Terrasse Paquin, Pont-Viau, et Jean-Paul Pépin, notaire, 710, Marie-Victorin, Tracy, pour les objets suivants: Exploiter des machines à distribution automatique, sous le nom de « Courchesne Vending Inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 750 actions privilégiées de $100 chacune.be siège social de la compagnie sera à Tracy, \u2022'strict judiciaire de Richelieu.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de décembre 1961.' Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.O'MH-o 15998-61 \u20141110/124 D R S Builders Supplies Limited Quebec, Solange Letarte, secretary, unmarried, 2079, Desrochers, Quebec, and Chritiane Sengstag, secretary, unmarried, 832, St-Eustache, apt.203, Quebec, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Corporation de Développement du Nord Inc.\u2014 Northern Development Corporation Inc.\", with a total capital stock of $100.000, divided into 5,000 common shares of $10 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00808-o 10021-62\u2014 1111/83 Cor so Holdings Ltd.* Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of January, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Israel Gepner, merchant, 1655, Grenet Street, Saint-Laurent, Jacob Rothman, advocate, 6434, Clanranald Avenue West, Montreal, and Martha Bent, secretary, fille majeure, 6452, Sherbrooke Street West, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Corso Holdings Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 5,000 preferred shares of a par , value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808-o 10118-62\u20141111/8 Courchesne Vending Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act letters patent, bearing date the 29th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Wilfrid Courchesne, mechanic, 911, Rivard, Tracy, Raymond St-Hilaire, manager, 21, Terasse Paquin, Pont-Viau, and Jean-Paul Pepin, notary, 710, Marie-Victorin, Tracy, for the following purposes: To operate automatic distributing machines under the name of \"Courchesne Vending Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Tracy, judicial district of Richelieu.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 15998-61 \u2014 1110/124 D R S Builders Supplies Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of* January, 1962, have Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a .été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la 1744 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 81 mars 1968, Tome 91, No 18 province de Québec, des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1962, constituant en corporation: Jacques Guérin, avocat, 193, boulevard Beaeonsfield, Beaeonsfield, Bernard Taillefer, avocat, 5595, rue Marcel-Monette, Montréal-Nord, et Gaëtane Richer, secrétaire, fille majeure, 5603, avenue Coolbrook, Montréal, pour les objets suivants: Commerce de marchandises et articles fabriqués, en tout ou en partie, de métal ou bois, sous le nom de « D R S Builders Supplies Limited », avec un capital total de $50,000, divisé en 2,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social'de la compagnie sera en la ville de Roxboro, district judiciaite de Montrât L Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 8e jour de janvier 1962.Le Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808-o 10128-62 \u2014 1112/111 Dako Limitée Dako Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 9e jour de janvier 1962, constituant en corporation: Solange Pcpin, épouse séparée de biens de Guy Beauchemin, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, ménagère, 262, des Alouettes, Pont-Viau, Julien Plouffe, avocat, 579, Fleury, est, Montréal, et Yves Gauthier, notaire, 10215, Gouin, est, Rivière-des-Piairies, pour les objets suivants: Faire le commerce de machineries, appareils, produits alimentaires, meubles et nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « Dako Limitée \u2014 Dako Limited », avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1242, rue St-Denis, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 9e jour de janvier 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.6O8O8-0 10113-62 \u2014 1110/85 been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Guérin, advocate, 193, Beaeonsfield Boulevard, Beaeonsfield, Bernard Taillefer, advocate, 5595, Marcel-Monette Sreet, Montreal-North, and Ga& tane Richer, secretary, spinster, 5603, Coolbrook Avenue, Montreal, for the following purposes : To carry on a business dealing in merchandise and manufactured articles, in whole or in part of metal or of wood, under the name of \"D 1 S Builders Supplies Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 2,500 common shares of $10 each and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be in the town of Roxboro, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 10128-62\u20141112,111 D-»ko Limitée Dako Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Ccmpanies Act, letters patent, bearing date the 9th day of January, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Solange Pepin, wife separate as to property of Guy Beauchemin, and duly authorized by him for these presents, housewife, 262, des Alouettes, Pont-Viau, Julien Plouffe, advocate, 579, Fleury east, Montreal, and Yves Gauthier, notary.10215, Gouin east, Rivière-des-Prairies, for the following purposes: To carry cn business dealing in machinery, apparatus, food products, furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Dako Limitée Dako Limited\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 1242 St.Denis Street, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 10113-62 \u2014 1110 sô De Niverville Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 7e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Valmore De Niverville, bourgeois, 7900, Marie-Victorin, Tracy, Berthe Charbon-neau, épouse séparée de biens dudit Valmore De Niverville, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, ménagère, 7900, Marie-Victorin, Tracy, Real De Niverville, gérant, Route Marie-Victorin, Contrecœur, et André De Niverville, assistant-gérant, 4025, Marie-Victorin, Tracy, pour les objets suivants: Exercer le commerce de boulangers et confiseur, sous le nom de « De Niverville Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et en 90 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Tracy, district judiciaire de Richelieu.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour de décembre 1961.I.e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.OO8O8-0 15934-61 \u2014 1109/68 De Niverville Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Valmore l>e Niverville, gentleman, 7900, Marie-Victorin, Tracy, Bcrthe Charbonneau, wife separate as to property of the said Valmore De Niverville, and duly authorized by him for these presents, housewife, 7900, Marie-Victorin, Tracy, Ileal De Niverville, manager, Marie-Victorin Road, Contrecoeur and André De Niverville, assistant manager, 4025, Marie-Victorin, Tracy, for the following purposes: To carry on a business as bakers and confectioners, under the name of \"De Niverville Inc \".with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $10 each and into 90 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Tracy, judicial district of Richelieu.Given at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of December, 1961.Raymond Douville, Aseistant Secretary of the Province.60808 15934-61 \u2014 1109 08 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 31, 1962, Vol.94, A'o.13 1745 Deschénes & d'Anjou Inc.Vvil est donné qu'en veitu de la première pailie de la Loi des compagnies de Québec, il a et- accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «In 18« jour de décembre 1961, constituant en corporation: J.-Wilfrid Deschênes, courtier d'as-iu races, Mont-Joli, Guy d'Anjou, courtier d'as-siu -niées, Mont-Joli, et Georges d'Astous, cour-ti( r d'assurances, Mont-Joli,- pour les obejts snr.ants: Vgir comme agents et courtiers d'assurances géu< rales, sous le nom de « Deschênes & d'Anjou In« », avec un capital total de $95.000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et en son actions privilégiées de $100 chacune.!.erg, student, 1000, McGregor Avenue, Montreal, and Rita Mahoncy, secretary, spinster, 5261.Walkley Avenue, Montreal, for the following purposes: To do business in the field of real estate, under the name of \"Fran-Mir Corp.\", with a total capital stock of $150,0(10.divided into 1,000 class \"A\" shares of a par value of $10 each and 14,000 class \"B\" of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808-0 10261 -61 \u2014 1110/61 Gagnon et Bélanger Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la pro vinos de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Jean-Paul Gagnon, comptable agréé, S68, Eymard, Québec, Benoît Gagnon, comptable agréé, 2291, 4e avenue, Québec, et Marcel Bélanger, comptable agréé, 839, Eymard, Québec, pour les objets suivants: Agir comme consultants ou agents pour toute entreprise commerciale ou toute organisation industrielle, dans le domaine de la recherche, de l'administration, de l'organisation, de la finance ou autres problèmes connexes, sous le nom de 11 a gnon et Bélanger Inc.», avec un capital total de $400,000, divisé en 100 actions ordinaires de s 100 chacune et en 3,900 actions privilégiées de ! i 00 chacune.liC siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, 28e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.0808-o 16251-61 \u2014 11 lt)/l 38 General Auto Spring Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu 29e jour de décembre 1961, constituant en ¦ \u2022_¦ i-por ation : Robert Brockbank, mécanicien, ?541, Chambord, Montréal, Guy Phénix, élec-l rinen, CP.152, Ormstown, et Gilles Phénix, agent d'assurance, 120, Montenach, Longueuil, pour les objets suivants: , / Faire le commerce de ressorts pouvant s'adapter A toutes sortes de véhicules automobiles et Gagnon et Bélanger Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent bearing date the 28th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean-Paul Gagnon, chartered accountant, 868, Eymard, Quebec.Benoit Gagnon, chartered accountant, 2291, 4th Avenue, Quebec, and Marcel Bélanger, chartered accountant, 839, Eymard,^Quebec, for the following purposes: To operate as consultants or agents for any commercial enterprise or any industrial organization in the field of research, administration, organization, finance or other similar problems, under the name of \"Gagnon et Bélanger Inc.\", with a t otal capital stock of $400.000, divided into 100 common shares of $100 each and into 3,900 preferred shares of $100 each.The head office of the companylwill be at Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 16251-61 \u2014 1110/138 General Auto Spring Inc.Notice is hereby given that under Part I of ' the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Robert Brockbank, mechanic, 4541, Chambord, Montreal, Guy Phénix, electrician, P.O.B.152, Ormstown, and Gilles Phénix, insurance agent 120, Montenach, Longueuil, for the following purposes: To carry on business dealing in springs which may be adapted to any type of automotive 1760 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, SI mars 1962, Tome 94, No 18 faire affaires comme garagistes, sous le nom de f General Auto Spring Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5114, chemin Chambly, Saint-Hubert, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de décembre 1961.Ia* Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.00606* 16037-61 -1110/86 Germax Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28c jour de décembre 1961, constituant en corporation: Michael Drazner, avocat, 130, Dufferin Road, Mlle Rosa B.Gualticri, avocat, 80, Hudson, et Harold Gossack, avocat, 3736, avenue Kent, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de placement, sous le nom de « Germax Investment Corp.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de décembre 1961.V§ Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.60808 16260-61 \u2014 1110/52 Colds take Realties Inc.Avis est donné qu'en veitu de la première part ie de la Loi des compagnies de Québec, il a été acco'dé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec, des lettres patentes, en date du 20e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Maurice Jean, industriel, 1975, rue de la Concorde, Duvernay, Paul Guilhault, avocat, 5480, Lafond, Montréal, et Richard Créneau, avocat, 1994, boulevard St-Joseph, est.Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Goldstake Realties Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 374, Sherbrooke, ouest, chambre 304, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de décembre 1961./0S08 16222-61 \u2014 1111/16 have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Jean-Marc St-Jean, accountant, 71 £, Rochon Street, Hull, Yves Carrière, civil employee, 111, Lois Street, Hull, and Lucien Parent, accountant.61 Berri Street, Hull, for the following purposes: To create and organize all possible types of receration in the parish of St-Joseph, under the name of \"Loisirs St.Joseph Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $75,000.The head office of the corporation will be at 234, Berri Street, Hull, judicial district of Hull.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 16165-61 \u2014 1110/17 Luxor Heating Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of December, 1961, babe been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Maurice J.Dostaler, lawyer, Gatineau, Claude-B.Begin, accountant, Gatineau, and Roland Théorêt, notary, Gatineau, for the following purposes: To deal in heating apparatus and appliances of all kinds, under the name of « Luxor Heating Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 1,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 282, Laviolette Street, Gatineau, judicial district of Hull.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808-o 16222-61 \u2014 1111/16 Machugo Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, 324, avenue Mercille, St-Lambert, Clifford George Meek, comptable, 3101, avenue Maple-uood, Montréal, et Charles Eric Humphrey, teneur de livres, 7376, avenue Truman, Verdun, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \u2022< Machugo Limited », avec un capital total de 15,000, divisé en 5,000 actions d'une valeur au pair de SI chacune.I .c siège social de la compagnie sera 395, rue D >wd, Montréal, district judiciaire de Montréal.I >onné au bureau du secrétaire de la province, ¦«\u2022 29e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 10067-62\u2014 1111/89 Manning-Brisbois Limited Avis est donné qu'en vertu de la première polie de la Loi des compagnies de Québec, il a Machugo Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Ernest William Mockridge, manager, 324, Mercille Avenue, St-Lambert, Clifford George Meek, accountant, 3101, Maplewood Avenue, Montreal, and Charles Eric Humphrey, book-keeper, 7376, Truman Avenue, Verdun, for the following purposes : To carry on the business of an investment and holding company, under the name of \"Machugo Limited\", with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 shares of the par value of SI each.The head office of the company will be at 395 Dowd Street, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808-o 10067-62 \u2014 1111/89 Manning-Brisbois Limited Notice is hereby given that under Part I of the Québec Companies Act, letters patent, 1768 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 31 mm 1962, Tome 94, N* 13 été accorclé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec, des lettres patentes, en date du 28e jour de décembre 1961, constituant en corporation: George Wanklyn Hall, ch., avocat, 130 nord avenue Ha liant y ne, Montréal-Ouest, John Ralph Hannan, avocat, 4329, avenue Mayfair, Montréal, et Oscar Henry Manning, administrateur, 770, rue Saint-Antoine, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes d'accessoires de bureaux sous le nom «le « Manning-Brishois Limited », avec un capital total de $10,000, divisé en 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 770.rue Saint-Antoine, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 28e jour «le décembre 1961.Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 16228-61 \u2014 1111/17 Manufactured Construction Components Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour «le décembre, 1961, constituant en corporation: Harold Cossack, avocat.3730.avenue Kent, Montréal, Michael Drazner, avocat, 130, Dufferin Road, Hampstead, et Rosa B.Gualtieri, avocat, 80, avenue Hudson, Mont Royal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et de construction, sous le nom de « Manufactured Construction Components Lt«l.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,600 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 266 ouest, rue Notre-Dame, Montréal, «listriot judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ee 28e jour de décembre 1961.I^e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 16259-61 \u2014 1110/53 I.onné au bureau du secrétaire de la province.».28e jour de décembre 1961.£i Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.60808 16258-61 \u2014 1110/88 Mulii-T.Y.Sales & Service Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date ¦ In 5e jour de janvier 1962, constituant en corporation: Jacob Rothman, avocat, 6434, Clanra-nald, Montréal, Edward Samuel Berger, avocat, 3017, Brighton, Montréal, et Shirley Schaffer, commis, fille majeure, 1081, St-Viateur, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de machinerie, appareils, dispositifs ou accessoires électriques de quelque genre ou sorte que ce soit, sous le nom de s Multi-T.Y.Sales & Service Inc.», avec un capital total de $1,000.divisé en 100 actions de $10 chacune.I* siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 5e jour de janvier 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.60808 10077-62 \u2014 1110/140 Adrien Nicol Ltée Avis est donné qu'en vertu de la premier*' partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date \u2022lu 27e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Adrien Nicol, garagiste, Mme Lsnrette Côté, épouse commune en biens dudit Adrien Nicol, et dûment autorisée par lui aux tins des présentes, ménagère, Yvan Gagnon, mécanicien et garagiste, et Mme Solange Nicol, épouse contractuellement séparée de biens dudit Yvan Gagnon, et dûment autorisée par lui aux tins des présentes, ménagère, tous quatre de l'almarolle, Abitibi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de véhicules automobiles cl faire affaires comme garagistes, sous le nom de < Adrien Nicol Ltée », avec un capital total de MO.O(K), divisé en 400 actions de $100 chacune.Multi-T.V.(d'Anjou) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1961, have l»een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Edward Samuel Berger, advocate, 3047 Brighton, Shirley Schaffer, secretary, spinster, 1081 St-Yiateur, and Sylvia Kogan, secretary, spinster, 5624 McMurray, all three of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of providing means for the transmission, conveying, relaying, diffusion, recording, reproduction and reception of television and radio signals, telecasts, broadcasts and messages, under the name of \"Multi-T.V.(d'Anjou) Inc.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 25.0C0 common shares of a par value of $1 each and 5,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Town of Anjou, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of December, 1961.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.OO8O8-0 16258-61 \u2014 1110/88 Multi-T.V.Sales & Service Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacob Rothman, advocate.6434 Clanrahald, Montreal, Edward Samuel Berger, advocate, 3047 Brighton, Montreal, and Shirley Schaffer, clerk, fille majeure, 1081 St-Viateur, Montreal, for the following purposes: To deal in electric machinery, apparatus, appliances or supplies of any nature or kind whatsoever, under the name of \"Multi-T.V.Sales & Service Inc.\", with a total capital stock of $1.000, divided into 1C0 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00808-o 10077-62 \u2014 1110/140 Adrien Nicol Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Adrien Nicol, garage-keeper, Mrs.Laurette Côté, wife common as to property of the said Adrien Nicol, and duly authorized by him for these presents, housewife, Yvan Gagnon, mechanic and garage-keeper, and Mrs.Solange Nicol, wife contractually separate as to property of the said Yvan Gagnon, and duly authorized by him for these presents, housewife, all four of Palmarolle, Abitibi, for the following purposes: To operate a business dealing in motor vehicles and to carry on business as garage-keepers, under the name of \"Adrien Nicol Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each. 1760 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI mars 1962, Tome 94, No 1S Le siège social de la compagnie sera ù Palma-rolle, district judiciaire d'Abitibi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour de décembre 1961.Le Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville.0000*4 16226-61 \u2014 1111/19 The head office of the company will be ai Palmarolle, judicial district of Abitibi.Given at the office of the Provincial Secretar this 27th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 16226-61 \u2014 11111'.Nordom Limited Nordom Limited Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I < ! partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters paten I.été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la bearing date the 11th day of January, 1962 province de Québec, des lettres patentes, en date have been issued by the Lieutenant-Governor of du lie jour de janvier 1962, autorisant la fusion the Province of Quebec, authorizing the amalga « Norval Oil Company Limited », constituée en mation of \"Norval Oil Company Limited corporation en vertu des dispesitu ns de la premiè- incorporated in virtue of the provisions of Part n- partie de la Loi des compagnies de Québec, par of the Quebec Companies Act, by letters paten; lettres patentes datées du 28e jour d^octobre dated the 28th day cf October, 1943, and \"Donii- 1943, et « Dominion Oil Limited », constituée en nion Oil Limited\", incorporated in virtue of tie corporation en vertu des di.positions de ladite provisions of the said Part I of the Quel» première partie de la Loi des compagnies de Companies Act, by letters patent dated the 6tl Québec, par lettres patentes datées du 5e jour de day of May, 1931, for the following purposes: mai 1931, pour les objets suivants: Exercer un commerce des produits du pétrole, To deal in petroleum products, natural ga - gaz naturel et autres produits chimiques et sous- and other chemicals and by-products of ever] produits de toutes sortes et descriptions, sous le kind and description, under the name Of \"Nordon nom de « Nordom Limited », avec un capital Limited\", with a total capital stock of $50,000, total de $50,000, divisé en 2,000 actions ordinaires divided into 2,000 common shares of $25 each, de $25 chacune.Le nom de la nouvelle compagnie est « Nordom The name of the new company is \"Nordom Limited ».Limited\".Le siège social de la compagnie sera 505 ouest, The head office of the company will be ni boulevard Dorchester, en les cité et district 505, Dorchester Boulevard West, in the city and judiciaire de Montréal.judicial district of Montreal.Donné au bureau du secrétaire de la province, Given at the office of the Provincial Secrctan ce 12e jour de mars 1962.this 12th day of March, 1962.Le Soue-eecrétaire de la province, Raymond Douville.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.60808 10220-62 \u2014 1110/135 6O8O8-0 10220-62 \u2014 1110/135 Otarion Hearing Service Quebec Ltd.Otarion Hearing Service Quebec Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of tin partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies Act, letters patent, bearing été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la date the 22nd day of December, 1961, have been province de Québec, des lettres patentes, en date issued by the Lieutenant-Governor of the Pro.du 22e jour de décembre 1961, constituant en ince of Quebec, incorporating: Jack Spinner, corporation: Jack Spinner, marchand, 39, Wild- merchant, 39, Wildtree Drive, Beaeonsfield, Lan tree Drive, Beaeonsfield, Laura Frishling, secré- ra Frishling, secretary, fille majeure, 4870, Bour taire, fille majeure, 4870, Bourret, Montréal, et ret, Montreal, and Carl Rosen, advocate, 4815.Carl Rosen, avocat, 4815, Fulton, Montréal, Fulton, Montreal, for the following purposes: pour les objets suivants: Exercer le commerce d'appareils auditifs, To deal in hearing aids, audiometers, and allied sonomètres électriques, et produits connexes, sous products, under the name of \"Otarion Hearing le nom de « Otarion Hearing Service Quebec Service Quebec Ltd.\", with a total capital stock Ltd.», avec un capital total de $20,000, divisé en of $20,000, divided into 1,000 common shares ol 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,000 $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Donné au bureau du secrétaire de la province, Given at the office of the Provincial Secretary ce 22c jour de décembre 1961.this 22nd day of December, 1961.\u2022 Le Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville, Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.«0808 16183-61 \u2014 1110/103 6O8O8-0 16183-61 \u2014 1110/m: Peel Plaza Ltd.Peel Plaza Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent, été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la bearing date the 12th day of December, 1901 province de Québec, des lettres patentes, en date have been issued by the Lieutenant-Governor of du 12e jour de décembre 1961, constituant en the Province of Quebec, incorporating: Joy ci corporation: Joyce B res low, épouse séparée de B res low, wife separate as to property of Michaei biens de Michael Breslow, secrétaire, 3440, Breslow, secretary, 3440, Decelles Place, Mont QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 31, 1062, Vol.0/f, No.13 1761 Pima Déceliez, Montréal, Ethel Saunders, épouse \u2022 \u2022\u2022parée tie Liens de Frank Saunders, secrétaire, ¦ 150, Décarie, Montréal, et borna Richmond, secrétaire, fille majeure, 1468, rue Bishop, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôteliers, sous le nom île « Peel Plaza Ltd.», avec un capital total de |]D0.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de *|() chacune, 1,000 actions privilégiées, catégorie \"A\", de $10 chacune et 7,000 actions privilégiées, catégorie « B », de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 12c jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60808 15976-61 \u2014 1110/46 Philmar Electric Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date \u2022lu 27e jour de décembre 1961, constituant en corporation : Lou Tannenbaum, avocat, 210 ouest, rue St-Jacqucs, Beverley Woolgar, secrétaire, eélibataire, 210 ouest, rue St-Jacques, et Grace El well, secrétaire, célibataire, 210 ouest, rue St Jacques, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce d'électriciens, sous le nom de c Philmar Electric Ltd.», avec un capital total de $20,000, divisé en 500 actions ordinaires \u2022le $10 chacune et 150 actions privilégiées de $100 eliacune.le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ee 27e jour de décembre 1961.Le Soue-eecrétaire de la province, Raymond Douville.60808 16209-61 \u2014 1111/67 real.Ethel Saunders, wife separate as to property of Frank Saunders, secretary, 5150, Décarie, Montreal, and Lorna Richmond, secretary, spinster of the full age of majority, 1468, Bishop Street, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of inn-keepers, under the name of \" I 'eel Plaza Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 2,000 common shares of $10 each, 1,000 class \"A\" preferred shares of.$10 each ami 7,000 class \"B\" preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00808-o 15976-61 \u2014 1110/46 Philmar Electric Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lou Tannenbaum, advocate, 210, St.James Street West, Beverley Woolpar, secretary, spinster, 210, St.James Street West, and Grace Elwell, secretary, spinster, 210, St.James Street West, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as electricians, under the name of \"Philmar Electric Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 500 common shares of $10 each and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808-o 16209-61 \u2014 1111/67 Paquette, Paquette & Associés Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1961, constituant en eoriwration: Adrien-R.Paquette, avocat, 212, I > loom field, Outremont, Marcel Paquette, avocat, 1320, Chan tec 1ère, St-Bruno, Micheline Simard, secrétaire, fille majeure, 4840, Parthe-nais, Montréal, Françoise Frégeau, secrétaire, fille majeure, 8747, Dirval, Montréal, et Denise Paquette, secrétaire, fille majeure, 250, Bloom-field, Outremont, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Paquette, Paquette & Associés Inc.», avec un capital divisé en 1,000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 1,250 actions privilégiées de $100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $17,500.le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de décembre 1961.Le Soue-eecrétaire de la province, Raymond Douville.00808-0 10036-62 \u2014 1111/40 Paquette, Paquette «Sfc Associés Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Adrien-R.Paquette, advocate, 212, Bloomfield, Outremont, Marcel Paquette, advocate, 1320, Chanteclerc, St-Bruno, Micheline Simard, secretary, fille majeure, 4840, Parthenais, Montreal, Françoise Frégeau, secretary, fille majeure, 8747, Dirval, Montreal, and Denise Paquette, secretary, fille majeure, 250, Bloomfield, Outremont, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Paquette, Paquette & Associés Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 shares of no par or nominal value and 1,250 preferred shares of $100 each, and the amount with which the company will begin its operations is $17,500.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 * 10036-62 \u2014 1111/40 1762 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 31 mart, 1962, Tome 94, A'o 13 Pat Bowling Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu prentière partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 13e jour de septembre 1961, constituant en corporation: Gaston Patenaude, entrepreneur-électricien, 30, rue Cousineau, Valleyfield, Anne-Marie Prévost, épouse commune en biens dudit Gaston Patenaude, et dûment autorisée par lui aux 6ns des présentes, ménagère, 30, rue Cousineau, Valleyfield, Philippe Prévost, contremaître, 19A, rue Tully, Valleyfield, et Jean-Guy Patenaude, électricien, 260, rue Dufferin, Valleyfield, pour les objets suivants: Exploiter des salles de quilles, de billard et autres places d'amusement, sous le nom de « Pat Bowling Inc.», avec un capital total de $40,01)0, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI0 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sala-berry-de-Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour de mars 1962.Iaj Soue-eecrétaire de la province, Raymond Douville.60808-o 14033-61 \u2014 1111/66 Pat Bowling Inc.Notice is hereby given that under Part i of the Quebec Companies Act, letters pa* i at, bearing date the 13th day of September, 1901, have been issued by the Lieutenant-Go\\, : of the Province of Quebec, incorporating: Gi «ton Patenaude, contractor-electrician, 30 Cou si , au Street, Valleyfield, Anne-Marie Prévost, »ife common as to property of the said Gaston Pate-uaude, and duly authorized by him for these presents, housewife, 30 Cousineau Street, Valley, field, Philippe Prévost, foremun, 19A Tully Street, Valleyfield, and Jean-Guy Patenaude, electrician, 260 Dufferin Street, Valleyfield, for the following purposes : To direct bowling alleys, billiard halls and other places of amusement, under the name of \"Pat Bowling Inc.\", with a total capital stack of $40,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and 2,000 prefej ed shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Salaberry-de-Valleyfield, judicial district of Beauharnois.Given at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of March, 1962.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Provitm.60808 14033-61 \u2014 1111/66 Pineault & Lachapelle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Marcel Landry, avocat, Montée Pré Vert, Beloeil, François Payette, avocat, 1652, Fleury, est, Montréal, et Pierre Magnan, avocat, 1267, rue Bougie.Saint-Laurent, pour les objets suivants : Faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Pineault & Lachapelle Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 10031, boulevard Saint-Michel, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de décembre 1961.El Soue-eecrétaire de la province, Raymond Douville.60808-o 10031 -62 \u2014 1110/89 Pineault & Lachapelle Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Marcel Landry, advocate, Montée Pré Vert, Beloeil, François Payette, advocate, 1652 Fleury east, Montreal, and Pierre Magnan, advocate, 1267 Bougie Street, Saint-Laurent, for the following purposes : To carry on business dealing in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Pineault & Lachapelle Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 10031 Saint-Michel Boulevard, Montreal-North, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of December, 1961.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.00808 10031-62\u2014 1110 89 Les Placements Clauromadore Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 27e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Jeanne Audet, secrétaire, fille majeure, 5519, rue Jeanne-d'Arc, Montréal, Rémi Lussier, notaire, 1760, Dauphin, St-Vincent-de-Paul (Duvernay), et Jean-Pierre Hardy, notaire, 2, chemin Chambly, Longueuil, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Les Placements Clauromadore Inc.», avec un capital total de $145,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune et en 1,400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Les Placements Clauromadore 'ne.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jeanne Audet, secretary, spinster, 5519, Jeanne d'Arc Street, Montreal, Rémi Lussier, notary, 1760 Dauphin, St-Vincent-de-Paul (Duvernay), and Jean-Pierre Hardy, notary 2, Chambly Road, Longueuil, for the following purposes: To carry on a business as an investment company, under the name of \"Les Placements Clauromadore Inc.\", with a total capital stock of $145,-000, divided into 1,000 common shares of a par value of $5 each and into 1,400 preferred shares of a par value of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 31, 11)62, Vol.94, No.13 1763 Ix- siège social de la compagnie sera 2319, rue cm-Talon, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ¦ e 27e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de ta province, Raymond Douville.0X08-0 16170-61 \u2014 1110/127 Les Placements Doré mi Inc.Avis est donné qu'en vertu de la premièie partie de la Loi des compagnies de Québec, il a i des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1962, constituant en corporation: bonis Pouliot, agent-vendeur, St-Félicien, Allen Gagnon, marchand, Albanel et Marie-Anna Pouliot (iagnon, épouse dudit Allen Gagnon, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, ménagère, Albanel, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands de bois, sous le nom de « Pouliot & Gagnon Ltée », avec on capital total de $40,000.divisé en 4,000 actions de $10 chacune.be siège social de la compagnie sera à Albanel, district judiciaire de Roberval.t Donné au but eau du secrétaire de la province, 'elle.Donné au bureau du secrétaire de lu province, ce 16e jour de janvier 1962.Le Soue-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.60S08-o 14561-61 \u2014 1111/24 Salon Alain Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Alain Benott, coiffeur, 8399A, rue St-Denis, Montréal, Mlle Thérèse Benoit coiffeuse, 8399A, nie St-Denis, Montréal, et Mlle Denise Sureau, ménagère, 8989, rue Fouché, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de coiffeurs et barbiers, sous le nom de e Salon Alain Inc.», avec un capital divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominale et en 4,000 actions privilégiées de $10 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $4,500.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de décembre 1961.Le Soue-eecrétaire de la prorince, Raymond Douville.60808-o 10004-62 \u2014 1111/1 The Savoy Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 4e jour de janvier 1962, constituant en corporation: Bernard Gardner, avocat, 412, Northcote Road, Rosemère, Gabriel Glazer, avocat, 5850, avenue Sou art, Montréal, et Mlle Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, 4840, avenue Bourret, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et de construction, sous le nom de « The Savoy Corp.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4e jour de janvier 1962.Le Soue-eecrétaire de la province.Raymond Douville.60808 10093-62\u2014 1111/55 Salle d'Accueil Domrémy de Mon t-Lan r h Notice is hereby given that under Part 111 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of January, 1902, have been issued by the Lieu tenant-Govern, of the Province of Quebec, to incorporate as » corporation without share capital: Dr.Yvan Marcotte, physician, Donat St-Louis, industria list, Liguori Lefebvre, barber, Father Jean-tiny Brière, priest-chaplain, Bernard St-Jean, indus trialist, Fernand Simard, journalist, all six of Mont-banner, and Maurice Moineau, foreman of Lac-des-Iles.for the following purposes: To give mutual aid to and help in the rehabili tation of alcoholics, under the name of \"Salle d'Accueil Domrémy de Mont-Laurier\".The amount to which the value of the immo\\ cable prapartj which the corporation may bold is to be limited; is $50,000.The head office of the corporation will be at Mont-Luurier, judicial district of Isabelle.Given at the office of the Provincial £ecretar t his 16th day of January, 1962.Raymond Douville, Aeeistant Secretary of the Province.(50808 14561-61 \u2014 1111/21 Salon Alain Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent bearing date the 29th day of December, 1961.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Alain Benott, hairdresser, 8399A St.Denis Street.Montreal, Miss Thérèse Benott, hairdresser.8399A St.Denis Street, Montreal, and Mis-Denise Sureau, housekeeper, 8989, boucle Street, Montreal, for the following purposes: To carry on business as hairdressers and bar bers, under the name of \"Salon Alain Inc.\" with a capital stock divided into 100 shares of no par or nominal value and 4,000 preferred share-of $10 each, and the amount with which the coin pany will begin its operations is $4,500.The head office of the company will be a I Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary this 29th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 10004-62 \u2014 1111/1 The Savoy Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Bernard Gardner, advocate, 412, Northcote Road, Rosemère, Gabriel Glazer, advocate, 5850, Souai -Avenue, Montreal, and Miss Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, 4840, Bourret Avenue, Montreal, for the following purposes: To do business in the fields of real estate and construction, under the name of \"The Savoy Corp.\", with a total capital stock of .$40,000.divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of January, 1962.Raymond Douville, Aeeistant Secretary of the Province.60808-o 10093-62 \u2014 1111/55 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.March 31.1962, VtA.94, No.13 1771 I.e* Scouts tie Roberval Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 7e jour de décembre 1961.constituant en corporation sans capital-actions: Alfred Martel, menuisier, Paul-A.Paquin, agronome, et Jean-< tries Parent, agent d'assurance, tous trois de biherval, pour les objets suivants: Promouvoir l'éducation religieuse, physique, intellectuelle et morale de la jeunesse, suivant la -nethode scoute, sous le nom de « Les Scouts di Roberval Inc.».Le montant auquel sont limités les revenus a miels des biens immobiliers que la corporation ut posséder, est de $20.000.Im siège social de la corporation sera à Ko h rval, district judiciaire de Roberval.Donné au bureau du secrétaire, de la province, ce 7e jour de décembre 1961.I.e Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douvillk.0080*4» 15916-61 - 110S 27 Sea Gliders Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, ira été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 21e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Jean-Claude Delorme, avocat, 14, Boni du Lac, Beaeonsfield, Roger-Louis Beau-lieu, avocat et conseil en loi de la Reine, 702, avenue llartland, Outremont, et André-Jean Clermont, avocat.2, rue D'Artois, Préville, pour les objet! suivants: Faire le commerce de meubles, d'effets mobiliers, d'articles de quincaillerie et d'articles de ^|k»rt, sous le nom de « Sea Gliders Inc.», avec un capitol total de $100,000, divisé en 2.000 actions ordinaires de $5 chacune et en 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Fabre-ville, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 2le jour de décembre 1961./> Soux-secrétaire de la province.Raymond Douville.' .0808-0 15956-61 \u2014 1110/55 Service Forestier Montréal Inc.Montreal Shade Tree Service Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 14e jour de décembre 1961, constituant en corporation : Jean Prieur, ingénieur professionnel, 5950, 38e avenue, Montréal.Isabelle Prieur, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Jean Prieur, 5950, 38e avenue, Montréal, et Guy Poirier, comptable agréé, 5270, boulevard Pie IX, Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce d'émondeurs, d'horticulteurs, de pépiniéristes, et, en général, de tout ce qui a trait au traitement et à la protection de l'arbre, sous le nom de « Service Forestier Montréal Inc.\u2014 Montreal Shade Tree Service Inc.», avec un capitol total de $70,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,600 actions privilégiées de $25 chacune.les Scouts de Roberval Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Alfred Martel, joiner.Paul-A.Paquin, agronomist, and Jean-Charles Parent, insurance agent, all three of Roberval, for the following purposes: To promote the religious, physical, intellectual and moral education of young people, according to the scout method, under the name of \"Les Scouts de Roberval Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to he limited, is $20,000.The head office of the corporation will be at ¦Roberval, judicial district of Roberval.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of December.1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.80808 15016-61 \u2014 1108/27 Sea Gliders Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean-Claude De lor n h-, advocate, 14 Bord du Lac, Beaeonsfield, Roger-bonis Beauiieu, advocate and Queen's Counsel.702 Hartland Avenue, Outremont, and Andre-, lean Clermont, advocate, 2 D'Artois, Prévillc, for the following purposes: To carry on business dealing in furniture, moveables, articles of hardware and sports articles, under the name of \"Sea Gliders Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 2,000 common shares of $5 each and 900 preferred* shares of $100 each.The head office of the company will be at Fahreville, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808 15956-61 \u2014 1110/55 Service Forestier Montréal Inc.Montreal Shade Tree Service Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean Prieur, professional engineer, 5950, 38th Avenue, Montreal, Isabelle Prieur housewife, wife contractually separate as to property of the said Jean Prieur, 5960, 38th Avenue, Montreal, and Guy Poirier, chartered accountant, 5270, Pie IX Boulevard, Montreal, for the following purposes: To carry on a business as primers, horticultures, seedsmen, and, generally to deal in anything having to do with the treating and protection of trees, under the name of \"Service Forestier Montréal Inc.\u2014 Montreal Shade Tree Service Inc.\", with a total capitol stock of $70,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and into 1,600 preferred shares of $25 each.1\" 1772 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 31 mars 1962, Tome 94, No 13 Le siège social de la compagnie sera 5040, 38e avenue, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 14e jour de décembre 1901.Ije Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.00808-o 15595-01 \u2014 1110/50 Simard Automobile (Lu Tuque) Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quél>cc, «les lettres patentes, en «late du 29e jour de décembre 1901, constituant en corporation: Chai les Simard, garagiste, Dame Louisa Tood, épouse commune en biens dudit Charles Simard, et dûment autorisée par lui aux fins «les présentes, ménagère, et Robert Simard, mécanicien, tous trois de La Tuque, pour les objets suivants: Commerce d'automobiles, sous le nom de « Simard Automobile (La Tuque) Incorporée », avec un capital total de $10,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à La Tuque, district judiciaire de Québec Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.60808-o 15994-61 \u2014 1111 /80 The head office of the company will be at 5940, 38th Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Seeretan.this 14th «lay of December, 1961.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province t»0*08 15595-61 - 1110/56 Simard Automobile (La Tuque) Incorporée Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters paten;, bearing dale the 29th day of December, 1961, have been Issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Charl< .Simard.garage-kee|>er, Dame Louisa Todd, wife common as to property of the said Charles Simard.and duly authorized by him for these presents, housewife, ami Robert Simard, mech.nic.all three of La Tuque, for the following pur poses : To deal in automobiles, under the name oi \"Simard Automobile (La Tuque) Incorporée\", with a total capitalstock of $40,000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be al La Tuque, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary this 29th day of December, 1961.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province 60008 15994-61 \u2014 1111/80 Odina Simard Ltée Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 27e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Francois Simard, commerçant, 39, rue de la Fabrique, Hagot vilie, Charles Tremblay, comptable agréé, 504, Chabanel, Chicoutimi, et Mlle Jacqueline Tremblay, comptable, 69, 2ième Rue, Port-Alfred, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers, sous le nom de « Odina Simard Ltée s, avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions onlinaires de $100 chacune.be siège social de la compagnie sera à Bagot-viIle, district judiciaire de Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.60808-o 16233-61 \u2014 1109,80 Souvenir Toys & Stationers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la premièie partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en «late «lu 4e jour «le janvier 1902.constituant en corporation: Arthur A.Garvis.avocat, 4764, La Peltrie, Montréal, Jean Lewis, secrétaire, fille majeure, 4080, Côte-Ste-Catherine.Montréal, et Madeleine Iknejian, dactylo, fille majeure, 7145, 7e Avenue, cité de Saint-Michel, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le toutes sortes «le produits, articles et marchandises faits, en tout ou en partie, «le cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et leurs sous-produits, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs gazeuses, livres et Odina Simard Ltée Notice is hereby given that under Purt I «»f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of December, 1901.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Francois Simanl, tradesman, 39, de la Fabrique Street.Bagotville, Charles Tremblay, chartere*! accoun tant, 504, Chabanel, Chicoutimi, and ftfiss Jacqueline Tremblay, accountant, 69, 2nd Street Port-Alfred, for the following purposes: To carry on business as grocers under the name of \"Odina Simard Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common snares of $100 each.The head office of the company will be at Bagotville, judicial district of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary this 27th day of December, 1961.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Pnrvince.H0808 16233-61 \u2014 1109/80 Souvenir Toys & Stationers Inc.Notice is hereby given that under Pail I of the Quel>ec Companies Act, letters patent, bearing «late the 4lh day of January, 1962.have been issued by the Lieutenant-Governor «\u2022!' the Province of Quebec-, incorporating: Arthur A.Garvis, advocate.4764, I-Ji Peltrie.Montreal.Jean Lewis, secretary, fille majeure.4080, C6t«-Ste-Catherine, Montreal, and Madeleine Ikm-jian, typist, fille majeure, 7145.7th Avenue, city of Saint-Michel, for the following purposes: To deal in all kinds of products, articles and merchandise made, in whole or in part.t»f leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur.textiles, glass and by-products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, works of art, chemical and beauty products, lend. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 31, 1962, Vol.94, No.13 1773 périodique*, œuvres d'art, produits chimiques et de beauté, produits de la terre, de la mer et de la foret, sous le nom de « Souvenir Toys & Stationers Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.I a- siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4e jour de janvier 1962.Le Soue-eecrétaire Je la province, Raymond Douvillk.69608 10046-62\u2014 1110/40 Spécialités de Construction CM.Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a él 14 février 1962.Le Sou*secrétaire de la province, Raymond Douville.iikOS 14284-58\u2014 1115/101 Wasserman & Charles Furs Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Quél>ec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 26 janvier 1962, à la compagnie « W.& W.Fur Basters & Tapers Inc.», constituée en corporation par lettres pa-i entes datées du 27e jour de janvier 1961, changeant son nom en celui de « Wasserman & Charles Furs Inc.».Donné au bureau du secrétaire de la province, le 26 janvier 1962.Le Soun-necrétaire de la province, Raymond Douville.'10808 10498-61 \u2014 1113/56 York Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 16 février 1962, à la compagnie « York Construction Inc.», augmentant son capital de $20,000 à $135,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,150 actions privilégiées de $100 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, le 16 février 1962.Le Soun-necrétaire de la province, Raymond Douville.60808 5836-45\u20141116/5 Zephyr Knitting Mills Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date «lu 5 février 1962 à la compagnie « Zephyr Knitting Mills Ltd.», augmentant son capital de $74,000 à $124,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, le 5 février 1962.Le Soun-necrétaire de la province, Raymond Douville.00808 10508-55 \u2014 1114/82 incorporating by letters patent dated the 27th «lay of July, 1955, changing its name to that of \"Superex Lt«b\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 24th «lay of January, 1962.Raymond Douville, Aeeietant Secretary of the Province.00S08-o 11781-55 \u2014 1114/05 Three Star Properties Ltd.Notice is hereby given tliat under Part I «>f the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of February, 1962, have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Three Star Properties Ltd.\", increasing its capital from $40,000 to $340,000, the additional capital stock being divided into 3,000 preferred shares of $100 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 14th «lay of February, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00808-o 14284-58 \u2014 1115/101 Wasserman & Charles Furs Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of January, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province cf Quebec, to \"W.& W.Fur Basters & Tapeis Inc.\", incorporated by letters patent dated the 27th day of January, 1961, changing its name to that of \"Wasserman & Charles Furs Inc.\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.6O8O8-0 10498-61 \u2014 1113/56 York Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of February, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"York Construction Inc.\", increasing its capital from $20,000 to $135,0C0, tie additional capital stock being divided into 1,150 preferred shares of $100 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 16th day of February, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.OOSO8-0 5836-45 \u2014 1116/5 Zephyr Knitting Mills Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 5th day of February, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Zephvr Knitting Mills Ltd.\", increasing its capital' from $74,000 to $124,000, the additional capital stock being divided into 5,000 preferred shares of $10 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of February, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00808-o 10508-55 \u2014 1114/82 1786 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI mars 1969, Tome 94.Ho IS Ministère du Travail Avis Fer et bronze d'ornementation L'honorable René Hamcl.ministre du Travail, donne avis par les présentes, con foi mément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 103 et amendements), que l'avis publié dans l'édition du 9 décembre 1961 de la Gazette officielle de Québec, concernant l'extension juridique d'une convention de travail intervenue dans l'industrie du fer et «lu bronze d'ornementation, est mtxlifié comme suit: 1° L«'s parties contractantes «le première part sont remplacées par les suivantes: « La Chambre «le Construction Inc., dont le siège social est à Montréal, agissant pour et au nom «les maisons suivantes: A.& S.Architectural Iron Limited; Do/ois St-lean Limitée; A.Faust in Company Ltd.; Locweld & Forge Producta Ltd.; Montreal Forge»! Products Ltd.; Montreal Iron Works Limited; Ornamental Metal & Machine Works Ltd.; Montreal Metal\\vorke«l Products Ltd.; Forge Laurentiennc Knrg.; Lord & Fils Co.Ltd.; Les Frères Lebrun Limitée; Alumcraft Corp.» 2° L'article III est remplacé par le suivant: « III.Durée du travail: a) La durée hebdomadaire «lu travail est «le quarante-quatre (44) heures distribuées comme suit: Neuf (9) heures par j.\\ the employers.d) The employees put to work during the «la\\ or night shall receive the full working period foi which they have been called; however, this pro vision is subject to sub-paragraphs 4V\" and \"/\" the present article.e) When work on the ship has to be «liscou tinued on account of adverse weather conditions employees shall be paid one (1) hour, in addition to any hour or hours alraedy worked./) The employees called to work mails, exprès» or baggage on Sunday, Good Friday, St.Jean Baptiste Day, July 1st (Confee replaced by the following: \"However, this exemption does not apply to bridge, viaduct and tunnel construction opera tions carried out on behalf of any one of the Departments lioreabove mentioned.\" The publication of the present'notice does not rentier obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the «late of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections, in duplicate, if possible, which the interested parties may wish to set forth.Gérard Tremblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 31, 1962.60830 c Notice of levy The Honourable René Hamel, Minister of Labour, hereby gives notice that the Barbers' and Hairdressers' Parity Committee of St.John and Iberville, formed under «lecree number 606 of June 15, 1955, has been authorized by a bylaw approved by Order in Council number 463 of March 20, 1962, section \"B\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163, and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans, the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned.1.Assessments The period of levy extends from April 1.1962 to April 1, 1963, it is laid as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 666 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to % of 1% of their payroll as regards employees governed by the said decree.6) The artisans governed by the said decree, number 666 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to 3 2 °f 1% of the average wages established by the said committee at $60.00 per week, i.e.an assessment of $0.30.e) The employees governed by the said decree, number 666 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to 1 £ of 1 % of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all particulars required by the Parity Committee shall be given.Professional employers shall complete and sign their reports and forward them to the Parity Committee every month. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 31, me.Vol.94, So.13 1791 L'employeur professionnel doit percevoir, à lu tin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.LYmployeur professionnel doit transmettre sou rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et de celles de ses salariés.Le Comité paritaire a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque lois qu'il le juge à propos.I.e prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise eu demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ses cotisations ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.(' i -annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des barbiers-coiffeurs de St-Jean et Iberville, pour la période comprise entre le 1er avril 1962 et le 1er avril 1963.Comité paritaihe deh Barbiers-Coiffeuhs de St-Jean et Iberville Siège social: St-Jean, P.Q.État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er avril 1962 et le 1er avril 1963.Recette: < 'otisations (M de 1%) : Employeurs professionnels.S 435.00 Salariés.435.00 Artisans.3,666.00 $4,536.00 Débourses: Salaires.$3,640.00 Loyer.84.00 Téléphone.72.00 Inspection.260.00 Papeterie.100.00 Frais de vérification.120.00 Frais légaux.160.00 Frais de déplacement.100.00 $4,536.00 Le Sous-ministre du Travail, Gerard Tremblay.Ministère du Travail, Québec, le 31 mars 1962.60830-o Avis de prélèvement L'honorable René Hamel, ministre du Travail donne avis par les présentes, que le Comité paritaire de l'Industrie de la Botte de Carton, juridiction de Québec, établi en exécution du décret numéro 758 du 19 juillet 1951, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté Professional employers shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of their employees by means of a deduction from their pay.Professional employers shall submit their monthly report to the Parity Committee on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which it is exigible; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employers and of the employees.The Committee may have the said report signed under oath when deemed advisable.The assessments laid by the present by-law are payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without not ice.Should u professional employer or an artisan refuse to pay his assessments or to give the necessary information, he will be given five (5) days, notice to fulfil his obligations towards t he Parity ( 'ommittee.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall make a quartely report covering its financial operations and remit same to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of The Barbers' and Hairdressers' Parity Committee of St.John and Iberville, for the period between April 1, 1962, and April 1, 1963.The Barbers' and Hairdressers' Parity Committee of St.Jobn and Iberville Head office: St.John's P.Q.Estimate of the receipts and disbursements for the period between April 1, 1962 and April 1, 1963.Receipts: Assessments (M of 1%) : Professional employers.$ 435.00 Employees.435.00 Artisans.3,666.00 $1,536.00 Disbursements: Salaries.$3,640.00 Rent.84.00 Telephone.72.00 Inspection.260.00 Stationary.100.00 Auditing expenses.120.00 Legal fees.160.00 Travelling expenses.100.00 $4,536.00 Gérard Tremblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 31, 1962.60830-© Notice of levy The Honourable René Hamel, Minister of Labour, hereby gives notice that the Parity Committee of the Paper Box Industry, Quebec Jurisdiction, formed under decree number 758 of July 19, 1951, has been authorised a by-law approved by Order in Council number 463 of 1792 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 31 mars 1962, Tome 94, No 18 en coi is*-il numéro 403 du 20 murs 1902, section « A », le tout «l'accord avec les dispositions'de la Loi de la convention collective, à prélever «les cotisations «les employeurs professionnels, des artisans, «les salariés assujettis audit «lécret, suivant lu méthode et le taux oi-uprès mentionnés.1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er avril 1902 au 22 septembre 1962; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit «lécret numéro 758 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à } 2 *'e 1% «le leur liste «le paye pour les salariés assujettis audit «lécret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 758 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à \\i «le \\% «lu salaire établi «lans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit $46.00 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 758 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à x/i de 1% «le leur rémunération.2.Mode de perception Bu vue de faciliter la perception de .ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels, des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir an Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration de la péri > QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 31.1962, Vol.94.So.13 1795 Avis de prélèvement L'honorable René Hamel, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire des Barbiers et Coiffeurs de Saint-Hyacinthe, établi en exécution du décret numéro 1010 du 26 septembre 1956 a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 463 du 20 mars 1962, section « D », le Lout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation ba période de cotisation s'étend du 1er avril 1969 au 31 mars 1963; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 1010 et amendements, «loi-vent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% des salaires, commissions et allocations qu'ils versent à leurs salariés assujettis audit décret.6) Les salariés assujettis audit décret numéro 1010 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% des salaires, commissions et allocations reçues.c) Les artisans assujettis audit décret numéro 1010 et amendements doivent verser au Comité paritaire les sommes suivantes: i.Les artisans barbiers, coiffeurs et coiffeuses pour dames des zones I et II : 10.30 par semaine ou $1.30 par mois.ii.Les artisans barbiers, coiffeurs et coiffeuses pour dames de la zone III: $0.25 par semaine ou $1.10 par mois.Tout employeur ou employeur professionnel qui pratique lui-même l'un ou l'autre des métiers visés par ledit décret numéro 1010 et amendements est de plus considéré, aux fins du présent règlement, comme un artisan.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport mensuel, sur lesquelles doivent être indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à leur emploi, leur qualification, les salaires, commissions et allocations payés et les sommes versées au Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et transmis au Comité paritaire le ou avant le 10 de chaque mois; ledit rapport doit couvrir le mois précédent.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même la rémunération de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire et les faire parvenir audit comité, en même temps que sa propre cotisation.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé par lui-même ou par une personne responsable à son emploi, avant d'être transmis au Comité paritaire.Ce Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport, chaque fois qu'il le juge à propos.L'employeur professionnel et l'artisan doivent faire parvenir leurs cotisations au Comité paritaire, le ou avant le 10 de chaque mois; ces cotisations doivent couvrir le mois précédent.Notice of levy The Honourable René Hamel.Minister of Labour, hereby gives notice that the Barbers' and Hairdressers' Parity Committee of Saint-Hyacinthe, formed under decree number 1010 of September 26, 1956, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 463 of March 20,1962.section \"D\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from April 1, 1962 to March 31.1963; it shall be laid in the following manner: a) The professional employers governed by the decree number 1010, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 'i> to 1% of the regular wages and of the >ercentages paid to their employees governed >y the decree.b) The employers governed by the decree 1010, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to of 1% of their regular wages and of the percentages received.c) The artisans governed by the decree number 1010, and amendments, shall pay the following assessments to the Parity Committee: i.Barbers, ladies' male and female hairdressers artisans of Zones I and II: $0.30 per week or $1.30 per month.ii.Barbers, ladies' male and female hairdressers artisans of Zone III: $0.25 per week or $1.10 per month.Any employer or professional employer who plies one of the trades subject to the decree number 1010 and amendments is considered as an artisan for the purposes of the present bylaw.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee shall supply the professional employers with printed report forms indicating the name in full and the residence of each employee in his employ, their qualification, the wages and percentages paid and the amounts paid to the Parity Committee.The professional employer shall have the report made and sent to the Parity Committee, on or before the 10th day of each month; the report shall cover the month preceding.The professional employer shall deduct, at the end of each week, from the wages of each one of his employees, the assessments owed to the Parity Committee and forward same to the said Committee, together with this own assessments.The report of the professional employer shall be signed by himself or by an authorized employee before it is sent to the Parity Committee or the local inspector.This Committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The professional employer and the artisan shall send their assessments to the Parity Committee, on or before the 10th day of each month; the assessments shall cover the month preceding. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI mars 1962, Tome 94, No 13 Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié sans mise en demeure au préalable.3.Rapport financier Selon les termes de la I Miscellaneous.125.00 $4,525.00 Disbursements: Employees' salaries.$1,200.1' Travelling expenses of members of Committee, investigations and inspections.1,150.00 Printing, stationery, publicity.175.(x) Postage, telephone.240.00 Meeting attendance fees.360.01 \u2022 Board of examiners.300.00 Hygiene courses.700.00 Legal and professional fees.100.0< I Rent and general expenses.300.(H > $4,525.00 Gérard Tremblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 31, 1962.60830-.Notice of amendment Barbering and Hairdreseing Tradee Region of St.John The Honourable René Hamel, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barbering and bairdressing trades in the region of St.John's, rendered obligatory by the decree number 666 of June 15, 1955 and amendments, have peti tioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree: 1.Article 101 will be replaced by the following: \"101.Daye kept ae holidays: There shall be no work on Sunday and the following holidays : New Year's Day, January 2, Epiphany, Good QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March SI, im.Vol.04.No.IS 1797 ¦ii Saint, l'Ascension, la St Jean-Baptiste, la Confédération, la fête du Travail, le jour d'Ac-Iion-de-Grâce, la Toussaint, l'Immaculée Con-( eption, Noël et le 26 décembre.Cependant, les coiffeurs pour dames peuvent travailler le Vendredi-Saint ».2° Le paragraphe « a » de l'article 104 sera remplacé par le suivant: « a) Dans la cité de Saint-Jean, les villes d'Ibcr-ville, Cowansville, Laprairie et le village de ^weetsburg et le territoire compris dans un rayon le six (6) milles de leurs limites: I>es mardi, mercredi et jeudi: de 9 a.m.à 0.30 p.m.I.e vendredi: de 9 a.m.à 9 p.m.I.e samedi: de 8 a.m.à 6 p.m.Dispositions spéciales: Durant les mois de juin, juillet et août, l'heure de cessât ion est 5 p.m.Si au cours de la semaine il y a une fête chômée, les heures de travail sont de 9 a.m.à 7 p.m.le lundi.Si le jeudi précède une fête chômée les heures de travail seront de 9 a.m.à 9 p.m.Semaine de Noël: Nonobstant les dispositions précédentes, les heures de travail sont de 9 a.m.à 9 p.m.les deux (2) jours précédant lu veille de Noël; la veille de Noël les heures de t ravail sont de 8 a.m.à 6 p.m.Nonobstant l'article 101, le 2 janvier et le 26 décembre ne sont pas chômés s'ils tombent un endredi ou un samedi.I,es heures «le travail «ont les heures régulières «lu vcn«lr«?di et «lu samedi.» 3e Le premier alinéa du paragraphe « c » de l'article 104 sera remplacé par le suivant: « c) Dane la ville de Coicansville et le territoire '\u2022omprie dans un rayon de six (6) milles de ses limites: » 4° Le paragraphe « «i » de l'article 104 sera remplacé par le suivant: « d) Dans la ville de Bedford et la municipalité d'IIenryville et le territoire compris dans un rayon de six (6*) milles de leurs limites: Le lundi: chômé.Les mardi et mercredi: «le 8 a.m.à 6 p.m.Le jeudi: de 8 a.m.à 8.30 p.m.I*e vendredi: de 8 a.m.à 9 p.m.I.e samedi: de 8 a.m.à 6 p.m.Cependant, s'il y a une fête chômée durant la semaine, les heures de travail du lundi sont celles établies pour le mardi ».5° L'article 106 sera remplacé par le suivant: « 106.Prix mini na die servit es: Les employeurs professionnels, les salariés et les artisans «loivent charger au public les prix minima suivants pour les services ci dessous menti nnés: o) St-Jean, Ilxrville, Laprairie, Cowansville.Farnham, Sweeteburg et un rayon de six {6) milles de leurs limitée: Barbe.SI.00 Coupe de cheveux pour adultes des deux sexes.1 -25 < 'oupe de cheveux en brosse pour adultes.1.35 t oupe de cheveux pour enfants de 14 ans et moins: Mardi, mercredi et jeudi.0.75 Vendredi, samedi et veille «le fêtes.1.00 >>) Bedford et la municipalité d'IIenryville et un rayon de six (6) milles de leurs limites: Barbe.S0.00 Coupe de cheveux pour adultes des deux sexes.;.1.00 f 'oupe de cheveux en brosse pour adultes.1.15 Coups de cheveux pour enfants «le 14 ans et moins: Mardi, mercredi et jeudi.0.60 Vend red i.samedi et veille de fêtes.0.75 Friday, Ascension Day, St.John the Baptist Day, Confederation Day, Labour Day, Thans-giving Day, All Saints Day, Immaculate Conception Day, Christmas Day and December 26.However, ladies' hairdressers are permitted to work on (itxxl Frulay.\" 2.Paragraph \"a\" of article 104 will be replaced by the following: \"a) In the city of Stint-Jean, the towns of Iberville.Cowansville, Laprairie and the village of Sweetshurg and the territory comprised in a radius of six (6) miles from their limits: Tuesduy, Wednesday an«l Thursday: 9:00 a.m.to 6:30 p.m.Friday: 9:00 am.to 9:00 p.m.Saturday: 8KM) a.m.to 6:00 p.m.Special provisions: During the months of June, July and August, the finishing time shall be 5:00 p.m.When a holiday falls in a week, the hours of work shall l>e from 9:C0 a.m.to 7:00 p.m.on Monday.When Thursday precedes a holiday, the hours of work shall be from 9:00 a.m.to 9:C0 p.m.Christmas Week: Notwithstanding the foregoing provisions, the hours < f work shall be from 9:00 a.m.to 9:00 p.m.on the two (2) days precetling Christ Eve; on Christmas Eve the hours of work shall l>e from 8:C0 a.m.to 600 p.m.Notwithstanding the provisions of article 101, January 2 and December 26 shall not be kept as holidays if they fall on a Friday or on a Saturday.The hours of work shall be the regular hours of Friday and Saturday.\" 3.The first sub-paragraph of paragraph \"e\" of article 104 will be replaced by the following: \"c) In the town of Cowansville and the territory comprised in a radiue of six (tf) miles from its limits:\" 4.Paragraph \"d\" of article 104 will be replaced by the following: \"d) In the town of Bedford and the municipality of HenryviUe and the territory comprised in a radius of eix (6*) miles from their limite: Monday: no work; Tuesday and Wednesday: 8:00 a.m.to 6: p.m.Thursday: 8:00 a.m.to 8:30 p.m.Friday: 8:00 am.to 9:00 p.m.Saturday: 8KM) a.m.to 6:00 p.m.However, when a h< I'd ay falls in the week, the hours of work of Monday shall be those estahoshed for Tuesday.\" 5.Article 106 will l>e replaced by the following: \"106.Minimum pricee of services: Professional employers, employees and artisans slu.Il charge the following minimum prices for the services hereunder mentioned: a) Saint-Jean, Iberville, laprairie.Cowansville, Farnham, Sweetsburg and a radiue of six (6) miles from their limits: Shave.Si.00 Haircut, adults (male and female).1.25 Brushcut, adults.1.35 Haircut, children \u2014 14 years of age or under: Tuesdav, Wednesday an«l Thursday.0.75 Friday, Saturday ami holiday eves.1.00 6) Bedford and the municipality of Ilenryville and a radius of six (6) miles from their limite: Shave.SO.60 Haircut, adults (mule and female).1-00 Brushcut, adults.1.15 Haircut, children \u2014 14 years of age or under : Tuesday, Wednesday ami Thursday.0.60 Friday.Saturday ami holiday eves.0.75 1798 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI mari, 1962, Tome 94, So IS c) Dane toute la juridiction territoriale: Flambage de* cheveux.$0.25 Shampooing.0.50 Massage au vibra tour, citron et rose.0.55 Lotion.0.85 Massage à la glaise.1.00 Aiguisage «le rasoir.0.50» 6° L'article 109 sera remplacé par le suivant: « 109.À Cowansville, les bargiers doivent prendre leur semaine de vacances aux dates suivantes: Rive sud, la troisième semaine de juillet; Rive nord, la quatrième semaine de juillet ».7° L'article 111 (Quatrième Partie) sera remplacé par le suivant: 111.Juridiction territoriale: La juridiction territoriale de la présente partie du décret comprend les districts électoraux de Saint-lean, Iberville, Napierville.Laprairie et Missisquoi, ainsi que les municipalités de Sutton et Abercorn et le territoire compris dans un rayon de six (6) milles de leurs limites ».8° L'article 113 sera remplacé par le suivant : t 113.Durée du travail: a) La semaine de travail est de quarante-six (46) heures réparties comme suit: Lundi : fermé toute la journée, sauf s'il y a une fête chômée dans la semaine, alors que les heures de travail sont celles du mardi; Mardi et mercredi: 9 a.m.à 7 p.m.; Jeudi et vendredi: 9 a.m.à 9 p.m.; Samedi: 8 a.m.à 5 p.m.; Veille de fêtes chômées: 8 a.m.à 9 p.m.Durant les mois de mai, juin et décembre et la semaine précédant la fête de Pâques, les heures de travail sont de 9 a.m.à 9 p.m.les mardi et mercredi.Nonobstant les dispositions précéflentes, lorsque l'Epiphanie, l'Ascension 1-a Toussaint et 1 Immaculée Conception tombent un vendredi ou un samedi ils sont ouvrables aux heures régulières du décret.Toute personne qui tient un salon de coiffure doit faire en sorte qu'il soit possible de voir à l'intérieur du salon en dehors des heures régulières de travail.Seuls sont autorisés à aller exercer leur métier à domicile les coiffeurs pour dames détenant le certificat de qualification et ceci durant les heures régulières de travail déterminées par le décret, exception faite pour services aux malades dans les hôpitaux et aux morts.b) Dans le cas d'un mariage, il est permis de coiffer la mariée en dehors des heures réglementaires.Dans le cas de mortalité, il est permis de coiffer les personnes dans la famille immédiate du défunt, en dehors des heures réglementaires avec l'approbation du Comité paritaire ».9\" L'article 116 sera remplacé par le suivant: 1116.Congé annuel payé: Sept (7) jours consécutifs de vacances payées doivent être accordés, chaque année, aux employés réguliers durant la période s'étendant entre le 1er juin et le 31 août.L'employeur doit faire connaître au salarié environ six (6) semaines à l'avance la date fixée pour ses vacances.La rémunération des vacances au taux de 2% du salaire brut (salaire et pourcentage) doit être payé au salarié avant son départ pour ses vacances.L'employé qui n'a pas un (1) an de service a droit à 2% du salaire brut pour la période qu'il a travaillé.Il est interdit à un employeur de remplacer par une indemnité compensatrice les vacances annuel-es payées.e) In the entire territorial jurisdiction: Singeing of the hair.$0.25 Shampoo.0.50 Vibrator massage (lemon and \"rose\").0 55 Lotion.0.38 \"Mud pack\".1.00 Razor setting.,.0.50'* 6.Article 109 will be replaced by the following: \"109.In Cowansville, barbers shall take their week of vacation on the following dates: South shore, third week of July; North shore, fourth week of July.\" 7.Article 111 (Part Four) will Ik- replaced lithe following: \"111.Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the present part of the decree comprises the electoral districts of Saint-Jean.Iberville, Napierville, Laprairie and Missis«pie performed for the bride beyond the hours of the decree.In the event of mortality, hairdressing work may be performed for the family of the deceased beyond the hours «>t the decree with the approval of the Parity Committee.\" 9.Article 116 will be replaced by the following: \"116.Annual vacation with pay: Seven (\"i consecutive days of vacation with pay shall be given each year to regular employees during the period extending from June 1 to August 31.Employers shall let the employees know the date of their vacation at least six (6) weeks in advance.Vacation pay at the rate of 2% of the gross wages (wages and percentage) shall be paid to the employee before the vacation.Employees who have not one (1) year of service shall be entitled to 2% of the gross wages for the period they have worked.No employer shall replace the annual vacation with pay by a compensating indemnity. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March SI, 1962, Vol.94, So.IS 1799 Tout «alario a droit à un préavis de sept (7) jours lorsque l'employeur veut le congédier.De même, tout salarié oui veut quitter le service de son employeur doit donner un préavis couvrant la même période ».10° L'article 117 sera remplacé pur le suivant: « 117.Prix minima des services: Les employeurs -rofessionnels, les artisans et les salariés doivent charger au public les prix minima suivants pom les services ci-dessous mentionnés: Coupe de cheveux.$1.00 Ondulation permanente: Ordinaire.6.00 Sachets chimiques.6.00 À froid.6.00 Mèche individuelle.0.25 Shampooing.0.50 Itepeignage des cheveux à sec.0.50 Massage facial.1.50 Traitement du cuir chevelu.1.50 Décoloration.3.00 Décapage.3.00 Shampooing teinture (avec mise en plis).4 00 Teinture.5.00 Rinçage nuanceur.0.50 Rinçage colorant.2 00 Manucure.1.00 Epilation des sourcils.0.75» 11° L'article 118 sera remplacé par le suivant: « 118.Prorate dee apprentie: Il doit y avoir en service régulier et permanent un coiffeur poui dames qualifié dans chaque salon de coiffure et une manucure-esthéticienne qualifiée dans chaque salon de beauté.Pour être admise à l'apprentissage, toute personne doit avoir 16 ans révolus et pas plus de 30 ans ».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendements.L'arrté e conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections en double copie, si possible, que les intéressés pourront désirer formuler.Le Soue-minietre du Travail, Gérard Tremblay.Ministère du Travail, Québec, le 31 mars 1962.60830-o Every regular employee is entitled to a notice of seven (7) days in the event of his dismissal by the employer.Also, every employee who wishes to leave his employer shall give a similar notice.\" 10.Article 117 will be replaced by the following: \"117.Minimum pricee of services: Professional employers, artisans and employees shall charge the following minimum prices for the services hereunder enumerated : Haircut.$1.00 Permanent wave: Ordinary.6.00 Chemical pads.6.00 Cold wave.6.00 Single curls.0.25 Shampoo.0.50 Dry recombing.0.50 Facial massage.1.50 Scalp treatment.1.50 Bleaching.3.00 Dye removing.3.00 Tint shampoo (with finger waves).4.00 Dyeing.5.00 Tinting rinse.0.50 Colouring rinse.2.00 Manicure.1.00 Depilut ion of eyebrows.0.75\" 11.Article 118 will be replaced by the following: \"118.Prorata of apprenticee: There shall be in regular and permanent service one certificated ladies' hairdresser in each hairdressing parlor and one certificated manicure-aesthetician in each beauty parlor.To be admitted to apprenticeship, every person shall be at least 16 years old and not more than 30 years old.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections, in duplicate,-if possible, which the interested parties may wish to set forth.Gerard Tremblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 31.1962.60830 Action en séparation de biens Baden vs Rackham Canada, province de Québec, district de Montreal, Cour Supérieure, No 564413.Dame Teresa Baden, épouse commune en biens de Kenneth Conrad Rackham, de ht cité de Pointe-Claire, district de Montréal, demanderesse ve Kenneth Conrad Rackham, de Pointe-Claire, district de Montréal, défendeur.Action for separation as to property Baden rs Rackham Canada, Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.564413.Dame Teresa Baden, wife common as to property of Kenneth Conrad Rackham, of the city of Pointe-Claire, district of Montreal, plaintiff, re Kenneth Conrad Rackham, of Pointe-Claire, district of Montreal, defendant. 1800 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI mare 1962, Tome 94.No 13 Action en séparation de bien» Une action en séparation de biens a été intentée en cette cause, le 12e jour de mars 1062.Montréal, ce 10 de mars 1962.Le Procureur de la demanderesse.Me Allan B.Fhank.4 est, rue Notre-Dame, Suite 705, Montréal, P.Q.00829 Action for separation as to property An action in separation as to property has hi en instituted in this cause on the 12th day of Man!i, 1962.Montreal, March 19,1962.Me Allan B.F'rank, Attorney for the plaintiff.4, Notre-Dame Street East, Suite 705, Montreal, P.Q.60829- Arrêtés en Conseil Orders in Council Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 463 Section « F » Québec, le 20 mars 1962.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le droit de prélèvement du Comité Conjoint cles métiers de la construction de Montréal, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 723 du 17 mars 1961, section « H », soit prolongé jusqu'au 31 mai 1962, aux mêmes taux et conditions.Jacques Prémont, 60830-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Order in Council Executive Council Chamber Number 463 Section \"F\" Quebec, March 20, 1962.Present : The Lieutenant-Governor in Council Concerning an extension of the right to bvj of the Building Trades Joint Committee of Montreal.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour; That the right to levy of the Building Track h Joint Committee of Montreal, authorized by a by-law approved by Order in Council number 72.'i of March 17,1961, section \"H\", be extended until May 31,1962, with the same rates and conditions.Jacques Prémont, 00830-o Deputy Clerk of the Executive Council.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 463 Section e G » Québec, 20 mars 1962.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du décret relatif à l'industrie et aux métiers de la Construction dans la région de Montréal.\u2022 Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le décret numéro 309 (A) du 8 avril 1959 et amendements, relatif à l'industrie et aux métiers de la Construction dans la région de Montréal, soit prolongé jusqu'au 31 mai 1962.Jacques Prémont, 60830-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Order in Council Executive Council Chamber Numéro 463 Section \"G\" Quebec, March 20, 1962.Present: The Lieutenant-Governor in Council Concerning an extension of the duration of the decree relating to the construction industry and trades in the region of Montreal.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That decree number 309 (A) of April 8, 1959 and amendments, relating to the construction industry and trades in the region of Montreal be extended until May 31, 1962.Jacques Prémont, 00830-n Deputy Clerk of the Executive Council.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 463 Section e II t Québec-.20 mars 1962.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du décret relatif aux métiers de l'imprimerie dans la région de Montréal et du droit de prélèvement du Comité paritaire chargé d'en assurer l'observance.Il est ordonné ,sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Order in Council Executive Council Chamber Numéro 463 SselMfi \"II\" Quebec, March 20, 1962.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an extension of the decree and of the right to levy of the Printing Industry Parity Committee of Montreal and district entrusted with its enforcement.It id ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: QUKUEV OFFICIAL GAZETTE, March 31, 1962, Vol.94, No, 13 1H01 1° Que le décret numéro 3088 du 7 août 1940 et amendements, relatif aux métiers de l'imprimerie dans la région de Montréal soit de nouveau prolongé jusqu'au 10 août 1962.2° Q^je le droit de prélèvement du Comité paritaire de l'Imprimerie de Montréal et du dis.triet, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1196 (H) du 2 août 1960, soit prolongé de nouveau jusqu'au 10 août 1962.aux mêmes taux et conditions.Jacques Pkémont, i.0830-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.1.That the decree number 30K8 of August 7.1946 and amendments, relating to the printing trades in the region of Montreal, be again extended until August 10, 1962.2.That the right to levy assessments of the Printing Industry Parity Committee for Montreal and district, authorized by a by-law approved hv Order in Council number 1196 (H) of August 2, 1960, be again extended until August 10, 1962, with the same rate und conditions.Jacques Prémont, 60630-o Deputy Clerk of the Executive Council.Avis divers Miscellaneous Notices Ville d'Auteuil Règlement No 180 Règlement pour fixer à trois (3) ans, à compter des élections générales, la durée des fonctions du Maire et des six (G) Êchevins.Proposé par O.Paquette, appuyé par M.Turcot, et résolu unanimement.Attendu qu'il est à propos et dans l'intérêt de la ville et de ses contribuables que la durée des fonctions du Maire et des Echevins soit fixée à trois (3) ans à compter des prochaines élections devant être tenue le premier lundi juridique de novembre 1962; Attendu que la durée du terme du Maire et des Êchevins fixée à trois (3) ans, sera une garantie de stabilité de l'administration des affaires municipales de Ville d'Auteu il: Attendu que le conseil peut, par règlement, fixer un tel terme; Qu'il boit statué, ordonné, décrété et réglé par règlement du Conseil de la Ville et il est, par le présent règlement statué, ordonné, décrété et réglé, sujet à toutes les approbations requises par la Loi, comme suit: Article 1: Le conseil fixe à trois (3) ans, à compter des prochaines élections générales, la durée des fonctions du Maire et des Echevins.Article 11: Ledit règlement devra être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et être publié dans la Gazette officielle de Québec.Article III: Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.Le Secrétaire4réeorier de la Ville d'Auteuil, 60782-12-2-o Ronald Boubcier.Société Saint-Jean-Baptiste Locale de St-Luc-de-Vincennes Avis est donné que l'honorable secrétaire de la province a, le 27 février 1962, émis un certificat constituant en corporation la « Société Saint-Jean-Baptiste Locale de St-Luc-de-Vin-cennes s, dont le siège social est situé dans la paroisse de Snint-Luc-de-Vincennes, comté de Champlain, dans le district judiciaire de T rois-Rivières, et ce, conformément aux dispositions «les articles 15 et suivants de la Loi concernant la Société Saint-Jean-Baptiste de la région de Trois-Rivières, 3-4 Elizabeth II, chapitre 161.Donné au bureau du secrétaire de la province, le 1er mars 1962.Le Sous-secrétaire de la province, 60856-o Raymond Douville.Town of Auteuil By-law No.180 By-law to fix at three (3) years, from and after the general elections, the term-of office of the Mayor and the six (6) Aldermen.Proposed by O.Paquette, seconded by m.Turcot, and unanimously resolved.Wiierea8 it is expedient and in the interest of the Town and its taxpayers that the term of office of the Mayor and of the Aldermen be fixed at three (3) years from and after the following elections which are to take place on the first judicial Monday of November, 1962.Whereas the term office of the Mayor and the Aldermen fixed at three (3) years, will be a guarantee of the stability of the administration of municipal affairs of the Town of Auteuil; Whereas the Council may, by by-law, fix such a term: Be it adjudicated, ordained, decreed and ordered, by by-law of the council of the Town, and it is by the present by-law adjudicated, ordained, decreed and ordered, subject to all the approvals required by law, as follows: Section I: The council does hereby fix at three (3) years, from and after the following general elections, the term of office of the Mayor and Aldermen.Section II: The said by-law must be approved by the Lieutenant-Governor in Council and be published in the Quebec Official Gazette.Section III: The present by-law will enter into force according to law.Ronald Bourcier, Secretary-Treasurer 60782-12-2 of the Town of Auteuil.Société Saint-Jean-Baptiste Locale de St-Luc-de-Vincennes Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has, on February 27, 1962, issued a certificate incorporating the \"Société Saint-Jean-Baptiste Locale de St-Luc-de-Vincennes\", the head office of which is situated in the parish of Saint-Luc-de-Vincennes, county of Champlain, in the judicial district of Trois-Rivières, and such, pursuant to the provisions of sections 15 and those following of the act respecting the \"Société Saint-Jean-Baptiste «le la région de Trois-Rivières\", 3-4 Elizabeth II, chapter 161.Given at the office of the Provincial Secretary on March 1, 1962.Raymond Douville, 60856 Assistant Secretary of the Province. 1802 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 81 mars 1962, Tome 94, Xo 1S Ville d'Auteuil Règlement Xo 181 Règlement pour fixer la «late des prochaines élections au 1er lundi de novembre 1062 dans la municipalité de ville d'Auteuil.Proposé |>ar O.Paquette, appuyé par A.Nad on.et résolu à l'unanimité.Attendu que le Conseil de Ville d'Auteuil peut, par règlement adopté à la majorité absolue de ses membres ales, décréter que l'élection générale du Maire et des êchevins de la municipalité aura lieu le 1er lundi juridique «le novembre 1962; Attendu qu'il est à propos et dans l'intérêt général «le la ville et «le ses contribuables électeurs que lesdites élections générales prochaines soient fixées au 1er lundi juridique de novembre 1962; Attendu que le 1er lundi juridique «le novembre 1962, soit le 5 novembre, ne prolonge pas la durée des fonctions «lu Maire et des êchevins actuels; Qu'il soit statué, ordonné, «lécrété, et réglé par règlement du conseil de la ville et il est, par le présent règlement, statué, ordonné, décrété et réglé, sujet à toutes les approbations requises par la loi, comme suit: Article I.Le conseil de la ville est autorisé à fixer la date des prochaines élections au 1er lundi juridique de novembre 1962; Article II.he Ministre des Affaires Municipales devra approuver ledit règlement; Article III.Le présent règlement entrera en vigueur 6 mois après sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Article IV.Ise présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.lf its ratepaying electors that the said next general elections be fixed to the 1st juridical Monday in Novcml>er, 1902; Whereas on the 1st juridical Monday in November, 1962, that is Noveinlwr 5, does not extend the term «>f the duties of the present mayor and aldermen; That it be enacted, ordained, decreed and ruled by by-law of the council of the town and it is, by the present by-law, enacted, ordained, decreed and ruled, subject to all the approvals required by the law, as follows: Article I.The town council is authorized to fix the date of the next elections to the 1st juridical Monday in November, 1962; Article II.The Minister of Municipal Affairs shall approve the said by-law; Article III.The present by-law will enter into force 6 months after its publication in the Quebec Official Gazette.Article IV.The present by-law shall enter into force according to law.Adrien Dusbault, Mayor of the Town of d'Auteuil.Ronald Bourcier, 60847 Secretary-Treasurer.Parish of Sain t-Félix-du-Cap-Rouge The council of the parish of St-Félix-du-Cap-Rouge has agreed, in principle, to the incorporation into a town of the municipality.The name of the planned municipality will be \"Town of Cap-Rouge\".The territory of the planned municipality will be the following: \"All the present territory of the municipality of St-Félix-du-Cap-Rouge, bounded on the southwest by the parish of St-Augustin, on the northwest by the said parish of St-Augustin and by the parish of Ancienne Lorette, on the northeast by the parish of Ste-Foy, and on the southeast by the center-line of the St.Lawrence River, including all the lots or parts of the original lots in the official cadaster of the parish of St-Félix-du-Cap-Rouge.registry division of Quebec, county of Quebec, also with all lot or lots now added or to be added, and the present and future subdivisions of these lots, as well as the roads, streets, lanes, railroad rights of way, rivers and water-ways or parts of the same lots on the beach or in deep water, the whole enclosed within the following boundaries, to wit: Starting at the point of intersection of the left bank of the St.Lawrence River with the southwest line of lot number 1 in the said cadaster, and thence, with reference to said cadaster, successively: the southwest line of lots 1 and 2; the northwest lines of lots 2, 3, 6, 7, 10,11,14, 15, 18, 19.22, 23, 26.27, 30.31, 168, 31-A, 40, 42, 46 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 31, 1962, Vol.94.So.13 jusqu'à l'axe du chemin public entre les lots 47 et 140; l'axe dudit chemin vers le nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 140; une ligne brisée limitant l'extrémité nord-ouest du lot 141; la ligne nord-ouest des lots 144 et 145; partie de la ligne sud-ouest du lot 148; Is ligne nord-ouest du lot 148; le prolongement de cette dernière jusqu'à l'axe de la Rivière du Cap-Rouge; ledit axe de la rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 150; la ligne nord-est des lots 150 «\u2022t 160 jusqu'au Ruisseau La Scie et en remontant .son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 151; une ligne brisée limitant au nord-est le lot 151; la ligne nord-est des lots 152 et 170 et son prolongement à travers le chemin Ste-Foy; la ligne nord-est et partie de la ligne sud-est du lot 153; la ligne nord-est du lot 164 et son prolongement à travers le chemin St-Louis; ht ligne nord-est des lots 165, 168, 161-A et 161; cette dernière prolongée jusqu'à l'axe du Fleuve St-Laurent; cedit axe en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest audit lot numéro 1 et enfin, ce dentier prolongement jusqu'au dit point de départ.» Le chiffre de la population, tel que constituée par le recensement ordonné par le conseil, est de 1,674 Ames.La municipalité sera érigée en ville en vertu des dispositions de la Loi des cités et villes.Donné à St-Félix-du-Cap-Rouge, ce 26 janvier 1962.Le Secrétaire-trésorier, 60859-13-2-0 Alph.Gaboury.Ville de Beauport Avis public est par les présentes donné que la Ville de Beauport, ayant une population de plus de 10,000 âmes, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d'obtenir des lettres patentes érigeant son territoire municipal actuel en municipalité de cité sous le nom de Cité de Beauport, le tout conformément à la Loi des cités et villes.Le Secrétaire4résorier, 60892-13-2-o (S) Georges E.Boutet.Bills \u2014 Assemblée législative Chambre du Conseil législatif Québec, 21 mars 1962.Aujourd'hui, à cinq heures et quinze minutes de l'après-midi, l'honorable lieutenant-gouverneur s'est rendu à la chambre du Conseil législatif au Palais législatif.Les membres du Conseil législatif étant assemblés, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur d'y faire requérir la présence de l'Assembée législative et, cette chambre s'y étant rendue, le greffier de la couronne en chancellerie a lu les titres des bills à être sanctionnés comme suit: 99 Loi modifiant la Loi du Barreau.110 Loi concernant la Corporation des psychologues de la province de Québec.119 Loi changeant le nom de Zdenek Podskalsky en celui de Denis Podskalsky Dennis.i Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.» and 47, as far as the center-line of the public road between lots 47 and 140; the center-line of said road towards the northwest as far as the extension of the northwest line of lot 140; a broken line bordering on the northwest extremity of lot 141 ; the northwest line of lots 144 and 145; part of the southwest line of lot 148; the northwest line of lot 148; the extension of the latter as far as the center-line of the Cap-Rouge River; the said center-line of the river following its course as far as the extension of the northeast liue of lot 150; the northeast line of lots 150 and 169 as far as La Scie Brook and following its course as far as the extension of the northeast line of lot 151; a broken line bordering on the northeast of lot 151; the mort beast line of lots 152 and 170 and its extension across Ste-Foy Road; the northeast line and part of the southeast line of lot 153; the northeast line of lot 164 and its extension across St.Louis Road; the northeast line of lots 165,168,161-A and 161 ; the latter extended as far as the center-line of the St.Lawrence River; the said center-line following its course as far as the extension of the southwest line of said lot number 1, and, finally, the latter extended as far as the said starting point.\" The population, as stated in the census ordered by the council, numbers 1,674 souls.The municipality will be erected into a town in accordance with the provisions of the Cities and Towns Act.Given at St-Félix-du-Cap-Rouge, on January 26, 1962.Alph.Gabouhy, 60859-13-2 Secretary-Treasurer.Town of Beauport Public notice is hereby given that the Town of Beauport, having a population of more than 10,000 souls, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the purpose of obtaining letters patent erecting its present municipal territory into a city municipality under the name of \"Cité de Beauport\", the whole pursuant to the Cities and Towns Act.(S) Georges E.Boutet, 60892-13-2 Secretary-Treasurer.Bills \u2014 Legislative Assembly Legislative Council Chamber Quebec, 21st March, 1962.This day, at fifteen minutes past five o'clock in the afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor proceeded to the Legislative Council Chamber, in the Legislative Building.The members of the Legislative Council being assembled, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to command the attendance of the Legislative Assembly, and that House being present the Clerk of the Crown in Chancery read the titles of the bills to be sanctioned as follows: 99 An Act to amend the Bar Act.110 An Act respecting the Corporation of psychologists of the Province fo Quebec.119 An Act to change the name of Zdenek Podskalsky to that of Denis Podskalsky Dennis.\"In Her Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor assents to these bills.\" . 1N04 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SI mars 1962, Tome 94, Sfi IS 26 Ixii octroyant à Sa Majesté «les deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1963 et pour d'autres 6ns du servit* public.À ce bill, la sanction royale a été donnée dans les termes suivants: « Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur remercie ses fidèles sujets, agrée leur benevolence et sanctionne ce bill.» 60843-o 26 An Act granting to Her Majesty mon.\\ .required for the expenses of the Government for the financial year ending on tlx 31st of March 1963, and for other purposes connecte»! with the public service.To this bill the Royal assent was signified m the following words: \"In Her Majesty's name the Honourable the Lieutenant-Governor thanks her loyal subjects accepts their benevolence and assents to tin.bill.\" 60843-o Compagnies autorisées à faire des affaires Companies Licensed to do Business Great Lakes Investment Co.Limited Avis est donné que la compagnie « Great Lakes Investment Co.Limited », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de la province d'Ontario, a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des Sociétés de Prêts et de Placements, S.R.Q., 1941, chapitre 288.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province sera établi à 901, carré Victoria, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre elle est M.Donald James Johnston, avocat, de ladite cité de Montréal.Montréal, P.Q., ce 7e jour de mars 1962.L'Agent principal, 60652-10-4 Donald Jamks Johnston.Union Finance Company Limited Avis est donné qu'une autorisation a été accordée, en date du 14 février 1962, à la compagnie « Union Finance Company Limited », conformément aux dispositions de la Loi des sociétés de prêts et de placements, autorisant ladite compagnie à exercer son commerce dans la province de Québec.Daté a Montréal, P.Q., ce Se jour de mars 1962.L'Agent principal, 60713-11-4 M.G.Angus.Great Lakes Investment Co.Limited Notice is hereby given that \"Great Lakes Investment Co.Limited\", a corporation incorpo rated under the Companies Act of the Province of Ontario, has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Loan and Investment Societies Act.R.S.Q.1941, chapter 288.The principal office of the said company in the province is to be established at 901, Victoria Square, in the city and judicial district of Mont real.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.Donald James Johnston, advocate, of the said city of Montreal.Montreal, P.Q., this 7th day of March, 1962 Donald James Johnston, 60652-10-4-o Chief Agent Union Finance Company Limited Notice is hereby given that a licence has been granted under date of February 14, 1962 to \"Union Finance Company Limited\", pursuant to the provisions of the Loan and Investment Societies Act authorizing the said company to carry on business in the Province of Quebec-Dated at Montreal, P.Q.this 8th day of March.1962.M.G.Angus, 60713-1 l-4-o Chief Agent.Talisman Mines Limited Avis est donné que la compagnie « Talisman Mines Limited », a été autorisée à vendre ou autrement aliéner dans la province de Québec, ses actions, titres, certificats-actions, obligations et autres valeurs.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre ladite compagnie, est M.J.Austin Murphy, en., de 132 ouest, rue St-Jacques, en la cité de Montréal.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province sera établi à 132 ouest, rue St-Jacques, en ladite cité et dans le district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 26e jour de mars 1962.l*e Soue-secrétaire de la province, Raymond Douville.00808 2-02- 1119/14 Talisman Mines Limited Notice is hereby given tliat \"Talisman Mines Limited\", has been authorized to sell or otherwise alienate in the Province of Quebec its shares, stocks, stock-certificates, debentures and other securities.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the said company is Mr.J.Austin Murphy, q.c, of 132 St.James Street West, in the city of Montreal.The principal office of the said company in the Province is to be established at 132 St.James Street West, in the said city and in tin-judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of March, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808-o 2-62\u20141119/14 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 31, 11)62.Vol.94.A'o.13 1805 St.Louis Terminal Field Warehouse Company Avis est donné que la compagnie « St.Louis 1 r nn i nul F ii'M Warehouse Company », une com-I .ignie à fonds social étrangère constituée en rporation en vertu des lois de l'État de Mis-xiuri, EU.A., a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, Statuts refondus de (Juéhec, 1941, chapitre 279.L'agent principal, aux fins de recevoir les -i«nations dans les procédures exercées contre dite compagnie est M.W.H.Laidley, de ¦ ambre 300,455 ouest, rue Craig, en la cité de Montréal.i .i' bureau principal de ladite compagnie dans la province sera établi à chambre 300,455 ouest, rue Craig, en ladite cité et dans le district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, e 26e jour de mars 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.-DS08 19-62 \u2014 1119/21 St.Louis Terminal Field Warehouse Company Notice is hereby given that \"St.Louis Terminal Field Warehouse Company\", an extra-provincial company incorporated in virtue of the laws of the State of Missouri, U.S.A., has l>een licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 279.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the said company is Mr.W.II.Laidley, of Room 300, 455 Craig Street West, in the city of Montreal.The principal office of the said company in the Province is to be established at Room 300, 455 Craig Street West, in the said city and in the judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of March, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60808-o 19-62 \u2014 1119/21 Chartes \u2014 Abandon de Whirl O Wash Inc.Avis est donné que \u2022 Whirl O Wash Inc.», incorporé sous la Loi des compagnies de Québec, d< mandera la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de ladite Loi.Montréal, le 20 mars 1962.Le Secrétaire-trésorier, tr>si5-o E.G.Caldbick.Par col Inc.Prenez avis que la compagnie « Par col Inc.», corps politique dûment incorporé sous la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social d:ms la cité de Montréal, demandera au Procureur-Général de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, suivant les dispositions de ht Loi des compagnies.Montréal, ce 22e jour de mars, 1962.Le Secrétaire, i .0821-0 Guy Gagnon.Art & Music Inc.Avis est donné que « Art & Music Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi ee pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, P.Q.26 mars 1962.Is Secrétaire, 60850 I« P.Saroirin.Evans Realty Co.Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Evans Realty Co.Ltd.» demandera au Procureur (îénéral de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 23 mars 1962.Is Secrétaire adjoint, 60851-o Erskine Buchanan.G.& B.Construction Ltd.Avis est donné que la compagnie « G.& B.Construction Ltd.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, s'adressera au Procureur Général «le la province de Québec pour l'abandon «le sa charte.Montréal, 23 mars 1962.Le Procureur du requérant, 60852 Blanka Gyulai.Gauthier, Mure bison Ltée Avis est par les présentes donné que « Gauthier, Murchison Ltée », une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies «le Québec, ayant son siège social à Ste-Agathe des Monts, s'atlressera au secrétaire de la Province «le Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément à la Loi des Compagnie de Québec.Les Procureurs de Gauthier, Murchison iÂée, 60853-o Duquette & Godard.Barnabe Automobiles Limited Please take notice that \"Barnabe Automobile» Limited\" will apply to the Genera) Attorney for leave for permission to surrender its charter plnard & plnard, Attorneys for 60849-o \"Barnabe AuUnnolnles Limited\".Chantccler Ski Tows Inc.Notice is hereby given that \"Ckanteeler Ski Tows Inc.\" will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec, f«»r leave to surrender its charter.Montreal, P.Q., March 26, 1902.1.P.Sakouhin, 60850-o Secretary.E\\ans Realty Co.Ltd.Notice is hereby given that \"Evans Realty Co.Ltd.\" will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Montreal.March 23, 1962.Erskink Buchanan, 00851-o Assistant Secretary.G.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.