Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 août 1959, samedi 1 (no 31)
[" Tome 91, N° 31 3015 Vol.91, No.31 i Jrapeau de la province de Québec adopté par I\\Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 1er août 1959 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1959.Québec, le 20 juin 1959.L'Imprimeur de la Reine, 50831-25-1 l-o RÊDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, August 1st, 1959 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1959.Quebec, June 20th.1959.REDEMFri PARADIS, 50831-25-11-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.i 3.Specify the number of insertions.\u2022 4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 3016 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est.comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: 81 la douzaine.Abonnement : S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMF1T PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502 \u2014 l-52-o Lettres patentes (P.G.11618-59) Aber Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la lx>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mars 1959, constituant en corporation: Max S.Kaufman, Joseph Roy Hoffman et Oscar Respitz, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et développement, sous le nom de \"Aber Development Corp.\", avec un capital total de will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edit ion.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties arc requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1 per dozen.Subscriptions: 87 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once arc followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502 \u2014 l-52-o Letters Patent (A.G.11618-59) Abcr Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of March, 1959, incorporating: Max S.Kaufman, Joseph Roy Hoffman and Oscar Rcspitz, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and developement company, under the name of \"Aber Development Corp.\", with a total capital QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.August 1st, 1959, Vol.91, No.31 3017 s 10.000, divisé on 30 actions ordinaires de S100 chacune et 370 actions privilégiées de $100 chacune.Ix' siège social de la compagnie sera à Montréal district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12252-59) Acme land Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept* avril 1059, constituant en corporation: Luc Geoffroy, de Chambly, Robert Dulube, de Dorion, et Robert-V.Lanthicr, de Ste-Rose, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de \"Acme Land Holdings Ltd.\", avec un capital-actions 'divisé en 100 actions sans valeur nominale ou pair, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $500.Ia' siège social de la compagnie sera 1771 rue Lacombe, Montréal, district judiciaire de Montréal.' Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant -procu reu r général suppléant.51113 P.FRENETTE.stock of 840.000, divided into 30 common shares of S100 each and 370 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the oflice of the Attorney General, this twenty-fourth day of March, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(AG.12252-59) Acme Land Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of April, 1959, incorporating: Luc Geoffroy, of Chambly, Robert Du hide, of Dorion, and Robert-Y.Lanthier, of Ste Rose, all lawyers, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Acme Land Holdings Ltd.\", with a capital stock divided into 100 shares having no nominal or par value, and the amount witli which the company will commence its operations will be 8500.The head office of the company will be at 4771 Lacombe Street.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the \"office of the Attorney General, this seventeenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12516-58) Albeel Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1959, constituant en corporation: Alilton W.Winston, notaire, de Côte St-Luc, Ann D.ruzin, secrétaire, fille majeure, de Longueuil.et Isidore J.('harness, avocat de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements sous le nom de \"Albeel Investment Corp.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4 est rue Notre-Dame chambre 504 Montréal district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(A.G.12510-59) Albeel Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of April 1959, incorporating: Milton W.Winston, notary, of Côte St.Luc, Ann Druzin, secretary, spinster, of Longueuil, and Isidore J.('harness, advocate, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Albeel Investment Corp.\", with a total capital stock of 810.000, divided into 100 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at 4 Notre-Dame Street East, Room 504, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12494-59) Aljon Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept avril 1959, constituant en corporation: Louis Orcnstein, avocat, Alan Golden, gérant, tous deux de Outremont, et Huguette St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de Ile Pcrrot, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom de \"Aljon Realty Corporation\", avec un capital total de (A.G.12494-59) Ai/on Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April, 1959, incorporating: Louis Orenstein, advocate, Alan Golden, manager, both of Outremont, and Huguette St-Marseille, secretary, fille majeure, of lie Perrot, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Aljon Realty Corporation\", with a total capital stock 3018 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 $10,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $1 chacune et S.OOO actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept avril 1959.L'Assistant procureur-général suppléant, 51113 P.FRENETTK.of $10,000, divided into 2,000 common shares of $1 each and 8,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12490-59) Alexandra Apparel Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I*oi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept avril 1959, constituant en corporation: Michael Garber, conseil en loi de la Heine, Harry Yohalem Garber, tous deux de Wostinount, et Jacob Harold Blumenstein, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Fabriquer, exercer le négoce ou le commerce de vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"Alexandra Apparel Co.Inc.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont real, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTK.(A.G.12490-59) Alexandra Apparel Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April, 1959.incorporating: Michael Garber, Queen's Counsel, Harry Yohalem Garber, both of Westmount, and Jacob Harold Blumenstein, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in or with wearing apparel of all kinds, under the name of \"Alexandra Apparel Co.Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 1,000 common shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12502-59) Alpha Realties (Chambly) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation: Ben Shectcr, Michael Awada, avocats, et Margaret McMartin.commis, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction et placement, sous le nom de \"Alpha Realties (Chambly) Inc.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 1,000 actions d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5757 avenue Dccclles, suite 114, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12502-59) Alpha Realties (Chambly) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1959, incorporating: Ben Scliccter, Michael Awada, advocates, and Margaret McMartin, clerk, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Alpha Realties (Chambly) Inc.\", with a total capital stock of $5.000, divided into 1,000 shares of a par value of $5 each.The head office of I he company will be at 5757 Dccelles Avenue, Suite 114, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-ninth dav of April, 1959.P.FRENETTE.51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12263-59) American Holdings Corp.Avis est donné (pi'en vertu de la première partie de la \\aà des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize avril 1959, constituant en corporation: Daniel Kingstone, Samuel Godinsky, avocats, et Katherine Ingledew, sténographe, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'agents d'immeubles et courtiers en immeubles, sous le nom de \"American Holdings Corp.\", avec un capital total de $5.000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, i district judiciaire de Montréal.(A.G.12263-59) American Holdings Corp.Notice is hereby given that under Part 'I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of April, 1959, incorporating: Daniel King-stone, Samuel Godinsky, advocates, and Katherine Ingledew, stenographer, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the business of real estate agents and real estate brokers, under the name of \"American Holdings Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.81 3019 Daté du bureau du Procureur général, le seize Dated at the office of the Attorney General, avril 1959.this sixteenth day of April, 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.P.FRENETTE, 51113 P.FRENETTE.51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12228-59) A.M.S.Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze avril 1959, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Max Teitel-baum, tous trois avocats, de Montréal, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure, d'Outremont.pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de construction générale et d'immeubles, sous le nom de \"A.M.S.Investment Corp.\", avec un capital total de §10,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5105 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTK.(A.G.12228-59) A.M.S.Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of April, 1959, incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Max Teitelbaum, all three advocates, of Montreal, and Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, of Outremont, for the following purposes: To operate as a general construction and real estate company, under the name of \"A.M.S.Investment Corp.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of a par value of 810 each and 900 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at 5165 Sherbrooke Street West.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12096-59) Antares Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du (piatorze avril 1959, constituant en corporation : Joseph Cohen, comptable, Joseph H.Freedman, avocat, et Dorothy Oliver, veuve, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux et.constructeurs, sous le nom de \"Antares Development Corporation\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de 810 chacune et 3,600 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1449 rue St-Alexandre.chambre 900, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le (piatorze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12096-59) Antares Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of April 1959, incorporating: Joseph Cohen, accountant, Joseph H.Freedman, advocate, and Dorothy Oliver, widow, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors and builders, under the name of \"Antares Development Corporation\", with a total capital stock of 840.000, divided into 400 common shares of S10 each and 3,600 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at 1449 St.Alexander Street, room 900.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of April, 1959.P.FRENETTE.51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12512-59) A.P.Dupuis Construction Ltéc A.P.Dupuis Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a é'té accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1959, constituant en corporation: Achille Dupuis, entrepreneur général, Alexandrina Lamarche, ménagère, épouse séparée de biens dudit Achille Dupuis, et Michel Côté, avocat, tous de Rosemère, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"A.P.Dupuis Construction Ltée \u2014 A.P.Dupuis Construction Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions communes de (A.G.12512-59) A.P.Dupuis Construction Ltée A.P.Dupuis Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of April, 1959, incorporating: Achille Dupuis, general contarctor, Alexandrina Lamarche, housewife, wife separate as to property of the said Achille Dupuis.and Michel Côté, advocate, all of Rosemere, for the following purposes: To operate a business as builders and general building contractors, under the name of \"A.P.Dupuis Construction Ltée \u2014 A.P.Dupuis Construction Ltd.\", with a total capital stock of 840,000.divided into 200 common shares of 8100 3020 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 81 $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 231, rue Corona, Rosemère, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51I13-0 P.FRENETTE.(P.G.12201-59) A.Pfefer Realty Inc.Avis est donné qu'en vertifTîe la première partie de la lx>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize avril 1959, constituant en corporation: Murray Lapin, de la ville de Hampstead, Alan IL Gold et Morris M.Weincr, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction et de placement, sous le nom de \"A.Pfefer Realty Inc.\", avec un capital total de $10,000, divise en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4393 avenue Mardi, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize avril 1959.L'Assistant-procureur-général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12564-59) Aqua Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation: Allan Colton, fabricant, Abe Arick, agent d'immeuble, et Manuel Sachs, comptable agréé, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, amélioration et construction, sous le nom de \"Aqua Investment Corp.\", avec un capital total de SI0.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant -procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.12515-59) Arizona Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1959, constituant en corporation: Philip F.Vineherg, Melvin Rothman, tous deux de Westmount, Godfroy Marin, de Pointe-Claire, tous trois, avocats, et Dorothea Calver, secréiaire, fillem ajeure, de Montréal, pour les objets suivants: Acheter ou autrement acquérir et détenir, posséder, y construire et développer des propriétés immobilières et biens fonciers aux fins de placements, et agir comme bailleurs et administrateurs relativement à iceux.sous le nom de \"Arizona each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 231 Corona Street, Rosemere, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12261-59) A.Pfefer Realty Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec-, bearing date the sixteenth day of April, 1959, incorporating: Murray Lapin, of the town of Hampstead, Alan B.Gold and Morris M.Weincr, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"A.Pfefer Realtv Inc.\", with a total capital stock of $10,000,\" divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at 4393 Marcil Avenue.Montréal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 5113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12564-59) Aqua Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1959, incorporating: Allan Colton, manufacturer, Abe Arick, realtor, and Manuel Sachs, chartered accountant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, improvement and construction company, under the name of \"Aqua Investment Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1.000 common shares of $1 each and 900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-ninth dav of April, 1959.P.FRENETTE.51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12515-59) Arizona Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of April.1959, incorporating: Philip F.Vineberg.Melvin Rothman, both of West-mount, Godfroy Marin, of Pointe-Claire, all three advocates, and Dorothea Calver, secretary, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on, and develop immoveable property and real estate for investment purposes, and to act as lessors and administrators in connection therewith, under the name of \"Arizona Invest- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 19Ô9, Vol.91.No.31 3021 Investments Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4.000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.ments Ltd.\", with a total stock of $40.000.divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of th?company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-eighth day of April, 1959.P.FRENETTE, 5U13-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12124-59) Astor Realties Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze avril 1959, constituant en corporation: Isidore Grcenbnum, de la ville Côte St-Luc, Baruch Pollack, d'Outremont, tous deux avocats, et Milton Friefcld.comptable agréé, de Montréal, pour les objets suivants Exercer un commerce général de courtiers en immeubles, sous le nom de \"Astor Realties Corp.\", avec un capital total de $10.000, divisé en 5.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général.le quatorze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.10360-59) Atlas Brothers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt décembre 1958, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, Alan Golden, férant, tous deux d'Outremont, et Huguettc St-Iarseillc, secrétaire, fille majeure, de l'Ile Pcrrot, pour les objets suivants: Exercer le commerce de rouliers.camionneurs, et livraison de véhicules-moteurs, achat et vente de moteurs et pièces motorisées, agir comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Atlas Brothers Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 1,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11907-59) Baltic Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1959, constituant en corporation: Manuel Shacter, de Dorval, Leo Rosentveig, Stanley Taviss et William Levitt, tous trois de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de \"Baltic Investment Corp.\", avec un capital total de $20.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $1 chacune et 18,000 actions privilégiées de $1 chacune.(A.G.12124-59) Astor Realties Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Aet.letters jwitent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of April, 1959, incorporating: Isidore Grcen-baum, of the town of Côte St.Lue, Baruch Pollack, of Outremont, both advocates, and Milton Friefeld.chartered accountant, of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the business of Real Estate brokers, under the name of \"Astor Realties Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the eompany will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at theoffice of the Attorney General, this fourteenth dav of April.1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10360-59) Atlas Brothers Inc.Notice is hereby given that tinder Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of December, 1958, incorporating: Louis Orenstein, advocate, Alan Golden, manager, both of Outremont, and Huguctte St-Marseille, secretary, fille majeure, of lie Perrot, for the following purposes: To carry on business as carters, truckers, delivery of motor-vehicles; buying and selling of motor and automotive parts; to act as general contractors and builders, tinder the name of \"Atlas Brothers Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 500 common shares of $10 each and 1,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of December, 1958.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11967-59) Baltic Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of April, 1959, incorporating: Manuel Shacter, of Dorval, Leo Rosentzvcig, Stanley Taviss and William Levitt, all three of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Baltic Investment Cor]).\",\"with a total capital stock of $20,000.divided into 2,000 common shares of Si each and 18,000 preferred shares of Si each. 3022 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.11959-59) Basbros Realties In'c.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois avril 1959, constituant en corporation : Boris Garmaise, procureur, Honoria Sharpe, secrétaire, fille majeure, et Frank Kisbner.comptable, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Basbros Realties Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.12567-59) Beach Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation : Allan Colton, fabricant, Abe Arick, agent d'immeubles, et Manuel Sachs, comptable agréé, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Beach Investment Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et 900 privilégiées et $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTK.(P.G.12290-59) Ittaurock Land Development Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1959, constituant en corporation: Irving Halperin.Daniel Morris, avocats.Ernest Rashkovan, notaire, tous trois de Montréal, et Hyman Rosenfeld, notaire, de ville Mont-Royal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de \"Beaurock Land Development Co.\", avec un capital total de $20.000.divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune et 1,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1255 rue Université, chambre 912, Montréal district judiciaire de Montréal.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11959-59) Basbros Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of April, 1959, incorporating: Boris Garmaise, Attorney, Honoria Sharpe, secretary, spinster of full age of majority, and Frank Kishner, accountant, all of Montreal, for the following purposes To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Basbros Realties Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 10,000 commons hares of a par value of $1 each and 3,000 preferred shares of a par value of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of April.1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12567-59) Beach Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1959, incorporating: Allan Colton, manufacturer, Abe Ariek, realtor, and Manuel Sachs, chartered accountant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Beach Investment Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12290-59) Beaurock Land Development Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of April, 1959, incorporating: Irving Halperin, Daniel Morris, advocates, Ernest Rashkovan, notary, all three of Montreal, and Hyman Rosenfeld.notary, of the town of Mount Royal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Beaurock Land Development Co.\", with a total capital stock of $20,000.divided into 5.000 common shares of $1 each and 1,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 1255 University Street, Room 912, Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91.No.31 3023 Daté du bureau du Procureur général, le dix- Dated at the office of the Attorney General, sept avril 1959.this seventeenth day of April, 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE.51113 P.FRENETTE.51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12572-59) 15«derest Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix)i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente avril 1959, constituant en corporation: Gregory Charlap, Max Slapack and Arthur Shulman, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtiers, agents à commission et vendeurs d'immeubles, ainsi que celui d'une compagnie de placements, sous le nom «le \"Belcrest Development Corp.\", avec un capital total de §50,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 450 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 0277 chemin Deacon.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.11019-59) Bella Vista Investment Ltd.Avis est donné cpi'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mars 1959, constituant en corporation: Leo Rosentzveig, Stanley Taviss, et William Levitt, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Bella Vista Investment Ltd.\", avec un capital total (le $5,000, divisé en 5.000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12377-59) Bermac Textiles Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux avril 1959, constituant en corporation: Julius Kolomeir, Marchand.Rernard McNicholl, vendeur, Melvin Salmon, avocat, tous trois de Côte St-Luc et Moe Moscovitch.avocat, d'Outremont.pour les objets suivants: Fabriquer, exercer le commerce ou le négoce de toutes sortes de tissus et de leurs produits, sous le nom de \"Bermac Textiles Corp.\", avec un capital total de $40.000, divisé en 20.000 actions ordinaires de $1 chacune et 2.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12572-59) Belcrest Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April.1959, incorporating: Gregory Charlap, Max Slapack and Arthur Shulman, all advocates, of Montreal, for the following purposes : To carry on business as real estate brokers, commission agents and salesmen, as well as the business of an investment company, under the name of \"Belcrest Development Corp.\", with a total capital stock of $50.000.divided into 500 common shares of $10 each and 450 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 0277 Deacon Road, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at.the office of the Attorney General, this thirtieth day of April.1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G 11019-59) Bella Vista Investment Ltd.Notice is herehy given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of March, 1959, incorporating: Leo Rosentzveig, Stanley Taviss and William Levitt, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a realty and investment company, under the name of \"Bella Vista Investment Ltd.\".with a total capital stock of $5.000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of March, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12377-59) Bermac Textiles Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of April, 1959, incorporating: Julius Kolomeir, merchant, Bernard McNicholl, salesman, Melvin Salmon, advocate, all three of.Côte St.Luc.and Moe Moscotiveh, advocate, of Outremont, for the following purposes: To manufacture and deal in or with all kinds of fabrics and fabric products, under the name of \"Bermac Textiles Corp.\".with a total capital stock of $40,000.divided into 20,000 common shares of $1 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of April.1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy.Attorney General. 3024 GAZETTE OFF ICI ELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959.Tome 91, N° 31 (P.G.12222-59) Bois Filion Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été aceordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze avril 1959, constituant en corporation: Jack Spinner, fabricant, .lack Grecnstein, avocat, et Lillian Lazare, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom de \"Bois Filion Investments Ltd.\", avec un capital total de 310,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11890-59) Bruni Industries Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la \\m\\ des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mars 1959, constituant en corporation: Bram G.Besner, Moe Covshoff, gérants, et Anne Shapiro, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Diriger et exercer le commerce général qui consiste à fabriquer et faire le négoce de vêtements de toute description pour hommes, adolescents, garçons et enfants, sous le nom de \"Bram Industries Corp.\", avec un capital total de $40,000.divisé en 2.000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 15 ouest, rue Ontario.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mars \"1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12553-59) Brookland Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Irving I.Finkelberg, avocats, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Opérer comme une compagnie de construction et d'immeubles en général et transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Brookland Investment Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5105 ouest rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12222-59) Bois Filion Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of April, 1959, incorporating: Jack Spinner, manufacturer.Jack Greenstein, advocate, and Lillian Lazare, secretary, spinster of the /nil age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Bois Filion Investments Ltd.\", with a total capital stock of $10.000.divided into 100 common shares of a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11890-59) Bram Industries Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of March, 1959, incorporating: Brain G.Besner, Moe Covshoff, managers, and Ann Shapiro, secretary, spinster of full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To conduct and carry on generally the business of manufacturing and dealing with men's, youth's, boys' and infants' wearing apparel of every description, under the name of \"Bram Industries Cor]).\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.Hie head office of the company will be at 15 Ontario Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of March, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12553-59) Brookland Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1959, incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Irving I.Finkelberg, advocates, and Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To operate as a general construction and real estate company and to carry on the business of an investment company, under the name of \"Brookland Investment Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 5165 Sherbrooke Street West, Montreal, ' judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, So.31 3025 (P.G.11738-59) By-Frank Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieu tenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux avril 1959, constituant en corporation: Emiric Kaufman, gérant, Cecilia Kaufman, ménagère, épouse séparée de biens dudit Emeric Kaufman, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, Louis Frank, marchand et Margaret Frank, ménagère, épouse séparée de biens dudit Louis Frank et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer tous ou aucun des commerces de confectionneurs, tailleurs, drapiers, bonnetiers, marchands de modes, costumiers, chapeliers, gantiers, fourreurs, marchands de soieries, carpettes, coton, étoffes et dentelles, marchands, manufacturiers ou importateurs de vêtements, sous le nom de \"By-Frank Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera ai Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.11892-59) Camel Investment Corporation Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier avril 1959, constituant en corporation: Stanley Haltrecht, notaire, de St-Laurent, S.Bernard Haltrecht, notaire, et Moe Ackman, avocat, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, d'améliorations et de construction, sous le nom de \"Camel Investment Corporation\", avec un capital total de $5,000, divisé en 1,000 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12320-59) Canbrook Realties & Investments Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première, partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1959, constituant en corporation: Milton L.Klein, avocat, Iown Lanteigne.sténographe, épouse séparée de biens de Roger Lanteigne, tous deux de Montréal, et Lewis J.Manolson, comptable, agréé, de ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'agents et courtiers d'immeubles pour la vente de toutes sortes de propriétés immobilières commerciales, domiciliaires, urbaines et rurales, sous le nom de \"Can- (A.G.11738-59) By-Frank Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April, 1959, incorporating: Emeric Kaufman, manager, Cecilia Kaufman, housewife, wife separate as to property of the said Emeric Kaufman, and duly authorized by him for the purpose of the sepresents, Louis Frank, merchant, and Margaret Frank, housewife, wife separate as to property of the said Louis Frank, and duly authorized by him for the purpose of these presents, all of Montreal, for the following purposes: To carry on all or any of the business of clothiers, tailors, drapers, hosiers, milliners, costumiers, hatters, glovers, furriers, silks, carpets, cotton, cloth and lace merchants, wearing apparel merchants, or manufacturers or importers, under the name of \"By-Frank Inc.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3.000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11892-59) Camel Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of April, 1959, incorporating: Stanley Haltrecht, notary, of St.Laurent, S.Bernard Haltrecht, notary, and Moe Ackman, advocate, both of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, improvement and construction company, under the name of \"Camel Investment Corporation\", with a total capital stock of $5.000.divided into 1.000 shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12320-59) Canbrook Realties & Investments Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April 1959, incorporating: Milton L.Klein, advocate, Iown Lanteigne, stenographer, wife separate as to property of Roger Lanteigne, both of Montreal, and Lewis J.Manolson, chartered accountant, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on business as real estate agents and brokers for the sale of all kinds of immoveable property, commercial, housing, urban and rural, under the name of \"Canbrook Realties & Invest- 3026 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° SI brook Realties & Investments Corporation\", avec un capital total de $5,000, divisé en 50 actions ordinaires de $10 chacune et 450 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1959.L'Assistant-procurcur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12107-59) Carladan Investment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixii «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec «les lettres patentes, en date du seize avril 1959.constituant en c«)rporation: Jean-Paul Cardinal, conseil en loi de la Reine, Jacques-P.Dansereau, tous deux «le Montréal, et Marcel Lajeunesse, «le Westmount, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de \"Carladan Investment Ltd.\", avec un capital total de $10,000.divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $1 chacune.Ia* siège social i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1959, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, Alan Golden, gérant, tous deux de Outremont, et Huguette St-Mar-seille, secrétaire, fille majeure, de Ile Perrot, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom de \"Codab Realty Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et 90 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera a Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12720-59) Coigny Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1959, constituant en corporation: Gaston Pouliot, avocat, de Ville Mont-Royal, Louise Bourdon et Lucille Roy, secrétaires, célibataires, de Montréal, pour les objets suivants : Exercer les opérations d'une compagnie de portefeuille (\"holding\"), sous le nom de \"Coigny Inc.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions communes d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.11911-59) Continental Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1959, constituant en corporation: Max Sidney Kaufman, de Westmount, Joseph Roy Hoffman et Oscar Respitz, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires de mécaniciens et marchands de moteurs, machinerie, outils et instruments de toutes sortes so\\is le nom de \"Continental Industries Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.the name of \"Châtcaugay Commercial Center Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each ami 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General^ this seventeenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12302-59) Codah Realty Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April, 1959, incorporating: Louis Orenstein, advocate.Alan Golden, manager, both of Outremont, and Huguette St-Marseille, secretary, fille majeure, of lie Perrot, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Codab Realty Ltd.\", with a total capital stock of $10,000.divided into 100 common shares of $10 each and GO preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12720-59) Coigny Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1959, incorporating: Gaston Pouliot, advocate, of the town of Mount-Royal, Louise Bourdon and Lucille Roy, secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a holding company under the name of \"Coigny Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11911-59) Continental Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1959, incoiporating: Max Sidney Kaufman, of Westmount, Joseph Roy Hoffman and Oscar Respitz, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of mechanics and dealers in engines, machinery, tools and implements of all kinds, under the name of \"Continental Industries Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each. 3028 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 1er août 1909, Tome 91, N° 31 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.The head office of the company will be a t Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Général, this twentv-sixth dav of March, 1959.P.FRENETTE.51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12288-59) Crestline Developments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1959.constituant en corporation: John L.Liberman.Alfred N.Segall, Max Teitcl-baum.tous trois avocats, de Montréal, et Marilyn Denny, scer taire, fille majeure.d'Outremont, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de construction générale et de placement, sous le nom de \"('restline Developments Inc.\".avec un capital total de SI0.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5105 ouest rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11947-59) Dalfen Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux avril 1959.constituant en corporation: Robert Dalfen, Ben Dalfen.marchands, et Andrée Gélinas, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, et développement, sous le nom de \"Dalfen Investment Cor]).\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4774 avenue Meridian.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le deux-avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.13008-58) Dalfen's Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux juin.1959.constituant en corporation: William Patrick Crcagh, commis en droit, de ville Mont-Royal, Clifford George Meek, de Montréal, Charles Eric Humphrey, de Verdun, Guy Ambrose Miller, «le St-Bruno, tous trois teneurs de livres, John Lawrence McCrory et Theodore William Martison, tous «leux commis, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer toutes ou aucunes de leurs spécialités respectives les commerce de magasins à rayons (A.G.122SS-59) Crestline Developments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Licutcnant-G overnor of the Province of Quebec, bearing «late the seventeenth day of April, 1959, incorporating: John L.Liberman.Alfred N.Segall, Max Tcitelbaum, all three advocates, of Montreal, and Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, of Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a general construction and investment company, under the name of \"Crestline Developments Inc.\".with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shams of a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office «>f the company will be at 5105 Sherbrooke Street West.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this .seventeenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11947-59) Dalfen Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April, 1959, incorporating: Robert Dalfen, Ren Dalfen, merchants, and Andrée Gélinas, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and development company, under the name of \"Dalfen Investment Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3.000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 4774 Meridian Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13008-59) Dalfen's Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-second day of June, 1959, incorporating: William Patrick Creagh, law clerk, of the town of Mount Royal, Clifford George Meek, of Montreal, Charles Eric Humphrey, of Verdun, Guy Ambrose Miller, of St.Bruno, all three bookkeepers, John Lawrence McCory and Theodore William Martinson, both clerks, of Montreal, for the following purposes: To carry on in any or all of their respective branches the businesses of departmental and QUEBEC Oil ICI AL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959.Vol.91, No.31 3029 el surccursales multiples, sous lé nom de \"Dalfen's Limited\", avec un capital total de $2,000,000, divise en 1,000 actions, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de SI chacune et 1.999,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.I.e siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, .Ml 13 l\\ FRENETTE.(P.G.12436-59) Dragon Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a .lé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois avril 1959, constituant en corporation: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch, tous deux de Montréal, et Melvin Salmon.Côte St-Luc, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Dragon Development Corp.\", avec un capital total de $10,000.divisé en 2.000 actions ordinaires de $5 chacune et 3.000 actions privilégiées de.$10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal district judiciaire de Montréal.Daté du bureeu du Procureur général, le vingt-trois avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11292-59) Elberg Associates Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu dix avril 1959.constituant en corporation: Yehuda Elberg, administrateur, Debbie Cabirïs-ky, teneuse de livres, Katherine Ingledew, sténographe, toutes deux filles majeures, et Joseph Nuss, étudiant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Elberg Associates Ltd.\".avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Ix- siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12113-59) Elex Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze avril 1959, constituant en corporation: Samuel David Rudcnko, conseil en loi de la Heine, Roi lin Gallay, tous deux avocats, et Sarah Miller, sténographe, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Elex Corp.\", avec un chain stores, under the name of \"Dalfen's Limited\", with a total capital stcck of S2,000,000, divided into 1,000 Class \"A\" shares of a par value of SI each and 1.999.000 common shares of a par value of SI each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of June, 1959.V.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.124:10-59) Dragon Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of April, 1959, incorporating: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch.both of Montreal, and Melvin Salmon, of Côte St.Luc.all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Dragon Development Corp.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 2,000 common shares of S5 each and 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11292-59) Elberg Associates Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April, 1959, incorporating: Yehuda Elberg, executive.Debbie Cabinsky.bookkeeper, Katherine Ingledew, stenographer, both spinsters, and Joseph Nuss, student, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Elberg Associates Ltd.\".with a total capital stock of S40,000, divided into 3.000 preferred shares of a par value of $10 each and 1,000 common shares of a par value of $10 each.\u2022 The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12113-59) Elex Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of April, 1959, incorporating: Samuel David Rudenko, Queen's Counsel, Rollin Gallay, both advocates, and Sarah Miller, stenographer, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Elex Corp.\", with a 3030 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er aoitt 1959, Tome 91, N° 31 capital total de $1,500.divisé en 1,500 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12414-59) Km il Ispas Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois avril 1959, constituant en corporation: Norman C.Denys, avocat, de ville Mont-Royal, Françoise Matte de Outremont, et Aline Fiset de Montréal, toutes deux secrétaires, filles majeures, usant de leurs droits, pour les objets suivants: Exercer un commerce général de taxis, sous le nom de \"Emil Ispas Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 10 actions ordinaires de $100 chacune et 90 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera S040 avenue Wiseman Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.total eapital stock of $1,500, divided into 1,500 shares of $1 each.The head office of the company will Im» at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12414-59) Kmil Ispas Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of April 1959, incorporating: Norman C.Denys, attorney-at-law, of the town of Mount-Royal, Françoise Slat te, of Outremont, and Aline Fiset.of Montreal, both secretaries, spinsters using their rights, for the following purposes: To generally carry on a taxicab business, unde the name of \"Emil Ispas Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10 common shares of $100 each and 90 preferred shares of $100 each.The head o.-e of the company will be at 8040 Wiseman Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third dav of April.1959.* P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12272-59) Inline Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1959, constituant en corporation: Rasil Danchysbyn, Gabriel Glazer, étudiants en droit, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants : Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de 'Tmlac Realty Corp.\", avec un capital total de $5,000.divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1440 rue Towers, chambre 100, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12272-59) Inline Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of April 1959, incorporating: Basil Danchysbyn, Gabriel Glazer, law students, and Anne Zifkin.secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of 'Tmlac Realty Corp.\", with a total eapital stock of $5,000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at 1440 Towers Street, Room 100, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11938-59) Engora Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du deux avril 1959, constituant en corporation: Leo Rosentzveig, Stanley Taviss, tous deux de Montréal, et Manuel Shacter de Dorval, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et placements, sous le nom de \"Engora Realties Ltd.\", avec un capital total de $0,000.divisé en 0,000 actions ordinaires de $1 chacune.(A.G.11938-59) Engora Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April, 1959, incorporating: Leo Rosentzveig, Stanley Taviss, both of Montreal, and Manuel Shactcr, of Dorval, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a realty and investment company, under the name of \"Engora Realties Ltd.\", with a total capital stock of $0,000, divided into 6,000 common shares of $1 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.31 3031 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.12468-59) Erd Development Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt-quatre avril 1950, constituant en corporal ion: Nathan Levine, constructeur, Moszek Brzozak.fabricant, et Ben TJdashkin, marchand, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom «le \"Erd Development Inc.\".avec un capital total «le §10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4855 avenue Isabelle, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-quatre avril 1059.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12273-59) Esman Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du quinze avril 1959, constituant en corporation: Allan Marcus, avocat, Lucille Blagdon, secrétaire, épouse sépararée de biens dudit Pierre Blagdon, tous deux «le Montréal, et David Kirshcnblatt, avocat, de ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie de placement, sous le nom de \"Esman Investment Corporation\", avec un capital total de $30,000, divisé en 200 actions ordinaires «le $10 chacune et 280 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.12280-59) E.S.Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu seize avril 1959, constituant en corporation: Reuben Spector, avocat et conseil en loi de la Reine, de Westmount, Dov Kravetz, avocat, et Marilyn Bridgeman, secrétaire, épouse séparée de biens dudit Donald M.Bridgeman, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, d'amélioration et construction, sous le nom de \"E.S.Realties Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12468-59) Erd Development Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by ; he Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of April, 1959, incorporating: Nathan Levine, builder, Moszek Brzozak, manufacturer, and Ben Udashkin, merchant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Erd Development Inc.\", with a total capital stock of $10.000, divided into 1.000 shares of $10 each.The head ofhYe of the company will be at 4S55 Isabelle Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth dav of April.1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12273-59) Esman Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of April, 1959, incorporating: Allan Marcus, advocate, Lucille Blagdon, secretary, wife separate as to property of Pierre Blagdon, both of Montreal, and David Kirshenblatt, advocate, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Esman Investment Corporation\", with a total capital stock of $30,000, divided into 200 common shares of $10 each and 280 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of April.1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12280-59) E.S.Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of April, 1959, incorporating: Reuben Spector, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, Dov Kravetz, advocate, and Marilyn Bridgeman, secretary, wife separate as to property of Donald M.Bridgeman, both of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, improvement and construction company, under the name of \"E.S.Realties Inc.\", with a total capital stock of $10,000.divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 3032 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 81 Daté du bureau du Procureur général, seize avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12207-59) Eston Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en «late «lu seize avril 1959, constituant en corporation^ Samuel (\"liait, Maxwell Shenker, avocats, John Hamilton, secrétaire, tous trois de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de Côte St-Luc, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Eston Development Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires «le SI chacune et 30,000 actions privilégiées «le SI chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 1255 rue Université, suite 1012, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le seize avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11957-59) Estoril Development Corporation Avis est donné «pi'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en «late du six avril 1959, constituant en corporation: Harry L.Aronovitch, avocat, «le ville Côte St-Luc,'Samuel Chait, Maxwell Shenker, avocats, et John Hamilton, secrétaire, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie d'immeubles et développement, sous le nom de \"Estoril Development Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 1255 rue Université, suite 1012, Montréal district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le six avril 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11710-59) Ettingcr Enterprises Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf mars 1959, constituant en corporation: Leo Roscntzveig.William Levitt et Stanley Taviss, tous avocats, «le Montréal, pour les objets suivants : Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et placement, sous le nom de \"Ettingcr Enterprises Corp.\", avec un capital total de $5,000.divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12207-59) Eston Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of April, 1959, incorporating: Samuel Chait, Maxwell Shenker, advocates, John Hamilton, secretary, all three of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Eston Development Corporation\", withTTa total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each ami 30.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be£at Suite 1012, 1255 University Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11957-59) Estoril Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the sixth day of April, 1959, incorporating: Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte St.Luc.Samuel Chait, Maxwell Shenker, advocates, and John Hamilton, secretary, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and development company, under the name of \"Estoril Development Corporation\", with a total capital stock of $-10,000, divided into 4,000 common shares of SI each and 30.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Suite 1012, 1255 University Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of April.1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11710-59) Ettingcr Enterprises Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of March, 1959, incorporating: Leo Roscntzveig, William Levitt and Stanley Taviss, all advocates, of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of a realty and investment company, under the name of \"Ettinger Enterprises Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nieteenth day of March, 1949.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OF E ICI AL GAZETTE.Quebec.August 1st, 1959, Vol.91, No.SI 3033 (P.G.12400-59) Fumons Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a ('\u2022te accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en «late >lii vingt-sept avril 1959, constituant en corporation: Albert Malouf, Peter Shorteno, avocats, Lily Malouf, secrétaire, fille majeure, tous trois de ville Mont Royal, et Bruno Rateras, avocat, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom «le \"Famous Enterprises Lt«l.\".avec un capital total «le 8100,000, divisé en 200 actions ordinaires «le S100 chacune, 200 actions privilégiées catégorie \"A\" de SI00 chacune et 000 actions privilégiées catégorie \"R\" «le SI00 chacune.Ia: siège social «le la compagnie sera 7200 rue Hutchison suite 301, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12193-59) Foyer des Textiles Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec des lettres patentes, en date du dix-huit avril 1959.constituant en corporation: James Libcnstein, marchand, de la ville Côte St-i uc, Percy Libcnstein.Philip Shrague Garonce et Ilyman Laddic Schnaiberg, avocats, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer tous ou aucun des commerces «le marchands de vêtements, tailleurs, drapiers, bonnetiers, modistes, costumiers, chapeliers, gantiers, fourreurs, marchands de soies, tapis, coton, drap dentelles et articles vestimentaires, ou confectionneurs ou importateurs, sous le nom de \"foyer des Textiles Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12105-59) Frozen Specialties (Quebec) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze avril 1959, constituant en corporation: Yves Pratte, «le Sillery, Pierre Côte et Charles Tremblay, «le Québec, tous avocats, pour les objets suivants: Entreprendre et exercer le commerce qui consiste à traiter, mettre en voHes, conserver, congeler, emballer ou autrement préparer pour le marché et la consommation humaine «les légumes, fruits, petits fruits, viandes, grains, lait, et produits laitiers, épiceries et tous autres articles ou choses convenant à la consommation, sous le nom de \"Frozen Specialties (Quebec) (A.G.12400-59) Famous Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April, 1959, incorporating: Albert Malouf, Peter Shorteno, advocates, Lily Malouf, secretary, spinster of the full age of majority, all three «>f the town of Mount Royal, and Bruno Pateras, advocate, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, «leve-lopment and construction company, under the name of \"Famous Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 200 common shares of SI00 each, 200 Class \"A\" preferred shares of $100 each and 000 Class \"R\" preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at suite 301, 7200 Hutchison Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12193-59) Foyer des Textiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April.1959, incorporating: .lames Libcnstein, merchant, of the town of Côte St.Luc, Percy Libcnstein.Philip Shrague Garonce and Ilyman Laddie Schnaiberg, advocates, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on all «>r any of the business of clothiers, tailors, drapers, hosiers, milliners, costumiers, hatters, glovers, furriers, silks, carpets, cotton, cloth ami lace merchants, wearing apparel merchants, or manufacturers or importers, under the name of \"Foyer «les Textiles Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dateil at the office of the Attorney General, this tenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12105-59) Frozen Specialties (Quebec) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the fourteenth day of April.1959, incorporating: Yves Pratte, of Sillery, Pierre Côte and Charles Tremblay, of Quebec, all am de \"Héneault Transport Inc.\", avec un capital total «le $40,000, «livisé en 400 actions «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Victoire, district judiciaire «l'Arthabaska.Daté «lu bureau du Procureur général, le cinq juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.Corp:', with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at 1410 Towers Street, r«x)in 100.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13307-59) Héneault Transport Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the fifth day of June, 1959, incorporating: Gaston Héneault, taxi and autobus service proprietor, Géralda M.Héneault, housewife, wife common as to property of the said Gaston Héneault, and duly authorized by him for these present purposes, ami Jacques Roberge.accountant, all of Victoriaville.for the following purposes: To carry on one or more services dealing in autobuses and taxis, under the name of \"Héneault Transport Inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 400 shares of $100 each.The hea«l office of the company will be at Sainte-Victoire, judicial «listrict of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June.1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(P.G.-12278-59) Herald Developments Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en «late du seize avril 1959, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Max Teitelbaum, tous trois avocats, «le Montréal, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure.d'Outremont, pour les objets suivants: Transiger les affaires ' «l'une compagnie «le construction en général et de placement, sous le nom de \"Herald Developments Inc.\", avec Un capital total «le $10,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège soe\\al de la compagnie sera à 5165 tmest rue Sherbrooke, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12010-59) Hervé Thivierge Incorporée Hervé Thivierge Incorporated Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes, en «late du vingt et un mai 1959, constituant encorpora-tion: Clamle Thivierge, avocat.Mlle Roberte Smith, et Mlle Claire Bastien, secrétaires, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le courtiers et agents d assurances, sous le nom de \"Hervé Thivierge (A.G.12278-59) Herald Developments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of April, 1959, incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall.Max Teitelbaum, all three advocates, of Montreal, ami Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, of Outremont, for the following purposes: To carry on the business «>f a general construction and investment company, under the name of \"Herald Developments Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The hea«l office of the company will be at 5165 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12010-59) Hervé Thivierge Incorporée Hervé Thivierge Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1959, incorporating: Claude Thivierge, advocate, Miss Roberte Smith, and Miss Claire Rastien, secretaries, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as brokers ami insurance agents under the name of \"Hervé Thivierge 3036 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1059, Tome 91, N° 31 Incorporée \u2014 Hervé Thivierge Incorporated\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.1a; siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.12383-59) Ilolliu Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux avril 1959, constituant en corporation: Hilliard Ginsberg, avocat.Basil Danchy-sliyn, étudiant en droit, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Hollin Realty Corp.\", avec un capital total de $5,000 divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1440 rue Towers chambre 100, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt -«leux avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12195-59) Hubroc Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la \\a» «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du «lix avril 1959, constituant en corporation: Lionel Albert Sperber, avocat et conseil en loi de la Reine, Harry Segal, salesman, et Rita Segal, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie «le placement, sous le nom de \"Hubroc Inc.\", avec un capital total de $50.000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 4,500 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $10 chacune.\\aî siège social de la compagnie sera à Montréal district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le dix avril 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11855-59) Importations du Globe Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1959, constituant en corporation: Abraham Cohen, avocat, Claire Wilisky, secrétaire, fille majeure et usant «le ses «Iroits, et Marcel Gélinas, marchand, tous «le Montréal, pour les objets suivants: Commerce de souvenirs, jouets, disques, tourne-disques, livres, revues, colifichets, peintures et papeterie, sous le nom de \"Importations «lu Globe Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé* en 1.000 actions communes de 810 cha- Ineorporée \u2014 Hervé Thivierge Incorporated\", with a total capital stock of $20,000.divided into 200 shares of $100 each.The hea«l office «)f the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-first dav of Mav, 1959.P.FRENE'lTE.51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.123S3-59) I l«>l I in Really Corp.Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of April 1959, incorporating: Hilliard Ginsberg, advocate, Basil Danchyshyn, law student, and Anne Zifkin.secretary, spinster of the full age of majority, all «>f Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Hollin Realty Corp.\", with a total capital stock of $5.000.divided into 5,000 common shares «)f $1 each.The head office of the company will be at 1440 Towers Street, room 100, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the offù^e of the Attorney General, this twenty-second f April, 1959, incorpt>rating: Lionel Albert Sperber, a«lvocate ami Queen's Counsel, Harry Segal, salesman, and Rita Segal, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Hubroc Inc.\", with a total capital stock of $50,000.divided into 500 common shares «)f a par value of $10 each and 4.500 preferre»! shares of a par value of $10 each.The head office of tin- company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Datc«l at the office of the Attorney General, this tenth day of April, 1959.P.FRENE'lTE.51113-0 Acting Deputy Attorney ('encrai.(A.G.11855-59) Importations du Globe Inc.Notice is hereby given that tinder Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-second day of May, 1959, incorporating: Abraham Cohen, advocate, Claire Wilisky, secretary, spinster ami in use of her rights, ami Marcel Gélinas, merchant, all of Montreal, for the following purposes: ' To carry on a business dealing in souvenirs, toys, discs, record-players, books, reviews, trinkets, paintings ami stationery, under the name of \"Importations «lu Globe Inc.\", with a total capital stock of $20.000.divided into 1,000 QUEBEC, OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1059, Vol.91, No.-il 3037 ounc et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 72, rue Jean-Tlon, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTK.(P.G.13018-59) Industrial Form Work Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i (les compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date «lu «lix-neuf mai 1959, constituant en corporation: John J.Pepper, de Westmount, Jacques Lef April, 1959.P.FRENE'lTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11170-59) J.E.L'Allier & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1959.incorporating: Raoul L'Allier, Roméo L'Allier and Joseph-Emmanuel L'Allier, all manufacturers, of Montreal, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in articles and novelties used in the «liplay of merchandise in stores or other business establishments, under the name of \"J.E.L'Allier & Fils Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of May.1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12428-59) Jenalt Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.31 3030 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu vingt-deux avril 1959, constituant en corporation: Abraham Sinister, avocat, Nathaniel Lichman, notaire, et Carl Rosen, étudiant en droit, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de 'Menait Development Corp.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune 900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12150-59) Jeper Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu vingt avril 1959, constituant en corporation: Pearl Berger, avocat, Hyman Berger, instructeur, Rhoda Kowarsky, secrétaire, fille majeure, et Gérald Kowarsky, agent d'immeubles, tous de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de construction et d'immeubles, sous le nom de \"Jeper Holdings Ltd.\", avec un capital total de $10.000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.1113 P.FRENE'lTE.(P.G.122S3-59) Josan Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la \\m\\ des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1959, constituant en corporation: Murray Lapin, de la ville de Hampstead, Alan B.Gold et Morris M.Weiner, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et placements, sous le nom de \"Josan Investment Corp.\", avec un capital total de $1.000.divisé en 1.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 330 ouest, rue Guizot, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENE'lTE.(P.G.1209-1-59) July Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze avril 1959, constituant en corporation: Cari Pomerlian, comptable agréé, Albert (iomberg, avocat, tous deux de Montréal, et Solomon Neamtan, comptable agréé, de St-Laurent, pour les objets suivants: been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of April, 1959, incorporating: Abraham Sinister, advocate, Nathaniel Liebman, notary, and Carl Rosen, law student, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Jenalt Development ( 'orp.\", with a total capital stock «)f SlO.OOO.divided into 100 common shares of $10 each and 900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of April, 1959.P.FRENETTE.51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12150-59) Jeper Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April, 1959, incorporating: Pearl Berger, advocate, Hyman Berger, instructor.Rhoda Kowarky, secretary of the full age of majority, and Gerald Kowarsky, realtor, all of Montreal, for the following purposes: To operate as a general construction and real estate company, under the name of \"Jeper Holdings Ltd.\".with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of April, 1959.P.FRENETTE.51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.122S3-59) Josan Investment Corp.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quel ice Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of April, 1959, incorporating: Murray Lapin, of the town of Hampstead; Alan B.Gold and Morris M.Weiner.of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and investment company, under the name of \"Josan Investment Corp.\".with a total capital stock of $1,000.divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at 330 Guizot Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April.1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy At torney ( Jeneral.(A.G.12094-59) July Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of April, 1959, incorporating: Carl Pomerlian, chartered accountant, Albert Gomberg, advocate, both of Montreal, and Solomon Neamtan.chartered accountant, of St.Laurent, for the following purposes: 3040 GAZETTE OIE ICI ELLE DE QUÉBEC,1 Québec, 1er août 19Ô9, Tome 91, N°31 Exercer le commerce ski, de Pointe-aux-Trembles, tous deux nettoyeurs, Mlle Janet Paproski.sténographe, fille majeur»', de Pointe-aux-Trembles, et Alexander I.Popligcr, avocat, de Westmount.pour les objets suivants: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"July Investment ( 'orporation\", with a total capital stock of §10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 395 Mayor Street, room 1011, Montreal, ju-«licial «listrict of Montreal.Dated at the «>ffice of the Attorney General, this fourteenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11055-59) Kaba Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issue«l by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty -thjrd day of March, 1959, incorporating: Max S.Kaufman.Joseph Roy Hoffman and Oscar Respitz, all af $10 each and 3.500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at suite 114, 5757 Decelles Avenue.Montreal, judicial district of Moidreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav «>f March, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11270-59) La Compagnie Aubotus Gagnon Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of June, 1959, incorporating: J.-Alphide Gagnon, carriage-maker, Courcel Gagnon, insurance broker, and Dr Gérard Guillemette, D.D.S.dentist, all of Port-Alfred, for the following purposes: To own and employ autobuses, taxi conveyances, trucks and all other means for public and private transportation, the whole subject to laws governing the said ways of transportation, under the name of \"La Compagnie Autobus Gagnon Ltée\", with a total capital stock of $40.000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will l>e at Port-Alfred, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of June.1959.P.FRENETTE.51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12153-59) La Compagnie Blanche Neige Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-ninth day of April.1959.incorporating: Errol Klock .McDougall.Queen's Counsel.Walter Austin Johnson and Herbert Birkett McNally, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To own.rent «>r operate a store or stores dealing in dairy products of all sorts, under the name of \"La Compagnie Blanche Neige Limitée\", with a total capital stock of $1.000.i «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la provimre «le Québeora-tion: Max M.Teitelbaum, Irving I.Finkelberg et Alfretl N.Segall, tous avocats, «le Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie de placement, sous le nom de \"Len-Or I^unl Corp.\", avec un capital total de $40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $J0 chacune et 300 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $100 chacune.Le sièg«* social de la compagnie sera a 4398 Blvd.St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le «piatorze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.(A.G.12120-59) Len-Or Land Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of April, 1959.incorporating: Max M.Teitelbaum, Irving I.Finkelberg and Alfred N.Segall, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Ixm-Or Land Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and !}()() preferred shares of a par value r $100 each.The head office of the company will be at 4398 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of April, 195').P.FRENE'lTE, 511 l3-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12035-59) Leon Investment Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du deux avril 1959, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, Alan Golden, gérant, tous deux d'Outremont, Danièle Blanchard, «le Montréal, et Huguette St-Marseille, de Ile Perrot, tous deux secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie d'immeubles et placement, sous le nom «le \"Leon Investment Ltd.\", avec un capital total «le $20,000, divisé en 50 actions ordinaires de $100 chacune et 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le deux avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12035-59) Leon Investment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April, 1959, incorporating: Louis Orenstein, adVocate, Alan Golden, manager, both of Outre-uiont, Danièle Blanchard, of Montreal, and Huguette St-Marseille, of He Perrot, both secretaries, filles majeures, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Leon Investment Ltd.\", with a total capital stock of $20.000.divided into 50 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $100 each.The hea«l office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of April, 1959.P.FRENE'lTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11711-59) Les Entreprises Talbot Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en (A.G.11711-59) Les Entreprises Talbot Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eigh- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec August 1st, 1959, Vol.91, No.31 3045 ¦ late du dix-huit mars 1959.constituant en corporation: Harry Blank.Baruch Pollack, Maxwell Shenker.avocats, et Albert Liddell, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et de construction en général, sous le nom de \"Les Entreprises Talbot Ltée\".avec un capital total de §75,000 divisé, en 300 actions ordinaires de §5 chacune et 7,350 actions privilégiées de $10 chacune.l>e siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.EH E NETTE.(P.G.12281-59) Ix;su Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize avril 1959, constituant en corporation : John .L Wasserman, de Westmount, Harold S.Freeman et Irving Halperin, de Montreal, tons avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Lesu Investment Corporation\", avec un capital total de $10.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 9,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Ix- siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.(P.G.11803-59) Lico Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux avril 1959, constituant en corporation: Samuel Stein, avocat, Lillian Lazare, Netty Mol, toutes deux secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie de placements, sous le nom de \"Lico Investments Ltd.\".avec un capital total de 850,000, divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.(P.G.13039-59) Ligue des Propriétaires de Noranda-Nord Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Ulric Lemay, plombier, Paul Poulin, journalier, et J.-Réginald Pou- teenth day of March.1959, incorporating: Harrv Blank, Baruch Pollack.Maxwell Shenker, advocates, and Albert Liddell.secretary, all of Montreal, for the following purposes: To operate as a real estate and general construction company, under the name of \"Les Entreprises Talbot Ltée\", with a total capital stock of 875,000, divided into 300 common shares of $5 each and 7,350 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of March, 1959.\" P.FRENE'lTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12281-59) Lesu Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of April, 1959, incorporating: John J.Wasserman.of Westmount.Harold S.Freeman and Irving Halperin, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development and construction company, under the name of \"Lesu Investment Corporation\", with a total capital stock of 810,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 9,000 preferred shares of a par value of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of April.1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11803-59) Lico Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April 1959, incorporating: Samuel Stein, advocate, Lillian Lazare, Netty Mol, both secretaries, spinsters of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Lico Investments Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 150 common shares of a par value of $100 each and 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13039-59) Ligue des Propriétaires de Noranda-Nord Notice is hereby given that under Part ni of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1959, to incorporate as a corporation without share capital: Ulric Lemay, plumber, Paul Poulin, laborer, and J.-Réginald 3046 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tonus 91, N° SI liot.commis, tous de Noranda-Nord, pour les objets suivants: Grouper en association, en vue de leurs intérêts, les propriétaires de résidences à Noranda-Nord et dans les environs, sous le nom de \"Ligue des Propriétaires de Noranda-Nord\".Le montant auquel sont limités les Liens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $10,000.Le siège social de la corporation sera à Noranda-Nord, district judiciaire de Houyn.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.12611-59) L.M.C.Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix)i des compagnies de Québec, il a été* accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mai 1959.constituant en corporation: Réal Lemire, pharmacien, Carmen Lambert Lemire.ménagère, épouse séparée de biens dudit Real Lemire, tous deux de Saraguay, .lean-Paul Marchildon, pompier, et Gisèle Lambert Marchildon, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jean-Paul Marchildon, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie ou le commerce d'entrepreneur général en construction, sous le nom de \"L.M.C.Construction Inc.\", avec un capital total de $20.000, divisé en 200 actions communes d'une valeur au pair de S100 chacune.I.c siège social de la compagnie sera 0203.boulevard Gouin, ouest, Saraguay.district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.11882-59) London Zig Zag Spring Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six mars 1959, constituant en corporation: David Goodman, de la ville de Hampstead, Melvin Leonard Rotlîman, de Westmount.tous deux avocats, et Dorothea Calvcr, secrétaire, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et en général faire le commerce de ressorts et dispositifs de fil de fer.sous le nom de \"London Zig Zag Spring Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et 2,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.(P.G.12497-59) Lou Frank Sales Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date Pouliot, clerk, all of Noranda-North, for the following purposes: To group into an association, in view of their interests, owners of residences at Noranda-Nord and in the vicinity, under the name of \"Ligue des Propriétaires de Noranda-Nord\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation mav hold is to be limited, is $10.000.The head office of the corporation will be at Noranda-North, judicial district of Rouyn.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of May, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12611-59) L.M.C.Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of May, 1959, incorporating: Real Lemire, pharmacist.Carmen Lambert Lemire, housewife, wife separate as to property of the said Real Lemire, both of Saraguay.lean-Paul Marchildon, fireman, and Gisèle Lambert Marchildon.housewife, wife separate as to property of the said Jean-Paul Marchildon, both of Montreal, for the following purposes: To carry on a business or industry as general building contractor, under the name of \"L.M.C.Construction Inc.\".with a total capital stock of $20.000.divided into 200 common shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at 9293 Gouin Boulevard, West, Saraguay, judicial district of Moid real.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of Mav.1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11X82-59) London Zig Zag Spring Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of March, 1959, incorporating: David Goodman, of the town of Hampstead.Melvin Leonard Rothman, of Westmount, both advocates, and Dorothea Calver, secretary, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and generally deal in springs and wire devices, under the name of \"London Zig Zag Spring Ltd.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 1,500 common shares of $10 each and 2.500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of March.1959.P.FRENE'lTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12497-59) Lou Frank Sales Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty- QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, August 1st.1969] Vol.91, No SI 3047 \u2022 lu vingt-sept avril 1059, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, Alan Golden, gérant, tous deux d'Outremont, et Huguette St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de Ile Perrot, pour les objets suivants: Exercer, dans toutes ses sépcialités, le com-rncrcd qui consiste à agir comme agent de ventes, fabricants, négociants, en gros et en détail, de fouets, bicylcttes, autos d'enfants, carosses «le bébés, trottinettes, meubles, bibelots, appareils ménagers i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1959, constituant en corporation: Rasil Danchyshyn, Gabriel Glazer, étudiants en droit, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Lymar Realty Corp.\", avec un capital total «le $5,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1440 rue Towers, chambre 100, Montréal «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le «lix-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12271-59) Lymar Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, bearing date the seventeenth day of April, 1959, incorporating: Rasil Danchyshyn, Gabriel Glazer, Law Students, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Lymar Realty Corp.\", with a total capital slock of $5.000, divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at 1440 Towers Street, Room 100.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of April.1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12131-59) Lyon Cordell Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en «late du quinze avril 1959, constituant en corporation: Lyon Cordell, opérateur d'immeubles, de Côte St-Luc.Larry Smith, comptable, de Montréal, et Françoise Matte, secrétaire, fille majeure et usant de ses droits, d'Outremont, pour les objets suivants: Transiger, diriger et exercer un commerce général de courtage d'immeubles, sous le nom «le \"Lyon Cordell Inc.\", avec un capital total $10,000.divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et 90 actions privilégiées «le $100 chacune.lx' siège social de la compagnie sera 4537 rue St-Denis, Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11800-59) Maytime Clothing Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Ix>i «les compagnies de Québec, il a «Hé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en «late «lu deux avril 1959, cosntituant en corporation: .Manuel Shacter, de Dorval, Léo Roscntzveig, Stanley Taviss, et William Levitt, tous trois de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de confectionneurs, marchands et négociants «le toutes sortes de vêtements, habillements, prêts à porter, articles vestimentaires, textiles, tissus et accessoires «le toutes sortes et descriptions, sous le nom de \"Maytime Clothing Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social «le La compagnie sera à sorit-réal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux avril 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12131-59) Lyon Cordell Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of April 1959, incorporating: Lyon Cordell, real estate operator, of Côte St.Luc.Larry Smith, accountant, of Montreal, and Françoise Matte, secretary, spinster using her rights, of Outremont, for the following purposes: To transact, conduct and carry on a general real estate brokerage business, under the name of \"Lyon Cordell Inc.\".with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $10 each and 90 preferred shares «>f $100 each.The head office of the company will be at 4537 St.Denis Street.Montreal, judicial district, of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fift«-entlr«lav «>f April.1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11800-59) Maytime Clothing Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April, 1959.incorporating: Manuel Shacter, of Dorval, Leo Rosentvcig, Stanley Taviss and William Levitt, all three of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of manufacturers and dealers and jobbers of all kinds of clothing, ready to wear garments, wearing apparel, textiles, fabrics and clothing accessories of all kinds ami description, under the name of \"Maytime Clothing Inc.\", with a to^al capital stock of $20,000.divided into 1,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol, 91, No.31 3049 (P.G.11817-59) Meridian Developments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieu tenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1959, constituant en corporation: Samuel Godingsky, Daniel Kingstone, avocats, Joseph Nuss, étudiant, et Katherine Ingle-dew, sténographe, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et développement, sous le nom de \"Meridian Developments Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.12407-59) M iron Cement Inc.Miron Ciment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept avril 1959, constituant en corporation: Émé.Lacroix, Armand Poupart, avocats et conseils en loi de la Heine, de Ville Mont-Royal, Jacques Vjau, avocat et conseil en loi de la Reine, «le Lachinc, Armand Poupart, fils, Lucien Thouin, avocats, Mlle Jacqueline Matte, el Mlle Monique Duquette, sténographes, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, acheter, vendre, importer et exporter et généralement faire le commerce «lu ciment, de ses produits, sous-produits et autres matériaux de construction, sous le nom de \"Miron Cernent Inc.\u2014 Miron Ciment Inc.\", avec un capital total de $1,000,000, divisé en 10.000 actions communes de $10 chacune et en 9,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2201, Côte Saint-Michel, Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-sept avril 1959 L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.11485-59) M.Katz Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du dix avril 1959, constituant en corporation: Moishe Katz, administrateur, Daniel Kingstone, procureur, et Katherine Ingledew, sténographe, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie de.placements, sous le nom de \"M.Katz Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.I>e siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.(A.G.11817-59) Meridian Developments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of April, 1959, incorporating:* Samuel Godinsky, Daniel Kingstone, barristers, Joseph Nuss, student, and Kathcrhie Ingledew, stenographer, spjnster, all of Montreal, for the fallowing purposes: To carry on the busuiess of a real estate anil development company, under the name of \"Meridian Developments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 preferred shares of a par value of $10 each and 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12407-59) Miron Cement Inc.Miron Ciment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of April, 1959, incorporating: Émé.Lacroix, Armand Poupart, advocates and Queen's Counsel, of the Town of Mount-Royal, Jacques Viau, advocate and Queen's Counsel, of Lachbre, Armand Poupart, son, Lucien Thouin, advocates, Miss Jacqueline Matte, and Miss Monique Duquette, stenographers, all four of Montreal for the following purposes: To manufacture, purchase, sell, import and export and to generally carry on a business dealing in cement, its products, by-products and in other budding material under the name of \"Miron Cement Inc.\u2014 Miron Ciment Inc.\", with a total capital stock of $1,000,000, divided into 10,000 common shares of $10 each and into 9,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 2201 Côte Saint-Michel, Saint-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of April, 1959.P.FRENE'lTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11485-59) M.Katz Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been {Issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, bearing date the tenth day of April, 1959, incorporating: Moishe Katz, executive, Daniel Kingstone, barrister, and Katherine Ingledew, stenographer, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"M.Katz Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 preferred shares of a par value of $10 each and 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, jmlieial «listrict of Montreal. 3050 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° SI Daté du bureau du Procureur général, le di: avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P- FRENETTE.(P.G.12007-59) Mona Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix avril 1959, constituant en corporation: Samuel Chait, Maxwell Shenker, avocats, John Hamilton, secrétaire, tous trois de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de Côte St-Luc, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de placement, sous le nom de \"Mona Investment Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1255 rue Université suite 1012 Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTK.(P.G.12057-59) Nap.Transport Cie.Ltée .Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre mai 1959, constituant en corporation: Jules Soucy, industriel, de St-Antonin.Maurice-W.Soucy, commerçant, et Hervé Goulet, commis, tous deux de Rivière-du-Loup, pour les objets suivants: Exercer le commerce du transport de passagers et de marchandises par voie de terre, sous le nom de \"Nap.Transport Cie.Ltée\".avec un capital total de $75,000, divisé en 5.000 actions communes de $10 chacune et en 2.500 actions privilégiées de $10 chacune.Ix' siège social de la compagnie sera à Rivière-du-Loup, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le quatre mai 1059.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.12220-59) Neutral Enterprises Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze avril 1959.constituant en corporation: Manuel Shacter, de Dorval, Samuel Ix-on Mendelsohn, conseil en loi de la Reine, de Westmount, Leo Rosentzveig, San ley Taviss et William IiCvitt, tous trois de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Neutral Enterprises Cor]).\", avec un capital total de 8100,000.divisé en 2.500 actions ordinaires de $10 chacune et 7,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 511 l3-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12057-59) Mona Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April, 1959, incorporating: Samuel Chait.Maxwell Shenker, advocates, John Hamilton, secretary, all three of Montreal, ami Harry L.Aronovitch, advocate, of Côte St.Luc.for the following purposes: To act as an investment corporation, under the name of \"Mona Investment Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 30,001) preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Suite 1012, 1255 University Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12057-59) Nap.Transport Cie.Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of May.1959 incorporating: Jules Soucy.industrialist, of St-Antonin, Maurice-W .Soucy, tradesman, and Hervé Goulet, clerk, both of Rivière-du-Loup.for the following purposes: To carry on a transportation business dealing in the transport of passengers and merchandise by land under the name of \"Nap.Transport Cié.Ltée\", with a total capital stock of $75.000.divided into 5,000 common shares of $10 each and into 2,500 preferred shares of SI 0 each.The head office of the company will be at Rivière-du-Loup, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of May.1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(AG.12220-59) Neutral Enterprises Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of April 1959, incorporating: Manuel Shacter, of Dorval, Samuel Leon Mendelsohn.Queen's Counsel, of Westmount, Ix'o Rosentzveig, Stanley Taviss and William I^evitt, all three of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a realty and investment company, under the name of \"Neutral Eiderprises Corp.\", \"with a total capital stock of $100.000.divided into 2.500 common shares of $10 each and 7.500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial dstrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.SI 3051 (P.G.12129-59) New Jersey Investments Ltd.Avis est donné qu'on vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a élé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze avril 1959, constituant en corporation: Bernard Sivak, avocat, de Côte St-Luc, Harry Y.Garber, avocat, de Westmount, Yves Geoffroy, étudiant en droit, Philippe Julien, notaire, tous deux de Montréal, et Ian Watson, étudiant en droit, de Howiek, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"New Jersey Investments Ltd.\", avec un capital total de S2.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et 1.000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12128-59) Northriver Lands Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze avril 1959, constituant en corporation: Bernard Sivak, de ville Côte St-Luc.Harry Garber, de Westmount, tous deux avocats, Yves Geoffroy, étudiant en droit.Philippe Julien, notaire, tous deux de Montréal, et Ian Watson, étudiant en droit de Howiek, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Northriver Lands Corp.\", avec un capital total de 82,000.divisé en 1.000 actions ordinaires de SI chacune et 1.000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11137-59) Ohio Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1959, constituant en corporation: Abraham Sinister, avocat, Nathaniel Lichman.notaire, et Carl Rosen, étudiant en droit, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Ohio Development Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de S10 chacune et 3.500 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12129-59) New Jersey Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the fifteenth day of April, 1959, incorporating: Bernard Sivak, advocate, of Côte St.Luc, Harry Y.Garber, advocate, of Westmount, Yves Geoffroy, student -at-law, Philippe Julien, notary, both of Slontreal, and Ian Watson, student-at-law.of Howiek, for the following purposes: To carry on the business of a real estate com-panyc, under the name of \"New Jersey Investments Ltd.\", with a total capital stock of $2,000.divided into 1,000 common shares of $1 each ami 1.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of April.1959.P.FRENETTE.51113-0 Acting Deputy Att«>rncy General.(A.G.1212S-59) Northriver Lands Corp.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act.leiters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province fo Quebec, bearing date the fifteenth day of April, 1959, incorporating: Bernard Sivak, of the town of Côte St.Luc, Harry Garber, of Westmount, both a«lvocatos, Yves Geoffroy, student-at-law, Philippe .lulien, notary, both of Montreal, and Ian Watson, student-at-law, of Howiek.for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Northriver Lands Corp.\".with a total capital stock of $2,000, divided into 1.000 common shares of 81 each and 1.000 preferred shares of $1 each.The head office «>f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the ofhVc of the Attorney General, this fifteenth day of April, -44)59.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11137-59) Ohio Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor f $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113- Acting Deputy Attorney General. 3052 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 19Ô9, Tome 91, N\" SI (P.C.12003-59) P.-A.I>arocque Inc.Avis est donne «m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de (Québec des lettres patentes, en date du trente avril 1959.constituant en corporation: Pierre-A.Larocque, négociant, de Grand'Mère, Maurice St-l>ouis, comptable, des Trois-Rivières, et André Carignau.commis, de St-Georges-«le-( '1 iiuni da in.pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités le commerce de quincaillerie, sous le nom de \"P.-A.Larocque Inc.\", avec un capital total de SS0.000, divisé en 800 actions communes de 850 chacune et en 800 actions privilégiées de 850 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Shawini-gan, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENE'lTE.(P.G.12221-59) Peerless Fuels Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Quévbcc, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze avril 1959, constituant en corporation: Marvin Vosko, marchand de combustible.Joseph Samuel Caplan, avocat.Esther Relia Vosko.marchande de combustible, épouse séparée de biens de Benny Vosko, et dûment autorisée par ce dernier aux lins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer, faire le commerce et le négoce de toutes sortes de charbon, combustibles et produits d'iceUx, appareils et outillage de chauffage et accessoires de toutes sortes et descriptions, sous le nom de \"Peerless Fuels Corp.\", avec un capital total de 810,000.divisé en 100 actions ordinaires «le $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.1255S-59) Penn Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959.constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Irving I.Finkelberg, avocats, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, poulies objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie «le construction et de placement, sous le nom de \"Penn Investment Corp.\", avec un capital * total de $10,000.divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 900 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5105 ouest rue Sherbrooke, Montréal district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.(A.G.12003-59) P.-A.Larocque Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tl»c Province of Quebec, bearing «late the thirtieth day of April, 1959, incorporating: Pierre-A.Larocque, tradesman, of Grand'Mère, Maurice St-Louis, accountant.«>f Trois-Rivières, ami André Carignan, clerk, of St-Georges-de-Cham-plain, for the following purposes: To carry on in all its specialties, a hardware business, under the name of \"P.-A.Larocque Inc.\", with a total capital stock of $80,000, divided into 800 common shares of 850 each ami into 800 preferred shares of $50 each.The head office' of the company will be at Shawinigan, jmlieial «listrict of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of April.1959.P.FRENE'lTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12221-59) Peerless Fuels Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of April, 1959, incorporating: Marvin Vosko, Fuel Merchant, Joseph Samuel Caplan.advocate, Esther Relia Vosko, Fuel merchant, wife separate as to property of Benny Vosko, and duly authorized by him for the purpose of these presents, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture, trade in .and deal with all kinds of coal, fuels and fuel products, heating appliances and equipment of all kinds of description ami accessories, under the name of \"Peerless Fuels Corp.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will bejjat Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of April.1959.P.FRENETTE.51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12558-59) Penn Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1959.incorporating: John L.Liberman.Alfred N.Segall.Irving I.Finkelberg.advocates, ami Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business «>f a construction and investment company, under the name of \"Penn Investment Corp.\".with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of a a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 5105 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of April.1959.P.FRENETTE.51113-t) Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.31 3053 (P.G.12194-59) Perjay Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix avril 1959, constituant en corporation: Percy Libcnstein, marchand, Philip Shrague Garonce, Hyman Laddie Schnaiberg, tous deux avocats, tous trois de Montréal, et James Libcnstein, marchand, de Côte St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce et les activités de constructeurs généraux et entrepreneurs et gérer toutes affaires de placements, sous le nom de \"Perjay Realty Corp.\".avec un capital total de $40,000, divise en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix avril 1959.L'Assistant -procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.12205-59) Pinehurst Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize avril 1959, constituant en corporation: Baruch Pollack, avocat, d'Outremont, Isidore Greenbaum, avocat, de ville Côte St-Luc, et Milton Friefeld, comptable agréé «le Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, développement, construction et placement, sous le nom de \"Pinehurst Development Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.(P.G.12549-59) Plomberie Centrale Inc.Avis est donné «pi'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1959, constituant en corporation: Luc Geoffroy, de Chambly, Robert Dulude, de Dorion, et Robert-Y.Lanthier, de Ste-Rose, tous avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et généralement faire le commerce de toutes sortes d'appareils ou systèmes de chauffage, sous le nom de \"Plomberie Centrale Inc.\", avec un capital divisé en 300 actions sans valeur au pair ou nominale et en 1,000 actions privilégiées de $25 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera d'au moins $4,000.Le siège social de la compagnie sera 77, boulevard Harwoo«l, Dorion, comté «le Vau-dreuil, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-huit avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 5U13-0 P.FRENE'lTE.(A.G.12194-59) Perjay Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April, 1959.incorporating: Percy Libens-tein, merchant, Philip Shrague Garonee, Hyman Laddie Schnaiberg, both advocates, all three of Montreal, and James Libcnstein, merchant, of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business ami activities of general builders and contractors and to operate all investment businesses, umler the name of \"Perjay Realty Corp.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1.000 common shares of $10 each and 3.000 prcferrei des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf avril 1959, constituant en corporation: Mortimer Dolan.notaire, Ellen Anne Hurley et Jeanino-L.Fobert, toutes deux secrétaires, filles majeures, tous de Montrerai, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Reshaban Land Inc.\", avec un capital total de $20.000, divisé on 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 19,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 4028 avenue Melrose, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général.le neuf avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(P.G.12251-59) Rino Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie do la Ix>i des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1959.constituant en corporation: Sydney Phillips, avocat, do Côte St-Luc, Norman N.Genser, avocat, de Hampstead, Rose-Marie Bourgoing, secrétaire, fille majeure de Montréal, et Gladys Kobalenko, secrétaire, fille majeure, do Verdun, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie de placement, sous le nom de \"Rino Investment The head office of the company will be at 5105 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth dav of March, 1959.P.FRENE'lTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12219-59) Reputation Hosiery Mills Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of April, 1959.incorporating: Alexander Stern, of Toronto, Ontario, Miklos Wreiss, of Montreal, both merchants, Melvin Salmon, of the Town of Côte St.Luc, and Moe Moscovitch, of Outremont, both advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in hosiery and women's wear and dress accessories, under the name of \"Reputation Hosiery Mills Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 40,000 common shares of a par value of $1 each and 10,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of April, 1959.P.FRENE'lTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12203-59) Reshaban Laud Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of April, 1959, incorporating: Mortimer Dolman, notary.Ellen Anne Hurley and Jeanine-L.Fobert.both secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Reshaban Land Inc.\", with a total capital stock of $20.000.divided into 1.000 common shares of $1 each and 19,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at 4028 Melrose Avenue, Montreal, jmlieial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney (Jouerai, this ninth dav of April, 1959.P.FRENETTE.51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12251-59) Rino Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the .seventeenth day of April.1959, incorporating: Sydney Phillips, advocate, of Côte St.Luc, Norman N.Genser, advocate, of Hampstead, Rose-Mario Rourgoing, secretary, unmarried of the full age of majority, of Montreal, and Gladys Kobalenko, secretary, unmarried of the full age of majority, of Verdun, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Rino Investment QUEBEC QEE ICI AL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.31 3057 Corp.\", avec un capital total de §40,000.divisé en 500 actions ordinaires dé $10 chacune et 350 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le «lix-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.Corp.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 500 common shares «>f $10 each ami 350 preferred shares of $100 each.The head office «>f the company will be at Montreal, jmlieial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of April.1059.P.FRENETTE.51113-0 Acting-Deputy Attorney General.(P.G.12075-59) Rochefort Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en «late du dix avril 1959, constituant en corporation: Samuel Chait, Maxwell Shenker, avocats, John Hamilton, secrétaire, tous trois «le Montréal, et Harry L.Aronovitch.avocat, «le ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de placements, sous le nom «le \"Rochefort Investment Corporation\", avec un capital total «le $40.000, divisé «\u2022n 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30.000 actions privilégiées «le $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 5105 ouest rue Sherbrooke, suite 301, Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le dix avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENETTE.(A.G.12075-59) Rochefort Investment Corporation Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of April, 1959, incorporating: Samuel Chait, Maxwell Shenker, advocates, John Hamilton, secretary, all three of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Cîite St.Luc, for the following purposes: To act as an investment corporation, under the name of \"Rochefort Investment Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.\u2022 The head office of the company will be at 5165 Sherbrooke Street West, suite 301, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of April.1959.P.FRENE'lTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12013-59) R.P.R.Automotive Supplies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date «lu six mai 1959, constituant en corporation: Leopold Pilon, «le Laval-des-Rapides, Raymond Racine, de Montréal-Nord, et Alphonse Racette, «le Montréal, tous marchands, pour les objets suivants: Commerce «le parties, pièces et accessoires d'automobiles et autres véhicules, sous le nom de \"R.P.R.Automotive Supplies Inc.\", avec un capital total de $21,000, divisé en 210 actions communes «l'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 215 boulevard Crémazie, ouest, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le six mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 5U13-0 P.FRENE'lTE.(A.G.12013-59) R.P.R.Automotive Supplies Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the sixth day of May, 1959.incorporating: Leopold Pilon, of Laval-des-Rapides, Raymond Racine, of Montreal-North, and Alphonse Racette, of Montreal, all merchants, for the following purposes: To carry on a business dealing in parts, pieces and accessories for automobiles and other vehicles, under the name of \"R.P.R.Automotive Supplies Inc.\", with a total capital stock of $21,000, divided into 210 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 215 Crémazie Boulevard, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of Mav.1959.P.FRENE'lTE, 51113 Act ing Deputy Attorney General.(P.G.11900-59) Sabra Realties Corp.Av^s est donné qu'en vertu «le la premiere partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en «late «lu trois avril 1959, constituant en corporation: Ann Druzin, «le Longueuil, Mary Gaffney, de Montréal, toutes deux secrétaires, filles majeures, et Gerald (\"harness, avocat, «le Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie de platement, sous le nom «le \"Sabra Realties Corp.\", avec un capital total «le $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune.(A.G.11900-59) Sabra Realties Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the third day of April, 1959.incorporating: Ann Druzin, of Longueuil, Mary Gaffney, of Montreal, both secretaries, spinsters of full age of majority, and Gerald Chamess.advocate, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Sabra Realties Corp.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $100 each. 3058 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÊBEl .Québec, 1er août 1969, Tome 91, N° 31 Le siège social de la compagnie sera à 4 est rue Notre-Dame, chambre 504, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.(P.G.11887-59) Sabre Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en «late du vingt-cinq mars 1950.constituant en corporation: .lack Ligbtstone, Marvin Riback.avocats, et Aimé Duranleau, huissier, tous «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie de placements, sous le nom de \"Sabre Investment Corp.\", avec un capital total de 810.000.divisé en 100 actions ordinaires «le S10 chacune et 900 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 4957 Avenue King Edward, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-cinq mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113 P.FRENE'lTE.(P.G.12002-59) Salons Cosy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en date du trente avril 1959.constituant en corporation: René Julen, Ernest Sonney et Albert Umlauft, tous coiffeurs, «le Montréal, p«>ur les objets suivants: Exercer en général le commercé «le salon de beauté et «le salon de coiffure, sous le nom «le \"Salons Cosy Inc.\".avec un capital total «le $80.000.divisé eu 500 actions communes de 8100 chacune et en 3.000 actions privilégiées «le s 1(H) chacune.I.o siège social de la compagnie sera 1331, rue Canora, ville Mont-Royal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le trente avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.12323-59) Sans Souei Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu «h- la première partie de la l«oi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date - du vingt avril 1959.constituant en corporation: Moe Ackinan.de L'Abord-à-Ploufl'c, Irwin Gliserman, «le (Vite St-Luc, et Sdincy Cutler, «le Montréal, tous avocats, pour l«>s objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie «l'im-meublcs, développement et construction, sous le nom «le \"Sans Souci Realty Corp.\", avec nu capital total f April.li)5!L_ P.FRENE'lTE.51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11887-59) Sabre Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of March, 1959.incorporating: .lack Ligbtstone, Marvin Riback.advocates, ami Ainu' Duranleau, bailiff, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, umler the name of \"Sabre Investment Corp.\", with a total capital stock of $10,000.divided into 100 common shares «>f $10 each and 900 preferred shares of $10 each.The head office «>f the company will be at 495\".King Edward Avenue.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, tins twenty-fifth day of March, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12002-59) Salons Cosy Inc.Notice is hereby given that umler Part I ol the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day «if April, 1959, incorporating: René Julen, Ernest Sonney and Albeit Umiauft, all hairdressers, of Montreal, for the following purposes: To generally carry on a beauty and haird-dres.-sing parlor business umler the name of \"Salons Cosy Inc.\".with a total capital stock of $80,000.divided into 500 common shares of $100 each and into 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be Jit 1331 Canora Street, town of Mount-Royal jmlieial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April.1959.P.FRENE'lTE.51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12323-59) Sans Souci Realty Corp.Notice is''hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth \u2022lay of April, 1959.incorporating: Moe Ackman, of L'Abord-àrPloufie, Irwin Gliserman, «>f Côte St-Luc.and Sidney Culter, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development, ami construction company, umler the name of \"Sans Souci Realty Corp.\".with a total capital stock of $10.000.divided into 300 common shares of $10 each ami 70 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, jmlieial «listrict «>f Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of April.1959.P.FRENETTE.51113-0 Acting Deputy Attorney General. QEBE OFF ICI AL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.31 3059 P.G.12557-59) Scuhrook Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix»i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959.constituant en corporation: John L.Lihcrman.Alfred N.Segall, avocats, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de cons-I met ion et placement, sous le nom de \"Scahrook Investment Corp.\", avec un capital total de ¦< 10.000.divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5757 avenue Dccclles.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le ingl-nciif avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.P.G.12285=59) Senior Holdings Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date ¦ lu dix-sept avril 1959, constituant eu corporation: Clifford George Meek, Guy Ambrose Miller, teneurs de livres, et John Lawrence McCrory, commis, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, immeubles, de celles qui consistent à passer des contrats et sous-contrats et aussi agir comme une compagnie de construction et développement en général et agir comme une compagnie d'affaires générales et portefeuilles, placements et gestion, ce dernier pouvoir ne devant considérer comme donnant à la compagnie le droit d'agir comme si elle était constituée en corporation en vertu des dispositions de la Iaj'i les compagnies de fiducie, sous le nom de \"Senior Holdings Limited\", avec un capital-action divisé en 1,000, actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant avec lequel la compagnie exercera son commerce ne sera moins «pie $5,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12557-59) Scahrook Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-ninth day of April, 1959.incorporating: John L.Liberman, Alfred X.Segall, advocates.an«l Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction and investment company, umler the name of \"Sea-brook Investment Corp.\", with a total capital stock of $10.000, divided into KM) common shares of a par value Of $10 each ami 900 preferred shares of a par value «>f $10 each.The head office of the company will be ta 5757 Dccclles Avenue.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.I22S5-59) Senior Holdings Limited .Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of April, 1959, incorporating: Clifford George Meek.Guy Ambrose Miller, bookkeepers, and John Lawrence McCrory, clerk, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the businesses of a land, real estate, contracting and sub-contracting and construction and general development company and the general business of a holding, investment and management company, the latter power not to be construed as empowering the Company to act as if incorporated under the provisions of the Trust Companies' Act, under the name of \"Senior Holdings Limited\", with a capital stock divided into 1.000 shares without nominal or par value, and the amount with which the company will carry on its business shall be not less than $5.000.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11900-59) Serviccmaster \u2014 Montreal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1959, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall.tous «leux avocats, de Montréal, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure, d'Outremont, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à nettoyer, traiter à l'épreuve des mites et du rétrécissement, déso«loriser.presser, teimlre, blanchir et réparer (A.G.11906-59) Serviccmaster \u2014 Montreal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of Mardi.1959, incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall, both advocates, of Montreal, and Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, of Outremont, for the following purposes: To carry on the business of cleaning, mothproofing, shrink-resisting, deodorizing, pressing, dyeing, laundering and repairing nigs, carpets. 3060 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° SI les tapis, carpettes, tapisserie, draperie, vêtement, tissus, meubles et fournitures de maison, de toutes sortes, et celui d'entreposeurs en général, sous le nom de \"Serviccmaster \u2014 Montreal Inc.\".avec un capital-actions divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant du capital avec lequel la compagnie commencera ses activités sera d'au moins §500.Ix; siège social de la compagnie sera à -13 Chemin Banstead, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mars 1959.L'Assistant -procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.upholstery, drapery, clothing, fabrics and household furnitures and furnishings of all kinds, and general storage warehousemen, under the name of \"Serviccmaster \u2014 Montreal Inc.\", with a capital stock divided into 100 shares without nominal or par value, and the amount with which the company will commence its operations will beat least $500.The head office of the company will be at \u202213 Banstead Road.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtv-first dav of March, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11511-59) Shceri Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la provinw de Québec des lettres patentes, en date du sept avril 1959.constituant en corporation: Nairn Sheeri, administrateur, Samuel Godinsky, avocat, et Katherine Ingledew.sténographe, fille majeure, tous «le Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie «le placement, sous le nom «le \"Sheeri Holdings Ltd.\", avec un capital total de §40,000, «livisé en 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune et 10,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Precureur général, le sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.11511-59) Sheeri Holding» Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issue»! by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day «>f April, 1959, incorporating: Nairn Sheeri, executive, Samuel Gof \"Sheeri Holdings Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, «livide»! into 30,000 preferre«l shares having a par value of $1 each an«l 10.0(H) common shares having a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of April.1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12291-59) Shelley Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1959.constituant en corporation: John J.Wasserroan, «le Westmount, Harold S.Freeman et Irving Halperin, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Shelley Realties Inc.\", avec un capital total «le $10,000 «livisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 9.000 actions privilégiées «le $1 chacune.Ix?siège social la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montré'al.Daté «lu bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12291-59) Shelley Realties Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the seventeenth day of April, 1959, incorporating: John J.Wasserman, of West mount.Harold S.Freeman and Irving Halperin, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business «>f a real estate, development ami construction company, under the name of \"Shelley Realties Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $1 each ami 9.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, jmlieial district of Montreal.Dated at the office «>f the Attorney General, this seventeenth dav of April.1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11876-59) Shoreerest Development Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1959, constituant en corporation: Milton L.Klein, avocat, Arthur D.Ruby, comptable agréé, et Iown Lanteigne, sténographe, épouse séparée «le biens «le Roger Lanteigne, tous de Montréal, pour les objets suivants: (A.G.11876-59) Shoreerest Development Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of March.1959, incorporating: Milton L.Klein, advocate.Arthur 1).Ruby, chartered accountant, and Iown Lanteigne, stenographer, wife separate as to property of Roger Lanteigne, all of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OEE ICI AL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol 91, No.31 3061 Ériger, améliorer, transformer et gérer des édifices et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Shoreerest Development Inc.\".avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mars 1059.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.To erect, improve, alter and manage buildings and deal in building materials, umler the name of \"Shoreerest Development Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $10 each and 3,600 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, jmlieial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of March, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12505-59) Shore Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I*)i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1959, constituant en corporation: Allan Colton, fabricant, Abe Arick, agent d'immeuble, et Manuel Sachs, comptable agréé, ions de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom de \"Shore Investment Corp.\", avec un capital total de §10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 900 actions privilégiées de $10 chacune.IiC siège social de la compagnie sera à Montréal, \u2022 listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.(A.G.12505-59) Shore Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant -Governor of the Province of Quebec, hearing date the twenty-ninth day of April, 1959, incorporating: Allan Colton, manufacturer, Abe Arick, realtor, and Manuel Sachs, chartered accountant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a realty and construction company, under the name of \"Shore Investment Corp.\", with a total capital stock of $10,000.divided into 1,000 common shares of $1 each ami 900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of April, 1959.P.FRENE'lTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12340-59) Skyline Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt avril 1959, constituant en corporation: Louis Hubscher.marchand, Mortimer S.Smith, avocat, Claude Morin, Shirley Simon, secrétaires cl Ellen Haggcnmucller.commis, toutes trois filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placement, sous le nom de \"Skyline Realties Inc.\", avec un capital total de $150.000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 1,450 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, ilistrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11656-59) Southampton Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois mars 1959, constituant en corporation: Alick Clements, Emil Kroo, tous deux agents, et Mme Lily Marks Clements, ménagère, épouse séparée de biens dudit Alick Clements, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: (A.G.12340-59) Skyline Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April, 1959, incorporating: Louis Hubscher, merchant, Mortimer S.Smith, advocate, Claude Morin, Shirley Simon, secretaries, and Ellen Haggenmueller, clerk, all three filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, umler the name of \"Skyline Realties Inc.\", with a total capital slock of $150,000, into 500 common shares of $10 each and 1,450 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of April, 1959.P.FRENE'lTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11056-59) Southampton Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the twenty-third day of March, 1959, incorporating: Alick Clements, Emil Kroo, both agents, and Mrs.Lily Marks Clements, housewife, wife separate as to property of the said Alick Clements, and didy authorized by him for the purpose of these presents, all of Montreal, for the following purposes: 3062 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° SI Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeubles, construction et placements, sous le nom «le \"Southampton Realty Corp.\", avec un capital total «le ?10,000, «livisé en 100 actions ordinaires «le $10 chacune et 000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le vingt-trois mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTK.(P.G.12279-59) St.Louis Land Development Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la \\m «les compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Qué'bec «les lettres patentes, en «late du seize avril 1959, «instituant en corporation: Max M.Teitelbaum.Irving Finkclberg et Alfred N.Segall, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de construction en général et «le placement, sous le nom de \"St.Louis Land Development Corp.\", avec un capital total «le $10,000, «livisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le §10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1LS7 Blvd Labelle, Sainte-Thérèse, «listrict judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le seize avril 1959.I,'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12213-59) Sunview Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie f $10 each.The head office of the company will be at 11S7 Labelle Blvd, Sainte-Thérèse, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of April, 1959.P.FRENETTE.51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12213-59) Sunview Development Corp.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the ninth day of April.1959.incorporating: Moe Ackman.advocate, of L'Àbord-à-Plouffe, Irwin Gliserman, Sidney Cutler, advocates, and Annette Katz.secretary, fille majeure, all three «>f Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate development ami construction company, under the name of \"Sunview Development Corp.\", with a total capital stock r $10.000, divided into 500 common shares of $10 each ami 509 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of April.1959.P.FRENE'lTE.51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11937-59) Teejay Investment Ltd, Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of April, 1959, incorporating: Leo Rosentzveig, Stanley Taviss and William Levitt, all advocates, of Montreal, for the following purposes : To carry on the business of a realty and investment company, umler the name of \"Teejay QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No:31 Investment Ltd.\".avec un capital total de §5.000, divisé en 5,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.Investment Ltd.\", with a total capital stock of §5,000.divided into 5,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of April.1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.P.G.12381-59) The Carlelon Press, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux avril 1959, constituant en corporation: John Paluzzi, Alfred Paluzzi, imprimeurs, et Isaura Rondina Paluzzi, ménagère, épouse commune en biens dudit John Paluzzi et dûment autorisée par ce dernier, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs, lithographes, stéréotypeurs, électrotypeurs, imprimeurs en photographie, graveurs, médailleurs, fabricants de livres de blancs, relieurs et papetiers, sous le nom de \"The Carleton Press, Limited\", avec un capital total de §35,000, divisé en 200 actions ordinaires de §100 chacune et 150 actions privilégiées de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(A.G.12381-59) The Carleton Press, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of April, 1959, incorporating: Jolin Paluzzi, Alfred Paluzzi, printers, and Isaura Rondina Paluzzi, housewife, wife common as to property of the said John Paluzzi, and duly authorized by him, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of printers, lithographers, stereotypers, electrotypers, photographic printers, engravers, dicsinkers, blank-book manufacturers, bookbinders and stationers, under the name of \"The Carleton Press, Limited\", with a total capital stock of §35,000, divided into 200 common shares of §100 each and 150 preferred shares of §100 each.The head office of the company will he at Montreal, jmlieial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11980-59) Thibault Electrique Limitée Thibault Electric Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la \\ayi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de (Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mai 1959, constituant en corporation: Rodrigue Farley, avocat, Rhéa Archani-bault et Gabriellc Ladéroute, employées, célibataires, tous de Hull, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en électricité et exercer le commerce d'appareils électriques de toutes sortes, sous le nom de \"Thibault Electrique Limitée \u2014 Thibault Electric Limited\", avec un capital total de §30,000, divisé en 2,000 actions communes d'une valeur au pair de §10 chacune et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 164, rue Laurier, Maniwaki, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(A.G.11980-59) Thibault Électrique Limitée Thibault Electric Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of May, 1959, incorporating: Rodrigue Farley, advocate, Rhéa Archambault and Ga-brielle Ladéroute, employees, spinsters, all of Hull, for the following purposes: To carry on business as electrical contractors and to operate a business dealing in electrical apparatus of all kinds, under the name of \"Thibault Electrique Limitée \u2014 Thibault Electric Limited\", with a total capital stock of §30,000, divided into 2,000 common shares of a par value of §10 each and into 1,000 preferred shares of a par value of §10 each.The head office of the company will be at 104 Laurier Street, Maniwaki, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of May, 1959.P.FRENE'lTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11929-59) Tosam Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier avril 1959, constituant en corporation: Leonard Liverman, Julius Rriskin et (A.G.11929-59) Tosam Investments Inc.Not ice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of April, 1959, incorporating: Leonard Liverman, Julius Rriskin and Arthur Vanofsky, all advo- 3064 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° SI Arthur Yanofsky, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires (l'une compagnie de placement, sous le nom «le \"Tosam Investments Inc.\".avec un capital total «le $-10,000, divisé en 500 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $10 chacune et 3,500 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $10 chacune.Ia- siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le premier avril 1050.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12092-69) Tov Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec «les lettres pateides, en «late «lu «piatorze avril 1050.constituant en corporation: Louis Frcedman, avocat et conseiller en loi de la Reine, «le Côte St-Luc, Irwin Aaron Frankel, avocat, de ville «le Mont-Royal, et' Sa«lie Gersovitz; secrétaire, fille majeure, «le Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie d'immeubles et «'«instruction, sous le nom «le \"Tov Investments Inc.\", avec un capital total de $42,000, «livisé en 1.400 actions ordinaires de $10 chacune et 2,800 actions privilégiées de $10 chacune.Le smge social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze avril 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12219-59) Toyland Playthings Incorporated Avis est donné qu'en vertu «!«\u2022 la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «!«' Québec des lettres patentes, en «late «lu seize avril 1959.constituant en corporation: Max Slapack.«le la ville Côte St-Luc.Arthur Shulman «4 Gregory Charlap.de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Fabriquer «4 faire le commerce «le jouets, nouveautés, meubles, quincaillerie et spécialités en bois, nouveautés «4 jouets de toutes sortes et descriptions, sous le nom «h- \"Toyland Playthings Incorporated\", avec un capital total de $20.000.divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 1.500 actions privilégiées de $10 \"chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «h- Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le seize avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11939-59) Trane Investment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Ix>i des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du deux avril 1959, constituant en corporation: Julius Rriskin, Leonard Liverman, tous deux de cat es, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Tosam Investments Inc.\", with a total capital stock «»f $40,000.divided into 500 common shares of a par value of $10 each and .'5,500 preferr«'«l shares of a par value of llO'each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office f the Attorney General, this first day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113- Acting Deputy Attorney General.(A.G.12092-59) Tov Investments Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of April, 1959, incorporating: Louis Freed-man, advocate ami Queen's Counsel, of C«Uc St.Luc, Irwin Aaron Frankel, advocate, of the town' of Mount Royal, ami Sadie Gersovitz, secretary, spinster, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate ami construction company, umler the name of \"Tov Investments Inc.', with a total capital stock of $42,000, divided into 1,400 common shares of $10 each ami 2,800 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office «>f the Attorney General, this fourteenth dav of April.1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12249-59) Toy land Playthings Incorporated Notice is hereby given that under Part I f Quebec, for the following purposes: To carry on the operations of builders or general contractors as electricians, installer of electrical apparats; to install.all electrical power and lighting systems, under the name of \"Universal Electric & Heating Co.Ltd.\", with a total capital stock of $38,000, divided into 200 common shares of 8100 each ami into 180 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12008-59) Vale Construction Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of May, 1959, incorporating: Charles-Joseph Gélinas, Queen's Counsel, of Outremount, Pierre Bourque and Jacques-Guy Béliveau,'of 3066 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 Béliveau, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le \"Vale Construction Ltd.\", avec un capital total «le 810,000, divisé en 300 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le 8100 chacune et en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre mai 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.12947-59) Versailles Builders Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mai 1959, constituant en corporation: Adrien-Roger PAquettc, avocat, d'Outremont, Denise Racicot, de St-Eustache-sur-lc-Lac, et Françoise Frégeau, d'Ahuntsic, toutes deux secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Commerce d'immeubles, de construction et de compagnie «le placements, sous le nom de \"Versailles Builders Ltd.\", avec un capital total «le $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENE'lTE.(P.G.11907-59) Wallace Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un mars 1959.constituant en corporation: Milton L.Klein, avocat, Arthur 1).Ruby, comptable agréé, et Iown éteigne, sténographe, épouse séparée de biens de Roger Lanteigne, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Wallace Realties Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et 1.000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mars 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.11286-59) Wallcrete of Canada Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze avril 1959, constituant en corporation: Murray Lapin, avocat, de ville «le Hampstead, Alan B.Gold, Morris M.Weiner, tous deux avocats, de Montréal, et Shirley Muggeridge, Montreal, all advocates, for the following pur poses : To carry on»a business as builders an«l general building contractors, under the name of \"Vale Construction Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 300 preferred shares of a par value of $100 each and into 1,000 common shares of a par value «>f $10 each.The head office «>f the company will be at Montreal, jmlieial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth dav of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12947-59) Versailles Builders Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-seventh day of May, 1959, incorporating: Adrien-Roger PAquettc, advocate, of Outremount, Denise Racicot, of St-Eustache-sur-le-Lac, and Françoise Frégeau, «>f Ahuntsic, both secretaries, of full age, for the following purposes: To deal in immoveables, construction ami an investment company, under the name of \"Versailles Builders Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh dav of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11907-59) Wallace Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, bearing «late the thirty-first day of March, 1959, incorporating: Milton L.Klein, advocate, Arthur I).Ruby, Chartered accountant, and Iown Lanteigne, stenographer, wife separate as to property of Roger Lanteigne, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Wallace Realties Inc.\", with a total capital stock of $20.0011.divided into 1,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head Office of the company will be at Montreal, jmlieial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first dav of March, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11286-59) Wallcrete of Canada Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of April, 1959, incorporating: Murray Lapin, advocate, of the town of Hampstead, Alan B.Gold.Morris M.Weiner, both advocates, of Montreal, and Shirley Muggeridge, secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1969, Vol.91, No.31 3067 secrétaire, fille majeure, de Verdun, pour les objets suivants: Diriger et exercer le commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Wallcrete ,,f Canada Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3.500 actions privilégiées .l'une valeur au pair de $10 chacune.L- siège social de la compagnie sera à 951 avenue Pratt, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12277-59) Westwood Developments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i dés compagnies de Québec, il a clé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize avril 1959, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Max Teitelbaum, tous trois avocats, de Montréal, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure.d'Outremont, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de construction en général et placements, sous le nom de \"Westwood Developments Inc.\".avec un capital total de $10,000.«livisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 900 actions privilégies d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5105 ouest rue Sherbrooke.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'ITK.spinster of the full age of majority, of Verdun, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Wallcrete of Canada Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and 3,500 preferred shares of a par value of 810 each.The head ofliee of the company will be at 951 Pratt Avenue.Montreal, jmlieial «listrict of Mont read.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day «>f April.1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12277-59) Westwood Developments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the sixteenth day of April, 1959, incorporating: John L.Liberman.Alfred N.Segall.Max Teitelbaum, all three advocates, of Montreal, and Marilyn Denny, secretary, spinster of the full age of majority, of Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a general construction and investment company, under the name of \"Westwood Developments Inc.\".with a total capital stock of $10,000.divided into 100 common shares of a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 5105 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of April, 1959.P.FRENE'lTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12330-59) Winridge Developments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt avril 1959, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Irving I.Finkelberg, tous trois avocats, de Montréal, et Marilyn Denny, secrétaire, fille majeure, d'Outremont, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et de placement, sous le nom de \"Winridge Developments Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires «Tune valeur au pair de $10 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5165 ouest rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENE'lTE.(A.G.12330-59) Winridge Developments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of April, 1959, incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall, Irving I.Finkelberg, all three advocates, of Montreal, and Marilyn Denny, secretary,'spinster of the full age of majority, of Outremont, for the following purposes : To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Winridge Developments Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each and 900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will befat 5105 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-o Acting Deputy Attorney General.' (P.G.11144-59) (A.G.11144-59) Wolf Brand Cravat & Suspender Co.Ltd.Wolf Brand Cravat & Suspender Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies' Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- 3068 GAZETTE GEE ICI ELLE DE QUEBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 province de Québec «les lettres patentes, en date du dix-sept avril 1959, constituant en corporation: Isidore Popliger, avocat et conseil en loi de la Heine, Wolf Hialik, marchand, et Hylda Sherman, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de fabricants, man-bands et négociants de toutes sortes de lainage, satins, tissus textiles et articles en cuir, y compris la vente et la distribution de cravates, bretelles et ceintures, sous le nom de \"Wolf Brand Cravat & Suspender Co.Ltd.\", avec un capital total de 875,000, divise'' en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et 050 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.(P.G.12197-59) Zclwin Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, U ta été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes en date du onze avril 1959, constituant en corporation: Gabriel Glazcr, étudiant en droit, Hilliard Ginsberg, avocat, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et construction, sous le nom de \"Zclwin Realty Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 5,000 actions «le 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1-140 rue Towers, chambre 100, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le onze avril 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113 P.FRENETTE.ince of Quebec, bearing date the seventeenth day of April 1959, incorporating: Isidore Popliger, advocate and Queen's Counsel, Wolf Bialik, merchant, ami Hylda Sherman, secretary, fillc majeure, all of Montreal, for the following purposes : To carry on the trade and business of manufacturers and dealers and jobbers in all kinds of wool lens, satins, textile fabrics and Leather goods, including the sale and distribution of cravats, suspenders and belts, under the name of \"Wolf Brand Cravat & Suspender Co.Ltd.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 100 common shares of 8100 each and 050 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office «)f the Attorney General, this seventeenth day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12197-59) Zelwiu Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April 1959, incorporating: Gabriel Glazer.law student, Hilliard Ginsberg, advocate, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Zclwin Reatly Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 5.000 shares of $1 each.The head office «>f the company will be at 1410 Towers Street, Room 100, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, tins eleventh dav of April, 1959.P.FRENE'lTE, 51113-0 Acting Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires (P.G.11181-59) Adrien Guuy & Fils Inc.Aviâ est donné (pi'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux mai 1959, à la compagnie \"Les Entreprises Matapédia Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la lx>i «les compagnies «le Québec, sous le nom originaire de \"Halle & Guay Limitée\", par lettres patentes du 19 février 1948, et par lettres patentes supplémentaires en date «lu 25 novembre 1953, changeant ledit nom originaire en celui de \"Les Entreprises Matapédia Inc.\", 1) changeant «le nouveau son nom en celui de \"Adrien Guay & Fils Inc.\"; 2) étendant ses pouvoirs; 3) augmentant son capital de $10,000 à $90,000.le capital-actions additionnel étant «livisé en 500 actions privilégiées de $100 chacune; 4) changeant son siège social de Saint-Léon-le-Grand à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le vingt-deux mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.Supplementary Letters Patent (A.G.11181-59) Adrien Guay & Fils Inc.Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-second day of May, 1959.to the company \"lx\\s Entreprises Matapé«lia Inc.\".constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act under the original name of \"Halle & Guay Limitée\"; by letters pateid dated 19 I'Vbruary, 1948, and by supplementary letters patent dated November 25.1953, changing the said original name to that of \"Les Entreprises Matapédia Inc.\", 1) changing once again its name to that of \"Adrien Guay & Fils Inc.\"; 2) extending its powers; 3) increasing its capital from the sum of $40.000 t«> $90.000.the additional share capital being divided into 500 preferred shares of $100 each; 4) changing its head office from Saint-Léon-lcrGrand to Rimouski, jmlieial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.81 3069 (P.G.13187-59) Apa Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-sept mai 1959.à la compagnie \"Apa Investments Ltd.\", 1) changeant ses 3.000 actions ordinaires sans valeur a»i pair en 3.000 actions ordinaires de $50.chacune; 2) subdivisant ces 3,000 actions ordinaires de 850 chacune en 30.000 actions ordinaires de 85 chacune; 3) réduisant son capital de 8150.000 à 815,000, le capital-actions annulé étant divisé en 27,000 actions ordinaires de 85 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1059.L'Assistant-procureur général suppléant.51113-0 P.FRENETTE.(P.G.14568-58) Artinar Equipment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date c 1 ii cinq mai 1959.à la compagnie \"Artmar Equipment Ltd.\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.51113-0 P.FRENETTE.(P.G.12945-59) Auto (Holding) Ltée\u2014Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze mai 1959, à la compagnie \"Lajeunesse Automobile Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de La Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 15 juin 1953, changeant son nom en celui de \"Auto (Holding) Ltée \u2014 Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général le quinze mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENE'lTE.(P.G.12147-59) Benaby Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur .de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du six mai 1959, à la compagnie \"Benaby Realties Ltd.\", augmentant son capital de $50,000 à 8150,000, le capital-actions additionnel étant «livisé en 50.000 actions ordinaires de $1 chacune et en 2.000 actions privilégiées classe \"B\" de $25 chacune.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le six mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.13295-59) Carsley's Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a (A.G.13187-59) Apa Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-»seventh day of -May, 1959, to the company \"Apa Investments Ltd.\", I) changing its 3,000 common shares without par value into 3,000 common shares of 850 each; 2) subdividing said common shares of 850 each into 30,000 common shares of 85 each; 3) decreasing its capital from the sum of SI50.000 to $15.000.the cancelled share capital being divided into 27.000 common shares of 85 each.Dated at the office «>f the Attorney General, this twentv-scventh dav of Mav.1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.1450S-58) Artmar Equipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fifth day of May, 1959, to the company \"Artmar Equipment Ltd.\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May.1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12945-59) Auto (.Holding) Ltée\u2014Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the fifteenth day of May, 1959, to the company \"Lajeunesse Automobile Limitée\", incorporated under the said Part I of thejQuebec Companies' Act, by letters patent of June 15.1953, changing its name into that of \"Auto (Holding) Ltée \u2014 Ltd.\".Dated at the office «>f the Attorney General, this fifteenth day «>f Mav, 1959.P.FRENE'lTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12147-59) Benaby Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the sixth day of May, 1959, to the company \"Benaby Realties Ltd.\", increasing its capital stock from the sum of 850,000 to $150.000, the additional share capital being divided into 50,000 common shares «>f $1 each ami 2.000 preferred shares Class \"B\" of $25 each.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of Mav, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13295-59) Carsley's Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary 3070 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 cté accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trois juin 1959, à la compagnie \"Carslev's Limited\", augmentant son capital de §20,000 à 8200,000, le capital-actions additionne] étant divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $100 cl lacune.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.13199-59) Champlain Footwear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-six mai 1959, à la compagnie \"Champlain Slippers Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 12 mai 1955, changeant son nom en celui de \"Champlain Footwear Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENE'lTE.(P.G.12955-59) C.Kern Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-neuf mai 1959, à la compagnie \"G.Kern Ltd.\", 1° augmentant son capital de $-10,000 à $100,000, le capital-actions additionnel étant i des compagnies de Québec, par lettres patentes du 3 avril 1950, changeant son nom en celui de \"Provincial Foam Products Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51I13-0 P.FRENETTE.(P.G.13207-59) Séguin Lcclerc Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la 1a» des compagnies de (Quél>ec, il a provisions of its former letters patent respecting the privileges and restrictions attaching to the preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of Mav 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12815-59) N.M.Shahin & Company Ltd.Notice- is hereby given that under Part I of the (Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of (Quebec, dated the twelfth day of May, 1959, to the company \"N.M.Shaliin & Company Ltd.\".extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of Mav, 1959.P.FRENE'lTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13131-59) Paperman & Sons Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-fifth day of May.1959, to the company \"Paperman & Sons Inc.\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of May, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12078-58) Patct Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-seventh day of April, 1959, to the company \"Patet Corp.\".extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of April, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12992-59) Provincial Foam Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters pateid have been issued by the Lieute- ¦ nant-Governor of the Province of Quebec, dated the nineteenth day of May, 1959, to the company \"American Electronics Company Ltd.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent, of April 3.1950, changing its name into that of \"Provincial Foam Products Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of May.1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13207-59) Séguin Leelerc Inc.Notice is hereby given that under Part I of the (Quebec Companies' Act, supplementary 3070 GAZETTE OIE ICI ELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° SI été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-huit mai 1950, à la compagnie \"Séguin Sniallwares Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 1S décembre 1952, changeant son nom en celui de \"Séguin Leclerc Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.C.12704-59) St Charles Adjusters Ltd.Sl-Charles Ajusteurs Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de (Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trois juin 1959, à la compagnie \"St Charles & Charland Limited \u2014 St Charles & Charland Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de (Québec, par lettres patentes du 30 janvier 195S, changeant son nom en celui de \"St Charles Adjusters Ltd.\u2014 St Charles Ajusteurs Ltée\".Daté du \"bureau du Procureur général, le trois juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-o P.FRENE'lTE.(P.G.13025-50) Superior Plastics Inc.Avis est donné qu!en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de (Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de (Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-neuf mai 1959, à la compagnie \"Canadian European Plastics Co.Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 20 janvier 1958, changeant son nom en celui de \"Superior Plastics Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf mai 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENE'lTE.(P.G.13050-59) Vallcyfield Golf and Country Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trois juin 1959, à la compagnie \"Vallcyfield Golf and Country Club Inc.\", augmentant son capital de $80.000 à $150,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 700 actions ordinaires de $100 checune.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.12588-59) Wcedon Mining Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Ix)i des compagnies minières de (Québec et de la première partie de la des compagnies letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-eighth day of May, 1959, to the company \"Séguin Sniallwares Limited\", incorporated under the said Part I of the (Quebec Companies' Act, by letters patent of December 18, 1952, changing its name into that of \"Séguin Ix'clcrc Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of Mav, 1959.P.FRENE'lTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12704-5!)) St Charles Adjusters Ltd.St-Charles Ajusteurs Ltée Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the third day of June, 1050, to the company \"St Charles & Charland Limited \u2014 St Charles & Charland Limitée\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of January 30, 1958, changing its name into that of \"St Charles Adjusters Ltd.\u2014 St Charles Ajusteurs Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this third dav of June, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13025-59) Superior Plasties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the nineteenth day of May.1959.to the company \"Canadian European Plasties Co.Ltd.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of January 20, 1958, changing its name into that of \"Superior Plastics Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of Mav.1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13050-59) Vallcyfield Golf and Country Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the third day of June 1959, to the company \"Valley-field Golf and Country Club Inc.\", increasing its capital stock from 880.000 to 8150,000.the additional share capital being divided into 700 common shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General, this third day ofMune 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12588-59) Weedon Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that umler the provisions of the Quebec Mining Companies' Act and Part I of the Quebec Companies' Act, supplemen- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1969, Vol.91, No.SI 3077 de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du huit juin 1959, à la compagnie \"Weedon Pyrite & Copper Corporation Limited\" (No Presonal Liability), constituée en corporation en vertu de ladite lx>i des compagnies minières de (Québec, par lettres patentés du 2.S décembre 1950.et par lettres patentes supplémentaires en date, respectivement, du 0 août 1953 et du 30 décembre 1955.changeant son nom en celui de \"Weedon Mining Corporation\" (No Personal Liability).Daté du bureau du Procureur général, le hint juin 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.tary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eighth day of .lune 1959, to the company \"Weedon Pyrite & Copper Corporation Limited\" (No Personal Liability), constituted as a corporation under said the (Quebec Mining Companies' Act, by letters patent dated December 28.1050.and by Supplementary letters patent dated August 6, 1953 and December 30, 1055 respectively, changing its name to that of \"Weedon Mining Corporation\" (No Personal Liability).Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of June.1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.Ventes pour taxes Sales for Taxes Province de Québec Cité de Montréal-Nord (Comté de Laval) Avis public est, par les présentes, donné que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère, à l'hôtel de ville de Montréal-Nord, MERCREDI, le DIX-NEUF AOÛT, mil neuf cent cinquante-neuf (1959) à DIX (10) heures de l'avant-midi, heure avancée, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.La Commission Municipale de Québec, par décision en date du 2 juillet 1959, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles, sous l'autorité de la Loi des Cités et Villes, art.550, tel qu'amendé par 24 George V, chapitre 33, section 3.Province of Quebec City of Montreal-North (County of Laval) Public notice is hereby given that the properties hereinafter described will be sold by auction at the office of the council of the citv of Montreal-North, on WEDNESDAY, the NINETEENTH (10th) of AUGUST, nineteen hundred and,fifty-nine (1050) at TEN (10) o'clock in the forenoon, daylight saving time, to satisfy the payment of the municipal and school taxes, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.The Quebec Municipal Commission, by a decision, dated July 2nd 1959, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of the article 550, of Cities and Town Act, as^amended by 24, George V, chapter 33, section 3.Noms des propriétaires\tCadastre\tSubdivisions Names of proprietors\tCadastral\tSubdivisions \t5.\t0-1, 0-2, 6-3, 7.Avec bâtisse dessus érigée.Mine-Mrs.Rubin Charbonneau.I 7.Avec bâtisse dessus érigée.With building thereon erected.3.With building thereon erected.People Mutual Building Society .Mm Fisher.Avec bâtisse dessus érigée.Patrick Trottier.I 38 Avec bâtisse dessus érigée.Gérard Pigeon.Avec bâtisse dessus érigée.Claude Ouimet.I 38 A vec bâtisse dessus érigée.30.40.30,31.39,109.With building thereon erected.____I 955, 950.With building thereon erected.38.1 1005, 1000.With building thereon erected.| 1019, 1050.With building thereon erected.J.L.O'Reilly.Iicni'o Bastion.38.48.Avec bâtisse dessus érigée, James McCartney.| 86, 90 Avec bâtisse dessus érigée.J.Mario Lépine.I 86.Avec bâtisse dessus érigée.Sahastino Brunozzi.I 93.Avec bâtisse dessus érigée.1101.23, 25.With building thereon erected.I 202, 203, 475, 476.With building thereon erected.I 247, 248.With building thereon erected.| 400, 401, 416, 417.With building thereon erected. 3078 i GAZETTE GEEKlELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° SI Noms dos propriétaires Names of proprietors\tCadastre Cadastral\tSubdivisions Subdivisions \t97.\t34.215.250.\t97.\t Avec bâtisse dessus érigéV.With building thereon erected.Three Stars Films Inc.| 116.| 311,312.313.Avec bâtisse dessus érigée.Sound Construction.I 110.With building thereon erected.347, 350.Les immeubles susdits Bont tous du cadastre de la The above immoveables are all in the plan and book paroisse du Sault-au-Réoollet, et situas dans la cité, de of reference of the parish of Sault-au-Récollot and Montréal-Nord.situated in the city of Montreal North.Ladite vente sera en outre faite uvec toutes les The said sale will be made with all active unci pasM- \u2022 servitudes actives et passives OU occultes, attachées servitudes apparont or occult, attached to the said auxdits immeubles.properties.Donné en la cité de Montréal-Nord, ce vingt Given at the city of Montreal-North, this et unième (21e) jour du mois de juillet, mil neuf twenty-first (21st) day of July, nineteen hundred cent cinquante-neuf ( 1959).and fifty-nine (1050).\\a> Secrétaire-trésorier, RENÉ HERGERON, G.A.51100-30-2-O RENÉ BERGERON, C.A.51100-30-2-O Secretary-Treasurer.Province de Québec Cite de la Pointe-aux-Trembles * (Comté de Laval) Avis public est par les présentes donné que les propriétés ci-dessou s désignées seront vendues à l'enchère à l'Hôtel-de-Ville de la cité de la Pointe-aux-Trembles, MARDI, le DIX-HUITIÈME jour du mois d'AOÛT, mil neuf cent cinquante-neuf (1959), à DIX heures de l'avant-midi (heure solaire) pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêt, plus les frais subséquemment encourus, à moins (pie ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant la vente.La Commission Municipale de Québec, par décision en date du 20 juin 1959, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles, sous l'autorité de la loi des Cités et Villes, article 550, tel qu'amendé par 24 (îeorge V, chapitre 33, section 3.Province of (Quebec City of Pointe-aux-Trembles (County of Laval) Public notice is hereby given that the proper-ties hereinafter described will be sold by public mixtion at the office of the council .it the City Hall of the city of Pointe-aux-Trembles, on TUESDAY the EIGHTEENTH day of the month of AUGUST nineteen hundred and fifty-nine (1959), at TEN o'clock in the forenoon (Eastern Standard Time), to satisfy the payment of the Municipal and School taxes plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest and cost be paid before the sale.The Quebec Municipal Commission by a decision dated the 20th of June, 1959, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of the article 550, of Cities and Town Act, as amended by 24, George V, chapter 33, section 3.Noms des propriétaires\tCadastre\t\tSubdivisions Names of proprietors\tCadastral\t\tSubdivisions Archambault, Célina, épouse de-wife of François Bonneau.Charlchois, Fortunate, épouse de-wife of Raoul Dumas, Eugène Churlebois ct at.\t205.\t132.\t \t198.\t241.\t \t175.\t476, 477, 478\t Avec bâtisses y dessus érigées With buildings thereon erected.Labrie, Roger.Rémillard, Victor.Sansoucy, Albert.Smith, Curtis.Robitaillc, Clément et al.La partie sud-est, de forme irrégulière, du lot connu et désigné sous le numéro vingt-six de la subdivision du lot originaire numéro deux cent douze (pte 212-20) sur le plan et dans le livre de renvoi officiels de la paroisse de la l'ointe-nux-Tremblcs, bornée au nord-ouest par le lot originaire N° 236; au sud-est par le lot N° 212-25; au sud-ouest par partie du lot N° 212-27; au nord-est par le 55e avenue (lot N° 212-201); contenant en superficie, deux mille huit cent trente-deux pieds 28320 carrés, plus ou moins, mesure anglaise.205.:.\t942, 943.198.\t95.90.198.\t394.395.396.182.\t310.212.\t26 pt.The southeasterly part of irregular form of the lot known and designated under number twenty-six, official subdivision of original lot number two hundred and twelve (p.212-26), on the official plan and book of reference of the parish of Pointe-aux-Trembles, bounded northwesterly by the original lot No.230: southeasterly by lot No.212-25; southwesterly by part of lot No.212-27; northeasterly by the 55th Avenue (lot No.212-201); containing as area of two thousand eight hundred and thirty-two (2832') square feet, more or less, English measure. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.SI 3079 Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Cadastral Déry, R.C.211.La partie sud-est.de forme irrégulière, du lot connu et désigné sous le numéro trois cent vingt-deux de la subdivision du lot originaire numéro deux cent onze pte 211-322) sur le plan et dans le livre de renvoi officiels do la paroisse de la Pointo-au-Trembles, bornée au nord-ouest par le lot originaire numéro 230, .m sud-est par le lot N° 211-321, au nord-est par partie du lot N° 212-27 et au sud-ouest par la 54o avenue (lot N° 211-308); contenant en superficie deux mille trente-deux pieds (2032') carrés, plus ou moins, mesure anglaise.Déry, It.C.I 212.La partie sud-est.de forme irrégulière, du lot connu t désigné sous le numéro vingt-sept de la subdivision du lot originaire numéro deux cent douze (pte 212-27), sur le plan et dans le livre de renvoi officiels de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, l>ornéc an nord-ouest par le lot originaire N° 2.5t>: au sud-est par le lot No.212-24; au sud-ouest par partie du lot N° 211-322; au nord-est par partie du lot No.212-20; contenant en superficie six cent dix-neuf pieds (6190 carrés, Iilou moins, mesure anglaise.Les immeubles susdits sont tous aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, et situées dans la cité de la Pointe-aux-Trembles.Ladite vente sera en outre faire avec toutes les servitudes actives et passive-, apparentes ou occultes, atta-léea auxdits immeubles.Subdivisions Subdivisions 322 pt.The southeasterly part of irregular form of the lot known and designated under number three hundred twenty-two, official subdivision of original lot number two hundred and eleven, (p.211-322) on the official plan and book of reference of the parish of Pointe-aux-Trembles, bounded northwesterly, by the original lot No.southeasterly by lot No.211-321 ; northeasterly by part of lot No.212-27; southwesterly by the 54th avenue (lot No.211-308); containing as area of two thousand and thirty-two (20320 square feet, more or English measure.I 27 pt.The southeasterly part of irregular form of the lot known and designated under numt>cr twenty-seven, official subdivision of original lot number two hundred and twelve (p.212-27), on the official plan and book of reference of the parish of Pointe-aux-Trembles, bounded northwesterly by the original lot No.236; southeasterly by lot No.212-24; southwesterly by part of lot No.211-322; northeasterly, by part of lot No.212-20; containing as area of six hundred and nineteen 0190 square feet, more or loss, English measure.The above immoveables are all on the plan and book of reference of the parish of Pointe-aux-Trembles.and situated in the city of Pointe-aux-Trembles.The said sale will l>e made with all active anil passive servitudes, apparent or occult attached to the said properties.Donné en la cité de hi Pointe-aux-Trembles, ce vingtième jour du mois de juillet, mil neuf cent cinquante-neuf.Ix- Secrétaire-! résorier, (Signé) PAUL A.TRUDEAU.51099-30-2-0 Given at the city of Pointe-aux-Trembles, this twentieth day of July, nineteen hundred and fiftv-nine.(Signed) PAUL A.TRUDEAU, Secretarv-Treasu rer.Ô1090-30-2-o Arrêté en Conseil Order in Council ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 031 Québec le 18 juin 1959.Présent: Ix; Lieutenant-Gouverneur en conseil.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Numéro 031 Quebec, June 18, 1959.Pscsent: The Lieutenant-Governor in Council.I 'on cernant certains actes secrétariat de la Province.administratifs du concerning certain administrative agreements of the Department of the Provincial Secretary*.Ii- est ordonne, sur la proposition de l'hono- It is ordained upon the recommendation of rable secrétaire de La province: the Honourable the Provincial Secretary: III concernant le classement de l'église et du presbytère de Saint-Joachim, dans le comté de Montmorency, en vertu de la Loi des monuments et sites historiques ou artistiques.Attendu Qu'en vertu de la loi des monuments et sites historiques ou artistiques (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 70, tel que remplacé par l'article 1 de la loi 15-16 George VI, chapitre 24, modifiée par la loi 4-5 Elizabeth II, chapitre 51), la Commission des monuments et sites historiques ou artistiques, par une résolution adoptéç le 17 juin 1959, et dont copie est annexée à la proposition sur laquelle est basé le présent arrêté en conseil, a recommandé le classement, comme monuments historiques, de l'église et du presbytère de Saint-Joachim, dans le comté de Montmorency; Attendu que le propriétaire actuel de ces immeubles consent au classement précité; Attendu Qu'en vertu de l'article 0 de la Loi des monuments et sites historiques ou artistiques, III concerning the classification of the Church and Presbytery of St.Joachim, in the county of Montmorency, in accordance with the Historic or Artistic Monuments and Sites Act.Whereas under the Historic or Artistic Monument qnd Sites Act (Revised Statutes of Quebec, 1041, chapter 70, as replaced by section 1 of Act 15-10 George VI, chapter 24, amended by Act 4-5 Elizabeth II, chapter 51), the Commission of Historic or Artistic Monuments and Sites, by a resolution adopted on June 17, 1959, and of which copy is annexed to the proposition on which is based the present Order in Council, has recommended the classification of the Church and Presbytery of St.Joachim, in the county of Montmorency, as historical monuments; Whereas the present owner of said immoveables consents to the aforesaid classification; Whereas in accordance with section 0 of the Historic or Artistic Monuments and Sites Act 3080 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1969, Tome 91.N° 31 le classement d'immeubles comme monuments historiques devient définitif après avoir été approuvé, avec ou sans modification, par décret du Conseil exécutif; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le classement desdits immeubles comme monuments historiques.Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Secrétaire de la province: Qu'en vertu de l'article G de la Ix>i des monuments et sites historiques ou artistiques (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 70.tel que remplacé par l'article 1 de la Ixn 15-10 George VI, chapitre 24, modifiée par la Loi 4-5 Elizabeth II, chapitre 51), le classement des immeubles mentionnés plus haut, recommandé par la Commission des monuments et sites historiques ou artistiques, en vertu de sa résolution du 17 juin 1959, soit approuvé; Que le présent arrêté en conseil soit pubbé dans la Gazette officielle de Québec et que le classement des immeubles précités uit force de loi à compter de la date de cette publication.(S.) C.LARICHELIÈRE, 51113-o Greffier suppléant du Conseil Exécutif.Avis divers Province de Québec TOWN OF BAIE DURÉE Avis public est, par les présentes, donné que la ville de Baie d'Urfée s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour lettres patentes amendant sa charte (1 George V (2ième session) chapitre 67, modifiée par 2-3 Elizabeth II, chapitre 111) sur les matières suivantes: Changer l'orthographie de \"Ville de Baie d'Urfée\" à \"Ville de Baie d'Urfé\" et pour d'autres fins.Donné à Baie d'Urfée, ce 9c jour de juillet mil neuf cent cinquante-neuf.Le Secrétaire-trésorier, 51010-29-4-o E.M.PILKEY.(P.G.11907-57) RENAUD & FRÈRES INCORPORÉE Règlement EE \"il est résoluunanimc ment de porter le nombre des administrateurs de la compagnie de 9 qu'il était auparavant à 11 dont 0 formeront quorum et le règlement DI) de la compagnie est modifiée en conséquence.\" Certifiée vraie copie.Le Secrétaire, 51115-0 C.-E.DOUVILLE.L'HARMONIE DE RIMOUSKI INC.Avis de changement de nom Conformément à l'article 4 du chapitre 304 S.R.Q.1941, avis est donné qu'à la date du 14 juin 1959, \"La Fanfare de Rimouski\" a changé son nom en celui de \"L'Harmonie de Rimouski Inc.\".Le Secrétaire, 51125-o HENRIETTE BLAIS.the classification of immoveables as historical monuments, becomes final after approval, with or without amendments, by an order of the Executive Council; Whereas it is deemed advisable to approve the classification of the said immoveables as historical monuments.It is therefore ordained, upon the recommendation of the Honourable the Provincial Secretary : That in accordance with section 0 of the Historic or Artistic Monuments and Site Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 70, as replaced by section 1 of Act 15-10 George VI, chapter 24, amended by Act 4-5 Elizabeth II, chapter 51) the classification of the said immoveables mentioned hereinabove recommended by the Commission of Historic or Artistic Monuments and Sites Act, by virtue of its resolution of June 17, 1959, l>e approved; That this Order in Council be published in tin Quebec Official Gazette, and that the classification of the aforesaid immoveables have the force of loq a^ from the date of said publication.(S.) C.LARICHELIÈRE, 51113 Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices Province of Quebec VILLE DE BAIE D'URÉE Public notice is hereby given that the town of Baie d'Urfée will apply to the Lieutenant-Governor in Council, to secure letters patent amending the charter of the town (1 George V (2nd session) chapter 07, as amended byj}2-3 Elizabeth II, chapter 111) as follows: To amend the spelling of the \"Town offBaie d'Urfée\" to the \"Town of Baie d'Urfé\" and for other purposes.Given at Baie d'Urfée, this 9th day of July, one thousand nine hundred and fifty-nine.E.M.PILKEY, 51010-29-4-o Secretary-Treasurer.(A.G.11907-57) RENAUD & FRÈRES INCORPORÉE By-law EE \"It is unanimously resolved to increase the number of the Company's directors from 0, it-previous number, to 11 of whom 6 shall form quorum and Company's by-law 1)1) is modifie-! accordingly.\" Certified true copy.C.-E.DOUVILLE, 51115 Secretary.L'HARMONIE DE RIMOUSKI INC.Notice of change of name In conformity with article 4 of chapter 304, R.S.Q.1941, notice is given that on the 14th day of June, 1959, \"La Fanfare de Rimouski\" has changed its name into that of \"L'Harmonie d< Rimouski Inc.\".HENRIETTE BLAIS, 51125 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1969, Vol.91, No.31 3081 s( )( i ÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE LOCALE DE STE-GENEVIÈVE Avis est donne que l'honorable Secrétaire de la province a, le six juillet 1050, émis un certificat constituant en corporation la \"Société Saint-Jean-Baptiste Locale de Stc-Gcneviève\", dont le siège social est situé dans la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, dans le district judiciaire des Trois-Rivières, et ce, conformément aux dispositions des articles 15 et suivants de la Loi concernant la Société Saint-Jean-Baptiste de la région des Trois-Rivières, 3-4 Elizabeth II, chapitre 101.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le six juillet 1959.Le Sous-secré'taire de la province.51120-o RAYMOND D()lTVILLE.(P.G.10994-59) ARTISTIC INVESTMENTS LTD.Règlement spécial \"A\" Le règlement N° 2, sous-paragraphe (a) sera remplacé par le suivant: 2° (a) Nombres des directeurs et quorum (i) Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est.par les présentes augmenté de trois à quatre de manière que le bureau de direction de la compagnie soit composé dorénavant de quatre directeurs.Trois directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.(ii) Tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles ;i ieelui sont, par les présentes amendés, modifiés et révisés pour donner effet audit règlement.Décrété ce 25e jour de juin 1959.Vraie copie certifiée.Le Secrétaire-trésorier, 51135 M.RUBINFELD.PEEL BUILDING CORPORATION Règlement \"A\" SOCIÉTÉ SAÏNT-JEAN-BAPTISTE LOCALE DE STE-GENEVIÈVE Notice is given that the Honourable the Secretary of the Province has, on July sixth, 1959, issued a certificate incorporating the \"Société Saint-Jean-Baptiste Locale de Ste-Geneviève-de-Bastican\" whose head office is situated in the parish of Sainte-Geneviève, in the judicial district of Trois-Rivières, and such pursuant to the provisions of sections 15 and following of the Act concerning the \"Société Saint-Jean-Raptiste de la région des Trois-Rivières\" 3-4 Elizabeth II, chapter 161.Given at the office of the Secretary of the Province, July sixth, 1959.RAYMOND DOUVILLE, 51126 Assistant-Secretary of the Province.(A.G.10994-59) ARTISTIC INVESTMENTS LTD.Special by-law \"yl\" By-law No.2, subparagraph (a) shall be replaced by the following: 2.(a) Number of directors and quorum (i) The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three to four so that the board of directors of the company shall hereinafter be composed of four directors.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.(ii) All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to the said by-law.Enacted this 25th day of June.1959.Certified true copy.M.RUBINFELD, 51135-o Secret ary -Treasurer.PEEL BUILDING CORPORATION By-lair \"A\" Il est résolu (pie l'actif de la compagnie soit Resolved that the assets of the company be partagé au pro rata et en espèces entre les ac- divided rateably and in kind among the share- tionnaires de la compagnie, conformément aux holders of the company in accordance with the dispositions de la Loi des compagnies de Québec, provisions of the Quebec Companies' Act.Montréal, 18 juin 1959.Montreal, June 18th, 1959.Le Secrétaire, BERTHA LAZARE, 51137 BERTHA LAZARE.51137-o Secretary.Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of CHERYL-LEE DRESS & SPORTSWEAR INC.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Cheryl-Lee Dress & Sportswear Inc.\", ayant son siège social en la cité de Montréal, province de Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Montréal, 21 juillet 1951;.Le Procureur de Cheryl-Lee Dress & Sportswear Inc., BERNARD SIVAK.Suite 230, 1450 rue City Councillors, Montréal, Que.51124 CHERYL-LEE DRESS & SPORTSWEAR INC.Notice is hereby given that.\"Cheryl-Lee Dress & Sportswear Inc.\", having its head office in the city of Montreal, Province of Quebec, will make application for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Quebec Companies' Act.Montreal, July 21, 1959.Attorney for Cheryl-Lee Dress & Sportswear Inc., BERNARD SIVAK.Suite 230,1450 City Councillors St., Montreal, Que.51124-o 3082 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.1er août 1959, Tome 91, N° 81 VENTURES CLAIMS (QUEBEC) LIMITED Avis est pur lu présente donné que \"Ventures Claims (Quebec) Limited\", une corporation constituée sous la l/>i des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la ville «le Duparquet, demandera au Procutrcur général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Ce 27 juillet 1959.\\m Secrétaire, 51127-o J.T.McWHIRTER.Compagnies dissoutes (P.G.12828-58) L.DUPONT LIMITÉE Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1911.chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"L.Dupont Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 12 mai 1948.Avis est de plus donne qu'à compter du qin/.e juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.12456-58) NORMANDIE TRADING CORPORATION LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1911, chapitre 276, article 20, et sujet à la responsbailité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général «l'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Normandie Trading Corporation Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 15 août 1950.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENETTE.(P.G.10768-58) CIE GAUTHIER & GAGNÉ LTÉE Avis est donné qu'en vertu de la première §artie de la Loi des compagnies de Québec, tatuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité dédrétée par l'article 27 de ladite loi.il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la \"Cie Gauthier & Gagnée Ltée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 17 mai 1956.VENTURES CLAIMS (QUEBEC) LIMITED Notice is hereby given that \"Ventures Claims (Quebec) Limited\", a corporation constituted tinder the Quebec Companies' Act and having its head office in the town of Duparquet, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.This 27th day of July, 1959.J.T.McWHIRTER, 51127-o Secretary.Companies Dissolved -\\-¦\u2014\u2014 (A.G.12S28-58) L.DUPONT LIMITÉE Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company '\"I.Dupont Limitée\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated May 12th, 1948.Notice is also given that from and after July fifteenth, 1959, the said compagny has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of July, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12456-58) NORMANDIE TRADING CORPORATION LIMITED Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Normandie Trading Corporation Limited\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated August 15, 1950.Notice is also gievn that from adn after Jul.\\ fifteenth, 1959, the said company has been dissolved.Dated'at the office of the Attorney General, this sixteenth day of July, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10768-58) CIE GAUTHIER & GAGNÉ LTÉE Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General, has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Cie Gauthier & Gagné Ltée\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated May 17, 1956. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1969, Vol.91, No.SI 3083 Avis est de plus donné qu'à compter du quinze juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 51113-0 P.FRENE'lTE.(P.G.13465-58) DELECTA COMPANY LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loj, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Dilecta Company Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 16 octobre 1953.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze juillet 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, Ô1113-0 P.FRENETTE.(P.G.13154-58) LANE & RORITAILLE LTD.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941.chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Lane & Robitaille Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 28 septembre 1932.Avis est de plus donné qu'à compter du trente juin 1959, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le quûize juillet 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.¦r)l 113-o P.FRENE'lTE.Demande à la Législature AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que Messieurs Armin Feldmann, marchand, Baruch Werzberger, ministre, Robert Monhcit, manufacturier, Mayer Pollak, fourreur, Sandor Grun-wald, boulanger, Moric Treitel, marchand, Abraham Edelstein, manufacturier de broderie, Simon Reichman, marchand, Salamon Werzberger, ministre du culte.Majse Zanger, ministre du culte, Sochlem Waldman, marchand, David Grunfeld, bouclier, Ernst Kremer, peintre, More Schwarc, tailleur, Aron Gluck, pourvoyeur, Leib Goldstein, épicier, Alexander Gellis, rembourreur, Armin Schonfeld, retraité, Hers Monheit, marchand, Hers Lipsitz, agent de voyage, tous des cité et district de Montréal s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session pour obtenir l'adoption d'une Loi les constituant en corporation et tels autres qui peuvent devenir subséquemment membres «l'une congrégation religieuse sous le nom de Notice is also given that from and after July fifteenth, 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth of July, 1959.P.FRENETTE, 51113 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13465-58) DILECTA COMPANY LIMITED Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.sect ion 26, chapter 276 R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney (Jeneral has been pleased to accept the sur-render of the charter of the company \"Dilecta Company Limited\", incorporated under the said Part 1 of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated October 16, 1953.Notice is also given that from and after July fifteenth, 1959, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney (Jeneral, this sixteenth of July, 1059.P.FRENE'lTE, 51113 Acting Deputy Attorney (Jeneral.(A.G.13164-58) LANE & ROBITAILLE LTD.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Lane & Robitaille Ltd.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated September 28.1932.Notice is also given that from and after June thirtieth, 1950, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of July, 1959.P.FRENE'lTE, 51113 Acting Deputy Attorney (Jeneral.Application to Legislature PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that Messrs.Armin Feldmann, merchant, Baruch Werzberger, minister, Robert Monheit, manufacturer, Mayer Pollak, furrier, Sandor Grunwald, baker, Moric Treitel, merchant, Abraham Edelstein, embroidery manufacturer, Simon Reichman, merchant, Salamon Werzberger, minister, Majse Zanger, minister, Sochlem Waldman, merchant, David Grunfeld, butcher, Ernst Kremer, painter, More Schwarc, tailor, Aron Gluck, caterer, Leib Goldstein, grocer, Alexander Gellis, upholsterer, Armin Schonfeld, retired, Hers Monheit, merchant, Hers Lipsitz, travel agent, all of the city an«l district of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next Session, for the passing of an act incorporating them and such others as may hereafter become members, into a religious congregation under the name of \"Community Holy Association of United Congregations\" with the right and power 3084 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 19.59, Tome 91, N° 31 \"Community Holy Association of United Con- to acquire and hold immoveable property which gregations\", avec le droit et le pouvoir d'acquérir may be required for a synagogue or place of et détenir des propriétés immobilières qui peu- worship, for a residence for a rabbi or officiating vent être requises pour une synagogue ou lieu minister, for a cemetary or burial ground; to du culte, pour une résidence servant au rabbin sell, lease, exchange, hypothecate or alienate its ou ministre officiant, pour un cimetière ou terrain property or any part thereof; and acquire other d'inhumation, vendre, louer, échanger, hypo- immoveable property in lieu thereof; to draw, théquer ou aliéner ses propriétés ou toutes par- make, accept and endorse for its own purpose, ties d'icelles et acquérir d'autres propriétés im- bills of exchange, promissory notes and other \u2022mobilières en lieu d'icelles; rédiger, faire, ac- negotiable instruments under the signature of cepter et endosser à ses propres fins des lettres its officers or others as may l>e determined by its \u2022de change, billets promissoires et autres instru- board of directors; to keep registers for acts of incuts négociables sous la signature de ses ou civil status to appoint from time to time, a autres qui peuvent être déterminée par son bu- rabbi or rabbis or officiating minister or ministers, reau de direction; conserver des registres d'actes and to remove him or them and appoint another de statut civil, nommer de temps en temps un ou or others in his or their places, the said rabbi des rabbins ou un ou des ministres officiants, et le or rabbis and/or officiating minister or ministers, ou les remplacer et en nommer un ou des autres of the congregation to have authority and power à sa ou leurs places, ledit ou lesdits rabbins et/ou to keep registers for acts of civil status and tu le ministre ou les ministres officiants de la congre- exercise in relation thereto, all other civil powers gut ion détiendront l'autorité et le pouvoir de pertaining to ministers of religious congregations; garder des registres concernant les actes de such rabbi or rabbis and/or officiating minister statut civil et les exercer relativement à iceux, or ministers shall not need to obtain a licence from tous autres pouvoirs civile propres aux ministres the Governor or person administering the Gode congrégations religieuses; tel rabbin ou vernment as enacted in the Act of the lato rabbins et/ou ministre ou ministres officiants Province of Lower Canada, 9-10, George IV, ne seront pas tenus «l'obtenir un permis du Gou- ch.75, and shall nevertheless have all the powers verneur ou personne administrant le Gouverne- conferred by the said Act on ministers so liment tel que décrété dans la Loi de l'ancienne censed; and to take over the assets and liabilities province du Has Canada, 9-10, George IV, cha- of any other similar corporation or other institu-pitre 75, et aura néanmoins tous les pouvoirs tion of a similar nature with the consent of the conférés par ladite Loi relativement aux ministres said corporation or institution, ainsi licenciés; et assumer l'actif et les obligations de toute autre corporation similaire ou autre institution de même nature, avec le consentement de ladite corporation ou institution.Montréal, le 12 mars 1959.Montreal, March 12.1959.Le Procureur de la requérante, LOUIS DINER, Q.C., 50976-28-4 LOUIS DINER C.R.50976-28-4-o Attorney for Petitioners.Département de l'Instruction Publique Department of Education N° 670-59 MUNICIPALITÉ SCOLAIRE DE PREISSAC Demande est faite de rectifier les limites de la municipailé scolaire «le Preissac, comté d'Abiti-bi-Est, de manière qu'elles comprennent à l'avenir le territoire ci-dessous décrit, savoir: Tous les lots des rangs 1 à 10 inclusivement «lu canton Preissac; les lots 1 à 44 inclusivement des rangs I, II, III du canton Villcmontel; les lots 33 à la limite est du canton des rangs 1 à 10 du canton \\m Pause.Québec, le 20 juillet 1959.Le Surintendant «le l'Instruction publique, 51133-31 -2-o O.J.DÉSAULNTERS.N° 568-59 MUNICIPALITÉ SCOLAIRE DE PASCALIS Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté en conseil N° 680.en «late du 14 juillet 1959, de changer le nom «le la municipalité scolaire de Pascalis, dans le comté d'Abitibi-Est, en celui de Perron, même comté.Ce changement prendra effet le 9 août 1959.Québec, le 27 juillet 1959.Le Surintendant «le l'Instruction publique, 51136-0 O.J.DÊSAULNIERS.No.070-59.SCHOOL MUNICIPALITY OF PREISSAC Application is made to rectify the limits of the school municipality of Preissac, county of Abitibi-East, so that they will in future comprise the territory herebelow described, to wit: All lots of ranges 1 to 10 inclusively of the township of Preissac; lots 1 to 44 inclusively of ranges I, II, III of the township of Villemontel; lots 33 to the east limit of the township of ranges 1 to 10 of the township La Pause.Quebec, July 20, 1959.O.J.DÉSAULNTERS, 51133-31 -2 Superintendent of Education.No.568-59.SCHOOL MUNICIPALITY OF PASCALIS His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council No.680 dated July 14, 1959, has been pleased to change the name of the school municipality of Pascalis, in the county of Abitibi-East, into that of Perron, same county.This change will take effect on August 9, 1959.Quebec.July 27, 1959.O.J.DÉSAULNIERS, 51136 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.81 3085 N° 602-59.MUNICIPALITÉ SCOLAIRE DE STE-C.ENEVIÈVE N° 1 Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Ste-Gcneviève N° I, dans le comté de Jacques-Cartier, en celui «le Ste-Geneviève-de-Picrrefonds, même comté.Québec, le 28 juijlet, 1959.fie Surintendant de l'Instruction publique, 51139-31-2-0 O.J.DÉSAULNTERS.No.602-59.SCHOOL MUNICIPALITY OF STE-GENEVIÈVE No.1 Application is ma«le t«> change the name of the school municipality of Ste-Geneviève, No.1, in the county of Jac«pies-Cartier, into that of Ste-Geneviève-de-Pierrefon«ls, same countv.Quebec, July 28.1959.O.J.DÉSAULNTERS, 51139-31-2 Superintendant of Education.N° 1225-58.MUNICIPALITÉ SCOLAIRE DE LAC-AU-SAUMON Demande est faite «le former une nouvelle municipalité scolaire distincte, sous le nom de Lac-au-Saumon, dans le comté «le Matapédia, laquelle comprendra le territoire actuel des municipalités scolaires «le la paroisse et «lu village de Lae-au-Saumon, même comté.Québec, le 28 juillet 1959.Ia: Surintendant de l'Instruction publique, 51140-31-2-o O.J.DÉSAULNTERS.N° 1225-58.SCHOOL MUNICIPALITY OF LAC-AU-SAUMON Application is made to form a separate new school municipality under the name of Lac-au-Saumon, in the county of Matape«lia.which shall comprise the present territory of the school municipalities of the parish ami of the village of Lac-au-Saumon, same countv.Quebec, July 28, 1959.O.J.DÉSAULNTERS, 51140-31-2 Superintendant of Education.Département des Terres et Forêts Department of Lands and Forest AVIS Cadastre officiel «lu canton «le Buckingham (municipalité de village «le Masson) division d'enregistrement «le Papineau.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 10-A-l-l et les lots 10-A-1-2 à 10-A-1-5, 10-R-l-l à 10-R-1-6 sont annulés en vertu «le l'article 2174A du Code civil.Québec, le 9 juillet 1959.lie Département «les Terres et Forêts.Service «lu Cadastre, Le Sous-ministre, 5II14-0 AVI LA BÉDARD.NOTICE Officiai cadastre «>f township of Buckingham (municipality of the village of Masson) registration division of Papineau.Notice is herehv given that a part of lot 10-A-l-l and lots 10-A-1-2 to 10-A-1-5.10-R-l-l to 10-R-1-6 are cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec.July 9.1959.Department of Lands ami Forests.( 'adastral Branch, AVI LA BÉDARD.51114-0 Deputy Minister.Cadastre officiel du canton de Dablon (municipalité de village «le Lac-Bouchette) division d'enregistrement «le Lac St-Jean-Ouest.Avis est par la présente «lonné que le lot 12-D «lu rang V est annulé et le lot 1.2-A est amendé en vertu «le l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 juillet 1959.Ia' Département «les Terres et Forêts, Service du Cadastre, IiC Sous-ministre, 51114-0 AVI LA BÉDARD.Cadastre officiel «le la paroisse «le St-Colomb de Sillery (municipalité de cité «le Sillery) division «l'enregistrement «le Québec.Avis est par la présente donné que le lot 204-1 est annulé en vertu de l'article 2174A «lu Code civil.Québec, le 17 juillet 1959.I.er 1953, carrying on a theatre business at Rouyn, P.Q.under the name, style ami firm of \"Alexander Theatre\" and owning certain immoveables.The above named Tafik Farrah.Eva Farrah, Willie Farrah, Abdella Farrah.Mary Farrah-Ellis and Nellie Farrah-Allevato appearing herein as heirs and legal successors to the said late Annse Dawood Farrah.Given at Rouyn.P.Q., this 29th dav of June 1959.J.-L.LEPINAY.C.A., 51116-0 Liquidator.Department of Finance Insurance Notice of cancellation of registration Whereas \"The Connecticut Fire Insurance Company\", whose head office is situate in Hartford, Connecticut, United States of America, has reinsured all its business in the province of Quebec with \"Phoenix Insurance Company\", whose head office is situate in Hartford, Connecticut, United States of America, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 12th of June, 1959; Whereas \"The Connecticut Fire Insurance Company\" has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the registration of \"The Connecticut Fire Insurance Company\" has been cancelled as from the 1st of July, 1959.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 13th of July, 1959.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 51086-30-2-o Superintendent of Insurance.Appointments Notice is given that His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to appoint, by Order in Council number 582.dated June 10, 1959, Messrs Marcel Cinq-Mars and Normand Grimard, advocates, members of the Rar of the Province, and practising their profession in the city of Rouyn: Queen's Counsel.Given at the office of the Provincial Secretary, the twenty-second dav of July, 1959.RAYMOND DOUVILLE, 51113-0 Assistant Secretary of the Province. 3090 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÊBE(\\ Québec, 1er août 1969, Tome 91, N° SI Sièges sociaux AUTOLEC SERVICES (QUEBEC) LIMITED Avis est, pur les présentes, donné que la compagnie \"Autolec Services (Quebec) Limited\", constituée en corporation conformément aux dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes, en date du 24e jour de février 11)59, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en la province de Québec, a établi son bureau à chambre 1,900.507 Place d'Armes.Montréal.P.O.A compter de la date «le cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme «''tant son siège social.Daté à Toronto, i des compagnies de Québec, le 26c jour de mars 1959, et ayant son siège social en la cité «le Montréal, en ladite province, a établi son bureau à 2455 rue Desautels, en ladite cité.' A compter de la date de cet avis ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté en la cité de Montréal, ce 31e jour de mars 1959.Le Secrétaire.51119 ARTHUR SCHIPPER.SENIOR HOLDINGS LIMITED Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Senior Holdings Limited\", constituée en corporation, dans la province de Québec par lettres patentes, émises conformément à la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, le 17e jour d'avril 1959, a établi son siège social à 1477 ouest, rue Sherbrooke, en la cité de Montréal, P.Q.Daté à Montréal, ce 17e jour «l'avril 1959.Le Président, 51120 CLIFFORD GEORGE MEEK.Head Offices autolec: SERVICES (QUEREC) LIMITED Notice is hereby given that \"Autolec Services (Quebec) Limited\", incorporated pursuant to the provisions of Part i of the Quebec Companies' Act by letters patent dated February 24th, 1050, and having its head office at the city of Montreal, in the Province of Quebec, has established its office at Room 1.9C0.507 Place d'Armes.Montreal.P.Q.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Toronto, this 10th day of duly.1959.Autolec Services (Quebec) Limited, Per: A.C.FIELD, 511 l~-t> Secretary.L.L.LOZEAU LTÉE Notice is hereby given that \"L.L.Lozeau Ltée\", incorporated by letters patent umler the Quebec Companies' Act on the 31st day of March.1959, having changed its name from \"Laurent Lozeau Limitée*', originally registered into the above mentioned name by supplementary letters patent dated June 4th.1059, and having its head office in the Province of Quebec, at Montreal, has established its office at number 6,229 St.Hubert Street, in the city and district of Montreal.From and after the «late of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office «>f the company.Dated at Montreal, this 16th day of June 1959.(Seal) L.LAURENT LOZEAU, 51118-0 President.Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal In the matter of : LONDON ZIG ZAG SPRING LTD.Notice of location of head office Notice is hereby given that \"London Zig Zag Spring Ltd.\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 26th day of March.1959, ami having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its head office at 2455 Desautels Street, in the said city.From and after the «late of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at the city of Montreal, this 31st daj «)f March.1959.ARTHUR SCHIPPER, 51119-0 Secretary.SENIOR HOLDINGS LIMITED Notice is hereby given that \"Senior Holdings Limited\", incorporated in the Province of Quebec by letters patent, granted under Fart I of the Quebec Companies' Act, on the 17th day of April, 1959.has established its head office at 1477 Sherbrooke Street West, in the city of Montreal.P.Q.Dated at Montreal, this, 17th day of April.1959.CLIFFORD GEORGE MEEK.51120-o President. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.31 3091 (V.G.12000-56) CLEAR-VIEW WINDOW CLEANING CO.LTD.Règlement numéro 100 (qui est un règlement changeant le siège social de la compagnie) \"Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Clear-View Window Cleaning Co.Ltd.\" epie le siège social de la compagnie soit et il est, par les présentes, transporté de 1575 rue Rochon, Montréal, P.Que., à 1200 rue Foment, ville St-Martin, F.Que.\" Je, le soussigné\", J.Plez.secrétaire de \"Clear-View Window Cleaning Co.Ltd.\", certifie, par les présentes, que le précédent est une copie véritable et authentique du règlement N° 100 de \"Clear-View Window Cleaning Co.«Ltd.\", décrété à l'unanimité par les directeurs de ladite compagnie à une assemblée tenue le 28 octobre 1958, et approuvé suhséqucmmcnt à ladite date par tous les actionnaires de la compagnie à une assemblée générale spéciale tenuecette fin.Ville St-Martin, 28 octobre 1958.Le Secrétaire, 51121 J.l'LEZ.COMMODITY INVESTMENT CORP.Avis est.par les présentes, donné que la compagnie \"Commodity Investment Corp.\", constituée en corporation par lettres patentes en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 31 janvier 1959, a établi son siège social à 5757 avenue Deeelles.en les cité et district de Montréal.Daté à Montréal, ce quinzième jour de juillet 1959.(Sceau) Le Secrétaire, 51122 LAWRENCE MARKS.GUY LEMIEUX INC.Avis est donné (pie la compagnie \"Guy Lemieux Inc.\", constituée en corporation en date du 25 octobre 1957, ayant son bureau principal dans la ville de Roxboro, district de Montréal, a établi son bureau au numéro 10409 ouest, boulevard Gouin, à Roxboro.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 23 juillet 1959.Le Procureur.51123-0 G L'Y GUÉRIN, avocat.Soumissions Province de Québec LES SYNDICS D'ÉCOLES PROTESTANTES POUR LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE ST-HILAIRE (Comté de Rouville) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, W.G.Higgs, secrétaire-trésorier, \"Otter-burn Heights\", comté de Rouville, jusqu'à 8.00 heures p,m., lundi 17 août 1959, pour l'achat de 8350,000.00 d'obligations des Syndics d'Écoles (A.G.12000-56) CLEAR-VIEW WINDOW CLEANING CO.LTD.By-Laiv number 100 (being a by-law changing the head office of the company) \"Be it and it is hereby enacted as a Ry-law of the \"Clear-View Window Cleaning Co.Ltd.\", that the head office of the company be and it is hereby changed from 1575 Rochon Street, Montreal, P.Que., to 1200 Froment Street, ville St.Martin, P.Que.\" I, the undersigned, J.Plez, secretary of \"Clear-View Window Cleaning Co.Ltd.\", hereby certify that the foregoing is a true and exact copy of By-law No.100 of \"Clear-View Window Cleaning Co.Ltd.\", unanimously enacted by the Directors of the said company at a meeting held on October 28th 1958, and subsequently approved on the said date by all of the shareholders of the company at a special general meeting held for the purpose.Ville St.Martin, October 28th, 1958.J.PLEZ, o 51121-0 Secretary.COMMODITY INVESTMENT CORP.Notice is herewith given by \"Commodity Investment Corp.\", incorporated by letters patent umler Part I of the Quebec Companies' Act on January 31, 1959, has established its head office at 5757 Dccclles Avenue, in the city and district of Montreal.Dated at Montreal, this fifteenth dav of July, 1959.(Seal) LAWRENCE MARKS, 51122-0 Secretary.GUY LEMIEUX INC.Notice is given that the company \"Guy Lemieux Inc.\", incorporated under date of October 25, 1957, having its head office in the town of Roxboro, district of Montreal, has established its office at number 10499 West, Gouin Boulevard, at Roxboro.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 23rd dav of July.1959.GUY GUÉRIN advocate, 51123 Attorney.Tenders Province of Quebec THE PROTESTANT SCHOOL TRUSTEES FOR THE MUNICIPALITY OF THE VILLAGE OF ST.HILAIRE (County of Rouville) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned W.G.Higgs, secretary-treasurer, Otterburn Heights, county of Rouville, until 8.00 o'clock p.m., Monday, August 17th, 1959, for the purchase of an issue of 8350,-000.00 of bonds of the Protestant School Trustees 3002 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° SI Protestantes pour la Municipalité du village de St-Hilaire (Rouville) datées du 1er juin 1959 et remboursables par séries du 1er juin 1900 au 1er juin 1079 inclusivement, avec intérêt à un taux non-inférieur à Wf/c, ni supérieur à 5l/&% par année payable seini-annuclleinent les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt datée du 31 mars 1959, telle ipie modifiée \u2014 Construction d'une école de dix classes.Aux fins de l'adjudication seulement, le calcul de l'intérêt sera fait à compter du 1er septembre 1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 9350,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1960.x $35,500.00 1er juin 1901.x 37,500.00 1er juin 1962.x 39,500.00 1er juin 1963.x 42,000.00 1er juin 1964.x 44,000.00 1er juin 1965 .6,500.00 1er juin 1966.7,000.00 1er juin 1967 .7,500.00 1er juin 1968 .8,000.00 1er juin 1969 .8,500.00 1er juin 1970 .9,000.00 1er juin 1971.9,500.00 1er juin 1972.10,000.00 1er juin 1973.10,500.00 1er juin 1974.11,000.00 1er juin 1975.11,500.00 1er juin 1976.12,000.00 1er juin 1977.13,000.00 1er juin 1978.13,500.00 1er juin 1979.14,000.00 Ix's \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi de $199,-316.80 accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $39,803.30 chacun, de 1960 à 1964 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.De plus, des soumissions pourront être envoyées et seront considérées pour des obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans., Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Beloeil, comté de Verchères.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, et au siège social de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juin 1966 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, avant le 1er juin 1967 inclusivement si elles sont émises à courte échéance quinze ans, ou avant le 1er juin 1909 inclusivement si elles sont émises à courte échéance vingt ans; après ces dates, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert com- for the municipality of the Village of St.Hilaire (Rouville), dated June 1st.1959 and redeemable serially from June 1st, 1960 to June 1st, 1979 inclusively, with interest at a rate not less than *W/o »°r more than 5J^% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the hole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated March 31st, 1959, as modified \u2014 Construction of a ten-classroom school.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from September 1st, 1959.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 9360.000.00 \u2014 20 years Year Capital June 1st, 1960.x $35,500.00 June 1st.1961.x 37.500.00 June 1st.1962.x 39.500.00 June 1st, 1963.x 42,000.00 June 1st, 1964.x 44,000.00 June 1st.1965 .6,500.00 June 1st, 1966 .7,000.00 June 1st.1967.7,500.00 June 1st, 1968 .8,000.00 June 1st, 1969.S.500.00 June 1st, 1970 .9,000.00 June 1st, 1971.9,500.00 June 1st, 1972.10,000.00 June 1st, 1973.10,500.00 June 1st, 1974.11,000.00 June 1st, 1975.11,500.00 June 1st, 1976.12.000.00 June 1st, 1977.13,000.00 June 1st.1978.13,500.00 June 1st.1979.14,000.00 The letters \"x\" indicate the years (hiring which annual payments of a total amount of $199,316.80 granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of $39,863.36 each, from I960 to 1964 inclusively, will be received and applied to the service of the said loan.Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered for ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Reloeil, countv of Verchères.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, and at the main office of the said bank in Toronto.The said bonds shall not be callable prior to maturity before June 1st, 1906 inclusively if issued at short-term ten-year, before June 1st.1967 inclusively if issued for short-term fifteen-year, or before June 1st, 1969 inclusively if issued for the twenty-year-term; after these bitter dates, the said bonds arc, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.SI 3093 comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des Syndics d'Écoles Protestantes qui sera tenue lundi 17 août 1959, à 8.00 heures p.m., à l'École \"Mountainview\", Otterburn Heights, comté de Rouville.Les Syndics d'Ecoles Protestantes se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Otterbun Heights, (Comté de Rouville), ce 14e jour de juillet 1959.Le Secrétaire-trésorier, W.G.HIGGS.Otterbun Heights, (Rouville), P.Q.Téléphone: WEllington 2-8422 à Montréal.51134 accrued on the bonds to the date o£ their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will he opened and considered at a meeting of the Protestant School Trustees to be held on Monday, August 17th, 1959, at 8.00 o'cloek p.m., at the Mountainview School, Otter-burn Heights, county of Rouville.The Protestant School Trustees do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Otterburn Heights, (County of Rouville).this 14th of July, 1959.Secretary-Treasu rer.W.G.HIGGS.Otterburn Heights.(Rouville), P.Q.Telephone: WEllington 2-8422 in Montreal.51134-o Province de Québec Province of Quebec VILLE D'ASBESTOS TOWN OF ASBESTOS (Comté de Richmond) (County of Richmond) Avis public est par les présentes donné que des Public notice is hereby given that sealed soumissions cachetées et endossées \"Soumissions tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be pour obligations\" seront reçues par le soussigné received by the undersigned J.-H.-L.Olivier, J.-H.-L.Olivier, secrétaire-trésorier, Hôtel de Secretary-Treasurer, Town Hall, Asbestos, coun- Ville, Asbestos, comté de Richmond, jusqu'à ty of Richmond, tintil 8.00 o'clock p.m.Wed- 8.00 heures du soir, mercredi, le 19 août 1959 nesday, August 19, 1959, for the purchase of an pour l'achat de $124,000.00 d'obligations de la issue of $124,000.00 of bonds for the town of ville d'Asbestos, comté de Richmond, datées Asbestos, county of Richmond, dated July 1st, du 1er juillet 1959 et remboursables par séries 1959, and redeemable serially from July 1st, du 1er juillet 1960 au 1er juillet 1979 inclusive- 1960 to July 1st, 1979 inclusively, with interest nient, avec intérêt à un taux non inférieur à at a rate not less than 4nor more than 5 \\x/2% ui supérieur à 5^%, par année, payable per annum payable semi-annually on January semi-annuellement le 1er janvier et 1er juillet 1st and July 1st of each year.The rate of de chaque année.Le taux «l'intérêt peut être interest may be the same for the whole issue le même pour toute l'émission ou il petit varier or it may vary according to maturities, suivant les échéances.Règlements d'emprunts numéros 388 \u2014 $67,- Loan by-laws numbers 388 \u2014 $67,000.00 \u2014 000.00 \u2014 pavage et construction de trottoirs \u2014 paving construction of sidewalks \u2014 391 \u2014 work 391 \u2014 travaux d'aqueduc et rénovation du on aqueduct and renovation of electrical sys- réseau électrique \u2014 $57,000.00.teni \u2014 $57,000.00.Pour fins (l'adjudication seulement, le calcul For adjudication purposes only, interest d'intérêt sera fait à compter du 1er septembre shall be calculated as from September 1st, 1959.1959.Le tableau d'amortissement est le suivant: The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 9184,000.00 \u2014 SO ans Table of redemption \u2014§124,000.00 \u201420 years Année Capital Year Capital 1er juillet 1960.$6,000.00 July 1st, 1900.$0,000.00 1er juillet 1961.6,000.00 July 1st, 1961.6,000.00 1er juillet 1962.6,000.00 July 1st, 1902.0,000.00 1er juillet 1963 .7,000.00 July 1st, 1963 .7,000.00 1er juillet 1964.0,000.00 July 1st, 1964 .6,000.00 1er juillet 1965.0,000.00 July 1st, 1965 .6,000.00 1er juillet.1966.7,000.00 July 1st, 1966.7,000.00 1er juillet 1967 .6,000.00 July 1st, 1967 .6,000.00 1er juillet 1968 .6,000.00 July 1st, 1968.6,000.00 1er juillet 1969.7,000.00 July 1st, 1969 .7,000.00 1er juillet 1970.6,000.00 July 1st, 1970 .0,000.00 1er juillet 1971.0.000.00 July 1st, 1971.0,000.00 1er juillet 1972 .7,000.00 July 1st, 1972 .7,000.00 1er juillet 1973 .0,000.00 July 1st, 1973.6,000.00 1er juillet 1974.6,000.00 July 1st, 1974 .0,000.00 1er juillet 1975.7,000.00 July 1st, 1975.7,000.00 1er juillet 1976.6,000.00 July 1er, 1976 .6,000.00 1er juillet 1977 .5,000.00 July 1st, 1977 .5,000.00 1er juillet 1978.6,000.00 July 1st, 1978.6,000.00 1er juillet 1979.6,000 00 July 1st, 1979.6,000.00 De plus, des soumissions pourront être en- Moreover, tenders may be forwarded and shall voyées et seront considérées pour des obligations be considered as ten-year short-term and fif- à courte échéance dix ans ou à courte échéance teen-year short-term bonds.However, tenders quinze ans.Cependant, les soumissions ne de- shall be considered for one of the three terms vront comporter qu'un seul des trois termes, only.Adjudication shall be made according to L'adjudication sera faite conformément à la loi.law. 3094 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêt courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Asbestos, comté de Richmond.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas raehetables par anticipation avant le 1er juillet 1966 inclusivement si elles sont émises à courte échéance dix ans, avnt le 1er juillet 1907 inclusivement si elles sont émises à courte échéance quinze ans, ou avant le 1er juillet 1969 inclusivement si elles sont émises pour le ternie de vingt ans; après ces dates lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1911.être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend on ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 19 août 19.59 à 8.00 heures du soir, à l'Hôtel tie Ville.Asbestos, comté de Richmond.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Asbestos.(Comté de Richmond), ce 28 juillet 1959.Le Secrétaire-trésorier, .J.-H.-L.OLIVIER.Adresse postale: C.P.9, Hôtel de Ville, Asbestos, (Richmond).P.Q.Téléphone: 116.51138-0 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any.by certified cheque payable at par at Asbestos, county of Richmond.Capital and interest aie payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank-mentioned in the loan procedure.The said bonds will not he redeemable by antcipation prior to July 1st, I960 inclusively, if issued as ten-year short-term bonds, prior t July 1st, 1907 inclusively, if issued as fifteen-year short-term bonds, and prior to July 1st, 1969 inclusively, if issued for a twenty-yea' term, after which dates the bonds are, under authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redemed by anticipation, en whole or in part, at par, at any inte lest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of tit present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their dc livery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to he held on Wedncs day, August 19, 1959, at 8.00 o'clock p.m., al the Town Hall, Asbestos, county of Richmond.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Asbestos, (County of Richmond), July 28, 1959.J.-H.-L.OLIVIER, Secretary-Treasu rcr.Postal address: P.O.R.9, Town Hall, Asbestos.(Richmond), P.Q.Telephone: 116.51138 Vente \u2014 Loi de faillite Canada, province de Québec, district de Québec, Cour Supérieure (En matière de faillite) N° 6250-F.Dans l'affaire dc la faillite de Roméo Grenier, aviculteur et cultivateur, rang 1, Ste-Louisc, comté de LTslet, débiteur.AVIS DE VENTE Avis est par les présentes donné que: \"MERCREDI, le DIX-NEUF d'AOUT 1959, à TROIS heures et TRENTE p.m., seront vendus par encan public, à la porte de l'église dc la paroisse de Ste-Louise, comté de LTslet les immeubles ci-après décrits, savoir: Item A) \"Un terrain faisant partie du lot désigné sous le numéro deux cent soixante et un (261) au cadastre officiel de la paroisse de St-Roch-des-Aulnaiès, contenant deux arpents dc largeur et trois arpents de profondeur environ, borné au nord-ouest par un ruisseau, au nord-est par le lot deux cent soixante-deux appartenant à Xavier Morin, au sud-est par le chemin de front ou fronteau «lu rang, au sud-ouest par le lot deux cent soixante appartenant à Atlianase Fortin ou représentants.\" Item R) \"Une ferme faisant partie du lot désigné sous le numéro soixuntc-dix-sept (77) au cadastre officiel de la paroisse de Ste-Louise, contenant environ quatre arpents de front sur une Sale \u2014 Bankruptcy Act Canada, Province of Quebec, district of Quebec.Superior Court (Sitting in Bankruptcy) No.6250-F.In the matter of the bankruptcy of Roméo Grenier, poultry-keeper and farmer, range 1, Ste-Louise, county of ITslet, debtor.NOTICE OF SALE Notice is herebv given that, on WEDNESDAY.AUGUST NINETEENTH, 1959,.at THREE o'clock and a HALF p.m., shall be offered for sale by public auction, at the church door of the parish of Ste-Louise, county f ITslet, the immoveables hereinafter described, to wit : Item A) \"A lot of land forming part of lot designated umler number two hundred and sixty-one (261) in the official cadaster of the parish of St-Roch-des-Aulnaies, containing two arpents in width and three arpents in depth approximately, bounded on the northwest by a brook, on the northeast by lot two hundred and sixty-two belonging to Xavier Morin, on the southeast, by the front road or ledge of range, on the southwest, by lot two hundred and sixty belonging to Athanasc Fortin or representatives.\" Item R) \"A farm forming part of lot designated under number seventy-seven (77) in Unofficial cadaster of the parish of Ste-Louise, containing approximately four arpents in front QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1950, Vol.91, No.31 3095 profondeur de trente arpents, bornée au nord-ouest par le fronteau du rang, au nord-est par le lot soixante-dix-huit appartenant à Arthur Fortin, nu sud-est par le résidu du lot soixante-dix-sept appartenant à Joseph G am ache et Zéphirin Dubé, au sud-ouest par le lot soixante-seize appartenant à Armand Michaml, avec constructions et dépendances.\" Item C) \"Un terrain faisant partie du lot désigné sous le numéro treize (13) au cadastre officiel dc la paroisse «le Saint-Aubert, comté «le l'fslet contenant trois arpents «le largeur sur une profondeur «le seize arpents environ, borné au nord-ouest par le chemin «le front, au nord-est par le lot numéro dix appartenant à Maurice Robichaud, au sud-est par le résidu dudit lot numéro treize appartenant à Elphègc Grenier et au sui de faillite.Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: argent comptant.Québec, 13 juillet 1959.Les Svndics, JOSEPH MARMETTE & RENÉ LEFAIVRE.Bureaux : 111, Côte de la Montagne, Québec.51055-29-2-o along a depth of thirty arpents, bounded on the northwest by the front ledge of the range, on the northeast by lot seventy-eight, belonging to Arthur Fortin, on the southeast, by the residue of lot seventy-seven belonging to Joseph Gama-che and Zéphirin Dubé, on the southwest by lot seventy-six belonging to Armand Michaml, with constructions ami dependencies.\" Item C) \"A lot of land forming part of lot designated umler number thirteen (13) in the official cadaster of the parish of Saint Aubcrt, county «>f I.'Islet, containing three arpents in width along a depth of sixteen arpents approximately, bounded on the northwest by the front road, on the northeast by lot number ten belonging to Maurice Robichaud, on the southeast by the residue of the said lot number thirteen belonging to Elphègc Grenier ami on the southwest by lot number fourteen belonging to Josephat Gaudreau.Umler reserve of a right-of-way which may exist on this immoveable in favor of Olivier Talbot or representatives, on the terms of a sale passed on March nineteenth, one thousand nine hundred and registered under number 32101.\" Items A-B-C shall be offered for sale to the last and highest bidder with rents as a charge thereon and Church apportionments which may exist as well subject to the servitudes both active and passive.Titles and certificates may be examined at all times by applying to the office of the undersigned.This sale is made in accordance with articles 710.717 and 719-A of the Code of Civil Procedure and also article 55 of the bankruptcy Act.This sale is equivalent to a sale made by Sheriff.Conditions of payment: cash.Quebec, July 13, 1959.JOSEPH MARMETTE & RENÉ LEFAIVRE, Trustees.Offices: 111 Mountain Hill, Quebec.51055-29-2 VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC, est par le présent donné «pie les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Québec St-Joscph de Bcauce, l T TNITED LOAN COR-N° 95-981, ) U PORAÏTON, cor-à savoir: j poration légalement cons-\\ tituée, ayant son principal bureau «l'affairés à 420, rue Du Pont, cité et «listrict dc Québec, contre GEORGES RÉDARD, résidant et domicilié à St-Côme, comté de Bcauce, district de Bcauce, à savoir: Le lot 43 du rang 7 «lu canton de Jersey, et les bâtisses dessus construites.Pour être vendu à la porte «le l'église paroissiale, en la paroisse de St-Côme, comté de Bcauce, le QUATRIÈME jour de SEPTEMBRE prochain à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.S.POULIOT.St-Joscph «le Reauce, le 27 juillet 1959.51132-3 l-2-o [Première insertion: 1er août 1959] [Seconde insertion: 15 août 1959] SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court \u2014 District of Quebec St.Joseph dc Beauce, / T TNITED LOAN No.95-981, ) ^ CORPORATION, To wit: \\ corporation legally cons- (, tituted, having its principal place of business at 120 Du Pont Street, city ami «listrict of Quebec versus GEORGES BEDARD, residing ami domiciled at St.Come, county of Bcauce, district of Bcauce.to wit : Lot 43 of Range 7 of the township of Jersey, and the buildings thereon erected.To be sold at the door of the parochial church, in the parish of St.Come, county of Reauce.the FOURTH day of SEPTEMBER next at TEN o'clock in the forenoon.J.S.POULIOT, Sheriff's Office, Sheriff.St.Joseph «le Beauce, July 27, 1959.51132-31-2 [First insertion: August 1st, 1959] [Second insertion: August 15th, 1959] 3090 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 81 CHICOUTIMI Fieri Facias Canada \u2014 Province «le Québec District de Chicoutimi Cour Supérieure, JT OUIS MORBIER, agent N° 22,929.< d'immeubles, des cité et v district de Chicoutimi, demandeur et défendeur roronvcntionncl; vs JOE VTCERI, agent d'immeubles, de St-Jean Eudes, district de Chicoutimi.défendeur et demandeur reconventionnel.Contre le défendeur et demandeur reconventionnel: 1° Tous les droits sur l'immeuble suivant: Une propriété à Chicoutimi, sur la rue Labrosse, connue et désignée au bureau d'enregistrement de Chicoutimi, comme étant un certain terrain ou emplacement de figure parallélogrammatique, étant formé de la partie sud-ouest du lot numéro quatre quarante-huit (Ptic S.O.No.4-48), pour le neuvième rang sud-ouest du chemin Sydenham, du canton Chicoutimi, des plans et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse dc Chicoutimi.partie maintenant comprise dans les limites de la cité de Chicoutimi, division d'enregistrement de Chicoutimi, mesurant cinquante pieds (50') de largeur et est borné comme suit: en front, du côté nord-ouest par la rue Labrosse, portant le N° 4-30 en cet endroit, du côté nord-est par le résidu dudit lot N° 4-48 suivant une droite parallèle à la limite sud-ouest dudit lot N° 4-48 et distante de cette dernière vers le nord-est de cinquante (50') pieds, du côté sud-est par une partie non subdivisée du lot numéro quatre et du cédé sud-ouest par le lot numéro quatre-quarante-sept (4-47).Ce terrain ainsi délimité contient une superficie de quatre mille quatre-vingt-neuf pieds carrés (4,089') environ.Le tout avec bâtisses y érigées et toutes dépendances.2° Tout ce lopin de terre ou emplacement, formant partie du lot numéro quatre cent soixan-te-et-sept (N° 407), au cadastre officiel de la ville de Chicoutimi, mesurant environ quarante-cinq pieds (45') de largeur, de l'est à l'ouest, sur environ cent pieds de profondeur, du sud au nord, et est compris dans les bornes suivantes: Vers le nord, à la rue Price, vers l'est par la propriété de M.Armand l'Heureux, vers le sud par le terrain de François-Xavier Boudreault, et vers l'ouest par le terrain de M.Gérard Gagnon; avec ensemble toutes les bâtisses dessus érigées et toutes dépendances.Pour être vendus au bureau du shérif, au palais de justice, à Chicoutimi, le TROISIEME jour du mois de SEPTEMBRE 1950, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RENÉ DELISLE.Chicoutimi, le 27 juillet 1959.51130-31-2-o MONTRÉAL Fieri Facias dc Terris Cour de Magistrat \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: fp IT É DE CÔTE ST-N° 4SG266.< ^ LUC, demanderesse, l vs HENRI UNFRANCHISE, défendeur.Ce certain emplacement ayant front sur le Chemin Baily au coin des rues Westbourne et Regent, dans la municipalité de Côte St-Luc, en les cité et district dc Montréal et composé de: a) Un lot de terrain connu comme étant la subdivision quatre-vingt-dix-huit (98) du lot originaire numéro quatre-vingt-treize (93) aux CHICOUTIMI Fieri Facias Canada \u2014 Province of Quebec District of Chicoutimi Superior Court, l T OUIS MORRIER, real No.22,929.< -L' estate agent, of the çitj mind district of Chicoutimi, plaintiff and cross-demand defendant, vs JOE VTCERI, real estate agent, of St-Jean-Eudes, district of Chicoutimi.defendant and cross-demand plaintiff.Against the defendant and cross-demand plaintiff: 1.All rights on the following immoveable: A property at Chicoutimi, on Labrosse Street, known and designated at the registration offic.of Chicoutimi, as being a certain lot or cmplacc ment of parallelogramatic figure, being formel of the southwest part of lot number four-forty-eight (S.W.It.No.4-48), for the ninth rang.' southwest of the Sydenham Road, of the Chicoutimi township, on plan and in the book of referen ce of the official cadaster for the parish of Chicoutimi, part presently comprised within the limits of the city of Chicoutimi, registration division of Chicoutimi, measuring fifty feet (50') in width and is bounded as follows: in front, on the northwest side by Labrosse Street, bearing No.4-39 at that place, on the northeast side by the residue of the said lot No.4-48 following a straight line parallel on the southwest limit of the said lot No.4-48 and distant from the latter on the northeast by fifty (50') feet, on the south east side, by a non-subdivided part of lot number four and on the southwest side by lot number forty-seven (4-47).This lot thus delimited contains an area of four thousand eighty-nine square feet (4,089') approximately.The whol< with buildings thereon erected and all dependencies.2.All this strip of land or emplacement forming part of lot number four hundred and sixty, seven (No.467), on the official cadaster of the town of Chicoutimi measuring approximately forty-five feet (45') in width, from east to west by about, one hundred feet in depth, from south to north, and is comprised within the following boundaries: On the north, on Price Street, towards the east by the property of Mr.Armand L'Heureux, on the south, by the land of François-Xavier Boudreault, and on the west, by the Jand of Mr.Gérard Gagnon; together with all the buildings thereon erected and all dependencies.To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, at Chicoutimi, on the THIRD day i the month of SEPTEMBER, 1959.at THREE o'clock in the afternoon.RENÉ DELISLE.Sheriff's Office, Sheriff.Chicoutimi, July 27, 1959.51130-31-2 MONTREAL Fieri Facias de Terris Magistrate's Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: fpiTÉ DE CÔTE ST-No.486266.\\ ^ LUC, plaintiff, v.-\\ HENRI LA FRANCHISE, defendant.That certain emplacement facing Baily Road on the corner of Westbourne and Regent Streets, in the municipality of Côte St.Luc, in the city and district of Montreal and composed of: a) One lot of land known as subdivision ninety-eight (98) of the original lot number ninety-three (93) on the official plan and book QUEBEC OFFICIA L GAZETTE.Quebec, August Ut, 1959, Vol.91.No.SI 3097 plan et livre de renvoi officiels de la-paroisse de Montréal; 6) Une partie d'un lot vacant ayant front sur le Chemin Baily, Côte St-Luc, étant une partie du lot mil soixante-dix-neuf (1079) de la subdivision d'un lot portant le numéro quatre-vingt-treize (93) aux plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse dc Montréal, mesurant douze pieds (12') dans les lignes ouest-est et cent pieds (100') respectivement dans les lignes nord-sud et bornée: A l'est en front par une autre partie de la subdivision numéro mille soixante-dix-neuf (1079) étant une partie du Chemin Haily; en arrière à l'ouest l'emprise du C.P.R.connue comme étant le lot quatre mille sept cent douze (4712) aux plan et livre ce renvoi officiels mentionnés ci-dessus de la paroisse de Montréal; au côté nord par la subdivision quatre-vingt-dix-huit (98) audit lot quatre-vingt-treize (93) au côté sud par une autre partie de la subdivision mille soixante-dix-neuf (1079), mesurant cinquante-quatre pieds (54') de largeur par cent pieds (100') de profondeur.Avec la construction dessus érigée portant le numéro civique 6861 Chemin Baily, dans la municipalité de Côte St-Luc, district de Montréal.Pour être vendu, à mon bureau, en la cité de Montréal, le QUATORZIÈME jour d'AOÛT 1959, à ONZE heures du matin.Le Shérif, CAISSE & LAURENCELLE.Bureau du Shérif, Montréal, le 6 juillet 1959.509S4-28-2 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: { THE CROWN LIFE IN-N° 470594.\"J A SURANCE COMPA-vNY, demanderesse vs ROBERT D.NADEAU INC., défenderesse.\"Un emplacement ayant front sur la rue Durham, en la cité de Montréal, mesurant vingt-cinq pieds (25') de largeur par une profondeur de cent pieds (100'), mesure anglaise et plus ou moins et connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Laurent comme étant la subdivision numéro deux cent trente-quatre du lot numéro deux cent soixante-neuf (269-234).Avec la résidence dont les murs nord-ouest et sud-est sont mitoyens avec les propriétés eontigues respectives et les dépendances dessus érigées.Avec ensemble et sujette à: 1° Une servitude réciproque de droit de vue en faveur de et sur la propriété vendue présentement et en faveur de et sur la propriété y adjacente au nord-ouest et est composée du lot numéro 269-235 auxdits plan et livre de renvoi officiels, de manière à légaliser une porte dans le mur dc façade de la propriété vendue présentement et une porte qui pourrait être pratiquée sur les constructions qui pourraient être érigées sur la propriété adjacente au nord-ouest à une distance de la ligne separative entre les deux dites propriétés, laquelle est moindre que celle prescrite par la Loi, dc manière à ce que lesdites ouvertures pourraient demeurer telles qu'elles sont actuellement sur la propriété vendue présentement et telles qu'elles pourraient exister sur les constructions devant être érigées sur la propriété adjacente au nord-ouest tant que les constructions, dont elles forment respectivement partie, subsisteront.2° Une servitude de droit de vue réciproque en faveur de et sur la propriété vendue présen- of reference of the parish of Montreal; b) One part of a vacant lot, facing Baity Road, Côte St.Luc, being part of lot one thousand seventy-nine (1079) of the subdivision of a lot bearing number ninety-three (93) on the official plan and book of reference of the parish of Montreal measuring twelve feet (12') in the west-east lines and one hundred feet (100') respectively in the north-south lines and bounded: On the east front by another part of the subdivision number one thousand seventy-nine (1079) being part of Baily Road; in rear west the C.P.R.right-of-way known as lot four thousand seven hundred and twelve (4712) on the above mentioned official plan and book of reference of the parish of Montreal; on the north side by the subdivision ninety-eight (98) of the said lot nine-three (93) and on the south side by another part of the subdivision one thousand seventy-nine (1079) measuring fifty-four feet (54') in width by one hundred feet (100') in depth.With the building thereon erected bearing civic number 6861 Baily Road, in the municipality of Côte St.Luc in the district of Montreal.To be sold at my Office, in the city of Montreal, on the FOURTEENTH day of AUGUST, 1959, at ELEVEN o'clock in the forenoon.CAISSE & LAURENCELLE, Sheriff.Sheriff's Office, Montreal, July 6, 1959.50984-28-2-0 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit : I THE CROWN LIFE IN-No.470594.< 1 SURANCE COMPA-l NY, plaintiff vs ROBERT D.NADEAU INC., defendant.\"An emplacement fronting on Durham Street, in the city of Montreal, measuring a width of twenty-five feet (25') by a depth of one hundred feet (100') English measure ami more or less and known uml designated on the official plan and book of reference of the parish of St.Laurent as subdivision number two hundred and thirty-four of lot number two hundred and sixty-nine (269-234).With the dwelling house whereof the northwesterly and southeasterly walls are mitoyen with the respective adjoining porperties and outbuildings thereon erected.Together with and subject to: 1.A reciprocal servitude of right of view in favour of and upon the property presently sold and in favour of and upon the property adjoining the same to the north-west ami is composed of lot number 269-235 on the said official plan and book of reference, in order to legalize one door in the front wall of the property presently sold and one door which may be placed on the buildings which may be erected on the property adjoining to the north-west at a distance from the division line between the said two properties which is less than the distance prescribed by law, in order that the said openings may remain as is at present on the property presently hypo-sold and as it may be on the buildings to be erected on the adjacent property to the northwest as long as the buildings of which they respectively form part and may form part shall subsist.2.A reciprocal servitude of right of view in favour of and upon the property presently sold 3098 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° Si tcment et en faveur de et sur la propriété y and in favour of and upon the property adjoining adjacente au sud-est et composée du lot numéro the same to the south-east and is composed ?269-233 auxdits plan et livre de renvoi officiels, lot number 200-233 on the said official plan and de manière à légaliser certaines ouvertures qui book of reference, in order to legalize certain sont pratiquées sur les constructions érigées openings which are pluced on the buildings sur chacune desdites deux propriétés, à une erected on each of the said two properties at a distance de la ligne separative entre lesdites distance from the division line between the said deux propriétés, laquelle est moindre que celle two properties which is less than the distance prescrite par la Loi, de manière à ce que lesdites prescribed by law, in order that the said openings ouvertures pourraient demeurer telles qu'elles may remain as they are at present as long as t In sont présentement, tant que les constructions, buildings of which they respectively form pari dont elles forment respectivement partie, sub- shall subsist, sistcront.Telle que ladite propriété se trouve actuelle- As the said property now subsists with all ment avec tous ses droits, membres et apparte- its rights, members and appurtenances without nances sans exception ou réserve d'aucune sorte exception or reserve of any kind and with such et avec tels droits de passage qui existent con- rights of passage as may exist leading to lane in duisant è la ruelle à l'arrière de ladite propriété the rear of the said property and in any lanes et dans toutes ruelles y conduisant.\" leading thereto.\" Pour être vendu, à mon bureau, en la cité de To be sold at niv office, in the citv of Montreal Montréal, le QUATORZIÈME jour d'AOUT on the FOURTEENTH day of AUGUST, 1959, 1959, à DIX heures et TRENTE minutes du at TEN THIRTY o'clock in the forenoon, matin.Le Shérif, CAISSE & CAISSE & LAURENCE LEE, Bureau du Shérif, LAURENCELLE.Sheriff's Office, Sheriff.Montréal, le 6 juillet 1959.50985-28-2 Montreal, July 6, 1959.50985-28-2-.Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: N° 470596.¦ THE CROWN LIFE IN-SURANCE COMPANY, demanderesse vs ROBERT D.NADEAU INC., défenderesse.\"Un emplacement ayant front sur la rue Durham en la cité dc Montréal,' mesurant en largeur vingt-cinq pieds (25') sur une profondeur de cent pieds (100'), mesure anglaise et plus ou moins, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Laurent, comme étant la subdivision numéro deux cent trente du lot numéro deux cent soixante et neuf (269-230).Avec la maison domiciliaire semie détachée, dont le mur nord-ouest est mitoyen avec la propriété adjacente et les dépendances dessus érigées.Avec ensemble et sujette à une servitude réciproque de droit de vue en faveur de et sur la propriété présentement vendue et en faveur de et sur la propriété y adjacente au nord-ouest et qui est formée du lot numéro 209-231 aux plan et livre de renvoi officiels, de manière à légaliser certaines ouvertures qui sont pratiquées sur les constructions érigées sur chacune desdites deux propriétés à une distance de la ligne separative entre lesdites deux propriétés laquelle est moindre que la distance prescrite par la Loi, de manière que lesdites ouvertures puissent demeurer comme elles sont présentement aussi longtemps que les constructions, dont elles forment respectivement partie, subsisteront.\" Pour être vendu, à mon bureau, en la cité dc Montréal, le QUATORZIÈME jour d'AOÛT 1959, à DIX heures du matin.Le Shérif, CAISSE & Bureau du Shérif, LAURENCELLE.Montréal, 6 juillet 1959.\"50980-28-2 Fieri Facias dc Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit : I THE CROWN LIEE I\\-No.470596.< SURANCE COM PA v N Y, plaintiff vs ROBERT I).NADEAU INC., defendant.\"An emplacement fronting on Durham Street, in the city of Montreal, measuring a width of twenty-five feet (25') by a depth of one hundred feet (100') English measure and more or less and known and designated on the official plan and book of reference of the parish of St.Laurent as subdivision number two hundred and thirty of lot number two hundred and sixty-nine (269-230).With the semi-detached dwelling bouse whereof the northwesterly wall is mitoyen with the adjoining property and outbuildings thereon erected.Together with and subject to a reciprocal servitude of right of view in favour of and upon the property presently sold and in favour f and upon the property adjoining the same to tin-northwest and is composed of lot number 20'.'-231 on the said official plan and book of reference-in order to legalize certain openings which are placed on the buildings erected on each of tin-said two properties at a distance from the division line between the said two properties which is less than the distance prescribed by law, in order that the said openings may remain as they are at present as long as the buildings of which they respectively form part shall subsist To be sold at mav office, in the city of Montreal, the FOURTEENTH day of AUGUST, 1959, at TEN o'clock in the forenoon.CAISSE & LAURENCELLE, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, July 0, 1959.50986-28-2-.» Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: l t AVAL PETROLEUM N° 446426.S \u2022L' LTÉE., demanderesse Us DAME AMANDA TESSIER, veuve de Wilfrid Boismenu, défenderesse.Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit : ( t AVAL PETROLEUM No.446426.S ¦L' LTÉE., plaintiff, vs v DAME AMANDA TESSIER, widow of Wilfrid Boismenu, defendant. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1969, Vol 91, No.31 3099 \"Un emplacement situé à St-Martin, ayant Iront au Boulevard Labelle mesurant cinquante pieds de largeur par cent cinquante-neuf pieds et six pouces de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, connu et désigne connue faisant partie du lot numéro cent quinze (Ptie N° 115) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse dc St-Martin, et plus spécialement localisé comme étant le lot numéro cent quarante-six (N° 140) sur le plan de P.Ruel, en date du 14 mars, 1940, et borné comme suit: en front à l'est par le Boulevard Curé Labelle.d'un côté au nord par 1 emplacement de M.Paresse, d'un autre côté au sud par M.Pilon, et en arrière vers l'ouest par une partie du lot cent quinze appartenant à M., avec les bâtisses dessus érigées.\" Pour être vendu, à la porte de l'église paroissiale, de la paroisse St-Martin.comté de Laval, le QUATORZIÈME jour d'AOÛT 1959.à ( INZE heures du matin.!/\u2022 Shérif.CAISSE & Bureau du Shérif, LAURENC ELLE.Montréal, le 6 juillet 1959.50987-28-2-O NICOLET Fieri Facias Canada Province de Québec District de Nicole! Cour Supérieure.{ T A CAISSE POPULAIRE N° 2390.< -L* DE STE-SOPHIE DE l LÉVRARD, dans le comté de Nicolet, corps politique et légalement incorporé, ayant son siège social à Sic-Sophie de Lévrard.district de Nicolet.demanderesse, vs M.BERNARD, ARCHAMBAULT, hôtelier, autrefois domicilié et résidant à Ste-Sophie cie Lévrard.comté et «listrict de Nicolet, aujourd'hui en les ville et district de Montréal, défendeur.\"Un terrain à distraire «lu lot numéro cinq cent quarante-neuf (Ptic 549) du cadastre officiel de St-Pierre-les-Becquets, mesurant un demi arpent de largeur sur environ soixante-six pieds de profondeur dans la ligne nord-est.soit sur la route «le St-Pierre-les-Becquets à Ste-Sophie et «'«-lit cinq pieds de profondeur, dans la ligne sud-ouest en suivant la déviation «lu chemin du fiième rang: à la mesure anglaise et plus ou moins et borné comme suit: au nord-ouest au terrain «le Bruno Founder, au sud-est au chemin du tiiènie rang, au nord-est à la route publique susdite et au sud-ouest, au terrain de Dame Vve Lucien Vervillc, avec la maison, un hangar-remise et un garage privé situés à l'arrière de ladite maison, les parties étant au fait «le sa Voir «pie ledit hangar-remise «4 le garage privé sont construits et annexés à une même partie «le bâtisse dont une partie appartient au débiteur et l'autre partie à Bruno Founder, le tout qui est séparé par une cloison «le bois.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Ste-Sophie de Lévrard, comté de Nicolet.le DEUXIÈME jour de SEPTEMBRE (1950) à DIX heures de l'avant -midi.\\jc Shérif.Bureau «lu Shérif, ANTONIO RLONDIN.Nicolet, 28 juillet 1959.51141-31-2-0 QUÉBEC Fieri Facias Dans la Cour d'Échiquier du Canada Québec, à savoir: / t A LOI DE L'IMPOT N° 153038.{ *-> SUR LE REVENU.I contre ROBERT DORÉ, de Donnacona, P.Q.\"An emplacement situated at St-Martin, having frontage on Labelle Boulevard, measuring fifty feet in width by one hundred and fifty-nine feet and six inches in depth, English measure and more or less, known ami designated as forming part of l«>t number one hundred.and fifteen (Pt.No.115) on the official plan and in the book of reference for the parish of St-Martin, and more specifically localized as being number one hundred ami forty-six (No.140) on the plan of F.Ruel, dated from March II, 1040, and bounded as follows: in front, on the east, by Curé Labelle Boulevard, on one side at the north, by the emplacement of Mr.Paresse, on the other side, on the south, by Mr.Pilon, and in rear, on tin- west, by part l lot one hundred and fifteen belonging to Mr.with the buildings thereon erected.\" To be sold, at the parochial church door in the parish of St-Martin, county of Laval, ou the FOURTEENTH day of AUGUST, 1059.a! ELEVEN o'clock in the forenoon.CAISSE & LAURENCELLE, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, July 6, 1959.50987-28-2 NICOLET Fieri Facias Canada \u2014 Province of Quebec District of Nicolet Superior Court.( T A CAISSE POPULAIRE No.2390.< *-» DE STE-SOPHIE DE ' LÉVRARD, in the county of Nicolet, body politic and legally incorporated, having its head office at Ste.Sophie «le Lévrard, district of Nicolet, plaintiff, vs M.BERNARD ARCHAMBAULT.hotel-keeper, formerly domiciled and residing at Ste.Sophie de Lévrard, county and district «>f Nicolet, to-day in the town and «listrict of Montreal, defendant.\"A piece of land to be excluded from lot number five hundred and forty-nine (P.519) of the official cadaster of St.Pierre-Ies-Becquets, measuring half an arpent in width by some sixty-six feet in depth within its northeasterly line, that is along the St.Pierre-les-Becquets road at Ste.Sophie and one hundred and five feet in depth within its southwesterly line following the deviation «>f the 6th.range rood; English measure and more or less, boumle«l as follows: northwesterly by-the land of Rruno Founder, southeasterly by the 6th.range rood, northeasterly by the above public road and southwesterly by the land of Dame Vve Lucien Verville, with bouse, a shed for storing and private garage erected at the rear of said house, the parties in fact, knowing that said shed for storing and private garage are erected and annexed to a same part of the building, one part of which belongs to the debtor and the other part to Bruno Eonrnier.all of which divided by a wooden partition.\" To be sold at the door of the parochial church of Ste.Sophie «le I/évrard.county of Nicolet, th.- SECOND day of SEPTEMBER (1959) at TEN o'clock in the forenoon.ANTONIO RLONDIN.Sheriff's Office.Sheriff.Nicolet, July 28, 1959.51141-31-2 QUEBEC Fieri Facias In the Exchequer Court of Canada Quebec, to wit: ( TNCOME TAX ACT, vs No.153638.4 * ROBERT DORÉ, of v Donnacona, P.Q. 3100 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 Le lot numéro 70-70 «le figure rectangulaire, bornée vers le nord-est par le lot 70-84 (rue), vers le sud-est par le lot 70-00 (rue), vers le sud-ouest par le lot 70-71 et vers le nord-ouest par le lot 70-72; mesurant une largeur de quarante-cinq pieds (45') par des profondeurs de quatre-vingt-neuf pieds et deux dixièmes (S0.2') dans sa ligne nord-est et quatre-vingt-neuf pieds et huit dixièmes (S0.S') dans sa ligne sud-ouest; contenant en superficie quatre mille, vingt-sept pieds et cinq dixièmes, mesure anglaise.(4,027.5') m.a.I/o lot numéro 70-71 de figure rectangulaire, bornée vers le nord-est par le lot 70-70, vers le sud-est par le lot 70-09, (rue), vers le sud-ouest par la partie non subdivisée du lot 70 et vers le nord-ouest par le lot 70-72; mesurant une largeur de quarante-cinq pieds (45') par des profondeurs dc quatre-vingt-neuf pieds et huit dixièmes (80.8') dans sa ligne nord-est et quatre-vingt-dix pieds et quatre dixièmes (00.4') dans sa ligne sud-ouest; contenant en superficie quatre mille cinquante-quatre pieds et cinq dixièmes, mesure anglaise.(4,054.5') m.\".Pour être vendus nu Bureau d'Enregistrement de Port neuf à Cap-Santé, comté de Portneuf, le QUATORZIÈME jour d'AOUT prochain à DIX heures de l'avant -midi.Le Shérif.Bureau du Shérif.Dr J.H.GOBEIL.Québec, le 6 juillet 1059.50992-28-2-O [Première insertion: le 11 juillet 1959] [Deuxième insertion: le 1er août 1959] Fieri Facias Québec, à savoir: ( \"RDMONT) BOURGAULT N'° 87.503.< -E» & WILFRID RI-'(TIABD.tous deux entrepreneurs généraux, de St-.Ican Port Joli, comté de L'Islet, contre ARTHUR RACINE, de St-Tite des ( laps, comté de Montmorency.1° Une terre étant la moitié sud-ouest du lot deux cent neuf (.'/\u2022> s.o.de 209) au cadastre pour la paroisse de St-Tite, comté de Montmorency, mesurant un arpent et trois quarts de front (1 %) sur trente arpents de profondeur (30) joignant au sud-ouest au lot deux cent dix (210) dc Paul Lacbàncc et au nord-est à l'autre moitié dudit lot deux cent neuf (200) appartenant à Ulric Paradis, sans bâtisse.2° Une terre (tant le lot numéro deux cent onze au cadastre pofir la paroisse de St-Tite, comté de Montmorency, (211) avec bâtisses et dépendances.A distraire l'emplacement de Joseph Racine, décrit comme suit: Un emplacement mesurant environ un arpent carré situé au coin sud-ouest du lot deux cent onze (Pts.s.o.211) audit cadastre de St-Tite.comté de Montmorency, borné au sud par le chemin public, à l'ouest à Ovide Simard, au nord et à l'est par la terre d'Arthur Racine, avec bâtisses et dépendances.Pour être vendu au Bureau d'Enregistrement ' de Château-Richer, comté de Montmorency, le TROISIÈME jour de SEPTEMBRE prochain à DIX heures de Pavat-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Dr.1.R*.GOBEIL.Québec, le 28 juillet 1959.51142-31-2-o [Première insertion: 1er août 1959] [Deuxième insertion: 22 août 1959] I.ot number 70-70 of rectangular figure, bounded on the northeast by lot 70-84 (street), on the southeast by lot 70-00 (street), on the southwest by lot 70-71 and on the northwest by lot 70-72; measuring width forty-five (45') by depths of eighty-nine and two/tenths feet (89.2') in its northeast line and eighty-nine and eight/tenths feet (89.8') in its southeast line; containing in area four thousand, twenty-seven feet and five/tenths, English measure, (4.027.5') E.M.Lot number 70-71 of rectangular figure, bounded on the northeast by lot 70-70, on the southeast by lot 70-69, (street), on the southwest by the unsubdivided part of lot 70 and on the north west by lot 70-72; measuring in width forty-five feet (45') by depths of eighty-nine feet and eight/tenths (89.8') in its northeast line and ninety feet and four/tenths (90.4') in its southwest line; containging in area four thousand fifty four feet and five/tenths, English measure (4,054.5') E.M.To be sold at the Registry Office of Portneuf al Cap-Santé, countv of l'ortneuf.on the FOUR TEE NTH day of AUGUST next at TEN o'clock in the forenoon.Dr J.R.GOBEIL, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, July 0.1059.50992-28 2 [First insertion: July 11, 1959] [Second insertion: August 1, 1959] Fieri Facias Quebec, to wit : j TJDMOND BOURGAULT No.87.503.\\ -C/ & WILFRID Rl-v CHARD, both general cons-tractors, of St.Jean Port Joli, countv of LTslet.versus ARTHUR RACINE, of St.Tito des Caps, county of Montmorency.1.A farm being the southwesterly half of lot two hundred and nine (S.W.Vo of*209) on the cadaster for the parish of St.Tite, county of Montmorency, measuring an arpent and three quarters in front by thirty arpents in depth (30) bordering to the southwest lot two bundled and ten (210) belonging to Paul Lachance and to the northest the other half of said lot two hundred and nine (209) belonging to Ulric Paradis, without buildings.2.A farm being lot number two hundred and eleven on the cadaster for the parish of St.Tite, county of Montmorency.(211) with buildings and dependencies.Save and except the emplacement of Joseph Racine, described as follows: An emplacement measuring about a square arpent situated at the southwesterly corner of lot two hundred and eleven (S.W.P.211) on the said cadastre of St.Tite, county of Montmorency, bounded southerly by the public highway, westerly by Ovide Simard, northerly and easterly by the farm of Arthur Racine, with buildings and dependencies.To be sold at the Registry Office of Chateau-Richer, countv of Montmorency, the THIRD day of SEPTEMBER next at TEN o'clock in the forenoon.Dr.J.R.GOBEIL, Shefilf's Office, Sheriff.Quebec, JÙ ly 28, 1959.511 42-31 -2 [Eirst insertion: August 1st, 1959] [Second inseftion: August 22, 1959] Fieri Facias Fieri Facias ébec, à savoir: » pAGNON EQUIPMENT Quebec, to wit: ( f^AGNON EQUIPMENT N° 94,623.\\ ^ LTÉE, corps politique No.94,623.\\ ^ LTÉE, a body politic ^ et incorporé ayant sa place ' ami incorporated having its QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.31 .3101 d'affaires à Québec, contre SIMON ASSELIN, 120 Royale, St-Tite-des-Caps, comté de Montmorency.\"Avis est par le présent donné (pie l'immeuble qui devait être vendu en la présente cause au Bureau d'Enregistrement de Château-Richer comté de Montmorency, le TREIZIÈME jour de MARS 1950, et qui ne l'a pas été.sera vendu au même endroit le QUATORZIÈME jour d'AOUT 1959 à DIX heures de l'ayant-midi.\" Ix- Shérif.Bureau du Shérif, Dr.1.R.GOBEIL.Québec, le 27 juillet 1959.51143-31-2-o [Première insertion: 1er août 1959] place of business at Quebec, against SIMON ASSELIN, 120 Royale, St-Tite-des-Caps, county of Montmorency.\"Notice is hereby given that the immoveable which was to have been sold in the present case to the Registration Office of Chateau-Richer, county of Montmorency, on the THIRTEENTH day of MARCH, 195!).* and which was not.shall be sold at the same place on the FOURTEENTH day of AUGUST.1959, at TEN o'clock in the forenoon.\" Dr.1.R.GOBEIL, Sheriff's Office.Sheriff.Quebec.July 27.1959.511 13-31 -2 [First insertion: August 1st.1959] Fieri Facias Québec, à savoir: l T 'INDUSTRIELLE COM-N° 95,992.\\ -L* PAG NIE D'ASSU-l RANGE SUR LA VIE, corps politique et incorporé ayant son siège social à I0S0.Chemin St-Ixmis, en la cité de Sillery, .listrict de Québec, contre JOSEPH Y VON TURCOTTE, domicilié à 2019 rue Terrebonne, eu la cité dc Ste-Eoy.district de Québec.\"La subdivision trente-huit du lot originaire cinquante-huit (3S-5S) du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Eoy, division d'enregistrement de Québec, avec la maison dessus construite, circonstances et dépendances.\" Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de Ste-Foy, comté de Québec, le QUATRIÈME jour de SEPTEMBRE prochain à DIX heures de l'avant-midi.Iaï Shérif, Bureau du Shérif, Dr.J.R.GOBEIL.Québec, le 28 juillet 1959.51144-3 l-2-o [Première insertion: 1er août 1959) [Deuxième insertion: 22 août 1959J Fieri Facias Quebec, to wit: ( THE INDUSTRIAL LIFE No.95,992.{ J- INSURANCE COM-v PANV, body politic- and corporate having its head office at 1080 St.Louis Road, in the city of Sillery, district of Quebec versus JOSEPH YVON TURCOTTE, domiciled at 2010 Terrebonne Street, in the city of St.Foy, district of Quebec.\"Subdivision thirty-eight of original lot fifty-eight (3S-5S) of the official cadaster of the parish of St.Foy, registry division of Quebec, with a house thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at the door of the parochial church of St.Foy, county of Quebec, the FOURTH day of SEPTEMBER next at TEN o'clock in the forenoon.Dr.J.R.GOBEIL, Sheriffs Office.Sheriff.Quebec, July 28.1959.51144-31 -2 [First insertion: August 1st.1959] [Second insertion: August 22nd.1959J RIMOUSKI Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Rimouski Cour Supérieure, ( ÈRARD RIOUX, mar-N° 21,041.< chand de l'endroit ap-v pelé St-Joachim de Tourelle, district de Gaspé et y faisant affaires seul sous la raison sociale de \"Le Meuble Moderne Enr.\", demandeur vs AIMÉ OTTS, de l'endroit appelé St-Cléophas, district de Rimouski, défendeur.Le lot numéro quarante-cinq (45), rang quatre (4) canton Awantjish, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de St-Cléophas, le DOUZIEME jour d'AOUT 1959, à DEUX heures de l'après-midi.Le Député Shérif, Bureau du Shérif, JACQUES MARTIN.Rimouski, 6 juillet 1959.50983-28-2-o SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias dc Terris District dc St-François Cour Supérieure, ( T OFFICE DU CRÉDIT N° 19,455- < -L* AGRICOLE DU QUÉ-v.BEC, corps politique et incorporée, ayant son siège social à Québec, district de Québcc.demandcur, vs ARMAND CHAR-LETTE, cultivateur, domicilié à Coaticook, comté de Stanstead, district de St-François, RIMOUSKI Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Rimouski Superior Court.I p ÉRARD RIOUX, mer-No.21,041.{ vJchant of the locality called t St.Joachim de Tourelle, district of Gaspé and carrying on business therein alone umler the name and style of \"Le Meuble Moderne Enr.\", plaintiff vs AIMÉ OTIS, of the locality called St.Cléophas, district of Rimouski, defendant.Lot number forty-five (45), range four (4) township of Awantjish, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the door of the church of the parish of St.Cléophas, the TWELFTH day of AUGUST, 1959, at TWO o'clock in the afternoon.JACQUES MARTIN, Sheriff's Office, Deputv Sheriff.Rimouski, July 0, 1959.50983-28-2 SAINT FRANCIS Fieri Facias de Terris District of St.Francis Superior Court, I QUEBEC FARM CRE-No.19,455- < VÇ DIT BUREAU, body v politic and incorporated, having its corporate seat in Quebec, district of Quebec, plaintiff vs ARMAND CHARLETTE, farmer, domiciled at Coatieook, county of Stanstead, district of St.Francis, defendant, & 3102 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 défendeur, & MARCEL R.SAVARI), syndic, de la cité de Sherbrooke, en sa qualité de syndic aux biens du cédant autorisé, présent défendeur, nus en cause.\"Une propriété dc ferme au canton de Barford et comprenant: 1° Le lot de cadastre numéro cinq-A (5-A) du dixième rang, d'environ cinquante acres, sauf et excepté: a) Un morceau de quatre acres autrefois vendu à Jos.Carbonneau et pris dans son coin nord-est et décrit, comme suit, savoir: Commençant au coin nord-est dudit lot, de là se dirigeant vers le sud en suivant la ligne est dudit lot.cent quatre-vingt-treize pieds à un poteau, de là se dirigeant vers l'ouest quatre cent quarante-cinq pieds à un poteau, de là se dirigeant vers le nord deux cent treize pieds au chemin public et de là se dirigeant vers l'est en suivant le côté sud du chemin public cinq cent quarante-cinq pieds au point de départ./;) Un autre morceau de terre qui a été vendu par Dame Palmyra Boivin et Wilfrid Boîvin à René Carbonneau par acte passé devant J.-A.Durochcr, notaire, le 31 juillet 19.%, enregistré à Coaticook sous le N° 35231; 2° Le lot.numéro cinq-D (5-D), rang dix, dudit canton, sauf et excepté de ce lot une certaine source d'eau vendue à René Carbonneau* par contrat en date du 30 septembre 1955, enregistré à Coaticook sous le N° 35232; 3° Ia' lot numéro six-A (6-A), rang dix, d'environ quatre-vingt-cinq acres tic terre, sauf et excepté de ces deux derniers lots la maison d'école étant un morceau mesurant vingt pieds de front sur le côté sud du chemin public par quatre-vingts pieds de profondeur pris dans le coin nord-Ouest du lot de cadastre N° cinq-D et un morceau de soixante-cinq pieds de front sur le coté sud dudit chemin par quatre-vingts pieds de profondeur pris dans le coin nord-est du lot de eadastie N° six-A, même rang, tel qu'actuellement occupe, sauf et excepté également du lot N° 6-A, même rang, une source d'eau vendue à René Carbonneau par Ix'on Côté & al., par contrat en date du 30 septembre 1955, enregistré à Coaticook sous le N° 35232; Le tout sujet au droit de passage et droit d'y installer des tuyaux souterrains pour aller aux-dites sources et affectant les trois lots plus haut décrits.Le tout avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\" Pour être vendus \"en bloc\" à la porte de l'église paroissiale de St-Edmond de Coaticook, MERCREDI, le DOUZIÈME jour d'AOUT 1959, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, JOSEPH LABKECQUE.Sherbrooke, ce 7 juillet 1959.50993-28-2-o [Première insertion le 11 juillet 1959] MARCEL R.SAVARI), trustee, of the city of Sherbrooke, in his quality of trustee to the authorized assignor's properties, present defendant, mis en cause.\"A farm property in the township of Harford and containing: 1.The cadastral lot number five-A (5-A) of the tenth range, of about fifty acres, save and exeept: a) A piece of four acres formerly sold to Jos.Carbonneau and taken in its northeast corner and described as follows, to wit: Commencing at the northeast corner of said lot, thence going southerly following the east line of said lot, one hundred and ninety-three feet to a post, thence going westerly four hundred and forty-five feet to a post, thence going northerly two hundred and thirteen feet to the public road and thence going easterly following the south side of the public road five hundred and forty-five feet to the starting point, b) Another piece of land that has been sold by Dame Palmyra Boivin and Wilfrid Boivin to René Carbonneau by deed passed before J.-A.Durochcr, notary, the 31st of July 1950.registered at Coaticook umler number 35231; 2.The lot number five-1) (5-D), range ten.of said township, save and except from this lot a certain spring sold to René Carbonneau Indeed dated September the 30th, 1955, registered at Coaticook under No.35232; 3.The lot number six-A (6-A), range ten, of about eighty-five acres, of land save and except from these two last lots the school house being a piece measuring twenty feet in front on the south side of the public road by eighty feet in depth taken in the north-west corner of cadastral lot No.five-D and a piece of sixty-five feet (n front on the south side of said road by eighty feet in depth taken in the northeast corner of cadastral lot No.six-A, same range, as actually occupied, save and except also from lot No.6-A, same range, a spring sold to René Carbonneau bv Léon Côté & al., by deed dated September the 30th, 1955.registered at Coaticook under No.35232; The whole subject to right of way and right of installing underground pipes going to the said springs and affecting the three lots above described.The whole with buildings thereon erected, circumstances and dependences.\" To be sold \"en bloc\" at the door of the parochial church of St-Edmond de Coaticook.WEDNESDAY the TWELFTH day of AUGUST, 1959.at TEN o'clock in the forenoon.JOSEPH LABRECQUE, Sheriff's Office, Sheriff.Sherbrooke, this 7th of July, 1959.50993-28-2-o [First insertion the 11th of July, 1959] Fieri Facias de Terris District de Saint-François Cour Supérieure, ( T 'OFFICE DU CRÉDIT N° 19 520.1 AGRICOLE DU QUÉ-> BEC, corps politique et incorporé, avant son siège social à Québec, «listrict de Québec, demandeur, vs ROGER BEAUREGARD, cultivateur, domicilié à Asbestos, comté de Richmond, district de St.François, défendeur, & JEAN ROY, syndic.Victoriaville, district d'Arthabaska, en sa qualité de syndic aux biens du cédant autorisé, présent défendeur, mis-en-cause.\"1° Le lot cadastral N° deux \"A\" (2-A) du quatrième rang de Shipton et le lot cadastral N° deux \"C\" (2-C) du cinquième rang de Shipton.Fieri Facias de Terris District of St.Francis Superior Court.( pU'EBEC FARM CRE-N° 19 520.< DIT BUREAU, body politic and incorporated, having its corporate seat at Quebec, district ol Quebec, plaintiff, vs ROGER BEAUREGARD, farmer, domiciled at Asbestos, county of Richmond, «listrict of St.Francis, defendant, & JEAN ROY, trustee, Victoriaville, «listrict of Arthabaska, in his quality of trustee to the authorized assignor's properties, present defendant, mis-en-cause.\"1.The cadastral lot No.two \"A\" (2-A) of the fourth range of Shipton ami the cadastral lot N° two \"C\" (2-C) of the fifth range of Shipton. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1959, Vol.91, No.31 3103 Moins et à distraire dudit lot N° deux \"A\" la partie vendue à la Corporation de St-Georges de Windsor, et décrite au long dans l'aete enregistré à Richmond N° 50434.2° Une lisière de terrain faisant partie du lot cadastra] N° deux \"B\" (2-1$) du cinquième rang de Shipton, sise et située entre le ligne sud-ouest du lot N° 2 C et la ligne nord-est du lot N° 2-1) du cinquième rang de Shipton, sur toute la profondeur dudit lot N° 2-C.3° Une lisière de terrain de vingt-huit pieds de largeur, faisant partie du lot N° deux \"B\" (2-B) du cinquième rang de Shipton, commençant au coin sud-est du lot N° 2 \"C\" du cinquième rang de Shipton, allant dans la direction nord-ouest, en suivant la ligne d'arrière dudit lot N° deux \"C\" jusqu'à la ligne sud-est du lot N° 2 \"D\" du même rang: de là en suivant ladite ligne sud-est du lot 2 \"D\" une distance de vingt-huit pieds (28') de là à angle droit, dans la direction sud-est, en ligne droit jusqu'à un point qui serait la continuation en ligne droite de la ligne sud-est dudit lot N° 2 \"C\" et à vingt-huit pieds \u2022,2s') d'ieelle.Le tout tel qu'autrefois occupé par Frédéric Labranchc.Le tout avec les bâtisses dessus construites.\" Pour être vendus \"en bloc\" au bureau d'enregistrement de Richmond, MERCREDI, le DEUXIÈME jour de SEPTEMBRE 1959, à DLX heures dc l'avant-midi.Le Shérif.Bureau du Shérif, JOSEPH LABRECQUE.Sherbrooke, ce 27 juillet 1959.51131-31 -2-o [Première insertion, le 1er août 1959] Less and to distract from said lot two \"A\" the part sold to the corporation of St-Georges de Windsor, ami fully described in the deed registered at Richmond No.50431.2.A strip of land being part of cadastral lot No.two \"B\" (2-1$) of the fifth range of Shipton, seated ami situate between the south-west line of lot No.2-C and the north-east line of lot No.2-D of the fifth range of Shipton.on all the depth of said lot No.2-C.\u2022 3.A strip of land of twenty-eight feet in width, being part of lot No.two \"B\" (2-1$) of the fifth range of Shipton, commending at the south-east corner of lot No.2 \"C\" of the fifth range of Shipton, going in the north-west direction, following the rear line of said lot No.two \"C\" to the south-east line of lot No.2 \"D\" of same range; thence following the said south-east line of lot 2 \"D\" a distance of twenty-eight feet (28'), thence at right angle, in the south-east direction, in straight line to a point that would be the continuance in straight line of the southeast line of said lot No.2 \"('\" and at twenty-eight feet (28') from said line.The whole as formerly occupied by Frederic Labranchc.The whole with buildings thereon erected.\" To be sold \"en bloc\" at the registry office, in Richmond, WEDNESDAY, the SECOND day of SEPTEMBER 1959, at TEN o'clock in the forenoon.JOSEPH LABRECQUE, Sheriffs Office, Sheriff.Sherbrooke, July the 27th 1959.51131-31-2-e [First insertion, August the 1st, 1959] TERREBONNE Canada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne < lour Supérieure, ( T 'OFFICE DU CRÉDIT N° 29205.< ¦L' AGRICOLE DU QUÉ-v BEC, corps politique incorporé, ayant son siège social à Québec, demandeur vs EUGÈNE PAQUETTE, domicilié à Arundel, «mité d'Argenteuil, défendeur.AVIS DE VENTE a) Le lot de terre numéro dix-huit A (18a) du rang huit du canton Arundel, des plan et livre de renvoi officiels dudit canton Arundel, contenant une superficie d'environ cent vingt acres, plus ou moins, avec maison et dépendances y érigées; moins et à distraire de ce lot l'emplacement d'écoles originairement vendu par acte enregistré sous le N° 41740 et appartenant aujourd'hui à William McMahon par acte enregist résous le N° 6380; b) Et les lots de terre numéros trente-deux, trente-sept et trente-huit (32, 37, 38) des plan et livre de renvoi officiels du canton DeSalaberry, sans bâtisse.\" Pour être vendu en bloc à la porte de l'église de St-Jovite.comté de Terrebonne, MERCREDI le DEUXIÈME jour dc SEPTEMBRE 1959 à DEUX heures de l'après-midi (2 septembre 1959).Le Shérif, Bureau du Shérif, GEO.AUCLAHt.St-Jérôme, 20 juillet 1959.51129-31-2-o TROIS-RIVIÈRES Canada \u2014 Province de Québec District de Trois-Rivières Cour Supérieure, ( TVVME MARIE VADE-N° 17686.< U BONCOEUR, ménagè-' re, épouse de feu Arthur TERREBONNE Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, / THE QUEBEC FARM No.29265.< 1 CREDIT BUREAU, v body politic and corporate, having its head office in Quebec, plaintiff vs EUGÈNE PAQUETTE, domiciled at Arundel, county of Argenteuil, defendant.NOTICE OF SALE a j I«ot of land number eighteen A (18a) of range eight of the township of Arundel, of the official plan and book of reference of said township of Arundel, containing an area of some one hundred ans twenty acres, more or less, with house and dependencies thereon erected; save, and to be excluded from this lot.the emplacement for schools originally sold by registered deed under No.44746 and belonging to-day to William McMahon by deed registered umler No.63486; b) And lots of land number thirty-two, thirty-seven ami thirty-eight (32.37.38) of the official plan and book of reference of the township of DeSalaberry, without building.\" To be sold in block at the door of the church of St.Jovite.countv of Terrebonne.WEDNESDAY the SECOND day of SEPTEMBER 1959 at TWO o'clock in the afternoon (September 2, 1959).GEO.AUCLAIR.Sheriffs Office.Sheriff.St.Jérôme, July 20, 1959.51129-31 -2 TROIS-RIVIÈRES Canada \u2014 Province of Quebec District of Trois-Rivières Superior Court, ITNAME MARIE VADE-No.17686.\\ U BONCOEUR, housewife.' wife of the later Arthur Ron- 3104 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1959, Tome 91, N° 31 Rouleau, en son vivant industriel de Grandes Piles, district de Trois-Rivières, demeurant en la cité d'Outremont, district de Montréal, est demanderesse originaire et en reprise d'instance; vs HENRI FORTIN, rentier, de Shawinigan, district de Trois-Rivières, est défendeur originaire, et CI IAR LES-ÉMILE BRUCHÉSI, des cité et district de Montréal, en sa qualité de curateur public et en sa qualité de curateur à la succession du défendeur Henri Fortin, est défendeur en reprise d'bistance, et ledit Charles-Emile Bruchési.en sa qualité de curateur public, curateur au délaissement de l'immeuble délaissé en l'instance.\"Un emplacement situé à Shawinigan Falls, faisant partie des lots dc terre numéro six cent cinq B et s\"ix cent six B de la subdivision du lot cadastral numéro six cent vingt-huit (628, P.605B et P.606B) au cadastre de la paroisse de Ste-Flore, de vingt-cinq pieds de largeur sur la profondeur de quatre-vingt-douze pieds, mesure anglaise, et sans garantie de mesure précise, bornée en front pur l'avenue des Cèdres, en arrière par la ruelle N° 628-60 5C du coté nord par Dame Eustache Fortin et du côté sud par les Nos 628-605A et 028-60(5.avec bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de St-Pierre à Shawinigan, VENDREDI, le VINGT-HUITIÈME jour du mois d'AOUT, nul neuf cent cinquante-neuf, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, L.P.MERCIER.Trois-Rivières, le 6 juillet 1959.50988-28-2-o leau, in his lifetime an industrialist of Grandes Piles, district of Trois-Rivières, residing in the city of Outremont, (listrictof Montreal, is original plaintiff and in continuance of suit; vs HENRI FORTIN, annuitant of Shawinigan, district of Trois-Rivières, is the original defendant, and CHARLES-ÉMILE BRUCHÉSI, of the city and district of Montreal, in his capacity of Publie Curator for the estate of the defendant Henri Fortin, is defendant in continuance of suit, and the said Charles-Emile Bruchési, in his capacity of Public Curator, Curator to the surrender of the immoveable surrendered in the suit-at-law.\"An emplacement situated at Shawinigan Falls, forming part of lots of land number six hundred and five B and six hundred and six B of the subdivision of cadastral lot number six hundred and twenty-eight (028, P.G05B and P.006B) of the cadastre of the parish of Ste.Flore, of twenty-five feet in width by a depth of ninety-two feet, English measure, without, guarantee as to exact measuring, bounded in front by Cedar Avenue, in the rear by lane No.628-50 5C, on the north side by Dame Eustache Fortin and on the south side by Nos.628-605A and 628-600, with buildings thereon erected, circumstances an dependencies.\" To be sold at the door of the Church of the parish of St.Peter, at Shawinigan, FRIDAY, the TWENTY-EIGHTH day of the month of AUGUST, one thousand nine hundred and fifty-nine, at THREE, o'clock in the afternoon.L.P.MERCIER, Sheriffs Office, Sheriff.Trois-Rivière.July 0, 1959.50988-2S-2 Index de la Gazette officielle de Québec, N° 31 Arrêté en Conseil: 631\u2014Concernant certains actes administratifs du Secrétariat dc la Province.3079 Avrs aux intéressés : 3015 Avis divers: Artistic Investments Ltd.(Directeurs).3081 Baie d'Urfée, (Modification de charte).3080 L'Harmonie de Rimouski Inc.(Nom changé).3080 Peel Building Corporation (Dist.de l'actif).3081 Renaud & Frères Incorporée (Directeurs).3080 Société Saint-Jean-Baptiste Ix>cale de Ste-Gcneviève (Corporation).3081 Chartes \u2014 Aman don de: Cheryl-Lee Dress & Sportswear Inc.3081 Ventures Claims (Quebec) Limited.3082 Compagnies dissoutes: Cie Gauthier & Gagné Ltée.3082 Dilccta Company Limited.3083 Lane & Robitail'le Ltd.3083 L.Dupont Limitée.-.3082 Normandie Trading Corporation Limited.3082 Index of the Quebec Official Gazette, No.31 Order in Council: 031 \u2014Concerning certain administrative agreements of the Department of .the Provincial Secretary.3079 Notice to interested Parties: 3015 Miscellaneous Notices: Artistic Investments Ltd.(Directors).3081 Baie d'Urfée, (Charter amendment) .3080 L'Harmonie de Rimouski Inc.(Name changed).\u2022.3081) Peel Building Corporation (Dist.of assets).30S! Renaud & Frères Incorporée (Directors)._.3080 Société Saint-Jean-Baptbitc Locale de Ste-Geneviève (Corporation).'.308! Charters \u2014 Surrender of: Cheryl-Lee Dress & Sportswear Inc.308 ! Ventures Claims (Quebec) Limited- 3082 Companies Dissolved: Cie Gauthier & Gagné Ltée.-.3082 Dilecta Company Limited.308'' Lane & Robitaille Ltd.3083 L.Dupont Limitée.3082 Normandie Trading Corporation Limited.3082 QUEBEC CEE ICI AL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1969, Vol.91, No.31 3105 Demande X la Législature: Application to Legislature: Community Holy Associiuion of United Congregations.3083 i ) I ; PARTEM ENTS \u2014 AVIS DES: Instruction publique: Municipalité scolaire de: Lac-au-Saumon.3085 Pascalis.3081 Preissac.3084 Ste-Geneviève N° 1.' 3085 Terres et Forets: Service du Cadastre: Buckingham, canton.3085 Dahlon, canton.3085 Sherbrooke, cité.3086 St-CoIomb-de-Sillery, paroisse.3085 Travail: Industrie ou métiers de: Employés «le garages, ville «le Rimouski (Modification).3086 Manutcnteurs «le fret, Havre de Montréal (Modification).3086 Examen du Barreau: Rimouski, étude.30SS Lettres patentes: Aber Development Corp.3010 Acme Land Holdings Ltd.3017 Albeel Investment Corp.3017 Aljon Realty Corporation.3017 Alexandra Apparel Co.Inc.3018 Alpha Realties (Chambly) lue.3018 American Holdings Corp.3018 A.M.S.Investment Corp.3010 Antares Development Corporation.3019 A.P.Dupuis Construction Ltée \u2014 A.P.Dupuis Construction Ltd.3010 A.Pfefer Realty Inc.3020 Aqua Investment Corp.3020 Arizona Investments Ltd.3020 Astor Realties Corp.3021 Atlas Brothers Inc.3021 Baltic Investment Corp.3021 Basbros Realties Inc.3022 Beach Investment Corp.3022 Beaurock Lan«l Development Co.3022 Belcrest Development Corp.3023 Bella Vista Investment Ltd.3023 Bermac Textiles Corp.3023 Bois Filion Investments Ltd.3024 Brain Industries Corp.3024 Brookland Investment Corp.3024 By-Frank Inc.3025 Camel Investment Corporation.3025 Canbrook Realties & Investments Corporation.3025 ( arhnlan Investment Ltd.3020 Chalan Investment Inc.3020 Chateauguay Commercial Center Inc.3026 Codab Realty Ltd.3027 Coigny Inc.3027 Continental Industries Ltd.3027 Crestline Developments Inc.3028 Dalfen Investment Corp.3028 Dalfen's Limited.3028 Community Holy Association of United Congregations.3083 DE PARTMENTAL NOTK 'ES: Education: School Municipality of: Lac-au-Saumon.3085 Pascalis.3084 Preissac.3084 Ste-Geneviève No 1.3085 Lands and Forest : Cadastral Branch: Buckingham, township.3085 Dahlon, township.3085 Sherbrooke, city.3086 St-Colomb-de-Sillcry, parish.3085 Labour: Industry or Trades of: Garage employees, town «>f Rimouski (Amendment).3086 Fre|ght handlers.Harbour of Montreal (Amendment).3086 Bar Examination: Rimouski, study.3088 Letters Patent: Aber Development Corp.3016 Acme Land Holdings Lt«l.3017 Allied Investment Corp.3017 Aljon Realty Corporation.3017 Alexandra Apparel Co.Inc.3018 Alpha Realties (Chambly) Inc.3018 American Holdings Corp.3018 A.M.S.Investment Corp.3019 Antares Development Corporation.3019 A.P.Dupuis Construction Ltd.\u2014A.P.Dupuis Construction Ltée.3019 A.Pfefer Realty Inc.3020 Aqua Investment Corp.3020 Arizona Investments Lt«l.3020 Astor Realties Corp.3021 Atlas Brothers Inc.3021 Baltic Investment Corp.3021 Basbros Realties Inc.3022 Reach Investment Corp.3022 Beaurock Land Development Co.3022 Belcrest Development Corp.3023 Bella Vista Investment Ltd.3023 Bermac Textiles Corp.3023 Bois Filion Investments Ltd.3024 Brain Industries Corp.3024 Brookland Investment Corp.3024 By-Frank Inc.3025 Camel Investment Corporation.3025 Canbrook Realties & Investments Corporation .3025 Carladan Investment Ltd.3020 Chalan Investment Inc.3026 Chateauguay Commercial Center Inc.3026 Codab Realty Ltd.'3027 Coigny Inc.3027 Continental Industries Ltd.3027 Crestline Developments Inc.302S Dalfen Investment Corp.3028 Dalfen's Limited.3028 3100 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 19f,9, Tome 91, N° 31 Dragon Development Corp.3029 Elberg Associates Ltd.3029 Elex Corp.3029 Emil Ispas Inc.3030 Tmlac Realty Corp.3030 Engora Realties Ltd.3030 Erd Development Inc.3031 Esman Investment Corporation.3031 E.S.Realties Inc.3031 Eston Development Corporation.3032 Estoril Development Corporation.3032 Ettingcr Enterprises Corp.3032 Famous Enterprises Ltd.3033 Foyer des Testiles lue.3033 Frozen Specialties (Quebec) Ltd.3033 G louberman Investments Ltd.3034 Gold Ribbon Developments Inc.3031 Gyle Realty Corp.3034 Héneault Transport Inc.3035 Herald Developments lue.3035 Hervé Thivierge Incorporée\u2014 Hervé Thivierge Incorporated.303\") Hollin Really Corp.3030 Hubroc Inc.3036 Importations du Globe Inc.3030 Industrial Form Work Limited.3037 Jaguar cc Freezers Limited.3051 Quenneville & Varin Ltée .3055 Redie Investments Ltd.3055 Redwood Developments Inc.3055 Reputation Hosiery Mills Ltd.3056 Reshaban Land Inc.3056 Rino Investment Corp.3056 Rochefort Investment Corporation.3057 R.P.R.Automotive Supplies Inc.'ill.\")?Sabra Realties Corp.3057 Sabre Investment Corp.3058 Salons Cosy Inc.3058 Sans Souci Really Corp.3058 Scahrook Investment Corp.3050 Senior Holdings Limited.3059 Serviccmaster \u2014 Montreal Inc.3059 Sheeri Holdings Ltd.3060 Shelley Realties Inc.3060 Shoreerest Development Inc.3000 Shore Investment Corp.3061 Skyline Realties Inc.3061 Southampton Realty Corp.3001 St.Louis Land Development Corp.3062 Sunview Development Corp.3062- Teejay Investment Ltd.3062 The Carleton Press.Limited.3003 Thibault Electrique Limitée \u2014 Thibault Electric Limited.3003 Tcsam Investments Inc.3063 Tov Investments Inc.3004 Toyland Playthings Incorporated.3064 Trane Investment Inc.3004 Twenty Seven Developments Ltd.3005 Universal Electric & Heating Co.Ltd.3005 Vale Construction Ltd.3005 Versailles Builders Ltd.3066 Wallace Realties Inc.3066 Wallcrete of Canada Ltd.3066 Westwood Developments Inc.30(57 Winridge Developments Inc.3067 Wolf Brand Cravat & Suspender Co.Ltd 3067 Zelvin Realty Corp.3068 Lettres patentes supplémentaires: Adrien Guay & Fils Inc.3068 Apa Investments Ltd.3009 Artmar Equipment Ltd.3069 Auto (Holding) Ltée \u2014 Ltd.3069 Benaby Realties Ltd.3009 Carsley's Limited.3009 Champlain Footwear Inc.3070 C.Kern Ltd.3070 Confection St-Roch Inc.3070 Côté, Boivin & Cie Incorporée.3070 Croydon Furniture Corporation .3071 Hillsdale Golf and Country Club Inc.3071 Hôpital des Laurentides.3071 Jack Schwartz Incorporated.3071 J.M.Bédard Limitée \u2014 J.M.Bédard Limited.3072 La Compagnie des Ciments du St- Laurent.3072 Léo Varin Inc.3072 Les Entreprises Somerville Ltée.3072 Les Entreprises Val Martin Inc.\u2014 Val Martin Enterprises Inc.3073 Librairie Hachette (Canada) Ltée.3073 L.L.Lozeau Ltée.3073 Melab Development Corporation.3073 Melvin Cohen Inc.3074 Perjay Realty Corp.3053 Pinehurst Development Corp.3053 Plomberie Centrale Inc.3053 Poirier & Béliveau Limitée.3054 Produits \"Lapidrite\" Products Corporation.3054 Quebec Freezers Limited.3054 Quenneville & Varin Ltée.3055 Redie Investments Ltd.3055 Redwood Developments Inc.3055 Reput ai ion Hosiery Mills Ltd.3056 Reshaban Land Inc.3056 Rino Investment Corp.3056 Rochefort Investment Corporation.3057 R.P.R.Automotive Supplies Inc.3057 Sabra Realties Corp.3057 Sabre Investment Corp.3058 Salons Cosy Inc.3058 Sans Souci Realty Corp.3058 Seabrook Investment Corp.3059 Senior Holdings Limited.3059 Serviccmaster \u2014 Montreal Inc.3059 Sheeri Holdings Ltd.3060 Shelley Realties Inc.3000 Shoreerest Development Inc.3060 Shore Investmeid Corp.3061 Skyline Realties Inc.3001 Southampton Realty Corp.3061 St.Louis Land Development Corp.3062 Sunview Development Corp.3062 Teejay Investment Ltd.3062 The Carleton Press, Limited.3063 Thibault Electric Limited \u2014 Thibault Électrique Limitée.3063 Tesam Investments Inc.3003 Tov Investments Inc.3064 Toyland Playthings Incorporated.3064 Trane Investment Inc.3064 Twenty Seven Developments Ltd.3065 Universal Elect ric & Heating Co.Ltd.3065 Vale Construction Ltd.3005 Versailles Rudders Ltd.3066 Wallace Realties Inc.3066 Wallcrete of Canada Ltd.3066 Westwood Developments lue.3007 Winridge Developments Inc.3067 Wolf Rrand Cravat & Suspender Co.Ltd 3067 Zelvin Realty Corp.3068 Supplementary Letters Patent: Adrien Guay & Fils Inc.3068 Apa Investments Ltd.3009 Artmar Equipment Ltd.3009 Auto (Holding) Ltée \u2014 Ltd.3009 Benaby Realties Ltd.3009 Carsley's Limited.3009 Champlain Footwear Inc.3070 C.Kern Ltd.3070 Confection St-Roch Inc.3070 Côté, Boivin & Cie Incorporée.3070 Croydon Furniture Corporation.3071 Hillsdale Golf and Country Club Inc.3071 Hôpital des Laurentides.3071 Jack Schwa .t z Incorporated.3071 J.M.Bédard Limited \u2014 J.M.Bédard Limitée.3072 La Compagnie des Ciments du St- Laurcnt.*\u2022 \u2022 \u2022 3072 Léo Varin Inc.3072 Les Entreprises Somerville Ltée.3072 Val Martin Enterprises Inc.\u2014 Les Entreprises Val Martin Inc.3073 Librairie Hachette (Canada) Ltée.3073 L.L.Lozeau Ltée.3073 Melab Development Corporal ion.30/3 Melvin Cohen Inc.3074 310S GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1er août 1969, Tome 91, N° SI Miss Montreal Ltd.3074 Miss Snowdon Ltd.3074 Morissette & Frère Ltée.3074 X.M.Shahin & Company Ltd.307,5 Paperman & Sons lue.3075 Patet Corp.3075 Provincial Foam Products Ltd.3075 Séguin Leelere Inc.3075 St Charles Adjusters Ltd.\u2014 St Charles Ajusteurs Ltée.3070 Superior Plastics Inc.3070 Valley field Golf and Country Club Inc.3070 Weedon Mining Corporation.3070 Liquidation, avis de: Farrah et al vs Allevato et al.3088 Ministère des Finances: Assurances: The Connecticut Fire Insurance Company .3089 Nominations: Divers.3089 Sieges sociaux: Autolec Services (Quebec) Limited.3090 Clear-View Window Cleaning Co.Ltd.3091 Commodity Investment Corp.3091 Guv Lemieux Inc.3091 L.L.Lozeau Ltée.3090 London Zig Zag Spring Ltd.3090 Senior Holdings Limited.3090 Soumissions: Asbestos, ville.3093 St-Hilairc, village, syndics d'écoles protestantes.3091 Vente.Loi des faillite: Grenier, Roméo.3094 Ventes pour taxes: Montréal-Nord, ville.3077 Pointe-aux-Trembles, cité.3078 VENTES PAR SHÉRIFS: Beauce: United Loan Corporation vs Bédard.3095 Chicoutimi: Morrier vs Viceri.3090 Montreal: Cité de Côte Saint-Luc vs Lafranchise.3096 Laval Petroleum Ltée vs Tessier.3098 The Crown Life Insurance Company vs Robert D.Nadeau Inc.3097 The Crown Life Insurance Company vs Robert D.Nadeau Inc.3098 Nicolet: La Caisse Populaire de Ste-Sophie dc Lévrard vs Arcbambault.3099 Miss Montreal Ltd.3074 Miss Snowdon Ltd.3071 Morissette & Frère Ltée.3074 N.M.Shahin & Company Ltd.307.\") Paperman & Sons Inc.3076 Patet Corp.307\") Provincial Foam Products Ltd.3075 Séguin Leclerc Inc.307,\") St Charles Adjusters Ltd.\u2014 St Charles Ajusteurs Ltée.3070 Superior Plastics lue.3076 Vallcyfield ( Jolf and Country Club Inc.3070 Weedon Mining Corporation.3076 Winding up Notices: Farrah /\u2022/ al vs Allevato et al.3088 Department of Finance: Insurance : The Connecticut Fire Insurance Company.3089 Appointments: Miscellaneous.3089 Head Offices: Autolec Services (Quebec) Limited.3090 Clear-View Window Cleaning Co.Ltd.309 ! Commodity Investment Corp.3091 Guy Lemieux Inc.3091 L.L.Lozeau Ltée.3090 London Zig Zag Spring Ltd.3090 Senior Holdings Limited.3090 Tenders: Asbestos, town.3093 St-Hilairc, village, Protestant School Trustees.3091 Sale, Bankruptcy Act: Grenier, Roméo.30'.'4 Sales for Taxes: Montreal North, town.3077 Pointe-aux-Trembles, city.30/ 8 SHERIFFS' SALES: Beauce: United Loan Corporation vs Bédard.3095 Chicoutimi: Morrier vs Viceri.3090 Montreal: Cité de Côte Saint-Luc vs Lafranchise 3096 Laval Petroleum Ltée vs Tessier.309s The Crown Life Insurance Company vs Robert D.Nadeau Inc.3097 The Crown Life Insurance Company vs Robert D.Nadeau Inc.3098 Nicolet: Iai Caisse Populaire de Ste-Sophie de Lévrard vs Arcbambault.309!) QUEBEC DEE ICI AL GAZETTE, Quebec, August 1st, 1969, Vol.91, No.81 3109 Quebec: Qitebkc: Bourgault et al vs Racine.3100 Bourgault et al vs Racine.3100 Gagnon Equipment Ltée vs Asselin.3100 Gagnon Equipment Ltée vs Asselin .3100 L'Industrielle Compagnie d'Assurance sur la Vic vs Turcotte.3101 Industrial Life Insurance vs Turcotte 3101 Loi de l'Impôt sur le Revenu vs Doré.3099 Income Tax Act vs Doré.3099 Rimouski: Rimouski: RiouxvsOtis.3101 Rioux vs Otis.3101 ^aint-Ekancois: Saint Fbancis: L'Office du Crédit Agricole du Québec Quebec Farm Credit Bureau vs Char- vsCharlette.3102 lette.3102 L'Office du Crédit Agricole du Québec Quebec Farm Credit Bureau vs Beau- vs Beauregard.3101 regard.3101 ' r kukebonne : Teukebonne : L'Office du Crédit Agricole du Québec Quebec Farm Credit Bureau vs Pa- vsPaquette.3103 quette.3103 Trois-Rivières: Trois-Rivières: Vadeboncoeur vs Fortin.3103 Vadeboncceur vs Fortin.3103 Québec: \u2014Imprimé par Rédemiti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rêdempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer. "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.