Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 21 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1959-02-21, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tomb 91, N^8 845 Vol.91, No.8 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette .(published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Quebec, samedi 21 février 1959 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, February 21st, 1959 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 846 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, $1 février 1969, Tome 91, N° 8 délai pour la réception des avis, documente ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argeirt sont soumises aux dispositions de l'article 7.' 9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces! Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: Si la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502 \u2014 l-52-o receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number.of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502\u2014l-52-o Lettres patentes (P.G.14999-58) A.Di Caprio & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de* la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: Antonio Di Caprio, marchand, Madame Angéline Fuoco Di Caprio, commerçante, épouse séparée de biens dudit Antonio Di Caprio, et Joseph Fuoco, machiniste, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'appareils et accessoires électriques, d'instruments de musique, de meubles et de nouveautés, sous le nom de \"A.Di Caprio & Fils Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 7396, rue St-Hubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistaftt-prccureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.Letters Patent - (A.G.14999-58) A.Di Caprio & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, incorporating: Antonio Di Caprio, merchant, Madame Angéline Fuoco Di Caprio, dealer, wife separate as to property of the said Antonio Di Caprio, and Joseph Fuoco, machinist, all of Montreal, for the following purposes: To deal in electrical apparatus and accessories, musical instruments, furniture and novelties, under the name of \"A.Di Caprio & Fils Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of {he company will be at 7396 St.Hubert Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1969, Vol.91, No.8 847 (P.G.14146-58) Allan Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit janvier 1959, constituant en corporation: Allan M.Langner, administrateur, Marcia Shetzen, secrétaire, célibataire, et Joseph Nuss, étudiant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Négocier et mettre en valeurs, et vendre, louer, échanger ou autrement céder et disposer d'immeubles ou intérêts .en iceux, sous le nom de \"Allan Investments Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14566-58) Amity Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre décembre 1958, constituant en corporation: David Lack, Avrum Cohen, tous deux avocats, de Montréal et Isadore Gesscr, pharmacien, d'Out remont, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, amélioration, construction et placements, sous le nom de \"Amity Enterprises Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 400 actions privilégiées u'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Outremont, district judiciaire de Montiéal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.14146-58) Allan Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the.Province of Quebec, bearing date the eighth day of January, 1959,.incorporating: Allan M.Langner, executive, Marcia Shetzen, secretary, spinster, and Joseph Nuss, student, all of Montreal, for the following purposes: To deal with and turn to account, and to sell, lease, exchange or otherwise make over and dispose of real estate or interests therein, under the name of \"Allan Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares of a par value of $100 each and 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14566-58) Amity Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of December, 1958, incorporating: David Lack, Avrum Cohen, both advocates, of Montreal, and Isadore Gesser, pharmacist, of Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, improvement, construction and investment company, under the name of \"Amity Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and 400 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Outremont, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.10069-59) \u2022s Arc Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des ce m pagines de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq janvier 1959, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, conseil en loi de la Reine, Clarence Reuben Gross, Rollin Gallay, tous trois avocats et Sarah Miller, sténographe, fille majeure, tous de Montiéal, pour les objets suivants: Négocier, mettre en valeur et disposer d'immeubles ou d'intérêts en iceux, sous le nom de ''Arc Realties Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 90 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.10069-59) Arc Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1959, incorporating: Samuel David Rudenko, Queen's Counsel, Clarence Reuben Gross, Rollin Gallay, all three advocates, -and Sarah Miller, stenographer, spinster of the full age ol majority, ail of Montreal, for the following pu i poses: To deal witn, turn to account and dispose of real estate or interest therein, under the name of \"Arc Realties Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 90 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of tne company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General. 848 ' GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1959, Tome 91, N° 8 (P.G.14749-58) Art Luggage & Novelties Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Maurice Zangar, Heibert Arthui Radier, tous deux fabricants, Julian Kotler, commis en loi et George Whelan, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: ; Exercer le commerce qui consiste à fabriquer des marchandises et nouveautés en cuir, et en général négocier de tels articles, sous le nom de \"Art Luggage & Novelties Co.Ltd.\", avec up capital total de $4O,C0O, divisé en 4C0 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.:Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14904-58) Baribeau & Fils Inc.\u2014 Baribeau & Son Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre décembre 1958, constituant en corporation: Lise Baribeau, secrétaire, fille majeure, Michel Baribeau, industriel, Simon Baribeau, gérant, tous trois de Lévis, et Jacques de Billy, avocat, de Sillery, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois et des produits et sous-produits du bois, sous le nom de \"Baribeau & Fils Inc.\u2014 Baribeau & Son Inc.\", avec un capital total de $1,030,030, divisé en 200 actions communes de $100 chacune, ô.OOO actions privilégiées \"A\" de $103 chacune et en 4,800 actions privilégiées \"B\" de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lévis, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur générai, le vingt-quatre décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14801-58) Barville Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembie 1958, constituant en corporation : Seymour Machlovitch, Morris Chai-kelson, tous deux avocats, et Nicole Paternault, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: 'Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, développement et construction, sous le nom de \"Barville Development Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9720 rue Jeanne Mance, Montréal, distiict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.14749-58) Art Luggage & Novelties Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Maurice Zanger, Herbert Arthur Raaler, both manufacturers, Julian Kotler, law clerk, and George Whelan, advocate, ail of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing leather goods and novelties and generally deal in and with such products, under the name of \"Art Luggage & Novelties Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $10 each and 3,600 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, ju iicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14904-58) Baribeau & Fils Inc.\u2014 Baribeau & Son Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of December, 1958, incorporating: Lise Baribeau, secretary, spinster, Michel Baribeau, industrialist, Simon Baribeau, manager, all three of Levis, and Jacques de Billy, advocate, of Sillery, for the following purposes: An industry and business dealing in lumber and lumber products and by-products, under the name of \"Baribeau & Fils Inc.\u2014Baribeau & Son Inc.\", with a total capital stock of $1,000,COO, divided into 200 common shares of $100 each, 5,000 preferred \"A\" shares of $100 each and into 4,800 preferred \"B\" shaies of $100 each.The head office of the company will be at Levis, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, tins twenty-fourth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14801-58) Barville Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of' the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, both advocates, and Nicole Paternault, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development, improvement and construction company, under the name of \"Barville Development Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 9720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February gist, 1959, Vol.91, No.8 849 (P.G.14923-68) Bernard Handbags Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patents, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: Henrf Weinzweig, fourreur, Sonia Wemzweig, ménagère, épouse séparée de biens dudit Henri Weinzweig et dûment autorisée par ce dernier et Rose Markis, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à fabnquer des sacoches, articles en cuir et faire celui du cuir et marchandises textiles de toutes soi tes, sous le nom de \"Bernard Handbags Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montiéal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14714-58) ~~ Bertwin Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des letties patentes, en date du dix-sept décembre 1958, constituant en corporation: David Litner, Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, avocats, et Rachel Souchereau, secrétaire, fille majeure, et usant de ses droits, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de portefeuille et placements, sous le nom de \"Bertwin Investment Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1958.L'Assistant-piocureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.13544-58) Biaise Allard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quebec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporationr-Mme Yvette B.Allard, veuve, femme d'affaires, Albert Deboés, journalier, tous deux dlberville, et Jean-J.Rufiange, comptable agréé, de Longucuil, pour les objets suivants: Faire affaires comme regrattiers, sous le nom de \"Biaise Allard Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1C0 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 30,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 37, 7ième Avenue, Iberville, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procuieur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(A.G.14923-58) Bernard Handbags Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tlje Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, incorporating: Henri Weinzweig, Fumer, Sonia Weinzweig, Housewife, wife separate as to property of the said Henri Weinzweig, and duly authorized by him, and Rose Markis, secietary, spinster, all of Montreal, for the following purpoes: To carry on the business of manufacturing handbags, leather goods, and to deal in leather and textile goods of every kind, under the name of \"Bernard Handbags Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thiity-first day of December, 1958.P.FRENETTE, .49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14714-58) } Bertwin Investment Corp.Notice is hereby given that under Paît I of the Quebec Companies' Act, -letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of December, 1958, incorporating: David Litner, Seymoui Machlovitch, Morris Chaikelson, advocates, and Rachel Souchereau, secretary, fille majeure et usant de ses droits, al 1 of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment corporation, under the name of \"Bertwin Investment Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the office of the Attorney Genera), this seventeenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13544-58) Blaise Allard Inc.t Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating : Mrs.Yvette B.Allard, widow, business woman, Albert Deboés, laborer, both of dlberviile, and Jean-J.Rufiange, chartered accountant, of Longucuil, for the following purposes: To carry on business as hucksters, under the name of \"Blaise Allard Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a nominal value of $100 each and into 30,000 preferred shares of a nominal value of $1 each.The head office of the company will be at 37, 7th Avenue, Iberville, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.\u2022 850 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SI février 1969, Tome 91,N°8 (P.G.13584-58) B.& R.Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation: Adrien Binette, Joseph-Ferdinand Robillard, entrepreneurs, et Armand-H.Viau, comptable agréé, tous de Verdun, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents d'immeubles et comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"B.& R.Construction Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 20 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 180 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5583, avenue Verdun, Verdun, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.49898-c P.FRENETTE.(P.G.14530-58) Brewster Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Neil Phillips, avocat, Yvonne Bélanger, Sylvia Vineberg, toutes deux secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, et Godfrey Marin, avocat, de Pointe Claire, pour les objets suivants: Acheter ou autrement acquérir et détenir, posséder, y construire et développer à des fins de placements, un certain emplacement situé dans la ville de St-Léonard de Port Maurice, sous le nom de \"Brewster Development Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14772-58) Brith Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Samuel Drazek, fourreur, Sidney Zoltak, vendeur, et Geiald Ellis, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Bnth Realty Corp.\", avec un capital total de $70,600, divisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et 690 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1060 ouest, rue Laurier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur générai, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.13584-58) B.& R.Construction Inc.Notice is«hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: Adrien Binette, Joseph-Ferdinand Robillard, contractors, and Armand-H.Viau, chartered accountant, all of Verdun, for the following purposes: To carry on business as real estate agents and general building contractors, under the name of \"B.& R.Construction Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 20 common shares of a par value of $100 each and 180 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 5583 Verdun Avenue, Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14530-58) Brewster Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-gouvenior of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Neil Phillips, advocate, Yvonne Bélanger, Sylvia V inch erg, both Secretaries, filles majeures, all three of Montreal, and Godfroy Marin, advocate, of Pointe Claire, for the following purposes: To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on and develop for investment purposes a certain emplacement situate in the town of St.Leonard de Port Maurice, under the name of \"Brewster Development Corporation\", with a total capital stock of $10,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE.49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14772-58) Brith Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Samuel Drazek, Furrier, Sidney Zoltak, Salesman, and Gerald Eliis, notary, all of Montreal, for the following purposes: To act as a realty and investment corporation, under the name of \"Brith Realty Corp.\", with a total capital stock of $70,000, divided into 100 common shares of $10 each and 690 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1060 laurier Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Slet, 1969, Vol.91, No.8 851 (P.G.14741-58) Brumer Manufacturing Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, conseil en loi de la Reine, Clarence Reuben Gross et Rollin Gallay, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce de marchands et vendeurs de toutes sortes de marchandises habituellement vendues par les bijoutiers, orfèvres, fabricants de montres, horlogers, sous le nom de \"Brumer Manufacturing Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau- du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-piocureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14717-58) Café de Rome Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de QuébecyJes lettres patentes, en date du dix-sept décembre 1958, constituant en corporation: Harry Lebovitz.restaurateur, Sam Lebo-vitz et Saul Cooper, gérants, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, fous le nom de \"Café de Rome Inc.\", avec un capital total de S10.0C0, divisé en 10,000 actions ordi-nzires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14056-58) Calumet Development Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes,' en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Abraham Sinister, avocat, Nathaniel Liebman, notaire, et Carl Rosen, étudiant en droit, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, développement et construction, sous le nom de \"Calumet Development Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, distiict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14930-58) Cedar brook Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a (A.G.14741-58) Brumer Manufacturing Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Samuel David Rudenko, Queen's Counsel, Clarence Reuben Gross and Rollin Gallay, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as merchants and dealers in all classes of merchandise usually carried in stock by jewellers, silversmiths, watchmakers, clockmakeis, under the name of \"Brumer Manufacturing Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial distiict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14717-58) Café de Rome Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of December, 1958, incorporating: Harry Lebovitz, lestaurateur, Sam Lebovitz and Saul Cooper, managers, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restau i ant keepers, under the name of \"Caté de Rome Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Gênerai, this seventeenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14056-58) Calumet Development Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Abraham Shuster, advocate, Nathaniel Liebman, notary, and Carl Rosen, student at law, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, development and construction company, under the name of \"Calumet Development Inc.\", with a total capital stock ol $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14930-58) Cedarbrook Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec-Companies' Act, letters patent have 852 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, tl février 1969, Tome 91, N° 8 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettrse patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Samuel Chait, avocat, John Hamilton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Aronotvitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, développement, amélioration et construction, sous le nom de \"Cedarbrook Realties Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,200 actions'ordinaires de $1 chacune et 35,800 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 655 rue Beaumont, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14441-58) Centre Social de la Ville de La Malbaie Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de Ja Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Alcide Harvey, rentier, Joseph-Edgar Bergeron, Pierre-René Bouliane, comptables, Richard Maltais, commis, Dr Jcseph Lambert, Dr Paul-Êmile Paquin, médecins, Georges Chaperon, marchand, Charles-Edmond Turcotte, gérant, Martial Assclin, avocat, et Pierre Néron, shérif, tous de La Malbaic, pour les objets suivants: Recueillir de toute manière légale les argents ftour favoriser le progrès et le développement tie 'urbanisme, de l'éducation, de la santé publique et des oeuvres et organisations charitables, scientifiques, artistiques, sociales, éducationncllcs et philanthropiques dans la ville de La Malbaic, sous le nom de \"Centre Social de la Ville de La Malbaie Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à La Malbaie, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14933-58) Charlemagne Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Murray Lapin, de la ville de Hamp-steaa, Alan B.Gold, de Montréal, tous deux avocats, Joli an Eccles, de West mount, et Una Margaret Thompson, de Verdun, toutes deux secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Charlemagne Realty Corporation\", avec un capital total de $40,0C0, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 300 rue St-Sacrement, suite 215, Montréal, district judiciaire de Montréal.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of' December, 1958, incorporating: Samuel Chait, advocate, John Hamilton, secretary, both of Montreal, and Harry L.Ardnovitch, advocate, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, development, improvement and construction company, under the name of \"Cedarbrook Realties Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,200 common shares of $1 each and 35,800 preferred shares of $1 each.The head office of the company^ will be at 655 Beaumont Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14441-58) Centre Social de la Ville de La Malbaie Inc.Notice is- hereby given that under Part III df the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Alcide Harvey, annuitant, Joseph -Edgar Bergeron, Pierre-René Bouliane, accountants, Richard Maltais, clerk, Dr.Joseph Lambert, Dr.Paul-Emile Paquin, physicians, Georges Chaperon, merchant, Charles-Edmond Turcotte, manager, Martial Assclin, advocate, and Pierre Néron, sheriff, all of La Mal baie, for the following purposes: To gather in every legal way money to favor the progress and development of urbanism, education, public health and the organization of charitable works and organization of scientific, artistic, social, educational and philanthropical works in the town of La Malbaie, under the name of \"Centre Social de la Ville de La Malbaie Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at La Malbaie, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14933-58) Charlemagne Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the.Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Murray Lapin, of the Town of Hampstead, Alan B.Gold, of Montreal, both advocates, Johan Eccles, of West mount, and Una Margaret Thompson, of Verdun, both secretaries, filles majeures, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Charlemagne Realty Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 300 St.Sacrement Street, Suite 215, Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1969, Vol.91, No.8 853 Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14888-68) Chaussures Pierre Inc.\u2014 Pierre Shoes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1968, constituant en corporation: Jean-Paul Labrecque, comptable, Roger Beaulieu, avocat, tous deux de Montréal, et Rita Savaria Boivin, sociétaire, épouse con-tractuellement séparée de biens de Benoît Boivin, de Fabrcville, poui les objets suivants;.Exercer le commerce de chaussures, sous le nom de \"Chaussures Pierre Inc.\u2014 Pierre Shoes Inc.\", avec un capital divisé en 100 actions sans valeur au pair ou nominale et en 760 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 enacune, et le montant avec lequel a compagnie commencera ses opérations est de $8,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14968-58) Cie des Pelleteries et Fourrures Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dé Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Adolphe Isidore Kern, fourreur, Myra Polacek, ménagère, épouse séparée de biens dudit Adolphe Isidore Kern, tous deux de la ville de Côte St-Luc, et Bruno Ganske, fourreur, de Montréal, pour les objets suivants: Commerce de fourrures, sous le nom de \"Cie des Pelleteries et Fourrures Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 367, rue St-Paul, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.10014-59) Clairment Delisle Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: Charles Clément, avocat, Clairment Delisle, entrepreneur général, et Pauline Boutin, comptable, fille majeure et usant de ses droits,, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce du bois, du charbon et autres combustibles, de quincaillerie et faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de \"Clairment Delisle Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions communes de $5 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14888-58) Chaussures Pierre Inc.\u2014 Pierre Shoes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1968, incorporating: Jean-Paul Labrecque, accountant, Roger Beau-lieu, advocate, both of Montreal, and Rita Savaiia Boivin, secretary, wife contractually separate as to property of Benoit Boivin, of Fat)revilie, for toe following purposes: To deal in footwear, under the name of \"Chaussures Pierre Inc.\u2014Pierre Shoes Inc.\", witu a capital stock divided into 100 shares without nominal or par value and 750 preferred shares of a par value of $100 each, and the amount with which the company shad commence Its operations will be $8,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14968-58) Ciè des Pelleteries et Fourrures Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1958, incorporating: Adolphe Isidore Kern, furrier, Myra Polacek, housewife, wife separate as to property of the said Adolphe Isidore Kern, both of the town of Côte St-Luc, and Bruno Ganske, furrier, of Montreal, for the following purposes: To deal in furs, under the name of \"Cie des Pelleteries et Fourrures Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 367 St-Paul Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49S98 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10014-59) Clairment Delisle Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, incorporating: Charles Clément, advocate, Clairment Delisle, general contractor, and Pauline Boutin, accountant, of full age of majority and making use of her rights, all of Montreal, for the following purposes: To deal in lumber, coal and other fuels, hardware and carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Clairment Delisle Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $5 each and 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal-North, judicial district of Montreal. - .-,- 854 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1959, Tome 91, N° 8 (P.G.10056-59) Combo Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept janvier 1959, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, conseil en loi de la Reine, Clarence Reuben Gross, Rollin Gallay, tous trois avecats, et Sarah Miller, sténographe fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Négocier, mettre en valeurs et disposer d'immeubles ou intérêt en iceux, sous le nom de \"Combo Realties Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 90 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant.49898 P.FRENETTE.(A.G.10056-59) Combo Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of January, 1959, incorporating: Samuel David Rudenko, Queen's Counsel, Clarence Reuben Gross, Rollin Gallay, all three advocates, and Sarah Miller, stenographer, spinster of full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To deal with, turn to account and dispose of real estate or interest therein, under the name of \"Combo Realties Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 90 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will Ik- at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.14803-58) Concord Plaza Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation: Jack Rudner, Joseph Mendelson, avocats, Celia Cohen, Margaret Page et Beverley Wrathall, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Construire, posséder, louer, entretenir et exploiter des places marchandes, constructions et toutes autres sortes de bâtisses de manière à retirer un revenu de leur location, sous le nom de \"Concord Plaza Corp.\", avec un capital total de $200,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,800 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.14803-58) Concord Plaza Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: Jack Rudner, Joseph Mendelson, advocates, Celia Cohen, Margaret Page and Beverley Wrathall, secretaries, spinsters of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To build, own, lease, maintain and operate shopping centres, structures, and all other kinds of buildirgi in order to derive rental income from the leasing of same, under the name of \"Concord Plaza Corp.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 1,800 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.14822-58) Creva le Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Seymour Machlovitch, Morris Chai-kelson, avocats, et Nicole Paternault, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et développement, sous le nom de \"Crevale Development Coip.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune.(A.G.14822-58) Crevale Development Corp.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, advocates, and Nicole Paternault, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and development company, under the name of \"Crevale Development Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.Daté du bureau du Procureur général, le trente .Dated at the office of the Attorney General, et un décembre 1958.this thirty-first day of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 49898-o P.FRENETTE.49898 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1969, Vol.91, No.8 855 Le siège social de la compagnie sera à 9720 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.\u201e Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14957-58) Danjou Mines Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: René Daoust, homme d'affaires, de Ville d'Anjou, Robert Allaire, prospecteur, et Mme Jeannine Gagnon, secrétaire, épouse séparée de biens dudit Robert Allaire, tous deux de Châteauguay, pour les objets suivants: Taire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais et en exercer le commerce, sous le nom de \"Danjou Mines Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de 15,000,000, divisé en 5,000,000 actions communes d'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14702-58) Dapper Dan Men's Wear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des cempagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize décembre 1958, constituant en corporation: Charles Clark, marchand, Claude Morin, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, et Shirley Simon, secrétaire, fille majeure, d'Ou-tremont, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de bas, laine, cotonnades, soies, toiles, drap et tissus à vêtements, habits et accessrires de toutes sortes, sous le nom de \"Dapper Dan Men's Wear Inc.\", avec un capital total 9e $75,C00, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.13980-58) .Dionne Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, autorisant la fusion des compagnies \"Albert Dionne Limitée\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes du 16 avril 1946, et \"Dionne The head office of the company will be at 9720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, tnis twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14957-58) Danjou Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec bearing date the twenty-ninth day of December 1958, incorporating: René Daoust, business man, of the town of Anjou, Robert Allaire, prospector, and Mrs.Jeannine Gagnon, secretary, wife separate as to property of Robert Allaire, both of Châteauguay, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Danjou Mines Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $5,000.000, divided into 5,000,000 common shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to tne company lor its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth, day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14702-58) Dapper Dan Men's Wear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of December, 1958, incorporating: Charles Clark, merchant, Claude Morin, secretary, fille majeure, both of Montreal, and Shirley Simon, secretary, fille majeure, of Outremont, for the following purposes: To manufacture and deal in hosiery, wool, cotton fabrics, silks, linens, cloth and clothing materials, clothing and accessories of all kinds, under the name of \"Dapper Dan Men's Wear Inc.\", with a lotal capital stock of $75,000, divided into 250 common shares of $100 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13980-58) Dionne Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, authorizing the amalgamation of the companies \"Albert Dionne Limitée\", incorporated under Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent dated the sixteenth day of April, 1946, and \"Dionne Auto- 866 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1969, Tome 91, N° 8 Automobiles Incorporé\", constituée en corporation en vertu de la première partie de ladite Loi par lettres patentes du 9 janvier 1951, pour les menus objets et les mêmes fins que ceux que possèdent et poursuivent lcsdit.es compagnies, sous le ncm de \"Dionr.e Automobiles Inc.\",, avec un capital total divisé en 20,000 actions privilégiées \"A\" de $10 chacune, 10,000 actions privilégiées \"B\" de $10 chacune et en 10,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le nom de la nouvelle compagnie est \"Dionne Automobiles Inc.\".Le siège social de la nouvelle compagnie sera à Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.mobiles Incorporé\", incorporated under Part I of the said Act by letters patent dated January ninth, 1951, for the same objects and purposes as those owned and followed by the said companies, under the name of \"Dionne Automobiles Inc.\", with a total capital stock divided into 20,000 preferred \"A\" shares of $10 each, 10,000 preferred \"B\" shares of $10 each and into 10,000 common shares of $10 each.The name of the new company is \"Dionne Automobiles Ire\".The head office of the new company shall be at Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, on December thirty-first, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney Genera).(P.G, 14765-58) Dora Rabinovitch Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date, du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Alan B.Gold, Morris M.Weiner, tous deux avocats, de Montréal, et Shirley Mugge-ridge, secrétaire, fille majeure, de Verdun, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Dora Rabinovitch Corp.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 14,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 6275 rue Northcrest, App.817, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14596-58) Dora's Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix décembre 1958, constituant en corporation: Leonard Li verm an, Julius Brisk in et Arthur Yanofsky, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de rest amateur, sous le nom de \"Dora's Restaurant Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montiéal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14865-58) Dortal Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en cor- (A.G.14765-58) Dora Rabinovitch Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letter s patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Alan B.Gold, Morris M.Weiner, both advocates, of Montreal, and Shirley Muggeridge, secretary, spinster of the lull age of majority, of Verdun, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Dora Rabinovitch Corp.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 50 common shares of a par value of $100 each and 14,000 preferred shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at 6275 Northcrest Street, Apt.817, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14596-58) Dora's Restaurant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of December, 1958, incorporating: Leonard Liver-man, Julius Briskin and Arthur Yanofsky, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a restaurant, under the name of \"Dora's Restaurant Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 preferred shares of a par value of $10 each and 2,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14865-68) Dortal Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1969, Vol.91, No.8 857 poration: Godfrey Marin, avocat, de Pointe Claire, < Yvonne Bélanger, et Sylvia Vineberg, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Acheter ou autrement acquérir et détenir, posséder, y construire et développer à des fins de placements, certains emplacements situés dans la cité de Montréal, et agir comme bailleurs et administrateurs en ce qui se rapporte à iceux, sous le nom de \"Dortal Investments Ltd.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 400 actions ordinaires de $50 chacune et 4,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14857-58) Edward de Yos Church Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Lci des cempagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Samuel H.Shriar, avocat, de St-Laurent, Max Polak, étudiant en droit, et Mollie Schwartz, secrétaire, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre et autrement faire le commerce d'articles ecclésiastiques et religieux de toutes sortes et descriptions, sous le nom de \"Edward de Vos Church Supplies Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14842-58) Electra Park Development Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Jack Light stone, Marvin Riback et John J.Gotlieb, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie déplacements, sous le nom de \"Electra Park Development Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14786-58) E.Meneghini & Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation: Samuel Chait, avocat, John Hamil- Godfroy Marin, advocate, of Pointe Claire, Yvonne Bélanger- and Sylvia Vineberg, secretaries, filles majeures, of Montreal, for the following purposes: * To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on and develop for investment purposes certain emplacements in the city of Montreal, and to act as lessors and administrators in connection therewith, under the name of \"Dortal Investments Ltd.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 400 common shares of $50 each and 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49S98-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14857-58) Edward de Vos Church Supplies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Qi ebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Samuel H.Shriar, advocate, of St.Laurent, Max Polak, law student, and Mollie Schwartz, secretary, both of Montreal, for the following purposes: To buy, sell and otherwise deal in church ecclesiastical and religious articles of all kinds and descriptions, under the name of \"Edward de Vos Church Supplies Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14842-58) Electra Park Development Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: .Jack Lightstone, Marvin Riback and John J.Gotlieb, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Electra Park Development Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14786-58) E.Meneghini & Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: Samuel Chait, advocate, John Hamilton, secretary, 858 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1969, Tome 91, N° 8 ton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Aronobitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Gérer et exercer un commerce de peinture et agir comme peintres décorateurs, sous le nom de \"E.Mencghini & Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, 997 actions privilégiées, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,900 actions privilégiées, catégorie \"B**, d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie seia à 2370\" Chemin Lucerne, Ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14979-58) Faucher Magasin à Rayons Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: Gregory Charlap, Max Slapack et Arthur Shulman, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de marchandises sèches, textiles, fournitures de maison, bibelots, menus articles, effets vestimentaires de toutes sortes et descriptions, articles de toilettes et autres marchandises de nature similaire, sous le nom de \"Faucher Magasin à Rayons Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.13399-58) Fortin Automobile Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Charles Fortin, garagiste, Gilbcrtc Fortin, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Charles Fortin, tous deux de Sherrington, et Rodolphe Malien, comptable agréé, d'Outremont, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'automobiles, meubles, couvre-planchers, tentures et nouveautés de toutes sortes; sujet aux dispositions de la loi concernant ces matières, exploiter des hôtels, motels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de \"Fortin Automobile Ltée\", avec un capital total de 175,000, divisé en 5,000 actions communes de $10 chacune et en 2,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherrington, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.both of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To conduct and carry on the business of painting and decorating contractors, under the name of \"E.Meneghini & Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3 common shares of a par value of $1 each, 997 class \"A\" preferred shares of a par value of $1 each and 3,900 class \"B\" preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 2370 Lucerne Road, town of Mount Royal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General» this twenty-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 40898-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.14979-58) Faucher Magasin à Rayons Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, incorporating: Gregory Charlap, Max Slapack and Arthur Shulman, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To deal in dry goods, textiles, household furnishings, notions, smallwares, wearing apparel of any kind and description, toilet articles and other merchandise of a line nature, under the name of \"Faucher Magasin à Rayons Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13399-58) Fortin Automobile Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December 1958, incorporating: Charles Fortin, garage-keeper, Gilherte Fortin, housewife, wife separate as to property of the said Charles Fortin, both of Sherrington, and Rodolphe Maheu, chartered accountant, of Outremont, for the following purposes: To deal in automobiles, furniture, floor coverings, hangings and novelties of every nature and kind; subject to the provisions of the Act respecting the following; operate hotels, motels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Fortin Automobile Ltée\", with a total capital stock of $75.000, divided into 5,000 common shares of $10 each and 2,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Sherrington, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February S1H, 1959, Vol.91, No.8 85» (P.G.14622-58) Gaétan Desabrais Inc.Avis est donné qu'en vertu de Ja première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: Gaétan Desabrais, agent d'assurances, Frédéric Hébert et Jean-Paul Dupuy, notaires, tous de Noranda, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtiers et agents d'assurances, sous le nom de \"Gaétan Desabrais Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14912-58) Gas Propane Blanchard Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre décembre 1958, constituant en corporation: Paul Lemieux, avocat, de St-Laurent, Mary Mathoul, secrétaire, épouse séparée de biens de Gaston Mathoul, et Lyette Maynard, secrétaire, célibataire, toutes deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de gaz propane et autres combustibles, sous le nom de \"Gaz Propane Blanchard Ltée\", avec un capital total de $40,-000, divisé en 1,000 actions communes d'une valeur au pair de $1 chacune, 3,800 actions privilégiées classe \"A\" d'une valeur au pair de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées classe \"B\" d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5300, boulevard Lévêque, Ville de Saint-Vincent-de-Paul, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14809-58) Glenrand Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation : Samuel (liait/ avocat, John Hamilton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, développement, amélioration et construction, sous le nom de \"Glenrand Investments Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 1,000 actions privilégiées, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,800 actions privilégiées, catégorie \"B\", d'une valeur au pair de $10 chacune.Le, siège social de la compagnie sera à 622 65e Avenue, L'Abord-à-Plouffe, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.14622-58) Gaétan Desabrais Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, incorporating: Gaétan Desabrais, insurance agent, Frédéric Hébert and Jean-Paul Dupuy, notaries, all of Noranda, for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers and agents, under the name èf \"Gaétan Desabrais Inc.\", with a total capital stock of $40,000» divided into 40,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14912-58) Gas Propane Blanchard Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth .day of December, 1958, incorporating: Paul Lemieux, advocate, of St-Laurent, Mary Mathoul, secretary, wife separate as to property of Gaston Mathoul, and Lyctte Maynard, secre- -tary, spinster, both of Montreal, for the following purposes: To operate a business dealing in propane gas and in other fuels, under the name of \"Gaz Propane Blanchard Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each, 3,800 preferred class \"A\" shares of a par value of $10 each and into 1,000 preferred class \"B\" shares of a par value ot $1 each.The head office oi the company will be at 5300 Lévêque Boulevard, Ville of St-Vincent-de-Paul, judicial ai strict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14809-58) Glenrand Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have-been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958.incorporaring: Samuel Chait, advocate, John Hamilton, secretary, both of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of a land, development, improvement and construction company, under the name of \"Glenrand Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each, 1,000 class \"A\" preferred shares of a par value of $1 each and 3.800 class \"B\" preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 622 65th Avenue, L'Abord-à-Plouffe, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 91 février 1969, Tome 91, N° 8 (P.G.14754-58) G.M.Barry Morton Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par .le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Henry Weir Davis, avocat et conseil en loi de la Reine, Ross Trenholme Clarkson, avocat, et Frank Wright, gérant de bureau, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce de courtiers d'assurances et agir comme agents d'assurances, sous le nom de \"G.M.Barry Morton Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 6,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5' chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14767-58) Gordon Textile Dyers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres pater.tcs, en date du dix-reuf décembre 1958, constituant en corporation: Louis Orerstcin, avocat, Alan Gd.len, gérant, tous deux d'Outremont, Jason Ruby, avocat, de Montréal, et Huguctte St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de l'Ile Perrot, pour les objets suivants: Exercer le commerce de teinturiers, finisseurs, blanchisseurs et'inspecteurs de textiles et articles vestimentaires, sous le nom de \"Gordon Textile Dyers Ltd.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14997-58) Goyette (Ormstown) Transport Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: Hervé Bélanger, avocat, Cécile Contant, secrétaire, célibataire, tous deux de Montréal, et.René Paiement, avocat, de Roxboro, pour les objets suivants: Exploiter des entreprises de camionnage et généralement faire le transport de personnes et de marchandises, sous le nom de \"Goyette (Ormstown) Transport Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Oms-town, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(A.G.14754-58) G.M.Barry Morton Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Henry Weir Davis, advocate and Queen's Counsel, Ross Trenholme Clarkson, advocate, and Frank Wright, -office manager, all of Montreal, for the following purposes: \\.To carry on the business of insurance brokers and to act as insurance agents, under the name of \"G.M.Barry Morton Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 6,000 preferred shares of a par value of $5 each and 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the* office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14767-58) Gordon Textile Dyers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of .Qjebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Louis Orenstein, advocate, Alan Golden, manager, both of Chit re m ont, Jason Ruby, advocate, of Montreal, and Huguctte St-Marseille, secretary, fille majeure, of lie Perrot, for the following purposes: To carry cn business as dyers, finishers, bleachers and examinons of textiles and articles of clothing, under the name of \"Gordon Textile Dyers Ltd.\", with a total capital stock of $75,-000, divided into 250 common shares of $100 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14997-58) Goyette (Ormstown) Transport Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, incorporating: Hervé Bélanger, advocate, Cécile Contant, secretary, spinster, both of Montreal, and René Paiement, advocate, of Roxboro, for the following purposes: Operate trucking concerns and to generally engage in the carrying trade of persons and goods, under the name of \"Goyette (Ormstown) Transport Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of $10 each and 2,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company will be at Ormstown, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the.Attorney General, this thirty-first dav of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1969, Vol.91, No.8 861 (P.G.14683-58) Hébert & Lagacé Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: Frédéric Hébert, Jean-Paul Dupuy, notaires, et Renaud Lagacé, agents d'assurances, tous de Noranda, pour Jes objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de courtiers et agents d'assurances, sous le ncm de \"Hébert & Lagacé Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 20,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Noranda, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14597-58) Helainia Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq décembre 1958, constituant en corporation: Stanley D.Haltrecht, notaire, Sylvia Haltrecht, ménagère, épouse séparée de biens dudit Stanley D.Haltrecht, et Maurice Gold, comptable agréé, tous de St-Laurent, pour les objets suivants: Exercer le commeice d'une compagnie de terrains, amélioration, construction et administration, sous le nom de \"Helainia Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en T.000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.# Daté du bureau du Procureur général, le cinq décembre 1958.L'Assistant-procureur général -suppléant, 49898 , P.FRENETTE.(A.G.14683-58) Hébert & Lagacé Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, incorporating: Frédéric Hébert, Jean-Paul Dupuy, notaries, and Renaud Lagacé, insurance agent, all of Noranda, for the following purposes: To carry on the busmess of insurance brokers and agents, under the name of \"Hébert & Lagacé Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 20,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Noranda, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14597-58) Helainia Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of December, 1958, incorporating: Stanley D.Haltrecht, notary, Sylvia Haltrecht, housewife, wife separate as to property of the said Stanley D.Haltrecht, and Maurice Gold, chartered accountant, all of St.Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a land, improvement, construction and management company, under the name of \"Helainia Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.14603-58) II.-E.Lalancette Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Rose-Ai mée Lévesque, Simonne Pot vin, sténographes, célibataires, et Cyrille Potvin, avocat, tous de Robcrval, pour les objets suivants: Faire le commerce de vêtements, sous le nom de \"II.-E.Lalancette Inc.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 75,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Roberval, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(A.G.14603-58) H.-E.Lalancette Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1958, incorporating.: Rose-Aimée Lévesque, Simonne Potvin, stenographers, spinsters, and Cyrille Potvin, advocate, all of Roberval, for the following purposes: To carry on a business dealing in clothing, under the name of \"H.-E.Lalancette Inc.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 75,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Roberval, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14859-58) Hernims Investments Ltd.(A.G.14859-58) Hermms Investments.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the twenty- 862 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1959, Tome 91, N° 8 du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en loi de la Reine, de West mount, Ethel Yussem, secrétaire, et Jean McFarlane, dactylo, toutes deux filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Hermms Investments Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 20,000 actions sans valeur nominale ou au pair de 15,000 actions privilégiées de $100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses activités sera de $250,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14875-58) Kingston Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation : Bernard Diamond, Harold Gossack, Jason Ruby, avocats, et Hyman L.Rosenfeld, comptable agréé, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrain et développement, sous le nom de \"Hingston Development Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 7480 rue Mountain Sights, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14788-58) Holmar Investments & Realty Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation: David Holtzman, vendeur, Helen Margolian Holtzman, ménagère, épouse séparée de biens dudit David Holtzman, et Harry H.Kliger, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Holmar Investments & Realty Co.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,000 actions, catégorie \"A\", «l'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5110 avenue Bessborough, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.ninth day of December, 1958, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, Ethel Yussem, secretary, and Jean McFarlane, typist, both filles majeures, of Montreal; for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Hermms Investments Ltd.\", with a capital stock divided into 20,000 shares having no nominal or par value and 15,000 preferred shares of $100 each, and the amount with which the company will commence its operations will be $250,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14875-58) Hingston Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing tlate the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Bernard Diamond, Harold Gossack, Jason Ruby, advocates, and Hyman L.Rosenfeld, chartered accountant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land and «levelop-ment company, under the name of \"Hingston Development Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The \"head office of the company will be at 7480 Mountain Sights Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated athe office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14788-58) Holmar Investments & Realty Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, I95S.incorporating: David Holtzman, salesman.Helen Margolian Holtzman, housewife, wife separate as to property of the said David Holt/man.and Hurry H.Kliger, advocate, all of Montreal, for the following pur] loses: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Holmar Investments & Realty Co.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 1,000 class \"A\" shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 5110 Bessborough Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE; Quebec, February Blet, 1969, Vol.91, No.8 863 (P.G.14489-58) Hôtel St-Maurice Incorporée 4 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Edmour Hudon, hôtelier, des Trois-Rivières, Armand PloufL?, homme d'affaires, et Robert-M.Gendron, comptable, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers et restaurateurs, sous le nom de \"Hôtel St -Maurice Incorporée\", avec un capital total de $200,000, divisé en 1,000 actions communes de $100 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.* L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14538-58) Invicta Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Hairy G laze r, marchand, Êlaine Rohr, ménagère, épouse séparée de biens dudit Harry Glazer, Alan Glazer, marchand, et Lillian Mos-eoviten, ménagère, épouse sépaiéc de biens dudit Alan Glazer, tous de Montréal, pour les objets suivants: r.- Fabriquer et faire le commerce de marchandises, articles, produits et effets dans les spécialités, telles que cadeaux, bijouterie et nouveautés, sous le nom de \"Invicta Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté, du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14806-58) Isolation Maritime Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: William Bel/il, agent d'assurances, de Québec, Raoul Langelîer, contremaître en isolation, de Montréal, et Pierre Rouleau, industriel, de Plessisville, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'isolants, sous le nom de \"Isolation Maritime Inc.\", avec un capital total de $25.000, divisé en 125 actions communes de $100 chacune et en 125 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(A.G.14489-58) Hôtel St-Maurice Incorporée Notice is hereby given that under Part I of.the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958J incorporating: Edmour Hudon, hotel-keeper, of Trois-Rivières, Armand Plouffe, business man, and Robert-M.Gendron, accountant, of Montreal, for the following purposes: To cany on business as hotel-keepers and restaurators under the name of \"Hôtel St-Maurice Incorporée\", with a total capital stock of $200,000 divided into 1,000 common shares of $100 each and into 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 .Acting Deputy Attorney General.(A.G.14538-58) Invicta Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Harry Glazer, merchant, Elaine Rohr, housewife, wife separate as to property of the said Harry Glazer, Alan Glazer, merchant,* and Lillian Moscovitch, housewife, wife separate as to property of the said Alan Glazer, all of Montreal, for.the following purposes: To manufacture and deal in goods, wares, products and merchandise in lines such as gift-ware, jewellery and novelties, under the name of \"Invicta Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will' be at Montreal, judicial distict of Montreal.Dated at the office of the Attoiney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14806-58) Isolation Maritime Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: William Belzil, insurance agent, of Quebec, Raoul Langelier, isolation foreman, of Montreal, and Pierre Rouleau, industrialist, of Plessisville, for the following purposes: To carry on a business dealing in insu lan ts, under the name of \"Isolation Maritime Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 125 common shares of $100 each and into 125 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General. 864 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 féerier 195», Toms 91, N° 8 (P.G.14981-58) Janep Ltée \u2014 Avis est donné qu'en vertu de la' première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: Marc Jessop, avocat, de Ste-Foy, Jean-Paul Joubert, professeur, et Philippe Mi-chaud, comptable de Rimouski, pour les objets suivants: .Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Janep Ltée\", avec un capital total de $40,-000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 87, rue de PÉvéché, Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958» L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o .P.FRENETTE.(P.G; 14615-58) Jf.-A.Roy Auto Parts Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Lionel Roy, industriel, Mme Ursule Hamel Roy, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Lionel Roy, tous deux de Sillery, et Jean Bernard, gérant, de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'accessoires et pièces pour automobiles et autres véhicules, sous le nom de \"J.-A.Roy Auto Parts Ltd.\", avec un capital tetal de $40,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 830, boulevard Charest, est, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14748-58) Jean Gervals Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Guy Girard notaire, d'Outremont, Lucien Pépin, notaire, et Jeannine Deschamps Picotte, veuve, secrétaire, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un ascenseur, maison d'entreposage et emmagasinage, sous le nom de \"Jean Gervais Inc.\", avec un capital total de $200.000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et 1,500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5270 rue Henri-Julien, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.14981-58) Janep Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty -first day of December, 1958, incorporating : Marc Jessop, advocate, of Ste-Foy, Jean-Paul Joubcrt, professor, and Philippe Michaud, accountant, of Rimouski, for the following purposes: To carry on a business dealing in real estate, under the name of \"Janep Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each, and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 87 l'Évêché Street, Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 \u2022 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14615-58) J.-A.Roy Auto Parts Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Lionel Roy, industrialist, Mrs.Ursule Hamel Roy, housewife, wife contractually separate as to property of the said Lionel Roy, both of Sillery, and Jean Bernard, manager, of Quebec, for the following purposes: To carry on a business dealing in accessories and spare parts for automobiles and other vehicles, under the name of \"J.-A.Roy Auto Parts Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 830 Charest .Boulevard, East, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office \"of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14748-58) Jean Gervais Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Guy Girard, notary, of Outremont, Lucien Pépin, notary, and Jeannine Deschamps Picotte, widow, secretary, of Montreal, for the following purposes: To generally carry on an elevator, warehouse and storage business, under the name of \"Jean Gervais Inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 500 common shares of $100 each and 1,500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 5270 Henri-Julien Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Blet, 1969, Vol.9h No.8 865 (P.G.14876-68) Jarry Rubin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes/en date du vingt-neuf décembre 1968, constituant en corporation: Julius Rubin, préposé à un poste de service, Sadie Gersovitz, secrétaire, célibataire, tous deux de Montréal, et Louis Freedman, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Fabriquer, négocier et faire le commerce de voitures de transport, véhicules et les accessoires et pièces d'iceux; exploiter des postes de service et garages, sous le nom de \"Jerry Rubin Inc\", avec un capital total de 140,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à.4814 Chemin Côte St-Luc, Montréal, district judiciaire de Montiéal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.13186-58) Joanne Modes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Julius Fedor, dessinateur, Bernard Cou sin eau, avocat, et Annette Daveluy, sténographe, célibataire majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de chapeaux, vêtements et accessoires pour dames, sous le nom de \"Joanne Modes Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1310, rue Mont-Royal, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14274-58) Jos.Beauregard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Joseph Beauregard, homme d'affaires, Robert Beauregard, comptable, et Yolande Beauregard Brodeur, ménagère, épouse séparée de biens de Pierre Brodeur, tous de St-Hyacinthe, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tabac, bonbons, cigarettes et brimborions (smallwares), sous le nom de \"Jos.Beauregard Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 229, Onzième Avenue de la Concorde, Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(A.G.14876-58) Jarry Rubin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: \"Julius Rubin, service station operator, Sadie Gersovitz, secretary, spinster, both of Montreal, and Louis Freedman, advocate, and Queen's Counseil, of the town of Côte St.Luc, for the iollowing purposes: To manufacture, trade and deal in and with conveyances and vehicles and the accessories and parts thereof and to operate service stations and garages, under the name of \"Jerry Rubin Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferres shares of $100 each.The head office of the company will be at 4814 Côte St.Luc Road, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1968.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13186-58) Joanne Modes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date eighteenth day of December, 1958, incorporating: Julius Fedor, draftsman, Bernard; Cousineau, \u2022 advocate, Ap-nette Daveluy, stenographer, spinster of full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To deal in hats, ladies' wear and accessories, under the name of \"Joanne Modes Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1310 Mount Royal Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December 1968.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.\u2022 (A.G.14274-58) Jos.Beauregard Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Joseph Beauregard, business man, Robert Beauregard, accountant, and Yolande Beauregard Brodeur, housewife, wife separate as to property of Pierre Brodeur, all of St-Hyacinthe, for the following purposes: To carry on a business dealing in tobacco, bonbons, cigarettes and smallwares, under the name of \"Jos.Beauregard Lie\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at 229 Eleventh Avenue of la Concorde, Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General. 866 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, tl février 1959, Tome 91, N° 8 (P.G.14768-58) K & K Importing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1058, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, Alan Golden, gérant, tous deux d'Outre m ont, Jason Ruby, avocat, de Montréal, et Huguette St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de l'Ile Perrot, pour les objets su i vanta: Importer des articles vestimentaires pour hommes, dames et enfants, sous le nom de \"K & K Importing Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé>n 100 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune et 100 actions, catégorie \"A\", de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14982-58) Koban Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: Paul E.Côté, entrepreneur, Edgar Banville, contremaître, et Philippe Michaud, comptable agréé, tous de Rimouski, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs, sous le nom de \"Koban Construction Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 3,000 actions provil(H de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 36, avenue Biais, Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1058.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14367-58) Laboratoires Mériot Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Claude Moncel Tétrault, Jacques Té-trault et Morgan Carlyle Johnston, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et généralement faire le commerce en gros de préparations pharmaceutiques et médicales, spécialités médicales et produits chimiques de toutes sortes, le tout sous réserve de la Loi de pharmacie de Quél>ec, sous le nom de \"La-, boratoires Mériot Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(A.G.14768-58) K & K Importing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Louis Orenstein, advocate, Alan Golden, manager, both of Outremont, Jason,Ruby, advocate, of Montreal, and Huguette St-Marseille, secretary, fille majeure, of lie Perrot, for the following purposes: To import men's, ladies' and children's wearing apparel, under the name of \"K & K Importing Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,-000, divided into 100 common shares of $100 each, 200 preferred shares of $100 each and 100 Class \"A\" shares of $100 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14982-58) Koban Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, incorporating: Paul-E.Côté, contractor, Edgar Banville, foreman, and Philippe Michaud, chartered accountant, all of Rimouski, for the following purposes: To carry on business as builders, under the name of \"Koban Construction Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 36 Biais Avenue, Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14367-58) Laboratoires Mériot Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the thirtieth day of December, 1958, incorporating:' Claude Moncel Tétrault, Jacques Tétrault and Morgan Carlyle Johnston, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and generally carry on the wholesale business of pharmaceutical and medical preparations, patent médecines and chemical products of all kinds, all of which subject to the Quebec Pharmacy Act, under the name of \"Laboratoires Mériot Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 shares of $1 each.The head office of the company' will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of Decemlier, 1958.P.FRENE'lTE, 49898 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1959, Vol.91, No.8 867 (P.G.14952-58) La Cie Kirby du St-Laurent Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a étéa ccordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Rosaire Cormier, distributeur, Laurette Marineau Cormier, ménagère, épouse commune en biens dudit Rosaire Cormier, et Marc Jessop, avocat, tous de Ste-Foy, pour les objets suivante: Exercer le commerce de balayeuses et accessoires électriques et plus spécialement le système sanitaire Kirby, sous le nom de \"La Cie Kirby du St-Laurent Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sillery, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.13567-58L, La Compagnie de Publication Malouine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation: Mario Du Mesnil, avocat, Hélène Lampion et Denise Sauvageau, toutes deux secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les activités d'entrepreneurs de publicité et de conseillers en publicité, sous le nom de \"La Compagnie de Publication Malouine Inc.\", avec un capital total de $49,000, divisé en 900 actions ordinaires de $10 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.a Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14934-58) Landfine Investment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation : Murray Lapin, de la ville de Hamp-stead, Alan B.Gold, de Montréal, tous deux avocats, Johan Eccles, de Westmount, et Una Margaret Thompson, de Verdun, tous deux secrétaire, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Landfine Investment Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 6605 Chemin Nice, ville Côte St-Luc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.14952-58) La Cie Kirby du St-Laurent Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1958, incorporating: Rosaire Cormier, distributor, Laurette Marineau Cormier, housewife, wife common sas to property of the said Rosaire Cormier, and Marc Jessop, advocate, all of Ste-Foy, for the following purposes: To carry on a business dealing in electrical sweepers and accessories and especially the Kirby Sanitary System, under the name of \"La Cie Kirby du St-Laurent Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sillery, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13567-58) La Compagnie de Publication Malouine Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: Mario Du Mesnil, advocate, Hélène Lampron and Denise Sauvageau, both secretaries, filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of advertizing contractors and advisers, under the name of \"La Compagnie de Publication Malouine Inc.\", with a total capital stock of $49,000, divided into 900 common shares of $10 each and 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14934-58) Landfine Investment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Murray Lapin, of the town of Hampstead, Alan B.Gold, of Montreal, both advocates, Johan Eccles, of Westmount, and Una Margaret Thompson, of Verdun, both secretaries, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Landfine Investment Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 6605 Nice Road, town of Côte St.Luc, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General. 868 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SI février 1969, Tome 91, N° 8 (P.G.14983-68) L'Association des Courtiers en Bois de Pulpe de Québec Quebec Pulpwood Brokers Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Fernand Boutin, ingénieur forestier, Camille Lacroix, industriel, tous deux de Québec, Frank Byrne, Jean-Charles Gagnon, Sévère Théberge, industriels, Martin Simak, ingénieur forestier, tous quatre de Sillery, Eustache Soucy, de Rimouski, et Oscar Soucy, de St-Alexandre, tous deux industriels, pour les objets suivants: Grouper en association, en vue de leurs intérêts et de la protection et de l'aménagement des ressources forestières, les courtiers en bois de pulpe de Québec, sous le nom de \"L'Association des Courtiers en Bois de Pulpe de Québec \u2014 Quebec Pulpwocd Brokers Association\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $60,000.Le siège social de la corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14599-58) L'Association des Pharmaciens du district de Québec, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Ls-Philippe Deniers, de Sillery, Georges Filteau, de Ste-Foy, Jacques Léveilié, de Québec, et Raymond Martel, de Lorettcville, tous pharmaciens, pour les objets suivants: Grouper en association, en vue de leurs intérêts, les pharmaciens licenciés du district pharmaceutique de Québec, sous le nom de \"L'Association des Pharmaciens du District de Québec, Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 .P.FRENETTE.(P.G.14841-58) Laval Lithographing Ltd.Lithographie Laval Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: François Wilhelmy, Bernard Cousi-neau, avocats, et Annette Daveluy, sténographe, fille majeure, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: .Exercer le commerce du papier et faire affaires comme éditeurs, imprimeurs, graveurs et litho- (A.G.14983-58) L'Association des Courtiers en Bois de Pulpe de Québec Quebec Pulp wood Brokers Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Fernand Boutin, forestry engineer, Camille Lacroix, industrialist, both of Quebec, Frank Byrne, Jean-Charles Gagnon, Sévère Théberge, industrialists, Martin Simak, forestry engineer, all four of Sillery, Eustache Soucy, of Rimouski, and Oscar Soucy, of St.Alexandre, both industrialists, for the following purposes: To group the Quebec Pulpwood Brokers into an association, with in view to their interests and the protection and planning of forestry resources, under the name of \"L'Association des Courtiers en Bois de Pulpe de Québec \u2014 Quebec Pulpwood Brokers Association\".¦ The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.«,- The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, tin's thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14599-58) L'Association des Pharmaciens \u2022 du district de Québec, Inc.Notice is hereby given that under Part IDT of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province fo Quebec, bearing date the ninth day of December, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Ls.-Philippe Demers, of Sillery, Georges Filteau, of Ste-Foy, Jacques Léveilié, of Quebec, and Raymond Martel, of Lorettcville, all pharmcaists, for the following purposes: To group into an association, in view of their interests, the licenced pharmacists of the pharmaceutical district of Quebec, under the name of \"L'Association des Pharmaciens du District de Québec, Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of December, 1958._ P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14841-58) Laval Lithographing Ltd.Lithographie Laval Ltée Notice is hereby given that .under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: François Wilhelmy, Bernard Cousineau, advocates, and Annette Daveluy, stenographer, spinster, of full age, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in paper, and to carry on business as editors, printers, engravers QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February gist, 1969, Vol.91, No.8 869 Îraveurs, sous le nom de \"Laval Lithographing ltd.\u2014 Lithographie Laval Ltée\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 24, rue Corbeil, Laval-des-Rapides, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.10081-59) Le Club de Ski de St-Angële du Mont-Joli Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept janvier 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Bertrand Dandonneau, industriel, Gaston Thibault, commerçant, Raymond DesRosiers, comptable, Louis Cyr, commis de bureau, Guy d'Anjou, courtier en assurances, et Georges-Henri Dubé, notaire, tous de Mont-Joli, pour les objets suivants: Former et administrer un club sportif et promouvoir en particulier le sport du ski, sous le nom de \"Le Club de Ski de Ste-Angèle du Mont-Joli\".Le montant auquel font limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $15,000.Le siège social de la corpora (ion sera à Mont-Joli, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le sept janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE, (P.G.14921-58) Leon Developments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre décembre 1958, constituant en corporation: Leon Kagan, marchand, Daniel Kingstone, avocat, et Katherine Ingledew, sténographe, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce et le négoce de propriétés immobilières, sous le nom de \"Leon Developments Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions oui mai res d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montiéal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14867-58) Lerna Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Neil Phillips, avocat, Sylvia Vine-berg, Yvonne Bélanger, toutes deux secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, et Godfrey Marin, avocat, de Pointe Claire, pour les objets suivants: and lithographers, under the name of \"Laval Lithographing Ltd.\u2014 Lithographie Laval Ltée\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 24 Corbeil Street, Laval-des-Rapides, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10081-59) Le Club de Ski de St-Angële du Mont-Joli Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of January, 1959, to incorporate as a corporation without share capital: Bertrand Dandonneau, industrialist, Gaston Thibault, trades-men, Raymond DesRosiers, accountant, Louis Cyr, office clerk, Guy d'Anjou, insurance broker, and Georges-Henri Dubé, notai y, all of Mont-Joli, for the following purposes: To form and administrate a sporting club and to promote especially the sport of skiing, under the name of \"Le Club de Ski de Ste-Angèle du Mont-Joli\".The amount to whicn the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $15,000.The head office of the corporation will be at Mont-Joli, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attoiney General, this seventh day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14921-58) Leon Developments Ltd.\u2022 Notice is hereby given that under Part 1 of th-j Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of Deceinner, 1958, incorporating: Leon Kagan, merchant, Daniel Kingstone, barrister, and Katherine Ingledew, stenographer, spinster, ail of Montreal, for the following purposes: To deal in and with immoveable property, under the name of \"Leon Developments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares having a par value of $10 each and 2,000 preferred shares having a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, tnis twenty-fourth day of December, 1958.' P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14867-58) Lerna Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Neil Phillips, advocate, Sylvia Vineberg, Yvonne Bélanger, both secretaries, filles majeuers, all three of Montreal, and Godfroy Marin, advocate, of Pointe Claire, for the following purposes: 870 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, tl février 1969, Tome 91, N°8 Acheter ou autrement acquérir' et détenir, posséder, y construire et développer à des fins de* Elacements, un certain emplacement situé dans i vdle de Saint-Léonard de Port-Maurice et agir comme bailleurs et administrateurs, en ce qui se rapporte à icelui sous le nom de \"Lerna Development Corp.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 20,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 ' P.FRENETTE.(P.G.14795-58) Le Roy Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt décembre 1958, constituant en corporation: Cam il Noël, conseil en loi de la Reine, Claude Rioux, avocats, et Fernand Sirois, comptable agréé, tous de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de Êlacements, sous le nom de \"LeRoy Holdings ae.\", avec un capital total de $250,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 4,000 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 195P.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.'14974-58) Les Entreprises Duchesne Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958.constituant en corporation: .1.-Jacques Beauchcmin, avocat, d'Outre-mont, Madeleine Riel, secrétaire, fille majeure, et André Valiquctte, avocat, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"Les Entreprises Duchesne Limitée\", avec un capital total dé $200,000, divisé en 1,000 actions communes d'une valeur au pair de $5 chacune, 1,000 actions privilégiées classe \"A\" d'une valeur au pair de $5 chacune et en 1,900 actions privilégiées classe \"B\" d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Yama-'chiche, district judiciaire de Saint-Maurice.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.11674-58) Les Knl reprises Nadon Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Archange Nadon, Conrad Nadon, menuisiers, et Etienne Nadon, entrepreneur, tous de Fabreville.pour les objets suivants: To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on and develop for investment purposes a certain emplacement situate in the Town of St.Leonard de Port Maurice and to act as lessors and administrators in connection therewith,, under the name of \"Lerna Development Corp.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 20,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14795-58) LeRoy Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of December, 1958, incorporating: Camil Noël, Queen's Counsel, Claude Rioux, advocates, and Fernand Sirois, chartered accountant, all of Quebec, for the following purposes: To carry on a a business as a holding company under the name of \"LeRoy Holdings Inc.\", with a tetal capital stock of $250,000, divided into 5,000 common shares of $10 each and into 4,000 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14974-58) Les Entreprises Duchesne Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, of Quebec, bearing date the thirtieth day of December 1958, incorporating: J.Jacques Beauchemin, advocate, of Outremont, Madeleine Riel, secretary, fille majeure, and André Vali-quette, advocate, of Montreal, for the following purposes: .To carry on the business of an investment and holding company, under the name of \"Les Entreprises Duchesne Limitée\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $5 each, 1,000 preferred shares Class \"A\" of a par value of $5 each and 1,900 preferred shares Class \"B\" of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Yamachiche, judicial district of Saint Maurice.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11674-58) Les Entreprises Nadon Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Archange Nadon, Conrad Nadon, carpenters, and Etienne Nadon, contractor, all of Fabreville, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1959, Vol.91, No.8 871 Exercer le commerce d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Les Entreprises Nadon Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 28, 6ème avenue sud, Fabreville, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14751-58) Les Entreprises O'Connell Ltée O'Connell Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en corporation : Roy Fraser Elliott, avocat, de ville Mont-Royal, Margot Mary Quinn et Mary Elizabeth Spracklin, secrétaires, célibataires, toutes deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Les Entreprises O'Connell Ltée \u2014 O'Connell Enterprises Ltd.\", avec un capital total de $12,001,000, divisé en 12,000 actions privilégiées d'Une valeur au pair de $f,000, chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à 6460 Chemin Côte-de-Liesse, Dorval, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14602-58) Les Immeubles de Rouville Ltée De Rouville Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Jean Filion, conseil en loi de la Reine, de Ville Mont-Royal, Jean Badeaux, de la ville de Hampstead, et Claude Béland, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs g'néraux en construction, sous le nom de \"Les Immeubles de Rouville Ltée \u2014De Rouville Realties Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune et en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Bclœil, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.49898-o P.FRENETTE.(P.G.14703-58) Les Immeuble» J.T.Z.Patenaude Ltée J.T.Z.Patenaude Realties Ltd.To carry on the business of a construction company, under the name of \"Les Entreprises Nadon Ltée\", with a total capital stock of $40,-000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 28, 6th.Avenue South, Fabreville, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attotney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14751-58) Les Entreprises O'Connell Ltée O'Connell Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Roy Fraser Elliott, advocate, of the Town of Mount Royal, Margot Mary Quinn and Mary Elizabeth Spracklin, secretaries, spinsters, both of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction company, under the name of \"Les Entreprises O'Connell Ltée \u2014 O'Connell Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $12,001,000, divided into 12,000 preferred shares of a par value of $1,000 each and 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at 6460 Côte-de-Liesse Road, Dorval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December.1958.P.FRENETTE.49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14602-58) Les Immeubles de Rouville Ltée De Rouville Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Jean Filion, Queen's Counsel, of the Town of Mount Royal, Jean Badeaux, of the Town of Hampstead, and Claude Béland, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To deal in real estate; carry on business as general building contractors, under the name of \"lies Immeubles de Rouville Ltée \u2014 De Rouville Realties Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 600 preferred shares of arpar value of $50 each and 2,000 common shares of a par value of $5 each.The heat! office of the company will l>e at Bclœil, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE.49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14703-58) Les Immeubles J.T.Z.Patenaude Ltée J.T.Z.Patenaude Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des\" lettres patentes, en date Province of Quebec., bearing date the twenty- du vingt-trois décembre 1958, constituant en third day of December, 1958,incorporaating: / 872 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, tl février 1969, Tome 91, JV° * corporation: Jean-Jacques Patenaude, administrateur, Mme Marguerite Monat Patenaude, ménagère, épouse séparée de biens dudit Jean-Jacques Patenaude, tous deux de Ville Mont-Royal, et Mme G.Patenaude Sauvageau, ménagère, épouse séparée de biens ae Etienne Sauvageau, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Immeubles J.T.Z.Patenaude Ltée \u2014J.T.Z.Patenaude Realties Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 3613, boulevard Décarie, Montréal, distiict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14242-58) L'Oeuvre des Terrains de Jeu de Charny Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq janvier 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Alexandre Picard contremaître, Louis-Philippe Arcand, employé de chemin de fer, Albert Deniers, chimiste, Gilles Filion, commis C.N.R., Paul-Henri Frechette, secrétaire municipal, Ernest Moffet, gérant de Caisse Populaire, et Bernard Larochelle, maître de poste, tous de Charny, pour les objets suivants: L'acquisition, l'établissement et le maintien de terrains de jeux, sous le nom de \"L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Charny Inc.\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens mimmobiliera que la corporation peut posséder, est de $20,000.Le siège social de la corporation sera à Charny, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14787-58) Loumel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation : Samuel Chait, avocat, John Hamilton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, développement, amélioration et construction, sous le nom de \"Loumel Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 1,000 actions privilégiées, catégorie \"A\", d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,800 actions privilégiées, catégorie \"B\", d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 614-65e Avenue, L'Abord-à-Plouffe, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.Jean-Jacques Patenaude, executive, Mrs.Marguerite Monat Patenaude, housewife, wife separate as to property of the said Jean-Jacques Patenaude, both of the town of Mount Royal, and'Mrs.G.Patenaude Sauvageau, housewife, wife separate as to property of Etienne Sauvageau, of Montreal, for the following purposes: To deal in immoveables, under the name of \"Les Immeubles J.T.Z.Patenaude Ltée \u2014 J.T.Z.Patenaude Realties Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each.# The head office of the company will be at 3613 Decarie Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14242-58) L'Oeuvre des Terrains de Jeu de Charny Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1959, to Incorporate as a corporation without share capital: Alexandre Picard, foreman, Louis-Philippe Arcand, railroad employee, Albert Demers, chemist, Gilles Filion, C.N.R.clerk.Paul-Henri Frechette, municipal secretary, Ernest Moffet, manager of a Caisse Populaire, and Bernard Larochelle, postmaster, all of Charny, for the following purposes: The acquisition, establishment and maintenance of playgrounds, under the name of \"L'Oeuvre des Terrains de Jeux de Charny Inc.\".The amount to which the revenue issuing from the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will be at Charny, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14787-58) Loumel Inc.Notice is hereby given that under Part I of-the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: Samuel Chait, advocate, John Hamilton, secretary, both of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte St-Luc, for the following purpeses: To carry on the business of a land, development, improvement and construction company, under the name of \"Loumel Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each, 1,000 Class \"A\" preferred shares of a par value of $1 each and 3,800 Class \"B\" preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will bea t 614-65th Avenue, L'Abord-à-Plouffe, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-second day of December, 1958.P.FRENETTE, ¦ 49898-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February gist, 1969, Vol.91, No.8 873 (P.G.10175-69) Luna Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux janvier 1959, constituant en corporation: Jehan Perdriau, Pierre Panneton, avocats, de Montréal, et Solange Vézina, secrétaire, de Boucher ville, pour les objets suivants: Exercer généralement le commerce d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Luna Construction Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14818-58) Marmur Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Jack Lightstone, Marvin Riback et John J.Gotiicb, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Marmur Investments Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, distiict judiciaire de Montiéal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14773-58) Matapédia Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf décembre 1958, constituant en cor- Si rat ion: Luc Geoffroy, de Chambly, Robert ulude, de Dorion, et Robert-Y.Lantluer, de Ste-Rose, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et faire affaires comme compagnie de construction et de placements, sous le nom de \"Matapédia Realties Inc.\", avec un capital divisé en 1,000 actions sans valeur au pair ou nominale, et»le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations seia d'au moins $5,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.11106-58) Mid-Town Motors Val d'Or Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze novembre 1958, constituant en corpo- (A.G.10175-59) Luna Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of January, 1959, incorporating: Jo-han Perdirau, Pierre Panneton, advocates, of Montreal, and Solange Vézina, secretary, of Boucherville, for the following purposes: To carry on generally a business as a construction company under the name of \"Luna Construction Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14818-58) Marmur Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor-of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Jack Lightstone, Marvin Riback and John J.Gotlieb, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Marmur Investments Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Monti eal, judicial district of.Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14773-58) Matapédia Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the nineteenth day of December, 1958, incorporating: Luc Geoffroy, of Chambly, Robert Dulude, of Dorion, and Robert Y.Lanlhier, of Ste Rose, all advocates, for the following purposes: To deal in real estate and carry on business as a construction and investment company, under the name of \"Matapédia Realties Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 shares without nominal or par value, and the amount with whicn the company shall commence its operations will be of at least $5,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898- Acting Deputy Attorney General.(A.G.11106-58) Mid-Town Motors Val d'Or Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor, of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1958, incorporating: Sam 874 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1969, Tome'91, N° 8 ration: Sam Disante, garagiste, Mme Cécile Chenier Bisante, ménagère, épouse cojatractuel-lement séparée de biens dudit Sam Bisante, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, de la paroisse de Notre-Dame de Fatima, et Claire Trudel.secrétaire, de Val d'Or, pour les objets suivants: , Exercer le commerce de garage, poste de service et agence d'automobiles, sous le nom de \"Mid-Town Motors Val d'Or Ltd.\", avec un capital total de $30,000, divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1111 Chemin Rouyn, Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.49898 P.FRENETTE.,.(P.G.14951-58) Mo-Bo Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a - été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Stanley D.Haltrecht, notaire, de St-Laurent, Moe Ackman, avocat, et Annette Katz, secrétaire, épouse séparée de biens d'Irving Katz, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, amélioration, construction et administration, sous le nom de \"Mo-Bo Holdings Inc.\", avec un capital total de $11,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 10,000 actions privilégiées de ?1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14351-58) Modern Children's Wear Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un décembre 1958, constituant en corporation: David Lack, Avrum Cohen, avocats, et Joseph Feig, fabricant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce de vêtements, articles vestimentaires et accessoires, sous le nom de \"Modem Children's Wear Co.Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14132-58) Montcalm Express Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Bisante, garagist* Mrs.Cécile Chenier Bisante, housewife, wife contractually separate as to property of the said Sam' Bisante, and duly authorized by him for the purpose of these presents, of the parish of Our Lady of Fatima, and Claire Trudel, secretary, of Val d'Or, for the following purposes: To carry on the businesses of garages, service station and car agency; under the name of \"Mid-Town Motors Val d'Or Ltd.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 300 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1111 Rouyn Road, Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney Genera).(A.G.14951-58) Mo-Bo Holdings- Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1958, incorporating: Stanley D.Haltrecht, notary, of St.Laurent, Moe Ackman, advocate, and Annette Katz, secretary, wife separate as to property of Irving Katz, both of MontreaJ.for the following purposes: To carry on the business of a land, improvement, construction and management company, under the name of \"Mo-Bo Holdings Inc.\", with a total capital stock of $11,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 10,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.* (A.G.14351-58) Modern Children's Wear Co.Inc.Notice is hereby given that under Part-1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of December, 1958, incorporating: David Lack, Avrum Cohen, advocates, and Joseph Feig, manufacturer, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing, wearing apparel and accessories, under the name of \"Modern Children's Wear Co.Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14132-58) Montcalm Express Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant -Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February gist, 1959, Vol.91, No.8 875 province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Joseph Lavallière, gérant, de Lévis, Michel Maillet, représentant, et Maurice DePal-ma, comptable agréé, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de transport et de camionnage, sous le nom de \"Montcalm Express Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lévis, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14881-58) National Sample Card Company Limited Avis est donné qu'en verti de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, consituant en corporation: Sam Kader, Moe Kader, imprimeurs, Morton Kader, gérant, et Annie Gottlieb Kader, ménagère, épouse séparée de biens dudit Sam Kader, tous de Montréal, pour les objets suivants: - Exercer le négoce ou le commerce d'imprimeurs généraux, éditeurs, éditeurs de journaux, lithographes, graveurs, relieurs, libraires, fondeurs de caractères, agents publicitaires et convertisseurs de papier, sous le nom de \"National Sample Card Company Limited*', avec un capital total de $50.000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 19 est.rue Notre-Dame, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Joseph Lavallière, manager, of Levis, Michel Maillet, representative, and Maurice DePalma, chartered accountant, of Montreal, for the following purposes: \u2022 To carry on the business of a forwarding and trucking company, under the name of \"Montcalm Express Inc.', with a total capital stock of $40,-000, divided into 300 common- shares of a par value of $100 each and 100 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Levis, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.49898 P.FRENETTE, Acting Deputy Attorney General.(A.G.14881-58) National Sample Card Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Sam Kader, Moe Kader, Printers, Morton Kader, manager, and Annie Gottlieb Kader, housewife, wife separate as to property of the said Sam Kader, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade or business of general printers, publishers, newspaper publishers, lithographers, engravers, bookbinders, booksellers, type founders and advertising agents and paper converters, under the name of \"National Sample Card Company Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 300 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 19 Notre-Dame Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14798-58) Panama Development Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date «lu vingt-deux décembre 1958.constituant en corporation: Seymour Machlovitch, Morris Chai-kelson, avocats, et Nicole Paternault, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et développement, sous le nom de \"Panama Development Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9720 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.(A.G.14798-58) Panama Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, advocates, and Nicole Paternault, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction an«l development company, under the name of \"Panama Development Corp.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 9720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.49S9S-0 P.FRENETTE, Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE. 876 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1969, Tome 91, N° 8 (P.G.10157-69) Patrice Roy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1959, constituant en corporation: André Couture, Marcel Guy, notaires, et Léonard .Guy, comptable, tous de Sherbrooke, pour les objets suivants: Industrie et commerce de chaussures et articles de cuir et leurs accessoires, sous le nom de \"Patrice Roy Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 107, rue King, ouest, Édifice Continental, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(A.G.10157-59) Patrice Roy Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 'Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January, 1959, incorporating: André Couture, Marcel Guy, notaries, and Léonard Guy, accountant, all of Sherbrooke, for the following purposes: An industry and business dealing in shoes and leather articles and their accessories, under the name of \"Patrice Roy Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company will be at 107 King Street, West, Continental Building, Sherbrooke, judicial district of Saint.Fraqcis.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January, 1959.¦ P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14820-58) Petit Monde \u2014 Little World Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Max Sidney Kaufman, avocat, de Westmount, Joseph Roy Hoffman, Oscar Res-pitz, avocats, et Sydney Sederoff, étudiant en droit, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à confectionner et en général commercer des vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures et articles vestimentaires, sous le nom de \"Petit Monde \u2014 Little World Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.14820-58) \u2022 Petit Monde \u2014 Little World Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date ' the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Max Sidney Kaufman, - advocate, of \"\"Westmount, Joseph Roy Hoffman, Oscar Respitz, advocates, and Sydney Sederoff, law student, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and generally dealing in men's, women's and children's clothing, footwear and wearing apparel, under the name of \"Petit Monde \u2014 Little World Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.14232-58) (A.G.14232-58) Placement Interprovincial Investment Inc.Placement Intcrprovincial Investment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation: René Beaudry, de Verdun, Louis-Claude Trudel et Joseph Vallières, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Placement Intérpro-vincial Investment Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: René Beaudry, of Verdun, Louis-Claude Trudel and Joseph Vallières.of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Placement Inter-provincial Investment Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attoreny General, this twenty-second day of December, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Feb'ruary Blet, 1969, Vol.91, No.8 877 (P.G.14954-58) Principal Clothing Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de\" la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, d'Oui remont, Jason Ruby, avocat, et Alan Golden, gérant, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce de vêtements pour hommes, garçons et dames, sous le nom de \"Principal Clothing Mfg.Co.Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et 850 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 ' P.FRENETTE.(P.G.14663-58) Quinto Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1958, constituant en corporation: I.J.Charness, Gerald N.F.Chamess, tous deux avocats, de Montréal, et Ann Druzin, secrétaire, de Longueuil, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et amélioration, sous le nom de \"Qi into Realties Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14815-58) R.Beau lie u Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1958, constituant en corporation: Roland Beaulieu, épicier-boucher, Armande S.Beaulieu, ménagère, épouse con-tractucllenient séparée de biens dudit Roland Beaulieu, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Sherbrooke, et Roderick Lemieux, comptable agréé, de Magog, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'épicier-boucher, sous le nom de \"R.Beaulieu Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 635, rue Conseil, Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1958.(A.G.14954-58) Principal Clothing Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governpr of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1958, incorporating: Louis Orenstein, advocate, of Outremont, Jason Rudy, advocate, and Alan Golden, manager, both of Montreal, for the following purposes: The manufacture and sale of men's, boys' and female clothing, under the name of \"Principal Clothing Mfg.Co.Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 150 common shares of $100 each and 850 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.\u2022 P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14663-58) > Quinto Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the -Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1958, incorporating: I.J.Charness, Gerald N.F.Charness, both advocates, of Montreal, and Ann Druzin, secretary, of Longueuil, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Quinto Realties Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14815-58) R.Beaulieu Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date' the twenty-ninth day of December, 1958, incorporating: Roland Beaulieu, grocer-butcher, Armande S.Beaulieu, housewife, wife contractually separate as to property of the said Roland Beaulieu, and duly authorized by him for these present purposes, both of Sherbrooke, and Roderick Lemieux, chartered accountant, of Magog, fer the following purposes: To carry on a business as grocer-butcher, under the name of \"It.Beaulieu Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 635 Conseil Street, Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1958.1 L'Assistant-procureur général suppléant.49898-0 - P.FRENETTE.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General. 878 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, tl février 1969, Tome 91, N° 8 (P.G.14916-58) Richard Auto Body Ltd.Avis est donné qu'en Vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois,décembre 1958, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, Alan Golden, gérant, tous deux d'Outremont, et Huguettc St-Marseille, secrétaire, fille majeure, de l'Ile Per rot, pour les objets suivants: Exploiter et administrer un commerce de garage, sous le nom de \"Richard Auto Body Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14606-58) Rockhill Apartment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Maurice Jonathan Garmaise, Mortimer Dolman et Philip Borrow, tous notaires, de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir par achat ou autrement, et posséder, exploiter, entretenir, prendre en location, louer, hypothéquer, ou autrement nantir ou grever des terrains et lieux situés en la cité de Montréal, province de Québec, et y construire, développer et améliorer lesdits terrains et lieux ou quelque partie ou parties d'iceux, et vendre entièrement ou partiellement lesdits terrains et lieux, sous le nom de \"Rockhill Apartment Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 8,000 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à chambre 35, 410 rue St-Nicho)as, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14634-58) Roshire Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt décembre 1958, constituant en corporation: Philip Levenson, Saul Lcvcnson, tous deux fabricants, de Saint-Laurent, et Harold Finkelstein, administrateur, de Montréal, pour objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements aux fins d'en retirer le revenu, sous le nom de \"Roshire Realty Corp.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et 1,900 actions privilégiées de $10 chacune.lie siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(A.G.14916-58) Richard Auto Body Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Louis Orenstein, advocate, Alan Golden, manager, both of Outremont, and Huguette St-Marseille, secretary, fille majeure, of He Perrot, for the following purposes: To operate, and conduct a garage business, under the name of \"Richard Auto Body Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common snares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14606-58) .Rockhill Apartment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Maurice Jonathan Garmaise, Mortimer Dolman and Philip Borrow, all notaries, of Montreal, for the following purposes: To acquire by purchase or otherwise, and to own, operate, maintain, rent, lease, mortage or otherwise charge or encumber, lands and premises situate in the city of Montreal, Province of Quebec, and to build upon, develop and improve the said lands and premises or any part or^ parts thereof, and to sell the whole or any part of the said land and premises, under the name of \"Rockhill Apartment Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 8,000 shares of $5 each.The head office of the company will be at Room 35, 410 St.Nicholas Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14634-58) Roshire Really Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued -by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of December, 1958, incorporating: Philip Levenson, Saul Levenson, both manufacturers, of Saint Laurent, and Harold Finkelstein, executive, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company for the purpose of earning the income thereof, under the name of \"Roshire Realty Corp.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and .1,900 preferred shares of $10 each.' The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1969, Vol.91, No: 8 879 (P.G.14369-58) Rouanda Rambler Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Frédéric Hébert, Jean-Paul Dupuy, tous deux notaires et Renaud Lagacé, agent d'assurances, tous de Noranda, pour les objets suivants: Fabriquer et en général, faire le commerce de toutes sortes d'automobiles et exploiter et administrer des garages, sous le nom de \"Rouanda Rambler Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de $100 cal jeune.Le siège social de la compagnie sera à Noranda, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur-général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14133-58) Royal Neckwear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la toi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois décembre 1958, constituant en corporation: Louis Feigenbaum, de St-Laurent, Hyman Solomon, de Ville Mont-Royal, et Perry Meyer, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce de parures de cou, cravates, foulards et accessoires, articles vestimentaires et fournitures de toutes sortes et descriptions, sous le nom de \"Royal Neckwear Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune - et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14756-58) Ruam Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1958, constituant en corporation: Harold W.Ashenmil, avocat, Lionel Conrad Mauer, vendeur, et Esther Frances .Allman, ménagère, épouse séparée de biens dudit Lionel Conrad Mauer, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'appareils électriques et électroniques, sous le nom de \"Ruam Enterprises Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 6,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 913 est, rue Ontario, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, ' 49898 P.FRENETTE.(A.G.14369-58) Rouanda Rambler Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by'the Lieutenant-governor of the.Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1958, incorporating: Frédéric Hébert, Jean-Paul Dupuy, both Notaries, and Renaud Lagacé, Insurance agent, all of Noranda, for the following purposes: To manufacture, generally deal in all kinds of automobiles and to operate and manage garages, under the name of \"Rouanda Rambler Inc.\", with a total capital tsock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Noranda, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14133-58) Royal Neckwear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of December, 1958, incorporating: Louis Feigenbaum, of St.Laurent, Hyman Solomon, of the Town of Mount Royal, and Perry Meyer, of Montreal, all advocates,- for the following purposes: To manufacture and deal in neckwear, scarves and accessories, wearing apparel and furnishings of every kind and description, under the name of \"Royal Neckwear Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of December,.1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14756-58) Ruam Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of December, 1958, incorporating: Harold W.Ashenmil, advocate, Lionel Conrad Mauer, salesman, and Esther Frances Allman, housewife, wife separate as to property of the said Lionel Conrad Mauer, and duly authorized by him for these presents, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an electric and electronics company, under the name of \"Ruam Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 4,000 common shares-of $1 each and 6,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at 913 Ontario Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General. 880 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec 21 février 1969, Tome 91, N° 8 (P.G.14525-58) Sardus Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Neil Phillips, avocat, Yvonne Bélanger, Sylvia Vineberg, secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, et Godfroy Marin, avocat, de Pointe Claire, pour les objets suivants: Acheter ou autrement acquérir et détenir, posséder, y construire et développer des propriétés immobilières et immeubles à des fins de placements; et agir comme bailleurs et administrateurs en ce qui se rapporte à iceux, sous le nom de \"Sardus Investments Ltd.\", avec un capital total de $1,000 divisé en 100 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.\u2022 Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14513-58) ., Service d'Arbre Guimont Ltée Guimont Tree Service Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Lci des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Alphonse Guimont, ingénieur-forestier, Rolande Côté Guimont, maîtresse de maison, et Jacques .Guimont, étudiant en génie-forestier, tous de Ste-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme arboriculteurs, sous le nom de \"Service d'Arlue Guimont Ltée \u2014 Guimont Tree Service Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2884, rue Providence, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-o P.FRENETTE.(P.G.14814-58) Shawinigan Music System Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre décembre 1958, constituant en corporation: Georges Crête, opérateur de machines musicales, Jean Crête, comptable, et Albert Crête, industriel, tous de St-Sévérin-de-Proulx-ville, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'instruments de musique ou d'amusements, sous le nom de \"Shawinigan Music System Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Sévérin-de-Proulxville, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(A.G.14525-58) v Sardus Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Neil Phillips, advocate, Yvonne Bélanger, Sylvia Vineberg, secretaries, filles majeures, all three of Montreal, and Godfroy Marin, advocate, of Pointe Claire, for the following purposes: To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on, and develop immoveable property and real estate for investment purposes, and to act as lessors and administrators in connection therewith, under the name of \"Sardus Investments Ltd.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 100 shares of $10 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14513-58) Service d'Arbre Guimont Ltée Guimont Tree Service Ltd.' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 190S, incorporating: Alphonse Guimont, forest engineer, Roland Côté Guimont, housekeeper, and Jacques Guimont, student in forest engineering, all of St.Foy, for the following purposes: To carry on business as nurserymen, under the name of \"Service «l'Arbre Guimont Ltée \u2014 Guimont Tree Service Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 2884 Providence Street, Saint.Foy, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.P.FRENETTE.49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14814-58) Shawinigan Music System Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Gouvernor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of December, 1958, incorporating: Georges Crête, music-machine operator, Jean Crête, accountant, and Albert Crête, industrialist, all of St-Sévérin-de-Proulxville, for the following purposes: To carry on a business dealing in musical instruments or amusements under the name of \"Shawinigan Music System Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at St-Sévérin-de-Proulxville, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February tlet, 1969, Vol.91, No.8 881 (P.G.10148-59) Société de Bienfaisance Gaspésienne Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1959, constituant en corporation sans capital-actions: Leopold Langlois, de Ste-Foy, Guy Pinsonnault, de Québec, et Jean-C.Lord, de Beaùport, tous avocats, pour les objets suivants: Au moyen de contributions, souscriptions, dons ou donations, promouvoir, dans les limites du comté de Matane, district de Rimouski, l'établissement, le placement, la disposition et la distribution d'un fonds social pour fins philanthropiques, charitables, patriotiques et de Bienfaisance, sous le nom de 'Société de Bienfaisance Gaspésicnne Incorporée\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut' posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera aux Mé-chins, comté de Matane, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14692-58) Sorti Auto Parts Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Roland Gendre au.marchand, Annette Laroche Goudreau, ménagère, épouse commune en biens dudit Roland Goudreau, et dûment autorisée par lui, tous deux de>Sorel, et Guy Goudreau, commis-marchand, «le Tracy, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le pièces, morceaux et accessoires d'automobiles, sous le nom de \"Sorel Auto Parts Inc.\", avec un capital total «le S20.000, divisé en 190 actions privilégiées «le $100 chacune et en 100 actions communes «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sorel.district judiciaire de Richelieu.Daté «lu bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14201-5S) Souvenir Agenries Ltd.Avis est donné «m'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-g«>uvemeur «le la province «le Québec, «les lettres patentes en «latc du vingt-quatre décembre 1958, constituant en corporation Sol Sydney Fels, «le Montréal, Bernard Gardner, «le llosemère, et Jules Leavitt.«le Ville Mont-Royal, tous avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce «le gravures, impressions, images, dessins, fanions, affiches, images transposées au moyen de décalquage, papeterie, souvenirs et nouveautés, sous le nom de \"Souvenir Agencies Ltd.\", avec un capital total «le $40.000, divisé en 1,000 actions ordi- (A.G.10148-59) Société de Bienfaisance Gaspésienne Incorporée Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January, 1959, to incorporate as a corporation without share capital: Leopold Langlois, of Ste-Foy, Guy Pinsonnault, of Quebec, and Jean-C.Lord, of Beauport, all advocates, for the following purposes: By means of contributions, subscriptions, gifts of donations, to promote within the limits of the county of Matane, district of Rimouski, the establishment, the placing, the provisions and distribution of a social fund for philanthropicaL charitable, patriotic and welfare purposes, under the name of \"Société de Bienfaisance Gaspésienne Incorporée\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Aux Méchins, county of Matane, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January, 1959._ P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14692-58) Sorel Auto Parts Inc.Notice is hereby given that under'Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor., of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December 1958, incorporating: Roland Goudreau, merchant, Annette Laroche Goudreau, housewife, wife common as to property^ of the said Roland Goudreau, and duly authorized by him, both of Sorel, and Guy Goudreau, merchant clerk, of Tracy, for the following purposes: To deal in automobile parts, pieces and accessories, under the name -of \"Sorel Auto Parts Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 190 preferred shares of $100 each and 100 common shares of $10 each.' The head office of the company will be at Sorel, judicial district of Richelieu.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1958.¦ P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14201-58) Souvenir Agencies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, l>caring date the twenty-fourth day of December, 1958, incorporating: Sol Sydney Feb, of Montreal, Bernard, Gardner, of Rosemere, and Jules Leavitt, of the Town of Mount Royal, all advocates, for the following pur],'oses: To manufacture and deal ill engraving, prints, pictures, drawings, pennants, posters, decalco-mania transfers, stationery, souvenirs and novelties, under the name of \"Souvenir Agencies Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value 882 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1969, Terne 91, N° 8 naires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Date du bureau du Procureur général, le vingt-quatre décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14608-58) Staley Brothers Petroleum Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1958, constituant en corporation: Edward H.Bernfeld, Jack B.Bobrove et Max Bernfeld, conseil en loi de la Reine, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer tous ou aucun des commerces habituellement ou opportunément exercés par les compagnies de gaz naturel, huile ou autres combustibles naturels ou fabriqués, sous le nom de \"Staley Brothers Petroleum Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14633-58) Stc.Foy Lunclieonnette Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt décembre 1958, constituant en corporation: Louis-Laurici Roy, marchand, de Sherbrooke, Gilles-R.Roy, pharmacien, Edward Olmstead, clief, et Mary Olmstcad, ménagère, épousé séparée de biens dudit Edward Olmstead, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateur, sous le nom de \"Ste.Foy Luchconnette Inc.\", avec un capital total de $20.000.divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14799-58) Sudan Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation : Seymour Machlovitch, Morris Chai-kelson, avocats, et Nicole Paternault, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et développement, sous of $10 each and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14608-58) Staley Brothers Petroleum Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been' issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1958, incorporating: Edward H.Bernfeld, Jack B.Bobrove and Max Bernfeld, Queen's Counsel, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on all or any of the businesses usually or conveniently carried on by naturel gas, oil or other natural or manufactured fuel product companies, under the name of \"Staley Brothers Petroleum Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14633-58) Ste.Foy Lunchconnette Inc.Notice is hereby given tliat under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of December, 1958, incorporating: Louis-Laurier Roy, merchant, of Sherbrooke, Gilles-R.Roy, pharmacist, Edward Olmstead, chef, and Mary Olmstead, housewife, wife separate as to property of the said Edward Olmstead, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a restaurant, under the name of \"Ste.Foy Luncheonette Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14799-58) Sudan Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December,.1958, incorporating: Seymour Machlovitch, Morris Chaikelson, advocates, and Nicole Paternault, secretary, spinster all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and development company, under QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Stlst, 1969, Vol.91, No.8 883 le nom de \"Sudan Development Corp.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 9720 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14299-58) Super Marché Biais Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1959, constituant en corporation: Armand Biais, marchand, Mme Jeanne Biais, ménagère, épouse séparée de biens, et Marcel Saubiiers, gérant, tous de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer le commerce de denrées alimentaires, sous le nom de \"Super Marché Biais Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 250 actions communes de $160 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14524-58) Susa Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1958, constituant en corporation: Neil Phillips, avocat, Sylvia Vineherg, Yvonne Bélanger, toutes deux secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, et Godfroy Marin, avocat, de Pointe Claire, pour les objets suivants: Acheter ou autrement acquérir te détenir, posséder, y construire et développer dds propriétés ¦ immobilières et immeubles à des fins de placements, et agir comme bailleurs et administrateurs en ce qui se rapporte à iceux, sous le nom de \"Susa Investments Ltd.\", avec un capital total de $1,000, divisé.en 100 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P; FRENETTE.(P.G.14802-58) The De Rice Building Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux décembre 1958, constituant en corporation: Frank De Rice, restaurateur, Jack Ross, agent, tous deux de Montréal, et Samuel Leon Mendelsohn, avocat et conseil en loi de la Reine, pour les objets suivants: Effectuer des placements et détenir des terrains et immeubles, sous le nom de \"The De Rice the name of \"Sudan Development Corp:\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common snares of $10 each.The head office of the company will be at 9720 Jeanne Mance Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second dav.of December, 1958.P.FRENETTE.49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.a 14299-58) Super Marché Biais Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1959, incorporating: Armand Biais, merchant, Mrs.Jeanne Biais, housewife, wife separate as to property, and -Marcel Saulniers, manager, all of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on a business dealing in foodstuffs under the name of \"Super Marché Biais Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14524-58) Susa Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1958, incorporating: Neil Phillips, advocate, Sylvia Vineberg, Yvonne Bélanger, both secretaries, filles majeures, all three of Montreal, and Godfroy Marin, advocate, of Pointe Claire, for the following purposes: To purchase or otherwise acquire and to hold, own, build on, and develop immoveable property and real estate for investment purposes, and to act as lessors and administrators in connection therewith, under the name of \"Susa Investments Ltd.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 100 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14802-58) The De Rice Building Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of December, 1958, incorporating: Frank De Rice, restaurateur.Jack Ross, agent, both of Montreal, and Samuel Leon Mendelsohn, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, for the following purposes To invest in and hold land and real estate, under the name of \"The De Rice Building Inc.\" 884 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1969, Tome 91, N° 8 Building Inc.\", avec un capital total de $250,000, divisé en 2,400 actions privilégiées de $100 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.with a total capital stock of $250,000, divided into 2,400 preferred shares of $100 each and 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.10067-59) Top Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq janvier 1959, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, conseil en loi de la Reine, Clarence Reuben Gross, Rollin Gallay, tous trois avocats, et Sarah Miller, sténegraphe, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'ure compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Top Holdings Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 90 actions privilégiées, d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14959-58) Tower Realty Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1958, constituant en corporation: Irving Halpcrin.Daniel Morris, avocats, et Ernest Rashkovan, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce d'entrepreneurs généraux et constructeurs et faire celui de négociants en propriétés immobilières, sous le ncm de \"Tower Realty Holdings Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et 3.600 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à 5811 avenue du Parc, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1958.L'Assistant-pn cureur général suppléant, 49898 P.FRENETTE.(P.G.14719-58) Tri sco Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie ec des lettres patentes supplé- Governor of the Province of Quebec, dated the mentaires, en date du vingt-neuf décembre twenty-ninth day of December 1958, to the 1958, à la compagnie \"Quebec Stitchdown Shoe company \"Quebec Stitchdown Shoe Limited\".Limited\", réduisant son capital de $110,000 decreasing its capital from the sum of $110,000 à $50,000, le capital-actions annulé étant divisé to $50,000, the cancelled share capital being en 600 actions privilégiées de $100 chacune.divided into 600 preferred shares of $100 each.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, vingt-neuf décembre 1958.this twenty-ninth day of December 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 49898-0 P.FRENETTE.49898 Acting Deputy Attorney General.892 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, tl février 1959, Tome 91, N\" 8 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21»t, 1969, Vol.91, No.8 893 (P.G.12682-68) Riviera Color Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du huit janvier 1959, à la compagnie \"Riviera Color Corporation\", 1° subdivisant ses 1,060 actions sans valeur au pair en 10,000 actions sans valeur au pair; 2° augmentant son capital, le capital-actions additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées classe \"A\" de $100 chacune; 3° fixant le montant avec lequel la compagnie continuera ses opérations à non moins de $74,100; 4° modifiant les dispositions de ses lettres patentes antérieures en ce qui regarde les privilèges et restrictions attachés aux actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur généra], le huit janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.10195-55) Saratoga Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt et un janvier 1959, à la compagnie \"Les Industries Meunier Industries Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 17 février 1955, changeant son nom en celui sde \"Saratoga Industries Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14949-58) The Royal Trust Realty Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-quatre décembre 1958, à la compagnie \"The Royal Trust Realty Company\", 1° réduisant son capital de $500,000 à $200,000, le capital-actions annulé étant divisé en 3,000 actions de $100 chacune; 2° augmentant son capital ainsi réduit de $200,000 à $900,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 7,000 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.10010-59) Universal.Bercusson.Furline Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente et un décembre 1958, à la compagnie \"Universal Fur & Supply Co.Ltd.\", constituée en corporation en vertu (A.G.12682-58) Riviera Color Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the eighth day of January, 1959, to the company \"Riviera Color Corporation\", 1.subdividing its 1,000 shares without par value into 10,000 shares without par value; 2.increasing its capital stock, the additional capital stock being divided into 400 preferred class \"A\" shares of $100 each; 3.fixing the amount with which the company shall continue its operations at not less than $74,100; 4.modifying the provisions of its previous letters patent in that which concerns the privileges and restrictions attached to preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this eight day of January, 1959.\u2014 P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10195-55) Saratoga Industries Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-first day of January 1959, to the company \"Les Industries Meunier Industries Inc.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated February 17, 1955, changing its name to that of \"Saratoga Industries Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of January 1959.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14949-58) The Royal Trust Realty Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-fourth day of December 1958, to the company \"The Royal Trust Realty Company\", 1.decreasing its capital from the sum of $500,000 to $200,000, the cancelled share capital being divided into 3,000 shares of $100 each; 2.increasing its capital thus decreased from the sum of $200,000 to $900.000, the additional share capital being divided into 7,000 prefered shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of December 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10010-59) Universal.Bcrcusson.Furline Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirty-first day of December, 1958, to the company \"Universal Fur & Supply Co.Ltd.\", incorporated under the said Part I of the Quebec 804 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, tl /Sérier 1969, Tome 91, N9 8 de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes du 11 mai 1942, 1) changeant son nom en celui de \"Universal.Bercusson.Furline Ltd.\"; 2) augmentant son capital de 520,000 à $140,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 10,000 actions privilégiées de S10 chacune et en 200 actions ordinaires de $100 chacune.Daté du bureau du Procuieur général, le trente et un décembre 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.14943-58) Val Hughes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt janvier 1959, à la compagnie \"Val Hughes Inc.\", augmentant son capital de $60,000 à $100,000.le capital-actions additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G, 10070-59) Virginia Mining Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du sent janvier 1959, à la compagnie \"Virginia Mining Corporation\" (No Personal Liability), augmentant son capitol de $3,500,000 à $5,000,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,500,-000 actions de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le sept janvier 1959.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE.(P.G.10153-59) Walter-Martin Press Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt et un janvier 1959, à la compagnie \"National Marketing Company Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, sous le nom originaire de \"Finer Lithographing & Printing Co.Ltd.\", par lettres patentes du 21 septembre 1950, et par lettres patentes supplémentaires en date du 30 septembre 1958, changeant ledit nom originaire en celui de \"National Marketing Company Ltd.\", changeant de nouveau son nom en celui de \"Walter-Martin Press Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un janvier 1959.Companies' Act, by letters patent May 11, 1942, 1) changing its name into that \"Universal.Bercusson.Furline Ltd.\"; 2) increasing its capitol stock from $20,000 to $140,000, the additional capitol stock being divided into 10,000 preferred .shares of $10 each and into 200 common shares of $100 each.Dated at the \u2022office of the Attorney General, this thirty-first day of December, 1958.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14943-58) Val Hughes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twentieth day of January, 1959, to the company \"Val Hughes Inc.\", increasing its capitol stock by $60,000 to $100,000, the additional capitol stock being divided into 400 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10070-59) Virginia Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining Companies' Act and Part I of the Quebec Mining Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the seventh day of January, 1959, to the company \"Virginia Mining Corporation\" (No Personal Liability), increasing its capitol stock from $3,5000,000 to $5,000,000, the additional capital stock being divided into 1,500,000 shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10153-59) Walter-Martin Press Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Piovince of Quebec, dated the twenty-first day of January, 1959, to the company \"National Marketing Company Ltd.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, under the original name of \"Finer Lithographing & Printing Co.Ltd.\", by letters patent of September 21, 1950, and by supplementary letters patent dated September 30, 1958, changing the said original name into that of \"National Marketing Company Ltd.\", again changing its name into that of \"Walter-Martin Press Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of January, 1959.P.FRENETTE, 49898 Acting Deputy Attorney General.L'Assistant-procureur général suppléant, 49898-0 P.FRENETTE. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 2 let, 1969, Vet.91, No.8 '895 Ventes pour taxes Sales for Taxes Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Municipalité du comté d'Abitibi Avis public vous est par les présentes donné par le soussigné, Laval Goulet, secrétaire de la corporation du comté d'Abitibi, que les immeubles, avec bâtisses, circonstances et dépendances ci-après détaillés, seront vendus à l'enchère publique au Palais de Justice d'Amos, au lieu ordinaire des sessions de ce Conseil, le second JEUDI du mois d'AVRIL 1959, soit le NEUF (9) avril, à DIX heures de l'avant midi pour non paiement de taxes municipales, scolaires, religieuse et repartition d'église, frais et charge dus sur chacun de ces immeubles à moins que ces taxes, frais et charge ne soient plus tot payés et acquittés avec les frais encourus avant la vente, savoir: Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Municipality or the county of Abitibi Public notice is hereby given by the undersigned, Laval Goulet, Secretary-Treasurer of the corporation of the county of Abitibi, that the immoveable property, buildings, circumstances and dependencies hereafter described, shall be sold by public auction at the Court House of Amos, in the place where this Council usually holds its sittings, the second THURSDAY of the month of APRIL 1959, namely the NINTH (9) day of april at TEN o'clock in the forenoon, for non-payment of municipal, school and church taxes, church apportionments, costs and charges due on each of these immoveables, unless said taxes, cots and charges are paid, including costs incurred, prior to the sale, to wit.\u2014 Corporation de St-Jacques de Dupuy \u2014 Commission scolaire de La Reine Corporation of St-Jacques of Dupuy \u2014 School Commission of Là Reine Canton ou village Township or village\tLot\tRang Bloe Range Block\tPropriétaire Owner\tTaxes munie.Munie taxes\tTaxes BCOl.School taxes\tTotal \u2022 \t60.34.f.\t1.7.\t\t821.60\t$62.46 66.00\t$83.96 66.00 \t\t\t¦Emile Martial.\t\t\t \t\t\t\t\t\t Corporation de Colombourg \u2014 Commission scolaire de Colombourg Corporation of Colombourg \u2014 School Commission of Colombourg\t\t\t\t\t\t \t68.\t2.\t\t7.68\t0.10\t16.78 \t\t\t\t\t\t Commission scolaire de St-Bernard de Sullivan \u2014 School Commission of St-Bernard of Sullivan\t\t\t\t\t\t \t64.\t1.\tWilbrod Ayotte.\t\t173.98 112.28 105.79\t173.98 112.28 106.79 \t6.\tA.\t\t\t\t \t10.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Commission scolaire de St-François de Sales \u2014 School Commission of St-François de Sales Destor.Dufresnoy.61 62 68 32 46 48 2.2.1.2.9.9.Henri Delcambre.Henri Delcambre.Edouard Marcoux.Suce-Est.Delphis Vaillan-court.Leopold Aube.Gilles Lévesque., 107.78\t107.78 85.70\t86.70 165.68\t166,68 67.90\t67.90 96.66\t96.65 69.17\t69.17 Commission scolaire de Ste-Gertrude \u2014 School Commission of Ste-Gortrude Villemontel.38.43.\t7.9.\t\t\t94.35 106.00 35.50 ME.47,48,49\t7.\t\t\t 94.36 106.00 36.60 Corporation de la paroisse de St-Lambert \u2014 Corporation of the parish of St-Lambert Deemeloiiea.13.20.16.4.4.«.Arthur Bureau.Bernard Jolicceur.Jean-Paul Bruneau.23.94\t 82.15\t 64.35\t 23.94 82.15 64.85 Emplacement sur ce lot d'une superficie de 60 pieds Emplacement on this lot of an area of 60 feet by P*r 180, borné au nord par le chemin public, à l'ouest 180, bounded on the north by the publie highway, par Rolland St-Georges, à l'est par Jacques Mélançon, on the west, by Rolland St-Georges, on th east, by au sud par Rolland St-Georges.Desmeloiies.26.Jacques Mélançon, Georges.on the south, by Rolland 8t- 9.Roger Aumond.56.35 5ÔT36 896 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, M février 1969, Tome 91, N° 8 Commission scolaire de Ste-Philomène de Manneville \u2014 School Commission of Ste-Philomène de Manneville Canton ou village Township or village\tLot\tRang Bloc Range Block\tPropriétaire Owner\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes sool.School taxes\tTotal \t7.\t8.\t\t\t106.94 207.84 131.60\t106.94 207.84 131.60 \t19.4.\t9.8.\t\t\t\t M\t\t\tMme-Mrs.Aurore Côté-St-Hilaire.\t\t\t \t\t\t\t\t\t Corporation de Ste-Hcïene de Mancebourg \u2014 Commission scolaire de Ste-Hêïène Corporation of Stc-Hélène of Mancebourg \u2014 School Commission of Ste-H6lène\t\t\t\t\t\t \t66.\t1.\t\t24.62\t65.96\t90.47 \t\t\t\t\t\t Corporation de Carpontier Courville \u2014 Commission scolaire de Belcourt Corporation of Carpontier Cnurvillo \u2014 School Commission of Belcourt Courville.» \u2022i M M Montguay.Carpentier 37-S.50B-4.59B-3-4.59B-8-9.60-B-18.35-8'.33-P-N.6.52.53.10.9.0.9.9.10.9.3.1.1.Léon Bisson.Emile Gurnoau.Emile Garneati.Emile Garneau Emile Garneau Emile Garneau Léandre Lafrancè., Louis Vaillancourt.Armand Lavigne.Emilien Marcotte.2 30\t\t2.36 0.85\t\t0.85 2.04\t\t2.04 54.76\t\t64.76 25.93\t\t25.93 1.10\t\t1.10 7.84\t\t7.84 \t4.80\t4.80 \t04.80\t94.80 \t42.01\t42.01 Corporation du village La Iteino \u2014 Commission scolaire La Koine Corporation of village La Heine\u2014 School Commission La Reine Village La Reine.10 et-and 11.11 et-and 12.14 et-and 15.15 23 49 Hormidas Biais Achille Gobeil.Aidé Poquin.8.59 4.85 17.98 24.75 15.25 60.84 Corporation de La Reine, paroisse\u2014 Commission scolaire de La Reine Corporation of La Reine, parish \u2014 School Commission of La Reine La Reino.M Deem eloù es 14.15.31.23 B.24.H N.de la-ofj wmtx \\ 7.\t\t12 60\t45.18\t57.78 7.\t\t9.45\t34.00\t43.75 10.\t\t20.74\t33.34\t64.08 2.\t\t6.75\t19.10\t24.85 2.\t\t12.05\t31.40\t43.45 4.\t\t8.70\t20.20\t28.90 \t\t\t\t Corporation de Normetal \u2014 Corporation of Normetal Deameloisea.46-2-46.46-2-47.P.N.45.45-16.45-28.45-29.45-30.45-56.45-58.45-59.45-60.45-61.45-62.45-63.45-64.45-05.45-66.46-67.46-97.45-104.45-107.45-108.45-119.-.P.N.44.44-5.44-66.44-67.44-68.44-69.44-70.44-71.44-90.44-94.10.10.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.Gaston Côté.Gaston Côté.Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux Louis Marcoux 26.00\t\t26.00 26.00\t\t26.00 25.63\t\t25.63 124.60\t\t124.60 122.45\t\t122.45 122.45\t\t122.45 122.45\t\t122.45 98.45\t\t98.45 98.45\t\t98.45 98.45\t\t98.45 98.45\t\t98.45 98.45\t\t98.45 80.45\t\t86.45 86.45\t\t86.45 98.45\t\t98.45 98.45\t\t98.45 95.00\t\t95.00 97.52\t\t97.52 76.90\t\t76.90 94.15\t\t94.15 94.15\t\t94.15 94.15\t\t94.15 75.55\t\t75.55 18.48\t\t18.48 386.00\t\t386.00 116.70\t\t116.70 122.45\t\t122.45 114.05\t\t114.05 98.45\t\t98.45 98.45\t\t98.45 98.45\t\t98.45 96.36\t\t96.36 108.36\t\t108.36 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Blet, 1969, Vol 91, No.8 897 Corporation de Senneterre, paroisse \u2014 Commission scolaire de Senneterre Corporation of Senneterre, parish \u2014 School Commission of Senneterre Canton ou village Township or village \tRang \tBloe Lot\t\u2014 \tRange \tBlock Emp.26-26.\t8.Emp.26-26.\t8.\t8.11.\t9.12, 13.\t9.14.\t9.28.\t9.27.\t10 28.\t10 21.\t6.19.\t2.\t3.21.\t4.P.27.\t7.P.28.\t7.28-6.\t8.Propriétaire Owner Taxes munie.Munio.taxes Taxes scol.School taxes Senneterre.Antoine Chauvigny.Roland Lemelin.Joseph Bourgault Joseph Bourgault Joseph Bourgault.Joseph Bourgault J.-E.Roussil.Dame Isidore Blouin.Ernest Roussil.Dame Rose Tremblay Antoine Martel.Marcel Vincent.Marcel Vincent.Joseph Gagné.Joseph Gagné.Dame Conrad Pépin.12.98 2.98 14.00 7.21 20.20 7.21 60.83 38.81 8.65 18.90 22.35 10.81 18.02 91.97 26.78 23.07 37.95 25.96 60.00 30.00 84.00 30.00 150 25 34.45 27.00 64.00 138.75 32.40 228.30 34.15 66.95 Commission scolaire de St-Edmond \u2014 School Commission of St-Edmond \t46.\t3.\t\t\t60.03 64.38 83.50 1.90\t60.03 64.38 83.50 1.90 \t56.\t3.\t\t\t\t II\t38c, 39a, 40a, 41a.49B.\t4.\t\t\t\t II\t\t4.\t\t\t\t 1 acre, coin nord-est du lot 49B.50B.61.47.1 acre seulement sur ee lot.Senneville.48.46.2.12.1 acre, corner northeast of lot 49B.4 4 5 7 9 4 6 Adrien Lussier.Joseph Desruisseaux.Roger Guilbert.1 acre only on this lot.Joseph Côté.Jean-Bte Perreault.Wilfrid Provencher.Rolland Thibeault.117.44 188.85 20.31 83.13 49.85 72.33 42.07 Commission scolaire de St-Nasaire Berry \u2014 School Commission of St-Nasaire Berry Berry.Trecesson.52 35 45 49 57 40 2;.\t\t 3:.\t\t 3.\tWellie Tood.\t 3.\t\t\u2022 8-,.\tHenri Chabot.,.\t.10.\t\t \t\t ¦68.50 71.25 60.18 62.50 .62.23 26.00 Corporation de St-Félix Dalquier \u2014 Commission scolaire de Dalquier Corporation of St-Félix Dalquier \u2014 School Commission of Dalquier Dalquier.27.\t6.30.\t5.34a b.\t6.35.\t5.39.\t6.M E.25.\t7.\t7.44 a b.\t7.47ab.\t7.13.\t8.18.\t8.45.\t8.29.\t9.36.\t9.2.\t10.25.\t10 \t Euro ne Sigouin.Alphonse Faquin.Alphonse Paquiu.Alphonse Paquin.Léo Gauthier.Dame Eugène Faut eux.Paul Brochu____.Joseph Labrerque.Maurice Gariépy.Roger Breault.Cyrille Beau vais.Remi Plante.Joseph Lord.Edgard Girard.Marcel Guindon.Léo Lefebvre.27.08 7.09 10.24 10.24 12.90 9.96 10.24 21.45 15.49 -8.18 19.99 18.61 80.63 18.90 27.30 27 30 38.10 28,86 .30.71 31.28 19.40 39.90 23.93 59.36 60.70 12.60 68.10 Corporation de Privât \u2014 Commission scolaire de Privât Corporation of Privât \u2014 School Commission of Privât Village de Privât.\t415.\t37\t\t10.66\t6.19\t16.86 \t\t\t\t\t\t 896 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, tî février 1969, Tome 91, N° 8 Corporation de St-Janvier \u2014 Commission scolaire de 8t-Janvier Corporation of 8t-Janvier \u2014 School Commission of St-Janvier Canton ou village Township or village Lot Rang Bloe Range Block Propriétaire Owner Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total La Sarre.Royal RoussUlon Chasel.51.68.M k.56 et-and H O.-w.57.30.31.23.24.25.8.8.8.9.9.1.1.1.Maurice Mercier.Henrf Provencher Henri Provencher Maurice But eau.Maurice Buteau., Lucien Bouchard.Arthur G 61 in an.Arthur Gélinas.32.52 74.26 49.76 151.93 37.00 78.71 49.11 46.61 36.42 148.65 66.20 109.60 102.70 117.89 94.45 59.15 68.94 222.81 114.06 261.53 139.70 196.60 143.56 106.76 Corporation de Launay \u2014 Commission scolaire de Launay Corporation of Launay \u2014 School Commission of Launay \t12.\t3.\t\t10.62 9.95 6.23 10.63 1.85 1.35 8.94\t22.10 20.65 12.68 22.10 3.25 2.90 18.49\t32.72 30.60 18.91 32.73 5.10 4.26 27.42 II\t14.\t3.\t\t\t\t \t17.\t3.\t\t\t\t \u2022 \u2022\t19.\t3.\t\t\t\t \t\t\tEdmond Ouellette\t\t\t \u20221\tHs 21.20.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.\tî!,.4.\t\t\t\t \u2022 i\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Corporation de Launay \u2014 Commission scolaire de Villemontel Corporation of Launay \u2014 School Commission of Villemontel\t\t\t\t\t\t \t60a b od.\t4.\t\t46.41\t88.86\t135.27 \t\t\t\t\t\t Commission scolaire de 8t-Benoit La Corne \u2014 School Commission of St-Benoit La Corne LaMotte.La Corne.LaMotte.43.Empl.lot 1.Emp.65 74.82 51.97 76.50 28.82 Emplacement 56, rang 3, camp d'été, situé sur le Emplacement 65, range 3, summer camp bord du lac Malartio.on the shores of Mslsrtio Lake.Fernand Bourgeault.Pierre Naud.Jean-Louis Rivard.Jean-Louis Rivard.74.82 61.97 76.50 28.82 situated La Corne.\t10.\t6.\tMaurice Fontaine.J.\t84.84\t84.84 \t\t\t\t\t _ Commission scolaire de Val 8enneville \u2014 School Commission of Vol Sennevills Bennevifte.|.|.I Georges Hardy.|.I 54.47 | 64.47 H partie est de la rivière, du lot 33, rang 1, et la H part east of the river, of lot 33, rangs 1, and the partie sud du lot 34, rang 1.port south of lot 34, range 1.Sennevifle.33.35.2.Albert Pépin.91.30 12.18 1.emplacement de 50 par 100 pieds, situé sur le lot 1 emplacement of 60 by 100 feet situated on lot 91.30 Clermont ForUer.1.12.18 subdivision 36.du rang 4.Sennevills.\tN28, 29.\t4.\tN 32.\t4.\t61.19.\t5.0.\t\t \t21.34.\t6.6.\t\t \t\t subdivision 35, of range 4.Adrien Ouimet.Adrien Ouimet.Alphonse Fortier.Clermond Gilbert.Dosithé Gilbert.E mi lien Desforges.i.Elie Raymond.Partie à l'est de la rivière, sur le lot 49, rang 6, et la Part at east of the river, on the lot 49, range 6, and partie sud do lot 60, rang 6.the part south of lot 50, range 6.35.64 53.22 62.01 49.94 102.16 62.50 87.78 35.64 53.22 62.01 49.04 102.16 62.50 87.78 Senneviue.86.36.7.J.H.Perrisr.M I.I.I Hlidège-fiilodesu Chalet situé sur les bords du lse Blouin.clubVol du Repos, lot 40.92.59 92.69 .I 92.61 | 92.61 Cottage situated on the shore of Blouin Lske, Val du Repos Club, lot 40.Corporation de La Motte \u2014 Commission scolaire de La Motte Corporation of La Motte\u2014 School Commission of La Motte Malartio.LaMotte.!.!.17.8.9.13.14.16.26.28.13.14.22.!.2.25.9 2 2 2 3 3 Lucien La voie.Arthur Choquette.Arthur Choquette.Simon Choquette.Armand Guay.Paul Ko n se v i c h.Eugène Richard.Wilfrid Richard, jr.Germain Deniers.Paul-Emile Guay.Cyrinos Laliberté.Leo Paulin.\".Lucien Meilleur.Wilfrid Richard, jr.Cyrénos Laliberté.Gérard Landry.14.92 2.70 15.20 13.93 14.52 25.80 26.76 25.27 13.91 5.67 5.67 15.55 15 34 25.99 61.92 29.60 21.74 42.98 80.74 71.02 109.74 78.38 43.72 35.40 19.88 16.34 38.27 14.92 18.04 26.99 67.12 43.43 21.74 67.60 108.54 71.02 109.74 106.13 68.99 49.31 26.08 21.01 63.81 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Blet, 1969, Vol.91, No.8 899 Commission scolaire d» Champneuf \u2014 School Commission of Champneuf Canton ou vulsgs Township or village\tLot\tRang Bloc Rangs Block\tPropriétaire Owner\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes sec4.School taxes\tTotal \tKN54, 52c, Hn53b.69.\t\t\t\t67.28 88.83 82.11 70.80 94.38-44.20 47.69 105.94 72.17 26.61 38.76 66.39 119.50 62.24 111.36 45.83 68.72 70.38 45.29 77.07 119.83 72.87 116.83 92.35 93.16 96.71 38.55 34.09 113.08 48.70 48.73 31.60 58.40 40.12 68.72 84.67 68.72\t67.28 88.83 82.11 70:80 94.38 44.20 47.60 106.04 72.17 26.61 38.76 66.89 118.60 62.34 111.36 45.83 68.72 70.38 45.29 77.07 119.83 72.87 116.83 92.35 93.16 96.71 38.65 34.09 113.08 48.70 48.73 31.60 58.40 40.13 68.72 84.67 68.73 M\t\t1.\t\t\t\t \t62a et and 63b 64.\t2\tGérard Goulet.\t\t\t \t\t2.2\tGérard Lebreuz.\t\t\t M\t57.\t\t\t\t\t \t\t1.\t\t\t\t M\t4.\t1.\t\t\t\t II\t8.\t1.\t\t\t\t II\t21.24.25.\t1.1.\t\t\t\t II\t\t\t\t\t\t II\t\t\t\t\t\t II.\t26.\t1.\t\t\t\t \u2022I\tHN 30 et-and 31.33.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Il\t34.\t1.\t\t\t\t M \u201e U\t3.18.19.\t2.2.2.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t II\t\t\t\t\t\t II\t24.\t2.\t\t\t\t II\t25.\t2.\tIsidore Caron.\t\t\t \u2022I\t33.\t2.\t\t\t\t M\t35.\t2.\tLucien Martin.\t\t\t \u2022I\t4.\t3.\tLéoopold Beaudoin.\t\t\t II\t12.\t3.\t\t\t\t \u2022I\t14.\t3.\tMosart Vésina.\t\t\t \t18.\t3.\t\t\t\t II\t19.\t3.\tEdouard Lauion.\t\t\t \u2022I\t20.26.\t3.\t\t\t\t II\t\t8.\t\t\t\t II\t30.\t3.\t\t\t\t \u2022\u2022\t\t4.\tLéo Pelletier.\t\t\t \u2022I\t1?.\t4.\tMaurice Raymond.\t\t\t II\t20.\t4.\t\t\t\t \u2022I\t21.\t4.\tGabriel Dubé.\".,.\t\t\t \t1/3 S18.19.20.« ,8-15.16.\t\tRoger Norm an din.\t\t\t \t\t0.\tLéon Norman din.\t\t\t II\t\t9.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Corporation ds Poularies \u2014 Commission scolaire de Poulariss Corporation of Poulariss \u2014 School Conimission of Poularies\t\t\t\t\t\t Poulariss.\t42.40ab.\t4.6.\tLauréat Per result.\t3.96 26.77 20.00 36.01\t15.05\t19.01 25.77 94.00 60.05 ii\t\t\tHenri Lampron.\t\t\t \u2022i\t\t5.\t\t\t74.00 25.04\t !\u2022\tH839.40.\t0.\tThomas Beaudette.\t\t\t \t\t\t\t\t\t Corporation du canton La Sarre \u2014 Commission scolaire de La Sarre Corporation of township La Sarre \u2014 School Commission of La Barre La Barre.\t8.\t7.\t19.\t7.ii\t20.\t7.\" O .O 0\t19.\t8.Il .\t49.\t \t12.\t9.II\t14, 16.\t9.\u2022I\t21.\t10 Clermont.\t4.\t1.Edmond Lsbeau.Edddy Tu r bide.Clément Déry., gavid Fortin.mile Thsrrien.Mme-Mrs.Lucien Descoteaux.Mme-Mrs.Luoien Descoteaux.Rosaire Mayer.Ernest Therrien.36.34\t88.73 3.01\t12.08 3.01\t11.66 20.00\t62.10 8.39\t33.65 25 80\t62.00 37.84\t92.40 33.76\t130.40 16.86\t \t Corporation d'Amos Ouest \u2014 Commission scolaire ds Delage Corporation of Amos-West \u2014 School Commission of Delage Figuery.15ab.10.Mario Thibeault.25a.10.1 Robert Trudel.15.75\t79.65\t95.40 10.50\t53.18 1\t63.68 Un emplacement sur ce lot 26a, rang 10, mesurant An emplacement on this lot 25o, rangs 10, measuring cinquante (60) pieds en front du nord au sud, par cent fifty (60) feet in front from north to south, by ons cinquante (160) pieds en profondeur situé à fa partis hundred and fifty.(160) feet in depth, situated on the est du lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi east part of lot known and designated on the official du cadastre officiel-pour le canton Figuery sous 19 plan and in the book of reference for the Figuery numéro 25a du rang 10, borné, ledit emplacement, township, under number 26a of range 10, bounded, the comms suit: au nord par une ligne parallèle à la ligne said emplacement, as follows: on ths north, by a lins \" \" »t, passing at ons on the east, in south, by s line par uns ligne 'parallèle à la ligne ouest de l'a route régififty-(50)\" \"feet of\" the 1 at ter HneVancTon the west ?by s noie passant à cent cinquante (150) pieds de oetts line parellel to the west line of the regional route paaaing derniers.at one hundred and fifty (150) feet of this latter. 900 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, SI février 1969, Tome 91, N° 8 Corporation d'Amoa Ouest \u2014 Commission scolaire de Delage (suite) Corporation of Amos-West \u2014 School Commission of Delage (continued) Canton ou\t\tRang\t\tTaxes\tTaxes\t village\t\tBloc\tPropriétaire\tmunie.\tscol.\t \u2014\tLot\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\tTotal Township or\t\tRange\tOwner\tMunie.\tSchool\t village\t\tBlock\t\ttaxes\ttaxes\t \t25a.\t10.\t\t15.57\t19.40\t34.97 _ Un emplacement sur ce lot 25a, rang 10, mesurant cinquante (50) pieds en front du nord au sud par cent cinquante (150) en profondeur, étant le coin sud est du lot connu at désigné aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel pour le canton Figuery, sous le numéro 25a du rang 10, borné ledit emplacement comme suit: au nord par une ligne parallèle à la ligne sud dUdit lot passant à ligne sud dut i lot passant à cinquante (50) pieds de cette dernière, à l'est, en front par la route régionale, au sud par le lot 26 du même rang et à l'ouest par une ligne parallèle à la ligne ouest de la route régionale, passant & oent cinquante (150) pieds de cette dernière.An emplacement on this lot 25a, range 10, measuring fifty (50) feet in front, from north to south, by one hundred and fifty (150) in depth, being the southwssst corner of lot known and designated on the official plan and in the book of reference of the official cad aster for the Figuery township, under number 25a of range 10, bounded the said emplacement as follows: on the north, by a line parallel to the south line of the said lot passing at the south line of the said lot passing at fifty (50) feet of the latter, on th east, in front, by the regional route, on the south, by lot 26 of the same range and on the west, by a line parallel to the west line of the regional route, passing at one hundred and fifty (150 feet of this latter.\t19.\t2.\t\t8.60 12.60\t21.42 63.77\t30.03 77.37 \t22.\t4.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Commission scolaire de Lac Castagnier \u2014 School Commission of Lac Castagnier\t\t\t\t\t\t Vassal.\t36.\t1.\t\t\t28.64 24.80 24.74 36.51 31.65 26.13\t28.64 24.80 24.74 36.51 31.55 26.13 \t20.\t9.\t\t\t\t \t22.\t10\t\t\t\t n\tV, 8.24,25.H 8.45,46.\t10\t\t\t\t \t\t10\t\t\t\t ii\t\t8.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Corporation de Ste-Germaine Boulé \u2014 Commission scolaire de Ste-Germaine Corporation of Ste-Germaine Boulé \u2014 School Commission cf Ste-Germaine Duparquet Palmarolle 20.34.33.43.27.10.10.1.1.1.Moïse Cadottè.Suce.-Est.Dome we-widow Noel St-Laurent.Léo Beaulieu.Charles Giroux.Rosaire Cadotte.25.03\t95.65\t120.68 87.89\t43.60\t81.39 21.72\t77.20\t98.92 29.90\t87.10\t117.00 27.32\t97.85\t126.17 Corporation d'Amoa Est \u2014 Commission scolaire de Dollard Corporation of Amos East \u2014 School Commission of Dollard Figuery.44ab.\" .I 45a.10.Roland Hamel.10.Paul Hamel.11.80\t' 114.00\t126.80 1.15\t6.80\t7.95 Un emplacement situé au coin sud-ouest du lot 45a, An emplacement situated at the southwest corner rang 10, Figuery, mesurant cinquante (60) pieds en of lot 45a, range 10 Figuery, measuring fifty (50) feet front par (100) cent en profondeur.in front by one hundred (100) in depth.Dalqfier.Figuery., Dalquier.61.2/3S46.56a, 57a.40 et-and HS 41.53.37b.38a et-and 39a.64.10.1.Fernand Hamel.Roger Hamel.Robert Hamel.Maurice Lambert.Claude Bissonnette.Rosaire Roy.36.20\t132.80\t169.00 4.00 4.50\t16.35 14.40\t20.35 18.90 20.75 8.45\t92.82 81.33\t113.57 89.78 1.75\t\t1.75 \t\t Commission scolaire de St-Dominique du Rosaire \u2014 School Commission of St-Dominique du Rosaire \t11c, 12a.\t1.\tAlbert d'Aoust.\t\t25.60 36.16 61.60 16.00\t25.60 36.16 61.60 16.00 II\t16c.\t3.\tDame we-widow Leopold Gauthier.Dame we-widow Leopold Gauthier.\t\t\t \u201e\t17b.\t3.\".\t\t\t\t II\t32.\t10\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Corporation de la paroisse de St-Mathieu \u2014 Commission scolaire de St-Mathieu Corporation of the parish of 8t-Mathieu \u2014 School Commission of St-Mathieu Villemontel Figuery.64.49.3 et-and >$N 4 4.21.2 3 4 5 5 Jean-Bte Larouche Jean-Bte Larouche Joseph Hébert____ Fernand Robert.Oscar Lanthier.31.50 10.26 20.00 24.75 49.50 102.50 31.60 41.00 48.25 224.00 184.00 41.86 61.00 78.00 273.50 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Hist, 1969, Vol.91, No.8 901 Commission scolaire de Vassan \u2014 School Commission of V ass an Canton ou village Township or village\tLot\tRang Bloc Range Block\tPropriétaire Owner\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes BCOl.School taxes\tTotal \t13ab\".\t9.\t\t\t59.86 49.37 61.20\tCO.30 49.37 61.20 \t\t9.\t\t\t\t M\tMS 19, 20.\t9.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Corporation du village Barraute \u2014 Commission scolaire de Fiedmont et Barrante Corporation of village Barraute \u2014 School Commission of Fiedmont and Barraute\t\t\t\t\t\t Village Barraute.\t19.\t9.\t\t43.00\t66.50\t109.60 \t\t\t\t\t\t Corporation de Fiedmont et Barraute \u2014 Commission scolaire de Fiedmont et Barraute Corporation of Fiedmont and Barraute \u2014 School Commission of Fiedmont and Barraute \t28.\t7.\t\t\t68.80 131.23 171.25\t68.80 165.23 214.07 \u2022I\t18.19.\t9.9.\t\t34.00 42.82\t\t \u2022(\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Corporation de Landrienne \u2014 Commission scolaire de Landrienne Corporation of Landrienne \u2014 School Commission of Landrienne\t\t\t\t\t\t \t11.27ab.\t7.8.\t\t18.00 4.50 10.35 15.30\t60.00 15.00 34.50 64.00\t78.00 19.60 44.86 69.80 \t\t\t\t\t\t Duverny.\t18.\t1.\t\t\t\t \t14-22.\t8.\t\t\t\t Donné à Amos, ce 31 janvier 1959.Given at Amos, this 31st day of January, 1959.Le Secrétaire-trésorier, LAVAL GOULET, de la corporation du comté d'Abitibi, Secretary-Treasurer, 49312-6-2-0 LAVAL GOULET.49812-6-2-o Corporation of the county of Abitibi.Province de Québec Province of Quebec La corporation municipale de comté The municipal corporation of the countt du Lac Sajnt-Jean-Est op Lake Saint John-East Avis public est par les présentes donné, que Public notice is hereby given that, pursuant conformément aux dispositions du Code muni- to the provisions of the Municipal Code of the cipal de la province de Québec, et au règlement Province of Quebec, and by-law number sixty numéro soixante de ce conseil de Comté, adopté of this County Council, adopted September 10, le 10 septembre 1947, et approuvé par l'Honorable 1947, and approved by the Honourable the Ministre des Affaires Municipales, les propriétés Minister of Municipal Affairs, the properties ci-dessous décrites, seront vendues 'pour taxes, hereinunder described shall be sold for taxes, at à l'Hôtel de Ville d'Alma (Salle du Conseil) the City Hall of Alma (Council-room) WED- MERCREDI le VINGT-NEUVIÈME jour NESDAY the TWENTY-NINTH day of APRIL d'AVRIL 1959, à DIX heures de l'avant-midi.1959, at TEN o'clock in the forenoon.Cette vente comprendra les bâtiments érigés This sale shall include the buildings erected sur les terrains mis en vente s'il en existe alors: on the lands put up for sale if any exist at that time: Vendu contre Sold versus\tLot\tRang Range\tCanton Township\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTaxes d'église et d'aqueduo Church and water taxes Bella Limitée (1).\tP.13.\t5.\tLabarre.Labarre.Village H6-bertville .Village Hébert ville .\t1352.40 156.76 6.36 625.17\t8389.40 46.16 2.60 995.45\t222.10 68.16 \tP.9.\t4.\t\t\t\t \t62-1-111-2 111-3, 111-4.i.288-289-293-294-295-P.281, 280-279-284-286.11-12.\t2 O.-W\t\t\t\t Paul Dufour.\u2022\t12C-CD.\t1 O.-W\thM6sy.Labarre.\t101 «74 6.68\t186.64 3.74\t \tP.7.\tCh.-Road Kén.R.O.-W.\t\t\t\t N «02 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1959, Tome 91, N\" 8 Vendu contre Sold versus Lot Rang Range Canton ' Township Taxes munie.Munie taxes Taxes sool.School taxes Taxes d'église et d'aqueduc Church and water taxes Louis-Henri Gagné (6) Armand Pelletier (7) .Maurice Simard (8) Isidore Tremblay (9) .Patrick Tremblay (10) Ladislas Lapointe (11).Philippe Fortin (12).René Fortin (13).Oswald Fleury.Bâtisse seulement sur ptie du lot 25.12 a.12 B.P.6a.19a.9B, 10a, et-and 10 b 17a, b, c.18a, b, o,.P.21.10.11-12.P.12.1 Est.-East.2 2 O.-W.O.Ch.-Road W.Kén.D.A.3.5.4.2.Buildings Caron .Mésy.Signal .Labarre.167.40 20.90 70.20 142.21 312.15 33.08 129.30 Labarre.Signal .Mésy.Taillon .196.09 14.87 8.70 576.79 24.16 76.00 Gordon M al key (14)- Lionel Ferland (16)- Léo Côté (16).Stanislas Savard.8taniaras Savard.Georges Audet W.(17) .Charles Côté (18).Ernest Côté W.(19).Robert Lajoie (20).Conrad Nadeau (21) .Real Tremblay.Welley Tremblay.Joseph Robitaille (22) .Norbert Mornesu (23).P.28-36 .P.14.P.28-13.P.Sud-South 18 .P.Sud-South lot 19.P.4-B.P.7-1.P.5D.P.17B.28 b, H-29.P.Sud-South 29-C .P.18-o.P.35.P.7A.7.6.7.12.12.10.10.10.10.8.A.10.7.Saguenay Taillon .Taillon ., only on pt Taillon .Taillon .Taillon .Taillon .Taillon .Signal .Signal .Signal .Signal .Signal .Signa! .Signal .Signal .Labarre.17.10 of lot 25.19.55 32.71 3.78 17.36 36.48 103.62 59.80 63.55 3.50 61.10 3.00 7.00 32.60 1.35 135.32 39.26 41.35 69.50 1.60 22.88 42.70 93.40 116.25 89.00 12.18 224.07 15.25 35.50 69.30 6.88 i4!72 112.50 4.50 (1) Un terrain situé à St-Bruno, comté du Lac St-Jean, mesurant 150 pieds de largeur du nord au sud, sur 100 pieds de profondeur oh de l'est à l'ouest, faisant partie du lot N4 13 du cadastre officiel pour le 5iome rang du canton Labarre.Borné à l'ouest à la route régionale; à l'est au reste du lot dont il fait partie; au nord au reste du lot dont il fait partie, soit à 262 pieds et 3/10 de la ligne de division des lots Nos.13 et 14, et au sud, au reste du lot dont il fait partie, appartenant au vendeur.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.(2) Un terrain emplacement sis et situé dans le village de St-Bruno, comté du Lac St-Jean, mesurant 50 pieds de largeur du sud au nord; sur 126 pieds de profondeur de l'est à l'ouest, faisant partie du lot N° 9 du cadastre officiel pour la 4ième rang du canton Labarre, avec ensemble les bâtisses dessus construites, appartenance et dépendance.Borné en front vers l'est au chemin d'Alma; en arrière à la profendeur vers l'ouest, au terrain de Osias Tremblay joignant au nord le terrain de Léonce Bouchard ou représentant, et au sud, celui de Gérard Côté fils David.(3) Un terrain ou emplacement étant formé des parties du lot numéro 52-1 et des lots 111-2, 111-3, 111-4 des plan et livre de renvoi du cadastre officiel du village de Notre-Dame d'Hébertville, comté de Lac St-Jean-Est.Le tout sans bâtisse, sauf â diatriare les terrains vendus et droits concédés suivant titre enregistré.(4) Un terrain ou emplacement situé â Notre-Dame d'Hébertville, avec les bâtisses y érigées, circonstances et dépendances, tant et comprenant: a) Les quatre-vingt-dix pieds nord des lots de terrain maintenant connus et désignés au plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour le village d'Hébertville, sous les numéros deux cent quatre-vingt et deux cent quatre-vingt-un (P.Nos 280 et 281) sur la largeur desdits lots soit cent trente-deux pieds (132') et bornes les quatre-vingt pieds nord en totalité comme suit: A l'ouest â la rue du chemin d'Alma, â l'est partie au lot deux cent quatre-vingt-cinq (ptie lot 285) et au sud â la partie sud des lots numéros deux cent quatre-vingt et deux cent quatre-vingt-un (Parties lots: 280 et 281) dont il font partie; b) Les lots de terre maintenant connus et désignés aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du village d'Hébertville, sous les numéros deux cent quatre-vingt-cinq, deux cent quatre-vingt-neuf, deux cent quatre-vingt-quatrose et deux cent quatre-vingt-quinse (Nos 286, 289.294 et 295).e) Les quatrose pieds ouest des lots de terre maintenant connus et désignés aux plan et livre de renvoi (1) A piece of land situated at St.Bruno, county of Lake St.John, measuring 150 feet in width from north to south, by 100 feet in depth or from east to west, forming part of lot No.13 of the official cadaster for range 5 of the township of Labarre.Bounded westerly by the local road, easterly by the residue of the lot forming part thereof; notherly by the residue of the lot forming part thereof, that is, at 262 feet and 3/10 from the dividing line of lots No.13 and 14, and southerly, by the residue of the lot forming part thereof, belonging to the vendor.All of which with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.(2) A land emplacement lying and situated in the village of St.Bruno, county of Lake St.John, measuring 60 feet in width from south to north; by 125 feet in depth from east to west, forming part of lot No.9 of the official cadsster for range 4.of the township of Labarre, together with the buildings thereon erected, appurtenances and dependencies.Bounded in front easterly by the Alma Road; in the rear by the depth to the west, the Isnd of Osias Tremblay adjoining to the north the land of Léonce Bouchard or representative, and southerly that of Gérard Côté, the son of David.(3) A piece of land or emplacement being formed of parts of lot No.52-1 and lots 111-2, 111-3, 111-4 of the plan and book of reference of the official cadaster of the village of Notre-Dame d'Hébertville, county of Lake St.John-East.All of which without buildings, save to be excluded the lands sold and rights granted according to registered deed.(4) A piece of land or emplacement situated at Notre Dame d'Hébertville, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, comprising: a) Those ninety feet north of the lots of land presently known and designated on the official plan and book of reference of the cadaster for the village of Hébertville, under numbers two hundred and eighty and two hundred and eighty-one (P.Nos.280 and 281) along the width of said lots, that is, one hundred and thirty-two feet (132'! and the northerly eighty feet entirely bounded as follows: westerly by the street of Alma Road, easterly partly by lot two hundred and eighty-five (P.lot 285) and southerly by tho south part of lot numbers two hundred and eighty and two hundred and eighty-one (P.lots 280 and 281).b) Lots of land now known and designated on the official plan and book of reference of the cadaster of the village of Hébertville, under numbers two hundred and eighty-five, two hundred and eighty-nine, two hundred and ninety-four and two hundred and ninety-five (Nos.285, 289.294 and 295).c) The fourteen feet west of lots of land now known and designated on the official plan and book of refe- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1959, Vol.91, No.8 903 officiels da cadastre du village d'Hébertville sous les numéros deux cent quatre-vingt-quatre; deux cent quatre-vingt-huit ' et deux cent quatre-vingt-treise (Nos 284, 288 et 293) lesquels 14 pieds ouest sont bornés en totalité comme suit: au nord à une rue, au sud su lot deux cent soixante-dix-neuf, à l'ouest aux lots deux cent quatre-vingt-cinq et deux cent quatre-vingt-neuf et deux cent qustre-vlngt-quatorse et â l'est à la partis est des lots deux oent quatre-vingt-quatre, deux oent quatre-vingt-huit et deux cent quatre-vingt-treiie appartenant au vendeur; \u2014 d) Une lisière de terrain ds quatorse pieds de largeur sur une profondeur de cent dix pieds (14 x 110) étant les qustorss pieds ouest du lot do terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du village d'Hébertville, sous Is numéro deux cent soixante et dix-neuf (14 pieds ouest N° 279) laquelle lisière est bornée: au nord au lot numéro deux, cent quatre-vingt-quatre; à l'ouest au lot numéro deux oent quatre-vingt; au sud aux quatorse pieds sud-ouest dudit lot deux cent soixante-dix-neuf et a l'est au résidu dudit lot deux oent soixante-dix-neuf dont il fait partie et appartenant à M.Ernest Girard; e) Un terrain mesurant soixante-six pieds de largeur (660 par vingt-cinq (25') de profondeur nord-sud, lequel terrain fait partie du lot de terre maintenant connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du village d'Hébertville sous le numéro deux cent quatre-vingt (Ptie N* 280) lequel terrain est ainsi borné: au nord à la partie nord du lot deux oent quatre-vingt décrit au paragraphe a) ci-dessus; au sud à la partie sud du lot deux cent quatre-vingt, appartenant au vendeur; à l'ouest à la partie du lot deux cent quatre-vingt-un appartenant à Stranislas Voisine et à l'est aux quatorse pieds ouest du lot deux cent soixante-dix-neuf décrit au paragraphe c) ci-dessus; f) Un terrain faisant partie du lot de terre maintenant connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du village d'Hébertville, sous le numéro deux cent quatre-vingt (Ptie N° 280) et étant la partie sud dudit immeuble mesurant soixante-six pieds (660 de largeur étant la largeur du lot sur une profondeur de rent dix pieds (1100 et ainsi borné: au sud â la rue Morin; au nord à la partie nord dudit lot deux oent quatre-vingt; à l'ouest au lot deux cent quatre-vingt-un appartenant â Stanislas Voisine, à 1 est au quatorse pieds ouest du lot numéro soixsnte-dix-neuf ci-après décrit; g) Les quatorse pieds ouest du lot de terre maintenant connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du village d'Hébertville sous le numéro deux cent soixsnto-dix-neuf (14 pieds ouest 270) lesquels quatorse pieds ouest sont ainsi bornés; au sud à la rue Morin; su nord et à l'est su résidu dudit lot deux cent soixante-dix-neuf appartenant au vendeur; à l'ouest su terrain ci-dessus décrit au paragraphe /) ci-dessus.(5)«a) Les lots de terre connus et désignés sous les numéros onse et douse (11 et 12) du cadastre officiel pour le rang deux (2) ouest du canton Mésy, contenant en totalité 206 acres de terre.6) Les lots 12 e et ed du cadastre officiel pour le rang un ouest du canton Mésy comprenant en superficie un acre de terre.Le tout avec bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Sauf h distraire, les terrains vendus et droits concédés suivant titre enregistré.(6) Les lots de terre connus et désignés sous les numéros douse-a et douse b, (12a et 126) du cadastre officiel pour le rang trois du canton Caron, contenant en totalité 113 acres de torre.Le tout avec bâtisses y érigées, circonstances et dependences.Ssuf â distraire, les terrains vendus et droits concédés suivant titres enregistrés.(7) a) Un terrain ou emplacement de forme rectangulaire, situé en.la paroisse de Notre-Dame d'Hébertville faisant partie du lot de terre connu et désigné au cadastre officiel du canton Mésy, sous le numéro cinq-a (Ptie 6a) du premier rang est dudit canton, mesurant une largeur de cinq cents piessd (500') dans le sens nord-sud, longeant le Lac-Vert, et une profondeur de deux cent cinquante pieds (2500 dans le sens est-ouest.Lequel terrain est borné comme suit: au nord et â l'est au terrain de Uldérie Deschênes ou représentant, soit M.Adrien Emond, propriétaire actuel; au sud au terrain de Uldérie Deschênes, propriété maintenant de M.Adrien Emond, encore â la clôture qui existe actuellement â deux pieds environ du côté sud du Ruisseau â Face, et â l'ouest au Lac-Vert; la ligne dans la borne ouest suit la sinuosité du Lac Vert.Avec droit de passage sur ledit N* 5a.8auf â distrsire les terrains vendus et droits concédés suivant titre enregistré.b) Un terrain situé â Hébertville, mesurant dans sa ligne ouest environ neuf cents pieds, logeant 1s Lac Vert sur une profondeur de cent pieds ou de l'est renée of the cadaster of the village of Hébertville under numbers two hundred and eighty-four; two hundred and eighty-eight and two hundred and ninety-three (Nos.234,28S and 293) which westerly 14 feet are entirely bounded as follows: northerly by a street, southerly by lot two hundred and seventy-nine, westerly by lots two hundred and eighty-five*, two hundred and eighty-nine and two hundred and ninety-four, and easterly by the easterly part of lots two hundred and eighty-four, two hundred and eighty-eight and two hundred and ninety-three belonging to the vendor: d) A strip of land of fourteen feet in width by a depth of one hundred and ten feet (14 x 110) being the fourteen feet west of lot of land known and designated on the official plan and book of reference of the cadaster of the village of Hébertville under number two hundred and seventy-nine (14 feet west No.279) which strip of land is hounded: northerly by lot number two hundred and eighty-four; westerly by lot number two hundred and eighty; southerly by fourteen feet to the southwest of said lot two hundred and seventy-nme and easterly by the residue of said lot two hundred and seventy-nine forming part thereof and belonging to Mr.Ernest Girard; e) A piece of land measuring sixty-six feet in width (660 by twenty-five feet (250 in depth to the north-south, which land forms part of lot of land presently known and designated on the official plan ana book of reference of the cadaster of the village of Hébertville under number two hundred and eighty (P.No.280) which land is bounded as follows: northerly by that northern part of lot two hundred and eighty described in paragraph \"a\" hereinabove; southerly by the southerly part of lot two hundred and eighty belonging to the vendor; westerly by that part of lot two hundred and eighty-one belonging to Stanislas Voisine and easterly by the fourteen feet wast of lot two hundred and seventy-nine described in paragraph c) hereinabove; /) A piece of land forming part of lot of land presently known and designated on the official plan ana book of reference of the cadaster of tho village of Hébertville, 'under number two hundred and eighty (P.No.280) and being the southerly part of said immoveable measuring sixty-six feet (660 wide being the width of the lot by a depth of one hundred and ten feet (1100 and bounded as follows: southerly by Morin Street: northerly by the northerly part of said lot two hundred and eighty, westerly by lot two hundred and eighty-one belonging to Stanislas Voisine, easterly by fourteen feet west of lot number seventy-nine described heroin-after; 17) The fourteen feet west of lot of land presently known and designated on the offioial plan and book of reference of the cadaster of the village of Hébertville under number two hundred and seventy-nine (14 feet west 279) which fourteen feet to the west are bounded as follows: southerly by Morin Street; northerly and easterly by the residue of said lot two hundred and seventy-nine belonging to the vendor; westerly by the land hereinabove described in paragraph/).(5) a) Lots of land known and designated under numbers eleven and twelve (11 and 12) of the offioial cadaster for range two (2) west of township Mésy, containing a total of 206 acres of land.6) Lots 12c and ed of the official cadaster for range one west of township Mésy comprising an ares of one acre of land.All of which with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Ssve and except, the pieces of lsnd sold and rights granted according to registered deed.(6) Lots of land known and designated under numbers twelve a and twelve 6, (12a and 126) of the official cadaster for range three of the township of Caron, containing a total of 113 acres of land.All of which with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.8avo and except, the pieces of land sold and rights granted according to registered deeds.(7) a) A piece of land or emplacement of rectangular shape, situated in the parish of Notre Dame d'Hébertville forming part of lot of land known and designated on the official cadaster of the township of Mésy, under number five-a (P.5-a) of east range one of said township, measuring a width of five hundred feet (5000 in a north-south direction, bordering Lac Vert, and a depth of two hundred and fifty feet (2500 in an eostwesterly direction.Which piece of land is bounded as follows: northerly and easterly by tho land of Uldérie Deschênes or representative, that is Mr.Adrien Emond, the present owner: southerly by the land of Uldérie Deschénes, owned presently by Mr.Adrien Emond, further by the fence which actually exists at some two feet from the south side of Ruisseau â Face, and westerly by Lao Vert; the west boundary line follows the bend of Lac Vert.With right-of-way on said No.5a.Save and except the lands sold and rights granted according to registered deed.b) A piece of land situated at Hébertville, measuring in its westerly line some nine hundred feet, bordering Lac Vert along a depth of one hundred feet or from east 904 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1969, Tome 91, N° 8 à l'ouest; faisant partie du lot numéro cinq-a, (Ptie 6-a) du premier rang est du cadastre officiel du canton Mésy et borné au nord au terrain de Armand Pelletier (ruisseau à face), à l'est au terrain d'Adrien Edmond; au sud au terrain d'Adrien Edmond, soit à environ deux cents pieds de la ligne de division des rangs un est et deux est dudit canton ;\" à l'ouest, au Lac Vert, tel que piqueté par les parties.Distraire toute la partie en culture, telle que déterminée par les parties, par des piquets posés par ces derniers.Sauf a distraire également tous les terrains vendus et droits concédés, suivant titre enregistré.(8) Le lot de terro connu et désigné sous le numéro dix-neuf-a (19a) du cadastre officiel pour le rang deux du canton Signal, contenant en totalité cinquante-trois acres de terre.Le tout avec bâtisses y érigées circonstances et dépendances.Sauf à distraire, les terrains vendus et droits concédés suivant titre enregistré.(9) Les lots de terre connus et désignés sous les numéros neuf-6 dix-a, et dix-6 (Nos 9-6, 10-a, 10-6) du cadastre officiel pour le rang deux ouest du canton Labarre, contenant en totalité environ cent cinquante-six acres de terre.Le tout avec bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Sauf a distraire les terrains vendus, et droits concédés suivant titre enregistré.(10) a) Les lots de terre connus et désignés sous les numéros dix-lmit-o et dix-huit-6, (Nos 18-a et 18-6) du cadastre officiel pour le rang lettre \"D\" du canton de Signal; 6) La partie sud-ouest de la demi ouest des lots do terre numéros dix-sept-6 et dix-sopt-*>4 c (Ptie S.O.de yi) N.17-6 et 17-c du cadastre pour le rang Ouest du Chemin Kénogami, dans le canton Labarre; c) la demi indivise du lot numéro un (M N4 1) du cadastre du troisième rang est du canton do Mésy; sauf à distriare desdits immeubles le terrain vendu à la Voirie, et les terrains vendus et droits concédés suivant titre enregistré.Le tout avec bâtisses érigées sur les susdits immeubles, appartenances et dépendances.(11) Un terrain faisant partie du lot numéro vingt et un (Ptie 21) du cadastre officiel du rang \"A\" dans le canton Mésy, mesurant deux cent cinquante-huit pieds (268') de largeur dans le sens du chemin public ou Route Régionale N° 56, sur quatre-vingt-dix pieds (90') de profondeur connu sous le nom de butte des épinettes, borné au nord par lesdites épinettes ou reste du terrain du vendeur, â l'est par la coulée ou reste du terrain du vendeur, â l'ouest par le bas de la coulée du ponceau \"Calvert\" et au sud par l'ancien chemin ou route régionale N° 65, avant sa réfection ou son élargissement, d'une superficie d'environ trois quarts d'arpent, sauf â en distraire la partie vendue au Ministère de la Voirie et la servitude concédée â la Compagnie Electrique du Saguenay par acte N° .42814.\u2022 t (12) Le lot de terre connu et désigné sous le numéro dix (10) au cadastre officiel du canton Taillon dans le rang trois; sauf â distraire la servitude concédée â la Compagnie Electrique du Saguenay.(13) Les lots de terre connus et désignés au cadastre officiel du canton Taillon sous les numéros onse et douse du cinquième rang; sauf â distraire les terrains vendus et droits concédés suivant titre enregistré.Ptie nord 12, rang 4 Taillon.La partie nord du let de terro connu et désigné sous le numéro douse do quatre acres en superficie, aux plan et livre de renvoi officiels pour le quatrième rang dudit canton Taillon, borné comme suit: au nord, au trait carré des rangs quatre et cinq; â l'est au lot numéro onse; au sud au chemin public et à l'ouest au let numéro treise desdits rang et canton; sauf â distraire les terrains vendus et droits concédés suivant titre enregistré.(14) Un terrain faisant partie du lot 28-36 d'une subdivision du lot numéro vingt-huit du rang sept du canton Taillon, â Ste-Monique, Lac St-Jean, mesurant 83 pieds de largeur au nord dans le sens Est-ouest, sur 60 pieds de profondeur, borné au nord â l'avenue 28-4, à 1 est au lot 28-26-2; au sud et â l'ouest au reste du lot dont ledit terrain fait partie avec les servitudes actives et passives avec droit de passage sur le lot 28-4 (Avenue) pour communiquer avec lo chemin public.Sauf â distraire la servitude concédée â la Compagnie Electrique du Saguenay.(15) Le lot de terre connu et désigné au cadastre officiel du canton Taillon sous le numéro 14 rang 6 dudit canton.Sauf â distraire la servitude condédée â la Compagnie Electrique du Saguenay.(16) Un terrain ou emplacement situé â Ste.Monique, mesurant 50 pieds du sud au nord sur 100 pieds de profondeur ou de l'est â l'ouest faisant partie du lot N° 28-12 rang 7 au cadastre officiel du canton Taillon, lequel terrain est borné: â l'est à la route régionale & l'ouest au lot 28-24 des mêmes rang et canton; au nord to west; forming part of lot number five-o (P.6-a) of east range one of the official cadaster of the township of Mésy and bounded northerly by the land of Armand Pelletier (Ruisseau â Face) easterly by the land of Adrien Emond; southerly by the land of Adrien Emond, that is, st some two hundred feet from the dividing line of east ranges one and two of said township; westerly, by Lac Vert, as staked out by the parties.Save and except all that part under cultivation, as determined by the parties, according to the pegs placed by the latter.Save and except also, all the lands sold and the rights granted according to registered deed.(8) The lot of land known and designated under number nineteen-a (19-a) of the official cadaster for range two of Signal township, containing a total of fifty-three acres of land.All of which with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Save and except, the lands sold and rights granted according to registered deed.(9) The lots of land known and designated under numbers nine-6, tcn-a, and ten-b (Nos.9-6, 10-a, 10-6) of the official cadaster for west range two of the township of Labnrro, containing a total of some one hundred and fifty-six acres of land.All of which with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Save and except the lands sold, and rights granted according to registered deeed.(10) a) Lots of land known and designated under numbers eighteen a and cighteen-6.(Nos.18-a and 18-6) of the official cadaster for range letter \"D\" of Signal township; 6) The southwesterly part of the westerly half of lots of land numbers seventeen-6 and seventeen-J^ e (P.S.W.of K) No.17-6 and 17-« of the cadaster lor range west of Kénogami Road, in the township of Labarre.c) The undivided half of lot number one (H No.1) of the cadaster of East rango three of the township of Mésy; savo and to be excluded from the said immoveables, that piece of land sold to the Roads Department, and the lands sold and rights granted according to registered deed.All of which with buildings erected on said immoveables, appartenances and dependencies.(11) A piece of land forming part of lot number twenty-one (P.21) of the official cadaster of range,\"A\" in the township of Mésy, measuring two hundred and fifty-eight feet (258') in width in the direction of the public highway or Regional Highway No.55, by ninety feot (90*) in depth known under the name of butte des épinettes\", bounded northerly by the said \"épinettes\", or the residue of the vendor's land, easterly by the gully or residue of the vendor's land, westerly by the bottom of the culvert gully and southerly by the former road or Regional Route No.55, prior to the repairing or widening thereof, of an area of some three quarters of an arpent, save to be excluded that part sold to the Department of Roads and the servitude grantod to tho Saguenay Power Company by deed No.42814.(12) Lot of land known and designated under, number ten (10) of the official cadaster of the township of Taillon in range three; savo to be excluded the servitude granted the Saguenay Power Company.(13) Lots of land known and designated on the official cadaster of the township of Taillon under numbers eleven and twelve of range five; save to be excluded the lands sold and rights granted according to registered title.P.north 12, rango 4 Taillon.The northerly part of lot of land known and designated under number twelve of four acres in area, on the official plan and book of reference for range four of said township of Taillon, bounded as follows: northerly by the \"trait carré\" of ranges four and five; easterly by lot number eleven; southerly by the public highway and westerly by lot number thirteen of said range and township; save to be excluded the lands sold and rights granted according to registered deed.(14) A pieoe of land forming part of lot 28-36 of a subdivision of lot number twenty-eight of range seven of the township of Taillon, at Ste.Monique, Lake St.John measuring, 33 feot in width to the north in an eastwesterly direction, by 60 feet of depth, bounded northerly by Avenue 28-4, easterly by lot 28-26-2: southerly and westerly by the residue of the lot of which the said land forms part with servitudes both active and passive, plus right-of-way on lot 28-4 (Avenue) to communicate with the public highway.Save to be excluded the servitude granted the Saguenay Power Company.(15) Lot of land known and designated on the official cadaster of the township of Taillon under number 14 range 6 of said township.Save and except the servitude granted to the Saguenay Power Company.(16) A piece of land or emplacement situate at Ste.Monique, measuring 50 feet from south to north by 100 feet of depth or from east to west forming part of lot No.28-12 range 7 of the official cadaster of the township of Taillon, which land is bounded: easterly by the Regional Route, westerly by lot 28-24 of the same range QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 2Ut, 1969, Vol.91, No.8 905 au lot 28-13 et au sud au chemin qui s'y trouve sur ne lot N° 28-12 étant une subdivision du lot originaire du lot numéro 28 dee mêmes rang et canton.Sauf à distraire la servitude concédée à la Compagnie Electrique du 8aguenay.(17) Un emplacement situé dans le village de St-Gédéon de la contenance d'environ vingt-cinq perches en superficie faisant partie du lot de terre connu et dêsi- 5né sous le N° 4-6 du cadastre pour le rang dix (10) u canton Signal, tel que clôturé de toutes parts, avec la maison, le hangar et étable dessus construits, circonstances et dépendances, borné comme suit: en front vers l'ouest au chemin public, en arrière vers l'est au terrain de Didyme Tremblay, représentant Joseph Fortin, joignant au nord l'emplacement de Jean-Baptiste Potvin, représentant de Wellie Doré et au sud l'emplacement de Evague Tremblay représentant Jules Bérubé.(18) Un emplacement sis et situé en la village de 8t-Géd6on dans le comté du Lac St-Jean, mesurant 55 pieds de largeur sur 160 pieds de profondeur plus ou moins, borné commo suit: au nord et à l'ouest à Adrien Lavoie, au sud â Herman Audet, à l'est au chemin publio, étant ledit emplacement la partie nord du lot de terre connu et désigné sous le numéro 7-6 du cadastre offioiel pour le dixième rang du canton Signal, avec les bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances.* (19) Un terrain ou emplacement situé au village de 8t-Gêdéon, mesurant environ 100 pieds de profondeur, faisant partie du lot de terre numéro 6-d du rang 10, au cadastre officiel du canton Signal, avec les bâtisses y érigées, lequel terrain est borné: en front â l'ouest au ohemin public, en arrière vers l'est et le sud-est â la ligne du chemin de fer Québec Se Lac St-Jean, joignant au sud au lot numéro 5-d, et au nord au reste du lot 6-d dont il fait partie.(20) a) Un terrain mesurant soixante-quinse pieds de tous les côtés, borné â l'est, â la route régionale; au sud au terrain vendu â Modeste Laforest et des autres côtés, au résidu du lot dont il fait partie et appartenant au vendeur, le tout faisant partie du lot de terre dix-sept 6, (Ptie 17-6) rang dix (10) canton Signal.6) Un terrain contigu au terrain ci-dessus, mesurant cent pieds de profondeur sur trente-cinq pieds de largeur; ot borné comme suit: â l'est, partie au terrain désigné au paragraphe A et partie â celui désigné au Paragraphe C; au sud, au terrain de Modeste Laforest; à ouest et au nord au terrain de Jean-Baptiste Boily, le tout faisant partie du lot dix-sept-6 (Ptie 17-6) du rang dix (10) canton Signal.c) Un terrain de soixante-quinze pieds de largeur sur vingt-cinq pieds de profondeur, borné au sud, au terrain désigné au paragraphe a; â l'ouest au terrain désigné au paragraphe 6; à l'est, â la route régionale; au nord, au terrain de Jean-Baptiste Boily, le tout faisant partie du lot dix-sept-6 (Ptie 17-6) du rang dix (10) du canton Signal.Sauf à distraire les droits concédés et le terrain vendu au Ministère de la Voirie par, acte N° 64598.(21) 1.La demi-est du lot de terre connu et désigné sous le numéro vingt-neuf du sixième rang aux plan et livre do renvoi officiels du cadastre du canton Signal ; sauf â distraire d'icelle demi-est l'emplacement de Alphonse Couture ou représentants, la demi-est étant borné comme suit: au nord au trait-carré du rang sept, au sud â celui du rang six, à l'ouest a la demi ouest du même lot, et à l'est à l'immeuble ci-après décrit, sans bâtisses.2.Le lot de terre connu et désigné sous le numéro vingt-huit-6 du sixièmo rang du cadastre officiel du canton Signal, avec les bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances; sauf à distraire cependant le chemin de Wilbrod Savard dont l'usage sera commun avec l'acquéreur; sauf à distraire si nécessaire les terrains et droits concédés suivant titre enregistré.(22) Les droits h un bail emphytéotique consenti par Dame Aquilas Lavoie à Joseph Robitaille sur un terrain de 60 pieds de front au chemin public, par 110 pieds de profondeur, faisant partie du lot maintenant connu et désigne au cadastre officiel du canton Signal sous le numéro 35, (ptie 35) du rang sept (7) et borné commo suit: en front, â l'ouest, au chemin public, au nord au torrain de M.Donald Gaudreault; au sud et â l'est, au reste du lot dont il fait partie, tel que le tout est décrit dans un acte de vente par Dame Aquilas Lavoie â le Granit National Limitée, en date du 5 octobre 1949, le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et sujet â toutes servitudes publiques et privée pouvant l'affecter.(23) Un terrain emplacement de soixante-quinse pieds de largeur par cent pieds de profondeur, le tout faisant partie du lot de terre connu et désigné sous le and township; northerly by lot 28-13 and southerly by the road on said lot No.28-12 being a subdivision of original lot of lot number 28 of the same range and township.Save to be excluded the servitude granted to the Saguenay Power Company.(17) An emplacement situated in the village of St.Gédéon containing some twenty-five rods in area forming part of lot of land known and designated under No.4-6.of the cadaster for range ten (10) of the Signal township, as fenced in on all sides, with house, hangar and stable theroon erected, circumstances and dependencies, bounded as follows: in front westerly by the Îublio highway, in the rear easterly by the land of >idymo Tremblay , representing Joseph Fortin, adjoining northerly the emplacement of Joan-Baptiste Potvin, representing Wellie Doré and southerly the emplacement of Evague Tremblay representing Jules Béxubé.(18) An emplacement bang and situated in the village of St.Gédéon in the county of Lake St.John, measuring 55 feet in width by 160 feat in depth more or less, bounded as follows: northerly and westerly by Adrien Lavoie, southerly by Herman Audet, easterly by the public highway, being the said emplacement, the northerly part of lot of land known and designated under number 7-6 of the official cadaster for rangs ten of tho township of Signal, with buildings thereon erected, appurtenances and dependencies.(19) A piece of land or emplacement situated in the village of St.Gédéon, measuring soms 101 feot in depth forming part of lot of land numbar 5-d of rame 10, of the official cadaster of tho township of Signal, with the buildings thereon erected, which land is bo ruled: in front westerly by the public highway, in the rear easterly and southeasterly by th9 Quebsc & Lake St.John Railway, adjoining southerly lot numb;r 5-d and northerly by the residue of lot 5-d of which it forms part.(20) a) A piece of land measuring saventy-five feet on all sides bounded easterly by the Roxional Route, southerly by the land sold to Modeste Laforest snd on tho other sides, by the residue of the lot forming part thereof and belonging to the vendor, all of which forming part of lot of land seventeen 6, (P.17-6) range ten (10) township of Signal.6) A piece of land adjacent to the land hereinabove, measuring one hundred feet in depth by thirty-five feet in width; and bounded as follows: easterly by part of the land designated in paragraph A and partly by that designated in paragraph C; southerly, by the land of Modeste Laforest ; westerly and northerly by the land of Je3n Baptiste Boily, all of which forming part of lot seventeen-6 (P.17-6) of range ten (10) township of Signal.c) A piece of land of seventy-five feet in width by twenty-five feet in depth, bounded southerly, by the land designated in paragraph a) ; westerly by the land designated in paragraph 6; easterly by, the Regional Route; northerly by tho land of Jean-Baptiste Boily, all of which forming part of lot seventeen-6 (P.17-6) of range ten (10).of the township ef Signal.Save to be excluded the rights granted and the land sold to the Department of Roads by deed No.64598.(21) 1.The easterly half of lot of land known and designated under number twenty-nine of range six on the official plan and book of reference of the cadaster of the township of Signal, save to be excluded therefrom the emplacement of Alphonse Couture or representatives, the easterly half being bounced as follows: northerly by the \"trait carré\" of range seven, so itherly by that of range six, westerly by the westerly half of same lot, and easterly by the immoveable hereinafter described, without buildings.2.Lot of land known and designated under number twenty-eight-d of range six of the official cadaster of the township of Signal, with the buildings thereon erected, appurtenances and dependencies; save to be excluded however, the road of Wilbrod Savard the use of which will be in common with tho buyer; save to be excluded if necessary the lands and rights granted according to registered deed.(22) The rights to an emphyteutic lease consented to by Dame Aquilas Lavoie to Joseph Robitaille on a lot of 60 feet in front on the public road, by 110 feet in depth, forming part of lot presently known and designated in the official cadaster for the township Signal, under number 35, (Pt.35) of range seven (7) and bounded as follows: In front, on the west, by the public road, on tho north, by the land of Mr.Donald Gaudreault; on the south, and on the east, by the remainder of lot of which it forms part, as the whole is described in a deed of sale by Dame Aquilas Lavoie to the \"Granit National Limitée , dated October 5, 1949, the whole with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and subject to all public and private servitudes by which it may be affected.(23) An emplacement lot of seventy-five feet in width by one hundred feet in depth, the whole forming part of lot of land known and designated under number 906 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, fil février 1969, Tomé 91, JV° 8 numéro sept-A aux plan et livre de renvoi officiels pour le rang Saguenay dans le canton Labarre, et compris dans les bornes suivantes: savoir: au nord et à l'est, au terrain du vendeur; à l'ouest à dix pieds au sud dudit terrain et & quatre pieds au nord de la ligne séparant le lot six du lot sept-A et au sud au chemin, sans bâti-m eut s; sauf â distraire les droits concédés suivant titre enregistré.seven-A on the official plan and in the book of reference for the Saguenay range in the Labarre township, and comprised within the following boundaries: to wit: on the north and on the east, by the land of the vendor; on the west, at ten feet south of the said land and at four feet north of the line dividing lot six from lot seven-A and at the south, by the road, without buildings; save to withdraw the rights conceded according to registered title.Donné à Saint-Jérôme, ce 31ième jour de .Given at Saint Jérôme, this thirty-first day of Janvier 1959.January 1959.Le Secrétaire-trésorier, LAURENT PLOURDE, 49818-6-2-0 LAURENT PLOURDE.49818-6-2 Secretary-Treasurer.Canada \u2014 Province de Québec Cité de Rouyn Avis public est par la présente donné par Roger Saint-Sauveur, secrétaire-trésorier de la cité de Rouyn, comté de Rouyn-Noranda, que les immeubles ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique, selon les dispositions de la Loi des Cités et Villes, au lieu ordinaire où le conseil municipal tient ses séances; soit la Salle de l'Hôtel de Ville de la cité de Rouyn, MERCREDI, le DIX-HUITIÈME jour de MARS 1959, à DEUX heures de l'après-midi, pour satisfaire aux taxes et redevances municipales, scolaires, église et autres, avec intérêts, mentionnées dans l'état ci-dessous, ainsi que les frais subséquents encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.Canada \u2014 Province of Quebec City of Rouyn Public notice is hereby given by Roger Saint-Sauveur, secretary-treasurer of the city of Rouyn, county of Rouyn-Noranda, that the properties herein after described will be sold by public auction in the sitting room of the council of-the said city of Rouyn, at the city of Rouyn, WEDNESDAY, the EIGHTEENTH day of MARCH, 1959, at TWO o'clock in the afternoon for the payment of taxes and municipal dues, school, church and other taxes with interests as mentionnée! in the herein under statiement, and costs which shall subsequently be incurred, unless said taxes, interests and costs shall- be paid before the said sale.Nom sur le rôle de perception Name on the assessment roll Morrissette, Marc.Plecan, Walter, et/and Prosowska, J.McLeod, J.D., et/and Aifier, Romano .Day, Thomas Joe .Nadon, Onésime .Hatfield, J.Bradford .Hatfield, J.Bradford .Ducharme, Patrick, et /ou \u2014and/or Vanasse, Salem .Grenier, Fernand .Leury, Albert.Giroux, Roméo Numéro de cadastre Cadastral number Une demi nord du lot 42, bloc 41 avec ensemble des bâtisses dessus construites et dépendances \u2014 One half north of lot 42, block 41, with the buildings thereon erected together with all rights, members and appurtenances.Partie ouest du lot 448, bloc 41, et partie ouest du lot 447, bloc 41 avec ensemble des bâtisses dessus construites et dépendances \u2014 Western part of lot 448, block 41, and western part of lot 447, block 41, with the buildings thereon erected together with all rights, members and appurtenances.Lot 78 bloc 8 (vacant) \u2014 Lot 78 block 8 (vacant).Lot 601 bloc 8 (vacant) \u2014 Lot 601 block 8 (vacant).Lot 66 bloc 201 (vacant) \u2014 Lot 66 block 201 (vacant).Lot 91.sub 146, bloc 201 (vacant) \u2014 Lot 91, sub 146, block 201 (vacant) Let 91, sub 147, bloc 201 (vacant) \u2014 Lot 91.sub 147.block 201.(vacant) Lot 93, sub 135.bloc 201 (vacant) \u2014 Lot 93, sub 135, block 201 (vacant) Partie du lot 95, sub 8 ouest, bloc 201, et partie ouest du lot'96, bloc 201 (vacant) \u2014 Part of lot 96, sub 8 west, block 201, and western part of lot 96, block 201 (vacant) Lot 67, bloc 125 (vacant) \u2014 Lot 67, block 125 (vacant).Lot 26, sub 13, du rang 6 nord, (vacant) \u2014 Lot 26, sub-13, range 6 north (vacant).Taxes munie.Munie, taxes 1,079.03 106.77 212.07 83.74 Taxes scol.School taxes 1,183.59 570.79\t374.43 279.26\t61.99 16.77\t13.99 219.39\t53.50 179.33\t35.40 179.33\t36.92 222.12\t67.37 26.01 138.64 13.00 Taxes église Church taxes 1,779.69 Frais Costs 100 00 75.00 55.00 40.00 50 00 50.00 50.00 50.00 45.00 55.00 40.00 Total 4,142.31 1 ,'020.22 396.25 70.76 322.89 264.73 266.25 339.49 177.78 406.31 136.74 Donné à Rouyn, ce neuvième jour de février Given at Rouyn, this ninth day of February 1959.1959.Le Secrétaire-trésorier, ROGER SAINT-SAUVEUR, 49915-8-2-o ROGER SAINT-SAUVEUR.49915-8-2-0 Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 21st, 1969, Vol.91, No.8 907 Action en séparation de biens Cour ' Supérieure, district de Rimouski, N° 22096.Dame Thérèse Brochu, épouse de Réal Levassent-, menuisier, de la ville de Mont-Joli, district de Rimouski, a institué une action en séparation de biens contre son mari.Rimouski, le 12 février 1959.Les Procureurs de la demanderesse, 49921-0 ASSELIN & ASSELIN.Avis divers Chambre du Conseil législatif Québec, 11 février 1969.Aujourd'hui, à cinq heures de l'après-midi, l'honorable lieutenant-gouverneur s'est rendu à la chambre du Conseil législatif au Paiais législatif.Les membres du Conseil législatif étant assemblés, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur d'y faire requéiir la présence de l'Assemblée législative et, cette chambre s'y étant rendue, le greffier de la couronne en chancellerie a lu les titres des bills à être sanctionnés comme suit: 15 Loi concernant l'École polytechnique et l'Ecole des hautes études commerciales de Montréal.¦22 Loi concernant les écoles professionnelles privées.26 Loi modifiant la Loi de l'instruction publi- que.27 Loi autorisant l'établissement d'une nou- velle école d'agriculture à Oka.31 Loi modifiant la Loi concernant la revision du Code Civil.33 Loi modifiant la Loi concernant la coloni- sation.34 Loi modifiant la Loi des services publics.36 Loi modifiant la Loi de la Régie provinciale de l'électricité.38 Loi modifiant la Loi des pensions.39 Loi concernant le budget municipal de la cité de Montréal.102 Loi concernant La corporation du canton de Portland et Les commissaires d'écoles pour la municipalité Notre-Dame de la Salette, dans le comté de Papineau; 109 Loi concernant Les commissaires d'écoles catholiques pour la municipalité de Mac-kayviile.110 Loi concernant les corporations municipales et scolaires de Beauceville, Beauceville-Est, Saint-François-Ouest et Saint-Fran-çpis-de-Beauce.Action for separation as to property Superior Court, district of Rimouski, No-22096.Dame Thérèse Brochu, wife of Real Levasseur, joiner, of the town of MontJoli-district of Rimouski, has instituted an action in separation as to property against her husband.Rimouski, February, 12th 1959.ASSELIN & ASSELIN, 49921 Attorneys for the plaintiff.Miscellaneous Notices Legislative Council Chamber Quebec, 11th of February, 1969.This day, at five o'clock in the afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor proceeded to the Legislative Council Chamber, in the Legislative Building.The members of the Legislative Council being assembled, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to command the attendance of the Legislative Assembly, and, that House being present the Clerk of the Crown in Chancery read the titles of the bills to be sanctioned as follows: 15 An Act respecting the École polytechnique -and the École des hautes études commerciales de Montréal.22 An Act respecting private vocational schools.26 An Act to amend the Education Act.27 An Act to authorize the establishment of a school of agriculture at Oka.31 An Act to amend the Act respecting the revision of the Civil Code.33 An Act to amend the Act respecting colo- nization.34 An Act to amend The Public Service Act.36 An Act to amend the Provincial Electricity Board Act.38 An Act to amend the Pension Act.39 An Act respecting the municipal budget of the city of Montreal.102 An Act respecting The corporation of the township of Portland and The school commissioners for the municipality of Notre-Dame de la Salette, in the county of Papineau.109 An Act respecting The Catholic school commissioners for the municipality of Mackay ville.110 An Act respecting the municipal and school corporations of Beauceville, Beauceville-Est, Saint-François-Ouest and Saint-Fran-çois-de-Beauce. 908 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 février 1969.Tomé 91, N* S 111 Loi concernant la succession de l'honorable Joseph Masson.115 Loi concernant La corporation du Milage de Price.120 Loi concernant La municipalité de la paroisse de Sainte-Marie, dans le comté de Beauce, et Les commissaiies d'écoles pour la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie, dans le comté de Beauce.122 Loi modifiant la charte de la cité de Saint-Jean.124 Loi constituant en corporation la ville de Gaspé et concernant Les écoles protestantes de la municipalité de Gaspé.125 Loi autorisant le Barreau de la province de Québec à admettre John Nemeth à I etude et à l'exercice de la profession d'avocat dans la province de Québec.126 Loi modifiant la charte de la ville de Saint- Félicien.128 Loi modifiant la charte de la cité de Drum- mond ville.129 Loi concernant la cité de la Pointc-aux- Trembles, Canadian International Paper Company et Hygradc Containers Limited.131 Loi concernant La corporation scolaire de Windsor.132 Loi modifiant la charte de la ville de Rich- r>.ond.140 Loi constituant en corporation la ville de Renaud.145 Loi modifiant la charte de la viile de Cour- ville.146 Loi modifiant la charte de la cité de Chicou- timi.147 Loi modifiant la chatte de la ville de Mont- magny.148 Loi modifiant la charte de la ville' de Sainte- Thérèse.149 Loi concernant La corporation municipale de Sainte-Thérèse-Ouest.151 Loi concernant l'adoption et le changement de nom de Peter Detlev Leichsenring.152 Loi concernant la cité de Saint-Hyacinthe.159 Loi concernant la ville de Chambly.161 Loi concernant la succession de Paul Emile Guilbeault.162 Loi concernant Les commissaires d'écoles.pour la municipalité de l'Ile Bizard, dans le comté de Jacques-Cartier.165 Loi concernant la charte de la ville Laval-des-Rapides.Ill An Act respecting the estate of the Honourable Joseph Masson.115 An Act respecting The corporation of the village of Price.120 An Act respecting The municipality of the gitish of Sainte-Marie, in the county of eauce, and The school commissioners for the municipality of the parish of Sainte-Maiie, in the county of Beauce.> 122 An Act to amend the charter of the city of St.John's.124 An Act to incorporate the town of Gaspé and respecting The Protestant schools of the municipality of Gaspé.125 An Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit John Nemeth to the study and practice of law in the Province of Quebec.126 An Act to amend the charter of the town, of Saint-Félicien.128 An Act to amend the charter of the city of Drummondville.129 An Act respecting the city of Point e-aux- Trembles, Canadian International Paper Company and Hygrade Containers Limited.131 An Act respecting The school corporation of Windsor.132 An Act to amend the charter of the town of Richmond.__ 140 An Act to incorporate the town of Renaud.145 Ad Act to amend the charter of the town of Courville.146 An Act to amend the charter of the city of Chicoutimi.147 An Act to amend the charter of the town of Montmagny.148 An Act to amend the charter of the town of Sainte-Thérèse.149 An Act respecting The municipal corpora- tion of Sainte-Thérèse-Ouest.151 An Act respecting the adoption and change of name of Peter Detlev Leichsenring.152 An Act respecting the city of Saint-Hyacin- the.159 An Act respecting the town of Chambly.161 An Act respecting the estate of Paul Emile Guilbeault.162 An Act respecting The school commissioners for the municipality of l'Ile Bizard, in the county of Jacques-Cartier.165 An Act respecting the charter of the town of Laval-des-Rapides. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 19B9, Vol.91, No.8 909 168 Loi concernant La commission des écoles catholiques de la cité de Dor val.170 Loi constituant en corporation La Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie de Québec.176 Loi concernant la ville de Saint-Eustache et La commission scolaire de Saint-Eustache.178 Loi concernant La corporation de la paroisse de Saint-Ambroise, dans le comté de Québec.179 Loi constituant en corporation Les Sœurs de Sainte-Marcelline.181 Loi modifiant la charte de la cité de Sher- brooke.182 Loi concernant l'acte de vente consenti par dame Ëmilienne Ouellette à Roland Liboi-ron.183 Loi concernant une propriété de Gérard D'Amour.185 Loi concernant Les commissaires d'écoles catholiques pour la municipalité de la cité de Longueuil.186 Loi concernant Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville d'Anjou, dans le comté de Laval.187 Loi concernant le testament de Charles Séraphin Rodier.192 Loi modifiant la charte de la ville de Roxbo- ID.197 Loi modifiant la charte de la cité de Saint-Lambert.199 Loi relative à The Laprairie Protestant Cemetery.200 Loi concernant la ville de Candiac, les corporations scolaires catholiques et protestantes de la ville de Candiac et Iroquois Glass Limited.202 Loi pour valider le titre de Dominion Steel and Coal Corporation, Limited sur certaines propriétés et pour valider certains accords faits par cette compagnie.204 Loi ratifiant, confirmant et validant cer- taines résolutions du conseil municipal de la cité de Beauharnois, et des commissaires d'écoles pour la municipalité de la cité de Beauharnois.205 Loi modifiant la charte de la ville des Sept- Res.209 Loi constituant en corporation la ville du Lac Delage.214 'Loi modifiant la charte de la cité de Shawinigan.216 Loi concernant Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville d'Amos, et les commissaires d'écoles pour les municipalités scolaires de Landrienne, de Delage et de Dollard.168 An Act respecting The Catholic school commission of the city of Dor val.170 An Act to incorporate the Quebec Mutual Life Assuiance Company.176 An Act respecting the town of Saint-Eustache and The school commission of Saint-Eustache.178 An Act respecting The corporation of the parish of Saint-Ambroise, in the county of Quebec.179 An Act to incorporate The Sisters of Sainte- Marcelline.181 An Act to amend the charter of the city of Sheibrooke.182 An Act respecting the deed of sale from Dame Emilienne Ouellette to Roland Liboiron.183 An Act respecting a property of Gérard D'Amour.185 An Act respecting The Catholic school com- missioners for the municipality of the city of Longueuil.186 An Act respecting The school commissioners for the municipality of the town of Anjou» in the county of Laval.187 An Act respecting the will of Charles Séraphin Rodier.192 An Act to amend the charter of the town of Roxboro.197 An Act to amend the charter of the city of Saint-Lambert.199 An Act respecting The Laprairie Protestant Cemetery.200 An Act respecting the town of Candiac, the Catholic and Protestant school corporations for the town of Candiac and Iroquois Glass Limited.202 An Act to validate the title of Dominion Steel and Coal Corporation, Limited to certain properties and to validate certain agreements made by it.204 An Act to ratify, confirm and validate certain resolutions of the municipal council of the city of Beauharnois, and of the school commissioners for the municipality of the city of Beauharnois.205 An Act to amend the charter of the town of Sept-Iles.209 An Act to incorporate the town of Lac Delage.214 An Act to amend the charter of the city of Shawinigan.216 An Act respecting The school commissioners for the municipality of the town of Amos and the school commissioners for the school municipalities of Landrienne, Delft-ge and Dollard.v. 910 GAZE TTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, il février 1969, Tome 91, N° 8 217 Loi concernant la ville de Gatineau et La commission scolaire catholique de Gatineau, Papincau.219 Loi modifiant la Loi concernant L'Association des médecins de langue française du Canada.224 Loi constituant en corporation Les Frères des Écoles Chrétiennes des Trois-Rivières.225 Loi concernant La corporation du village de Sayabec et Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Sayabec, dans le comté de Matapédia, ainsi que La corporation de - la paroisse de Sainte-Marie-de-Sayabec.232 Loi concernant La Compagnie des Ciments du Saint-Laurent, et la ville et Les commissaires d'écoles de Villeneuve.233 Loi modifiant la charte de la cité de Sorel et constituant un organisme pour promouvoir l'industrie dans la région de Sorel.234 Loi concernant La commission des écoles catholiques de Pointe-aux-Trembles.235 Loi concernant La paroisse de Notre-Dame- de-l'Ile-Perrot.236 Loi modifiant la charte de la cité de la Pointe-aux-Trembles.237 Loi autorisant le Collège des chirurgiens dentistes de la province de Québec à admettre dame Colette Perroux-Maranda au nombre de ses membies, après examen.238 Loi modifiant la Loi concernant l'instruction publique dans la cité de Rivière-du-Loup.239 Loi concernant l'instruction publique dans la cité de Sherbrooke.240 Loi modifiant la charte de la ville de Fort Chambly.244 Loi modifiant la charte de la cité de Saint-Martin.249 Loi modifiant la charte de la cité de Salaber- ry-de-Valleyfield.250 Loi modifiant la charte de la ville de Green- field Park.251 Loi concernant La Cie de Films Trans- atlantique Inc.252 Loi concernant Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la cité de Drum-mondville, dans le comté de Drummond.253 Loi concernant la Communauté Helleno- Canadienne.254 Loi concernant certaines corporations sco- laires des comtés de Chicoutimi, Jonquière-Kénogami et La commission des écoles catholiques de Chicoutimi.256 Loi autorisant le Barreau de la province de Québec à admettre Traian Constantin à l'exercice de la profession d'avocat dans la province de Québec.217 An Act respecting the town of Gatineau and The Catholic school commission of Gatineau, Papineau.219 An Act to amend the Act concerning the Association des médecins de langue française du Canada.224 An Act to incoiporate Les Frères des Écoles Chrétiennes des Trois-Ri viè.-es.225 An Act respecting The corporation of thé village of Sayabec and The school commissioners for the municipality of Sayabec, in the county of Matapédia.as well as The corporation of the parish of Sainte-Marie-de-Sayabec.232 An Act respecting St-Lawrence Cement Company arid the town and The school commissioners of Villeneuve.233 An Act to amend the charter of the city of Sorel and to establish a body to promote industry in the region of Sorel.234 An Act respecting* The Catholic school commission of Pointe-aux-Trembles.235 An Act respecting The parish of Notre- Dame-de-1'He-Perrot.236 An Act to amend the charter of the city of Pointe-aux-Trembles.237 An Act to authorize the College of Dental Surgeons of the Province of Quebec to admit Dame Colette Perroux-Maranda among its members, sifter examination.238 An Act to amend the Act respecting educa- tion in the city of Rivière-du-Loup.239 An Act respecting education in the city of Sherbrooke.240 An Act-to amend the charter of the town of Fort Chambly.244 An Act to amend the charter of the city of Saint-Martin.249 An Act to amend the charter of the city of Salaberry-de-Valleyfield.250 An Act to amend the charter of the town of Greenfield Park.251 An Act respecting Transatlantic Films Co.Inc.252 An Act respecting The school commissioners for the municipality of the city of Drum-mondville, in the county of Drummond.253 An Act respecting the Hellenic-Canadian Community.254 An Act respecting certain school corporations of the counties of Chicoutimi, Jonquière-Kénogami and The Catholic school commission of Chicoutimi.256 An Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit Traian Constantin to the practice of the legal profession in the Province of Quebec. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February S 1st, 1969, Vol.91, No.S' 911 265 Loi concernant la ville de Waterloo.265 An Act respecting the town of Waterloo.267 Loi relative au titre de propriété de Wilfrid 267 An Act respecting the title of ownership of Simoneau aux lots 163-691 et 163-739 du Wilfrid Simoneau to lots 163-691 and cadastre officiel de La paroisse du Sault- 163-739 of the official cadastre for the au-Récollet.parish of Sault-au-Récollet.268 Loi modifiant la charte de la cité de Verdun.268 An Act to amend the charter of the city of Verdun.269 Loi modifiant la charte de la ville de L'Abord- 269 An Act to amend the charter of the town of à-PIouffe.L'Abord-à-Plouffe.273 Loi concernant la succession de l'honorable 273 An Act respecting the estate of the Honour-Georges filie Amyot.able Georges Élie Amyot.' 275 Loi autorisant le Collège des chirurgiens 275 An Act to authorize the College of Dental dentistes de la province de Québec à Surgeons of the Province of Quebec to admettre Robert Archambault au nombre admit R obéit Archambault among its de ses membres.members.276 Loi modifiant la charte de La Communauté des Soeurs de Charité de la Providence.276 An Act to amend the charter of La Commu-nauté des Soeurs de Charité de la Providence.278 Loi concernant Les commissaires d'écoles 278 An Act respecting The school commissioners pour la municipalité de Saint-Théophile, for the municipality of Saint-Théophile, dans le comté de Laval.in the county of Laval.279 Loi concernant Les commissaires d'écoles 279 An Act respecting The school commissioners pour la municipalité de Saint-Charles, dans for the municipality of Saint-Charles, ilk le comté de Saint-Sauveur.the county of Saint-Sauveur.La sanction royale est prononcée sur ces bills par le greffier du Conseil législatif, comme suit: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.\" 25 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1959, et pour d'autres fins.42 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour 1 année financière se terminant le 31 mars 1959, et pour d'autres fins.To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Legislative Council in the following words: '» \"In Her Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor assents to these bids.\" 25 An Act granting «to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the financial year ending on the 31st of March, 1959, and for other purposes.\u2022 '\u2022\u2022 >-.\\ \\ 42 An Act granting to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the financial year ending on the 31st of March, 1959, and for other purposes.A ces bills, la sanction royale a été donnée To these bills the Royal assent was signified dans les termes suivants: in the following words: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieute- \"In Her Majesty's name thé Honourable the nant-gouverneur remercie ses fidèles sujets, Lieutenant-Governor thanks her loyal subjects, agrée leur benevolence et sanctionne ces bills.\" accepts their benevolence and assents to these bills.\" : ., 49919-o 49919-o .\u2022 «\u2022 :.«* 258 Loi concernant la succession de feu J.258 An Act respecting the.estate of the late J.Timothy Donohue.Timothy Donohue.259 Loi concernant La commission des écoles 259 An Act respecting The Catholic school com- catholiques de Mont-Royal.mission of Mount Royal.2G1 Loi concernant Les commissaires d'écoles 261 An Act respecting The school commissioners pour la municipalité du village de Rawdon.for the municipality of.the village of Rawdon.263 Loi légalisant un acte entre BP Canada 263 An Act to legalize a certain deed between Limited et la cité de Montréal, ainsi que le BP Canada Limited and the city of Mont-règlement numéro 2,450 de la cité de real, and by-law number 2,450 of the city Montréal.of Montreal.264 Loi modifiant la chaite de la cité de Granby.264 An Act to amend the charter of the city off Granby. 91S OAZSTTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1959, Tome 91, N° 8 Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a, le quatorze janvier 1959, émis un certificat constituant en corporation la \"Société Saint-Jean-Baptiste Locale de Ste-Catherine de Sienne\", dont le siège social est situé dans la paroisse de Sainte-Catherine-de-Sienne, de Trois-Rivières, dans le district judiciaire des Trois-Rivièrés, et, ce, conformément aux dispositions des articles 15 et suivant de la Loi concernant la Société Saint-Jean-Baptiste de la région des Trois-Rivières, 3-4 Elizabeth II, chapitre 161.Donné au bureau du Secrétaire de la province, fe dix-neuf janvier 1959.Le Sous-secrétaire de la province, 49917-o JEAN BRUCHÊSI.(P.G.8298-48) .The Priort School Inc.i Extrait des minutes d'une assemblée du bureau de direction de \"The Priory School Inc.\", tenue à Montréal, b 16e jour de janvier 1959, conver-nant une augmentation du nombre des directeurs de cinq à neuf.i .Sur proposition dûment faite et secondée, il a été résolu à l'unanimité, que l'article XXII des règlements soit décrété comme suit: î Que l'article IV des règlements soit et il est, par les présentes, de plus amendé de manière que dorénavant, la première phrase se lise \"Le bureau de direction par lequel le commerce et les affaires de la corporation sont administrés, sera composé de neuf membres.\" ; Je, le soussigné, secrétaire-trésorier de \"The Priory School Inc.\", certifie, par les présentes, que les précédents articles des règlements ont été décrétés à une assemblée des directeurs tenue le 16 janvier 1959, et ratifiés et confirmés à une assemblée générale spéciale des membres tenue le 19 janvier 1959.Montréal, Québec, ce 2e jour de février 1959.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 49922 DAVID E.HOWLEY.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de St-Théophile de Laval\", en date du 8 février 1959, dont le siège social est situé à Laval-Ouest, district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le douze février 1959.Le Sous-secrétaire de la province, 49923-0 JEAN BRUCHESI.(P.G.14117-58) Patrician Investment Corp.\u2022 Règlement N° 2K Un règlement pour diminuer le nombre de directeurs de 4 à 3.\" ' Qu'il soit décrété comme le règlement N° 24 de \"Patrician Investment Corp.\".1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de quatre à trois.2.Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendés pour se conformer au précédent.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary, has, on January fourteenth, 1959, issued a certificat incorporating the \"Société Saint-Jean-Baptiste Locale de Ste-Catherine de Sienne\", whose head office is situated in the parish of Sainte-Catherine-de-Sienne, of Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières and such pursuant to the provisions of section 15 and following of the law concerning the \"Société Saint-Jean-Baptiste\" for the region of Trois-Rivières, 3-4 Elizabeth n, chapter 161.Given at the office of the Provincial Secretary, on January nineteenth, 1959.JEAN BRUCHÊSI, 49917 Under Secretary of the Province.(A.G.8298-48) The Priory School Inc.Extract from the minutes of a meeting of the board of directors of the \"Priory School Inc.\" held at Montreal on the 16th day of January 1959, concerning an increase in the number of directors from five to nine.On motion duly made and seconded it was unanimously resolved that article XXII of the By-laws be enacted as follows: That article IV of the By-laws be and it is hereby further amended so that henceforth the first sentence shall read \"The Board of Directors by whom the business and affairs of the corporation shall be managed shall consist of nine members\".I, the undersigned, Secretary-Treasurer of \"The Priory Shcool Inc.\", hereby certify that the foregoing Articles of the By-laws were enacted at a meeting of the directors held on 16th January, 1959, and ratified and confirmed at a special general meeting of the members held on 19th January 1959.Montreal, Quebec, this 2nd day of February, 1959.(Seal) DAVID E.HOWLEY, 49922-o Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de St-Théophile de Laval\", under date of February 8, 1959, whereof the head office is at Laval-West, judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twelfth day of February, 1959.JEAN BRUCHÊSI.49923 Under Secretary of the Province.(A.G.14117-58) Patrician Investment Corp.By-Law No.2k A by-law to decrease the number of directors ffom 4 to 3.Be it enacted as By-law No.24 of \"Patrician Investment Corp.\".1.That the number of directors of the company be and the same is hereby decreased from four to three.2.That the By-laws of the company be and the same are hereby amended to agree with the foregoing. r?.-'- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Met, 1959, Vol.91, No.8 913 Décrété ce 28 janvier 1959.Copie véritable certifiée du règlement N° 24, de \"Patrician Investment Corp.\" adopté à l'una-mité par les directeurs le 28 janvier 1959, et approuvé à l'unanimité par les actionnaires à une assemblée générale spéciale tenue le 28 janvier 1959.Patrician Investment Corp., (Sceau) Le Secrétaire, 49924 MANUEL SACHS.(P.G.14104-58) Patriot Investment Corp.Règlement N° 2k Un règlement pour directeurs de 4 à 3.diminuer le nombre de Qu'il soit décrété comme le règlement N° 24 de \"Patriot Investment Corp.\".Ie Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de quatre à trois.2° Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendés pour se conformer au précédent.Décrété ce 28 janvier 1959.Copie véritable certifiée du règlement N° 24, de \"Patriot Investment Corp.\", adopté à l'unanimité par les directeurs le 28 janvier 1959, et approuvé à l'unanimité par les actionnaires à une assemblée générale spéciale tenue le 28 janvier 1859.Patriot Investment Corp., (Sceau) Le Secrétaire, 49925 MANUEL SACHS.(P.G.13777-58) Epic Investment Corp.Enacted January 28th, 1959.Certified true copy of By-law No.24 of \"Patrician Investment Corp.\", adopted unanimouly by the-directors on January 28th, 1959, and approved unanimously by the shareholders at a special general meeting held January 28th, 1959.Patrician Investment Corp., (Seal) MANUEL SACHS, 49924-o Secretary.(A.G.14104-58) Patriot Investment Corp.By-law No.i\\ A by-law to decrease the number of directors from 4 to 3.Be it enacted as by-law No.24 of \"Patriot Investment Corp.\".1.That the number of directors of the company be and the same is hereby decreased from four to three.2.That the by-laws of the company be and the same are hereby amended to agree with the foregoing.Enacted January 28th, 1959.Certified true copy of by-law No.24 of \"Patriot Investment Corp.\", adopted unanimously by the directors of January 28th, 1959, and approved unanimously by the shareholders at a special general meeting held January 28th, 1959.Patriot Investment Corp., (Seal) MANUEL SACHS, 49925-o Secretary.(A.G.13777-58) Epic Investment Corp.Règlement N° 24 By-law No.£4 Un règlement pour diminué le nombre de direc- A by-law to decrease the number of directors teurs de 4 à 3.from 4 to 3.Qu'il soit décrété comme le règlement N° 24 de \"Epic Investment Corp.\".Ie Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de quatre à trois.2° Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendés pour se conformer au précédent.Décrété ce 28 janvier 1959.Copie véritable certifiée du règlement N° 24, de \"Epic Investment Corp.\", adopté à l'unanimité par les directeurs le 28 janvier 1959, et approuvé à l'unanimité par les actionnaires à une assemblée générale spéciale tenue le 28 Janvier 1959.Epic Investment Corp., (Sceau) Le Secrétaire, 49926 MANUEL SACHS.(P.G.10328-59) La Compagnie de Transport de Levis (Levis Transport Company) Be it enacted as by-law No.24 of \"Epic Investment Corp.\".1.That the number of directois of the company he and the same is hereby decreased from four to three.2.That .the by-laws of the company be and the same are hereby amended to agree with the foregoing.Enacted January 28th, 1959.Certified true copy ol by-law No.24 of \"Epic Investment Corp.\", adopted unanimously by the directors on January 28th, 1959, and approved unanimously by the shareholders at a special general meeting held January 28th, 1959.Epic Investment Corp., (Seal) MANUEL SACHS, 4992C-o Secretary.: (A.G.10328-69) La Compagnie de Transport de Levis (Levis Transport Company) Extrait du procès-verbal d'une assemblée Excerpt from the minutes of a meeting of the du bureau de direction de La Compagnie de board of directois of the \"Compagnie de Trans-Transport de Levis (Levis Transport Company) port de Levis\" (Levis Transport Compam) held tenue à Québec, le 31 décembre 1958 à 10.00 a.m.at Quebec on December 31, 1958, at 10.00 a.m.\"Règlement N° 19 diminuant le nombre des directeurs de 5 à 3.\"By-law No.19 deci easing the number of directors from 5 to 3.Qu'il soit et il est par les présentes décrété That it be and it is hereby enacted as by-law comme règlement N° 19 de la Compagnie de No.19 of the \"Compagnie de Transport de Lévis\" 914 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 février 1959, Tome 91, N° 8 Transport de Lévis (Lévis Transport Company) ce qui suit: 1 Le nombre des directeurs de la Compagnie est, par les présentes, diminué de 5 à 3; 2 Le quorum aux assemblées du bureau de direction sera de 2; - 3* Le secrétaire de la Compagnie M.Claude Rioux, reçoit instructions de prendre les mesures requises pour assurer le dépôt du présent règlement auprès du Procureur Général et sa publication 'dans la Gazette officielle de Québec, le tout conformément à l'article 176 de la Loi des Compagnies de Québec\".Adopté par les directeurs ce 31ième jour de décembre 1058.Confirmé unanimement par les actionnaires ce SOième jour de janvier 1050.Certifiée vraie copie d'un règlement de la Cmpagnie ci-haut adopté aux date et lieu plus ut mentionnés, à l'unanimité des votes des directeurs et des actionnaires aux assemblées desquelles il y avait quorum.Le Secrétaire, 49927-0 CLAUDE RIOUX.\u2022\u2022 ' AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de *1îAssociation des Détaillants d'Alma Inc.\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques; sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province.ledouzé février 1959.Le siège social'du syndicat professionnel précité est situé à Aima, district judiciaire de Roberval.Le Sous-secrétaire de la Provirce, 49940-o JEAN BRUCHÊSI.i Chartes \u2014 Abandon de (Levis Transport Company) the following : 1.The number of the directors of the Company is, by these presents, decreased from 5 to 3; 2.The quorum at the meeting of the board of directors shall be of 2; 3.The Secretary of the Company, Mr.Claude Rioux, receives instructions to take the necessary measures to assure the deposit of the present bylaw to the Attorney General and or it publication in the Quebec Official Gazette, the whole in conformity with section 176 of the Quebec Companies' Act\".Adopted by the directors this 31st day of December, 1958.Unanimously confirmed by the shareholders, this ïOth day of January, 1959.Certified tiue copy of a by-law of the company above adopted on the date and place above mentioned, by the unanimity of votes by the Directors and shareholders at the meeting at which there was quorum.CLAUDE RIOUX, 49927 Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association des Détaillants d'Alma Inc.\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on February twelfth, 1959.The prircipal place of business of the said professional syndicate is at Alma, judicial district of Roberval.JEAN BRUCHÊSI, 49940 Under Secretary of the Province.Charters \u2014 Surrender of Avis est par les présentes donné qre \"Aero Mining Corporation\" (No Personal Liability), présentera une requête à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur de la provirce de Québec, pour demander l'annulation de sa charte.\u2022 Daté à Montréal, ce Sème jour de février 1959.Le Secrétaire, 49900-o I.A.MORGULIS.Pi m a Mines Limited (No Personal.Liability) Avis est, par les présentes donné que \"Pima Mines Limited\", une corporation constituée en vertu de la Loi des cempagnies minières de Québec,'et ayant son siège sccial en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec.Daté ce lOièmé jour de février 1959.Le Secrétaire, 49914 J.E.MASTEN.Avis est donné conformément à la Loi des Compagnies de Québec, que la compagnie \"Mmes Salim Jarjour & Alp.Dion Ltée\", demandera la permission d'abandonner sa charte.Québec, le vingt-neuf août mil neuf cent cinquante-huit.Le Secrétaire, 40941-O .GASTON DOLBEC.Notice is hereby given that \"Aero Mining Corporation\" (No Personal Liability), will make an application to the Honourable the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 5th day of February, 1959.I.A.MORGULIS, 49900-o Secretary.Pima Mixes Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that \"Pima Mines Limited\", a corporation constituted under the Quebec Mining Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act.Dated this 10th day of February, 1959.J.E.MASTEN, 49914-o Secretory.Notice is given in accordance with the Quebec Companies' Act, that the company \"Mmes Salim Jarjour & Alp.Dion Ltée\", will apply for leave to surrender its charter.Quebec, the twenty-ninth day of August, one thousand nine hundred and fifty-eight.GASTON DOLBEC, 49941 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February Hat, 1959, Vol.91, No.8 915 Curatelle publique Canada \u2014 Province de Québec District d'Abitibi Succession vacante d'Ovila Picard, en son vivant de St-Bruno, Rapides Danseurs.Le soussigné donne avis que cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 17 décembre 1958 par un juge de la cour supérieure siégeant À Amos dans le district d'Abi.ibi, que, sous l'autorité de la loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.62), il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.LE CURATEUR PUBLIC, 187, rue Sainte-Catherine (Ouest), 49928-o Montréal 18.Département de l'Agriculture Industrie laitière Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec Ordonnance N° 4-57B (Région de Sherbrooke) Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mercredi, le 18 février 1959, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Montréal, à 10 heures du matin.Présents: MM.Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert, J.-Albert Chartrand, Stanislas Panneton, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire, et Charles-A.Gamache, c.r., conseiller juridique.La Commission décrète ce qui suit: 1* L'article 2 de l'ordonnance N° 4-57, tel qu'édicté par l'ordonnance N° 4-57A, est remplacé par le suivant: \"2.\u2022 La région de Sherbrooke comprend la cité de Sherbrooke; les villes de Bromptonville, Lennoxville et Windsor; les villages de Deauville, North Hatley, Waterville et Ayer's Cliff; la Ïtaioisse de St-François-Xavier-de-Brompton et s municipalité de Rock Forest.\" 2° L'article 4 de l'ordonnance N° 4-57 est remplacé par le suivant: \"4.Toutefois il est loisible au marchand de lait de convenir avec ses producteurs-fournisseurs, par contrat écrit approuvé par la Commission, d'un prix minimum pour le lait utilisé à d'autres fins que la consommation en nature.Ce marchand de lait devra payer à ses producteurs-fournisseurs, au prix fixé par l'article 3 de la présente ordonnance, le lait utilisé pour fins de consommation en nature plus une quantité équivalant à au moins 2% du lait ainsi utilisé, et au prix déterminé dans le contrat dûment approuvé par la Commission, le reste du lait reçu.Tel marchand de lait devra faire parvenir à la Commission de l'Industrie Laitière, le ou avant le 15 de chaque mois, un rapport en la forme établie par la Commission, indiquant pour le mois précédent: Public Curatorship Canada \u2014 Province of Quebec District of Abitibi Vacant estate of Ovila Picard, in his lifetime of Saint-Bruno, Rapides Danseurs.The undersigned gives notice that the said estate has been declared vacant in virtue of a judgment rendered on December 17, 1958, by a judge of the Superior Court sitting at Amos, in the district of Abitibi, that he is, under the authority of the Public Curatorship Act (9 Geo.VI ch.62), curator ex-officio to the said estate, and that he will receive, at the address given below, the payment of all debts owing to the said estate and proof of all claims against it.PUBLIC CURATOR, 187, Sainte Catherine Street (West), 49928 Montreal 18.Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission of the Province op Quebec Order No.4-67B (Region of Sherbrooke) Excerpt from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Wednesday, February 18th, 4959, held in the office of the Dairy Industry Commission in Montreal at 10 o'clock in the morning.Present: Messrs.Omer-E.Milot President, Joseph Hébert, J.-Albert Chartrand, Stanislas Panneton, Commissioners, Alphonse Savoie, Secretary, and Charles-A.Gamache, Q.C., Legal Adviser.It is enacted as follows: 1.Article 2 of Order No.4-57, as enacted in Order No.4-57A, is replaced by the following: \"2.The region of Sherbrooke includes the city of Sherbrooke; the towns of Bromptonville, Lennoxville ,and Windsor; the villages of Deauville, North \"Hatley, Waterville and Ayer's Cliff; the parish of St.François Xavier de Brompton and the municipality of Rock Forest.\" 2.Article 4 of Order No.4-57 is replaced by the following: \"4.Yet, the milk dealer may agree with his Eroducer-suppliers, by written contract approved y the Commission, as to a minimum price for milk used for other purposes than fluid milk consumption.This milk dealer shall pay to his producer-suppliers, at the price fixed in article 3 of the present Order, the milk used for consumption in its natural state plus a quantity equal to at least 2% of the milk thus used, and at the price established by contract duly approved by the Commission, the balance of the milk received.i* This milk dealer shall supply the Dairy Industry Commission on or prior to the 15th of each month,, with a report in the form as prescribed by the said Commission, showing for the preceeding month: ^ 016 .GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, tl février 1969, Tome 91, N° 8 a) la quantité totale du lait reçu; b) la quantité du lait utilisé pour fins de consommation en nature\"; c) la quantité du lait utilisé pour autres fins; d) la quantité du lait payé au prix fixé par l'article 3; e) le prix payé pour le lait utilisé à d'autres fins que la consommation en nature\".3 La présente ordonnance annule l'ordonnance N° 4-57A et entrera en vigueur le 1er mars 1959.Le secrétaire de ladite Commission est chargé de la publication de la présente ordonnance dans la Gazette officielle de Québec.Signé: Certifié: 49948-0 Omer-E.M îlot, président, Joseph Hébert, commissaire, J.-A.Chartrand, commissaire, Stanislas Panneton, commissaire, Alphonse Savoie, set rétaire.a) total quantity of milk received; b) quantity of milk used for consumption in its natural state; e) quantity of milk used for other purposes; ( d) quantity of mjlk paid for at the price mentioned by section 3; e) price paid for milk used for other purposes than fluid milk consumption.3.The present Order cancels Order No.4-57A and shall come into force on March 1st, 1959.The Secretary of said Commission is charged with the publication of the present Order in the Quebec Official Gazette.Signed; Omer-E.Mi lot, President, Joseph Hébert, Commissioner, J.-A.Chartrand, Commissioner, Stanislas Panneton, Commissioner.Certified: Alphonse Savoie, Secretary.49948-o Département de l'Instruction Publique Department of Education N° 121-59.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Fabreville, dans le comté de Laval, les lets 262, 278, la partie nord du lot 288 limitée à la ligne sud du let 279, les lots 289, 291 et 292, tous du cadastre officie! de la paroisse de Ste-Rcsc, pour les annexer à la municipalité scolaire de la ville de Ste-Rose, même comté.Québec, le 17 février 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 49936-8-2-o O.J.DÊSAULNIERS.N° 1143-56.Demande est faite d'annexer à la municipalité scolaire de St-Félix-de-Valcis, dans le comté de Joliette, le territoire actuel de la municipalité scolaire de la paroisse de St-Félix-de-Valois, même comté.Québec, le 16 février 1959.Le Surintendant de l'Instruction publique, 49937-8-2-0 O.J.DÊSAULNIERS.¦ i Département des Terres et Forêts No.121-59.Application is made to detach from the School Municipality of Fabreville, in the county of Laval, lots 262, 278, the northerly part of lot 288 bounded by the southerly line of lot 279, lots 289, 291 and 292, all of the official cadaster of the parish of Ste.Rose, in order to annex them to the School Municipality-of the town of Ste.Rose, same county.Quebec, February 17, 1959.O.J.DÊSAULNIERS, 49936-8-2 Superintendent of Education.No.1143-56.Application is made to annex to the School Municipality of St.Félix-de-Valois, in the county of Joliette, the present territory of the School Municipality of the parish of St.Félix-dc-Valois, same county.Quebec, February 16, 1959.O.J.DÊSAULNHîRS, 49937-8-2 Superintendent of Education.Department of Lands and Forest AVIS Cadastre officiel de la paroisse du Sault-au-Récollet (municipalité de ville de Montréal-Nord) division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 20-190 à 20-297, 20-304 à 20-331 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 6 février 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 49899-o AVILA BÊDARD.Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Famille de Boucherville division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné que les lots NOTICE Officiai cadastre of the parish of Sault-au-Récollet (municipality of town of Montreal-North) registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 20-190 to 20-297, 20-304 to 20-331 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, February 6, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVDLA BÊDARD, 49899-o Deputy Minister.Official cadastre of the parish of Ste-Famille de Boucherville registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots 173-71, 173-72 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February girt, 1969, Vol.91, No.8 917 173-71, 173-72 et 173-73 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 6 février 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 49899-0 AVILA BÊDARD.Cadastre officiel de la paroisse de Ste-M arguer i te, canton de Wexford division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné que les lots 23 et 24, rang m sont annulés, les lots 21, 22 et 25, rang m sont corrigés; les lots 23-A, 23-B, 24-A, 24-B rang III et les lots 1 à 76 du rang A sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 6 février 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 49899-0 AVILA BÊDARD.Cadastre officiel de la paroisse de St-Clcment (municipalité de cité de Beauharnois) division d'enregistrement de Beauharnois.Avis est par la présente donné que le lot 145-1 est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 4 février 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Soi's-miristre, 49899-o AVILA BÊDARD.Cadastre officiel de la paroisse de St-Martin (municipalité de la ville de Pont-Viau) division d'enregistrement de Laval.Avis est par la présente donné que le lot 328-3-3 est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 6 février 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 49899-o AVILA BÊDARD.Cadastre officiel de la paroisse de St-Vincent de Paul (municipalité de ville de Duvernay), division d'enregistrement de Laval.Avis est par la présente donné que les lots 65-2-6 à 65-2-10 sont annulés en vertu de l'article 2174 A du Code civil.Québec, le 5 février 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 49899-0 AVILA BÊDARD.Cadastre officiel du canton de Labelle (municipalité de canton de Joly), division d'enregistrement de Labelle Avis est par la présente donné que les lots 38, 39, 40 et 41 du rang C sont corrigés et les lots 1 à 30 du rang F sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 23 janvier 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 49899-0 AVILA BÊDARD.and 173-73 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, February 6, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVDLA BÊDARD, 49899-o Deputy Minister.Official cadastre of the parish of Ste.Marguerite, township of Wexford registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that lots 23 and 24, range III are cancelled, lots 21, 22 and 25V range III are corrected; lots 23-A, 23-B, 24-A, 24-B ronge UI lots 1 to 76, range A are added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, February 6, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 49899-o Deputy Minister.Official cadastre of the parish of St-Clement (municipality of city of Beauharnois) registration division of Beauharnois.Notice is hereby given that lot 145-1 has been cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, February 4, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, A VILA BÊDARD, 49899-0 Deputy Minister.Official cadastre of the parish of St-Martin (municipality of town of Pont-Viau) registration division of Laval.Notice is hereby given that lot 328-3-3 has been cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, February 6,1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 49899-o Deputy Minister.Official cadastre of the parish of St-Vincent de Paul (municipality of town of Duvernay) Registration division of Laval.Notice is hereby given that lots 65-2-6 to 65-2-10 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, February 5, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVIXA BÊDARD, 4)899-o Deputy Minister.Official cadastre of township of Labelle (Municipality of township of Joly), registration division of Labelle Notice is hereby given that lots 38, 39, 40 and 41, range C are corrected and lots 1 to 30, range F are added in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, January 23, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 49899-o Deputy-Minister. 918 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, £1 février 1959, Tome 91;N° 8 Cadastre officiel du canton de Labelle (Municipalité de canton de Joly), division d'enregistrement de Labelle Avis est par la présente donné que les lots 38-B et 44-A sont annulés; les lots 36-B, 37-B, 39-A, 39-B, 40-A*40-B, 41-A, 41-B, 42-A, 42-B, 43-A, 43-B, 44-B, 45 et 46 sont corrigés; les lots 1 à 33, 34-A, 34-B, 35 à 46 du rang D et les lots 1 à 80 rang £ sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 23 janvier 1959.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 49899-0 AVILA BÊDARD.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION Conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendments), le Ministre du Travail donne avis par les présentes qu'il a l'intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil la modification suivante au décret numéro 988 du 2 octobre 1958, relatif à l'industrie de la construction dans les comtés de Drum-mond, Arthabaska et Nicolet: Le paragraphe \"d\" suivant sera ajouté à l'article XIII: \"d) De plus, les salaries permanents préposés à l'entretien des institutions d'assistance publique, hôpitaux et hospices ne sont pas assujettis au décret.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel, peut rendre obligatoires ses dispositions, avec ou sans amendements.L'Arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 21 février 1959.49944-o Ministère des Finances Assurances Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné, par les présentes, que \"Peerless Insurance Company\" enregistrée sous le numéro 612, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1440 qui l'autorise, à compter du 8 mai 1958, à effectuer dans la province des contrats d'assurance relatifs aux genres suivants: Incendie et accessoirement, agitation civile, choc de véhicules, chute d'aéronef, défectuosité d'extincteurs automatiques, fuite d'eau, grêle, intempéries, ouragan, tremblement de terre; Accident; Automobile; Biens immobiliers; Biens mobiliers; Officiai cadastre of township of Labelle (Municipality of township of Joly), registration division of Labelle Notice is hereby given that lots 38-B and 44-A are cancelled; lots 36-B, 37-B, S9-A, 39-B, 40-A, 40-B, 41-A, 41-B, 42-A, 42-B, 43-A, 43-B, 44-B, 45 and 46 are corrected; Lots 1 to 33, 34-A, 34-B, 35 to 46, range D and lots 1 to 80, range E are added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, January 23, 1959.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÊDARD, 49899-0 Deputy-Minister.Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT Pursuant to the procedure provided in section 8 of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour hereby gives notice that he intends to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the decree number 988 of October 2, 1958, relating to the construction industry in the counties of Drummond, Arthabaska and Nicolet: The following paragraph \"n front on the national highway, Quebec-Montreal, along a depth of one hundred and fifty feet (150') English measure, forming part of lot number ninety-nine ^ (pt.of 99) on the official cadaster for the parish of Cap Santé, county of Portneuf, and bounded as follows: on the north, by Dame Alfred Piché, on the south, by the national highway, Quebec-Montreal, on the west, by the immoveable above described, and on the east, by Dame Alfred Piché\".Subject to the servitudes which may exist in favor of Shawinigan Water & Power Co., of the Bell Telephone Co.of Canada and of the Donnacona Paper Co.This item shall be sold to the last and highest bidder with rents as a charge thereon and the Church apportionments which may exist.Titles and certificates may be examined at all times by applying to the offices of the undersigned Trustees.This sale is carried out pursuant to articles 716, 717 and 719-A of the Code of Civil Procedure as well as article 55 of the Bankruptcy Act 1949.This sale is equivalent to a sale by Sheriff.Conditions of payment: cash.Quebec, February 16, 1959.LEFAIVRE, MARMETTE & LEFAIVRE, Trustees.Ill Mountain Hill, Quebec.49918-8-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February gist, 1969, Vol.91, No.8 935 VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC, eat par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.' GASPÉ Fieri Facias de Terris Cour de Magistrat, éT^R.GAÉTAN LEMI-Rimouski, 1 RE, médecin Stc-An-N° 34,581.) ne des Monts, district de { Gaspé, vs DÉSIRÉ VAL-LÊE, Sacré-Coeur, district de Gaspé.La propriété à vendre est la suivante: \"Les droits de préemption, les défrichements, les améliorations et impenses sur la moitié nord-ouest du lot numéro trente-cinq (35) du rang quatre (4) canton Tourelle, avec maison dessus construites, circonstances et dépendances.\" Pour être vendre à la porte de l'église de St.Joachim de Tourelle, MARDI, le VINGT-QUATRIÈME jrur de MARS 1959, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.Percé, le 16 février 1959.49935-8-2-o HULL Canada \u2014 Province de Québec District électoral de Gatineau Cour de Magistrat, ( D ICHARD PAQUIN, N° 5300.< ^ commerçant domici-l lié et résidant à Ste.Thérèse de Gatineau, district électoral de Gatineau, demandeur, vs DAVID MORIN, jr., de Gracefield, district électoral de Gatineau, défendeur.\"Le lot huit (lot 8) rang deux (R.2) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wright, P.Que., avec bâtisses dessus y érigées\".Pour être vendu à la porte de l'église La Visitation, dans le village de Gracefield, le SIXIÈME jour de MARS, 1959.à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif.R.ST-PIERRE.Hull, ce 27 janvier 1959.49787-5-2-o MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: (THE CROWN DIA-N° 42S644.< * MOND PAINT CO.' LTD., demanderesse; vs JEAN-PAUL LOISELLE.de la cité de Verdun, district de Montréal, y faisant affaires seul sous la raison sociale de \"Verdun Paint Specialties\", défendeur.\"Un emplacement ayant front sur la rue Willibrord, à Verdun, composé du lot numéro dix-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre mille six cent cinquante-six (4656-17) du plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal, mesurant vingt-cinq pieds de largeur sur cent vingt-deux.pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, avec toutes les bâtisses dessus érigées, portant les numéros civiques 135 et 137 de ladite rue Willibrord, et autres bâtisses et avec droit de passage en commun avec tous autres y ayant droit, dans la ruelle conduisant audit emplacement.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seised, and will be sold at the respective times and places mentioned below.GASPÊ Fieri Facias de Terris Magistrate's Court, é [\\R.GAÉTAN LEMI-Rimouski, ) RE, physician, Ste.No.34,581.j Anne des Monts, district ! of Gaspé vsDÉSIRÊ VALLÉE, Sacré-Coeur, district of Gaspé.The property for sale is the following: The pre-emption rights, clearing, improvements and upkeep on the northwesterly half of lot number thirty-five (35) of range four (4) township of Tourelle, with house therein erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at the door of the church of St.Joachim de Tourelle, TUESDAY, the TWENTY-FOURTH day of MARCH 1959, at TEN o'clock in the forenoon.J.F.MEAGHER.Sheriff's Office, Sheriff.Percé, February 16, 1959.49935-8-2 HULL Canada \u2014 Province of Quebec Electoral District of Gatineau Magistrate's Court,, f T3 ICHARD PAQUIN, No.5300.< tradesman, domiciled v and residing at Ste.Thérèse of Gatineau, electoral district of Gatineau, plaintiff, vs DAVID MORIN, Jr., of Gracefield, electoral district of Gatineau, defendant.\"Lot eight (lot 8) range two (R.2) on the official plan and in the book of reference of the township of Wright, P.Que., with buildings thereon erected\".To be sold at the church door of La Visitation, in the village of Gracefield, on the SIXTH day of MARCH, 1959, at THREE o'clock in the afternoon.R.ST-PD3RRE, Sheriff's Office, Sheriff.Hull, this 27th of January, 1959.49787-5-2 MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit :(THE CROWN DIA-No.428644.{ A MOND PAINT CO.I LTD., plaintiff: vs JEAN-PAUL LOISELLE, of the city of Verdun, district of Montreal, carrying on business alone in said city under the name and style of \"Verdun Paint Specialties\", defendant.\"An emplacement fronting on Willibrord Street, in Verdun, comprised of lot number seventeen of the official subdivision of original lot number four thousand six hundred and fifty-six (4656-17) of the official plan and book of reference of the parish of Montreal, measuring twenty-five feet in width by one hundred and twenty-two feet in depth, English measure and more or less, with all the buildings thereon erected, bearing civic numbers 135 and 137 of the said Willibrord Street, and other buildings, with right-of-way in common with any others having a right thereto, ia a lane leading to said emplacement.\" 936 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 81 février 1959; Tome 91, JV° 8 Pour être vendu, à mon bureau, en la cité de Montréal, le CINQUIÈME jour de MARS 1959, à DIX heures du matin.Le Shérif, CAISSE & Bureau du Shérif, LAURENCELLE.Montréal, 28 janvier 1959.49793-5-2-o QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: l f ES PRÉVOYANTS DU N° 93-800.< -L* CANADA, corporation ' légalement constituée ayant son siège social à Québec, district de Québec, contre JEAN PAUL GAGNON, 960,1ère Avenue Québec et AURÈLE LECLERC, en sa qualité de Régistrateur de la Division d'enregistrement pour le district de Québec, mis en cause.\"Un immeuble correspondant à la subdivision cinq cent trente-quatre du lot originaire numéro cinq cent neuf (509-534) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de St-Rcch Nord, en la cité de Québec, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu à mon bureau en la cité de Québec, le VINGT-SIXIÈME jour de MARS prochain à DIX heures de l'avant-mirii.Le Shérif, Bureau du Shérif, DR J.R.GOBEIL.Québec, le 18 février 1959.49938-8-2-o '[Première insertion, le 21 février 19591 [Deuxième insertion, le 14 mars 19591 Fieri Facias Québec; à savoir: ( I ''OFFICE DU CRÉDIT N° 95,269.\\ AGRICOLE DU QUÉ-iBEC, corps politique et incorporé, ayant son siège social à Québec, contre JOSEPH GÉRARD GELLY, 3184 Chemin Ste-Foy, Québec, district de Québec.\"Une terre située en la paroisse de St-Janvier de Joly, rang quatre, connue et désignée comme étant le lot numéro cent cinquante, des subdivisions du lot originaire numéro trois cent quatre-vingt-huit (388-150), aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de St-Êdouard (aujourd'hui Joly), contenant en superficie quatre-vingt-quatre arpents (84 arpents) le tout, plus ou moins, avec la maison dessus construite, circonstances et dépendances, sauf et à distraire cependant de cedit lot de terre, la partie occupée par la voie Sir Wilfrid Laurier, vendue au Ministère de la Voirie de la province de Québec, ainsi que la pièce de terrain suivante: Une pièce de terrain détachée dudit lot numéro (388-150) trois cent quatre-vingt-huit-cent cinquante, mesurant cent vingt-cinq pieds (1250 de largeur à partir de la ligne de division entre ledit terrain et la.terre de Clotaire Thurmel, sur deux cents pieds (2000 de profondeur, plus ou moins, borné au sud par le chemin de front du rang quatre; au sud-ouest par la terre dudit Clotaire Thurmel ; et les deux autres côtés par le reste dudit lot N° 388-150, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu \"en bloc\" à la porte de l'église paroissiale de St-Edouàrd, comté de Lotbinière (aujourd'hui Joly), le VINGT-SIXIÈME jour de MARS prochain, à DIX heures de l'avant -midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Dr J.-R.GOBEIL.Québec, le 18 février 1959.49039-8-2-o fPremière insertion, le 21 février 1959.] [Deuxième insertion, le 14 mars 1959.] To be sold, at my office, in the city of Montreal, the FIFTH day of MARCH 1959, at TEN o'clock m the morning.CAISSE & LAURENCELLE, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, January 28, 1959.49793-5-2 QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit : ( t ES PRÉVOYANTS DU No.93-800.S CANADA, corporation ' legally constituted having its head office in Quebec, district of Quebec, versus JEAN PAUL GAGNON, 960 1st Avenue, Quebec and AURÈLE LECLERC, in his capacity of Registrar of the Registry Division for the district of Quebec, mis en cause.\"An immoveable corresponding to subdivision five hundred and thirty-four of original lot number five hundred and nine (509-534) of the official plan and book of reference of St.Roch North, in the City of Quebec, with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at my office in the city of Quebec the TWENTY-SIXTH day of MARCH next at TEN o'clock in the forenoon.DR J.R.GOBEIL.Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, February 18, 1959.49938-8-2.[First insertion, February 21, 19591 [Second insertion, March 14, 1959i Fieri Facias Quebec, to wit:(QUEBEC FARM CRE-No.95,269.\\ v£ DIT BUREAU, a body I politic and corporate, having its head office at Quebec, against JOSEPH GÉRARD GELLY, 3184 Ste-Foy Road, Quebec, district of Quebec.\"A farm situated in the parish of St-Janvier de Joly, range four, known and designated as being lot number one hundred and fifty, of the subdivisions of the original lot number three hundred and eighty-eight (388-150), on the official plan and in the book of reference of the official cadaster for the parish of St-Edouard (today, Joly), containing in area eighty-four arpents (84 arpents) the whole, more or less, with the house thereon erected, circumstances and dependencies, save and to withdraw however from the said lot of land, that part occupied by the Sir Wilfrid Laurier highway, sold to the Roads Department of the Province of Quebec, as well as the following piece of land: A piece of land detached from the said lot number (388-150) three hundred and eighty-eight - one hundred and fifty, measuring one hundred and twenty-five feet (1250 in width starting from the dividing line between the said lot of land and the farm of Clotaire Thurmel, along two hundred feet (2000 in depth, more or less, bounded on the south by the front road of range four; on the southwest, by the farm of the said Clotaire Thurmel; and on the other two sides by the remainder of the said lot No.388-150, circumstances and dependencies.\" To be sold \"in block\" at the parochial church door of St-Edouard, county of Lotbinière (today, Joly) on the TWENTY-SIXTH day of MARCH next, at TEN o'clock in the forenoon.' Dr J.-R.GOBEIL, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, February 18, 1959.49939-8-2 [First insertion: February 21, 1959.] [Second insertion: March 14, 1959.] QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Québec, February gist, 1969, Vol.91, No.8 937 saint-françois st.francis Fieri Faciae de Terris Fieri Facias de Terris District de St-François District of St.Francis Cour Supérieure, ( T ^OFFICE DU CRÉDIT Superior Court, / /QUEBEC FARM CRE-N° 18 639.< -L» AGRICOLE DU QUE- No.18 639.< v£ DIT BUREAU, body v BEC, corps politique et in- V politic and incorporated, hav-corporé, ayant son siège social à Québec, district ing its corporate seat in Quebec, district of de Quebec, demandeur; vs JULIEN LEPITRE, Quebec, plaintiff, vs JULIEN LEPITRE, former-ci-devànt domicilié à St-Herménégilde, comté de ly domiciled at St-Herménégilde, county of Stanstead, Que, et aujourd'hui à Toronto, Ont., Stanstead, Que, and presently at Toronto, Ont., défendeur.defendant.\"Une terre au canton de Barford, désignée \"A farm in the township of Barford, designated comme étant le lot de cadastre N° trois-A (3-A), as being the cadastral lot No.three-A (3-A), du deuxième rang, d'environ quarante-six acres of the second range, of about forty-six acres and et toute cette partie des lots de cadastre trois-B all that part of cadastral lots three-B and three-C et trois-C (3-B, 3-C) du même rang, contenant (3-B, 3-C), of the same range, containing together ensemble environ soixante-six acres, se trouvant about seventy acres, being to the south of the au sud du nouveau chemin traversant cesdits new road crossing these said lots form the east to - lots de l'est à l'ouest, dans leur partie nord, ce the west, in their north part, this new road nouveau chemin se trouvant à environ six arpents being at about six arpents to the south of the au sud de la ligne nord desdits lots; avec bâtisses north line of the said lots; with buildings thereon y érigées.Le tout se trouvant dans le deuxième erected.The whole being in the second range rang des plan et livre dé renvoi officiels du cadas- upon the official plan and book of reference of tre du canton de Barford.the cadastre of the township of Barford.Sous la réserve d'une source d'eau sur ledit * Under the reserve of a spring on the said lot lot trois-A en faveur de Raphaël Godbout, three-A in favour of Raphaël Godbout, according suivant l'installation actuelle pour l'usage de ses the actual installation for the use of his buildings bâtisses sur sa propriété voisine et droits s'y on his next property and rights relating thereto, rapportant, tel que mentionné dans un acte as mentioned in a deed registered at Coaticook enregistré A Coaticook sous le N° 19091.\" unde No.19091\".> Pour être vendus \"en bloc\" les immeubles > To be sold \"en bloc\" the above described ci-haut décrits, â la porte de l'église paroissiale immoveables, at the door of the parochial church de St-Herménégilde de Barford, MERCREDI, of Saint-Herménégilde de Barford, WEDNES- le QUATRIÈME jour de MARS 1959, à ONZE DAY, the FOURTH day of MARCH 1959, at heures de l'avant-midi.ELEVEN o'clock in the forenoon.Le Shérif, JOSEPH LABRECQUE, Bureau du Shérif, JOSEPH LABRECQUE.Sheriff's Office, Sheriff.Sherbrooke, ce 24 janvier 1959.49767-5-2-o Sherbrooke, January the 24th, 1959.49767-5-2-o (Première insertion: le 31 janvier 1959.] [First insertion, January the 31st, 1959.] Fieri Facias de Bonis et de Terris Fieri Facias de Bonis et
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.