Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 juillet 1958, samedi 19 (no 29)
[" Tome 90, N° 29 2451 Vol.90, No.29 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 19 juillet 1958 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1958.Québec, le 21 juin 1958.L'Imprimeur de la Reine, 48009-25-1 l-o RÊDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, July 19th, 1958 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to roon on-Wednesday of each week, during the months of July and August, 1958.Quebec, June 21st, 1958.RÊDEMPTI PARADIS, 48009-25-1 l-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 2452 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N° £9 ^ préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus.l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014Les chiffres placés au bas des avis Ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMF1T PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502\u2014 l-52-o will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's.Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.- Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: 81.per dozen.Subscriptions: $7 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec.June 27th, 1940.41502 \u2014 l-52-o.Lettres patentes (P.G.12081-58) A.Laurin & Fils Transport Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept juin 1958, constituant en corporation: Lucien-D.Laurin, entrepreneur-camionneur, de St-Lambert, Émilien Laurin, de Pont-Viau, et Louis-Philippe Laurin, de Montréal, tous deux camionneurs, pour les objets suivants: Exercer le commerce du transport de marchandises; exercer le commerce d'immeubles, sous le Letters Patent (A .G.12081-58) A.Laurin & Fils Transport Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companise' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of June, 1958, incorporating: Lucien-D.Laurin, trucking contractor, of St.Lambert, Êmilien Laurin, of Pont-Viau, and Louis-Philippe Laurin, of Montreal, both truckers, for the following purposes: To carry on the business of forwarding merchandise, deal in real estate, under the name of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol 90, No.29 2453 nom de \"A.Laurin & Fils Transport Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 800 actions communes de $25 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-0 P.FRENETTE.> (P.G.12071-58) Arrow Door Manufacturing Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1958, constituant en corporation: J.-Claude Bureau, avocat, Marcel Hamclin, notaire, et Thérèse David, secrétaire, fille majeure et usant de ses droits, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de portes de garages, opérateurs automatiques et autres accessoires mécaniques, sous le nom de \"Arrow Door Manufacturing Company Limited\", avec un capital total de $25.000, divisé en 500 actions communes de $25 chacune et en 500 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-0 P.FRENETTE.(P.C.11043-58) Atlas Bricklaying Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente mai 1958.constituant en corporation: Ludwik Kos-Rabcewicz-Zubkowski, avocat, d'Ou-tremont, Piotr Zieba, entrepreneur-briqueteur, et Dominik Stankicwicz, contremaître, de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre l'achat et la vente- de matériaux de construction; des contrats de briquetage, maçonnerie et démolition, sous le nom de \"Atlas Bricklaying Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 800 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.\"A.Laurin & Fils Transport Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 800 common shares of $25 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12071-58) Arrow Door Manufacturing Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the tenth day of June, 1958, incorporating: J.-Claude Bureau, advocate.Marcel Hamelin, notary, and Thérèse David, secretary, spinster and in use of her rights, all of Montreal, for the following purposes: To operate the industry and business dealing in garage doors, automatic operators and other mechanical accessories, under the name of \"Arrow Door Manufacturing Company Limited\", with a total capital stock of $25,000, divided into 500 common shares of $25 each and into 500 preferred shares of $25 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11643-58) Atlas Bricklaying Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Queliec, bearing date the thirtieth day of May, 1958, incorporating: Ludwik Kos-Rabcewicz-Zubkowski, advocate, of Outremont, Piotr Zieba, bricklaying-contractor, and Dominik Stonkiewicz, foreman, of Montreal, for the following purposes: Purchase and sale of building materials; contracting in bricks, masonry and demolition, under the name of \"Atlas Bricklaying Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 800 shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48171-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12019-58) v(A.G.12019-58) Boulevard Development Co.Inc.Boulevard Development Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec ties lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the thirteenth du treize juin 1958, constituant en corporation: day of June, 1958.i icorporating: Daniel King-Daniel Kingstone, avocat, Kay Sheehy et Claire stone, advocate, Kay Shechy and Claire Saxe, Saxe, secrétaires, filles majeures, tous de Mont- secretaries, spinsters, all of Montreal, for the real, pour les objets suivants: following purposes: Transiger les affaires d'une compagnie d'im- To carry on the business of a real estate, immeubles, d'amélioration et de développement, provement and development company, under sous le nom de \"Boulevard Development Co.the name of \"Boulevard Development Co.Inc.\", 2464 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N\" 29 Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11950-58) B.R.M.Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente mai 1958, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall et Daniel Lazare, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"B.R.M.Investments Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 750 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.with a total capital stock of $10,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11950-58) B.R.M.Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies! Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of May, 1958, incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall and Daniel Lazare, all advocates, of Montreal, for the following purposes: ' To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"B.R.M.Investments Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 250 common shares of a par value of $10 each and into 750 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district' of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11985-58) Capri Development Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre juin 1958, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall, avocats, et Eva E.Levi, secrétaire, épouse séparée de biens de Leo Levi, et dûment autorisée par ce dernier, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction et amélioration, sous le nom de \"Capri Development Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 750 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.12056-58) Carinthia Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la-Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: Samuel (\"hait, avocat, John Hamilton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Aro-novitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une corporation de placements, sous le nom de \"Carinthia Investment Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur (A.G.11985-58) Capri Development Inc.- Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June, 1958, incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall, advocates, and Eva E.Levi, secretary, wife separate as to property of Leo Levi, and duly authorized by him, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Capri Development Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 250 com-com shares of a par value of $10 each and into 750 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12056-58) Carinthia Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1958, incorporating: Samuel Chait, advocate, John Hamilton, secretary, both of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of an investment corporation, under the name of \"Carinthia Investment Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2455 au pair de $1 chacune et 39*000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.12011-58) Cartier Publicité Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq juin 1958, constituant en corporation: Gérard Couillard, notaire, Marc Êmond, gérant de Caisse Populaire, et Gilles Grégoire, agent de publicité, tous de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents ou conseils en publicité, sous le nom de \"Cartier Publicité Inc.\", avec un capital total de $1,000, divisé en 100 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le cinq juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.shares of a par value of $1 each and- into 39,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12011-58) Cartier Publicité Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of June, 1958, incorporating: Gérard Couillard, notary, Marc Êmond, manager of a People's Bank, Gilles Grégoire, publicity agent, all of Quebec, for the following purposes: To carry on business as publicity agents or advisers, under the name of \"Cartier Publicité Inc.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 100 shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11930-58) Clement Bernard I.tee Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente mai 1958, constituant en corporation: Clément Bernard, marchand, Simone Lévesque sernard, ménagère, épouse contractuellementi séparée de biens dudit Clément Bernard, et Henri Cayer, laitier, tous de St-Raymond, pour les objets suivants: Commerce de matériaux de construction, de machineries et outillages de construction, d'articles de quincaillerie, de meubles et appareils électriques, articles de sport, bijouterie, d'épicerie et de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Clément Bernard Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Raymond, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-0 P.FRENETTE.(P.G.14029-58) Comité des Loisirs de l'Orme Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize juin, 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Moisan, boulanger-pâtissier, Armand Duchesneau, employé de î'Anglo Canadian Pulp, et Roland Durand, comptable, tous de Loretteville, pour les objets suivants: L'organisation \"des loisirs et le développement moral, intellectuel et physique des jeunes, sous le nom de \"Comité des Loisirs de l'Orme Inc.\".(A.G.11930-58) Clément Bernard Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of May, 1958, incorporating: Clément Bernard, merchant, Simone Lévesque Bernard, housewife, wife contractually separate as to property of the said Clément Bernard, and Henri Cayer, milkman, all of St-Raymond, for the following purposes : Dealing in a business of building materials, machinery and building equipment, articles of hardware, furniture and electrical apparatus, articles of sport, jewellery, groceries and as builders and general building contractors, under the name of \"Clément Bernard Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Raymond, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.14029-58) Comité des Loisirs de l'Orme Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of June, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Marcel Moisan, baker-confectioner, Armand Duchesneau, employee of the Anglo-Canadian Pulp, and Roland Durand, accountant, all of Loretteville, for the following purposes: Recreational organization and the moral, intellectual and physical development of youth, under the name of \"Comité des Loisirs «le l'Orme Inc.\". 2456 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N° 29 Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Loretteville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le seize juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 4817l-o ' P.FRENETTE./ _ (P.G.11875-58) Cosy Corner Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize juin 1958, constituant en corporation: Armand Poupart, fils, avocat, Jacqueline Matte et Monique Duquette, sténographes, célibataires, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs, entrepreneurs généraux en construction et comme compagnie de portefeuille \"holding\"; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Cosy Corner Incorporated\", avec un capital total de $100,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune /et en 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dorval, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(P.G.12028-58) Dahne Construction Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall et Daniel Lazare, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de \"Dahne Construction Corporation\", avec un capital total de $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11888-58) Darstro Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de Ja première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de_ Québec des lettres patentes, en date du onze juin 1958, constituant en corporation: Samuel Chait, de Montréal, Harry L.Aronovitch, de la ville Côte St-Luc, tous deux avocats, et John-Hamilton, secrétaire, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction, développement et amélioration, sous le nom de \"Darstro Realty Corpora- The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Loretteville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11875-58) Cosy Corner Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of June, 1958, incorporating: Armand Poupart, son, advocate, Jacqueline Matte and Monique Duquette, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To carry on as builders, general building contractors and as Holding Company to carry on real estate business, under the name of \"Cosy Corner Incorporated\", with a total capital stock of $100,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and into 800 preferred shares of a par value of^lOO each.The head office of the company will be at Dorval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12028-58) Dahne Construction Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall and Daniel Lazare, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Dahne Construction Corporation\", with a total capital stock of $50,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 400 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11888-58) Darstro Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June, 1958, incorporating: Samuel Chait, of Montreal, Harry L.Aronovitch, of the town of Côte St.Luc, both advocates, and John Hamilton, secretary, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction, development and improvement company, under the name of \"Darstro Realty Corporation\", with QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2457 tion\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 36,000 actions privilégiéds de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.12017-58) D.C.Chemical Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: Armand Biais, gérant, J.-Claude Guillemette, avocat, tous deux de Shawinigan, et Marcel Houle, vendeur, de.Shawinigan-Sud, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de produits chimiques, sous le nom de \"D.C.Chemical Products Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Shawinigan, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-0 P.FRENETTE.a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and into 36,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12017-58) D.C.Chemical Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1958, incorporating: Armand Biais, manager, J.-Claude Guillemette, advocate, both of Shawinigan, and Marcel Houle, salesman, of Shawinigan-South, for the following purposes: To carry on the business of and deal in chemical products, under the name of \"D.C.Chemical Products Inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Shawinigan, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11941-58) Denvin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un mai 1958, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Gabriel Glazer, étudiant en droit, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Denvin Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1420 rue Towers, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, du trente et un mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(A.G.11941-58) Denvin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of May, 1958, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Gabriel Glazer, law student, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Denvin Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 1420 Towers Street, Room 100, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11789-58) Ditar Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept juin 1958, constituant en corporation: Nathan Levitsky, Solomon Weber, tous deux avocats et Carol Jones, sténographe, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Ditar ^Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions de $100 chacune.(A.G.11789-58) Ditar Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June, 1958, incorporating: Nathan Levitsky, Solomon Weber, both lawyers, and Carol Jones, stenographer, all.of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Ditar Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 shares of $100 each. 2468 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept juin 1968.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.12007-58) Electronic Tabulating Service Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre juin 1958, constituant en corporation: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch et Melvin Salmon, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Pourvoir aux services d'une tenue de livres y compris celui des calculs, computatlins, arrangements en tableaux concernant tous les livres de records, sous le nom de \"Electronic Tabulating Service Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et 3,600 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11696-58) Elgo Textiles Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1958, constituant en corporation: Samuel Leon Mendelsohn, conseil en loi de la Reine, de Westmount, Leo Rosentzveig, Stanley Taviss, tous deux de Montréal et William Levitt, d'Outremont, tous avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de vêtements et textiles, sous le nom de \"Elgo Textiles Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 20 actions ordinaires de $100 chacune, 180 actions catégorie \"A\" de $100 chacune et 800 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compangie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12007-58) Electronic Tabulating Service Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June, 1958, incorporating: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch and Melvin Salmon, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To provide the service of bookkeeping including the making of calculations, computations and tabulations in respect of all books of record, under thé name of \"Electronic Tabulating Service Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $10 each and into 3,600 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, udicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11696-58) Elgo Textiles Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June, 1958, incorporating: Samuel Leon Mendelsohn, queen's counsel, of Westmount, Leo Rosentzveig, Stalney Taviss, both of Montreal, and William Levitt, of Outremont, all advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel and textiles, under the name of \"Elgo Textiles Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 20 common shares of $100 each, 180 Class \"A\" shares of $100 each and into 800 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12055-58) Fair Isle Knitting (Quebec) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: Lawrence Marks, de Westmount, Edward Irving Auerback, de Montréal, tous deux avocats et solliciteurs, Madeleine Ferguson et Miriam Bernard, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de machines à tricoter, machines à coudre, outillage électrique et accessoires, articles d'usage domestique et de ménage, quincaillerie, textiles et 'produits du tricot de toutes sortes, sous le nom de \"Fair Isle Knitting (Quebec) Ltd.\", avec un capital (A.G.12055-58) Fair Isle Knitting (Quebec) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1958, incorporating: Lawrence Marks, of Westmount, Edward Irving Auerback, of Montreal, both barristers and solicitors, Madeline Ferguson and Miriam Bernard, secretaries, spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in knitting machines, sewing machines, electrical equipment and appliances, domestic and household articles, hardware, textiles and knitted products of all kinds, under the name of \"Fair Isle Knitting (Quebec) Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec,'July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2459 total de $50,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $50 chacune et 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1450 rue Mountain, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11889-58) Four Hundred Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1958, constituant en corporation: Samuel Chait, avocat, John Hamilton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Four Hundred Realty Corporation\", avec un capital total de $40,009, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et 36,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.12008-58) Franksin Mines Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq juin 1958, constituant en corporation: Maurice Martel, avocat, Lucille Roy et Louise Bourdon, secrétaires, célibataires, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des exploration ou recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Franksin Mines Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de $5,000,000, divisé en 5,000,000 actions 'communes d'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera 159, rue Craig, ouest, suite 204, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(P G 12026-58) Gardénia Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: divided into 200 common shares of a par value of $50 each and into 800 preferred shares of a par value of $50 each.The head office of the company will be at 1450 Mountain Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11889-58) Four Hundred Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June, 1958, incorporating: Samuel Chait, advocate, John Hamilton, secretary, both of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Four Hundred Realty Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and into 36,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12008-58) Franksin Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec bearing date the fifth day of June, 1958, Maurice Martel, advocate, Lucille Roy, and Louise Bourdon; secretaries, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Franksin Mines Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $5,000,000, divided into 5,000,000 common shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at 159 Craig St., West, suite 204, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12026-58) Gardénia Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June 1958, incorporating: Jacques Lapointe, 2460 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 Jacques Lapointe, Jean Bérubé et Guy des Rivières, tous avocats, de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme fleuristes, sous le nom de \"Gardénia Limitée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(P.G.11878-58) G.Kaplan Inc.Avis est donné qu'en vçrtu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du cinq juin 1958, constituant en corporation: Max Sidney Kaufman, de Westmount, Joseph Roy Hoffman, de Montréal et Oscar Respitz, de Ville Mont-Royal, tous avocats, pour lés objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de marchandises sèches, vêtements et textiles, sous le nom de \"G.Kaplan Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de ontréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11787-58) G.Lefebvre & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: Claude Beauregard, Georges Beauregard, Henri Messier, tous trois notaires, et Pauline Richard, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Commerce de vêtements, chapeaux, chaussures et articles de mercerie et de toilette, sous le nom de \"G.Lefebvre & Fils Inc.\", avec un capital divisé en 400 actions sans valeur au pair ou nominale et en 1,600 actions privilégiées de $25 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $6,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(P.G.12033-58) G.& Z.Lumber Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: Charles Brownstein, Aloses Moscovitch et Irving L.Adessky, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Jean Bérubé and Guy des Rivières, all advocates, of Quebec, for the following purposes: To carry on business as florists, under the name of \"Gardénia Limitée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11878-58) G.Kaplan Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of June, 1958, incorporating: Max Sidney Kaufman, of Westmount, Joseph Roy Hoffman, of Montreal, and Oscar Respitz, of the town of Mount Royal, all advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, wearing apparel and textiles, under the name of \"G.Kaplan Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of .the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11787-58) G.Lefebvre & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1958, incorporating: Claude Beauregard, Georges Beauregard, Henri Messier, all three notaries and Pauline Richard, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in clothing, hats, shoes and dry goods and toilet articles, under the name of \"G.Lefebvre & Fils Inc.\", with a capital stock divided into 400 shares without nominal or par value and into 1,600 preferred shares of $25 each and the amount with which the company will start its operations is $6,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12033-58) G.& Z.Lumber Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: Charles Brownstein, Moses Moscovitch and Irving L.Adessky, all advocates, of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2461 Exercer un commerce de bûcherons, exploitants de la forêt, marchands de bois et propriétaires de scierie, moulin à planer et moulin à pulpe, sous le nom de \"G.& Z.Lumber Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.1,000 actions privilégiées participantes d'une valeur au pair de $10 chacune et 200 actions privilégiées non-participantes, d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.To carry on the business of loggers, lumbermen, lumber merchants and sawmill, planing-mill and pulpmill owners, under the name of \"G.& Z.Lumber Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each, 1,000 participating preferred shares of a par value of $10 each and into 200 non-participating preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE.48171-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11890-58) Harvard Holding Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze juin 1958, constituant en corporation: Samuel ('hait, avocat, John Hamilton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction, amélioration et placements, sous le nom de \"Harvard Holding Corporation\", avec un capital total de $33,600, divisé en 3,600 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(A.G.11890-58) Harvard Holding Corporation Notice is hereby given tliet under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June, 1958, incorporating: Samuel Chait, advocate, John Hamilton, secretary, both of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction, improvement and investment company, under the name of \"Harvard Holding Corporation\", with a total capital stock of $33,600, divided into 3,600 common shares of a par value of $1 each and into 30,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12059-58) Imprimerie Bou-Ra-Ca Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: Raymond Massé, de Mont-Laurier, Robert Massé et Jacques Massé, de Montréal, tous commerçants, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, sous le nom de \"Imprimerie Bou-Ra-Ca Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-0 P.FRENETTE.(P.G.11978-58) Industrial Fasteners Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre juin 195$, constituant en corporation: Benjamin Robinson, Joseph Shapiro, avocats et conseils en loi de la Reine, de Westmount, Jonathan J.Robinson, Theodore H.Shapiro, avocats, (A.G.12059-58) Imprimerie Bou-Ra-Ca Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1958, incorporating: Raymond Massé, of Mont Laurier, Robert Massé and Jacques Massé, of Montreal, all merchants, for the following purposes: To carry on business as printers, under the name of \"Imprimerie Bou-Ra-Ca Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company wfll be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11978-58) Industrial Fasteners Ltd., Notice is hereby given that under Part I of the Quel)ec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of June, 1958, incorporating: Benjamin Robinson, Joseph Shapiro, advocates and Queen's Counsel, of Westmount, Jonathan J.Robinson, Theodore H.Shapiro, advocates, Margaret Lang- 2462 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 Margaret Langmaid, secrétaire et Jean McFar-lane,' teneuse de livres, toutes deux filles majeures, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de fils de fer et produits d'iceux, machinerie, moteurs, outils, instruments et ferronnerie de toutes sortes, sous le nom de \"Industrial Fasteners Ltd.\", avec un capital total de $200,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune et 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.maid, secretary, and Jean McFarlane, bookkeeper, both spinsters of the full age of majority, all four of Montreal, for the following' purposes: To manufacturé and deal in wire and wire products, machinery, engines, tools, implements and hardware of all kinds, under the name of \"Industrial Fasteners Ltd.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1,000 common shares of $100 each and into 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of June, 1958.P.FRENETTE, 4817l-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12027-58) Jakmar Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: David Litner, Seymour Machlovitch, avocats et Doreen Shere Gordon, secrétaire, épouse séparée de biens de Eugene Gordon, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Jakmar Investment Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11971-58) Josef Dress Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: Irwin S.Brodie, Theodore H.Polisuk, avocats, et Sonya Schneyer, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce d'articles vestimentaires pour dames, sops le nom de \"Josef Dress Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1418 rue Bleury, chambre 8, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11440-58) Kautex (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq juin 1958, constituant en corporation: (A.G.12027-58) Jnkmar Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: David Litner, Seymour Machlovitch, advocates, and Doreen Shere Gordon, secretary, wife separate as to property of Eugene Gordon, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment corporation, under the name of \"Jakmar Investment Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and into 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11971-58) Josef Dress Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1958, incorporating: Irwin S.Brodie, Theodore H.Polisuk, advocates, and Sonya Schneyer, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in women's wearing apparel, under the name of \"Josef Dress Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 1418 Bleury Street, room 8, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11440-58) Kautex (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of June, 1958, incorporating: John DiMassino, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2463 John DiMassino.surintendant, George Whelan, avocat, Millie Tobenstein,-secrétaire et Toshiko Nakatsuka, dactylo,* toutes deux filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à fabriquer et faire le négoce de toutes sortes de matières plastiques et de produits, articles et effets dérivés d'icelles, sous le nom de \"Kautex (Canada) Ltd.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.12022-58) Kramar Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Gabriel Glazer, étudiant en droit, Michael Hornstein, agent d'immeubles, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme distributeurs et marchands de gazoline, huiles, pétroles, produits et sous-produits; celui de garagistes, vendeurs d'automobiles, sous le nom de \"Kramar Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 6650 avenue Darlington, chambre 330, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.12044-58) Les Ateliers Roland Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: Joseph-Bernard Carisse, avocat, de Ville d'Anjou, Rosaire Beaulé, avocat, et Denise Asselin, secrétaire, célibataire, majeure, de Montréal, pour les objets suivants Exercer l'industrie et le commerce de meubles et de nouveautés, sous le nom de \"Les Ateliers Roland Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Drum-mondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 4817l-o P.FRENETTE.(P.G.12072-58) Les Bois du Ruisseau Grand Nord Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la superintendent, George Whelan, advocate, Millie Tobenstein, secretary, and Toshiko Nakatsuka, typist, both of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in all kinds of plastic materials and in products, goods and wares derived therefrom, under the name of \"Kautex (Canada) Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be *»t Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12022-58) Kramar Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Gabriel Glazer, Law Student, Michael Hornstein, realtor, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as dstributors of and traders in gasoline, oils, petroleum, products and by-products; to carry on business as garage keepers; to deal in automobiles, under the name of \"Kramar Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 6650 Darlington Avenue, room 330, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12044-58) Les Ateliers Roland Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1958, incorporating: Joseph-Bernard Carisse, advocate, of the Town of Anjou, Rosaire Beaulé, advocate, and Denise Asselin, secretary, spinster, of full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of and deal in novelties, under the name ot \"Les Ateliers Roland Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12072-58) Les Bois du Ruisseau Grand Nord Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 2464 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tomé 90, N\" 29 province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1958, constituant en corporation: Nérée Arsenault, ingénieur forestier, de Québec, Guy Letarte, de Ste-Foy, et André Trotier, de Charlesbourg, tous deux avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce du bois et des produits du bois, sous le nom de \"Les Bois du Ruisseau Grand Nord Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1218, rue Albert Lozeau, Sillery, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-0 P.FRENETTE.Province of Quebec, bearing date the tenth day of June, 1958, incorporating: Nérée Arsenault, forest engineer, of Quebec, Guy Letarte, of Ste.Foy, and André Trotier, of Charlesbourg, both advocates, for the following purposes: Deal in lumber and the products thereof, under the name of \"Les Bois du Ruisseau Grand Nord Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1218 Albert Lozeau Street, Sillery, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11171-58) Les Enchères Prosper Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1958, constituant en corporation: Henri-Paul Lemay, de Montréal, Paul-Edouard Ross, de Verdun, tous deux avocats, et Ghislaine Gagné, secrétaire, fille majeure, de Laval-des-Rapides, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce, dont la vente aux enchères, du bois et autres matériaux et leurs produits, sous le nom de \"Les Enchères Prosper Inc.\".avec un capital total de $20,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 1,900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.48171-o P.FRENETTE.(P.G.12034-58) Les Industries B & L.Inc.The B & L Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenantflouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: Laurent Brisson, électricien.Dame Jacqueline Paiement, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Laurent Brisson, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de St-Léonard-de-Port-Maurice, et Fernand Lapointe, vendeur, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens, constructeurs, entrepreneurs généraux en construction et comme quincailliers; exercer l'industrie et le commerce d'appareils et accessoires électriques, de systèmes de chauffage, d'articles en métal et de combustibles, sous le nom de \"Les Industries B & L.Inc.\u2014 The B & L Industries Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant-prociiKcur général suppléant, n 48171-0 P.FRENETTE.(A.G.11171-58) Les Enchères Prosper Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of June, 1958, incorporating: Henri-Paul Lemay, of Montreal, Paul-Êdouard Ross, of Verdun, both advocates, and Ghislaine Gagné, secretary, spinster, of Laval-des-Rapides, for the following purposes: To carry on an industry and business, especially auctions sales, of lumber and other materials and their products, under the name of \"Les Enchères Prosper Inc.\" with a total capital stock of $20,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each andinto 1,900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12034-58) Les Industries B & L.Inc.The B & L Industries Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: Laurent Brisson, electrician, Dame Jacqueline Paiement, housewife, wife contractually separate as to property of the said Laurent Brisson, and duly authorized by him for these present purposes, both of St-Léonard-de-Port-Maurice, and Fernand Lapointe, salesman, of Montreal, for the following purposes: To carry on-aS\"electricians, builders and hardware dealers; to operate and industry and business dealing in electrical apparatus and accessories, heating systems, metal articles and fuels under the name of \"Les Industries B & L.Inc.\u2014 The B & L Industries Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General. / QUEBEC OFFICIAL GAZETTE^ Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2465 (P.G.11954-58) Lester Realty Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première ^partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente mai 1958, constituant en corporation: John L.Liberman, Alfred N.Segall et Daniel Lazare, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Lester Realty Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 2,400 actions privilégiées catégorie \"A\" d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,500 acious privilégiées catégorie \"B\" d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1457 rue Metcalfe, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11376-58) Les Ventes aux Enchères du Témiscamingue Inc.Auction Sales of Témiscamingue Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze juin 1958, constituant en corporation: Maurice Lefebvre, camionneur, Mme Rita Go-din, ménagère, épouse séparée de biens dudit Maurice Lefebvre, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Charles Lefebvre, commerçant, tous de Ville-Marie, pour les objets suivants: Faire la vente aux enchères ou de gré à gré avec particuliers, d'animaux, équipements, machines, produits manufacturés ou produits de la forêt ou de mines, sous le nom de \"Les Ventes aux Enchères du Témiscamingue Inc.\u2014 Auction Sales of Témiscamingue Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.lie siège social de la compagnie sera en le village de Ville-Marie, district judiciaire de Témiscamingue.Daté du bureau du Procureur général, le douze juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, -48171-0 P.FRENETTE.(A.G.11954-58) Lester Realty Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of May, 1958, incorporating: John L.Liberman, Alfred N.Segall and Daniel Lazare, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Lester Realty Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each, 2,400 class \"A\" preferred shares of a par value of $10 each and into 1,500 class \"B\" preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 1457 Metcalfe Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48171-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11376-58) Les Ventes aux Enchères du Témiscamingue Inc.Auction Sales of Témiscamingue Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of June, 1958, incorporating: Maurice Le-febvre, trucker, Mrs.Rita Godin, housewife, wife separate as to property of the said Maurice Lefebvre, and duly authorized by him for these present purposes, and Charles Lefebvre, tradesman, all of Ville-Marie, for the following purposes: To carry on auction sales or by private contract with individuals, of animals, equipment, machines, manufactured products or products of the forest or mines, under the name of \"Les Ventes aux Enchères du Témiscamingue Inc.\u2014 Auction Sales of Témiscamingue Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at the village of Ville-Marie, judicial district of Témiscamingue.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11892-58) Lin wood Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze juin 1958, constituant en corporation: Gérald Desparois, avocat, d'Outremont, Robert Maillet, avocat, et Madeleine Soumis, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Linwood Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.(A.G.11892-58) Linwood Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of June 1958, incorporating: Gerald Despa-rois, advocate, of Outremont, Robert Maillet, advocate, and Madeleine Soumis, secretary, of full age of majority making use of her rights, of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate; carry on business as general building contractors, under the name of \"Linwood Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1.000 common shares of 810 each and 300 preferred shares of S100 each. 2466 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 Le siège social de la compagnie -sera 1100, rue Beaumont, Ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(P.G.12032-58) Mescar Holding Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: Gregory Charlap, Max Slapack, Arthur SImlman, tous trois avocats, et Sylvia Teitlebaum, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transifer les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Mescar Holding Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant procureur-général suppléant, 48171 P.FRENETTE.The -head office of the company will be at 1100 Beaumont Street, Town of Mount Royal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of June 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12032-58) Mescar Holding Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: Gregory Charlap, Max Slapack, Arthur Shulman, all three advocates, and Sylvia Teitlebaum, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Mescar Holding Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and into 360 preferred shares of $r00 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11847-58) M.Pesner & Sons Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 195S, constituant en corporation: Irwin S.Brodie, Theodore H.Polisuk, avocats, et Sonya Schneyer, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Préparer et faire le commerce de viandes, œufs, poissons, produits d'animaux, laitiers, maraîchers et potagers, sous le nom de \"M.Pesner & Sons Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 16 Marché Bonsecours, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant procureur-général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.10753-58) New Croydon Development Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze juin 1958, constituant en corporation: Max-Henri Gagnon, notaire, Roger Fortier, comptable agréé, tous deux de Montréal, et Lucien St-Onge, comptable, de Verdun, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"New Croydon Development Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 (A.G.11847-58) M.Pesner & Sons Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: Irwin S.Brodie, Theodore H.Polisuk, advocates, and Sonya Schneyer, secretary, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in meat, eggs, fish, animal, dairy, farm and garden produce, under the name of \"M.Pesner & Sons Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and into 3,500 preferred shares of $10 exch.The head office of the company will be at 16 Bonsecours Market, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10753-58) New Croydon Development Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the; Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June 1958, incorporating: Max-Henri Gagnon, notary, Roger Fortier, chartered accountant, both of Montreal, and Lucien St-Onge, accountant, of Verdun, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"New Croydon Development Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2467 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Jacques-Cartier, comté de Chambiy, district judiciaire del M ont réal.Daté du bureau du Procureur général,'le onze juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-0 P.FRENETTE.(P.G.11923-58) North-End Sanitation Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: Georges Bilodeau, de Montréal-Nord, Bernard Bilodeau, de Westmount, tous deux avocats, et Andrée Pontbriand, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, de Montréal, pour les objets suivants: Entreprise de transport de vidanges et de déchets pour le service de corporations ou de particuliers, sous le nom de \"North-End Sanitation Co.Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(P.G.11735-58) Orchard Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit mai 1958, constituant en corporation: Harry L.Aronovitch, de la ville Côte St-Luc, Samuel Chait, et Maxwell Shenker, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction, amélioration et développement, sous le nom de \"Orchard Development Corporation\", avec un capital total de $5,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté \"du bureau du Procureur général, le vingt-huit mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.12003-58) Palmer Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq juin 1958, constituant en corporation: Jack Rudner, Joseph Mendelson, avocats, et Celia Cohen, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce d'articles vestimentaires et fourniture de ménage, sous le nom de \"Palmer Sales Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordi- of a par value of $100 each and 20,000 common shares of a par value of $1 each.^The head office of the company will be at Jacques Cartier, county of Chambly, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11923-58) North-End Sanitation Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1958, incorporating: Georges Bilodeau, of Montreal-North, Bernard 'Bilodeau, of West-mount, both advocates, and Andrée Pontbriand, secretary, of full age of majority making use of her rights, of Montreal, for the following purposes: An undertaking for the transportation of garbage and refuse for servicing corporations or private individuals, under the name of \"North-End Sanitation Co.Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General (A.G.11735-58) Orchard Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of May, 1958, incorporating: Harry L.Aronovitch, of the town of Côte St.Luc, Samuel Chait and Maxwell Shenker, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction, improvement and development company, under the name of \"Orchard Development Corporation\", with a total capital stock of $5,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12003-58) Palmer Sales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of June, 1958, incorporating: Jack Rudner, Joseph Mendelson, advocates, and Celia Cohen, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel and household furniture, under the name of \"Palmer Sales Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares 2468 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 naires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 371 rue Dowd, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq juin 1958.L'Assistant procureur-général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11858-58) Park Ave.Businessmen's Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept juin 1958, constituant en corporation sans capital-actions: John Mishkin, Issie daymen, Jack Kugler, magasinier,.Pierre LeBlanc, administrateur, Sam Preval, photographe et Al Cornfield, fleuriste, tous de [Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts économiques, financiers, commerciaux, industriels, professionnels, sociaux, culturels, patriotiques et civiques des hommes d'affaires de l'avenue «lu Parc et des environs.en les cité et district de Montréal, sous le nom de \"Park Ave.Businessmen's Association\".Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est $25,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 371 Dowd Street, Montreal, judicial district of Montreal.' Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 -o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11858-58) Park Ave.Businessmen's Association Notice fs hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the seventh day of June, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: John Mishkin, Issie Clay-men, Jack Kugler, store-keepers, Pierre LeBlanc, executive, Sam Preval, photographer, and Al Cornfield, florist, all of Montreal, for the following purposes: To promote the economic, financial, commercial, industrial, professional, social, cultural, patriotic and civic interests of the businessmen of Park Avenue and the surrounding area in the city and district of Montreal, under the name of \"Park Ave.Businessmen's Association\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may possess, is to be limited is $25,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12078-58) Patet Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du dix juin 1958, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Gabriel Glazer, étudiant en droit, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Patet Corp.\", avec un capital total de $20,-000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1477 avenue MacDonald, chambre 101, St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.12004-58) Paul L'Heureux Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: Emile Trottier, d'Outremont, Marcel Lajeunesse, de Baie d'Urfée, tous deux avocats, et Jacque- (A.G.12078-58) Patet Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June* 1958, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Gabriel Glazer, law student, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Patet Corp.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 1477 MacDonald Avenue, room 101, Saint Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48l71-o ' Acting Deputy Attorney General.(A.G.12004-58) Paul L'Heureux Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: Emile Trottier, of Outremont, Marcel Lajeunesse, of Baie d'Urfée, both advocates, and Jacqueline Daoust, _QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2469 (P.G.11975-58) Persillier Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois juin 1958, constituant en corporation: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch et Melvin Salmon, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Persillier Development Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3 actions ordinaires de $100 chacune et 3,970 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 940 Chemin Côte de Liesse, Suite 305, Ville Mont Royal, 'district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 v P.FRENETTE.(P.G.10835-58) Personal Credit Assistance Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a (A.G.11975-58) Persillier Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies 'Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of June, 1958, incorporating: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch and Melvin Salmon, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Persillier Development Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3 common shares of $100 each and into 3,970 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 940 Côte de Liesse Row), Suite 305, Town of Mount Royal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10835-58) Personal Credit Assistance Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have line Daoust, secretaire, fille majeure, de Mont- secretary, spinster of the full age of majority, real, pour les objets suivants: *of Montreal, for the following purposes: Transiger les affaires d'une compagnie de ter- To carry on the business of a land, construc- rains, construction, développement et améliora- tion, development and improvement company, tion, sous le nom de \"Paul L'Heureux Inc.\", underVhe name of \"Paul L'Heureux Inc.\", with avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 a total capital stock of $20,000, divided into actions de $10 chacune.2,000 shares of $10 each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, six juin 1958.this sixth day of June, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 1*.FRENETTE, 48171 P.FRENETTE.48l7l-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11275-58) ' (A.G.11275-58) Paul Maney Laboratories Quebec Ltd.Paul Maney Laboratories Quebec Ltd.Laboratoires Paul Maney Québec Ltée Laboratoires Paul Maney Québec Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il the Quebec Companies' Act, letters.patent a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de have been issued by the Lieutenant-Governor la province de Québec des lettres patentes, en of the Province of Quelle, bearing date the date du douze juin 1958.constituant en corpora- twelfth day of June, 1958, incorporating: Hélène tion: Hélène De Graeve.secrétaire, épouse De Graeve, secretary, wife separate as to proséparée de biens de Fortuné De Graeve, de perty of Fortuné De Graeve, of St.Vincent de St-Vincent de Paul, Zygmunth Piver-Pivlica, Paul, Zygmunth Piver-Pivlica, merchant, and marchand, et Harry Melville Budyk, avocat, Harry Melville Rudyk, advocate, of Montreal, de Montréal, pour les objets suivants: for the following purposes: Prépare, distribuer, acheter, vendre, importer To manufacture, distribue, buy, sell, import et exporter des produits pharmaceutiques aussi and export pharmaceutical products as well as bien que des substances chimiques, accessoires chemical, hospital, surgical, medical and dental d'Hôpitaux, de chirurgie médicaux et dentaires supplies as wholesalers only, the whole, subject comme grossistes seulement, sujet A la Loi de to the Quebec Pharmacy Act, under the name Pharmacie de Québec, sous le nom de \"Paul of \"Paul Maney Laboratories Quebec Ltd.\u2014 Maney Laboratories Quebec Ltd.\u2014 Labora- Laboratoires Paul Maney Quél)ec Ltée\", with toires Paul Maney Québec Ltée\", avec un a total capital stock of $40,000, divided into capital total de $40,000, divisé en 150 actions 150 common shares of $100 each and into 250 ordinaires de $100 chacune te 250 actions privi- preferred shares of $100 each, légiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at district judiciaire de Montreal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, douze juin 1958.this twelfth day of June, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 4S171 P.FRENETTE.4817l-o Acting Deputy Attorney General. été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1958, constituant en corporation: Sol Sidney Fels, Bernard Gardner et Jules Leavitt, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: S'enquérir et faire rapport aux créanciers de la situation financière de certaines personnes, marchands, maisons de commerce et corporations et échanger entre les souscripteurs des informations concernant le crédit et l'état financier des marchands, sous le nom de \"Personal Credit Assistance Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune., Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE; (P.G.11451-58) Petit Lac Nominingue Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1958, constituant en corporation: Andrew S.Beaubien, courtier en placements, Claude Beaubien, représentant de ventes, Joseph Beaubien, industriel, Philippe Beaubien et Pierre Beaubien, entrepreneurs en électricité, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Petit Lac Nominingue Incorporée\", avec un capital total de $22,500, divisé en 225 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.been issued by.the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June, 1958, incorporating: Sol Sidney Feb, Bernard Gardner and Jules Leavitt, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To inquire and report to creditors upon 'the financial standing of persons, merchants, firms and corporations and to exchange among subscribers information as to the credit and standing of merchants, under the name of \"Personal Credit Assistance Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10 common shares of a par value of $100 each and into 390 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal,, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11451-58) Petit Lac Nominingue Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June, 1958, incorporating: Andrew S.Beaubien, investment broker, Claude Beaubien, sales representative, Joseph Beaubien, industrialist, Philippe Beaubien and Pierre Beaubien, electrical contractors, all of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Petit Lac Nominingue Incorporée\", with a total capital stock of $22,500, divided into 225 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11997-58) Roger Distributors Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a ét4 accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze juin 1958, constituant en corporation: John Henry Ernest Colby, Marc Brière, avocats et Galen Lee Prime, gérant, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de vêtements, cadeaux, bijouterie, meubles et appareils électriques, sous le nom de \"Roger Distributors Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze juin 1958.L'Assistant procureur-général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(A.G.11997-58) Roger Distributors Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of June, 1958, incorporating: John Henry Ernest Colby, Marc Brière, advocates, and Galen Lee Prime, manager, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deaf in^ clothing, gifts, jewellery, furniture and electrical appliances, under the name of \"Roger Distributors Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-0 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12045-58) Rosemont Metal Craft Inc.(A.G.12045-58) Rosemont Metal Craft Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Québec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2471 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: J.-Bernard Carisse, avocat, de Ville d'Anjou, Rosaire Beaulé, avocat, et Denise Asselin, secrétaire, célibataire, majeure, de Montréal, pour les objets suivants: ** Exercer l'industrie et le commerce d'articles et marchandises faits, totalement ou partiellement, de métal ou de bois, sous le nom de \"Rosemont Metal Craft Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions communes de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.< Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(P.G.11395-58) Ross Office Supplies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: Nathan Livitsky, Solomon Weber, avocats, et Carol Jones, sténographe, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de toute et aucune sortes d'accessoires de bureaux, sous le nom de \"Ross Office Supplies Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1193 Place Phillips, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin' 1958.~~ L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June 1958, incorporating: J.Bernard Carisse, advocate, of the Town of Anjou, Rosaire Beaulé, advocate and Denise Asselin, secretary, spinster of full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of and deal in articles and merchandise made, wholly or partly, of metal or wood, under the name of \"Rosemont Metal Craft Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11395-58) Ross Office Supplies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued \"by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: Nathan Le vit sky, Solomon Weber, attorneys, and Carol Jones, stenographer, fille majeure, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in any and all kinds of office supplies, under the name of \"Ross Office Supplies Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1193 Phillips Place, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 -o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11049-58) Semaines Sociales du Canada (Secteur Français) Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Maximilien Caron, Jean Deschamps, Esdras M inville, professeurs, Rév.père Joseph-Papin Archambault, Jésuite, Alfred Charpentier, fonctionnaire, Léon-Mercier Gouin, avocat et sénateur, Mgr Olivier Maurault, archiviste, Hon.Thibaudeau Rinfret, C.P., juriste, tous huit de Montréal, Guy Vanier, conseiller en loi de la Reine, avocat et administrateur, Arthur Saint-Pierre, courtier en immeubles, tous deux de Westmount, Rév.père Louis Lachance, Dominicain, d'Outremont, et François-Albert Angers, professeur, de St-Lambert, pour les objets suivants: Grouper en assocaition les personnes intéressées à diffuser la doctrine sociale de l'Église catholique par des conférences, des cours et des publications, sous le nom de \"Semaines Sociales du Canada (Secteur Français)\".Le revenu annuel des immeubles appartenant à la corporation et possédés par elle pour des fins de revenu ne devra pas excéder $20,000.(A.G.11049-58) Semaines Sociales du Canada (Secteur Français) Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day -of June, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Maximilien Caron, .Jean Deschamps, Esdras Minville, professors, Rev.Father Joseph-Papin Archambault, Jesuit, Alfred Charpentier, civil servant, Léon-Mercier Gouin, advocate and senator, Mgr.Olivier Maurault, archiviste, Hon.Thibaudeau Rinfret,'P.C., jurist, all eight from Montreal, Guy Vanier, Queen's Counsel, advocate and administrator, Arthur Saint-Pierre, real estate broker, both of West-mount, Rev.Father Louis Lachance, Dominican, of Outremount, and François-Albert Angers, professor, of St-Lambert, for the following purposes: To group into an association people interested in spreading the social doctrine of the Catholic Church, by lectures, courses and publications, under the name of \"Semaines Sociales du Canada (Secteur Français)\".- The amount to which the annual revenue of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $20,000. 2472 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N° 29 Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11607-58) Sherbrooke Perlite Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux juin 1958, constituant fti corporation: Léonel St-Laurent, cultivateur, de Martinville, Alonzo Felteau, entrepreneur, et Charles Leblanc, avocat, de Sherbrooke, pour les objets suivants: \"* Exercer l'industrie et le commerce de la perlite et de ses sous-produits; faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Sherbrooke Perlite Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le deux juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(A.G.11607-58) Sherbrooke Perlite Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of June, 1958, incorporating: Léonel St-Laurent, farmer, of Martinville, Alonzo Felteau, contractor, and Charles Leblanc, advocate, of Sherbrooke, for the following purposes: To operate an industry and business dealing in perlite and its by-products; to carry on business as builders and general building contractors under the name of \"Sherbrooke Perlite Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares of a par value of $100 each and into 200 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this second day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(P.G.12080-58) Sherbrooke Plastering Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958, constituant en corporation: Camille Messara, avocat, Yolande Roy, secrétaire, et Eugène Lamoureux, comptable, tous de Sherbrooke, pour, les objets suivants: Exercer le commerce du ciment et autres matériaux de construction, sous le nom de \"Sherbrooke Plastering Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 250 actions d'une valeur au pair de $40 chacune.Le siégé social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o .P.FRENETTE.(A.G.12080-58) Sherbrooke Plastering Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June 1958, incorparing: Camille Messara, advocate, Yolande Roy, secretary, and Eugène Lamoureux, accountant, all of Sherbrooke, for the following purposes: To deal in cement and other building materials, under the name of \"Sherbrooke Plastering Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 250 shares of a par value of $40 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11683-58) Société d'Importations Européennes Co.Ltée Ayis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze juin 1958, constituant en corporation: Henri Vinet, notaire.Lorraine Dansercau Vinet, épouse séparée de biens dudit Henri Vinet, tous deux de St- Martin, et Janine Vinet, secrétaire, de Montréal, pour les objets suivants: Importer, exporter et.exercer le commerce de produits, articles et marchandises faits, en tout ou en partie, de cuir, caoutchouc, métal, métalloïde, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, verre et leurs sous-produits, de (A.G.11683-58) Société d'Importations Européennes Co.Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth date of June, 1958, incorporating: Henri Vinet, notary, Lorraine Dansereau Vinet, wive separate as to property of the said Henri Vinet, both of St-Martin, and Janine Vinet, secretary, of Montreal, for the following purposes: To import, \"export and operate a business dealing in articles and manufactured merchandise, made in whole or in part of leather, rubber, metal, metalloids, wood, paper nylon, plastic, fur, textile, glass and their by-products, of QfJEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2473 merceries, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et périodiques, peintures, travaux d'art, produits comestibles, chimiques et de beauté, produits de la terre, de la mer et des forêts, sous le nom de \"Société d'Importations Européennes Co.Ltée\", avec un capital total de $40.000, divisé en 6,000 actions communes de $1 chacune et'en 340 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté_du bureau du Procureur général, le douze juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE._ \u2022 * (P.G.12005-58) Ste.Thérèse Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq juin 1958, constituant en corporation: David Stendel, comptable agréé, de St-Laurent, Henry Zipes, Edward Ordel, tous deux agents d'immeubles et Doreen Gordon, secrétaire, épouse séparée de biens de Eugène Gordon, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Négocier ou faire le commerce de propriétés immobilières, sous le nom de \"Ste Thérèse Enterprises Inc.\", avec un capital-actions divisé en 200 actions sans valeur nominale ou au pair, et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $1,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(P.G.11998-58) 'St.Lawrence Gas Corporation Corporation Gazifère du St-Laurent Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze juin 1958, constituant en corporation: Christophe-Antoine Geoffrion, avocat, de Westmount, Guillaume Geoffrion, Raymond-Gervais Decary, Fernand Lalonde, tous trois avocats, Gilles Graveline, comptable, Réjane Laberge, avocat, et Thérèse Bourassa, secrétaire, toutes deux filles majeures, tous six de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer, rafiner, acheter, emmagasiner, transporter, distribuer, vendre et faire le commerce en gros ou au détail, directement ou comme agents, de l'huile brute, de l'essence, du gaz naturel, du gaz propane et butane et de leurs produits et sous-produits et faire toutes les autres opérations s'y rapportant, sous le nom de \"St.Lawrence Gas Corporation \u2014 Corporation Gazifère du St-Laurent\", avec un capital total de $160,000, divisé en 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le onze juin 1958.# L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.dry good s, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, paintings, sorks of art, edible chemical and beauty products, products of land, sea aa forests, under the name of \"Société d'Importations Européennes, Co.Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 6,000 common shares of $1 each and into 340 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12005-58) Ste.Thérèse Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of June, 1958, incorporating: David Stendel, Chartered Accountant, of St.Laurent, Henry Zipes, Edward Ordel, both Realtors, and Doreen Gordon, secretary, wife separate as to property of Eugène Gordon, all three of Montreal, for the following purposes: To deal in or with immoveable property, under the name of \"Ste.Thérèse Enterprises Inc.\", with a capital stock divided into 200 shares without nominal or par value, and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will be $1,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of June, 1958.P.FRENETTE.4817l-o \" Acting Deputy Attorney General.(A.G.11998-58) St.Lawrence Gas Corporation Corporation Gazifère du St-Laurent Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of June, 1958, incorporating: Christophe-Antoine Geoffrion, advocate, of Westmount, Guillaume Geoffrion, Raymond-Gervais Decary, Fernand Lalonde, all three advocates, Gilles Graveline, accountant, Réjane Laberge, advocate, and Thérèse Bourassa, secretary, both spinsters of full age, all six of Montreal, for the following purposes : To manufacture, refine, purchase, store, transfer, distribute, sell and carry on a wholesale and retail business, directly or as agents, in crude oil, gazoline, natural gas, propane and butane gas and in their products and by-products and carry on all other operations pertaining thereto, under the name of \"St.Lawrence Gas Corporation \u2014 Corporation Gazifère du St-Laurent\", with a total capital stock of $160,000, divided into 1,500 preferred shares of a par value of $100 each and into 10,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General. 2474 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, &° 29 (P.G.12042-58) Stucco, Latte & Plâtre (Quebec) Inc.Stucco, Lath & Plaster (Quebec) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de.la province de Québec des lettrés patentes, en date du sept juin 1958, constituant en corporation: Pierre Bienjonetti, Jacques Morency, tous deux avocats, de Sillery, et Louise B.Vallée, sténographe, veuve, de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs-plâtriers en général; exercer le commerce du ciment et autres matériaux de construction, sous, le nom de \"Stucco, Latte & Plâtre (Québec) Inc.\u2014 Stucco, Lath & Plaster (Quebec) Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 300 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1059, rue St-Paul, L'Ancienne-Lorette, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le sept juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(P.G.11976-58) Supertest Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois juin 1958, constituant en corporation: Arthur I.Bronstein, avocat, Stanley Weigens-berg, administrateur, tous deux de Montréal, et Morton Bell, avocat, de St-Laurent, pour les les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Supertest Construction Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(A.G.12042-58) Stucco, Latte & Plâtre (Québec) Inc.Stucco, Lath & Plaster (Quebec) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of June, 1958, incorporating: Pierre Bienjonetti, Jacques Morency, both advocates, of Sillery, and Louise B.Vallée, stenographer, widow, of Quebec, for the following purposes: To carry on business as general plaster contractors: to carry on a business dealing in cement and in other building materials under the name of \"Stucco, Latte & Plâtre (Québec) Inc.\u2014 Stucco, Lath & Plaster (Quebec) Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 300 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.\u2022 The head office of the company will be at 1059 St-Paul St., L'Ancienne-Lorette, judicial district of Quebec.Dated at the-office of the Attorney General, this seventh day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11976-58) Supertest Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of June, 1958, incorporating: Arthur I.Bronstein, advocate, Stanley Weigensberg, executive, both of Montreal, and Morton Bell, advocate, of St.Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a construction company, under the name of \"Supertest Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.12077-58) Teegide Inc.(A.G.12077-58) Teegide Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies \"de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1958, constituant en corporation: Manuel Shacterv de Dorval, Leo Rosentzveig, Stanley Taviss, tous deux de Montréal et William Levitt, d'Outremont, tous avocats, pour les ob-' jets suivants: Fabriquer et exploiter d'aucune et quelque manière quelconque un dispositif de guide pour tiroirs et/ou toutes autres pièces mobiles, sous le nom de \"Teegide Inc.\", avec un capital total de $40,000 divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune et 35,000 actions privilégiées de $1 chacune.' Le siège social de la compagnie sera à \"Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1958, incorporating: Manuel Shacter, of Dorval, Leo Rosentzveig, Stanley Taviss, both of Montreal, and William Levitt, of Outremont, all advocates, for the following purposes: To manufacture and exploit in any and every manner whatsoever a guide device for drawers and/or any other moving parts, under the name of \"Teegide Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of SI each and into 35,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Mont real, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2475 (P.G.11224-58) Tremblay Ready Mix Ltée 'Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente mai 1058, constituant en corporation: Henri - Paul Tremblay, entrepreneur, Joseph Tremblay, journalier, et Léonard Tremblay, commis, tous de Normandin, pour les objets suivants: Exercer le commerce de ciment, béton ou autres matériaux de construction semblables, ainsi que d'appareils servant pour la préparation desdits matériaux; entreprendre des travaux d'excavation, de déblaiement et de remplissage, sous le nom de \"Tremblay Ready Mix Ltée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Albanel, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le trente mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(P.G.12Ç31-58) Vaudland Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1958.constituant en corporation: Gregory Charlap, Max Slapack, Arthur Shulman, tous trois avocats, et Sylvia Teitlebaum, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Vaudland Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.» Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171 P.FRENETTE.(A.G.11224-58) Tremblay Ready Mix Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of May, 1958, incorporating: Henri-Paul Tremblay, contractor, Joseph Tremblay, laborer, and Léonard Tremblay, clerk, all of Normandin, for the following purposes: To carry on a business dealing in cement,\"^-concrete or other similar building materials, as -well as apparatus used in the preparation of the said materials; to undertake excavation, ground clearing and filling-in work, under the name of \"Tremblay Ready Mix Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 20,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at Albanel, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12031-58) Vaudland Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1958, incorporating: Gregory Charlap, Max Slapack, Arthur Shulman, all three advocates, and Sylvia Teitlebaum, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Vaudland Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and into 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1958.P.FRENETTE, 48171-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11854-58) Vincent Transport Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1958, constituant en corporation: Etienne Pesant, commerçant, de St-Vincent-de-Paul, Raymond Galarneau, comptable, et Marc-Aurèle Gendron, ingénieur, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce du transport de marchandises, sous lé nom de \"Vincent Transport Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Vincent-de-Paul, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48171-o P.FRENETTE.(A.G.11854-58) Vincent Transport Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June 1958, incorporating: Etienne Pesant, merchant, of St.Vincent-de-Paul, Raymond Galarneau, accountant, and ManrAurèle Gendron, engineer, of Montreal, for the following purposes: To deal in the forwarding of merchandise, under the name of \"Vincent Transport Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint Vincent-de-Paul, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June 1958.P.FRENETTE, 48171 Acting Deputy Attorney General. 2476 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québecf 19 juillet 1958, Tome 90, N° 29 Département du Travail AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio \"Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire des Matériaux de construction, établi en vertu du décret numéro 324 du 30 mars 1950, et chargé de la mise a exécution du décret numéro 660 du 19 juin 1958, relatif à l'industrie du fer et du bronze ornemental a été autorisée par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 728 du 9 juillet 1958, section \"D\", le tout, «l'accord avec le paragraphe \"i\" de-l'article 20 de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements) à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés régis par ledit décret, suivant la méthode et*le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend de la date de publication du présent règlement dans la Gazette officielle de Québec au 31 mars 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels assujettis audit «lécret numéro 660 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% des salaires fixes, commissions, bonis ou allocations payés à leurs salariés assujettis audit décret.b) Tous les artisans assujettis au décret numéro 660 doivent également verser au Comité paritaire une somme .équivalente à 14 de 1% des salaires qu'ils ont gagnés dans l'exécution de travaux assujettis audit décret.c) Les salariés assujettis audit décret numéro 660 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yt de 1% de leurs salaires fixes, commissions, bonis et allocations.2.Mode de perception Afin de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire doit mettre à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués les heures de travail, l'argent parçu durant la semaine et les sommes versées au Comité paritaire.L'employeur professionnel doit remplir ces formules et les retourner au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même le salaire de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé avant d'être envoyé au Comité paritaire.Ce Comité a le droit d'exiger Passer mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le rapport, accompagné des cotisations, doit être envoyé au Comité paritaire le ou avant le mercredi suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible.3.Rapport financier D'acéôrd avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Department of Labour NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Building Materials Joint Committee, established under decree number 324 of March 30, 1950, and entrusted with the enforcement of the decree number 66Ô of June 19, 1958, relating to the ornamental iron and bronze industry, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 728 of July 9, 1958, part \"D\", in conformity with subsection \"1\" of section 20 of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Levy The period of Levy shall extend from the date of gazetting of the present by-law to March 31, 1959, and apply as hereinafter mentioned: ?a) The professional employers governed by decree number 660, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yi or 1% of their fixed wages, commissions, bonuses, allocations paid to their employees subject to the said decree.b) All the artisans subject to decree number 660, shall also pay to the Parity Committee Y£ of 1% of the wages earned by them for work governed by the said decree.c) The employees governed by the said decree, number 660, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to of 1% of their fixe regular wages, commissions, bonuses, allowances.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these levies, the Parity Committee shall furnish the professional employers with printed forms indicating the hours of labour, the money collected during the week and the sums sent to the Parity Committee.The professional employer shall have these forms filled in and returned to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect at the end of each week, from the wages of every one of his employees, the sums owned to the Parity Committee.The report of every professional employer shall be signed before it is sent to the Parity Committee.The Committee shall have the right to exact sworn reports when deemed advisable.The report, together with levies, shall be sent to the Parity Committee on or before the Wednesday following the date of expiration of the period for which the said report is requirable.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall present a quartely report of its financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2477 L'estimé des recettes et des déboursés pour la mise à exécution dudit décret, numéro 660, était inclus dans la requête présentée par le Comité conjoint des Matériaux de Construction pour la période se terminant le 31 mars 1959.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 juillet 1958.48178-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire des barbiers-coiffeurs de Saint-Jean et d'Iberville, établi en exécution du décret numéro 666 du 15 juin 1955, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 728 du 9 juillet 1958, section \"C\", le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs- professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend de la date de publication du présent règlement dans la Gazette officielle de Québec au 1er avril 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 666 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à % de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.6) Les artisans régis par ledit décret numéro 666 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à )A de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré dans leur métier.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 666 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseigne- The estimate of receipts and disbursements for the administration of the said decree, number 660 was included in the Building Materials Joint Committee levy by-law, for the period ending march 31, 1959.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 19, 1958.48178-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Parity Committee of the Barbers and Hairdressers of Saint-Jean and Iberville, formed under decree No.666 of June 15, 1955, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.728 of July 9, 1958, part \"C\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163, and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans, and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned : 1.Assessments The period of levy extends from the date of publication of the present by-law in the Quebec Official Gazette to April 1, 1959; it is laid as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 666, and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1% of their payroll as regards employees governed by the said decree.b) The artisans governed by the said decree, number 666, and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1% of the lowest wages established in the decree for a journeyman of their trade.c) The employees governed by the said decree, number 666, and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the pro essional employers with report forms on whic'i all particulars required by the Parity Committee shall be given.Professional employers shall complete and sign their reports and forward them to the Parity Committee every month.P ofessional employers shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of their employees by means of a deduction from th ir pay.Professional employers shall submit their monthly report to the Parity Committee on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for .which it is exigible- the said report shall be sent together with the assessments of the professional employers and of the employees.The Committee may have the said repor': signed under oath when deemed advicable.The assessments laid by the present by-law are payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Should a professional employer or na artisan refuse to pay or to give necessary informa- 2478 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 monts nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera, donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état .des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des barbiers-coiffeurs de Saint-Jean et Iberville, pour la période se terminant le 1er avril 1959.Le Comité Paritaire des Barbiers-Coiffeurs de Saint-Jean et Iberville (Siège social: Saint-Jean, P.Q.) État des recettes et des déboursés probables pour la période se terminant le 1er avril 1959.Recettes: \u2022 Cotisations (Y de 1%): Employeurs professionnels.S 10.00 Artisans.000.00 Salariés.10.00 $620.00 Déboursés: Salaires: inspecteurs .$180.00 Frais de déplacement: Inspection._ 30.00 Administration.25.00 Frais légaux.25.00 Papeterie, timbres, téléphone.50.00 Vérification des livres.60.00 Assurance.5.00 Dépenses diverses et imprévues.25.00 $400.00 Surplus.K.220.00 $620.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 juillet 1958.48178-0 tion, he will be given five (5) days'notice to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to the provisions o the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall make a quartely report covering its financial operations and remit same to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Parity Committee of the Barbers and Hairdressers of Saint-Jean and R>erville for the period ending Aprir 1, 1959.Th Parity Committee of the Barbers and Hairdressers of St.Jean an Iberville \" (Head office: St.John's P.Q.) Estimate of the receipts and di bursements for the period ending April 1, 1959.Receipts: Assessments (J^ of 1%) : Professional employers.$ 10.00 Artisans.-.600.00 Employees.'.10.00 $620.00 Disbursements: Salar'es: inspectors.$180.00 Travelling expenses: Inspection.30.00 Administration.25.00 Legal fees.25.00 Stationery, stamps, telephone.50.00 Auditing of books.;.60.00 Insur nee.5.00 Miscellaneous and unforeseen expenses.25.00 $400.00 Surplus.220.00 $620.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 19, 1958.48178-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail donne avis par les présentes, que le Comité paritaire du Camionnage du district de Québec, établi en exécution du décret numéro 706 du 7 juillet 1954 a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 729 du 9 juillet 1958, section \"B\", le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans, des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés.1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 30 juin 1958 au 30 juin 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: à) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 706 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équi- NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Comité paritaire .du Camionnage du district de Québec, formed under decree number 706 of July 7th, 1954, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 729 of July 9, 1958, part \"B\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act, to levy assessments from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from June 30, 1958 to June 30, 1959; such levy is laid as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 706 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2479 valente k % de 1% de leur liste de paye pour equivalent to of 1% of their payroll as regards les salariés assujettis audit décret.the employees governed by the said decree.b) Les artisans régis par ledit décret numéro b) The artisans governed by the said decree, 706 et amendements doivent verser au' Comité number 706 and amendments, shall pay to the paritaire une somme équivalente k Y de 1% Parity Committee an amount equivalent to Y du salaire établi dans le décret pour le salarie of 1% of the highest wages established in the le plus rémunéré*.decree for employees.c) Les salariés régis par ledit décret numéro c) The employees governed by the said decree, 706 et amendements doivent verser au Comité number 706 and amendments, shall pay to the paritaire une somme équivalente à Y de 1% Parity Committee an amount equivalent to Yï de leur rémunération.of 1% of their remuneration.2.Mode de perception m 2.Mode of collection En vue de faciliter la perception de ces coti- In order to facilitate the collection of these sations, le Comité paritaire met à la disposition assessments, the Parity Committee supplies the des employeurs professionnels des formules de professional employers with report forms on rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous which all particulars required by the said Parity les renseignements exigés par ledit Comité pari- Committee shall be given, taire.L'employeur professionnel doit compléter son Professional employers shall complete and rapport, le signer et le faire parvenir au Comité sign their report and forward it to the Parity paritaire à chaque mois.Committee every month.L'employeur professionnel doit percevoir à la Professional employers shall collect, at the fin de chaque semaine, au nom du Comité pari- end of each week, on behalf of the Committee, taire, le prélèvement imposé à ses salariés au the assessments of their employees by means of moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers, a deduction from their wages.L'employeur professionnel i doit transmettre Professional employers shall forward their son rapport mensuel au Comité paritaire avant monthly report to the Parity Committee on or le 10 du mois suivant la date d'expiration de la before the 10th day of the month following the période pour laquelle il est exigible; ledit rapport date of expiration of the period for which it is doit être accompagné de la cotisation de l'em- requirable; the said report shall be sent together ployeur professionnel et des sommes payables with the assessments of the professional em-au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité plovers and the sums payable to the Parity a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit Committee by their employees.The committee rapport chaque fois qu'il le juge à propos.has the right to demand sworn reports when deemed advisable.Le prélèvement imposé par le présent règle- The assessments imposed by the present by-ment est payable mensuellement par l'employeur law are payable every month by the professional professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise' employers, the artisans and the employees, en demeure au préalable.without notice from the committee.Sur refus d'un employeur professionnel ou Should a professional employer or an artisan d'un artisan de payer ou de donner les rensei- refuse to pay or to give the necessary information, .gnements nécessaires, un avis de cinq (5) jours five (5) days notice shall be given to him to fulfil lui sera donné pour remplir ses obligations his obligations towards the Parity Committee, envers le Comité paritaire.3.Rapport financier 3.Financial report D'accord avec la Loi de la convention collée- Pursuant to the Collective Agreement Act, tive, le Comité paritaire doit présenter un the Parity Committee shall submit a quarterly rapport trimestriel de ses opérations financières report of his financial operations to the Minister au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: of Labour on the following dates: March 31, 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.June 30, September 30 and December 31.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés Hereto annexed is an estimate of the receipts prévus par le Comité paritaire du Camionnage and disbursements of the Comité paritaire du du district de Québec, pour, la période comprise Camionnage du district de Québec, for the entre le 30 juin 1958 et le 30 juin 1959.period between June 30, 1958 and June 30, 1959.Comité paritaire du Camionnage Comité paritaire du Camionnage du district de Québec du district de Québec État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 30 juin 1958 et le 30 juin 1959.Recettes: Cotisations (Y de 1%): Employeurs professionnels.$11,600.00 Salariés.11,600.00 Artisans.1,200.00 Déboursés: Salaire du secrétaire et employés de bureau.$ 7,450.00 Estimate of receipts and disbursements for the period between June 30, 1958 and June 30, 1959.Receipts: Assessments (Y of 1%)': Professional employers.$11,600.00 Employees.11,600.00 Artisans.1,200.00 $24,400.00 Disbursements: Secretary and office employees salaries.$7,450.00 $24,400.00 2480 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N° 29 Salaires des inspecteurs.7,280.00 Frais de déplacements: Inspecteurs.:.900.00 Administration.950.00 Loyer et entretien de bureau.1,500.00 Frais légaux.1,500.00 Papeterie, impressions, timbres, télé- .phone, etc.800.00 Ameublement et accessoires de bureau.500.00 Frais de vérification et banque.200.00 Assurances, publicité et assurance-chômage.500.00 Déplacements du président et des membres, jetons de présence.1,800.00 Dépréciation.400.00 Divers.530.00 $24,400.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 juillet 1958.48178-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre dû Travail, donne avis par les présentes que le Comité conjoint de l'industrie de la peinture, établi en exécution du décret numéro 299 du 5 avril 1956, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 729 du 9 juillet 1958, (section \"D\"), le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et-le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juillet 1958 au 14 avril 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 299 et amendements doivent verser au .Comité paritaire une somme équivalente à 1/10 de 1% des salaires fixes et des pourcentages, bonis et allocations payés à leurs salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 299 et amendements doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 1/10 de 1% du salaire établi pour le salarié compagnon le moins rémunéré, soit $1.21'l'heure (salaire minimum fixé par le décret).c) Les salariés régis par le décret numéro 299 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1/10 de 1% de leur salaire fixe, pourcentage, bonis et allocations.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués les heures de travail, l'argent perçu au cours de la semaine et les sommes versées au Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce que ces rapports soient remplis et retournés au Comité paritaire à tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même le salaire de cha- Inspectors salaries.7,280.00 Travelling expenses: Inspectors.900.00 Management.950.00 Rent and office upkeep.1,500.00 Legal fees.1,500.00 Stationery, Printing, Postage, Telephone, etc.800.00 Office furniture and equipment.500.00 Audition and bank charges.200.00 Insurance, publicity and unemployment insurance.500.00 Travelling expenses of president and members, attendance fees.1,800.00 Depreciation.400.00 Miscellaneous.530.00 $24,400.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quelle.July 19, 1958.48178-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Paint Industry, formed under decree number 299 of April 5, 1956, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 729 of July 9, 1958, (part \"D\"), in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), to collect levies from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned.1.I^evy The period of levy shall extend from July 1, 1958 to April 14, 1959; it shall apply as hereinafter mentioned : a) The professional employers governed by the decree No.299, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 1/10 of 1% of the fixed wages, commissions, bonuses, allocations paid to their employees subject to the said decree.b) The artisans governed by the decree No.299, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 1/10 of 1% of the wages fixed for the least remuneratedjourneyman, i.e.$1.21 per hour (minimum rate fixed by the decree).c) The employees governed by the said decree No.299, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 1/10 of 1% of their fixed wages,'commissions, bonuses and allocations.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these levies, the Parity Committee shall furnish the professional employers with printed forms indicating the hours of labour, the money collected during the week and the sums owed to the Parity Committee.The professiona employer shall have these reports made and returned to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect at the end of every week, from the wages of every one of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2481 cun de ses salariés, les ommes qui reviennent au Comité paritaire.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au Comité paritaire.Ce Comité a le pouvoir d'exiger l'asser-mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.3.Rapport financier Selon les termes de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opératlns financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et .31 décembre Ci-annexé, un état des recettes et «les déboursés probables du Comité Conjoint de l'Industrie «le la Peinture, pour la ]>ériode comprise entre le 1er juillet 1958 et le 14 avril 1959.Le Comité Conjoint de l'Industrie de la Peinture 3000, rue Barclay, Chambre 400, Montréal État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er juillet 1958 et le 14 avril 1959.Recettes: Cotisations (1/10 de 1%): Employeurs professionnels.83,000.00 Salariés.3,000.00 80.000.00 Déboursés: Service du Comité Conjoint des Maté- tériaux de construction (12 mois à $250.00 par mois).$3,000.00 Frais judiciaires et professionnels- 500.00 Dépenses des membres y compris les jetons de présence.1.900 00 Impressions et papeterie.150.00 Divers.450.00 §6,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère «lu Travail, Québec, 19 juillet 1958.48178-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements) que le Comité paritaire de l'Alimentation en Détail de Sherbrooke et Région, établi en exécution du décret numéro 20 du 5 janvier 1955, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 729 du 9 juillet 1958, (section \"A\"), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés régis par ledit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 30 juin 1958 au 30 juin 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels, régis par ledit décret numéro 20 et amendements doivent his employees, the sums owed to the Parity Committee.The report of every professional employer shall be signed before it is sent to 'the Parity Committee.This Committee has the right to demand sworn reports when deemed advisable.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall present a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30, and December 31.Annexed .hereto iian estimate of the receipts and disbursements required by the Joint Committee of the Paint Industry for the period between July 1, 1958 and April 14, 1959.The Joint Committee of the Paint Industry 3000 Barclay Street, Room 400, Montreal Estimate of receipts and disbursements for the period comprised between July 1st, 1958 and April 14, 1959.Receipts: Levies (1/10 of 1%): Professional employers.$3,000.00 Employees.3,000.00 86,000.00 Disbursements: Services from the Building Materials Joint Committee (12 months at $250.00 per nlonth).$3,000.00 Legal and professional expenses.500.00 Representatives expenses including attendance fees.1,900.00 Printing and stationery.150.00 Sundry expenses.450.00 $6,000.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 19, 1958.48178-0 NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), as amended, that the Parity Committee of the Retail Food Trade of Sherbrooke ami Vicinity, formed under decree numl)er 20 of January 5, 1955, has been authorized by a by-laws approved by Oreler in Council number 729 of July 9, 1958, (Part \"A\"), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the following method and rate: 1.Assessments The period of levy extends from June 30, 1958, to June 30, 1959, such levy shall be applied as follows: a) All professional employers governed by the said decree, number 20, and amendments, shall 2482 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N* 99, verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 20 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à de 1% du salaire moyen fixé par le comité à $20.00 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 20 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mob.L'employeur professionnel doit percevoir, à la -fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements' nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la Convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, \"30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de l'Alimentation en Détail de Sherbrooke et région, pour la période comprise entre le 30 juin 1958 et le 30 juin 1959.Le Comité paritaire de l'Alimentation en Détatil de Sherbrooke et région pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1% of their payroll as regards employees governed by the said decree.b) All artisans governed by the said decree, number 20 and amendments, shall pay to the Parity Committee en amount equivalent to Y of 1% of the average wage rate fixed at $20.00 per week by the Committee.c) All employees governed by the said decree, number 20 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which shall be given all particulars required by the said Parity Committee.The professional employer shall complete and sign his report and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of his employees by means, of a deduction from the hitter's wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which it is requirable.The said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and those of his employees.The Committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The levy enacted by the present by-law is payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Should à professional employer or an artisan refuse to pay or to give the necessary information, he will be given five (5) day's notice to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall make a quarterly report of its financial operations and file it with the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Parity Committee of the Retail Food Trade of Sherbrooke and Vicinity, for the period comprised between June 30, 1958 and June 30, 1959.The Parity Committee of the Retail Food Trade of Sherbrooke and Vicinity État des recettes et des déboursés probables pour Estimate of the receipts and disbursements for la période comprise entre le 30 juin 1958 et le the period comprised between June 30, 30 juin 1959.1958 and June 30, 1959.Recettes: Cotisations (Y de 1%): Employeurs professionnels.$ 2,400.00 Artisans.500.00 Salariés.2,400.00 Recettes diverses.200.00 Receipts: Assessments (Y of 1%): Professional employers.$ 2,400.00 Artisans.,.500.00 Employees.2,400.00 Miscellaneous.200.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Déboursés: Salaires : Secrétaire.Disbursements: $1,600.30 Wages: Secretary.$ 1,600.00 QUEBEC OFFICIAL AZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2483 Frais de déplacement: Inspection.1,110.00 Administration.200.00 Loyer du bureau.\\.600.00 Frais légaux.100.00 Papeterie, impressions, timbres, téléphone et télégrammes.200.00 Ameublement et accessoires de bureau.100.00 Vérification des livres.100.00 Assurances et frais de cautionnement 5.00 Frais de déplacement «lu président et des membres.150.00 Jetons de présence aux membres du Comité.400.00 Taxes d'affaires et autres.25.00 Publicité.310.00 Dépenses diverses et imprévues.600.00 $ 5,500.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère «lu Travail, Québec, le 19 juillet 1958.48178-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, établi en exécution du décret numéro 505 du 7 mai 1952, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 729 du 9 juillet 1958, section \"E'\\ le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et «les salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionné : 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juillet 1958 au 30 juin 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 505 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1/6 de \\% «lu salaire total payé à leurs salariés régis par le «léerct, y compris bonis, etc.6) Les salariés régis par le «lécret numéro 505 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente ù 1/6 de 1% de.leur salaire total, y compris bonis, etc.Travelling Expenses f Inspection.1,110.00 Administration.____ 200.00 Office Rent.600.00 Legal Fees.100.00 Stationery, printing, postage, telephone and telegrams.200.00 Furniture and Fixtures.100.00 Auditing.100.00 Insurance and fidelity bond.5.00 Travelling expenses of president and members.150.00 Committee members attendance fees .400.00 Business and other taxes.25.00 Publicity.310.00 Miscellaneous and unforeseen expenses.600.00 S 5,500.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 19, 1958.48178-0 NOTICE OF LEVY \u2014 _ t.The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Furniture Industry of Quebec, established under decree number 505 of May 7th, 1952 has been authorized by by-law approved by Order in Council number 729 of July 9, 1958, partv \"E\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendment), to levy assessments upon the professional employers and employees governed by the said «îecree according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Levy The period of levy shall extend from July 1, 1958 to June 30, 1959; the levy shall apply as hereinafter mentioned : a) The professional employers governed by the decree number 505 and amendments, shall pay to the Joint Committee a sum equivalent to 1/6 of 1% of the total wages paid to their employees governed by the tlecree, including bonuses, etc.b) The employees governed by the said decree, number 505 and amendments, shall pay to the Joint Committee a sum equivalent to 1/6 of 1% of their total wages, including bonuses, etc.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels, des formules «le rapport, lesquelles doivent être remplies selon les règlements du Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce .que ces rapports soient transmis au Comité paritaire tous les mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine à même le salaire de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire, à titre de prélèvement.Le rapport de l'employeur professionnel, accompagné des cotisations doit être signé devant témoin et adressé au Comité paritaire dans un 2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms which must be filled according to the by-laws of the Committee.The professional employer shall see to it that these reports be forwarded to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, from the wages of each one of his employees, the assessments owed to the Parity Committee.The report of the professional employer, together with the assessments, shall be signed and witnessed before it is sent to the Parity Com- 2484 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec,-19 juillet 1958, Tome 90, N° 29 délai de quinze (15) jours après l'expiration de la période pour laquelle il est exigible.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre «lu Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre'.Ci-annexé, un état des recettes -et des déboursés probables du Comité paritaire de l'Industrie du Meuble de Québec, à compter du 1er juillet 1958 au 30 juin 1959.Le comité paritaire de l'Industrie du Meuble de Québec * État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er juillet 1958 et le 30 juin 1959.Recettes: Estimé des gages pour l'année: $15,417,000.00 Cotisations (1/6 de 1%): Employeurs professionnels.$25,700.00 Salariés.25,700.00 $51,400.00 Déboursés: Salaire du secrétaire.$ 4,800.00 Salaires: \u2022Employés de bureau et inspecteurs 25,480.00 Loyer.'.2,400.00 Taxes d'eau et «l'affairés.100.00 Frais de voyage: Inspecteurs et secrétaire.4,580.00 Dépenses des délégués.12,000 00 Téléphone et télégrammes.350.00 Frais légaux.1,600 00 Frais de vérification.400.00 Impression et papeterie.1,800 00 Timbres-poste.500.00 Frais généraux.500.00 Mauvaises créances.'.100.00 Frais bancaires.s.350.00 Actions légales \u2014 réserve.3,000.00 Assurance-groupe.350 00 Assurance-chômage.180 00 $58,490.00 Déficit probable ù être comblé par la réserve accumulée.7,090.00 $51,400.00 Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 juillet 1958.48178-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la Région de Québec, établi en exécution du décret numéro 973 du 30 juin 1948 a été autorisée par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 729 du 9 juillet 1958, section \"C\", .à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés suivant les conditions ci-après décrites: mittee no later than fifteen (15) days after the expiration of the period for which it is exigible.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Joint Committee shall submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour, on t tit- following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Furniture Industry of Quebec, for the period extending from July 1, 1958 to June 30, 1959.Joint Committee of the Furniture Industry of Quebec Estimated budget for the period extending from July 1, 1958< to June 30, 1959.Receipts: Estimate of Annual Wages: $15,417,000.00.Assessments (1/6 of 1%): Professional Employers.$25,700.00 Employees.\u2022 25,700.00 $51,400.00 Disbursements: Secretary's Salary.$ 4,800.00 Salaries: Office and inspectors.25,480.00 Rent.2,400.00 Water and Business Taxes.100.00 Travelling Expenses: Inspectors & Secretory.4,580.00 Expenses: Membres of the Committee 12,000.00 Telephone and telegrams.350.00 Legal Fees.1,600.00 Audition Fees.400.00 Printing & Stationery.1,800.00 Postage.500.00 General Expenses.500.00 Bad Debts.100.00 Bank Fees.350.00 Court actions and reserve.3,000.00 (i roup insu ranee.350.00 Unemployment insurance.180.00 $58.490.00 Estimated deficit to be covered by reserve.7.090.00 $51,400.00 .GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 19, 1958.48178-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, (R.S.Q.; 1941, chapter 163 and amendments), that the Parity Committee of Metal Trades of the Quebec district formed under decree number 973 of June 30, 1948, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 729 of July 9, 1958, part *'C\" to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees, according to the following conditions: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90., No.29 2485 1 Cotisation 1.Assessments La période de cotisation s'étend du 10 juillet 1958 au 10 juillet 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par .ledit décret numéro 973 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro' 973 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à j/£ de 1% du salaire moyen de $36.00 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 973 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels dés formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaireVi chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseigne-, ments nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, ,un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des Métiers de la Métallurgie de la région de Québec, pour la période comprise entre le 10 juillet 1958 et le 10 juillet 1959.Le Comité Paritaire des Métiers de la Métallurgie de la Région de Québec The period of levy extends from July 10, 1958, to July 10, 1959; this levy shall be laid as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 973 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ^ of 1% of their payroll for the employees governed by the said decree.b) The artisans governed by the said decree, number 973 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1% of the average wage of $36.00 per week.c) The employees governed by the said decree, number 973 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee shall supply the professional employers with report forms on which shall be given all the information required by the said Parity Committee.The professional employer shall complete and sign his report, and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments laid upon his employees by means of a deduction from their wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity' Committee on or before the 15th day of the month following the date of expiry of the period for which it is exigible; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to the Committee by his employees.The Committee has the right to demand sworn reports whenever it deems it advisable.The levy enacted by the present by-law is payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice from the Committee.Should a professional employer or an artisan refuse to pay or to give the necessary information, five (5) days' notice will be given to him to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In pursuant of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quartely financial report to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Parity Committee of Metal Trades of the Quebec District for the period between July 10, 1958 and July 10, 1959.Parity Committee of Metal Trades of Quebec District \u2022 État des recettes et des déboursés probables Estimate of the receipts and disbursements for pour la période comprise entre le 10 juillet the period between July 10, 1958 and July 10, 1958 et le 10 juillet 1959.1959.Recettes: Cotisations i}A de 1%): Employeurs professionnels.Receipts: Assessments (Y of 1%): $ 6,870.00 Professional employers.$ 6,870.00 2486 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 Salariés.6,870.00 Artisans.260.00 $14,000.00 Déboursés: Salaires: Secrétaire.$4,535.00 Inspecteur.4,535.00 Frais de déplacement: Inspecteur.200.00 Administration.400.00 Loyer du bureau.480.00 Frais légaux.800.00 Papeterie, impressions, timbres, téléphone.:.350.00 Ameublement et .accessoires de bureau.100.00 Vérification des livres.100.00 Assurance et frais de cautionnement, fonds de pension.700.00 Jetons de présence aux membres du Comité.600.00 Bureau des Examinateurs.800.00 Dépréciation.50.00 Dépenses diverses et imprévues.350.00 $14,000.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 juillet 1958.48178-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité conjoint des barbiers, coiffeurs et coiffeuses de la cité et du district de Hull, établi en exécution du décret numéro 387 du 24 avril 1958, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 729 du 9 juillet 1958, section \"G\", le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend de la date de publication du présent règlement dans la Gazette officielle de Québec au 1er septembre 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 387 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Vz de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) tes artisans régis par ledit décret numéro 387 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit $35.00 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 387 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de leur rémunération.Employees.6,870.00 Artisans.260.00 $14,000.00 Disbursements: Salaries: Secretary.$4,535.00 Inspectors.4,535.00 Travelling expenses: Inspectors.200.00 Administration.400.00 Office rent.480.00 Legal fees____.800.00 Stationery, printing, postage, telephone.350.00 Furniture and office equipment.100.00 Audition.____.100.00 Insurance and fidelity bond and pension fund.700.00 Meeting expenses of committee members.600.00 Board of examiners.800.00 Depreciation.50.00 Miscellaneous and unforeseen expenses.350.00 .$14,000.00 * GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 9, 1958.48178-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour; hereby gives notice that \"Le Comité paritaire des barbiers-coiffeurs de Hull\", formed under decree number 387 of April 24, 1958, has been authori :ed by a by-law approved by Order in Council number 729 of July 9, 1958, part \"G\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 103 and amendments), to levy assesstments, from the professional employers, the artisans and the employers governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentionc: 1.Assessments The period of levy extends from the date of gazetting of the present by-law to September 1, 1959; it is laid in the following manner; a) The professional employers governed by decree number 387, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y of 1% of the regular wages, commissions, bonuses and allocations paid to their employees governed by the decree.b) The master barbers or female hairdressers working alone (artisans) governed by decree number 387, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y of 1% of their receipts based upon the amount of $35.00 per week (lowest wage rate fixed by the decree for journeymen).c) The employees governed by decree number 387, shall pay to the Parity Committee and assessment equivalent to Y of 1% of their remuneration. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol 90, No.29 2487 2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement1 imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, Partisans et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin.30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé.un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire des barbiers-coiffeurs de Hull, pour la période comprise entre le 10 mai 1958 et le 1er septembre 1959.Le Comité paritaire des Barbiers-coiffeurs de Hull État des recettes et des déboursés probables pour la période se terminant le 1er septembre 1959.Recettes: Cotisations fj^de 1%): Employeurs professionnels.$100.00 Artisans.260.00 Salariés.100.00 $460.00 Déboursés: Salaire du secrétaire.$ 40.00 Frais de déplacement \u2014 inspecteurs .40 00 Loyer de bureau,.50.00 Papeterie, impressions, timbres, téléphone et télégrammes.14.00 Vérification des livres.60.00 Frais de déplacement du président et des membres.40.00 Jetons de présence aux membres du comité.216.00 $460.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 juillet 1958.48178-o 2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all.particulars required by the said Parity committee shall be given.The professional employer shall complete and sign his report and forward it to the Parity committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the committee, the assessments of his employees by means of a deduction from the latter's wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity committee on or before the 15th of the month following the date of expiration of the period for which it is requirable.The said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and those of the employees.The committee has the right to demand sworn reports when deemed advisable.The assessments laid by the present by-law are payable every month .by the professional employee, the artisan and the employee, without notice.Upon refusal by a professional employer or an artisan to pay or to give the necessary information, five (5) days' notice will pe given to them to fulfil their obligations towards the Parity committee.3.Financial report Pursuant to section 21 of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall present a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of \"Le Comité paritaire des barbiers-coiffeurs de Hull\", for the period between May 10, 1958 and September 1, 1959.Le Comité Paritaire des Barbiers-Coiffeurs de Hull Estimate of the receipts and,disbursements for the period ending September 1, 1959.Receipts: Assessments of 1%): Professional employers.$100.00 Artisans.260.00 Employees.100.00 $460.00 Disbursements: Secretary's services.$ 40.00 Travelling expenses \u2014 inspectors.40 00 Office rent.50.00 Stationery, stamps, office equipment.14 00 Auditing of books.60.00 Travelling expenses of chairman and members.40.00 Committee members' attendance fees.216.00 $460.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 19, 1958.48178-o 2488 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N\" 29 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163*et amendements), que le Comité paritaire du Commerce de Détail d'Asbestos, établi en exécution du décret numéro 622 du 20 juin 1951, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 729 du 9 juillet 1958, section \"H\", à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des salariés et des artisans assujettis audit décret et ses amendements, suivant la méthode et le taux ci-après décrits: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 30 juin 1958 au 30 juin 1959; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: o) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 622 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret, (salaires fixes, pourcentages, allocations, commission ou bonis payés).b) Les artisans régis par ledit décret numéro 622 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit $30.00 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 622 et amendements doivent verser au Comité Eiritaire une somme équivalente à Y de 1% de ur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis payés).2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 de chaque mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables par ses salariés.Le Comité paritaire a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport, chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèfement imposé par le présent règlement est payable mensuellement, par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure aU préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements -nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the Joint Committee of the Retail Trade of Asbestos, formed under decree number 622 of June 20, 1951, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 729 of July 9, 1958, part \"H\", to levy assessments upon the professional employers, the employees and the artisans governed by the said decree and its amendments, according to the method and rate herenafter described : k 1.Assessments The period of levy extends from June 30,1958 to June 30, 1959; the levy shall be.applied as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 622 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to.Y of 1% of their payroll in respect of all employees governed by the said decree (regular wages and percentages, allowances, commisssions or bonuses paid).b) The artisans governed by the said decree, number 622 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1% of the lowest wages established in the decree for journeymen, i.e.$30.00 per week.c) The employees governed by the said decree, number 622 and amendments, shall pay.to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1 % of their remuneration (regular wages and percentages, allowances, commissions or bonuses paid).2.Mode of collection In order to\" facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all particulars required by the said Parity Committee shall be given.Professional employers shall complete and sign their report, artd forward it to the Parity Committee every month.Professional employers shall collect, at the en of each week, in the name of the Committee, the assessments of their employees by means of a deduction from their wages.Professional employers shall forward their monthly report to the Parity Committee on or before the 15th of the month following the date of expiration of the period for which it is requi-rable; the said report shall be sent with the assessments of the professional employers and those of their employees.The Committee has the right to demand sworn reports when deemed advisable.* The levy laid by the present by-law is payable every month by the professional employers, the artisans and the employees without notice from the Committee.Should a professional employer or an artisan refuse to pay or to give the necessary information, he shall be notified to do so within five (5) days.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la Convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au 3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Committee shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial operations, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2489 Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire du Commerce de Détail d'Asbestos, pour la -période comprise entre le 30 juin 1958 et le 30 juin 1959.Le Comité Paritaire du Commerce de Détail d'Asbestos Siège social: Asbestos, Que.État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 30 juin 1958 et le 30 juin 1959.Recettes: Cotisations: Employeurs professionnels.$1,055.00 Salariés.1.055.00 Artisans.370.00 $2,480.00 Déboursés: Secrétariat.$ 1,520.00 Administration.120 00 Frais légaux.40.00 Papeterie, timbres, etc.60.00 Vérification des livjes.54.00 Jetons 'de présence.520.00 Dépenses diverses et imprévues.110.00 $2,424.00 Surplus prévus.56.00 $2,480.00 Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 juillet 1958.48l78-o Avis d'approbation de règlements L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément -aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que, par l'arrêté en conseil numéro 728-E du 9 juillet 1958, deux règlements spéciaux du Comité conjoint des matériaux de construction, établi en exécution du décret numéro 324 du 30 mars 1950 et chargé de surveiller l'observance du décret numéro 660 du 19 juin 1958, ont été approuvés et ajoutés à la constitution et aux règlements généraux' dudit Comité paritaire déjà approuvés par l'arrêté en conseil numéro 625-D du 31 mai 1950.En vertu de la Loi, les dispositions suivantes desdits règlements spéciaux ont été déclarés obligatoires.\"Certificat de qualification: D'accord avec l'article 25 de la Loi de la convention collective, le Comité conjoint des matériaux de construction décide de rendre le certificat de qualification obligatoire pour toute personne employée comme mécanicien, ajusteur, forgeron, monteur et apprenti dans la zone I de la juridiction territoriale du décret numéro 660 du 19 juin 1958, relatif à l'industrie du fer et du bronze d'ornementation, dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observance.Bureau d'Examinateurs: Les certificats de qualification seront émis par le bureau d'examinateurs composé de cinq (5) membres désignés par les parties contractantes à la convention on the following dates: March 31, June 30» September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Retail Trade of Asbestos for the period between June 30, 1958 and June 30, 1959.-The Joint Committee op the Retail Trade of Asbestos Head Office : Asbestos, Quebec.Estimate of the receipts and disbursements for the period between June 30, 1958 and June 30, 1959.Receipts: Assessments: Professional employers.$1,055.00 Employees.1,055.00 Artisans.370.00 $2,480.00 Disbursements: Secretary's office.$1,520.00 Administration.120.00 Legal fees.40.00 Stationery, postage, etc.60.00 Audition.54.00 Meeting expenses.520.00 Various and unforeseen expenses.110.00 $2,424.00 Probable surplus.56.00 $2,480.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 19, 1958.48178-o Notice of Approval of By-Laws The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that, by Order in Council number 728-E of July 9, 1958, two special by-laws of the Building Materials Joint Committee, formed under decree number 324 of March 30, 1950, and entrusted with the administration of the decree number 060 of June 19, 1958, have been approved and added to the constitution and general by-laws of the said Joint Committee, already approved by Order in Council number 625-D of May 31, 1950.In pursuance of the terms of the Act, the following provisions of the said special by-laws have been rendered obligatory: \"Certificate of competency: The Building Materials Joint Committee decides, in conformity with section 25 of the Collective Agreement Act, that the certificate of competency be rendered obligatory for any person engaged as mechanic, fitter, blacksmith, erector and apprentice in zone I of the territorial jurisdiction of decree number 660 of June 19, 1958, relating to the ornemental iron and bronze industry, which is administered by the said Committee.Board of Examiners: Such certificate of competency shall be issued by the Board of Examiners composed of five (5) members appointed by and representating the contracting parties to the 2490 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 collective de travail rendue obligatoire par le collective Labour agreement rendred obligatory décret.\" by the said decree.\" Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 19 juillet 1958.48178-o Quebec, July 19, 1958.48178-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 103 et amendements) que la Section de Hull et du district de la Corporation des Maîtres-Électriciens de la province de Québec et le Syndicat des Travailleurs en Construction de la Vallée de l'Outaouais lui ont présenté une requête à l'effet de rendre obligatoire les dispositions d'une convention collective de travail intervenue en eux.A cet effet, une nouvelle section \"E\" sera ajoutée au décret numéro 810 du 14 août 1957, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Hull, laquelle section se lira comme suit: NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that The Branch of Hull and District of the Corporation of Master Electricians of the Province of Quebec, and Le Syndicat des Travailleurs en Construction de la Vallée de l'Outaouais have petitioned' lîim to render obligatory a collective labour agreement entered into between them.To that effect, a new section \"E\" will be added to decree No.810 of August 14, 1957, relating to the construction industry and trades in the region of Hull, which .section will read as follows: Section \"E\" Part \"E\" Dispositions spéciales concernant le metier d'électricien I.a) Juridiction professionnelle: La présente section s'applique à tout travail de construction exécuté et soumis à la Loi concernant les électriciens et les installations électriques (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 172 et amendements).Cependant, la présente section ne s'applique pas aux mécaniciens de brûleurs à l'huile.b) Juridiction territoriale: Pour les fins de la Ërésente section, la zone I comprend la cité de [ull et un rayon de quarante (40) milles de ses limites.IL Taux minima de salaires: Les taux minima de salaires sont Je s suivants: Zones Entrepreneur maître-électricien I II travaillant comme salarié et Par heure détenteur de la licence \"A\" ou \"B\", qu'il utilise ses outils ou agisse comme contremaître ou remplisse toute autre fonction de surveillance.$3.75 $2.25 Special provisions concerning the electrical trade I.a) Professional Jurisdiction: The present part applies to and is effective in all work executed and governed by the Electricians and Electrical Installations Act (R.S.Q.1941 chapter 172 ami amendments).However, the present part does not apply to oil-burner-mechanics.b) Territorial Jurisdiction: For the purposes of the present par, zone I comprises the city of Hull and a radius of forty (40) miles from its limits.II.Schedule of wage rates: The following minimum wage rates shall be payable: Contracting Master Electrician working as an employee and holding license \"A\" or \"B\", whether be uses his tools or acts as foreman or fulfils any other supervisory functions.Zones I II per hour .75 $2.25 Compagnon-électricien, détenteur de la Licence \"C\".1.95 1.45 A compter du 1er septembre 1958.2.10 A compter du 1 er décembre 1958 2.25 A compter du le.mars 1959.2.32 Apprentis: Les taux de salaires payables aux apprentis .sont fixés suivant le pourcentage du salaire minimum légal payé au compagnon électricien.Ce pourcentage de rémunération est le suivant: Zones I II lèe année.40% 40% 2ème année____,.50% 60% 3ème année.65% 75% 4ème année.80% 90% i III.Durée régulière du travail: a) La durée régulière de travail pour les compagnons et les apprentis électriciens est de huit (8) heures par jour, distribuées entre 8.00 a.m.et 5.00 p.m.les Electrical journeyman holding license \"C\".1.95 1.45 From September 1, 1958.2.10 From December 1, 1958.2.25 From March 1, 1959.*.2.32 Apprentice: Rates of wages paid to apprentices shall be fixed according to the following percentage of legal minimum wages paid to electrical journeymen: Zones I II 1st year.40% 40% 2nd year.50% 60% 3rd year.65% 75% 4th year.80% 90% \u2022III.Regular duration of labour: a) Regular duration of labour for electrical journeymen and apprentices shall be eight (8) hours per day between 8.00 a.m.and 5.00 p.m.on Mondays, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2491 lundi', mardi, mercredi, jeudi et vendredi, le tout devant constituer une durée hebdomadaire de quarante (40) heures.b) Cependant, dans la zone II, la durée régulière de travail est de neuf (9) heures par jour entre 7.00 a.m.et 5£ 57.00 1.45 58.00 Finisseur-A \u2014 Finisher-A.1.60 64.00 1.62»* 65.00 Finisseur-B - Finisher-B.137^ 55.00 1.40 \u2014 56.00 Bloqueur-Faconneur-A \u2014 Blocker-Trimmer-A.\\ A2}4 57.00 1.50 60.00 Bloqueur-Façonneur-B - Blocker-Trimmer-B.1.15 46.00 \\ .22x/2 49.00 Examinateur-A \u2014 Examiner-A.152^ 61.00 1.55 62.00 Examinateur-B \u2014 Examiner-B.1.27^ 51.00 1.30 52.00 Couturière à la machine-A'\u2014Female operator-A.1.40 56.00 1.45 58.00 Couturière à la machine-B \u2014 Female operator-B.1.17)4 47.00 1.20 48.00 Finisseuse-A - Female finisher-A.1.35}£ 54.20 1.35>2 54.20 Finisseuse-B \u2014 Female finisher-B.1.15 46.00 1.17^2 47 00 Fermeu r de manteaux \u2014 Coat closer.1.75^ 70.20 1.75V2 70.20 Fermeuse de manteaux \u2014 Coat closer.1.40 56.00 1.45 58.00 Opératrice et coupeuse de doublures \u2014 Female operator and lining cutter.1.29)4 51.80 1.29>i 51.80 Coupeuse de doublures \u2014 Female lining cutter.1.24>£ 49.80 1.24j/£ 49.80 Opératrice de doublures \u2014 Female lining maker.\\.\\2\\4 45.00 1.1214 45.00 Finisseuse contremaîtresse \u2014 Finishing foreladies.1.43)^ 57.40 1.45 5S.00 6) Apprentis des deux sexes: Le stage d'appren- b) Male and female apprentices: The appreiif tissage est divisé en six (6) périodes de six (6) ticeship period is divided in six (6) periods o mois, et les salaires minima sont les suivants: six (6) months and the minimum wage rates are as follows: 1ère année.1er semestre \u2014 1st year, 1st six months.\\.$0.67H $ 27.00 $0.67U S 27 00 1ère année.2c semestre \u2014 1st year, 2nd six months.0.7214 29.00 0.72^ 29.00 2e année.1 er semestre \u2014 2nd year, 1 st six months.0.77K 31.00 0.77>£ 31.00 2e année.2e semestre \u2014 2nd year, 2nd six months.0.87>é 35.00 0.87^ 35 00 3e année,.1er semestre \u2014 3rd year, 1st six months.0.97^2 39.00 0.97)4 39.00 3e année.2e semestre \u2014 3rd year, 2nd six months.1.07>£ 43.00 1.07^ 43.90 2494 ' GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N° 29 V N.B.\u2014 Ce deuxième semestre de la 3e N.B.\u2014 This 2nd six months of the 3rd year année ne s'applique pas aux apprentis coupeurs, does not apply to apprentices-cutters^for then car ils entrent alors dans leur catégorie particu- they enter in their special category of \"Appren- lière- \"Apprentis coupeurs\" 1ère année, 1er se- tice cutters\" 1st year, 1st six months: $43.00.mestre: $43.00.Apprentis coupeurs: Le stage d'apprentissage Apprentices-cutters: The period of apprentice-pour les coupeurs est divisé en six (6) périodes de ship is divided into six (0) periods of six months 6 mois, et les salaires minima sont les suivants: and the minimum rates of wages shall be as follows: 1ère année.1er semestre \u2014 1st year.1st six months 1ère année.2e semestre \u2014 1st year, 2nd six months 2c année, 1er semestre \u2014 2nd year, 1st six months.2e année, 2e semestre \u2014 2nd year, 2nd six months.3e année, 1er semestre \u2014 3rd year, 1st six months.3e année, 2e semestre \u2014 3rd year, 2nd six months.c) Sécurité sociale: Tous les employés, doivent c) Social security: All employees shall receive recevoir, chaque semaine, une rémunération each week, a remuneration equal to 2.75% of égale à 2.75% de leurs salaires à titre de sécurité their wages as social security benefit, sociale.Tout employeur qui, par contrat avec une Kvery employer who.by contract with a compagnie d'assurance reconnue et bona fide recognized and bona fide insurance company or ou avec une caisse d'assurance reconnue par with an insurance fund recognized by the Insu-le Surintendant des Assurances de la province de ranee Superintendent of the Province of Quebec Québec, ou qui.par contrat avec une association or who.by contract with a bona fide association bona fide est tenu de payer et paye une somme is bound to pay and does pay a sum equivalent équivalente à 2.75% du salaire total de ses to 2.75% of the tojal wages of his employees employés assujettis à la juridiction de ce décret, regulated by the decree under a social security en vertu d'un projet de sécurité sociale couvrant plan covering, in whole or part, cases of illness, en tout ou en partie les cas de maladie, d'acci- accident, hospitalization, death or retirement is dent, d'hospitalistion, de mortalité ou plan de not required to pay the remuneration of 2.75% pension, n'est pas tenu de payer la rémunération provided under this paragraph \"c\".de 2.75% prévue dans cedit paragraphe \"c\".Un employeur peut instituer un plan de mala- An employer may set up a sickness, accident, die, d'accident, d'hospitalisation, de mortalité hospitalization, death or pension plan for his ou plan de pension au bénéfice de ses salariés, employees .as above, descrilied which will cost de la façon ci-haut décrite dont le coût est infé- less than 2.75% of the employees' wages but he rieur à 2.75% mais il doit payer la différence shall pay the difference Ivetween the cost such entre le coût de tel plan et les 2.75% du salaire a plan and the amount equivalent to 2.75% of de ses salairiés et ce, en espèces, chaque semaine, the employees' wages and such payment shall be paid in cash, each week.Tout plan de bien-être social de cette nature Every social welfare plan of this nature insti-institué par un employeur de la façon susdite, tuted by an employer as above described is est sujet à examen par le comité paritaire et les subject to inspection by the Parity Committee registres de l'employeur s'y rapportant doivent and the employer's books concerning such plan en tout temps être tenus à la disposition des shall be at all times at the disposal of the repre-représentants du Comité paritaire pour fins sentatives of the Parity Committee for inspec-d'inspection et d'examen.tion and examination purposes.Si un tel examen révèle au Comité paritaire Should such an examination reveal that the que le paiement par l'employeur d'une somme payment by the employer of a sum equal to égale à 2.75% n'est pas entièrement utilisé au 2.75% has not been used entirely to the benefit bénéfice de ses salariés ou que le but de tel plan of his employees, or that the purpose of such de bien-être social n'est pas conforme à l'esprit social welfare plan is not in conformity with the et aux fins de cette clause, ou si l'employeur refuse spirit and purpose of this provision, or should de donner les détails ou de soumettre les registres an employer refuse to give details or to show the de tel plan, ledit comité peut alors aviser l'em- books of such plan, then the Committee may no-ployeur par lettre recommandée et ce dernier tify the employer through registered letter and doit payer la pleine rémunération de 2.75% the latter shall pay the full remuneration of à compter de la date d'un tel avis.\" 2.75% from the date of such notice.\" 4° L'article XI sera remplacé par le sui- ¦ 4.Article XI will be deleted and the follow-vant: ing substituted therefor: \"XI.a) Pas de travail à domicile: Défense est \"XI.a) No home work: No employer shall faite à l'Employeur d'autoriser ses employés à authorize his employees to bring fur work out-apporter du travail de la fourrure à l'extérieur Side the shop, let it be for his own benefit or de l'atelier, que ce soit pour son propre bénéfice that of his employees.ou pour celui de ses employés.Nor shall employees do home work on a con- Défense est faite également aux employés de tract or sub-contract basis or on their own ac-la fourrure de travailler à domicile, soit à contrat, count, à sous-contrat ou pour leur propre compte.A partir du 1er m'ai 1959 From May 1, 1959 Heure Semaine Heure Semaine per hour per week per hour per week $1.07*4 * 43.00 $1.0714 $ 43.00 1.17}| 47.00 \\.171A 47.00 1.27)| 51.00 1.2713 51.00 1.37)$ 55.00 1.37)1 55.00 1.473$ 59.00 1.47)$ 59.00 1.62)$ 65.00 1.62K, 65.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90.No.29 2495 h) Contrats individuels: Aucun Employeur ne fera de contrat individuel avec son ou ses employés, ni n'exigera ou n'acceptera des dépôts en argent ou autres sortes de garantie de quel-qu'employé que ce soit, ni ne conviendra d'un arrangement avec un employé en particulier pour garnatir une période quelconque de travail.c) Contrat et sous-contrat: Tout travail à contrat, à sous-contrat ou à la pièce est prohibé à l'intérieur de l'atelier dd l'Employeur, et aussi à l'extérieur dudit atelier.De plus aucune personne assujettie à la présente'convention ne peut être autorisée à donner du travail de la fourrure à contrat, à sous-contrat ou à l'extérieur de son atelier.Nonobstant ce qui précède, il est permis de fournir du travail de la fourrure à un contracteur ou à un sous-contracteur pourvu que ceux-ci détiennent un licence municipale ou provinciale appropriée à leur commerce, payent la taxe d'affaires, et soumettent au Comité paritaire de la fourrure au détail un rapport mensuel mentionnant les noms et adresses de leurs employés, les salaires et les heures de travail, le nom et l'adresse de l'Employeur qui leur fournit du travail, ainsi que toutes autres informations que le Comité paritaire jugera utiles à la bonne administration du décret.De plus les employeurs devront s'abstenir en tout temps de faire exécuter du travail de la fourrure à l'extérieur de leur atelier, sauf les cas où les employés refusent de faire du travail supplémentaire ou ne peuvent, même en faisant tel'travail, remplir à temps les commandes de l'employeur.\" 5° L'article IX sera remplacé par le suivant: \"IX.Vacances payées: a) Les salariés doivent bénéficier de vacances payées pour le travail accompli durant la période comprise entre le 1er juin d'une année et le 31 mai de l'année suivante, aux conditions ci-après: Tout salarié régi par le présent décret a'droit à un congé annuel continu d'une durée dejqua-torze (14) jours et rémunéré de la façon suivante: soit 4% du revenu total gagné durant la période comprise entre le 1er juin}; d'une année et le 31 mai de l'année suivante.h) Un salarié présentement assujetti audit décret et ayant travaillé pour plus d'un employeur assujetti au même décret, peut réclamer de chacun d'eux des vacances payées, en proportion du\" temps qu'il a été à leur emploi et tel que prévu au paragraphe \"a\" du présent article.c) Tout salarié qui quitte volontairement le service de son employeur, durant la période comprise entre le 1er août et le 15 janvier de l'année suivante, pour toutes causes, excepté la maladie, ou le mariage, perd le droit de réclamer de son employeur les vacances prévues dans cet article.* d) Tout salarié qui est congédié à raison d'une condamnation pour vol chez son employeur, perd le droit de réclamer les vacances prévues dans cet article.e) Les vacances doivent être accordées et prises entre le 1er juin et le 31 août mais, sur demande du salarié avec le consentement de l'employeur, le Comité paritaire peut autoriser une autre période.Dans ces cas, cependant, le paragraphe \"c\" du présent article ne peut jouer\".La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date h) Individual contracts: No employer shall enter into individual contracts with his employee or employees, nor shall he accept cash deposits or other kinds of guarantee from any employee, nor shall he conclude any agreement with an individual employee to guarantee any period of work.c) Contracts and sub-contracts: All work on a contract, sub-contract or piece-work basis is prohibited inside or outside the shop of the employer.Also, no one regulated by the present agreement may be authorized to give fur work on a contract or sub-contract basis or work to be 'executed outside his shop.Notwithstanding the foregoing, fur work may be given to a contractor or sub-contractor providing he holds an appropriate municipal or provincial trade license, he pays the business tax and he submits to the Joint Committee of the Retail Fur Trade a monthly report giving the names and address of their employees, the wages and hours of work, the name ami address of the employer giving out the work*as well as any other particulars which the Parity Committee may deem useful for the proper enforcement of the decree.Furthermore, employers shall not give fur trade work to be executed outside their establishment except when employees refuse to work overtime or cannot, even when working overtime, do all the work requested by employers.\" 5.Article IX will be replaced by the following: \"IX.Vacation with pay: a) The employees shall benefit by a vacation with pay for work done during the period comprised between the 1st of June of one year and the 31st of May of the following year, pursuant to the following conditions: Every employee governed by the present decree is entitled to a continuous yearly vacation of fourteen (14) days with pay equivalent to 4% of the total wages earned during the period comprised between June 1st of one year and May 31st of the following year.b) An employee now governed by the said decree who has worked for more than one employer governed by the same decree may claim from each one of his employers a vacation with pay in proportion to the period worked in their employ and as provided for in subsection \"a\" of the present section.c) Every employee voluntarily leaving the service of his employer in the period between August 1st and January 15th of the following year for any cause other than illness or marriage, loses his right to claim from his employer the vacation provided for in this section.d) Every employee dismissed by reason of theft loses the right to claim the vacation provided for in this section.e) Vacations shall be granted and taken between June 1st and August 31st but, upon request from an employee and with the employer's consent, the Parity Committee may authorize another period.In this case, however, subsection \"c\".of the present section shall not apply.\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments can only be rendered obligatory by an Order-in-Council which comes into force on the 2496 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle dé Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail.Québec, le 19 juillet 1958.48178-0 date of its publication in the Québec Officia Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 19.195;>.48178-o Action en- separ.ition de biens Canada, province de Québec, district .de Montréal, Cour Supérieure, N° 450,573.Dame Louise Bédard, épouse commune en biens de Clément Marcil, des cité et district de Montréal, demanderesse; v.s Ledit Clément Marcil, des cité et district de Montréal, défendeur.AVIS Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 10 juillet 1958.Montréal, ce 11 juillet 1958.Les Procureurs de la demanderesse, 48184-o TRAHAN, HODGE & TRUDELLE.Action for separation as to property Canada.Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.450,573.Mrs Louise Bédard, wife common as to property of Clément Marcil, residing and domiciled in the City and district of Montreal, plaintiff; vs the said Clément Marcil, residing and domiciled in the city and district of Montreal, defendant.NOTICE An action in separation of property has been instituted in this case, on July 10th, 1958.Montreal, this 11th day of July, 1958.TRAHAN, HODGE & TRUDELLE, 48184-o Attorneys of plaintiff.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 728 Section \"A\" Québec, le 9 juillet 1958.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant des modifications au décret relatif au commerce de l'alimentation au détail dans la région de Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative au commerce de l'alimentation au détail dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 1658 du 17 mai 1944, amendé par les arrêtés en conseil numéros 1922 te 2200 des 24 mai et 8 juin 1945, 3578 du 6 septembre 1946, 615-G et 1907-E des 10 avril et 19 novembre 1947, 1078-B et 1720-C des 12 août et 16 décembre 1948, 787-C du 20 juillet 1949, 225-C et 737-C des 22 février et 21 juin 1950, 640-B du 20 juin 1951, 138-D, 590, 805-C, 9'62-C et 1226-A des 27 février, 21 mai, 30 juillet, 25 septembre et 19 novembre 1952, 173-A et 1085-C des 19 février et 24 septembre 1953, 1065-E du 3 novembre 1954, 555-D du 18 mai 1955, 644-G et 1207-B des 26 juin et 19 décembre 1957, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 10 mai 1958; Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 728 Part \"A\" Quebec, July 9, 1958.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the decree relating to the food products retail trade in the region of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement, relating to the food products retail trade in the region of Quebec, rendered obligatory by the decree number 1658 of May 17, 1944, amended bv the Orders in Council numbers 1922 and 2200 of May 24 and June 8, 1945, 3578 of September 6, 1946, 615-G and 1907-E of April 10 and November 19, 1947, 1078-B and 1720-C of August 12 and December 16, 1948, 787-C of July 20, 1949, 225-C and 737-C of February 22 and June 21, 1950, 640-B of June 20, 1951, 138-D, 590, 805-C, 962-C and 1226-A of February 27, May 21, July 30, September 25 and November 19, 1952, 173-A and 1085-C of February 19 and September 24, 1953, 1065-E of November 3, 1954, 555-D of May 18, 1955, 644-G and 1207-B of June 26 and December 19, 1957, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant Governor in Council some amendments to the said decree : Whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of May 10, 1958; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2497 Attendu que les objections formulées ont Whereas the objections set forth have been été appréciées conformément à la Loi;.duly considered, as required by the Act; Il est ordonne, en conséquence, suHa pro- It is ordained, therefore, upon the recommen-position de l'honorable Ministre du Travail: dation of the Honourable the Minister of Labour; Que ledit décret, numéro 1658, soit modifié That the said decree, number 1658, be amend-comme suit: ed as follows: 1° La Section des Produits alimentaires de 1.\"La Section des Produits Alimentaires\" l'Association des Marchands Détaillants du of the Retail Merchants Association of the District de Québec est acceptée comme partie District of Quebec is accepted as contracting contractante de première part et remplace, à ce party of the first part and replaces \"La Section titre, la Section des Marchands de Produits des Marchands de Produits Alimentaires\" of the Alimentaires de l'Association des Marchands Retail Merchants Association of Canada, Inc., Détaillants du Canada, Inc., District de Québec, District of Quebec and \"La Section des Mar-et la Section des Marchands de Lévis de l'Asso- chands de Levis\" of the Retail Merchants Association des Marchands Détaillants du Canada, ciation of Canada, Inc., District of Quebec.Inc., District de Québec.2° Le paragraphe \"b\" de l'article I est rem- 2.Paragraph \"b\" of article I is replaced by placé par le suivant: the following: \"/>) Le terme \"produits alimentaires\" désigne \"b) The term \"food products\" means and tous produits d'alimentation, tels que viande includes any food product such as cooked or cuite ou crue, charcuterie, poisson,* épiceries, raw meat, pig meat, fish, grocery, vegetables, légumes, bonbons, fruits, liqueurs, bière et tous bonbons, fruits, soTt drinks, beer, and all other autres produits communément vendus dans les products commonly sold in establishments établissements assujettis au décret.\" regulated by the present decree.\" 3° Les paragraphes \"a\", \"6\", \"c\", \"d\" et V* 3.Paragraphs \"a\", \"6\", \"c\\ \"d\" and \"e\" de l'article III sont remplacés par les suivants: of article III are replaced by the following: \"a) La semaine régulière et normale de \"a) The regular and standard work week in travail dans les établissements assujettis au the establishments governed by the present decree présent décret est de quarante-neuf (49) heures shall consist of forty-nine (49) hours, distributed réparties comme suit: as follows: 1.Le lundi: de 1.00 p.m.à 6.00 p.m.; toute- 1.Monday: from 1.00 p.m.to 6.00 p.m.; fois si, durant la semaine, il y a un jour chômé et however, should there occur in the week a holiday payé, le lundi précédant le travail sera de 8.00 with pay, working hours on the preceding Mon-a.m.à 6.00 p.m.; day shall be from 8.00 a.m.to 6.00 p.m.; 2.Les mardi, mercredi, jeudi: de 8.00 a.m.à 2.Tuesday, Wednesday, Thursday: from 8.00 6.00 p.m.; a.m.to 6.00 p.m.; 3.Le vendredi: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.; 3.Friday: from 8.00 a.m.to 9.00 p.m.; 4.Le samedi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; 4.Saturday: from 8.00 a.m.to 0.00 p.m.; 5.Le Vendredi-Saint, les heures de travail 5.On Good Friday, hours of work shall be sont de 8.00 a.m.à 1.00 p.m.et de 0.00 p.m.à from 8.00 a.m.to 1.00 p.m.and from 6.00 p.m.9.00 p.m.to 9.00 p.m.0.Cependant, durant les mois de juillet et 6.However, during months of July and août le travail se termine à 5.00 p.m.le samedi.August, work shall cease at 5.00 p.m.on Saturday.b) Pendant la période des fêtes, soit trois (3) 6) For the holidays period, i.e.three (3) jours ouvrables avant la veille de Noël et deux working days before Christmas Eve and two (2) (2) jours ouvrables avant la veille du Premier de working days before New Year's Eve, including l'An, y compris la veille des autres jours chômés, the eve of the other holidays, the working hours les heures de travail peuvent être prolongées may be extended until 9.00 p.m., and regular jusqu'à 9.00 p.m., le salarié régulier n'ayant droit employees shall not be entitled to any remu-à aucun salaire pour le travail exécuté durant neration for work performed during such overtime telles heures additionnelles.Cependant, la veille hours.However, on Christmas and New Years' de Noël et du Premier de l'An, tout travail doit eves, work shall cease at 6.00 p.m.cesser à 6.00 p.m.¦ c) En dehors des heures mentionnées ci-haut c) \"Outside the hours above mentioned and on et durant les jours de fêtes chômées, un salarié holidays, an employee shall not work at the sale ne peut travailler à la vente des produits ali- of food products at the counter, by telephone or mentniics au comptoir ou par téléphone ni en delivery and employers or professional employers faire la livraison, et un employeur ou un em- shall not work or cause an employee to work at ployeur professionnel ne peut faire travailler un the sale of food products at the counter, by salarié à la vente des produits alimentaires au telephone or delivery.comptoir, par téléphone ou à leur livraison.d) Jours de fêtes chômés: Tout employé régu- d) Observed holidays: Every regular employee lier doit être rémunéré au taux régulier ou au shall receive the regular rate of pay or the rate taux de salaire qui lui est actuellement payé, si actually paid to him, if the latter is higher than ce dernier taux est supérieur à celui du décret, the one fixed by the decree, for the following pour les jours de fêtes chômés suivants: le observed holidays: New Year's Day, January 2, Premier de l'An, le 2 janvier, l'Epiphanie, le Epiphany Day, Ascension Day, St.JeanBaptis-jour de l'Ascension, la Saint-Jean-Baptiste, le te Day, Confederation Day, Labour Day, All jour de la Confédération, la fête du Travail, la Suints' Day, Immaculate Conception Day, Toussaint, l'Immaculée Conception, le jour de Christmas Day and December 20 and all days Noël et le 26 décembre et tous les autres jours, other than the observed holidays which are not autres que les jours chômés non mentionnés mentioned above during which the establishment ci-haut, où l'employeur tient son établissement of the employer is closed, provided the em-fermé, en autant que l'employé aura travaillé la ployer is closed, provided the employee has veille et le lendemain du.jour chômé.worked the day before and the day after the day off. 2498 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 Lorsque le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le jour de la Confédération et le 2 janvier tombent un dimanche, lé lundi suivant immédiatement est chômé et payé.Si les autres jours de fêtes chômés énumérés à l'alinéa précédent tombent un dimanche, ils ne sont pas payés.Nonobstant les deux alinéas précédonts, si l'Epiphanie, la Toussaint, l'Immaculée Conception et le 20 décembre tombent un vendredi ou un samedi, le jour chômé est reporté au lundi suivant et le travail ne doit alors commencer qu'à 9.00 a.m.ces jours-là.Si le lundi devient un troisième jour consécutif non ouvrable, il est loisible de travailler de 1.00 p.m.à 6.00 p.m.ce jour-là.e) Tout travail exécuté par un salarié en plus de 49 heures par semaine ou en dehors des heures de travail déterminées au paragraphe \"a\" ci-haut est considéré comme travail supplémentaire et doit être rémunéré conformément au paragraphe \"c\" de l'article V.\" 4° Aux paragraphes \"/t\" et \"j\" de l'article V, les mots \"cinquante-deux heures et demie (52)$)\" sont remplacés par les mots \"quarante-neuf (49) heures.\" 5° Aux sous-paragraphes 1, 2 et '¦] du paragraphe \"h\" de l'article V, les mots \"cinquante-deux heures et demie (52)4)\" sont remplacés par les mots \"quarante-neuf (49)-heures\".6° Aux paragraphes \"a\" et \"d\" de l'article VI, les mots \"30 septembre\" sont remplacés par les mots \"30 octobre\".7° L'article VIII est remplacé par le suivant: \"VIII.Durée du décret: Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 28 février 1960.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante* (60) jours ni de moins de trente (30) jours avant le 28 février de l'année 1960 ou de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.\" L.DÉSILETS, \u2014 48178-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 728 Section \"B\" Québec, le 9 juillet 1958.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant une modification au décret relatif aux établissements commerciaux duns les villes de Dolbeau et Mistassini et un rayon de trois (3) milles de leurs limites.Attendu que, conformément aux dispositions de la I.oi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux établissements commerciaux dans les villes de Dolbeau et Mistassini et un rayon de trois (3) milles de leurs limites, rendue obligatoire par le décret numéro 621 du 20 mai 1953 et amendements, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverncUr en Conseil une modification audit décret; When St.Jean Baptiste Day, Confederation Day and January 2 fall on Sunday, the following Monday is observed as a holiday with pay.When the other holidays enumerated in the foregoing paragraph fall on Sunday, they are not paid.Notwithstanding the foregoing two paragraphs, when Epiphany Day, All Saints Day, Immaculate Conception Day and December 26 fall on a Friday or a Saturday, the holiday or day off is postponed to the following Monday and employers shall not open before 9.00 a.m.on such days.Should a Monday become a third consecutive day off, then hours may be worked on that dav from 1.00 p.m.to 6.00 p.m.e) All time worked by an employee in excess of forty-eight (48) hours in one week or in excess of the working hours determined in paragraph \"a\" hereof shall be considered as overtime work and remunerated in pursuance of paragraph \"c\" of article V.\" 4.In paragraphs \"h\" and \"j\" of article V, the words \"fifty-two hours and a half (52)$)\" are replaced by the words \"forty-nine (49) hours\".5.In sub-paragraphs 1, 2 and 3 of paragraph \"/t\" of article V, the words \"fifty-two hours and a half (52)$)\" are replaced by the words \"forty-nine (49) hours\".6.In paragraphs \"a\" and \"d\" of article VI, the words \"September 30\" are replaced by the words \"October 30\".7.Article VIII is replaced by the following: \"VIII.Duration of the decree: The present decree remains in force until February 28, 1960.It then renews itself automatically from year to year unless one of the contracting parties notified the other party, in writing, to the contrary withing the period extending from the sixtieth (60th) to the thirtieth (30th) day prior to February 28 of the year 1960 or of any subsequent, year.Such a notice shall also be filed with the Minister-of Labour.\" L.DÉSILETS, 48178-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 728 Part \"2?\" ** Quebec, July 9, 1958.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an amendment of the decree relating to the retail trade in the towns of Dolbeau and Mistassini and a radius of 3 miles from their limits.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments) the contracting parties to the collective labour agreement relating to commercial establishments in the towns of Dolbeau and Mistassini and a radius of 3 miles from their limits, rendered obligatory by the decree number 621 of May 20, 1953, as amended have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the .Lieutenant-Governor in Council an amendment to the said decree; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2499 Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 3 mai 1958; v Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 621, soit modifié comme suit: Le paragraphe 'V suivant est ajouté à l'article I: \"*) Le mot \"artisan\" signifie toute personne qui exploite, seule ou en société, un établissement régi par le présent décret et qui n'emploie pas de salarié.\" L.DÉSILETS, 48178-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF * Numéro 739 Québec, le 9 juillet 1958.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant certains actes administratifs du département des Affaires municipales.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Preuve photographique de certains documents 5° Conformément et sous l'autorité de l'article 6 du Statut 5-6 Elizabeth II, chapitre 67, la loi concernant la preuve photographique de certains documents est déclarée applicable à la cité de Dorval, à la suite d'une demande contenue à la résolution adoptée par le conseil de ladite cité le 13 juin 1958.(Signé): L.DÉSILETS, 4821 l-o Greffier du Conseil Exécutif.Avis divers Whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of May 3, 1958; Whereas no objection has been mode against the approval of the amendment proposed; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour; That the said decree, number 621, be amended as follows: The following paragraph \"*\" is added to article I: \".») The word \"artisan\" means any person who operates, alone or in partnership, an establishment governed by the present decree and who has no employees.\" L.DÉSILETS, 48178-0 Clerk of the Executive Counsil.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 739 Quebec, July 9, 1958.« Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting certain administrative agreements of the Department of Municipal Affairs.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Municipal Affairs, as follows: Photographic Proof of Certain Documents 5.In conformity and under the authority of section 6 of Statute 5-6 Elizabeth II, chapter 67, the Act respecting photographic proof of certain documents is declared applicable to the city of Dorval, following a request contained in the resolution adopted by the Council of the said city on June 13, 1958.(Signed): L.DÉSILETS, 48211 Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices Val Royal Baptist Church \"Avis est, par les présentes, donné que \"Val Royal Baptist Church\", une congrégation baptis-te ayant son lieu de culte à 11905 rue Grenet, cité de Montréal, s'adressera au Lieutenant-gouverneur en conseil pour lui demander sa constitution en corporation 'sous le nom de \"Val Royal Baptist Church\" conformément aux dispositions du chapitre 311 S.R.Q.1941.\" Westmount, Que.23 juin 1958.Les Requérants, HUTCHESON, JOHNSTON, 48084-26-5 LAFERTÉ & TODD.Avis- est donné au public, conformément à Parcicle 38, section 6, de la Loi du régime des eaux courantes, que \"Donohue Brothers Limited\", de Québec, comté de Québec, se propose d'exécuter le travail suivant: La construction d'un barrage permanent aux eaux mortes des Érables, sur la concession forestière de la Rivière Malbaie n° 2-A, à environ vingt-cinq milles en amont de l'embouchure de la rivière Malbaie.Val Royal Baptist Church \"Notice is hereby given that \"Val Royal Baptist Church\", a Baptist Congregation having its place of worship at 11905 Grenet Street, city of Montreal, shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for Incorporation under the name of \"Val Royal Baptist Church\" in conformity with the provisions of Chapter 311 R.S.Q.1941.\" Westmount, Que., June 23rd, 195S.HUTCHESON, JOHNSTON, LAFERTÉ & TODD, 48084-26-5-o Petitioners.Public notice is hereby given, in accordance with article 38, section 6, of the Water Course Act, that \"Donohue Brothers Limited\", of the city of Quebec, in the county of Quebec, intends to execute the following work: The construction of a driving dam at the dead water of Les Érables, in timber limit Malbaie River No.2-A, at about twenty-five miles above the mouth of La Malbaie River. 2500 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Ï9 juillet 1968, Tome 90, N° 29 Avis est de plus donné qu'une requête à cette fin, accompagnée des plans et devis indiquant la nature des travaux et le terrain qui sera affecté par ces travaux, a été transmise au ministre des Ressources Hydrauliques, et qu'un duplicata de ces plans et devis a été déposé au bureau de la première division d'enregistrement de Charlevoix, à La Malbaie.La demande contenue dans la requête sera prise en considération par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil le ou après le jour suivant la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Donohue Brothers Limited, Par le Vice-président et Secrétaire, 48163-28-4-0 A.E.BEAUVAIS, C.A.Notice is also given that a petition to that effect, accompanied by a plan and specifications showing the nature of the work has been forwarded to the Minister of Hydraulic Resources, and that a duplicate of such plan and specifications has been deposited at the Registry Office of the first Registration Division of Charlevoix at La Malbaie, Que.The application contained in the petition will be taken into consideration by the Lieutenant-Governor on or after the day following the date of the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Donoiiue Brothers Limited, Per A.E.BEAU VAIS, C.A., 48163-28-4-o Vice-President and Secretary.Avis est donné au public, conformément à l'article 38, section 6, de la Loi du régime des eaux courantes, que \"Donohue Brothers Limited\", de Québec, comté de Québec, se propose de demander: L'approbation d'un barrage construit au mois d'août 1957 au lac du Coq sur la rivière Barley, tributaire de la rivière Malbaie, sur la tenure libre de Barley, comté de Charlevoix.Avis est de plus donné qu'une requête à cette fin, accompagnée des plans et devis indiquant l'emplacement choisi pour la construction de ces ouvrages et le terrain affecté, a été transmise au ministre des Ressources Hydrauliques et qu'un duplicata de ces plans et devis a été déposé au bureau de la deuxième division d'enregistrement de Charlevoix, à la Baie St-Paul.La demande contenue dans la requête sera prise en considération le ou après le jour suivant la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Donohue Brothers Limited, Par le Vice-président et Secrétaire, 48104-28-4-o A.E.BEAUVAIS, C.A.Public notice is hereby given, in accordance with article 38, section 6, of the Water Course Act, that \"Donohue Brothers Limited\", of the city of Quebec, in the county of Quebec, intends to ask: The approval of a dam built in the month of August 1957 at Lake du Coq on the Barley River, tributary of the Malbaie River, on Barley freehold, in the county of Charlevoix.Notice is also given that a petitition to that effcct,|accompanied by a plan and specifications showing the nature of the work and the land which wijl be affected by such work has been forwarded to the Minister of Hydraulic Resources, and that a duplicate of such plan and specifications has been deposited at the Registry Office of the second Registration Division of Charlevoix at Baie St.Paul, Que.The application contained in the petition will be taken into consideration by the Lieutenant-Governor in Council on or after the day following the date of the publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Donoiiue Brothers Limited, Per A.E.BEAUVAIS, C.A., 48164-28-4-0 Vice-President and Secretary.Village de St-Jérôme Village of St-Jérô.me Comté de Lac St-Jean County of Lake St.John Tirage d'obligations Drawing of bonds Les obligations suivantes émises en vertu du The following bonds, issued under By-Law règlement N° 82, ont été tirées au sort: No.82, have been drawn by lots: Dénomination de $100.00: C-38, 52, 62, 120 Denomination of $100.00: C-38, 52, 02, 120 et 141.and 141.Dénomination de $500.00: D-42, 119, 155 et Denomination of $500.00: D-42.119, 155 and 170.\u2022 170.Lesdites obligations seront remboursables le The said bonds shall be redeemable on the first premier septembre 1958, date à laquelle elles of September, 1958, from which date they shall cesseront de porter intérêt.shall cease to bear interest.Le Secrétaire-trésorier, LAURENT PLOURDE, 48183-o LAURENT PLOURDE.48183-o Secretary-treasurer.(P.G.10736-55) Progrès de Crémazie Ltée Règlement No IV Que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de trois (3) à quatre (4) directeurs.Certifié vraie copie.\u2022 Montréal, le 26 juin 1958.Le Secrétaire, 48185-0 J.-ALFRED ÉTHIER.(A.G.10736-55) Progrès de Crémazie Ltée By-Law No.IV That the number of directors of the company be increased from three (3) to four (4) directors.Certified true copy.Montreal, June 26, 1958.J.-ALFRED ÉTHIER, 48185 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2601 (P.G.11382-54) Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.Règlement No XV Que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de trois (3) à quatre (4) directeurs.Certifié vraie copie.Montréal, le 26 juin 1958.Le Secrétaire, 48186-o J.-ALFRED ÉTHIER.(P.G.10988-54) Notre-Dame Construction Ltée Règlement N° XV 0 - Que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de trois (3) à quatre (4) directeurs.Certifié vraie copie.Montréal, le 20 juin 1958.Le Secrétaire, 48187-0 J.-ALFRED ÉTHIER.(P.G.4800-44) Gagné Construction Ltée Gagné Construction Ltd.Règlement N° XV Que le nombre des directeurs de la compagnie soit augmenté de trois (3) à quatre (4) directeurs.Cert fié vraie copie.Montréal, le 26 juin 1958.Le Secrétaire, 48188-o J.-ALFRED ÉTHIER.(P.G.10011-58) Intercontinental Veneers Ltd.Règlement N\" 20 Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Intercontinental Veneers Ltd.\" (ici nommée la \"Compagnie\") ce qui suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par.les présentes, augmenté de trois (3) à quatre (4), de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de quatre (4) directeurs.2.Trois (3) directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3.Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie, incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.Décrété ce 14e jour de mai 1958.Vraie copie certifiée.Le Secrétaire, 48189 MONROE ABBEY.(P.G.14257-53) Holt, Renfrew & Co., Limited Règlement N° XXIV Augmentant le nombre des directeurs de neuf à dix \"Il a été proposé, secondé et résolu à l'unanimité que le règlement N° XXDH de la compagnie (A.G.11382-54) Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.By-Law No.XV That the number of directors of the company be increased from three (3) to four (4) directors.Certified true copy.Montreal, June 26, 1958.J.-ALFRED ÉTHIER, 48186 Secretary.(A.G.10988-54) Notre-Dame CoNSTRUCTipN Ltée By-law No.XV That the number of directors of the company be increased from three (3) to four (4) directors.Certified true copy.Montreal, June 26, 1958.J.-ALFRED ÉTHIER, 48187 Secretary.(A.G.4800-44) Gagné Construction Ltée Gagné Construction Ltd.By-law No.XV That the number of directors of the company be increased from three (3) to four (4) directors.Certified true copy.Montreal, June 26, 1958._ J.-ALFRED ÊTHD3R, 48188 Secretary.(A.G.10611-58) Intercontinental Veneers Ltd.By-law No.20 Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of \"Intercontinental Veneers Ltd.\" (herein called the \"Company\") as follows: 1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three (3) to four (4) so that the board of directors of the company shall hereafter be composed of four (4) directors.2.Three (3) directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Enacted this 14th day of May, 1958.Certified a true copy.MONROE ABBEY, 48189-o Secretary.(A.G.14257-53) Holt, Renfrew & Co., Limited By-law No.XXIV Increasing the number of directors from nine to ten \"It was moved, seconded and unanimously \u2022 resolved that By*Law No.XXHI of the Com- 2502 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 soit et il est, par les présentes, rayé et remplacé par le suivant, règlement N° XXTV: Règlement N° XXIV: Un bureau de dix directeurs sera élu annuellement parmi les actionnaires de la compagnie détenant des actions en leur propre droit et n'ayant pas d'arrérages relativement à tous appels sur icelles.Le bureau de direction peut, de temps en temps, entre la confirmation du règlement et la prochaine assemblée annuelle, nommer au bureau de direction, des actionnaires»de la compagnie qualifiés, juqu'à ce qu'il y ait élection, ajoutant ainsi au présent nombre de directeurs un nombre suffisant pour que le bureau de direction soit au complet.Jusqu'à ce qu'un bureau de direction soit au complet le nombre présent de directeurs et les actionnaires élus par eux comme directeurs, de temps en temps, administreront les affaires de la compagnie.\" Vraie copie certifiée.19 avril 1955.Le Secrétaire-trésorier, 48206 R.G.LIDDY.(P.G.14257-53) Holt, Renfrew & Co.Limited Règlement N° 26 1.Que le nombre des directeurs de \"Holt, Renfrew & Co., Limited\" soit et il est par les présentes, augmenté de dix à onze, de manière que le bureau de direction de la compagnie.soit dorénavant composé de onze directeurs.2.Tous règlements et résolutions de la compagnie incompatibles à icclui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.Je certifie, par les présentes, que le règlement ci-dessus a été décrété par les directeurs de \"Holt, Renfrew & Co., Limited\" à une assemblée régulière tenue le 18e jour d'avril 1958, et qu'il a été approuvé, sanctionné et confirmé par tous les actionnaires à une assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 21 mai 1958.Le Secrétaire-trésorier «le Holy, Renfrew & Co., Limited, (Sceau).48206 IL N.AUSTER.(P.G.13562-57) Les Immeubles Delrano Inc., Règlement N° 8 Règlement réduisant le nombre des Directeurs.Qu'il soit et il est par les présentes décrété, comme Règlement N° 8 de \"Les Immeubles Delrano Inc.\" (ci-après appelée \"La Compagnie\") ce qui suit: 1.Le nombre des directeurs de la Compagnie, \"Les Immeubles Delrano Inc.\", est par les présentes réduit de cinq (5) à trois (3) directeurs, et aux assemblées du Bureau de direction le quorum est réduit de trois (3) à deux (2) directeurs.2.Tous règlements, résolutions et procès-verbaux de la Compagnie, inconciliables avec le présent règlement, sont en conséquence modifiés pour donner effet au présent règlement.Copie certifiée conforme d'un règlement adopté par les directeurs de \"Les Immeubles Delrano \u2022Inc.\" à une assemblée en date du 27 juin 1958, et ratifié à une assemblée générale spéciale des pany be and the same is hereby repealed and replaced by the following By-Law No.XXIV: By-Law No.XXIV: A Board of ten directors shall be elected annually from among the shareholders of the Company holding stock absolutely in their own right and not in arrears in respect to any calls thereon._ The Board of directors may, from time to time, between the confirmation of the By-Law and the next annual meeting elect to the Board qualified shareholders of the Company until there shall have been elected, in addition to the present number of directors, a sufficient number to make a full Board.Until a full Board is elected the present number of directors and the shareholders from time to time elected by them as directors shall manage the affairs of the Company.\" Certified a true copy.April 19th, 1955.R.G.LIDDY, 48206-o Secretary-Treasurer.(A.G.14257-53) Holt, Renfrew & Co., Limited By-lMtv No.26 1.The number of directors of \"Holt, Renfrew & Co., Limited\" be and the same is hereby increased from ten to eleven so that the bord of directors of the Company shall hereafter be composed of eleven directors.2.All prior by-laws and resolutions of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.I hereby certify that the above by-law was enacted by the directors of \"Holt, Renfrew & Co.Limited\" at a regular meeting held on the 18th day of April, 1958.and that it was approved, sanctioned and confirmed by all the shareholders at a special general meeting of shareholders held on May 21.1958.H.N.AUSTER.(Seal).Secretary-Treasurer, 4S206-O Holt, Renfrew & Co., Limited.(A.G.13562-57) Les Immeubles Delrano Inc.By-law No.8 By-law decreasing the number of directors.Be it enacted and it is hereby enacted as Bylaw No.8 of \"Les Immeubles Delrano Inc.\" (hereinafter called \"The Company\") as follows: 1.The number of directors of the Company \"Lés Immeubles Delrano Inc.\", is hereby decreased from five (5) to three (3) directors, and at meetings of the Board of directors the quorum is decreased from three (3) to two (2) directors.2.AH by-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended in order to give effect to this By-law.Certified true copy of a by-law adopted by the directors of \"Les Immeubles Delrano Inc.\" at a meeting dated June 27, 1958, and confirmed at a special general meeting of shareholders, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2503 actionnaires, en date du 27 juin 1958, à laquelle tous les actionnaires étaient présents et votèrent en faveur dudit règlement.(Sceau).Le Secrétaire, 48207-o ROGER LÊTOURNEAU.(P.G.12784-54) Globe Paper Box Co.Limited Règlement N° 30 Attendu qu'il est jugé nécessaire d'augmenter le nombre des directeurs de la compagnie de trois à six; En conséquence, qu'il soit décrété comme un règlement de la compagnie; Que le combre des directeurs de la compagnie soit changé en augmentant le nombre de ces directeurs de trois à six.Daté ce lie jour d'avril 1958.Vraie copie certifiée.Le Secrétaire, 48208 D.WAINBERG.(P.G.11927-58) Belleterre Quebec Mines Limited (No Personal Liability) Résolution Spéciale Passée par le bureau de direction de \"Belleterre Quebec Mines Limited\" à une assemblée tenue le 6 mars 1958.\"Résolu comme une résolution spéciale de la compagnie: 1° Qu'il soit décrété comme'un règlement de \"Belleterre Quebec Mines Limited\" (No Personal Liability) que le combre des directeurs de la compagnie, soit et il est, par les présentes, augmenté de cinq à six de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de six directeurs.2° Quatre directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie, incompatibles à icelle sont, par les présentes, amendés modifiés et revisés de manière à donner effet à cette résolution spéciale.4° Que les officiers de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, autorisé» à faire, signer et exécuter toutes choses, actes et documents nécessaires ou opportuns à la bonne exécution du précédent.\" Vraie copie certifiée.Daté ce 28e jour de mai 1958.Le Secrétaire, 48209 F.T.McKINNEY.(P.G.16260-53) Zed Corporation Règlement spécial \"B\" (1958) pour augmenter le nombre des directeurs .Il est décrété comme règlement spécial de la compagnie: 1 Le nombre des directeurs de la compagnie est augmenté de trois (3) à cinq (5).2° Deux (2) directeurs formeront le quorum de toute assemblée du Conseil d'Administration.3° Lorsque ce règlement deviendra valide les directeurs en fonction à cette époque pourront nommer parmi les actionnaires dûment qualifiés dated June 27, 1958, at which meeting all the shareholders were present and voted in favour of said By-law.(Seal).ROGER LÊTOURNEAU,.¦ 48207 Secretary.(A.G.12784-54) Globe Paper Box Co.Limited By-law No.30 Whereas it is expedient to increase the number of directors of the company from three to six; Now therefore be it enacted as a by-law of the company; That the number of directors of the company be varied by increasing the number of such directors from three to six.Dated this 11th day of April, 1958.Certified a true copy.D.WAINBERG, 48208-o Secretary.(A.G.11927-58) , Belleterre Quebec Mines Limited (No Personal Liability) Special Resolution Passed by the board of directors of \"Belleterre Quebec Mines Limited\" at a meeting held March 6th, 1958.\"Resolved as a special resolution of the company that: 1.Be it enacted as a by-law of \"Belleterre Quebec Mines Limited\" (No Personal Liability) that the number of directors of the company be and the same is hereby increased from five to six so that the board of directors of the company shall hereafter be composed of six directors.2.Four directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this special resolution.4.The proper officers of the company l>e and they are hereby authorized to do, sign and execute all things, deeds and documents necessary or desirable for the due carrying out of the foregoing.\" Certified a true copy.Dated this 28th day of May, 1958.F.T.McKINNEY, 48209-o Secretary.(A.G.16260-53) Zed Corporation Special by-law \"B\" (7958) to increase the number of directors Be it enacted as a special by-law of the company: 1.The number of directors of the company is increased from three (3) to five (5).2.Two (2) directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.After this by-law has become valid the directors then in office may elect from amongst the duly qualified shareholders of the company 2504 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N° 29 de la compagnie deux (2) autres directeurs pour demeurer en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.Copie véritable du règlement ci-dessus adopté par les directeurs de \"Zed Corporation\" le 30 avril 1958 et approuvé à l'unanimité le même jour par les actionnaires de ladite compagnie.Montréal, le 30 avril 1958.(Sceau) Le Secrétaire, 48210-o E.DESORCY.Chartes \u2014 Abandon de two (2) other directors to remain in office until the next annual general meeting or until their successors are elected.Certified true copy of the above by-law enacted by the directors of \"Zed Corporation\" on April 30th 1958 and unanimously approved the same day by the shareholders of the saidi company.Montreal, April 30th, 1958.(Seal) E.DESORCY, 48210-o Secretary.Charters \u2014 Surrender of L.Dupont Limitée Avis est donné que la compagnie \"L.Dupont Limitée\", constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la cité de Verdun, demandera au Procureur général de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Verdun, le 27 juin 1958.Le Secrétaire, (Signé) MARIE FLORE DUPLESSIS.48172-0 L.Dupont Limitée Notice is hereby given that \"L.Dupont Limitée\", a corporation constituted under Part I of the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Verdun, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Verdun, this 27th day of June, 1958.(Signed) MARIE FLORE DUPLESSIS, Secretary.48172-o Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Autocam Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec, en date du 15 avril 1940, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 1er mai 1958.lies Procureurs de \"Autocam Inc.\", 48179 RAPPAPORT & WHELAN.Notice is hereby given that \"Autocam Inc.\", incorporated by letters patent, of the Province of Quebec, dated April 15th, 1946, will make application for leave to surrender its charter.Montreal, May 1, 1958.RAPPAPORT & WHELAN, 48179-0 Attorneys for \"Autocam Inc.\".Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Exposition Displays Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec, en date du 24 février 1954, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 17 avril 1958.* Les Procureurs de \"Exposition Displays Inc.\", 48180 RAPPAPORT & WHELAN.AVIS Prenez avis que la compagnie \"Ed.Rona & Co.Ltd.\" demandera au Procureur général la permission d'abandonner sa charte.Les Procureurs de la compagnie, DURANLEAU, DUPRÉ, DURANLEAU, LETTE 48182-o & COUSINEAU.Notice is hereby given that \"Exposition Displays Inc.\", incorporated by letters patent, of the Province of Quebec, dated February 24, 1954, will make application for leave to surrender its charter.Montreal, April 17, 1958.RAPPAPORT & WHELAN, Attorneys for 48180-o \"Exposition Displays Inc.\".NOTICE Take notice that the company \"Ed.Rona & Co.Ltd.\" will apply to the Attorney General for leave to surrender its charter.DURANLEAU, DUPRÊ, DURANLEAU, LETTE & COUSINEAU, 48182 Attorneys for the company.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Central Outfitting Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec, en date du 9 juillet 1941, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal.24 juin 1958.Les Procureurs de \"Central Outfitting Co.Ltd.\", 48199 GENSER & PHILLIPS.Notice is hereby given that \"Central Outfitting Co.Ltd.\", incorporated by letters patent of the Province of Quebec, dated 9th July, 1941, will make application for leave to surrender its charter.Montreal, June 24th, 1958.GENSER & PHILLIPS, Attorneys for 48199-o \"Central Outfitting Co.Ltd.\". QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2505 AVIS En vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, \"Karp & Einhorn Ltd.\", donne , par les présentes, avis qu'elle s'adressera au Lieutenant-gouverneur en Conseil pour obtenir l'abandon de sa charte et son annulation à compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Montréal.14 juillet 1958.\"Karp & Einhorn Ltd.\" Par le Secrétaire, 48205 MARCEL KARP.Disthict Development Inc.Prenez avis que la compagnie \"District Development Inc.\", une compagnie dûment incorporée en vertu de la loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social à Châteauguay Village, demandera au Procureur Général de la Province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Date à Châteauguay Village ce 14ième jour du mois de juillet 1958.48215-0 YVETTE MARCOUX.Édifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.Avis est par les présentes, donné, que la Compagnie dite \"Édifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.\".demandera au Procureur Général la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 14 juillet 1958.Le Secrétaire, DOCTEUR ALPH.PLESSIS-BÉLAnt.48216-o NOTICE Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"Karp & Einhorn Ltd.\", hereby gives notice that it will make application to the Lieutenant-Governor in Council for the acceptance of the surrender of its charter and its cancellation as and from a date to be fixed by him.Montreal, July 14th, 1958.\"Karp & Einhorn Ltd.\" Per: MARCEL KARP, 48205-o Secretary.District Development Inc.Notice is hereby given that \"District Development Inc.\",*a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in Châteauguay Village, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Châteauguay Village this 14th day of July 1958.48215 o YVETTE MARCOUX.Édifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.Notice is hereby given that the Company called \"Édifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.\", will apply to the Attorney General for leave to surrender its charter.Montreal, July 14, 1958.DOCTOR ALPH.PLESSIS-B ÉLAIR, Secretary.48216 Département de l'Instruction Publique N° 1264-57.Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Boniface-dc-Shawinigan paroisse, dans le comté de St-Maurice, à celui de la municipalité scolaire de St-Boniface-de-Shawinigan village, même comté.Québec, le 11 juillet 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48200-29-2-O 0.,J.DÉSAULND3RS.N° 1272-55.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire du village de St-Martin.dans le comté de Laval, en celui de \"La municipalité scolaire de St-Martin\", même comté.Québec, le 11 juillet 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48201-29-2-o O.J.DÉSAULNIERS.Department of Education No.1264-57.Application is made to annex the present territory of the school municipality of St.Boni-face-de-Shawinigan parish, in the county of St.Maurice, to that of the school municipality of St.Boniface-de-Shawinigan village, same county.Quebec, July 11, 1958.O.J.DÉSAULNIERS, 48200-29-2 Superintendent of Education.No.1272-55.Application is made to change the name of the school municipality of the village of St.Martin, in the county of Laval, to that of \"The school municipality of St.Martin\", same county.Quebec.July 11, 1958.O.J.DÉSAULNIERS, 48201-29 -2 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption de Repentigny (municipalité de ville de Repentigny) division d'enregistrement de l'Assomption.NOTICE Officiai cadastre of the parish of Notre-Dame de l'Assomption de Repentigny (municipality of town of Repentigny) registration division of l'Assomption. 2506 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 Avis est par la présente donné que les lots 120-143 à 120-145, 123-893 à 123-901 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 30 juin 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 48170-o A VILA BÉDARD.Notice is hereby given that lots 120-143 to 120-145, 123-893 to 123-901 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, June 30, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 48176-o Deputy Minister.Nomination Avis est donné qu'il a plu au Lieutenant-Gouverneur en Conseil de nommer, par arrêté en conseil numéro 582, en date du 4 juin 1958, M.Jean-H.Gagné, avocat, membre du Barreau de la province, résidant dans la cité de Ste-Foy et pratiquant dans la cité de Québec, conseil en loi de la Reine.Donné au bureau du Secrétaire de la province le onze juillet 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48171-0 JEAN BRUCHÊSI.Appointment Notice is given that -His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council number 582, dated June 4, 1958.to appoint Mr.Jean-H.Gagné, advocate, member of the Provincial Bar, residing in the City of St.Foy and practising in the City of Quebec, Queen's Counsel.Given at the\" office of the Provincial Secretary, the eleventh day of July 1958.JEAN BRUCHÊSI, 48171 Under Secretary of the Province.Sièges sociaux Anthonian Mining Corporation Limited (No Personal Liability) Avis de changement du siège social Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Anthonian Mining Corporation Ltd.\" (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, par lettres patentes en date du 28 septembre 1950 et ayant son siège social en la cité de Montréal, où son bureau était situé à 303, 437 ouest, rue St Jacques, l'a transporté à chambre 304, 477 rue St-François-Xavier.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la corporation comme étant le siège social de la corporation.Daté à Montréal, ce 24e jour de juin 1958.Anthonian Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability) Par Le Président, 48173 EDWARD D.REDFEARN.Head Offices Anthonian Mining Corporation Limited (No Personal Liability) Notice of change of head office Notice is hereby given that \"Anthonian Mining Corporation Ltd.\" (No Personal Liability), incorporated under the Quebec Mining Companies' Act by letters patent dated 28 September 1950 and having its head office in the city of Montreal where its office was situated at room 303, 437 St.James Street West has moved it to room 304, 477 St.François-Xavier Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the corporation as being the head office of the corporation.Dated at Montreal, this 24th day of June, 1958.Anthonian Mining Corporation Ltd.(No Personal Liability) Per EDWARD D.REDFEARN, 48173-o President.\"Cresus Investments Inc.\" Avis est donné que la compagnie \"Cresus Investments Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 17 mai 1958, et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal, district de Montréal, a établi son bureau au numéro 201 de la rue St-Zotique est.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 20c jour de juin 1958.48174-o Le Président, JACQUES TOZZI.Roger Distributors Inc.\"Cresus Investments Inc.\" Notice is hereby given that \"Cresus Investments Inc.\", incorporated by letters patent dated May 17th, 1958, and having its head office in Montreal, district of Montreal, has established its office at 201 St.Zotique Street East.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated at Montreal, this 20th day of June, 1958.JACQUES TOZZI, 48174-o President.Roger Distributors Inc.Avis est donné que la compagnie \"Roger Notice is hereby given that \"Roger Distri-Distributors Inc.\", constituée, en corporation butors Inc.\", incorporated by letters patent par lettres patentes conformes à la première pursuant to Part I of the Quebec Companies' QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, So.29 2507 partie de la Loi des compagnies de Québec, en date du douzième jour de juin, 1958, et ayant son bureau principal dans la ville de Montréal, a établi son bureau au numéro 166 rue King.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, P.Q., ce dix-neuvième jour de juin 1958.Le Président, 48175-o (Signé) ROGER VÊZINA.(P.G.10506-58) Candiac Construction Ltd.Re: Changement du siège social de Montréal à Ville Mont-Royal \"Règlement un \u2014 Article 2: Situation des bureaux.Le siège social et principale place d'affaires de la compagnie sera à Ville Mont-Royal, province de Québec.Canada.La compagnie peut établir et maintenir en plus de son siège social et principale place d'affaires tels autres bureaux, places d'affaires et agences ailleurs dans les limites ou en dehors de la province de Québec, tel que le bureau de direction ou tout officier administrateur peut le déterminer de temps en temps.\" Vraie copie certifiée du règlement un, article 2 «le \"Candiac Construction Ltd.\", tel qu'amendé par les directeurs de la compgnie à une assemblée du bureau de direction dûment convoquée et tenue le 24 mars 1958, et approuvé, ratifié, sanctionné et confirmé par le vote unanime de tous les actionnaires de la compagnie à une assemblée générale spéciale «les actionnaires dûment convotjuée et tenue le 24 mars 1958.(Sceau).Le Président, JEAN LEMAN.Le Secrétaire, 48177 GILLES DORÉ.(P.G.12374-58) East Malartic Mines Limited (No Personal Liability) Règlement numéro \"F\" \"Un règlement qui change la situation du siège social de la compagnie de la cité de Montréal à la ville de Norrie\".Qu'il soit décrété et il est.par les présentes, décrété comme un règlement de la compagnie que la situation du siège social de la compagnie soit et elle est, par les présentes, transportée de la cité de Montréal, province de Québec, à la ville*de Norris, province de Québec.Passé par les directeurs ce 10e jour de mars 1958.Le Président, R.C.STANLEY, Jr.Le Secrétaire, M.C.MADDIGAN.Nous, J.George Boeckh et Mary C.Maddigan, vice-président et secrétaire respectivement de \"East Malartic Mines Limited (No Personal Liability)\", certifions, par les présentes, sous le sceau corporatif de la compagnie, que le précédent est une copie conforme et authentique du règlement numéro \"F\" de la compagnie adopté régulièrement par les directeurs de ladite compagnie à une assemblée dûment convoquée et Act, on the 12th June, 1958, and having its head office in- the city of Montreal, has established its office at 166 King Street, Montreal, P.Q.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, P.Q., this 19th ec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation prior to September 1st, 1968 inclusive; after which date the said bonds may, under the authority ôf chapter 212, Revised Statutes of Quelle, 1041, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to he redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on tjie bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Tuesday, August 5, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the Ste.Anne College, at Ste.Anne de Beaupré, county of Montmorency. 2512 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N° 29 Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Anne de Beaupré, (Comté de Montmorency), ce 10 juillet 1958.Le Secrétaire-trésorier, CHS.-ED.RACINE.Ste-Anne de Beaupré, (Montmorency), P.Q., Téléphone: 212.48195-o The school commissioners are not bound to accept the highest or any of the tenders.Ste.Anne de Beaupré, (County.of Montmorency), this July 10, 1958.CHS.-ED.RACINE, Secretary-Treasurer.Ste.Anne de Beaupré, (Montmorency), P.Q., Telephone: 212.48195 Province de Québec Province of Quebec Village de Shawinigan Sud (Comté de St-Maurice) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Paul-E.Hamel, secrétaire-trésorier.Hôtel de Ville.900, 6e avenue, Shawinigau-Sud, comté de St-Maurice, jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 4 août 1958, pour l'achat de 838,000.00 d'obligations «lu village de Shawinigan-Sud, comté de St-Maurice, «latées du 1er juillet 1958 et remboursables par séries du 1er juillet 1959 au 1er juillet 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% pour les échéances de 1959 à 1968 inclusivement non inférieur à pour les échéances de 1969 à 1978 inclusivement, et non supérieur à 5% pour les échéances de 1959 à 1978 inclusivement, payable semi-annuel-lcment les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, l^e taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt No.131 -\u2014 organisation des loisirs et de l'œuvre des terrains de jeux.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er septembre 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 S38.000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juillet 1959.$1,000.00 1er juillet 1960.1,000.00 1er juillet 1961.1,000.00 1er juillet 1962.1,000.00 1er juillet 1963.1,500.00 1er juillet 1964.1,500.00 1er juillet 1965.'.1,500.00 1er juillet 1966.1,500.00 1er juillet 1967.1,500.00 1er juillet 1908 .2,000.00 1er juillet 1969 .2,000.00 1er juillet 1970 .2,000.00 1er juillet 1971.2,000.00 1er juillet 1972 .2,000.00 1er juillet 1973 .2.500.00 1er juillet 1974 .2,500.00 1er juillet 1975 .2,500.00 1er juillet 1970 .3,000.00 1er juillet 1977 .3,000.00 1er juillet 1978 .3,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Shawinigan-Sud, comté de St-Maurice.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juillet 1968 inclusi- VlLLAGE OF SlIAWlXIGAX-SoUTII \u2022(County of St.Maurice) Public notice is hereby given that scaled tenders, endorsed \"Tenders for bon«ls\" will be received by the undersigned Paul-E.Hamel, Secretary-Treasurer, City Hall, 900, 6th Avenue, Shawi-nigan-South, county of St.Maurice, until 8.00 o'clock p.m., Monday, August 4, 1958, for the purchase of an issue of $38,000.00 of bonds of the village of Shawinigan-South, county of St.Maurice, dated July 1st, 1958 ami redeemable serially from July 1st, 1959 to July 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate of not less than 4% for maturities from 1959 to 1968 inclusive, nor less than 4%% for maturities from 1969 to 1978, nor more than 5% for maturités from 1959 to 1978 inclusive, payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan By-law No.131 \u2014 for the organizing of recreational activities and play grounds.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from September 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 988,000.00 \u2014 20 years Year Capital July 1st, 1959.$1,000:00 July 1st, 1960.1,000.00 July 1st, 1961.1,000.00 July 1st, 1962.1,000.00 July 1st, 1963.1,500.00' July 1st, 1964.1,500.00 July 1st.1965.1,500.00 July 1st, 1966.1,500.00 July 1st, 19Q7.1,500.00 July 1st, 1968 .2,000.00 July 1st, 1909 .2,000.00 July 1st, 1970 .2,000.00 July 1st, 1971.2,000.00 July 1st, 1972.2.000.00 July 1st, 1973 .2,500.00 July 1st, 1974 .2,500.00 July 1st, 1975 .2,500.00 July 1st, 1976., 3,000.00 July 1st, 1977 .3,000.00 July 1st, 1978 .3,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Shawinigan-South, county of St.Maurice.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation prior to July 1st, 1968 inclusive; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2513 vement; après cette date,- lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute éehéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance «lu conseil qui sera tenue lundi, le 4 août 1958, à 8.00 heures du soir, en l'Hôtel de Ville, 900, 6e avenue, Shawinigan-Sud, comté de St-Maurice.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Shawinigan-Sud, (Comté de St-Maurice), ce 11 juillet 1958.Le Secrétaire-trésorier, PAUL-E.HAMEL.Hôtel de Ville, 900, 6e avenue, Shawinigan-Sud, (St-Maurice), P.Q., Téléphone : LEcture 6-5318.48196-o after which date, the said bonds may, under the authority of chapter 212.Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will l>e called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must l>e accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will l>e oj)cned and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, August 4.1958, at 8.00 o'clock p.m.at the City Hall, 900, 6th.Avenue.Shawinigan-South, county of St.Maurcie.The Council is not hound to accept the highest or any of the tenders.Shawinigan-South.(Countv of St.Maurice), this Julv 11, 1958.PAUL-E.HAMEL, Secretary-Treasurer.City Hall.900, 6th Avenue, Shawinigan-South, (St.Maurice), P.Q., Telephone: LEcture 6-53IS.48196 Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité de RlMOUSKI-EsT (Comté de Rimouski) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Roméo Poirier, secrétaire-trésorier, 590 rue St-Germain, Rimouski-Est, comté de Rimouski, jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 4 août 1958, pour l'achat de S 100,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de Rimouski-Est, comté de Rimouski, datées du 1er juin 1958 et remboursables par séries du 1er juin 1959 au 1er juin 1966 inclusivment, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 26 mai 1958, telle que modifiée \u2014 construction d'une école au village.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er septembre 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $100,000.00 \u2014 8 ans Année Capital 1er juin 1959.x$24,000.00 1er juin 1960.x 25,000.00 1er juin 1961.x 26.000.00 1er juin 1962 .4,500.00 1er juin 1963 .5,000.00 1er juin 1964.5,000.00 1er juin 1965 .5,000.00 1er juin 1966 .5,500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $09,000.00, accordé par le Secrétaire de la province et payable en trois versements de $23,000.00 chacun, de 1959 à 1961 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of Rimouski-East (County of Rimouski) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Roméo Poirier, Secretary-Treasurer, 590 St.Germain Street, Rimouski-East, county of Rimouski, until 8.00 o'clock p.m., Monday, August 4, 1958 for the purchase of an issue of $100,000.00 of bonds of the School Commissioners for the Municipality of Rimouski-East, county of Rimouski, dated June 1st, 1958 and redeemabld serially from June 1st, 1959 to June 1st, 1966 inclusively, with interest at a rate of not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semi-annually on June 1st and December 1st, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan Resolution dated May 26, 1958, as modified.\u2014 erection of a school in the village.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from September 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $100,000.00 \u2014 8 years Year Capital June 1st, 1959.xS24,000.00 June 1st, 1960.x 25.000.00 June 1st, 1961.x 20,000.00 June 1st, 1962 .4,500.00 June 1st, 1963.5,000.00 June 1st, 1904 .5,000.00 June 1st, 1965 .5,000.00 June 1st, 1966 .5,500.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $69,000.00 granted by the Provincial Secretary and payable in three instalments of $23,000.00 each, from 1959 to 1961 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan. 2514 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90.N° 29 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Rimouski-Est, comté de Rimouski.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% «lu montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 4 août 1958, à 8.00 heures du soir, à l'école du village, Rimouski-Est, comté de Rimouski.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumission.Rimouski-Est.(Comté de Rimouski), ce 15 juillet 1958.Le Secrétaire-trésorier, ROMÉO POIRIER.590 rue St-(îermain.Rimouski-Est, (Rimouski), P.Q.Tél.: RAymond 3-4485.48212-o The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Rimouski-East, county of Rimouski.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Shcool Commissioners to be held on Monday, August 4, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the Village School, Rimouski-East.county of Rimouski.The School Commissioners are not bound to accept the highest or any of the tenders.Rimouski-East, (County of Rimouski).this July 15, 1958.ROMÉO POIRIER.Secretary-Treasu rer.590 St.Germain Street.Rimouski-East.(Rimouski), P.Q.Tel.: RAymond 3-4485.48212 Province «le Québec Village de Thurso (Comté de Papineau) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné.R.Pelletier, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, rue Galipeault, Thurso, comté de Papineau, jusqu'à 8.00 heures du soir, mercredi, le 6 août 1958, pour l'achat de $62,500.00 d'obligations du village de Thurso, comté de Papineau, datées du 1er juillet 1958 et remboursables par séries du 1er juillet 1959 au 1er juillet 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% pour les échéances de 1959 à 1968 inclusivement, non inférieur à 4^£% pour les échéances de 1969 à 1978 inclusivement, et non supérieur à 5% pour les échéances «le 1959 à 1978 inclusivement, payable semi-annucllement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 182 \u2014 première tranche du règlement N° 182 au total de $1,25.000.00 \u2014 travaux d'égouts.d'aqueduc, ouverture de rues, construction de lignes de distribution électrique, construction «le trottoirs, etc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er septembre 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant : Tableau d'amortissement \u2014 $62,500.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juillet 1959.$2,000.00 1er juillet 1960 .2,000.00 1er juillet 1961.2,000.00 1er juillet 1962 .2,000.00 1er juillet 1963 .2,500.00 1er juillet 1964 .2,500.00 1er juillet 1965 .2,500.00 1er juillet 1966.2,500.00 1er juillet 1967.3,000.00 Province of Quebec Village of Thurso (County of Papineau) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned R.Pelletier, Secretary-Treasurer, city Hall, Galipeault Street, Thurso, county of Papineau, until 8.00 o'clock p.m., Wednesday, August 6, 1958 for the purchase of an issue of $62,500.00 of bonds of the village of Thurso, county of Papineau, dated July 1st, 1958 and redeemable scriaHy from July 1st, 1959 to July 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate of not less than 4% for maturities from 1959 to 1908 inclusive, nor less than 43^% for maturities from 1909 to 1978 inclusive, nor more than 5% for maturities from 1959 to 1978 inclusive, payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.182 \u2014first slice of by-law No.182 in a total amount of $125,000.00 \u2014 operations re sewage, waterworks, opening of streets, building of power distribution lines, building of sidewalks, etc.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from September 1st, 1958.The table of redemption is as follows: \u2022 Table of redemption \u2014 $62,500.00 \u2014 20 years Year Capital July 1st, 1959.$2,000.00 July 1st, 1960.2,000.00 July 1st, 1961.2.000.00 July 1st.1962.,.2,000.00 July 1st, 1963.2,500.00 July 1st, 1964 .2,500.00 July 1st, 1965 .2,500.00 July 1st, 1966 .2,500.00 July 1st, 1967.3,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2515 1er juillet 1968 .3,000.00 1er juillet 1969 .3,000.00 1er juillet 1970 .3,000.00 1er juillet 1971.3,500.00 1er juillet 1972 .3,500.00 1er juillet 1973.3,500.00 1er juillet 1974 .4,000.00 1er juillet 1975 .4,000.00 1er juillet 1976.4,500.00 1er juillet 1977 .4,500.00 ' 1er juillet 1978 .5,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il .y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Thurso, comté de Papineau.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'aux succursales de ladite banque à Ottawa et à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juillet 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 6 août 1958, à 8.00 heures du soir, en l'Hôtej de Ville, rue Galipeault, Thurso, comté de Papineau.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Thurso, (Comté de Papineau), ce 15 juillet 1958.Le Secrétaire-trésorier, R.PELLETIER.Adresse postale: Hôtel de Ville, CP.210, Rue Galipeault, Thurso, (Papineau), P.Q., Téléphone: 75.48213-o Province de Québec Ville de Mistassini , (Comté de Lac St-Jean) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Réal Lalancette, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, Mistassini, comté de Lac St-Jean, jusqu'à 7 h.30 du soir, lundi, le 4 août 1958, pour l'achat de $125,000.00 d'obligations de la ville de Mistassini, comté de Lac St-Jean, datées du 1er juin 1958 et remboursables par séries du 1er juin 1959 au 1er juin 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% pour les échéances de 1959 à 1968 inclusivement, non inférieur à 4H% pour les échéances de 1969 à 1978 inclusivement, et non supérieur à 5% pour les échéances de 1959 à 1978 inclusivement, payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.July 1st, 1968 .3,000.00 July 1st, 1969.3,000.00 July 1st, 1970 .3,000.00 July 1st, 1971.3,500.00 July 1st, 1972.3,500.00 July 1st, 1973 .3,500.00 July 1st, 1974 .4,000.00 July 1st, 1975 .4,000.00 July 1st, 1976.4,500.00 July 1st, 1977 .4,500.00 July 1st, 1978 .5,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any.by certified cheque payable at par at Thurso, county of Papineau.x Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as the branches of said bank in Ottawa and Toronto.The said bonds shall not be redeemable by anticipation prior to July 1st, 1968 inclusive; after which date, the said bonds may, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a-certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday, August 6, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the City Hall, Galipeault Street, Thurso, county of Papineau.The Council is not bound to accept the highest or any of the tenders.Thurso, (County of Papineau), this July 15, 1958.R.PELLETIER, Secretary-Treasurer.Post Office address: City Hall, P.B.210, Galipeault Street, Thurso, (Papineau), P.Q., Telephone: 75.48213 Province of Quebec Town of Mistassini (County of Lake St.John) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Real Lalancette, Secretary-Treasurer, City Hall, Mistassini.county of Lake St.John, until 7.30 p.m.o'clock Monday, August 4, 1958 for the purchase of an issue of $125,000.00 of bonds of the Town of Mistassini, county of Lake St.John, dated June 1st, 1958 and redeemable serially from June 1st, 1959 to June 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate of not less than 4% for maturities from 1959 to 1968 inclusive, nor less than for maturities from 1969 to 1978 inclusive nor over 5% for maturities from 1959 to 1978 inclusive, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities. 2516 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 Règlement d'emprunt No 55 \u2014 $125,000.00 \u2014 Loan by-law No.55 \u2014 $125,000.00 \u2014 muni-travaux municipaux.ci pal works.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul For adjudication purposes only; interest shall 'intérêt sera fait à compter du 1er septembre be calculated as from September 1st, 1958.The table of redemption is as follows: d 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $125,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1959.$4,000.00 1er juin 1960.4,000.00 1er juin 1961.4.000.00 1er juin 1962 .4,500.00 1er juin 1963.4.500.00 1er juin 1964.5.000.00 1er juin 1965 .5,000.00 1er juin 1966.5.500.00 1er juin 1967.5,500.00 1er juin 1968 .6,000.00 1er juin 1969.6.000.00 1er juin 1970 .6,500.00 1er juin 1971.6,500.00 1er juin 1972 .7,000.00 1er juin 1973 .7,500.00 1er juin 1974.8,000.00 1er juin 1975.8,500.00 1er juin 1976 .8,500.00 1er juin 1977.9,000.00 1er juin 1978 .9,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Dolbeau, comté de Lac St-eJan.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juin 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 4 août 1958, à 7 heures 30 du soir, en l'Hôtel de ville, Mistassini, comté de Lac St-.Iean.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Mistassini, (Comté de Lac St-Jean), ce 15 juillet 1958.Le Secrétaire-trésorier, REAL LALANCETTE.Adresse postale: Hôtel de Ville, CP.97, Mistassini, (Lac St-Jean), P.Q.Téléphone: 1140.48214-o Table of redemption \u2014 $125,000.00 \u2014 20 years Year Capital June 1st, 1959.$4,000.00 June 1st.1960 .4,000.00 June 1st, 1961.4,000.00 June 1st.1962.:.4,500.00 June 1st, 1963.4,500.00 June 1st, 1964 .5,000.00 June 1st, 1965 .5,000.00 June 1st, 1966.5,500.00 June 1st.1967 .5,500.00 June 1st, 1968 .6,000.00 June 1st, 1969 .6,000.00 .June 1st, 1970.6.500.00 June 1st, 1971.6,500.00 June 1st, 1972 .7,000.00 June 1st, 1973.7,500.00 June 1st, 1974 .8,000.00 June 1st, 1975.8,5-00.00 June 1st, 1976 .8,500.00 June 1st, 1977 .9,000.00 June 1st, 1978.9,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Dolbeau, county of Lake St.John.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation prior to June 1st, 1968 inclusive, after which date the said bonds may under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part^ at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will l>e opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday,.August 4.1958.at 7.30 o'clock p.m.at the City Hall, Mistassini, county of Like St.John.The Council is not bound to accept the highest or any of the tenders.Mistassini, (County of Lake St.John), this July 15.1958.REAL LALANCETTE, Secretary-Treasurer.Post Office address: City Hall, P.B.97, Mistassini, (Lake St.John), P.Q.Telephone: 1140.48214 Vente \u2014 Loi de faillites Sales \u2014 Bakrupcy Act Canada.Province de Québec, district de St-François-Bedford, Cour Supérieure \"En Faillite\", N° 2023.Dans l'affaire de la faillite de Roger Nadeau.commerçant d'automobiles, 99, rue St-Jacques, Asbestos, Que.Canada.Province of Quebec, District of St.Francis-Bedford, Superior Court \"Sitting in Bankruptcy\", No.2023.In the matter of the bankruptcy of Roger Nadeau, automobile dealer, 99 St.James Street, Asbestos, Que. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2517 VENTE A L'ENCAN Avis est par les présentes donné que: MARDI, le DOUZE AOÛT 1958, à DEUX heures de l'après-midi, seront vendus par encan public, à la porte de l'église de la paroisse de St-Aimé de Shipton, à Asbestos, comté de Richmond, Que., les immeubles ci-après décrits, savoir: \"Le lot numéro cent cinq de la subdivision officielle du lot originaire cinq (5-105) aux plan et livre de renvoi officiel du cadastre pour le village d'Asbestos, mesurant cinquante pieds de front par cent pieds de profondeur, borné au nord-ouest par la rue Bourdeau, au nord-est par la rue St-Jacques, au sud-est par le lot 5-104 et au sud-ouest par le lot numéro 5-117, sans bâtisses.\" \"Un emplacement voisin situé du côté sud-ouest de celui ci-dessus décrit en premier lieu, désigné comme étant la partie nord-est du lot numéro cent dix-sept de la subdivision officielle dudit lor originaire numéro cinq (5-ptie N.E.117) auxdits plan et livre de renvoi officiels, bornée, ladite partie comme suit: au nord-est, par le lot 5-105 ci-dessus décrit, au sud-ouest par le résidu dudit lot 5-117, en front au nord-ouest, par la rue Bourbeau, et en arrière, au sud-est par partie du lot 5-104, mesurant environ cinquante pieds de largeur en front sur la rue Bourbeau, par toute la profondeur, soit toute la largeur dudit lot 5-117, moins la partie de ce lot ayant fait l'objet d'un bail conditionne! par Roger Nadeau à Albert Ringuetté, suivant acte reçu devant Me Armand Corbeil, notaire, le 2 septembre 1953, sous le numéro 5487 de son répertoire; Avec les bâtisses dessus construites, notamment un garage portant le numéro civique 70 rue Bourbeau, Asbestos, et dépendances.\" Cçs immeubles seront vendus au plus haut et dernier enchérisseur, à charge des rentes et autres servitudes qui j>euvcnt exister.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant au syndic soussigné.Cette vente est faite conformément aux articles 716, 717 et 719-A du C.P.C.et aussi à l'article 55 de la Loi sur la faillite; cette vente équivaut à la vente au shérif.Le tout suivant jugement rendu par l'Honorable Tribunal des Faillites, pour la division numéro 4 St-François-Bedford.Conditions de paiement: argent comptant.Victoriaville, ce 27 juin 1958.Le Syndic, JEAN ROY, C.A.120, Est, rue Notre-Dame, Victoriaville, Que.48122-27-2-.AUCTION SALE Notice is hereby given that on TUESDAY, the TWELFTH day of AUGUST 1958, at TWO o'clock in the afternoon, shall \\te sold by public auction, at the door of the church of the parish of St.Aimé de Shipton, at Asbestos, county of Richmond, Que., the immoveables hereinafter described, to wit: \"Lot number one hundred and five of the official subdivision of original lot five (5-105) of the official plan and book of reference for the village of Asbestos, measuring fifty feet of frontage by one hundred feet of depth, bounded northwesterly by Bourbeau Street, northeasterly by St.James Street, southeasterly by lot 5-104 and southwesterly by lot number 5-117, without buildings.\" \"A neighbouring emplacement situate on the southwesterly side of that described hereinabove, firstly, designated as being the northeasterly part of lot number one hundred and seventeen of the official subdivision of said original lot number five (5-P.N.E.117) on the said official plan and book of reference, said part bounded as follows: northeasterly by lot 5-105 described hereinabove, southwesterly by the residue of said lot 5-117, in front to the northwest, by Bourbeau Street, and in the rear, southwesterly by part of lot 5-104, measuring some fifty feet wide in front along Bourbeau Street, by the entire depth, that is all the width of said lot 5-117, minus that part of said lot having been the subject of a conditional lease between Roger Nadeau and Albert Ringuette, according to deed received before Me Armand Corbeil, Notary, September 2, 1953, under number 5487 of his records; With buildings thereon erected, notably a garage bearing civic number 70 Bourbeau Street, Asbestos, and dependencies.\" These immoveables shall be sold at the last and highest bidder, with rents and other servitudes which may exist as a charge thereon.Titles and certificates may be examined at any time by applying to the undersigned trustee.This sale is carried out pursuant to articles 710, 717 and 719-A of the C.C.P.and also article 55 of the Bankruptcy Act; this sale is equivalent to a sale by Sheriff.All of which according to a Judgment rendered by the Honourable Bankruptcy Court, for division number 4 St.Francis-Bedford.Conditions of sale: Cash.Victoriaville, this June 27, 1958.JEAN ROY, C.A., Trustee.120 Notre Dame Street, East, Victoriaville, Que.48122-27-2 Province de Québec, division N° 4, St-François-Bedford, Cour Supérieure (En faillite), N° 2140-1957.Dans l'affaire de la faillite de: Robert Bélanger (Red Clovers Cabins), St-Armand Ouest (Phillipsburgh), comté de Missisquoi, P.Q., failli, et Rémi Lévesques, syndic.Province of Quebec, division No.4, St.Francis-Bedford, Superior Court (Sitting in Bankruptcy).No.2140-1957.In the matter of the bankruptcy of: Robert Bélanger (Red Clovers Cabins), St, Armand West (Phillipsburgh), Missisquoi county, P.Q., Bankrupt, and Rémi Lévesque, trustee. 2618 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N° 29 AVIS DE VENTE Avis public est par les présentes donné que l'immeuble suivant, savoir: Un terrain ou emplacement sis et situé dans la paroisse de St-Armand Ouest, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour ladite paroisse de St-Armand Ouest, comme étant partie du lot numéro trente-quatre (P.34), mesurant six cent vingt-et-un pieds (621') dans la ligne ouest longeant la nouvelle route N° 7 conduisant de Montréal à St-Alban, deux cent trente pieds (2300 dans 1* ligne nord, environ sept cent quatre-vingt pieds (780') dans la ligne est longeant le vieux tracé de la route 7, le tout mesure anglaise, et borné ledit terrain comme suit: à l'ouest par la nouvelle route 7, Montréal-St-Alban, au nord par un chemin privé faisant partie dudit lot numéro 34, à l'est par le vieux tracé de la route 7, et au sud-ouest par une parcelle dudit lot numéro 34 et appartenant au gouvernement de la province de Québec, avec toutes les bâtisses dessus érigées, notamment celles servant de restaurant, ainsi que dix-sept cabines.\u2014 Aussi compris le droit à perpétuité en faveur de l'acquéreur et ses successeurs et ayant cause de puiser l'eau à la source naturelle d'eau qu'il y a sur la ferme de feu Adhémar Messier formant partie dudit lot numéro 34 dudit cadastre pour la paroisse de St-Armand Ouest, ladite source étant à environ deux cent cinquante pieds de l'emplacement ci-haut décrit, et à cet effet lé droit de passage nécessaire sur ladite ferme jusqu'à l'emplacement ci-haut décrit, ainsi que le droit de poser des conduites d'eau souterraines pour emmener l'eau de ladite source .jusqu'aux bâtisses de l'emplacement plus haut désigné; et il est entendu que les frais d'entretien de ladite source sont pour une moitié aux frais de l'acquéreur ou ses successeurs, et pour l'autre moitié aux frais de la succession Adhémar Messier ou représentants légaux: en outre le chemin de vingt-cinq pieds de lafgeur et de deux cent trente pieds de longueur, longent ladite ligne nord du terrain de l'acquéreur sera mitoyen, mais son entretien sera aux frais de l'acquéreur.Enfin il est entendu que la succession Adhémar Messier ou représentants légaux, auront la priorité de puiser l'eau à ladite source pour les besoins de la ferme susmentionnée.Sera vendu en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure pour le district de St-François-Bedford (en faillite), rendu le 4e jour de juillet 1958, à l'enchère publique suivant les dispositions des articles 55 et suivants de la Loi de 1949 sur la faillite, pour ladite vente avoir l'effet du décret aux termes du Code de Procédure Civile.La vente aura lieu le VINGTIEME jour d'AOÛT 1958, à la porte de l'église paroissiale de St-Philippe de Philiipsburgh (St-Armand Ouest) comté de Missisquoi à DIX heures et TRENTE de l'avant-midi, heure avancée de l'est.Conditions: Comptant.Aucune enchère ne sera acceptée à moins qu'elle ne soit accompagné d'un dépôt de $1,030.00 (10% de l'évaluation municipale) en argent ou par chèque visé à l'ordre du syndic.En plus du prix d'achat l'acquéreur devra payer les droits du Gouvernement de 2%% conformément à la Loi.Pour autres renseignements et cahier des charges, s'adresser au soussigné.NOTICE OF SALE Public notice is hereby given that the following immoveable, to wit: t A piece of land or emplacement lying and situated in the parish of St.Armand West, known and designated on the official plan/and book of reference of the cadastre for said parish of St.Armand West, as being part of lot number thirty-four (P.34), measuring six hundred and twenty-one feet (621') along its westerly line bordering the new Highway No.7 leadmg to Montreal at St.Albans, two hundred and thirty feet (230') along its northerly line, some seven hundred and eighty feet (780') along its easterly line bordering the old lay-out of Highway No.7, alt of which in English measure, and bounded, the said land, as follows: westerly by the new Highway No.7, Montreal-St.Albans, northerly by a private road forming part of said lot number 34, easterly by the old lay-out of Highway 7, and southwesterly by a parcel of said lot number 34 and belonging to the Government of the Province of Quebec, with all the buildings thereon erected, notably those serving as a restaurant, as well as seventeen cabins.Also included a right for ever in favour of the purchaser, his successors and legal assignees, to draw water from a naturel source of spring-water on the farm of the late Adhémar Messier forming part of said lot No.34 of said cadastre for the parish of St.Armand West, the said source being located at some two hundred and fifty-five feet from the emplacement described hereinabove, and for said purpose, the required right-of-way on said farm as far as the emplacement hereinabove described, as well as the right to lay underground water piping in order to bring water from the said source as far as the buildings located on the emplacement designated above; and it is understood that the maintenance costs of said source to be divided as follows; on half to be assumed by the purchaser or successors and the other half by the Adhémar Messier estate or legal representatives: moreover *the road of twenty-five feet in width and two hundred and thirty feet in length, bordering said northerly line of the purchaser's land shall be in common, but its maintenance shall be at the expense of the purchaser.Finally, it is understood that the Adhémar Messier estate or legal representatives, shall have priority as to drawing water from said source for the needs of the above-mentioned farm.Shall be sold by virtue of a judgment of the Superior Court for the district of St.Francis-Bedford (Sitting in Bankruptcy), rendered the 4th day of July 1958, by public auction according to the provisions of articles 55 and the following of the Bankruptcy Act 1949, the said sale to have the effect of a sale by Sheriff in the terms of the Civil Code of Procedure.The sale shall take place on the TWENTIETH day of AUGUST 1958, at the door of the parochial Church of St.Philippe de Philiipsburgh (St.Armand West), Missisquoi county, \" at TEN-THIRTY o'clock in the forenoon, Eastern Daylight Saving Time.Conditions: Cash.No bid shall be accepted unless it be accompanied by a deposit of $L030:00 (10% of the municipal valuation) in cash or an accepted cheque to the order of the trustee.Over and above the purchasing price, the purchaser shall pay a Government tax of 2^% in accordance with the Law.For further information and the list of charges, apply to the undersigned. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2519 Daté à Montréal, ce 5e jour de juillet 1958.Dated at Montreal, this 5th day of July 1958.Le Syndic, RÉMI LÉVESQUE, RÉMI LÉVESQUE.Trustee.Bureau: Office: , 4277 Delorimier, Montréal.48143-28-2-o 4277 Delorimier, Montreal.48143-28-2 Vente par licitation Canada, Province de Québec, district de Québec, N° 90-939.Dans la Cour Supérieure.Dominique Asselin, vérificateur, de Beauport, Gemma Asselin, fille majeure, de Beauport, Jean Asselin, employé de la cité de Québec, Françoise Asselin, fille majeure de Beauport, Gabriel Asselin, employé de la cité de Montréal, Dame Thérèse Asselin, ménagère, épouse séparée de biens de Maurice Parent de Beauport et ce dernier pour autoriser \"et assister son épouse aux fins des présentes, Dame Lucienne Asselin, ménagère, épouse séparée de biens de Gilbert .Drouin, voyageur de Beauport, et ce dernier pour autoriser et assister son épouse aux fins des présentes, demandeurs, vs Gérard Asselin, 17, rue Carette, Thetford Mines, défendeur.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à Québec, dans le district de Québec, le 2 juillet 1958, dans une cause entre les parties ci-dessus désignées, ordonnant la licitation de certains immeubles désignés comme suit, savoir: a) Une propriété située en la ville de Beauport, côté ouest de la rue du Manège, comprenant: La subdivision vingt-cinq du lot originaire N° quatre cent soixante-huit (468-25) et la subdivision vingt du lot originaire N° quatre cent soixante-treize (473-20) du cadastre officiel de Beauport; Une lisière de terrain faisant partie de la subdivision vingt-quatre du lot originaire N° quatre cent soixante-huit (468-24 ptie) et de la subdivision dix-neuf du lot originaire N° quatre cent soixante-treize (473-19 ptie) dudit cadastre de Beauport, comprenant toute la largeur qu'il peut y avoir entre la propriété de Jean Giroux, faisant partie des mêmes lots, au sud, et les lots 468-25 et 473-20 au nord, par toute la profondeur contenue entre la rue du Manège à l'est et le lot 473 non subdivisé à l'ouest; ~ Une partie non subdivisée du lot originaire N° quatre cent soixante-treize (473 ptie) du cadastre officiel de Beauport, comprenant toute la profondeur qu'il peut y avoir entre l'emplacement de Roland Tremblay et le chemin de sortie au sud et le terrain de la ville de Beauport au nord, par environ soixante-sept pieds de largeur; bornée au sud par la prorpiété de Roland Tremblay et le chemin de sortie (473 ptie), vers l'ouest par le lot 472, vers le nord par une autre partie dudit lot 473 appartenant à la ville de Beauport et vers l'est par les subdivisions dudit lot 473.Le tout avec maison, magas n et entrepôt dessus construits, circonstances et dépendances.b) Un emplacement faisant partie du lot originaire N° quatre cent soixante-treize (473 ptie) du cadastre officiel de Beauport, comprenant toute la profondeur qu'il peut y avoir entre le terrain de la ville de Beauport au sud et celui de Ls.de G.Giroux ou représentants et vers l'est par les subdivisions du lot 473, sans bâtisse.Sale by Licitation V Canada, Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court, No.90-939.Dominique Asselin, auditor, of Beauport, Gemma Asselin, fille majeure, of Beauport, Jean Asselin.employee of the city of Quebec, Françoise Asselin, fille majeure, of Beauport, Gabriel Asselin, employee of the city of Montreal; Dame Thérèse Asselin housewife, wife separate as to property of Maurice Parent, of Beauport and the latter in order to authorize and assest his wife for the proposes herein, Dame Lucienne Asselin, housewife, wife separate as to property of Gilbert Drouin, traveller, of Beauport, and the latter to authorize and assist his wife for the purposes her in, plaintiffs vs Gérard Asselin, 17 Carette Street, Thetford Mines defendant.NOTICE OF LICITATION Notice is given that by virtue of a judgment rendered by the Superior Court, sitting at Quebec, in the district of Quebec, July 2, 1958, in a cause between the parties hereinabove designated, ordering the licitation of certain immoveables described as follows, to wit: \u2022 o) A property situated in the town of Beauport, on the west side of du Manège Street, comprising: Subdivision twenty-five of original lot No.four hundred and sixty-eight (468-25) and subdivision twenty of original lot No.four hundred and seventy-three (473-20) of the official cadastre of Beauport; A strip of land forming part of subdivision twenty-four of original lot No.four hundred and sixty-eight (468-24)-of subdivision nineteen of original lot No.four hundred and seventy-three (473-19) of the said cadastre of Beauport, comprising all that width which may exist between the property of Jean Giroux, forming part of the same lots, to the south, and lots 468-25 and 473-20 to the north, by all the depth contained between du Manège Street easterly and non-subdivided lot 473 to the west; A non-subdivided part of original lot No.four hundred and seventy-three (P.473) of the official cadastre of Beauport, comprising all that depth which may exist between the emplacement of Roland Tremblay and the exit road south of the land of the town of Beauport to the north, by some sixty-seven feet in width; bounded southerly by the property of Roland Tremblay and the exit road (P.473), westerly by lot 477, northerly by another part of said lot 473 belonging to the town of Beauport and easterly by the subdivisions of lot 473.All of which with house, store and warehouse thereon erected, circumstances and dependencies.b) An emplacement forming part of original lot No.four hundred and seventy-three (P.473) of the official cadastre of Beauport, comprising all that depth which may exist between the land of the town of Beauport to the south and that of Ls.de G.Giroux or representatives and easterly by the subdivisions of lot 473.without buildings. 2620 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90,N°29 - Les immeubles ci-dessus designés seront mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, le VINGT-NEUF AOÛT 1958, à DIX heures et TRENTE a.m., au bureau du protonotaire du district de Québec, au Palais de justice, à Quél>ec.sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de ladite Cour; et que toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à ladite licitation, devra être déposée au greffe du protonotaire de ladite Cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et, à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.Québec, le 10 juillet 1958.I«cs Procureurs des demandeurs, TURGEON, LESAGE et BIENVENUE.48202-29-2-O The immoveables hereinabove designated shall be put up for sale by auction and adjudged to the highest and last bidder, on the TWENTY-NINTH day of AUGUST, 1958, at TEN-THIRTY o'clock a.m., in the office of the prothonotary of the district of Quebec, in the Court House, at Quebec, subject to charges, clauses and conditions indicated in the list of charges deposited in the office of the prothonotary of the said Court; and that any opposition to annul, to secure charges or to withdraw, to be made to the said licitation, must be filed in the office of the prothonotary of the said court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication and any opposition for payment must be filed within six days following the adjudication and failing the interested parties to file such opposition within the dalys hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.Quebec.July 10, 1958.TURGEON, LESAGE et BIENVENUE.48202-29-2 Attorneys for plaintiffs.Ventes pour taxes Sales/ for Taxes Province de Québec Ville Montréal.-Nohd (Comté de Laval) Avis public est.par les présentes, donné que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère, à l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord, MERCREDI, le SIX (6) AOÛT, mil neuf cent cinquante-huit (1958), à DIX (10) heures de l'ayant-midi, heure avancée, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.La Commission Municipale de Québec, par décision en date du 30 juin 1958, a autorisé une enumeration abrégée «les numéros cadastraux des immeubles, sous l'autorité de la Loi des Cités et Villes, article 550, tel qu'amendé par 24 George \"V, chapitre 33, section 3.Province of Quebec Town of Montreal North (County of Laval) Public notice is hereby given that the properties hereinafter described will be sold by auction at the office of the Council of theTown of Montreal North, on WEDNESDAY, the SIXTH (6) of AUGUST, nineteen hundred and fifty-eight (1958), at TEN (10) o'clock in the forenoon, daylight saving time, to satisfy the payment of the municipal and school taxes, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.The Quebec Municipal Commission, by a decision, dated June 30th 1958, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of the article 550, of Cities and Town Act, as amended by 24, (ieorge V, chapter 33, section 3.Noms dos propriétaires Names of proprietors Jean-Paul Dupéré (Avec bâtisse dessus érigée \u2014 With building thereon erected) Association du Bien Être de la Jeunesse.Jean-Paul Dupéré (Avec bâtisse dessus érigée\u2014With building thereon erected) Isidore Hercy.D.L.Hughes (Mlle-Miss).Florian Pomcrleau (Avec bâtisse dessus érigée\u2014With building thereon erected) A distraire cependant des susdits lots une certaine partie vendue & la Ville Montréal-Nord pour l'élargissement du Boulevard St-Michel \u2014 To distract from the said lots a certain part sold to the Town of Montreal North for the widening of St.Michel Blvd.Patrick Trotticr (Avec bâtisse dessus érigée\u2014With building thereon erected).Diamond Investment Corp.Subdivisions 241.242.915.37-2.125, 126, 127 51».542, 543.290.297.955, 956.18 Les immeubles susdits sont tous du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet, et situés dans la Ville Montréal-Nord.The above immoveables are all in the plan and book of reference of the parish of Sault-au-Récollet, and situated in the Town of Montreal North.Ladite vente sera en outre faite avec toutes The said sale will be made with all active and les servitudes actives et passives ou occulte, passive servitudes apparent or occult, attached attachées auxdits immeubles.to the said properties. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2521 Donné en la Ville Montréal-Nord, ce huitième (8) jour du mois de juillet, mil neuf cent cinquante-huit (1958).(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 48162-28-2-0 RENÉ BERGERON, c.a.La corporation de la cité des Trois-Rivières Avis public est par le présent donné que le DOUZIÈME jour du mois d'AOÛT, mil neuf cent cinquante-huit, à DIX heures de l'avant-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la cité des Trois-Rivières, les terres et héritages ci-dessous désignés seront vendus comme étant grevés de taxes sur trottoirs permanents non exigibles, qui n'ont pas été payées dans les six mois après l'avis du dépôt du rôle, tel que requis par la loi, savoir: 1° Un emplacement situé sur la rue St-Chris-tophe en la cité des Trois-Rivières connu et désigné comme étant le lot N° 63 de la subdivision officielle du lot N° 1124 (1124-63) du cadastre officiel de la cité des Trois-Rivières, sans bâtisses, comme appartenant à M.Clément Campbell; y 2° Un emplacement situé en la cité des Trois-Rivières, connu et désigné comme étant une partie de forme irrégulière du lot N° 1119 du cadastre officiel de la cité des Trois-Rivières borné vers le nord-ouest par le lot N° 1119-A, vers le nord-est par la rivière St-Maurice et vers l'est, le sud-est et le sud-ouest par les subdivisions 960 à 953 du lot N° 1119, donnant une superficie de 132,334 pieds carrés, mesures anglaises, sans bâtisses, comme appartenant à M.Marcel La-flamme.Trois-Rivières.Le Greffier de la Cité, Hôtel-de-Ville.GEORGES BEAUMIER.le 12 juillet 1958.48204-29-2-O Given at the Town of Montreal North, this eighth (8) day of July, nineteen hundred and fifty-eight (1958).(Seal) RENÉ BERGERON, c.a., 48162-28-2-o Secretary-Treasurer.The corporation op the city of Trois-Rivières Public notice is hereby given that on the TWELFTH day of the month of AUGUST, one thousand nine hundred and fifty-eight, at TEN o'clock in the forenoon, at the City Hall of the city of Trois-Rivières, the lands and tenements hereinunder designated shall be sold as being burdened with taxes, non-claimable on permanent sidewalks, which have not l)een paid within the six months following the notice of the depositing of the collection roll, as required by Law, to wit: 1.An emplacement situated on St.Christophe Street, in the city of Trois-Rivières, known and designated as l>eing lot No.63 of the official subdivision of lot No.1124 (1124,-63) of the official cadastre of the city of Trois-Rivières, minus buildings, as belonging to Mr.Clément Campbell; 2.An emplacement situated on the city of Trois-Rivières, known and designated as being a part of lot No.1119, of irregu'ar shape, of the official cadastre of the city of Trois-Rivières bounded northwesterly by lot No.1119-A, northeasterly by the River St.Maurice and easterly, southeasterly and southerly by subdivisions 960 to 953 of lot No.1119, an area of 132,-334 square feet, English measure, minus buildings, as belonging to Mr.Marcel Laflamme.Trois-Rivières, GEORGES BEAUMIER, City Hall, City Clerk.July 12, 1958.48204-29-2 VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ABITIBI Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Cour Supérieure, / A DRIEN LUSSIER.N° V-3774.\\ marchand de St- l Edmond, district d'Abitibi, saisissant; vs ROGER GUILBERT, mineur, de St-Edmond, district d'Abitibi, saisi.AVIS DE VENTE L'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 47 du rang V, aux plan et livre de renvoi officiel pour le canton Vassan, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Edmond de Vassan, le VINGTIÈME jour d'AOÛT 1958 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi,.Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, 10 juillet 1958.48203-29-2-O SHERIFF'S SALES PUBLIC NOTICE, is hereby riven that the undermentioned LANDS and* TENEMENTS have been seized, and will he sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Superior Court, / A DRIEN LUSSIER, No.V-3774.\\ merchant of St- l Edmond, district of Abitibi.distrainor; vs ROGER GUILBERT, miner, of St-Edmond, district of Abitibi, distrainee.NOTICE OF SALE The immoveable known and designated as being lot number 47 of range V, on the official plan and in the book of reference for the Vassan township, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of St-Edmond de Vassan on the TWENTIETH day of AUGUST, 1958, at TWO o'clock in the afternoon.J.A.GAUTHIER.Sheriff's Office, Sheriff of Abitibi.Amos, July 10.1958.48203-29-2-O 2522 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N° 29 CHICOUTIMI Fieri Fadas District de Chicoutimi Cour Supérieure, / t A CD3 INDUSTRIELLE N° 23,102 < -l» DU SAGUENAY LTÉE, (corporation légalement constituée ayant une place d'affaire en les cité et district de Chicoutimi, demanderesse; vs LOUIS-PHIUFPE LAROUCHE, domicilié à St-Am-b roi se, comté et district de Chicoutimi, défendeur.Un lopin de terre ou emplacement connu et désigné au cadastre officiel pour le rang est (Rg.E.), du Canton Bourget, comme formant partie du lot numéro vingt-sept, (Ptie 27), lequel terrain mesure trente pieds (30') de largeur de l'est à l'ouest, sur trois cents pieds (300') de profondeur du nord-au sud, et est borné vers le nord, par le chemin public, vers l'ouest, par le terrain de Fernand Larouche, vers le sud, par le terrain de Auguste Larouche.et ses représerr-tants, et vers l'est, par le terrain de Dame Clermont Décoste née Cecilia Larouche, avec ensemble les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Un lopin de terre à l'emplacement connu et désigné au cadastre officiel, pour le rang est (rg E) du canton Bourget, comme formant partie du lot numéro vingt-sept (ptie 27) laquelle dite lisière du terrain mesure dix pieds (10') de largeur de l'ouest à l'est, sur trois cents pieds (300') de profondeur du nord au sud, et est bornée vers le nord par le chemin public, vers l'ouest par une partie résiduelle dudit lot dont il forme partie, propriété de Louis-Philippe Larouche, vers le sud par une autre partie résiduelle dudit lot dont il forme partie, propriété d'Auguste Larouche ou ses représentants, et vers l'est par Une autre partie résiduelle dudit même lot dont il forme partie, propriété de Dame Cécilia Larouche, avec ensemble les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Un lopin de terre à l'emplacement connu et désigné au cadastre officiel pour le rang est (rg E) du canton Bourget comme formant partie du lot numéro vingt-sept (Ptie 27) laquelle dite lisière du terrain mesure dix pieds (10') de largeur de l'ouest à l'est sur trois cents pieds (300') de profondeur du nord au sud et est borné vers le nord par le chemin public, vers l'ouest par une partie résiduelle dudit lot dont il forme partie, propriété de Fernand Larouche, vers le sud par.une autre partie résiduelle dudit lot dont il forme partie, propriété de Auguste Larouche ou ses représentants, et vers l'est par une autre partie résiduelle dudit même lot dont il forme partie, propriété de Louis-Philippe Larouche, avec ensemble les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus en bloc à la porte de l'église paroissiale de St-Ambroise, le TRENTE ET UNIÈME jour du mois de JUDLLET 1958, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RENÉ DELISLE.Chicoutimi, le 21 juin 1958.48081-2G-2-o CHICOUTIMI Fieri Facias District of Chicoutimi Superior Court, / t A CD3 INDUSTRIELLE No.23,102 -J -l* DU SAGUENAY LTÉE, v legally incorporated corporation having a place of business in the city and district of Chicoutimi, plaintiff; vs LOUIS-PHILIPPE LAROUCHE, domiciled at St-Ambroise, county and district of Chicoutimi, defendant.A strip of land or emplacement known and designated on the official cadaster for the \"East range (East Range) of Bourget Township, as forming part of lot number twenty-seven, (Pt.27), which lot of land measures thirty feet (30') in width from East to West, by three hundred feet (300') in depth from North to South, and is bounded on the North the public road, on the West, by the land of Fernand Larouche.by Larouche, on the South, by the lot of land of Auguste Larouche and his representatives,\"and on the East, by the land of Dame Clermont Decoste née Cecilia Larouche, together with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.A strip of land on the emplacement known and designated on the official cadaster, for the East Range (Range E) of the Bourget Township, as forming part of lot number twenty-seven (Pt.27) which said strip of land measures ten feet (10') in width from West to East, on three hundred feet (300') in depth from North to South, and is bounded on the North by the public road, on the West by a residual part of the said lot of which it forms part, property of Louis-Philippe Larouche, on the South by another residual part of the said lot of which it forms part, property of Auguste Larouche or his representatives, and on the East by another residual part of the same said lot of which it forms part, property of Dame Cecilia Larouche, together with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.A strip of4and on the emplacement known and designated on the official cadaster of the East Range (East Range) of the Bourget Township as forming part of lot number twenty-seven (Pt.27) which said strip of land measures ten feet (10') in width from West to East along three hundred feet (300') in depth from North to South and is bounded on the North by the public road, on the West, by a residual part of the said lot of which it forms part, property of Fernand Larouche, on the South, by another residual part of the said lot of which it forms part, property of Auguste Larouche or his representatives, and on the East, by another residual part of the same lot of which it forms part, property of Louis-Philippe Larouche, together with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold in block at the parochial church door of St-Ambroise, on the THIRTY-FIRST day of the month of JULY, 1958, at THREE o'clock in the afternoon.RENE DELISLE, Sheriff's Office, Sheriff.Chicoutimi, June 21, 1958.48081-26-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2523 HULL Canada \u2014 Province de Québec District de Hull Cour Supérieure, (J A CAISSE POPULAIRE N° 6137.NOT RE-DA ME l DE HULL, corporation civile dûment incorporée sous l'autorité de la Loi des Syndicats Coopératifs de la Province de Québec, ayant sa principale place d'affaires à Hull, dit district, demanderesse, vs Dame MARIE THÉRÈSE PARENT, épouse contractuellement séparée de biens de Gérard Gauvreau, homme d'affaires domicilié et résidant à Hull, dit district, et ce dernier pour autoriser son épouse aux 6ns des présentes, défenderesse.\"Un immeuble sis à Hull, comté de Hull, province de Québec, consistant en toute cette propriété connue et désignée comme étant le4ot quatre (4) de la re-sub-division officielle du lot un (1) de la sub-division officielle du lot original quatre (4) du quartier un (1), au plan et livre de renvoi de la cité de Hull, avec bâtisess dessus érigées, circonstances et dépendances, et telles bâtisses portant le numéro civique 169 de la rue Caron, en la cité de Hull.\" Pour être vendu à mon bureau, au Palais de Justice, en la cité de Hull, le TRENTE ET UNIÈME jour du mois de JUILLET 1958, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST-PIERRE.Ce 23 juin, 1958.48092-26-2-o Canada \u2014 Province de Québec District de Hull Cour Supérieure, / T> RUNO POTVIN, contrac-N° 6603.< -L* teur, demeurant à Mas-Ison, district de Hull, demandeur; vs WILBERT BIGELOW, gentilhomme, demeurant à Buckingham, district de Hull, défendeur, et F.LEDUC, notaire, registrateur de la division d'enregistrement du comté de Papineau, district de Hull, mis-en-cause.\"Un morceau de terrain connu et désigné comme étant partie du lot numéro douze \"A\" du cadastre officiel pour le quatrième rang du canton de Buckingham (Ptie.No.12A rang 4) maintenant compris dans les limites de la ville de Buckingham telle que plus au long décrite dans l'acte de vente par Robert Bruce Walker audit Vilbert Bigelow devant Me Roger Munn, notaire, le 19 octobre 1956, et enregistré au bureau d'enregistrement de la division de Papineau, le 24 novembre 1956, sous le No.79667; borné â l'est par les lots, les rues et la propriété de G.H.Sigouin y décrite, au sud par le résidu sud dudit lot 12-A propriété de Rolland Acres ou représentants, à l'ouest par le lot 13-B, propriété de John McFaul ou représentants, et au nord par le résidu dudit lot 12-A ayant front sur le chemin entre les rangs 4 et 5 dudit canton de Buckingham, appartenant â Elzéar Laileur ou représentants.\"A déduire toutefois dudit terrain sus-décrit les emplacements déjà vendus tel que relaté en l'acte de vente ci-haut numéro 79667, savoir: a) à S.N.McCullough, vente enregistrée sous numéro 67294; 6) à A.Chénard, par vente enregistrée sous numéro 67295; c) à A.Renaud, par vente enregistrée sous numéro 67331; d) à O.Léplhe, par vente enregistrée sous numéro 67302; HULL Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Superior Court, (TA CAISSE POPULAIHE No.6137.-J ¦l' NOTE E-D AME v DE HULL, a civil corporation duly incorporated under the authority of the Cooperative Syndicates' Act of the Province of Quebec, having its head office at Hull, said district, Plaintiff, vs Dame MARIE THÉRÈSE PARENT, wife contractually separate as to property of Gérard Gauvreau, business-man domiciled and residing at Hull, said district, and the latter to authorize his wife for these present purposes, defendant.\"An immoveable seized at Hull, county of Hull, Province of Quebec, consisting in all this property known and designated as being lot four (4) of the official re-sub-division of lot one (1) of the official subdivision of the original lot four (4) of Ward one (1), on the plan and in the book of reference of the city of Hull, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and such buildings bearing civic number 169 Càron Street, in the city of Hull.\" To be sold at my office, at the Court House, in the city of Hull, on the THIRTY-FIRST day of JULY, 1958, at THREE o'clock in the afternoon.^ R.ST-PRERRE, Sheriff's Office, Sheriff.June 23, 1958.48092-26-2 Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Superior Court, / \"D RUNO POTVIN, contrac-No.6603.< \" tor, residing at Masson, 'district of Hull, plaintiff; vs WILBERT BIGELOW, gentleman, residing at Buckingham, district of Hull, defendant, and F.LEDUC, notary, registrar of the registry division of the county of Papineau, district of Hull, mis-en-cause.\"A piece of land known and designated as being part of lot number twelve \"A\" of the official cadastre for range four of the township of Buckingham (P.No.12A, range 4) presently included in the limits of the town of Buckingham such as described at greater lenght in the deed of sale by Robert Bruce Walker to said Wilbert Bigelow before Me Roger Munn, notary, October 19, 1956, and registered in the registry office of the Papineau division, November 24, 1956, under No.79667; bounded easterly by the lots, streets and the property of G.H.Sigouin described therein, southerly by the residue of said lot 12-A.property of Roland Acres or representatives, westerly by lot 13-B, property of John McFaul or representatives, and northerly by the residue of said lot 12-A fronting on the highway between ranges 4 and 5 of said township of Buckingham, belonging to Elzéar Lafleur or representatives.\"To be excluded however, from the land hereinabove described, those emplacements already sold and such as stated in the above deed of sale number 79667, to wit: a) to S.N.McCullough, sale registered under number 67294; 6) to A.Chénard, by sale registered under number 67295; c) to A.Renaud, by sale registered under number 67331; d) to O.Lépine, by sale registered under number 67302; 2524 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1968, Tome 90, N\" 29 e) à R.R.Desjardins, par vente enregistrée sous numéro 67384; /) à H.E.Sharp, par vente enregistrée sous numéro 67381 ; g) à R.D.Gauthier, par vente enregistrée sous numéro 69758; h) à R.W.MacMiilan, par vente enregistrée sous numéro 67004; i) à Townsend Loyal Orange Lodge, par vente enregistrée sous numéro 72643; j) à Ville de Buckingham, par donation enregistrée sous numéro 77686.Avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église St-Gré-goire de Naziance, en la ville de Buckingham, district de Hull, le VINGT-DEUXIÈME jour du mois d'AOÛT 1958, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST-PIERRE.ce 9 juillet, 1958.48220-29-2-o MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: / TACK SCHWARTZ & AL N° 445156.< J demandeurs; vs Dame (AGNES FOREST, veuve de Joseph Forest, défenderesse.\"Un emplacement ayant front sur la rue de l'Êpée en la cité d'Outremont, mesurant vingt-cinq pieds de largeur par quatre-vingts pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins et composé: a) De la partie sud-est du lot N° trente-trois de la subdivision du lot originaire X trente-trois (P.S.K.N° 33-33) des plan et livre de renvoi officiels de la municipalité de la paroisse de Montréal; mesurant cinq pieds de largeur par quatre-vingts pieds de profondeur; mesure anglaise et plus ou moins; borné en front, au sud-ouest par la rue de l'Épée, en arrière, au sud-est, par une ruelle, dont sept pieds et six pouces de profondeur par ladite largeur de cinq pieds pris à même les quatre-vingts pieds de profondeur, du côté sud-est par la partie ci-après décrite du lot N° 33-34 et du côté nord-ouest par le résidu dudit lot N° 33-33.b) De la partie nord-ouest, contigue à la partie du lot N° 33-33, ci-dessus décrite, du lot N° trente-quatre de la subdivision officielle du lot N° trente-trois (P.N.-O.N° 33-34) des plan et livre de renvoi officiels de la municipalité de la paroisse de Montréal; mesurant vingt pieds de largeur par quatre-vingts pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; bornée en front au sud-ouest, par la rue de l'Êpée, en arrière; au nord-est par ladite ruelle, dont sept pieds et six pouces de profondeur par ladite largeur de vingt pieds, pris à même les quatre-vingts pieds de profondeur, du côté nord-ouest, par la partie ci-dessus décrite du lot N° 33-33 et du côté sud-est par le résidu du lot N° 33-34.Avec une bâtisse à trois logements y érigée, portant les Nos civique 135, 137 et 139 de ladite rue de l'Êpée dont le mur de division nord-ouest est mitoyen et les dépendances y attachées.Pour être vendu, à mon bureau, en la cité de Montréal, le VINGT-DEUXIÈME jour d'AOÛT 1958, à ONZE heures du matin.Le Shérif, CAISSE & LAURENCELLE.Bureau du Shérif, Montréal, 15 juillet 1958.48218-29-2-o e) to R.R.Desjardins, by sale registered under number 67384; /) to H.E.Sharp, by sale registered under number 67381; g) to R.D.Gauthier, by sale registered under number 69758; h) to R.W.MacMiilan, by sale registered under number 67004; i) to Townsend Loyal Orange Lodge, by sale registered under number 72643; j) to town of Buckingham, by donation registered under number 77686; With all buildings thereon erected, circonstances and dependencies.To be sold at the door of the Church of St.Grégoire de Naziance, in the town of Buckingham, district of Hull, the TWENTY-SECOND day of AUGUST 1958, at THREE o'clock in the afternoon.R.ST-PIERRE, Sheriff's Office, Sheriff, this July 9, 1958.48220-29-2 MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: / TACK SCHWARTZ & AL No.445156.< J plaintiffs; vs Dame ( AGNES FOREST, widow of Joseph Forest, defendant.\"An emplacement fronting on de l'Êpée Street in the city of Outrcmont, measuring twenty-five feet in width by eighty feet in depth, English measure and more or less and composed of: o) The southeasterly part of lot No.thirty-three of the subdivision of original lot No.thirty-three (P.S.E.No.33-33) of the official plan and book of reference of the municipality of the parish of Montreal; measuring five feet in width by eighty feet in depth; English measure and more or less; bounded in front to the southwest by de l'Êpé Street, in the rear, to the southeast, by a lane, of which seven feet and six inches of depth by said width of five feet taken from the said eighty feet of depth, on the southeasterly side by the part hereinafter described of lot No.33-34 and on the northwesterly side by the residue of said lot No.33-33.6) The northwesterly part, adjacent to that part of lot No.33-33 hereinabove descril>ed of lot No.thirty-four of the official subdivision of lot No.thirty-three (P.N.W.No.33-34) of the official plan and book of reference of the municipality of the parish of Montreal; measuring twenty feet in width by eighty feet in depth, English measure and more or less, bounded in front to the southwest by de l'Êpée Street, in the rear, to the northeast by said lane, of which seven feet and six inches of depth by said width of twenty feet, taken from the said eighty feet of depth, northwesterly by that part hereinabove described of lot No.33-33 and southeasterly side by the residue of.lot No.33-34; With a house containing three flats thereon erected, bearing civic Nos.135, 137 and 139 of said de l'Êpée Street of which the northwesterly, dividing wall is a common one, and dependencies attached thereto.To be sold, at mv office, in the city of Montreal, the TWENTY-SECOND day of AUGUST 1958, at ELEVEN o'clock in the morning.CAISSE & LAURENCELLE, Sheriff.Sheriff's Office, Montreal, July 15, 1958.48218-29-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.29 2525 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: / A IMÉ MARTIN, de-No-438512.mandeur; vs VVIL- { FRID DUPRÉ, défendeur.\"Un emplacement situé dans la ville de Jacques-Cartier, comté de Chambly, district de Montréal, étant les lots deux cent vingt-trois et deux cent vingt-quatre de la subdivision du lot originaire quatre-vingt-douze (92-223-224) et deux cent quatre-vingt-douze et deux cent quatre-vingt-treize de la subdivision du lot originaire quatre-vingt-onze (91-292-293) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine de Longueuil; ces lots formant deux emplacements et mesurant en tout, soixante pieds de largeur par quatre-vingt-trois pieds de profondeur, mesure anglaise, et plus ou moins, avec, b.vtisses sus-érigées et portant le numéro civique 394 de la rue King-Georges, en la cité Jacques-Cartier.\" Pour être vendu, au bureau d'enregistrement du comté de Chambly, à Longueuil, le VINGT-DEUXIÈME jour d'AOÛT 1958, à ONZE heures du matin.Le Shérif, CAISSE & LAURENCELLE.Bureau du Shérif, Montréal, 15 juillet 1958.48219-29-2-o Fieri Facias c'e Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: / A IMÉ MARTIN, plain-No-438512.tin; vs WILFRID l DUPRÉ, defendant.\"An emplacement situated in the town of Jacques-Cartier, county of Chambly, district of Montreal, being lots two hundred and twenty-three and two hundred and twenty-four of the subdivision of original lot ninety-two (92-223-224) two hundred and ninety-two and two hundred and ninety-three of the subdivision of original lot ninety-one (91-292-293) of the official plan and book of reference of the parish of St.Antoine de Longueuil; these lots form two emplacements and measuring in all, sixty feet in width by eighty-three feet in depth.English measure, and more or less, with buildings thereon erected and bearing civic number 394 King George Street, in the city of Jacques Cartier\".\" To be sold, in the registry office of the county of Chambly, at Longueuil, the TWENTY-SECOND day of AUGUST 1958, at ELEVEN o'clock in the morning.CAISSE & LAURENCELLE, Sheriff.Sheriff's Office, Montreal.July 15, 1958.48219-29-2 \u2022 QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: / \"D OBERT L'HEUREUX, N° 90,331.< notaire, domicilié à Lo-l retteville, Que., en sa qualité d'administrateur de la succession de feu Gérard G.Bastien, nommé suivant la Loi des Indiens; contre LUCD3N SIOUI, domicilié au Village Huron, comté de Québec, district de Quél>ec.\"Garage ou hangar situé dans la Réserve Huronne de Lorette, avec tous les droits d'occupation que possède Lucien Sioui sur la moitié ouest, du terrain originairement concédé à Albert Sioui, senior.Ledit emplacement étant borné comme suit: vers le nord par la rue Principale, vers le sud par la Rivière Saint-Charles, vers l'ouest par le terrain occupé par Roméo Picard et vers l'est par le terrain occupé par Albert Sioui, jr., circonstances et dépendances.\" Pour être vendu au Bureau d'Enregistrement à Québec, le PREMIER jour d'AOÛT prochain à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Dr J.R.GOBEIL.Québec, le 25 juin 1958.48102-26-2-O [Première insertion: le 28 juin 1958] [Deuxième insertion: le 19 juillet 1958] QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit : /\"R OBERT L'HEUREUX, No.90,331.notary, domiciled at l Loretteville, Que., in his quality of administrator for the estate of the late Gérard G.Bastien, appointed according to Indian Law; against LUCIEN SIOUI, domiciled in the Huron Village, county of Quebec, district of Quebec.\"Garage or shed situated in the Huron Reserve of Lorette, with all the occupational rights which Lucien Sioui possesses on the western half of the originally owned land conceded to Albert Sioui, Senior.The said emplacement is bounded as follows: on the north by the main street, on the south, by the St.Charles River, on the west, by the land occupied by Roméo Picard and on the east, by the land occupied by Albert Sioui, Jr., circumstances and dependencies.\" To be sold at the Registry Office at Quebec, on AUGUST FIRST next, at TEN o'clock in the forenoon.Dr J.R.GOBEIL, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, June 25, 1958.48102-26-2 [First insertion: June 28, 1958] [Second insertion: July 19.195S] TERREBONNE Canada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne Cour Supérieure, ( T^EACON MOTOR SALES « N° 25248.< Y LIMITED, corps poli-v tique et incorporé, dûment incorporé selon la loi, ayant sa principale place d'affaires en la ville de Lachute, comté d'Argen-teuil, district de Terrebonne, demanderesse; vs NAPOLÉON MORISSETTE, camionneur de la ville de Lachute, comté d'Argenteuil, district de Terrebonne, défendeur.TERREBONNE Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne Superior Court, ( \"TvEACON MOTOR SALES No.25248.< Y LIMITED, body poli-v tic and corporate, duly incorporated according to the law, having its head office in the town of Lachute, county of Argenteuil, district of Terrebonne, plaintiff; vs NAPOLEON MORISSETTE, trucker of the town of Lachute, county of Argenteuil, district of Terrebonne, defendant. 2526 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, No 29 AVIS DE VENTE \"Un certain morceau de terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Chatham comme étant partie sud du lot numéro neuf soixante-seize (Ptie S.976) dans le onzième rang, mesurant environ cent soixante-deux acres, borné au nord par un ruisseau, au sud par le rang dix* à l'est par le lot 975 et à l'ouest par le lot 977, avec un camp dessus érigé.\" Pour être vendu à la porte de l'église catholique Ste-Anastasie de Lachute, MERCREDI le SIXIÈME jour d'AOÛT 1958 à DIX heures de l'avant-midi.Conditions de vente: argent comptant.Le Shérif, Bureau du Shérif, GEO.AUCLAIR.20 juin 1958.48082-26-2-o NOTICE OF SALE \"A certain lot of land known and designated on the official plan and in the book of reference for the township of Chatham as being the southern part of lot number nine hundred and seventy-six (Pt.S.976) in the eleventh range, measuring approxamately one hundred and sixty-two acres hounded on the north by a brook, on the south by range ten, on the east by lot 975 and on the west, by lot 977, with a camp thereon erected.\" To be sold at the Catholic church door of Ste.Anastasie of Lachute, WEDNESDAY the SIXTH day of AUGUST, 1958, at TEN o'clock in the forenoon.Conditions of sale: cash.GEO.AUCLAIR, Sheriff's Office, Sheriff.June 20, 1958.48082-26-2 In d ex de la Gazette officielle de Québec, N° 29 Action en separation de biens: Bédard vs Marcil.2496 Arrêtés en Conseil: 728-A \u2014 Concernant des modifications au décret relatif au commerce de l'alimentation au détail dans la région de Québec.2490 728-B \u2014 Concernant une modification au décret relatif aux établissements commerciaux dans les villes de Dolbeau et Mistassini et un rayon de trois milles de leurs limites.2498 739 \u2014 Preuve photographique de certains documents (Dorval).2499 Avis aux intéressés: 2451 Réception des annonceurs.2451 Avis divers: Belleterre Quebec Mines Limited (Directeurs) .2503 Donohue Brothers Limited (Barrage).2499 Donohue Brothers Limited (Barrage).2500 Gagné Construction Ltée \u2014 Gagné Construction Ltd.(Directeurs).2501 Globe Paper Box Co.Limited (Directeurs).2503 Holt, Renfrew & Co.Limited (Directeurs).2501 Holt, Renfrew & Co.Limited (Direc-' teurs).\\ .2502 Intercontinental Veneers Ltd (Directeurs).2501 Les Immeubles Delrano Inc.(Directeurs).2502 Montreal Construction Supply & Equipment Ltd (Directeurs).2501 Notre-Dame Construction Ltée (Directeurs) .2501 Progrès de Crémazie Ltée (Directeurs).2500 St-Jérôme village (Rachat d'obligations).2500 Val Royal Baptist Church (Incorpo-tion).2499 Zed Corporation (Directeurs).2503 Index of the Quebec Official Gazette, No.29 Action for Separation as to Property: Bédard vs Marcil.2496 Orders in Council: 728-A \u2014 Concerning amendments to the decree relating to the food products trade in the region of Quebec.2496 728-B \u2014 Concerning an amendment of the decree relating to the retail trade in the towns of Dolbeau and Mistassini and a radius of 3 miles from their limits.2498 739 \u2014 Protographic Proof of certains documents (Dorval).2499 Notice to Interested Parties: 2451 Receipt of advertising, copies.2451 Miscellaneous Notices: Belleterre Quebec Mines Limited (Directors) .2503 Donohue Brothers Limited (Dam)- 2499 Donohue Brothers Limited (Dam).2500 Gagné Construction Ltée \u2014 Gagné Construction Ltd (Directors).2501 Globe Paper Box Co.Limited (Directors).2503 Holt, Renfrew & Co.Limited (Directors).:\\.2501 Holt, Renfrew & Co.Limited (Directors).2502 Intercontinental Veneers Ltd (Directors).2501 Les Immeubles Delrano Inc.(Directors).2502 Montreal Construction Supply & Equipment Ltd (Directors).2501 Notre-Dame Construction Ltée (Directors).2501 Progrès de Crémazie Ltée (Directors).2500 St-Jérôme village (Redemption of Bonds).2500 Val Royal Baptist Church (Incorporation).2499 Zed Corporation (Directors).2503 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 19th, 1958, Vol.90, No.89 2527 Chartes \u2014 Abandon de: Charters \u2014 Surrender, of: Autocam Inc.2504 Central Outfitting Co.Ltd.2504 District Development Inc.2505 Édifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.____.2505 Exposition Displays Inc.2504 Karp & Einborn Ltd.2505 L.Dupont Limitée.2504 Ed.Rona & Co.Ltd.2504 D ÉPARTEMENTS \u2014 AVIS DES : Autocam Inc.2504 Central Outfitting Co.Ltd.2504 District Development Inc.2505 Édifice du Dépôt Dentaire de Montréal Inc.2505 Exposition Displays Inc.2504 Karp & E inborn Ltd.2505 L.Dupont Limitée.2504 Ed.Rona & Co.Ltd.2504 DEPARTMENTAL NOTICES: Instruction publique: Municipalité scolaire de: St-Boniface-de-Shawinigan, village.St-Martin.Terres et Forêts: Service du Cadastre: Notre-Dame de l'Assomption de Repentigny, paroisse.^.Travail: Industrie ou métiers de: 2505 Alimentation en Détail de Sherbrooke et région (Prélèvement).2481 Barbiers-coiffeurs de Hull (Approbation).2492 Barbiers-coiffeurs de Hull (Prélèvement).:.:.2486 Barbiers-coiffeurs St-Jean et d'Uberville (Prélèfement).2477 Barbiers, coiffeurs et coiffeuses, Victoriaville et al (Modification).2492 Camionnage, district de Québec (Prélèvement).2478 Commerce en détail d'Asbestos (Prélèvement).2488 Fourrure section du détail, région de Montréal (Modification).2492 Industrie du Meuble de Quéliec (Prélèvement).2483 Industrie de la Peinture (Prélèvement).2480 Maître Électriciens de Hull et district (Modification).2490 Matériaux de Construction (Approbation).2489 Matériaux de Construction (Prélèvement).2476 Métallurgie de la région de Québec (Prélèvement).2484 Lettres patentes: A.Laurin &*Fils Transport Inc.2452 Arrow Door Manufacturing Company Limited.2453 Atlas Bricklaying Co.Ltd.2453 Boulevard Development Co.Inc.2453 B.R.M.Investments Inc____ .2454 Capri Development Inc.2454 Carinthia Investment Corporation.2454 Cartier Publicité Inc.2455 Clément Bernard Ltée.2455 Comité des Loisirs de l'Orme Inc.2455 Cosy Corner Incorporated.2456 Dahne Construction Corporation.2456 Darstro Realty Corporation.2456 D.C.Chemical Products Inc.2457 Denvin Inc.2457 Ditar Etd.2457 Education: School Municipality of: 2505 St-Boniface-de-Shawinigan, village.2505 2505 St-Martin.2505 Lands and Forest: Cadastral Branch: Notre-Dame de l'Assomption de Repentigny, parish.2505 Labour: Industry or Trades of: Retail Food Trade of Sherbrooke and vicinity (Levy).2481 Barbiers-coiffeurs de Hull (Approval).2492 Barbiers-coiffeurs de Hull (Levy).2486 Barbers-Hairdressers of St-Jean and Iberville (Levy).2477 Barbering and hairdressing trades, Victoriaville et al (Amendment).2492 Camionnage, district de Québec (Levy).2478 Retail Trade of Asbestos (Levy).2488 Fur industry retail section, region of Montreal (Amendment).2492 Furniture Industry of Quebec (Levy).2483 Paint Industry (Levy).2480 Master Electricians of Hull and district (Amendment).,.2490 Building Materials (Approval).2489 Building Materials (Levy).2476 Metal Trades of the Quebec district (Levy).2484 Letters Patent: A.Laurin & Fils Transport Inc.2452 Arrow Door Manufacturing Company Limited.2453 Atlas Bricklaying Co.Ltd.2453 Boulevard Development Co.Inc.2453 B.R.M.Investments Inc.2454 Capri Development Inc.2454 Carinthia Investment Corporation.2454 Cartier Publicité Inc.2455 Clément Bernard Ltée.2455 Comité des Loisirs de l'Orme Inc.2455 Cosy Corner Incorporated.2456 Dahne Construction Corporation.2456 Darstro Realty Corporation.2456 D.C.Chemical Products Inc.2457 Denvin Inc.2457 Ditar Ltd.2457 2528 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 juillet 1958, Tome 90, N\" 29 Electronic Tabulating Service Corp.Elgo Textiles Ltd.Pair Isle Knitting (Quebec) Ltd.Four Hundred Realty Corporation- Franksin Mines Ltd.-.Gardénia Limitée.G; Kaplan Inc.G.Lefebvre & Fils Inc.'.G.& Z.Lumber Co.Ltd.Harvard Holding Corporation.Imprimerie Bou-Ra-Ca Ltée.Industrial Fasteners Ltd.Jakmar Investment Corp.Josef Dress Inc.Kautex (Canada) Ltd.Kramar Inc.Les Ateliers Roland Inc.Les Bois du Ruisseau Grand Nord Inc.Les Enchères Prosj>ère Inc.Les Industries B & L.Inc.\u2014 The B & L Industries Inc.Lester Realty Corp.Les Ventes aux Enchères du Témiscamingue Inc.\u2014 Auction Sales of Témiscamingue Inc.Linwood Inc.Mescar Holding Corp.M.Pesner & Sons Ltd.New Croydon Development Ltd.North-End Sanitation ('o.Limited.'.Orchard Development Corporation.Palmer Sales Inc.Park Ave.Businessmen's Association.Patet Corp.Paul L'Heureux Inc.Paul Maney Laboratories Quel>ec Ltd.\u2014 Laboratoires Paul Maney Québec Ltée.Persillier Development Corp.Personal Credit Assistance Ltd.Petit Lac Nominingue Incorporée.Roger Distributions Inc.Rosemont Metal Craft Inc.Ross Office Supplies Ltd.Semaines Sociales du Canada (Secteur Français).Sherbrooke Perlite Inc.Sherbrooke Plastering Ine*.Société d'Importations Européennes Co.Ltée.Ste.Thérèse Enterprises Inc.St.Lawrence Gas Corporation \u2014 Corporation Gazifère du St-Laurent.Stucco, Latte & Plâtre (Québec) Inc.\u2014 Stucco, Lath & Plaster (Quebec) Inc.Supertest Construction Inc.Teegide Inc.Tremblay Ready Mix Ltée.Vaudland Corp.Vincent Transport Ltée.Nomination: 2458 Electronic Tabulating Service Corp.2458 Elgo Textiles Ltd.'.2458 Fair Isle Knitting (Quebec) Ltd.2459 Four Hundred Realty Corporation.2459 Franksin Mines Ltd.2459 Gardénia Limitée.2460 G.Kaplan Inc.2460 G.Lefebvre & Fils Inc.2460 G.& Z.Lumber Co.Ltd.2461 Harvard Holding Cor]>oration.2401 Imprimerie Bou-Ra-Ca Ltée.2461 Industrial Fasteners Ltd.2402 Jakmar Investment Corp.2462 Josef Dress Inc.2462 Kautex (Canada) Ltd.2463 Kramar Inc.2463 Les Ateliers Roland Inc.2463 Les Bois du Ruisseau Grand Nord Inc.2464 Les Enchères Prospère Inc.Les Industries B & L.Inc.\u2014 The B & 2464 L Industries Inc.2465 Lester Realty Corp.Les Ventes aux Enchères du Témiscamingue Inc.\u2014 Auction Sales of Te- 2465 miscamingue Inc.2465 Linwood Inc;.2466 Mescar Holding Corp.2460 M.Pesner & Sons Ltd.2466 New Croydon Development Ltd.2407 North-End Sanitation Co.Limited- 2467 Orchard Development Corporation.2467 Palmer Sales Inc.2468 Park Ave.Businessmen's Association.2468 Patet Corp.2468 Paul L'Heureux Inc.Paul Maney Laboratories Quebec Ltd.\u2014 Laboratoires Paul Maney Québec 2469 Ltée./.2469 Persillier Development Corp.2469 Personal ('redit Assistance Ltd.2470 Petit Lac Nominingue Incorporée.2470 Roger Distributions Inc.2470 Rosemont Metal Craft Inc.2471 Ross Office Supplies Ltd.Semaines Sociales du Canada (Secteur 2471 Français).2472 Sherbrooke Perlite Inc.2472 Sherbrooke Plastering Inc.Société d'Importations Européennes Co.2472 Ltée.2473 Ste.Thérèse Enterprises Inc.St.Lawrence Gas Corporation.\u2014 Cor- 2473 poration Gazifère du St-Laurent.Stucco, Latte & Plâtre (Québec) Inc.\u2014 2474 Stucco, Lath & Plaster (Quebec) Inc.2474 Suiœrtest Construction Inc.2474 Teegide Inc.2475 Tremblay Ready Mix Ltée.2475 Vaudland Corp.2475 Vincent Transport Ltée.Appointment: 2458 2458 2458 2459 2459 2459 2460 2460 2460 2461 2461 2461 2462 2462 2462 2463 2463 2463 2464 2464 2465 2465 2465 2466 2466 2466 2467 2467 2467 2468 2468 2468 2469 2469 2469 2470 2470 2470 2471 2471 2472 2472 2472 2473 2473 2474 2474 2474 2475 2475 2475 Gagné, Jean-H.Sièges sociaux: Anthonian Mining Corporation Limited Acier d'Armature Ltée \u2014 Armature Steel Ltd.Barnat Mines Ltd.Bureau de Montréal de la Fédération du Détail et des Services de Québec Inc.\u2014 Montreal Office of the Quebec Federation of Retail and Service Organizations Inc.Candiac Construction Ltd.2506 Gagné, Jean-H.Head Offices: 2506 2509 2510 2508 2507 Anthonian Mining Corporation Limited Acier d'Armature Ltée \u2014 Armature Steel Ltd.Barnat Mines Ltd.Bureau de Montréal de la Fédération du Détail et des Services de Québec Inc.\u2014 Montreal Office of the Quebec Federation of Retail and Service Organizations Inc.Candiac Construction Ltd.2506 2506 2509 2510 2508 2507 QUEBEC OFFICIAL GAZETTEfQuebec, July 19th, 1968, Vol.90, No.29 2529 Cresus Investments Inc.2506 East Malartic Mines Limited.2507 La Cie Photographique Aérienne Ltée \u2014 Aerial Photography Company Limited____.2508 .La Compagnie Photo Air Laurentides.2509 Paul-Émile Lachance Ltée.2509 Roger Distributors Inc.2506 Webmont Corporation.2508 Wolfesfield Limited.2509 Soumissions: Mistassini, ville.2515 Rimouski-Est, comm.scolaire.2513 Ste-Anne de Beaupré, comm.scolaire.2510 Shawinigan-Sud, village.2512 Thurso village.2514 Ventes, Loi de faillite: Bélanger, Robert.2517 Nadeau, Roger.2516 Vente par licitation: Asselin et al vs Asselin.2519 Ventes pour taxes: Montréal-Nord, ville.2520 Trois-Rivières, cité.2521 VENTES PAR SHÉRIFS: Abitibi : Lussicr vs Guilbert.2521 Chicoutimi: La Cie Industrielle du Saguenay Ltée vs Larouche.2522 Hull: Caisse Populaire Notre-Dame de Hull vs Parent.2523 Potvin vs Bigclou.2523 Montréal: Martin vs Dupré.-'.2525 Schwartz et al vs Forest.2524 Québec: L'Heureux vs Sioui.!.2525 Terrebonne: Deacon Motor Sales Limited vs Mo-rissette.2525 Cresus Investments Inc.2506 East Malartic Mines Limited.2507 La Cie Photographique Aérienne Ltée \u2014 Aerial Photography Company Limited____.2508 La Compagnie Photo Air Laurentides.2509 Paul-Émile Lachance Ltée.2509 Roger Distributors Inc.2506 Webmont Corporation.2508 Wolfesfield Limited.2509 Tenders: Mistassini, town.2515 Rimouski-Est, school comm.2513 Ste-Anne de Beaupré, school comm.2510 Shawinigan-Sud, village.2512 Thurso village.2514 Sales, Bankruptcy Act: Bélanger, Robert.2517 Nadeau, Roger.2516 Sale by Licitation: Asselin et al vs Asselin.2519 Sali» for Taxes: Montreal-North, town.2520 Trois-Rivières, city.2521 SHERIFFS' SALES: Abitibi: Lussier vs Guilbert.2521 Chicoutimi: La Cie Industrielle du Saguenay Ltée vs Larouche.2522- Hull: Caisse Populaire Notre-Dame de Hull vs Parent.^.2523 Potvin vs Bigelou.2523 Montreal: Martin vs Dupré.2525 Schwartz et al vs Forest.2524 Quebec: L'Heureux vs Sioui.2525 Terrebonne: Deacon Motor Sales Limited vs Mo- rissette.2525 Québec: \u2014Imprimé par Rêdempti Paradis, Quebec: \u2014Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer. "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.