Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 juin 1958, samedi 28 (no 26)
[" Tome 90, N° 26 2253 Vol.90, No.26 \t\t \t\t* \t\t¦ 1 \t\t \t\t Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 28 juin 1958 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1958.Québec, le 21 juin 1958.L'Imprimeur de la Reine, 48009-25-1 l-o RÉDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue,' la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, June 28th, 1958 RECEIPT OF ADVERTISING COPD3S Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1958.Quebec, June 21st, 1958.RÉDEMPTI PARADIS, 48009-25-1 l-o Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules *-1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 2254 ÔAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais de reprise.Tarif des Annonces! Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: Si la douzaine.Abonnement: S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une~seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502 \u2014 1-52 will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7 per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502\u20141-52 Lettres patentes (P.G.11756-58) \u2022 A.B.C.Électrique Limitée A.B.C.Electric Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mai 1958, constituant en corporation: François Laporte, vendeur, Florian Lacroix et Claude Thérien, électriciens, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens; exercer l'industrie et le commerce d'appareils et acces- Lctters Patent (A .G.11756-58) A.B.C.Électrique Limitée A.B.C.Electric Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1958, incorporating: François Laporte, salesman, Florian Lacroix and Claude Thérien, electricians, all of Montreal, for the following purposes: To carry on as electricians; to operate a business and industry dealing in electrical appli- ~\u2014^^^^^^^^^^ soires électriques, sous le nom de \"A.B.C.Électrique Limitée \u2014 A.B.C.Electric Limited\", avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o , P.FRENETTE.(P.G.11595-58) Astor CoiTee Shops Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1958, constituant en corporation: Isidore M.Bobrove, Jack B.Bobrove et Max Bernfeld, conseil en loi de la Reine, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, hôteliers et taverniers, sous le nom de \"Astor Coffee Shops Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.ances and apparatus, under the name of \"A.B.C* Électrique Limitée \u2014 A.B.C.Electric Limited\", with a total capital stock of $25,000, divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11595-58) Astor Coffee Shops Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1958, incorporating: Isidore M.Bobrove, Jack B.Bobrove and Max Bernfeld, Queen's Counsel, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurant, hotel and tavern keepers, under the name of \"Astor Coffee Shops Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of-$100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.10956-58) (A.G.10956-58) Auvents de la Mauricie Inc.Auvents de la Mauricie Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the sixteenth du seize mai 1958, constituant en corporation: day of May, 1958, incorporating: Paul Bilodeau, Paul Bilodeau, Conrad Bilodeau, manufacturiers, Conrad Bilodeau, manufacturers, of Cap-de-la- du Cap-de-la-Madeleine, et Henri Cinq-Mars, Madeleine, and Henri Cinq-Mars, notary, of notaire, des Trois-Rivières, pour les objets sui- Trois-Rivières, for the following purposes: vants: Exercer l'industrie et le commerce d'auvents, To operate a business dealing in awnings, doors de portes et de fenêtres, sous le nom de \"Auvents and windows, under the name of \"Auvents de de la Mauricie Inc.\", avec un capital total de la Mauricie Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.$20,000, divided into 200 shares of $100 each.Le siège social de la compagnie sera au Cap- The head office of the company will be at de-la-Madeleine, district judiciaire des Trois- Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières.Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le seize Dated at the office of the Attorney General, mai 1958.this sixteenth day of May, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 48063-o P.FRENETTE.48063 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11548-58) (A.G.11548-58) Béïque & Murphy Inc.Béïque & Murphy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the seventh du sept mai 1958, constituant en corporation: day of May, 1958, incorporating: Morton Bell, Morton Bell, Dov Kravetz, Michael Awada, Dov Kravetz, Michael Awada, advocates, and avocats, et Margaret McMartin, commis, fille Margaret McMartin, clerk, spinster, all of majeure, tous de Montréal, pour les objets sui- Montreal, for the following purposes: vants: Exercer le commerce de bijoutiers, sous le nom To carry on business as jewellers, under the de \"Béïque & Murphy Inc.\", avec un capital name of \"Béïque & Murphy Inc.\", with a total total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires capital stock of $40,000, divided into 2,000 d'une valeur au pair de $10 chacune et 200 actions common shares of a par value of $10 each-and privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune, into 200 preferred shares of a par value of $100 each.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2265 «256 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90,2V*° 26 Le siège social de la compagnie sera à 1412 rue Drummond, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11817-58) Berkshire Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois mai 1958, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, Theodore H.Shapiro, Jonathan Joseph Robinson, tous deux avocats, et Jean McFarlane, teneuse de livres, fille majeure, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction, amélioration, portefeuille et placements, sous le nom de \"Berkshire Realties Ltd.\", avec un capital total de S10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.The head office of the company will be at 1412 Drummond Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11817-58) Berkshire Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of May, 1958, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, Theodore H.Shapiro, Jonathan Joseph Robinson, both advocates, and Jean McFarlane, Bookkeeper, spinster, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction, improvement, holding and investment company, under the name of \"Berkshire Realties Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.10459-58) (A.G.10459-58) Bernard & Freda Goldstein Foundation Bernard & Freda Goldstein Foundation Avis est donné qu'en vertu de la troisième Notice is hereby given that under Part III of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the twenty-air vingt-six mai 1958, constituant en corpora- sixth day of May, 1958, to incorporate as a tion sans capital-actions: Bernard Goldstein, corporation without share capital: Bernard fabricant, Freda Sterntlud Goldstein, ménagère, Goldstein, Manufacturer, Freda Sternthal Gold-épouse séparée de biens dudit Bernard Goldstein, stein, Housewife, wife separate as to property tous deux d'Outremont, et Ben Zion Goldstein, of the said Bernard Goldstein, both of Outremont, fabricant, de Montréal, pour les objtes suivants: and Ben Zion Goldstein, Manufacturer, of Montreal, for the following purposes: Recevoir et entretenir un ou des fonds devant To receive and maintain a Fund or Funds for servir à des fins religieuses, charitables ou éduca- religious, charitable or educational purposes, tives, sous le nom de \"Bernard & Freda Goldstein under the name of \"Bernard & Freda Goldstein Foundation\".Foundation\".Le montant auquel est limitée la valeur de The amount to which the value of the immov-la propriété immobilière que la corporation peut eable property which the corporation may hold posséder $1,000,000.is to be limited to $1,000,000.Le siège social de la corporation sera à Mont- The head office of the corporation will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, vingt-six mai 1958.this twenty-sixth day of May, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 48063 P.FRENETTE.48063-o Acting Deputy Attorney General (P.G.11762-58) Blainville Construction Ltee Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du seize mai 1958, constituant en corporation: Aldéric Laro.se, entrepreneur, de la paroisse de Ste-Thérèse-de-Blainville, Paul Desrochers, de Roscmère, et Georges Lockhead, de la ville de Ste-Thérèse, tous deux comptables, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de construction, sous le nom de \"Blainville Cons- (A.G.11762-58) Blainville Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1958, incorporating: Aldéric Larose, contractor, of the parish of Ste-Thérèse-de-Blainville, Paul Desrochers, of Rosemère, and Goerges Lockhead, of the Town of Ste-Thérèse, both accountants, for the following purposes: To operate a business dealing in construction, under the name of \"Blainville Construction QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2257 t ruction Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11589-58) British American Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois mai 1958, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, Melvin Leonard Rothman, tous deux de Westmount, David Goodman, de la ville de Hampstead, Neil Franklin Phillips, de Montréal, Godfroy Marin, de Pointe-Claire, tous cinq avocats, ¦ Sylvia Vineberg et Yvonne Bélanger, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et exercer le commerce d'une ou de certaines propriétés immobilières, sous le nom de \"British American Enterprises Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.\u201e Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.48003 P.FRENETTE.(P.G.11693-58) Buffet l.ciiiirjjx Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mai 1958, constituant en corporation : Roland Lemieux, restaurateur, Fernande Corri-veau Lemieux, ménagère, épouse séparée de biens dudit Roland Lemieux, et Philippe Boyer, administrateur, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers et restaurateurs, sous le nom de \"Buffet Lemieux Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11703-58) Caret te Automobiles Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1958, constituant en corporation: Nicolas Carette, homme d'affaires, de Montréal, André Carette et Michel Carette, vendeurs, de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et autres moyens de transports; faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Carette Automobiles Ltée\", avec un capital total de Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be in the parish of Sainte-Thérèse-de-Blainville, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11589-58) British American Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing* date the twenty-third day of May, 1958, incorporating: Philip Fischel Vineberg, Melvin Leonard Rothman, both of Westmount, David Goodman, of the Town of Hampstead, Neil Franklin Phillips, of Montreal, Godfroy Marin, of Pointe-Claire, all five advocates, Sylvia Vinel>crg, and Yvonne Bélanger, secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with certain immoveable property or properties, under the name of \"British American Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1958.1».FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11693-58) Buffet Lemieux Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1958, incorporating: Roland Lcmicux, restaurant-keeper, Fernande Corriveau Lemieux, housewife, wife separate as to property of the said Roland Lemieux, and Philippe Boyer, administrator all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as hotel and restaurant-keepers, under the name of \"Buffet Lemieux Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11703-58) Carette Automobiles Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1958, incorporating: Nicolas Carette, business man, of Montreal, André Carette, and Michel Carette, salesmen, of Quebec, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in automobiles and in other means of transportation; to carry oh as garage-keepers, under the name of \"Carette Automobiles Ltée\", with a 2268 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1265, De la Canardière, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11428-58) Castle & Gates Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1958, constituant en corporation: Albert Malouf, Peter Shorteno, tous deux de Ville Mont-Royal et John Ciaccia, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et exerce le commerce d'articles en cuir; exercer le commerce comme tanneurs, sous le nom de \"Castle & Gates Limited\", avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de* la compagnie sera à 1925 Boulevard Edward, Mackayville, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11461-58) Central Management Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été acordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1958, constituant en corporation: Samuel Chait, avocat, John Hamilton, secrétaire, tous deux de Montréal, et Harry L.Arono-vitch, avocat, de la ville Côte St-Luc, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme agents d'immeubles aux fins de louer des propriétés et les gérer et administrer, sous le nom de \"Central Mana- rsment Corporation\", avec un capital total de 10,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11759-58) City Asphalt Paving Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mai 1958, constituant en corporation: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch et Melvin Salmon, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme paveurs, maîtres-carriers, marchands de pierre et constructeurs, sous le nom de \"City Asphalt Paving Inc.\", avec un capital total de $40,000, divise en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1265 De la Canardière, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11428-58) Castle & Gates Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1958, incorporating: Albert Malouf, Peter Shorteno, both of the Town of Mount Royal, and John Ciaccia, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in leather goods; to carry on business as tanners, under the name of \"Castle & Gates Limited\", with a total capital stock of $25,000, divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1925 Edward Boulevard, Mackayville, judicial district of Montreal.Dated at the office of .the Attorney General, this twenty-first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11461-58) Central Management Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1958, incorporating: Samuel Chait, advocate, John Hamilton, secretary, both of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the Town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of real estate agents for the purpose of renting property, and managing and administrating same, under the name of \"Central Management Corporation\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May ,1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11759-58) City Asphalt Paving Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quelle, bearing date the sixteenth day of May, 1958, incorporating: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch and Mclvin Salmon, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as pavers, quarry masters, stone merchants and builders, under the name of \"City Asphalt Paving Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2259 Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11737-58) Country Side Homes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1958, constituant en corporation : Harry Fcinstein, de Montréal, Hyman Lanner, de la ville de Côte Saint-Luc, tous deux, marchands, et Lillian Lazare, secrétaire, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, de construction, d'amélioration et de placements, sous le nom de \"Country Side Homes Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 360 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11709-58) Cover-Tite Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mai 1958, constituant en corporation: Abraham Shuster, Bernard Diamond et Jason Ruby, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à couvrir des toits et poser des bardeaux sous le nom de \"Cover-Tite Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11777-58) Cresus Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mai 1958, constituant en corporation: Leo Davignon, comptable, de Laval-des-Rapides, Jacqueline Davignon et Yvette Marcoux, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction et placements, sous le nom de \"Cresus Investments Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.48063 P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11737-58) Country Side Homes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incorporating: Harry Fein-stein, of Montreal, Hyman Lanner, of the town of Côte Saint-Luc, both merchants, and Lillian Lazare, secretary, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction, improvement and investment company, under the name of \"Country Side Homes Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $10 each and into 360 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11709-58) Cover-Titc Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of May, 1958, incorporating: Abraham Shuster, Bernard Diamond and Jason Ruby, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of roofing and shingling, under the name of \"Cover-Tite Ltd.\", with a total capital stock divided into 500 common shares of a par value of $10 each and into 3,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district .of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11777-58) Cresus Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of May, 1958, incorporating: Leo Davignon, accountant, of Laval-des-Rapidcs, Jacqueline Davignon and Yvette Marcoux, secretaries, spinsters of full age, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Cresus Investments Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. 2260 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 (P.G.11723-58) Cypress Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1958, constituant en corporation : Bernard Desjarlais, Albert Ouellette et Roma Cousineau, tous avocats, de Verdun, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Cypress Construction Inc.\", avec un capital total de $300,000, divisé en 1,600 actions communes de $25 chacune, 1,600 actions privilégiées classe \"A\" de $100 chacune et en 2,000 actions privilégiées classe \"B\" de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11514-58) Dal-Laur Land Holding Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1958, constituant en corporation: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch et Charles Brownstcin, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Dal-Laur Land Holding Corp.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciare de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063, P.FRENETTE.(P.G.11250-58) Daykay Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mai 1958, constituant en corporation: Harry L.Aronovitch, avocat, de la ville Côte Saint-Luc, Samuel ('hait.Max Shenker, avocats, et John Hamilton, secrétaire, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: ' Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Daykay Inc.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11722-58) Desalaberry Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la (A.G.11723-58) Cypress Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incorporating: Bernard Desjarlais, Albert Ouellette and Roma Cousineau, all advocates, of Verdun, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors; to operate a business dealing in real estate, under the name of \"Cypress Construction Inc.\", with a total capital stock of $300,000, divided into 1,600 common shares of $25 each, 1,600 preferred classe \"A\" shares of $100 each and into 2,000 preferred classe \"B\" shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11514-58) Dal-Laur Land Holding Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1958, incorporating: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch and Charles Brownstein, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Dal-I^ur Land Holding Corp.\", with a total capital stock of $401000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11250-58) Daykay Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of May, 1958, incorporating: Harry L.Aronovitch, advocate, of the town of Côte Saint-Luc, Samuel ('liait, Max Shenker, advocates, and John Hamilton, secretary, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Daykay Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11722-58) Desalaberry Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2261 province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1958, constituant en corporation: Joseph Shapiro, avocat et conseil en loi de la Reine, de Westmount, Théodore H.Sha- Siro, Jonathan Joseph Robinson, avocats, Jean IcFarlane, teneu.se de livres, Leah Engel et Margaret Langmaid, secrétaires, filles majeures, tous cinq de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, de construction, d'amélioration, de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Desalaberry Realties Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.48063 P.FRENETTE.(P.G.11791-58) .Dessaules Automotive Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1958, constituant en corporation: Real Payette, marchand, Mme Hélène Proyencher, ménagère, épouse séparée de biens dudit Real Payette, tous deux de St-Jean, et Germain Lucier, marchand, de Joliette, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et autres moyens de transport; exercer le commerce du transport de passagers et de marchandises; faire affaires comme garagistes et quincailliers, sous le nom de \"Dessaules Automotive Inc.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 350 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune et en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2940, rue Dessaules, Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11442-58) Dollard Land Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mai 1958, constituant en corporation: Mortimer S.Smith, avocat, Shirley Simon, Claude Morin, secrétaires et Ellen Haggenmuel-ler, commis, toutes trois filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction et amélioration, sous le nom de \"Dollard Land Development Corp.\", avec un capital total de $80,000, divisé en 30,000, actions ordinaires de $1 chacune et 50,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incorporating: Joseph Shapiro, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, Theodore H.Shapiro, Jonathan Joseph Robinson, advocates, Jean McFarlane, bookkeeper, spinster, Leah Engel and Margaret Langmaid, secretaries, spinsters, all five of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction, improvement, holding and investment company, under the name of \"Desalaberry Realties Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11791-58) Dessaules Automotive Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1958, incorporating: Real Payette, merchant, Mrs.Hélène Provencher, housewife, wife separate as to property of the said Real Payette, both of St-Jcan, and Germain Lueicr, merchant, of Joliette, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in automobiles and in other means of transportation; to operate a business dealing in the transportation of passengers and other merchandise; to carry on business as garage-keepers and hardware dealers, under the name of \"Dessaules Automotive Inc.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 350 common shares of a par value of 8100 each and into 400 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at 2940 Dessaules St., Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 , Acting Deputy Attorney General.(A.G.11442-58) Dollard Land Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1958, incorporating: Mortimer S.Smith, advocate, Shirley Simon, Claude Morin, secretaries, and Ellen Haggenmueller, clerk, all three filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Dollard Land Development Corp.\", with a total capital stock of $80,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and into 50,000, preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. 2262 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N\" 26 (P.G.11796-58) Dominique Furniture Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1958, constituant en corporation: Albert Vandal, dessinateur, Jacqueline Laliberté, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, et J.-Êloi Gervais, avocat, de Lon-gueuil, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de meubles et de nouveautés, sous le nom de \"Dominique Furniture Co.Ltd.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 50 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune et en 150 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, .48063-0 P.FRENETTE.(P.G.10978-58) Fabreville Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mai 1958, constituant en corporation: Norman Cecil Deny s, avocat, de Ville Mont-Royal, Françoise Matte et Aline Fiset, secrétaires, filles majeures, usant de leurs droits, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Fabreville Investments Inc.\", avec un capital total de $30,000, divisé en 30 actions ordinaires de $100 chacune et 270 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11790-58) F.& G.Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1958, constituant en corporation: Zwi Fêler, mécanicien.Yaacov Grinshpan, marchand, et Chaya Truszinsky Grinshpan, ménagère, épouse séparée de biens dudit Yaacov Grinshpan et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de tous types de marchandises pour le consommateur, sous le nom de \"F.& G.Company Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11796-58) Dominique Furniture Co.Ltd.' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1958, incorporating: Albert Vandal, draughtsman, Jacqueline Laliberté, secretary, spinster, both of Montreal, and J.-Êloi Gervais, advocate, of Longueuil, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in furniture and novelties, under the name of \"Dominique Furniture Co.Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 50 common shares of a nominal value of $100 each and into 150 preferred shares of a nominal value of $100 each.' The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montréal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10978-58) Fabreville Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of May, 1958, incorporating: Norman Cecil Denys, attorney-at-law, of the Town of Mount Royal, Françoise Matte and Aline Fiset, secretaries, spinsters using their rights, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Fabreville Investments Inc.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 30 common shares of $100 each andinto 270 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11790-58) F.& G.Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1958, incorporating: Zwi Feler, mechanic, Yaacov Grinshpan, merchant, and Chaya Truszinsky Grinshpan, housewife, wife separate as to property of the said Yaacov Grinshpan, and duly authorized by him for all purposes hereof, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all types of ordinary consumer goods, under the name of \"F.& G.Company Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares of a par value of $100 each and into 200 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 .2263 (P.G.11316-58) .Fidelity Finance Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois mai 1958, constituant en corporation: Manuel Shacter, de Dorval, William Levitt, d'Ûutremont, Leo Rosentzveig, Stanley Taviss, de Montréal, tous les quatre avocats, et Bertha Mendelson, secrétaire, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires générales d'une compagnie de prêts, finances et placements, sous le nom de \"Fidelity Finance Corp.\", avec un Capitol total de $225,000, divisé en 25,000 actions ordinaires de $1 chacune et 200,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11802-58) Fribourg Investment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1958, constituant en corporation: Thérèse Dubreuil, secrétaire, de Montréal, Bernard Bourdon, conseil en loi de la Reine, et André Bourdon, tous deux avocats, d'Out remont, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et comme compagnie de placements, sous le nom de \"Fribourg Investment Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 160 actions ordinaires de $25 chacune et en 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à L'Abord-à-Plouffe, comté de Laval, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1958: L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11280-58) F.W.Jackson & Sons Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1958, constituant en corporation: Bart Nelson Holtham, avocat et conseil en loi de la Reine, Reginald Edward Jackson, marchand, et Frederick Arthur Jackson, peintre, tous de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer un commerce de entrepreneurs-peintres, sous le nom de \"F.W.Jackson & Sons Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11316-58) Fidelity Finance Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of May, 1958, incorporating: Manuel Shacter, of Dorval, William Levitt, of Outre-mont, Leo Rosentzveig, Stonely Taviss, of Montreal, all four advocates, and Bertha Mendelson, secretary, spinster of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To carry on the general business of a loan, finance and investment company, under the name of \"Fidelity Finance Corp.\", with a total capital stock of $225.000, divided into 25,000 common shares of $1 each and into 200,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May.1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11802-58) Fribourg Investment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1958, incorporating: Thérèse Dubreuil, secretary, of Montreal, Bernard Bourdon, Queen's Counsel, and André Bourdon, both advocates, of Outremont, for the following purposes: To carry on a business dealing in immoveables; to operate as general building contractors and as an investment company, under the name of \"Fribourg Investment Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 160 common shares of $25 each and into 360 preferred shares of $100 each.\u2022 The head office of the company will be at L'Abord-à-Plouffe, county of Laval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11280-58) F.W.Jackson & Sons Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incorporating: Bart Nelson Holtham, advocate and Queen's Counsel, Reginald Edward Jackson, merchant, and Frederick Arthur Jackson, painter, all of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on the business of painting contractors, under the name of \"F.W.Jackson & Sons Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. 2264 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 (P.G.11515-58) Giftlines Trading Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier mai 1958, constituant en corporation: Clarence Reuben Gross, avocat, de Westmount, Samuel David Rudcnko, avocat et conseil en loi de la Reine, Sarah Miller, sténographe, et Moses Silverstein, commis, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Importer, exporter et exercer le commerce de cadeaux, nouveautés, jouets, cartes de souhaits et emballages de cadeaux, sous le nom de \"Giftlines Trading Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11808-58) Greengold Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1958, constituant en corporation: Adam Grcçnspoon, marchand, Samuel Moskovitch, conseil en loi de la Reine, Seymour Machlovitch, tous deux avocats, et Betty Kessehnan Bradley, secrétaire, épouse séparée de Biens de Victor Bradley, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, constructioh et améliorations, sous le nom de \"Greengold Realties Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 v P.FRENETTE.(P.G.11704-58) Guy Poirier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1958, constituant en corporation: David Belhumeur, Pierre Beaudoin, comptables agréés, et Gaston Bellerive, comptable, tous des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bière et de breuvages non alcooliques, sous le nom de \"Guy Poirier Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2915, Place Harper, Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(A.G.11515-58) Giftlines Trading Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of May, 1958, incorporating: Clarence Reuben Gross, advocate, of Westmount, Samuel David Rudenko, advocate and Queen's Counsel, Sarah Miller, stenographer, and Moses Silverstein, clerk, all three of Montreal, for the following purposes: To import, export and deal in giftwares, novelties, toys, greeting cards and gift wrappings, under the name of \"Giftlines Trading Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial District of Montreal.Doted at the office of the Attorney General, this first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11808-58) Greengold Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have In'cn issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1958, incorporating: Adam Grccnspoon, Merchant, Samuel Moskovitch, Queen's Counsel, Seymour Machlovitch, both advocates, and Berry Kesselnian Bradley, secretary, wife separate as to property of Victor Bradley, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Greengold Realties Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and into 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11704-58) Guy Poirier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1958, incorporating: David Belhumeur, Pierre Beaudoin, chartered accountants, and Gaston Bellerive, accountant, all of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on a business dealing in beer and non-alcoholic beverages under the name of \"Guy Poirier Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 150 common shares of $100 each and into 250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 2915 Harper Place, Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2265 (P.G.11676-58) Henry Greenfield Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur 'de la province de Québec des lettres patentes, én date du dix mai 1958, constituant en corporation: Boris Garmaise, Cyril Edgar Schwisberg, avocats, et Frank Kishner, comptable, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction, portefeuille et placements, sous le nom de \"Henry Greenfield Investments Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,000 actions privilégiées de $Î0 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11594-58) Imperial Jewellery Manufacturing Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1958, constituant en corporation: Samuel Leon Mendelsohn, conseil en loi de la Reine, de Westmount, Leo Rosentzveig, Stanley Taviss, tous deux de Montréal et Manuel Shacter, de Dorval, tous avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de toutes catégories de marchandises ordinairement tenues en magasin par des bijoutiers, orfèvres, marchands de montres, horlogers, merciers et magasins à rayons, sous le nom de \"Imperial Jewellery Manufacturing Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune, 5,000 actions privilégiées catégorie \"A\" de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées catégories \"B\" de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.' Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11649-58) Independent Productions Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de 'la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mai 1958, constituant en corporation: Max Bernfield, Conseil en Loi de la Reine, Edward H.Bernfield et Jack B.Bobrove, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer, produire, distribuer et montrer des films de vues animées et tous accessoires s'y rapportant, sous le nom de \"Independent Productions Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Saint-Pierre, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11676-58) Henry Greenfield Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of May, 1958, incorporating: Boris Garmaise, Cyril Edgar Schwisberg, attorneys, and Frank Kishner, accountant, all of Montreal,, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction, holding and investment company, under the name of \"Henry Greenfield Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11594-58) Imperial Jewellery Manufacturing Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1958, incorporating: Samuel Leon Mendelsohn, Queen's Counsel, of Westmount, Leo Rosentzveig, Stanley Taviss, both of Montreal, and Manuel Shacter, of Dorval, all advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in all classes of merchandise usually carried in stock by jewellers, silversmiths, watchmakers, clockmakers, haberdashers and chain stores, under the name of \"Imperial Jewellery Manufacturing Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of $1 each, 5,000 Class \"A\" preferred shares of $1 each and into 30,000 Class \"B\" preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11649-58) Independent Productions Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been.issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1958, incorporating: Max Bernfield, Queen's Counsel, Edward H.Bernfield and Jack B.Bobrove, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To manufacture, produce, distribute and exhibit moving picture films and all accessories thereto, under the name of \"Independent Productions Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Ville Saint Pierre, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. 2266 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 (P.G.11596-58) International Fabrics Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1958, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, avocat et conseil en loi de la Reine, Clarence Reuben Gross, avocat et Sarah Miller, sténographe, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de textiles, marchandises sèches et vêtements, sous le nom de \"International Fabrics Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.14035-57) John G.Assels & Sons Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1958, constituant en corporation: John.George Assels, marchand, Joseph Arnold Assels, contremaître, Robert John Assels, mécanicien, et Elizabeth Vautier Assels, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit John George Assels, et dûment autorisée par ce dernier aux lins des présentes, tous de Port-Daniel Centre, pour les objets suivants: Faire le commerce de bois de pulpe, bois de construction, meubles et égir comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"John G.Assels & Sons Limited\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Port-Daniel Centre, district judiciaire de Bonavcnture.Daté du bureau du Procureur général, le sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11529-58) Jules Côté Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation: Jules Côté, agent, Marcel Samson, hôtelier, et Laurette Vaillancourt Côté, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Jules Côté, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous de Lévis, pour les objests suivants: Faire affaires comme distributeurs d'aliments, de liqueurs, de bière et autres breuvages alcooliques; le tout en se conformant aux dispositions de la loi des liqueurs, sous le nom de \"Jules Côté Ltée\", avec un capital total de $75,000, divisé en 600 actions ordinaires de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.(A.G.11596158) International Fabrics Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1958, incorporating: Samuel David Rudenko, advocate and Queen's Counsel, Clarence Reuben Gross, advocate, and Sarah Miller, stenographer, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in textiles, dry goods and clothing, under the name of \"International Fabrics Inc.\", with a total capital stock of $20,-000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and into 150 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.14035-57) John G.Assels & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of May, 1958, incorporating: John George Assels, merchant, Joseph Arnold Assels, foreman, Robert John Assels,* mechanic, and Elizabeth Vautier Assels, housekeeper, wife contractually separate as to property of the said John George Assels, and duly authorized by him for the purpose of these presents, all of Port-Daniel Centre, for the following purposes: To deal in pulpwood, lumber, furniture, and general contracting, under the name of \"John G.Assels & Sons Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Port-Daniel Centre, judicial district of Bonaven-ture.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11529-58) Jules Côté Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, incorporating: Jules Côté, agent, Marcel Samson, hotel-keeper, and Laurette Vaillancourt Côté, housewife, wife contractually separate as to property.of the said Jules Côté, and duly authorized by him for these present purposes, all of Levis, for the following purposes: To carry on business as distributors of food, soft drinks, beer and other alcoholic beverages; the whole in conformity with the provisions of the\" Liquor Law, under the name of \"Jules Côté Ltée\", with a total capital stock of $75,000, divided into 600 common shares of $100 each and into 150 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2267 Le siège social de la compagnie sera 96, rue Commerciale, Lévis, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11828-58) Julien Plante Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1958, constituant en corporation : Julien Plante, entrepreneur, de Québec, Gérard Plante, contremaître, des Saules, et Jean-Guy Plante, commis, de Giffard, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Julien Plante Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 250 actions communes de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 225.rue des Pins, est, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11700-58) La Jouvencelle Spécialités Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1958, constituant en corporation: Marie Brassard, Germaine Brassard et Juliette Brassard, toutes trois marchandes, filles majeures, de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de vêtements, sous le nom de \"La Jouvencelle Spécialité Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 605, boulevard Charest, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11780-58) Lakeshore Hardware Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mai 1958, constituant en corporation: Jeanine L.Fobert, secrétaire, Louis Drazin, étudiant, et Mortimer Dolman, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de quincaillerie et appareils de ménage, sous le nom de \"Lakeshore Hardware Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.The head office of the company will be at 96 Commerciale Street, Levis, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11828-58) Julien Plante Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1958, incorporating: Julien Plante, contractor, of Quebec, Gérard Plante, foreman, of des Saules, and Jean-Guy Plante, clerk, of Giffard, for-the following purposes: To carry on business as builders and general contractors under the name of \"Julien Plante Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and into 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 225 des Pins St., East, Quebec* judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11700-58) La Jouvencelle Spécialités Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1958, incorporating: Marie Brassard, Germaine Brassard and Juliette Brassard, all three merchants, spinsters of full age, of Quebec, for the following purposes: To carry on an industry and business dealing in clothing under the name of \"La Jouvencelle Spécialité Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 605, Charest Boulevard, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11780-58) Lakeshore Hardware Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the seventeenth day of May, 1958, incorporating: Jeanine L.Fobert, secretary, Louis Drazin, student, and Mortimer Dolman, notary, all of Montreal, for the following purposes: To deal in hardware and household appliances, under the name of \"Lakeshore Hardware Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. 2268 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N\" 26 (P.G.11493-58) La mon tagnc Commercial Equipment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente avril 1958, constituant en corporation: Jean-Paul Jobin, Louis-André-Trudel, comptables, et Henri Chassé, notaire, tous de Ste-Foy, pour les objets suivants: Fabriquer, importer, vendre et installer, direc-.tement ou indirectement, en gros ou au détail, toutes sortes d'équipements, moteurs, machines, appareils, accessoires pour fins domestiques, industrielles ou commerciales, sous le nom de \"Lamontagne Commercial Equipment Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 350 actions communes de $100 chacune et en 50 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera ù Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.48063-o P.FRENETrE.(P.G.11758-58) Landbert Realty Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mai \"1958, constituant en corporation: Benny Landsman, constructeur, Herbert Kless, marchand, et Seymour Machlovitch, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"Landbert Realty Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11562-58) Leaside Realty Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1958, constituant en corporation: Samuel Leon Mendelsohn, conseil en loi de la Reine, de Westmount, Manuel SI meter, de Dorval, tous deux avocats, Stanley Taviss, avocat, et Bertha Mendelson, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Leaside Realty Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.\u2022 L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11493-58) Lamontagne Commercial Equipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April, 1958, incorporating: Jean-Paul Jobin, Louis-André Trudel, accountants, and Henri Chassé, notary, all of Ste-Foy, for the following purposes: To manufacture, import, sell and install, directly or indirectly, wholesale or retail, all kinds of equipment, motors, machines, apparatus, accessories for domestic, industrial or commercial purposes, under the name of \"Lamontagne Commercial Equipment Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 350 common shares of $100 each and into 50 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11758-58) Landbert Realty Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1958, incorporating: Benny Landsman, builder, Herbert Kless, merchant, and Seymour Machlovitch, advocate, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Landbert Realty Co.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11562-58) Leaside Realty Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incorporating: Samuel Leon Mendelsohn, Queen's Counsel, of Westmount, Manuel Shacter, of Dorval, both advocates, Stanley Taviss, advocate, and Bertha Mendelson, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Leaside Realty Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFF ICI AL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2269 (P.G.11635-58) Le Magasin du Meuble Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1958, constituant en corporation: Joseph-E.Langlois, commerçant, Mme Berthe Langlois, ménagère, épouse séparée de biens dudit Joseph-E.Langlois, tous deux de Carleton-sur-Mer, et Maxime Langlois, avocat, de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de meubles et de nouveautés, sous le nom de \"Le Magasin du Meuble Ltée\", avec un capital -total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Carleton-sur-Mer, district judiciaire de Bonaventure.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11608-58) Les Entreprises Notre-Dame Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1958, constituant en corporation: Guy-E.Boisvert, Georges-C.Lachance, de Montréal, et François Limoges, de Ville Êmard, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Les Entreprises Notre-Dame Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 81, rue Crépin, Châteauguay Station, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11298-58) Les Entreprises Riviera Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois mai 1958, constituant en corporation: Lucien Audette, Jean Laurin, plâtriers, Nicolas Antonacci, menuisier, Raoul Brassard, policier, et René Roy, inspecteur-comptable, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs, entrepreneurs généraux en construction et comme agents d'immeubles, sous le nom de \"Les Entreprises Riviera Ltée\", avec un capital total de $60,000, divisé en 12,000 actions communes de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera 10260, rue Cham bord, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(A.G.11635-58) Le Magasin du Meuble Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May 1958, incorporating: Joseph E.Langlois, tradesman, Mrs.Berthe Langlois, housewife, wife separate as to property of the said Joseph E.Langlois, both of Carleton-sur-Mer, and Maxime Langlois, advocate, of Quebec, for the following purposes: To carry on a business and industry dealing in furniture and novelties under the name of \"Le Magasin du Meuble Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Carleton-sur-Mer, judicial district of Bonaventure.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11608-58) Les Entreprises Notre-Dame Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1958, incorporating: Guy-E.Boisvert, Georges-C.Lachance, of Montreal, and François Limoges, of Ville Emard, all advocates, for the following purposes: To carry on a business dealing in real estate; to operate as general building contractors under the name of \"Les Entreprises Notre-Dame Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be 81 Crépin St., Châteauguay Station, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11298-58) Les Entreprises Riviera Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of May, 1958, incorporating: Lucien Audette, Jean Laurin, plasterers, Nicolas Antonacci, joiner, Raoul Brassard, policeman, and René Roy, inspector-accountant, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders, and general building contractors and real estate agents, under the name of \"Les Entreprises Riviera Ltée\", with a total capital stock of $60,000, divided into 12,000 common shares of $5 each.The head office of the company will be at 10260 Chambord Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General. 2270 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 (P.G.11237-58) Les Entreprises Saint-Paul Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mai 1958, constituant en corporation: Jean Morand, entrepreneur, Guy Caron et Roger Hamel, courtiers, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en constructions, sous le nom de \"Les Entreprises Saint-Paul Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 5,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.10910-58) Les Immeubles Boucherville Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1958, constituant en corporation: Clovis Langlois, marchand, Aimé Racicot, constructeur, et Paul Décarie, cultivateur, tous de Boucherville, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Les Immeubles Boucherville Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 800 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Boucherville, district jueiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatroze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11417-58) Les Immeubles Radisson Ltée Radisson Realty Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de /la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1958, constituant en corporation: David Abraham Schwartz, avocat, de Valois, Joseph Guiseppe Levi, agent de voyage, de Montréal, et Jack David Dubney, homme d'affaires, de Ville LaSalle, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une, compagnie de terrains, construction et amélioration, exercer le commerce d'agents d'immeubles, sous le nom de \"Les Immeubles Radisson Ltée\u2014.Radisson Realty Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11237-58) Les Entreprises Saint-Paul Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1958, incorporating: Jean Morand, contractor, Guy Caron and Roger Hamel, brokers, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in real estate; to carry on business as general contractors in construction, under the name of \"Les Entreprises Saint-Paul Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 5,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated \"at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10910-58) Les Immeubles Boucherville Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incorporating: Clovis Langlois, merchant, Aimé Racicot, builder, and Paul Décarie, farmer, all of Boucherville, for the following purposes: To carry on a business dealing in real estate; to carry on as general building contractors, under the name of \"Les Immeubles Boucherville Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 800 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Boucherville, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11417-58) Les Immeubles Radisson Ltcc Radisson Realty Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1958, incorporating: David Abraham Schwartz, advocate, of Valois, Joseph Guiseppe Levi, Travel agent, of Montreal, and Jack David Dubney, businessman, of Ville LaSalle, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company; to carry on business as real estate agents, under the name of \"Les Immeubles Radisson Ltée \u2014 Radisson Realty Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Sept-Ues, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of April, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE,Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2271 (P.G.11818-58) \u2022 Les Loisirs de Mackayville Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la' province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois mai 1958, constituant en corpor ration sans capital-actions: Paul-Emile La vergue, Jacques Gagné, étudiants, Fernand Gadbois, vendeur, tous trois de Mackayville, et Hormidas Thibault, instituteur, de Ville Lemoyne, pour les objets suivants: Établir et diriger un ou des centres de loisirs, sous le nom de \"Les Loisirs de Mackayville\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera 2065, rue Charles, Mackayville, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11560-58) L-G Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1958, constituant en corporation: Eli Michael Berger, Donald Kujan, avocats et Margaret Johnston, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce de taxis; exercer le commerce comme garagistes; fabriquer et négocier des automobiles et autres véhicules, sous le nom de \"L-G Enterprises Ltd.\", avec un capital total de $40,000.divisé en 200 actions ordinaires de $25 chacune et 1,400 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compganic sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11818-58) Les Loisirs de Mackayville Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of May, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Paul-Emile Lavergne, Jacques Gagné, students, Fernand Gadbois, salesman, all three of Mackayville, and Hormidas Thibault, teacher, of Ville Lemoyne, for the following purposes: To establish and direct one or more recreational centers, under the name of \"Les Loisirs de Mackayville\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at 2065 Charles St., Mackayville, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11560-58) L-G Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1958, incorporating: Eli Michael Berger, Donald Kujan, advocates, and Margaret Johnston, secretary, fille majeure usant de ses droits, all of Montreal, for the following purposes: To carry on a taxi cab business; to carry on business as garage keepers; to manufacture and deal in automobiles and other vehicles, under the name of \"L-G Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $25 each and into 1,400 preferred shares of $25 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11569-58) Lorn a Mae Fashions Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1958, constituant en corporation: Samuel Leon Mendelsohn, conseil en loi de la Reine, de Westmount, Manuel Shacter, de Dor-val, Stanley Taviss et William Levitt, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants : Fabriquer et exercer le commerce de vêtements et marchandises sèches; négocier des propriétés immobilières, sous le nom de \"Lorna Mae Fashions Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 800 actions privilégiées de $100 chacune et 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le sièges ocial de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le ept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11569-58) Lorna Mae Fashions Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of May, 1958, incorporating: Samuel Leon Mendelsohn, Queen's counsel, of Westmount, Manuel Shatter, of Dorval, Stanley Taviss and William Levitt, of Montreal, ail advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel and dry goods; to deal in immoveable properties, under the name of \"Lorna Mae Fashions Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 800 preferred shares of $100 each and into 2,000 common shares of $10 each.The head office of the company will£be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. 2272 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 (P.G.11631-58).Macabee Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1958, constituant en corporation: Michael Hornstein, agent d'immeubles, Basil Danchyshyn, étudiant en droit, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction et amélioration, sous le nom de \"Macabee Construction Co.Ltd.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 10 actions ordinaires de $100 chacune et 190 actions privi-ligiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 6555 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11757-58) Machinerie Agricole et Industrielle Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mai 1958, constituant en corporation: Léon Prince, commerçants Geneviève Villeneuve Prince ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Léon Prince, tous deux de Cap-Rouge, et Pierre-Julien Houde, étudiant, de Ste-Foy, pour les objets suivants: Exercer le commerce de machinerie agricole et industrielle, sous le nom de \"Machinerie Agricole et Industrielle Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 8,000 actions communes de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cap-Rouge, district judiciaire de Quebec.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11550-58) Marcel Bon in Sports Inc.Avis est donné qu'en, vertu de la première partielle la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1958, constituant en corporation: Marcel Bonin, athlète professionnel, de Montréal, Gaston Laporte, pharmacien, et Jean Malo, courtier en valeurs, de Joliette, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'articles de sports, de jouets, de nouveautés et de vêtements sportifs, sous le nom de \"Marcel Bonin Sports Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions communes de $1 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Joliette, district judiciaire de Joliette.Daté du bureau du Procureur général, le sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(A.G.11631-58) Macabee Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of.Quebec, bearing date the seventh day of May, 1958, incorporating: Michael Hornstein, realtor, Basil Danchyshyn, law student, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Macabee Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 10 common shares of $100 each and into 190 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 6555 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11757-68) Machinerie Agricole et Industrielle Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1958, incorporating: Léon Prince, tradesman, Geneviève Villeneuve Prince, housewife, wife contractually separate as to property of the said Léon Prince, both of Cap-Rouge, and Pierre-Julien Houde, student, of Ste-Foy, for the following purposes: To carry on a business dealing in farming and industrial machinery, under the name of \"Machinerie Agricole et Industrielle Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 8,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Cap-Rouge, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11550-58) Marcel Bonin Sports Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, tetters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh, day of May, 1968, incorporating: Marcel Bonin, professional athlete, of Montreal, Gaston Laporte, pharmacist, and Jean Malo, stock broker, of Joliette, for the following purposes: To carry on a business dealing in articles of sport, toys, novelties and sportswear, under the name of \"Marcel Bonin Sports Inc.\", with a total capital of $40,000, divided into 5,000 common shares of $1 each and into 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Joliette, judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2273 (P.G.11657-58) M.Filiatrit Co.Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation: Majella Filiault, plombier, de Saint-Michel, \u2022I.-Claude Bureau, avocat, et Marcel Hamelin, notaire, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage et réfrigération, sous le nom de \"M.Filiault Co.Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions communes de $100 chacune et en 100 actions privilégiées \"de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11526-58) Morson House Aids Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation: Daniel Kingstone, avocat, Kay Sheehy, Benita Smith et Claire Saxe, toutes trois sténographes filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce et le négoce de nettoyeurs, machines à laver et autres appareils et accessoires d'usage domestique, sous le nom de \"Morson Home Aids Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au nair de $100 chacune et 100 actions ordinaires aune valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11725-58) Motor Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1958, constituant en corporation: Kirby C.Boyd, marchand, de Ville Mont-Royal, Gordon Fox, comptable agréé, et Anne Goldenblatt, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de \"Motor Holdings Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11657-58) M.Filiault Co.Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, incorporating: Majella Filiault, plumber, of Saint-Michel, J.-Claude Bureau, advocate, and Marcel Hamelin, notary, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as contractors in plumbing, heating and refrigeration under the name of \"M.Filiault Co.Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $100 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11526-58) Morson House Aids Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, incorporating: Daniel Kings-tone, advocate, Kay ,Shechy, Benita Smith and Claire Saxe, all three stenographers, spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in or with cleaners, washing machines and other domestic devices and appliances, under the name of \"Morson Home Aids Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares of a par value of $100 each and into 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11725-58) Motor Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incorporating: Kirby C.Boyd, merchant, of the town of Mount Royal, Gordon Fox, chartered accountant, and Anne Goldenblatt, secretary, spinster, both of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Motor Holdings Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares having a par value of $10 each and into 2,000 preferred shares having a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. 2274 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26_ (P.G.11721-58) (A.G.11721-58) ' Natural Gas Heating Installation Co.Ltd.Natural Gas Heating Installation Co.Ltd.La Cie d'Installation de Chauffage au La Cie d'Installation de Chauffage au Gaz Naturel Ltée Gaz Naturel Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the fourteenth du quatorze mai 1958, constituant en corpora- day of May, 1958, incorporating: Gérard Corbeil, tion: Gérard Corbeil, avocat, de Longueuil, advocate, of Longucuil, Madeleine Clermont and Madeleine Clermont et Yvette Marcoux, secré- Yvette Marcoux, secretaries, spinsters, of Mont- taires, filles majeures, de Montréal, pour les real, for the following purposes: objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plom- To carry on a business dealing in plumbing and berie et en chauffage, sous le nom de \"Naturel heating, under the name of \"Natural Gas Heating Gas Heating Installation Co.Ltd.\u2014 La Cie Installation Co.Ltd.\u2014 La Cie d'Installation de d'Installation de Chauffage au Gaz Naturel Chauffage au Gaz Naturel Ltée\", with a total Ltée\".avec un capital total de $40,000, divisé capital stock of $40,000, divided into 300 preen 300 actions privilégiées d'une valeur au pair ferred shares of a par value of $100 each and de $100 chacune et en 1,000 actions ordinaires into 1,000 common shares of a par value of $10 d'une valeur au pair de $10 chacune.each.Le siège social de la compagnie sera a Mont- The head office of the company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur general, le Dated at the office of the Attorney General, quatorze mai 1958.this fourteenth day of \"May, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE.48063-o P.FRENETTE.48063 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11720-58) Naturel Gas Units Distributors Co.Ltd.La Cie de Distribution d'Unités de Gaz Naturel Ltée (A.G.11720-58) Naturel Gas Units Distributors Co.Ltd.La Cie de Distribution d'Unités de Gaz Naturel Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the fourteenth du quatorze mai 1958, constituant en corpora- day of May, 1958,.incorporating: Gérard Cor-tion: Gérard Corbeil, avocat, de Longueuil, beil, advocate, of Longueuil, Madeleine Cler-Madeleine Clermont et Yvette Marcoux, secré- mont, and Yvette Marcoux, secretaries, spinsters taires, filles majeures, de Montréal, pour les of Montreal, for the following purposes: objets-suivants: \\ Exercer l'industrie et le commerce de systèmes To carry on an industry and business dealing de chauffage et autres, sous le nom de \"Natural in heating systems and others, under the name Gas Units Distributors Co.Ltd.\u2014 La Cie de of \"Natural Gas Units Distributors Co.Ltd.\u2014 Distribution d'Unités de Gas Naturel Ltée\", La Cie de Distribution d'Unités de Gaz Naturel avec un capital total de $40,000, divisé en 300 Ltée\", with a total capital stock of $40,000, actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 divided Jnto 300 preferred shares of a par value (P.G.11570-58) .(A.G.11570-58) National Recreation Equipment Company National Recreation Equipment Company Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date \" Province of Quebec, bearing date the seventh du sept mai 1958, constituant en corporation: day of May, 1958, incorporating: Leonard Liver-Leonard Liverman, Arthur Yanofsky et Julius man, Arthur Yanofsky and Julius Briskin, all Briskin, tous avocats, de Montréal, pour les advocates, of Montreal, for'the following pur-objets suivants: poses: Fabriquer et exercer le commerce d'articles et To manufacture and deal in sporting goods fournitures de sport, accessoires de parcs et and equipment, park and playground equip-terrains de jeux, jouets, meubles, nouveautés, ment, toys, furniture, novelties, luggage and bagages et articles en cuir, ferronnerie, bicy- leather goods, hardware, bicycles, motors, boats, dettes, moteurs, bateaux, trophées et vêtements trophies and sports clothes, under the name of de sport, sous le nom de \"National Recreation \"National Recreation Equipment Company\", Equipment Company\", avec un capital total with a total capital stock of $40,000, divided into de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une 100 common shares of a par value of $10 each valeur au pair de $10 chacune et 3,900 actions and into 3,900 preferred shares of a par value of privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.$10 each.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company will l>e at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le sept Dated at the office of the Attorney General, mai 1958.this seventh day of May, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 48063 P.FRENETTE.4G063-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2275 chacune' et-en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.* Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11656-58) Nettoyeurs Alpha Dry Cleaners Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mai 1958, constituant en corporation: Lucien Tremblay, industriel, Roland-E.Lemire, vendeur, et François Nobert, avocat, tous des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Faire affaires comme nettoyeurs, teinturiers, buandiers, et faire la réparation de vêtements, tissus, marchandises et ameublements de maison, sous le nom de \"Nettoyeurs Alpha Dry Cleaners Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 800, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11783-58) North Shore Builders Supply Ltd.Les Matériaux de Construction Côte Nord Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation: Claude Guérin, avocat, de Laval-sur-le-Lac, Léo Davignon, comptable, de Laval-des-Rapides, Gérard Corbeil, avocat, de Longueuil, Jacqueline Davignon et Madeleine Clermont, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"North Shore Builders Sup- Ely Ltd.\u2014 Les Matériaux de Construction Côte ford Ltée\", avec un capital total de $25,000, divisé .en 2,500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11276-58) Oak Leaf Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six mai 1958, constituant en corporation: Claude Goulet, de Ville Mont-Royal, Jacques Rousseau, et Pierre Lauzon, de Montréal, tous comptables, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de errains, construction et développement, sous le of $100 each and into 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11656-58) Nettoyeurs Alpha Dry Cleaners Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1958, incorporating: Lucien Tremblay, industrialist, Roland-E.Lcmire, salesman, and François Nobert, advocate, all of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on business as cleaners, dyers, launderers, and to repair clothing, fabrics, merchandise and house furnishings, under the name of \"Nettoyeurs Alpha Dry Cleaners Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of a par value of $100 each and into 100 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 800 des Récollets Boulevard, Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11783-58) North Shore Builders Supply Ltd.Les Matériaux de Construction Côte Nord Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, incorporating: Claude Guérin, advocate, of Laval-sur-lc-Lac, Léo Davignon, accountant, of Laval-des-Rapidcs, Gérard Corbeil, advocate, of Longueuil, Jacqueline Davignon and Madeleine Clermont, secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To operate a business dealing in building materials under the name of \"North Shore Builders Supply Ltd.\u2014 Les Matériaux de Construction Côte Nord Ltée\", with a total capital stock of $25,000.divided into 2,500 shares of 810 each.The head office of the company will be at Stpt-Iles, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1598.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11276-58) Oak Leaf Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of May, 1958, incorporating: Claude Goulet, of the town of Mount Royal, Jacques Rousseau and Pierre Lauzon, of Montreal, all accountants, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and development company, under the name 2276 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 nom de \"Oak Leaf Enterprises Ltd.\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 8255 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11567-58) Oryx Realty Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1958, constituant en corporation: John J.Wasserman, avocat, de Westmount, Harold S.Freeman, Irving J.Halperin, tous deux avocats, et Dorothy Martel, sténographe, fille majeure, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction, développement, portefeuille et placements, sous le nom de \"Oryx Realty Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11782-58) Panzini Ltée \u2014 Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation: Claude Guérin, avocat, de Laval-sur-le-Lac, Léo Davignon, comptable, de Laval-des-Rapides, Jacqueline Davignon et Madeleine Clermont, secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Panzini Ltée \u2014 Ltd»\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11605-58) Paris Originals Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1958, constituant en corporation: Marie Kantrowitz, ménagère, épouse judiciairement séparée de corps et de biens de Isai Kantrowitz, d'Outremont, Esther Zaidener Cooper, ménagère, femme seule, Mina Zaidener Blevinal, ménagère, veuve de feu Harry Blevinal, et Anne Goldenblatt, secrétaire, fille majeure, toutes trois de Montréal, pour les objets suivants: of \"Oak Leaf Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10.each.The head office of the company will be at 8255 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11567-58) Oryx Realty Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of May, 1958, incorporating: John J.Wasserman, advocate, of Westmount, Harold S.Freeman, Irving J.Halperin, both advocates, and Dorothy Martel, stenographer, spinster of the full age of majority, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction, development, holding and investment company, under the name of \"Oryx Realty Corporation\", with a total capital stock of $40,-000, divided into 1,000 common shares of $1 each and into 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11782-58) Panzini Ltée \u2014 Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the twentieth day of May, 1958, incorporating: Claude Guérin, advocate, of Laval-sur-le-Lac, Léo Davignon, accountant, of Laval-des-Rapides, Jacqueline Davignon and Madeleine Clermont, secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Panzini Ltée \u2014 Ltd\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each: The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENE1TE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11605-58) Paris Originals Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1958, incorporating: Marie Kantrowitz, housewife, wife judicially separate as to bed and board of Isai Kantrowitz, of Outremont, Esther Zaidener Cooper, housewife, femme seule, Mina Zaidener Blevinal, housewife, widow of the late Harry Blevinal, and Anne Goldenblatt, secretary, spinster, all three of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2277 Confectionner et^faire le commerce d'articles vestimentaires pour dames, sous le nom de \"Paris Originals Ltd.\", avec un capital total de $25,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11829-58) P.E.Pépin Transport Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1958, constituant en corporation: Paul-Emile Pépin, industriel, Paul-René Pépin et Jean-Claude Pépin, commis, tous de Donnacona, pour les objets suivants: Exercer le commerce du transport de passagers et de marchandises, sous le nom de \"P.E.Pépin Transport Inc.\", avec un capital total de $100,-000, divisé en 550 actions communes de $100 chacune et en 450 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Donnacona, comté de Portneuf, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11052-58) Pointe-Claire Asphalte & Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1958, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, de Saint-Lambert, John Lawrence MeCrory, clerc, et Clifford George Meek, comptable, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Pointe-Claire Asphalte & Construction Inc.\".avec un capital total de $50,0(0, divisé en 4'50 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 50 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11805-58) Préfontaine Machinery & Equipment Inc.Machinerie & Equipement Préfontaine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mai 1958, constituant en corporation: Robert Dulude, de Dorion, Luc Geoffroy, de Chambly, tous deux avocats, et Réjane Schmidt, secrétaire, fille majeure, de Verdun, pour les objets suivants: To manufacture and deal in ladies' wearing apparel, under the name of \"Paris Originals Ltd.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 150 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11829-58) P.E.Pépin Transport Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1958, incorporting: Paul-Emile Pépin, industrialist, Paul-René Pépin and Jean-Claude Pépin, clerk, all of Donnacona, for the following purposes: To carry on a business dealing in the transportation of passengers and merchandise, \u2022 under the name of \"P.E.Pépin Transport Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 550 common shares of $100 each and into 450 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Donnacona, county of Portneuf, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11052-58) Pointe-Claire Asphalte & Construction Inc.Notice is hereby given that under Part Ifof the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1958, incorporating: Ernest William Mockridge, manager, of Saint-Lambert, John Lawrence McCrory, clerk, and Clifford George Meek, accountant, both of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general constructors and as general building contractors, under the name of \"Pointe-Claire Asphalte & Construction Inc.\", with a' total capital stock of $50,000, divided into 450 preferred shares of a par value of $100 each and into 50 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Pointe-Claire, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11805-58) Préfontaine Machinery & Equipment Inc.Machinerie & Equipement Préfontaine Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1958, incorporating: Robert Dulude, of Dorion, Luc Geoffroy, of Chambly, both advocates, and Réjane Schmidt, secretary, spinster, of Verdun, for the following purposes: 2278 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 Commerce de machines, moteurs, outils, instruments et quincaillerie de toutes sortes, sous le nom de \"Préfontaine Machinery & Equipment Inc.\u2014 Machinerie & Équipement Préfontaine Inc.\", avec un capital divisé en 200 actions sans valeur au pair ou nominale et en 900 actions privilégiées de $10 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera d'au moins $10,000.Le siège social de la compagnie sera à Ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.To operate a businesijjdealing in machines, motors, tools, instruments and hardware of all kinds; under the name of \"Préfontaine Machinery & Equipment Inc.\u2014 Machinerie & Équipement Préfontaine Inc.\", with a capital stock divided into 200 shares without nominal or par value and into 900 preferred shares of $10 each and the amount with which the company shall start its operations shall be at least $10,000.The head office of the company will be at Ville Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11460-58) Premier Auto Supply Inc.\u201e Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit avril 1958, constituant en corporation: Leonard Liverman, Julius Briskin et Arthur Yanofsky, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce d'automobiles et autres véhicules, quincaillerie, jouets, plats et nouveautés, sous le nom de \"Premier Auto Supply Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social delà compagnie sera à Montréal, district judiciaire de .Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11349-48) Premier Lining Supply Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1958, constituant en corporation: Daniel Kings tone, avocat, Kay Shechy et Benita Smith,, sténographes, filles majeures, tous de Montreal, pour les objets suivants: Importer, exporter des doublures, sous le nom de \"Premier Lining Supply (Jo.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11460-58) Premier Auto Supply Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of April, 1958, incorporating: Leonard Liverman, Julius Briskin ami Arthur Yanofsky, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in automobiles and other vehicles, hardware, toys, dishes and novelties, under the name of \"Premier Auto Supply Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 1,500 preferred shares of a par value of $10 each and into 500 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.DatcH at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of April, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11349-58) Premier Lining Supply Co.Notice îs hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1958, incorporating: Daniel Kingstone, advocate, Kay Sheehy and Benita Smith, stenographers, spinsters, all of Montreal, for the fol-loging purposes: Import and export of linings, under the name of \"Premier Lining Supply Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 preferred shares of a par value of $10 each and into 1,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1958.P.FRENETTE.48063-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11141-58) Princeton Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mai 1958, constituant en corporation: Daniel Morris, Irving Halperin, avocats et Ernest Rasbkovan, notaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: (A.G.11141-58) Princeton Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1958, incorporating: Daniel Morris, Irving Halperin, advocates, and Ernest Rash-kovan, notary, all of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2279 Exercer le commerce d'agents d'immeubles, sous le nom de \"Princeton Realties Ltd.\", avec un capital total de $2,000, divisé en 200 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4012 avenue Kent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11486-58) Ranoma Sportswear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente avril 1958, constituant en corporation: Motek Rotsztain, Sam Cemach Rotsztain, manufacturiers, Sala Rotsztain, ménagère, épouse séparée de biens dudit Sam Cemach Rotsztain, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, et Paula Rotsztain, ménagère, épouse séparée de biens dudit Motek Rotsztain, et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce d'articles vestimentaires, sous le nom de \"Ranoma Sportswear Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11746-58) Real Lumber Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mui 1958, constituant en corporation : Mme Edouard Boutliillctte.sténographe, épouse séparée de biens de Edouard Boutliillctte, de Levis, David I.anglais, agent, de Loretteville, et Valérien Drouin, chauffeur, de Bienville, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux; exercer l'industrie et le commerce «lu bois, sous le nom de \"Real Lumber Co.Ltd.\", avec un capital total de $150,000, divisé en 1,500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 510, rue St-Franeois, Disraeli, comté Wolfe, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11661-58) Roger Faucher Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation: Gérard Tunnel, avocat, de Sweetsburg, Paul- To carry on business as real estate agents, under the name of \"Princeton Realties Ltd.\", with a total capital stock of $2,000, divided into 200 shares of $10 each.The head office of the company will be at 4012 Kent Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11486-58) Ranoma Sportswear Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April, 1958, incorporating: Motek Rotsztain, Sam Ccmach Rotsztain, manufacturers, Sala Rotsztain, housewife, wife separate as to property of the said Sam Ccmach Rotsztain, and duly authorized by him for the purpose of these presents, and Paula Rotsztain, housewife, wife separate as to property of the said Motek Rotsztain, and duly authorized by him for the purpose of these presents, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, under the name of \"Ranoma Sportswear Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares of a par value fo $100 each and into 200 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April.1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11746-58) Real Lumber Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have l)een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incor|>orating: Mrs Edouard Boutliillctte.stenographer, wife separate as to property of Edouard Boutliillctte, of Levis, David I,anglais, agent, of Loretteville, and Valérien Drouin.chauffeur, of Bienville, for the following purposes: To carry on business as general contractors; to operate an industry and business dealing in lumber, under the name of \"Real Lumber Co.Ltd.\", with a total cupital stock of Si50.000, divided into 1.500 shares of $100 each.The head office of the company will be at 510 St-Francis Street.Disraeli, county of Wolfe, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of tiie Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11661-58) Roger Faucher Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, incorporating: Gérard Tur-mel, advocate, of Sweetsburg, Paul-Émile Brault, 2280 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, 'N° 26 Emile Brault, agent d'assurance, et Fernand Poulin, journalier, de Cowansville, pour les objets suivants; Faire affaires comme entrepreneurs généraux en travaux de pavage et en construction, sous le nom de \"Roger Faucher Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cowansville, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o - P.FRENETTE.(P.G.11279-58) Roger Pilon Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1958, constituant en corporation: Roger Pilon, constructeur, Hélène M iron Pilon, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Roger Pilon, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Hubert DeBonville, contremaître, tous de St-Laurent, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Roger Pilon Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o - P.FRENETTE.(P.G.11047-58) Roland Gagné Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mai 1958, constituant en corporation: Paul Trudeau, avocat, de La val-des-Ra- Çides, Roch-André Bédard, avocat, et Huguette ardif, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles et de nouveautés, sous le nom de \"Roland Gagné Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 25,000 actions communes de $1 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11381-58) Roméo I.agacé Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mai 1958, constituant en corporation: Jacques Viau, avocat et conseil en loi de la Reine, de Lachine, Armand Poupart, fils, avocat, et Monique Duquette, sténographe, célibataire, majeure, flous deux de Montréal, pour les objets suivants : insurance agent, and Fernand Poulin, laborer*' of Cowansville, for the following purposes: To carry on business as general contractors in paving and construction, under the name of \"Roger Faucher Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Cowansville, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE.48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11279-58) Roger Pilon Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1958.incorporating: Roger Pilon, builder, Hélène Miron Pilon, housewife, wife contractually separate as to property of the said Roger Pilon, and duly authorized by him for these present purposes, and Hubert DeBonville, foreman, all of St.Laurent, for the following purposes : To carry on business as general constructors and as general building contractors, to carry on a business dealing in real estate under the name of \"Roger Pilon Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 t Acting Deputy Attorney General.(A.G.11047-58) Roland Gagné Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of May, 1958, incorporating: Paul Trudeau, advocate, of Laval-des-Rapides, Roch-André Bédard, advocate, and Huguette Tardif, secretary, spinster, both of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in furniture and novelties, under the name of \"Roland Gagné Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 25,000 common shares of $1 each and into 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of May, 1958.P.FRENETTE.48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11381-58) Roméo I-agacé Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of May, 1958, incorporating: Jacques Viau, advocate, and Queen's Counsel, of Lachine, Armand Poupart, son, advocate, and Monique Duquette, stenographer, spinster of full age, both of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2281 Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Roméo Lagacé Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 8,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Martin, district judiciaire de Montréal.' Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11795-58) Rove Construction Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1958, constituant en corporation: J.-Eloi Gervais, avocat, de Longueuil, Guy Guérin, avocat, et Claudette Foisy, secrétaire, célibataire majeure, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Rowe Construction Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,500 actions privilégiées de $10 chacune et en 250 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville LaSalle, district judiciaire dé Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11291-58) R.Thibodeau Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mai 1958, constituant en corporation: Roger Thibodeau, manufacturier, Madeleine Marcoux, opératrice, fille majeure, tous deux de Montréal, et Albert Roberge, opérateur, de Jacques-Cartier, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, de construction et d'amélioration-, sous le nom de \"R.Thibodeau Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11606-58) S.& A.Mfg.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1958, constituant en corporation: Albert Malouf, Peter Shorteno, tous deux de Ville Mont-Royal, et John Ciaccia, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: To carry on business as constructors and contractors in construction under the name of \"Roméo Lagacé Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 8,000 preferred shares of a par value of $10 each and into 2,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Saint-Martin, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May, 1958.P FRENETTE 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11795-58) Rowe Construction Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1958, incorporating: J.-Eloi Gervais, advocate, of Longueuil, Guy Guérin, advocate, and Claude Foisy, secretary, spinster of full age, both of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors to operate a business dealing in real estate under the name of \"Rowe Construction Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,500 preferred shares of $10 each and into 250 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Ville LaSalle, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11291-58) R.Thibodeau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of May, 1958, incorporating: Roger Thibodeau, manufacturer, Madeleine Marcoux, operator, spinster, both of Montreal, and Albert Roberge, operator, of Jacques-Cartier, for the following purposes: To carry on -the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"R.Thibodeau Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and into 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11606-58) S.& A.Mfg.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incorporating: Albert Malouf, Peter Shorteno, both of the Town of Mount Royal, and John Ciaccia, of Montreal, all advocates, for the following purposes: 2282 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 Confectionner et faire le commerce d'articles vestimentaires, textiles, nouveautés, jouets, bijouterie, fournitures de maison et marchandises de sport, sous le nom de \"S.& A.Mfg.Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune et 600 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 60 ouest, rue Jean Talon, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorzième jour de mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11806-58) Service Shoe Trimmings Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1958, constituant en corporation: Leonard Liverman, Arthur Yanofsky et Julius Briskin, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de bottines, chaussures et marchandises de cuir, sous le nom de \"Service Shoe Trimmings Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11688-58) Sherbrooke-Drummond Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1958, constituant en corporation: Morris Mashaal, administrateur, Daniel Kingstone, avocat, Gloria Bell et Benita Smith, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, amélioration et développement, sous le nom de \"Sherbrooke-Druinmond Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FfcENETTE.(P.G.10237-58) Silica ('(irecel) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres gatentes, en date du vingt-trois mai 1958, constituant en corporation: Maurice Martel, Paul Lemieux, avocats, et Lucille Roy, secrétaire, célibataire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de matériaux de construction; exploiter des carrières; faire To manufacture and deal in wearing apparel, textiles, novelties, toys, jewellery, household furniture and sporting goods, under the name of \"S.& A.Mfg.Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 400 common shares of $100 each and into 600 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 60 Jean Talon Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11806-58) Service Shoe Trimmings Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1958, incorporating: Léonard Liverman, Arthur Yanofsky and Julius Briskin, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in boots, shoes and leather goods, under the name of \"Service Shoe Trimmings Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11688-58) Sherbrooke-Drummond Ltd.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1958, incorporating: Morris Mashaal.executive, Daniel Kingstone, advocate, Gloria Bell and Benita Smith, secretaries, spinsters, all of Montreal, for the followjng purposes: To carry on the business of a real estate, improvement and development company, under the name of \"Sherbrooke-Drummond Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares of a par value of $100 each and into 100 common shares of a par value of.$100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10237-58) Silica (Grecel) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of May, 1958, incorporating: Maurice Martel, Paul Lemieux, advocates, and Lucille Roy, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To operate an industry and business dealing in building materials; to operate quarries; to carry QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2283 affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Silica (Grecel) Inc.\", avec un capital total de $600,000, divisé en 80,000 actions communes de $5 chacune et en 8,000 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.10348-58) Société Sportive Saint Louis Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation sans capital-actions: M.l'abbé Alfred Gagnon, prêtre, curé dess.Rodrigue Pinettc, Octave Caron, marchands, Alphonse Belzil, barbier, Hermel Côté, professeur, Rosaire Pelletier et Romain Caron, cultivateurs, tous de St-Jean-de-la-Lande, pour les objets suivants: Former et diriger une association sportive; promouvoir le sport et la culture physique en général, sous le nom de \"Société Sportive Saint-Louis Incorporée\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Jean-de-la-Landei (Témiscouata), district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.' L'Assistant-procureur général suppléant.48063-o .P.FRENETTE.(P.G.11667-58) Sommet Laurentien Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation: René Lortie.commerçant, Léo Lortie, garagiste, et André Bertrand, comptable agréé, tous de Sainte-Agathe-des-Monts, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"Sommet Laurentien Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions communes de $10 chacune et en (KX) actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Agathe-des-Monts, district judiciaire de Terre-bonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.10300-58) Sportswear Specials Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date on business as general building contractors, under the naine of \"Silica (Grecel) Inc.\", with a total capital stock of $600,000, divided into 80,000 common shares of $5 each and into 8,000 preferred shares of $25 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal, Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10348-58) Société Sportive Saint Louis Incorporée Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Rev.Father Alfred Gagnon, priest, pastor acting as substitute pastor in charge, Rodrigue Pinette, Octave Caron, merchants, Alphonse Belzil, barber, Hermel Côté, professor, Rosaire Pelletier and Romain Caron, farmers, all of St-Jean-de-la-Lande, for the following purposes: To form and direct a sports' association, to promote sports and physical culture generally, under the name of \"Société Sportive Saint Louis Incorporée\".* The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at Saint-Jean-de-la-Lande, (Témiscouata), judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11667-58) Sommet Laurentien Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, incorporating: René Lortie, tradesman, Léo Lortie, garage-keeper, and André Bertrand, charted accountant, all of Sainte-Agathe-des-Monts, for the following purposes: To carry on a business dealing in real estate; to carry on business as general contractors in construction, under the name of \"Sommet Laurentien Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 600 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at Sainte-Agathe-des-Monts, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10300-58) Sportswear Specials Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty- 2284 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 du vingt-neuf janvier 1958, constituant en corporation: Morris Chai kelson, Perry Meyer, avocats, de Montréal, et Morris Shuter, comptable, de St-Laurent, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce d'articles vestimentaires, sous le nom de \"Sportswear Specials Inc.\", avec un capital total de $25,000, divisé en 1,250 actions ordinaires de $10 chacune et 1,250 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf janvier 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11784-58) Stanfold Inversaient Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres-patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation: Samue] Chait, Maxwell Shenker, avocats, John Hamilton, secrétaire, tous trois de Montréal, et Harry L.Aronovitch, avocat, de la ville Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une corporation de placements, sous le nom de \"Stanfold Investment Corporation\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 36,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11544-58) Ste Adèle Marine and Sports Centre Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1958, constituant en corporation: Ralph Hibbard, Hubert Ashley Hibbard, marchands, Shirley Simon, secrétaire, et Ellen Haggenmueller, commis, toutes deux filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de véhicules moteurs électriques et à gazoline, agrès de pêche, fournitures pour le camp et le sport; transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction, développement et amélioration, sous le nom de \"Ste Adèle Marine and Sports Centre Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, et 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Adèle-en-Bas, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11014-58) Steel Processing Inc.\u2022 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date ninth day of January, 1958, incorporating: Morri8 Chaikelson, Perry Meyer, attorneys, of Montreal* and Morris Shuter, accountant, of St.Laurent, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, under the name of \"Sportswear Specials Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 1,250 common shares of $10 each and into 1,250 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of January, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11784-58) Stanfold Inversment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, incorporating: Samuel Chait, Maxwell Shenker, advocates, John Hamilton, secretary, all three of Montreal, and Harry L.Aronovitch, advocate, of the Town of Côte Saint-Luc, for the following purposes: To carry on business as an investment corporation, under the name of \"Stanfold Investment Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $1 each and into 36,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11544-58) Ste Adèle Marine and Sports Centre Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1958, incorporating: Ralph Hibbard, Hubert Ashley Hibbard, merchants, Shirley Simon, secretary, and Ellen Haggenmueller, clerk, both filles majeures, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in electrical and gasoline motor vehicles, fishing, camping and sporting equipment; to carry on the business of a land, construction, development and improvement company, under the name of \"Ste Adèle Marine and Sports Centre Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and into 10,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Sainte-Adèle-en-Bas, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o s, Acting Deputy Attorney General.(A.G.11014-58) - \" Steel Processing Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2285 du seize mai 1958, constituant en corporation: Maurice Steinberg, avocat, Thomas Gavin, comptable, et Frances Morrison, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Préparer, trier, assortir et traiter tous types\" de métaux, matériaux et liquides, et tous leurs sous-produits, sous le nom de \"Steel Processing Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11639-58) St.Hubert Paving Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1958, constituant en corporation: Serge Morin, Guy Guérin et François Boisclair, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants : Faire affaires comme constructeurs et comme entrepreneurs généraux en travaux de pavage et en construction, sous le nom de \"St.Hubert Paving Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 350 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2500, rue Deslauriers, Ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11535-58) St.Leonard Shopping Centre Ltd.Centre d'Achat St.Léonard Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux mai 1958, constituant en corporation: Melvin Rothman, avocat, de Westmount, Neil Phillips, avocat, Yvonne Bélanger, et Sylvia Vineberg, secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir certaine propriété immobilière ou propriétés dans St-Léonard de Port Maurice et entreprendre des projets de construction, l'administration et l'exploitation de centres commerciaux, et places marchandes s'y rapportant, sous le nom de \"St.Leonard Shopping Centre Ltd.\u2014 Centre d'Achat St-Léonard Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11601-58) St.Martin Heights Gardens Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>cc, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la day of May, 1958, incorporating: Maurice Steinberg, advocate, Thomas Gavin, accountant, and Frances Morrison, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To prepare, grade, sort and process all types of metals, materials and liquids, and all of their by-products, under the name of \"Steel Processing Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of 10 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11639-58) St.Hubert Paving Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1958, incorporating: Serge Morin, Guy Guérin and François Boisclair, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as constructors and general contractors in paving and construction, under the name of \"St.Hubert Paving Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 350 common shares of a par value of $100 each and into 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 2500 Deslauriers St., Ville Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11535-58) St.Leonard Shopping Centre Ltd.Centre d'Achat St.Léonard Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of May, 1958, incorporating: Melvin Roth-man, advocate, of Westmount, Neil Phillips, advocate, Yvonne Bélanger and Sylvia Vineberg, secretaries, filles majeures, all three of Montreal, for the following purposes: To acquire certain immoveable property or properties in St.Leonard de Port Maurice and to undertake construction projects and the management and operation of commercial centres and shopping centres in connection therewith, under the name of \"St.Leonard Shopping Centre Ltd.\u2014 Centre d'Achat St.Léonard Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May, 1958.P.FRENETTE.48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11601-58) St.Martin Heights Gardens Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 2286 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N\" 26 province de Québec des lettres patentes, en date du neuf mai 1958, constituant en corporation: Abraham Sinister, Bernard Diamond et Jason Ruby, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et améliorations, sous le nom de \"St.Martin Heights Gardens Inc.\", avec un capital-actions divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.10778-58) Stone Machinery & Equipment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente avril 1958, constituant en corporation: Emile Guilmette, fabricant, Xudovic Tardif, machiniste, et Lucienne Mallette, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et faire des affaires comme fabricants de matériaux utilisés dans la construction de bâtisses, sous le nom de \"Stone Machinery & Equipment Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11660-58) Stormont General Constractors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation: Paul Lemieux, Walter Guillery, avocats, et Mary Mathoul, secrétaire, épouse séparée de biens de Gaston Mathoul, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Stormont General Contractors Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 32, boule-levard St-Joseph, Lachine, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11571-58) St.Thérèse West Land Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Province of Quebec, bearing daté the ninth day of May, 1958, incorporating: Abraham Shu s ter, Bernard Diamond and Jason Ruby, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"St.Martin Heights Gardens Inc.\", with a capital stock divided into 500 common shares of a par value of $10 each and into 3,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10778-58) Stone Machinery & Equipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of April, 1958, incorporating: Emile Guilmette, manufacturer, Ludovic Tardif, machinist, and Lucienne Mallette, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade and to do business as manufacturers of materials used in the construction of buildings, under the name of \"Stone Machinery & Equipment Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and into 400 preferred shares of a par value of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of April, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11660-58) Stormont General Constractors Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, incorporating: Paul Lemieux, Walter Guillery, advocates, and Mary Mathoul, secretary, wife separate as to property of Gaston Mathoul, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders, and general building contractors to operate a real estate business under the name of \"Stormont General Contractors Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 32 St-Joseph Boulevard, Lachine, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11571-58) St.Thérèse West Land Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2287 province de Québec des lettres patentes, en date du sept mai 1958, constituant en corporation: Irving L.Adessky, Moses Moscovitch et Melvin Salmon, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sous le nom de \"St.Thérèse West Land Corp.\", avec un capital total de ?HM),000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune et 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11556-58) Sun Automatic Parking Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit mai 1958, constituant en corporation: Edmond-Jacques Courtois, de Westmount, Ross Trenholme Clark son, de Ville Mont-Royal, tous deux avocats, et Margaret Esther Sheila Donovan, secrétaire, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de propriétaires, bailleurs, directeurs ou gérants de terrains de stationnement et propriétés pour le stationnement, comme garage et entrepôt pour automobiles, camions et voitures de toutes sortes, sous le nom de \"Sun Automatic Parking Inc.\", avec un capital-actions de 600 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses activités ne sera pas moins de $3,000.Le siège social de la compagnie sera chambre 1022, 132 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.- Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11476-58) Superior Agencies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf avril 1958, constituant en corporation: Leonard Liven nun, Julius Briskin et Arthur Yanofsky, tous avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de marchandises pour sport et accessoires, jouets, fournitures, nouveautés, bagages et marchandises de cuir, quincaillerie, bicyclettes, moteurs, bateaux, trophées et vêtements de sport, sous le nom de \"Superior Agencies Inc.\", avec un capital actions divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair, 3,950 actions privilégiées de $10 chacune et le montant avec leque la compagnie commencera ses activités sera $5,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf avril 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.Province of Quebec, bearing date the seventh day of May, 1958, incorporating: Irving L.Adessky,.Moses Moscovitch and Melvin Salmon, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"St.Thérèse West Land Corp.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 5,000 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11556-58) Sun Automatic Parking Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1958, incorporating: Edmond-Jacques Courtois, of Westmount, Ross Trenholme Clark-son, of the Town of Mount Royal, both advocates, and Margaret Esther Sheila Donovan, secretory, spinster, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of owners, lessors, operators or managers of parking lots and properties for the parking, garaging and storing of automobiles, trucks and cars of all kinds, under the name of \"Sun Automatic Parking Inc.\", with a capital stock divided into 600 shares without nominal or par value, and the amount of capital stock with which the company will commence its operations will not be less than $3,000.The head office of the company will be at Room 1022, 132 St.James Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11476-58) Superior Agencies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of April, 1958, incorporating: Leonard Liverman, Julius Briskin and Arthur Yanofsky, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in sporting goods and equipment, toys, furniture, novelties, luggage and leather goods, hardware, bicycles, motors, boats, trophies and sports clothes, under the name of \"Superior Agencies Inc.\", with a capital stock divided into 100 shares having no nominal or par value and into 3,950 preferred shares of $10 each, and the amount with which the company will commence its operations will be $5,000.The head office of the.company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of April, 1958.P.FRENETTE, 48063-o ' Acting Deputy Attorney General. 2288 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 (P.G.11609-58) The Cabaret Room Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq mai 1958, constituant en corporation: Guy-E.Boisvert, Georges-C.Lachance, tous deux de Montréal et François Limoges, de Ville Émard, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de \"The Cabaret Room Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.10490-58) The Lingerie & Underwear Manufacturera Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en ( ate du sept mai 1958, constituant en corporation sans capital-actions: Saul Kugler, de Montréal, Théo Rossy, de Ville Mont-Royal, Russell Bou-samra, de St-Laurent, et Harold Brownstein, de Westmount, tous manufacturiers, pour les objets suivants: Promouvoir le bien-être et le meilleur intérêt des membres engagés dans le commence de confectionneurs de lingerie, sous-vêtements et autres articles vestimentaires pour dames, sous le nom de \"The Lingerie & Underwear Manufacturers Association\".Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété que la corporation peut posséder est $50,000.Le siège social de la comporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11539-58) The Mayfair Hospital Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1958, constituant en corporation: Monroe Abbey, de Westmount, Max Slapack, de la ville Côte St-Luc, tous deux avocats, Gregory Charlap, Arthur Shulman, avocats, et Sylvia Teitlebaum, secrétaire, fille majeure, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Établir, aménager, entretenir, exploiter et diriger ùn hôpital, sous le nom de \"The Mayfair Hospital Ltd.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 4,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11609-58) The Cabaret Room Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of May, 1958, incorporating: Guy-E.Boisvert, Georges-C.Lachance, both of Montreal, and François Limoges, of Ville Émard, all lawyers, for the following purposes: To carry on business as restaurant keepers, under the name of \"The Cabaret Room Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated, at the office of the Attorney General, this fifth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10490-58) The Lingerie & Underwear Manufacturers Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of May, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: Saul Kugler, of Montreal, Theo Rossy, of the town of Mount Royal, Russell Bousamra, of St.Laurent, and Harold Brownstein, of Westmount, all manufacturers, for the following purposes: To promote the welfare and best interest of the members engaged in the business of manufacturers of lingerie and underwear and other articles of women's apparels, under the name of \"The Lingerie & Underwear Manufacturers Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11539-58) The Mayfair Hospital Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May, 1958, incorporating: Monroe Abbey, of Westmount, Max Slapack, of the town of Côte St.Luc, both advocates, Gregory Charlap, Arthur Shulman, advocates, and Sylvia Teitlebaum, secretary, spinster, of the full age of majority, all three of Montreal, for the following purposes: To establish, equip, maintain, operate and conduct a hospital, under the name of \"The Mayfair Hospital Ltd.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2289 (P.G.10489-58) The Optimist Club of Lake St.' Louis Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt mai 1958, constituant en corporation sans capital-actions: William Donald Liddell, Rupert Holmes, vendeurs, et Harold Mullan, gérant de bureau, tous de Pointe-Claire, pour les objets suivants: Effectuer et perpétuer le travail et l'entreprise exécutés ci-devant par le Club optimiste du Lac St-Louis, sous le nom de \"The Optimist Club of Lake St.Louis\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P:G.10889-58) Tiny Tots Knitting Mills Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept mai 1958, constituant en corporation: Harvey Crestohl, d'Outremont, Donald William Seal, de Montréal, tous deux avocats, et Joseph S.Kaplan, notaire, de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce de marchandises tricotées, sous le nom de \"Tiny Tots Knitting Mills Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4078 boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11830-58) Trader Vic's Bar and Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux mai 1958, constituant en corporation: Jonathan J.Robinson, avocat, Jean McFarlane, teneuse de livres, et Margaret Lang-maid, secrétaire, toutes deux filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme propriétaire d'un bar et «restaurant, sous le nom de \"Trader Vic's Bar and Restaurant Inc.\", avec un capital-actions divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair et le montant du capital-actions avec lequel la compagnie commencera ses activités sera de $500.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.10489-58) The Optimist Club of Lake St.Louis Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1958, to incorporate as a corporation without share capital: William Donald Liddell, Rupert Holmes, salesmen, and Harold Mullan, officer manager, all of Pointe-Claire, for the following purposes: To carry on and perpetuate the work and undertaking heretofore carried on by the Optimist Club of Lake St.Louis, under the name of \"The Optimist Club of Lake St.Louis\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Pointe-Claire, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.10889-58) * Tiny Tots Knitting Mills Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of May, 1958, incorporating: Harvey Crestohl, of Outremont, Donald William Seal, of Montreal, both advocates, and Joseph S.Kaplan, notary of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in knitted goods, under the name of \"Tiny Tots Knitting Mills' Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 4078 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney Genera).(A.G.11830-58) Trader Vic's Bar and Restaurant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of May, 1958, incorporating: Jonathan J.Robinson, advocate, Jean McFarlane, bookkeeper, and Margaret Langmaid, secretary, both spinsters, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as bar and restaurant keepers, under the name of \"Trader Vic's Bar and Restaurant Inc.\", with a capital stock divided into 100 shares having no nominal or par value, and the amount with which the companv will commence its operations will be $500.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General. 2290 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N\" 26 (P.G.11559-58) Vanguard Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec des lettres patentes, en date u huit mai 1958, constituant en corporation: Morris Chaikelson, de Montréal, Hyman Solomon de Ville Mont-Royal, tous deux avocats, et Morris Shuter, comptable, de Saint-Laurent, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme agents d'immeubles, sous le nom de \"Vanguard Realties Inc.\", avec un capital total de $25,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11669-58) - Vaudreuil Holdings Corp.Avis est donné qu'en' vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec des lettres patentes, en date u douze mai 1958, constituant en corporation: Max Slapack, Arthur Shulman, avocats, Sylvia Teitlebaum, Margueriet Dadd et Judith Fink, toutes trois secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, construction et amélioration, sous le nom de \"Vaudreuil Holdings Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires de $100 chacune et 360 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.11559-58) Vanguard Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of May, 1958, incorporating: Morris Chaikelson, of Montreal, Hyman Solomon, of the Town of Mount Royal, both attorneys, and Morris Shuter, accountant, of Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on business as real estate agents, under the name of \"Vanguard Realties Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 1,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11668-58) Vaudreuil Holdings Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1958, incorporating: Max Slapack, Arthur Shulman, advocates, Sylvia Teithlebaum, Marguerite Dadd and Judith Fink, all three secretaries, spinsters of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Vaudreuil Holdings Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of $100 each and into 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11540-58) V.K.Restaurant Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieuteannt-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux mai, 1958, constituant en corporation: Max Slapack, de la ville Côte St-Luc, Gregory Charlap et Arthur Shulman, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, hôteliers, taverniers et aubergistes, sous le nom de \"V.K.Restaurant Ltd.\", avec un capital total de $40,-000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Lé siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11359-58) Walter J.Cross Inc.(A.G.11540-58) V.K.Restaurant Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of May, 1958, incorporating: Max.Slapack, of the town of Côte St.Luc, Gregory Charlap and Arthur Shulman, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on business as restaurant, hotel, tavern and inn keepers, under the name of \"V.K.Restaurant Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11359-58) Walter J.Cross Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.28 2291 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1958, constituant en corporation : J.Austin Murphy, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Mildred Murphy, célibataire, et Francis J.Dolan, comptable, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de bottines, chaussures et marchandises en cuir, sous le nom de \"Walter J.Cross Inc.\", avec un capital-actions divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1958, incorporating: J.Austin Murphy, advocate and Queen's Counsel, Mildred Murphy, unmarried woman, and Francis J.Dolan, accountant, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in boots, shoes and leather goods, under the name of \"Walter J.Cross Inc.\", with a capital stock divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will beat Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.10583-58) W.B.Miller Investments Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mai 1958, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, avocat et Conseil en Loi de la Reine.Gertrude Litner et Mary Watt, secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"W.B.Miller Investments Corp.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 990 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(P.G.11563-58) Webbmont Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1958, constituant en corporation: Gaétan Lagarde, d'Outremont, Neil Phillips et James Soden, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Webbmont Corporation\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.(A.G.10583-58) W.B.Miller Investments Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of May, 1958, incorporating: Louis H.Rohrlick, advocate and Queen's Counsel, Gertrude.Litner and Mary Watt, secretaries, spinsters of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"W.B.Miller Investments Corp.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 990 preferred shares of a par value of $100 each and into 1,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11563-58) Webbmont Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1958, incorporating: Gaétan Lagarde, of Outremont, Neil Phillips and James Soden, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Webbmont Corporation\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at* Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.11547-58) \u2022 Women's World Inc.^Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1958, constituant en corporation: Samuel Leon Mendelsohn, conseil en loi de la (A.G.11547-58) Women's World Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1958, incorporating: Samuel Leon Mendelsohn, Queen's Counsel, of Westmount 2292 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 Reine, de Westmount, Manuel Shacter, de Dorval et Stanley Taviss, de Montréal, tous avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et exercer le commerce de vêtements, sous le nom de \"Women's World Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063 P.FRENETTE.Manuel Shacter, of Dorval, and Stanley Taviss, of Montreal, all advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, under the name of \"Women's World Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,-000 common shares of $1 each and into 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063-o Acting Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent (P.G.11585-58) (A.G.11585-58) Adat Development Corp.Adat Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary let- été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ters patent have been issued by the Lieutenant-province de Québec des lettres patentes supplé-.Governor of the Province of Quebec, dated May m entai res, en date du deux mai 1958, à la com- second, 1958, to the company \"Adat Develop- pagnie \"Adat Development Corp.\", étendant ment Corp.\", extending its powers, ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le deux Dated at the office of the Attorney General, mai 1958.this second day of May, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 48063-o P.FRENETTE.48063 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11572-58) ' (A.G.11572-58) Bedford Realties Ltd.Bedford Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary let-été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ters patent have been .issued by the Lieutenant-province de Québec des lettres patentes supplé- Governor of the Province of Quebec, dated May mentaires, en date du sept mai 1958, à la com- seventh, 1958, to the company \"Bedford Realties pagnie \"Bedford Realties Ltd.\", augmentant Ltd.\", increasing its capital stock from $10,000 son capital de $10,000 à $50,000, le capital- to $50,000, the additional capital stock being actions additionnel étant divisé en 400 actions divided into 400 preferred shares of $100 each, privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le sept Dated at the Office of the Attorney Genera], mai 1958^ this seventh day of May, 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE, 48063-o P.FRENETTE.48063 Acting Deputy Attorney General.(P.GM 1765-58) B.K.Johl Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-neuf mai 1958, à la compagnie \"B.K.Johl Inc.\", modifiant certaines dispositions de ses lettres patentes' originaires et lettres patentes supplémentaires antérieures.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11546-58) Café \"Le Chanteclerc\" Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du huit mai 1958, à la compagnie \"Café Coq d'Or Inc.\", constituée en (A.G.11765-58) B.K.Johl Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May twenty-ninth, 1958, to the company \"B.K.Jolil Inc.\", modifying certain provisions of its original and its previous supplementary letters patent.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11546-58) Café \"Le Chanteclerc\" Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May eighth, 1958, to the company \"Café Coq d'Or Inc.\", incorporated under the said Part I QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2293 corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 14 décembre 1946, changeant son nom en celui de \"Café \"Le Chanteclerc\" Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le huit mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11586-58) Canadian Pacific Recreation Club (Montreal) Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt mai 1958, à la corporation \"Canadian Pacific Recreation Club 'Montreal) Inc.\", étendant ses pouvoirs en portant le montant des biens immobiliers que peut posséder ladite corporation de $150,000 à $250,000.Daté du bureau du Procureur général,-le vingt mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11263-58) Candiac Automobiles Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatorze mai 1958, à la compagnie \"Cowansville Sales & Service Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 22 novembre 1957:1° changeant son nom en celui de \"Candiac Automobiles Ltée\"; 2°' changeant l'endroit de son siège social de Sweetsburg, district judiciaire de Bedford, à Delson, district judiciaire de Montréal; 3° convertissant 350 de ses 400 actions ordinaires de $100 chacune en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Daté «lu bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958./ L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.of the Quebec Companies' Act, by letters patent of December 14, 1946, changing its name into that of \"Café \"Le Chanteclerc\" Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this eighth of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11586-58) Canadian Pacific Recreation Club (Montreal) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May twentieth, 1958, to the corporation \"Canadian Pacific Recreation Club (Montreal )Inc\", extending its powers by carrying the amount of immoveable property which the corporation may own from $150,000 to $250.000.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48003 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11263-58) Candiac Automobiles Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Queliec, dated May fourteenth, 1958, to the company \"Cowansville Sales & Service Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of November 22, 1957: 1° changing its name into that of \"Candiac Automobiles Ltée\"; 2° changing the place of its head office from Sweetsburg, judicial disrict of Bedford, to Delson, judicial district of Montreal; 3° converting 350 of its 400 common shares of $100 each into 350 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11223-58) Chase Tools & Equipment Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente mai 1958, à la compagnie \"Dibblee-Chase Tools Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 14 mars 1951, changeant son nom en celui de \"Chase Tools & Equipment Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le trente mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(A.G.11223-58) Chase Tools & Equipment Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May thirtieth, 1958, to the company \"Dibblee-Chase Tools Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of March 14, 1951, changing its name irto that of \"Chase Tools & Equipment Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11523-58) Cine-World Canadian Corporation Ciné-Monde Canadien Limitée (P.G.11523-58) Cine-World Canadian Corporation Ciné-Monde Canadien Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary let-été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ters patent have been issued by the Lieutenant- 2294 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N\" 26 province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du six mai 1958, à la compagnie \"Cine-World Canadian Corporation \u2014 Ciné-Monde Canadien Limitée\", augmentant son capital de $60,000 à $3,060,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 30,000 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.Governor of the Province of Quebec, dated May sixth, 1958, to the company \"Cine-World Canadian Corporation \u2014 Ciné-Monde Canadien Limitée\", increasing its capital stock from $60,-000 to $3,060,000, the additional capital stock being divided into 30,000 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11629-58) Compagnie France Film Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la, province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du six mai 1958, à la \"Compagnie France Film\", modifiant les dispositions de ses lettres patentes originaires en ce qui concerne les privilèges, conditions et restrictions attachés aux actions privilégiées.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11402-58) J.H.Smith Construction Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux mai 1958, à la compagnie \"International Industries Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 1er août 1957, Ie changeant son nom en celui de \"J.H.Smith Construction Corp.\"; 2° étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11565-58) Just Equipment & Supply Company, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-neuf mai 1958, à la compagnie \"Just Equipment & Supply Company, Limited\", réduisant son capital, le capital-actions annulé étant divisé en 25,000 actions privilégiées de $50 chacune et le montant avec lequel ladite compagnie continuera ses opérations étant fixé à $145,000.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(A.G.11629-58) Compagnie France Film Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May sixth, 1958, to the company \"Compagnie France Film\", amending the provisions of its original letters patent in that which concerns the privileges, conditions and restrictions attached to the preferred shares.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11402-58) J.H.Smith Construction Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated twenty-second day of May, 1958, to the company \"International Industries Ltd.\", incorporated under Paît I of the Quebec Companies Act, by letters patent of August 1st, 1957, 1.changing its name into that of \"J.H.Smith Construction Corp.\"; 2.extending its powers.Dajted at the office of the Attorney General, this twenty-second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11565-58) Just Equipment & Supply Company, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May twenty-ninth, 1958, to the company \"Just Equipment & Supply Company, Limited\", reducing its capital stock, the cancelled capital stock being divided into 25,000 preferred shares of $50 each and the amount with which the said company shall continue its operations being fixed at $145,000.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(P.G.11645-58) Les Entreprises Bellehumeur Ltée Bellehumeur Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du six mai 1958, à la com- (A.G.11645-58) Les Entreprises Bellehumeur Ltée Bellehumeur Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May sixth, 1958, to the company \"Les Meubles QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.28 2295 pagnie \"Les Meubles Chez Henri Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 17 septembre 1954: 1° changeant son nom en celui de.\"Les Entreprises Bellehumeur Ltée \u2014 Bellehumeur Enterprises Ltd.\"; 2° étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le six mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11424-58) L.Gordon Tarlton Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt et un mai 1958, à la compagnie \"L.Gordon Tarlton Limited\", 1° résuisant son capital de $49,900 à $25,000: le capital-actions annulé étant divisé en 249 actions ordinaires de $100 chacune; 2° augmentant son capital ainsi réduit de $25,000 à $325,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 300,000 actions privilégiées de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.10896-58) Northern Loan and Finance Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du treize mai 1958.à la compagnie \"Norther Investment Corporation\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 11 février 1957,1° étendant ses pouvoirs; 2° changeant son nom en celui de \"Northern Loan and Finance Corp.\"; 3° réduisant son capitol de $200,000 à $120,000, le capital-actions annulé étant divisé en 8,000 actions privilégiées de $10 chacune; 4° augmentant son capitol ainsi réduit de $120,000 à $225,000.le capital-actions additionnel étant divisé en 10.500 actions privilégiées de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.48063-o P.FRENETTE.(P.G.11612-58) Prudential Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-neuf mai 1958, à la compagnie \"Prudential Investment Corporation\", modifiant certaines dispositions de ses lettres patentes supplémentaires en date du 21 mars J957.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant.48063-o P.FRENETTE.Chez Henri Inc.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent of September 17, 1954: 1.changing its name to that of \"Les Entreprises Bellehumeur Ltée \u2014 Bellehumeur Enterprises Ltd.\"; 2.extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11424-58) L.Gordon Tarlton Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May twenty-first, 1958, to the company \"L.Gordon Tarlton Limited\", 1° reducing its capitol stock from $49,900 to $25,000: the cancelled capitol stock being divided into 249 common shares of $100 each; 2° increasing its capitol stock thus reduced from $25,000 to $325,000, the additional capitol stock being divided into 300,000 preferred shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10896-58) Northern Loan and Finance Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May thirteenth, 1958, to the company \"Northern Investment Corporation\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of February 21, 1957, 1.extending its powers 2.changing its name into that of \"Northern Loan and Finance Corp.\"; 3.reducing its capitol stock from $200,000 to $120,000, the cancelled capitol stock being divided into 8,000 preferred shares of $ 10 each ; 4.increasing its capitol stock thus reduced from $120,000 to $225.000, the additional capitol stock being divided into 10,500 preferred shares of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11612-58) Prudential Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May twenty-ninth, 1958, to the company \"Prudential Investment Corporation\", modifying certain provisions of its supplementary letters patent dated March 21, 1957.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11480-58) Quebec Land & Realty Company (P.G.11480-58) Quebec Land & Realty Company Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary 2296 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du neuf mai 1958, à la compagnie \"Quebec Land.Company\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 29 août 1906, et par lettres patentes supplémentaires en date, respectivement, du 29 juin 1912, du 25 juin 1947 et du 2 mai 1952: 1° changeant son nom en celui de \"Quebec Land & Realty Company\"; 2° étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le neuf mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11611-58) Quebec Structure & Metal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province\" de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du cinq mai 1958, à la compagnie \"Quebec Structure & Metal Inc.\", augmentant son capital de $45,000 à $250,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 2,050 actions ordinaires de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le cinq mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11423-58) Saunders Materials (Quebec) Ltd.Avis 'est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatorze mai 1958, à la compagnie \"Saunders Joint Materials (Quebec) Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, sous le nom originaire de \"Saunders Quebec Joint Materials Limited\", par lettres patentes du 12 juin 1957, et par lettres patentes supplémentaires en date du 26 juin 1957, changeant, inter alia, ledit nom originaire en^celui de \"Saunders Joint Materials (Quebec) Limited\", changeant de nouveau son nom en celui de \"Saunders Materials (Quebec) Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11521-58) Specialloid (Canada) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du deux mai 1958, à la compagnie \"Specialloid (Canada) Limited\", augmentant son capital de $600,000 à $1,100,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 500,-000 actions ordinaires de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le deux mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P'G.11715-58) T.J.Moore & Company, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May ninth, 1958, to the company \"Quebec Land Company\" incorporated by letters patent dated August 29th, 1906, and by supplementary letters patent June 29, 1912 from June 25, 1947 and from May 2, 1952: 1° changing its name into that of \"Quebec Land & Realty Company\"; .2° extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11611-58) Quebec Structure & Metal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May fifth, 1958, to the company \"Quebec Structure & Metal Inc.\", increasing its capital stock from $45,000 to $250,000, the additional capital stock being divided into 2,050 common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, ' this fifth day of May, 1958.P.FRENETTE, 38063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11423-58) Saunders Materials (Quebec) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May fourteenth, 1958, to the company \"Saunders Joint Materials (Quebec) Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, under the original name of \"Saunders Quebec Joint Materials (Quebec) Limited\", by letters patent of June 12,1957, and by supplementary letters patent dated June 26, 1957, changing, inter alia, the said original name into that of \"Saunders Joint Materials (Quebec) Limited\", again changing its name into that of \"Saunders Materials (Quebec) Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11521-58) Specialloid (Canada) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May second, 1958, to the company \"Specialloid (Canada) Limited\", increasing its capital stock from $600,000 to $1,100,000: the additional capital stock being divided into 500,000 common shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this second day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11715-58) T.J.Moore & Company, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2297 province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du treize mai 1958, à la compagnie \"T.J.Moore & Company, Limited\", augmentant son capital de $49,000 à $124,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 7,500 actions privilégiées de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.(P.G.11564-58) Wise Bros.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-six mai 1958, à la compagnie \"Wise Bros.Limited\", subdivisant ses 200 actions ordinaires de $100 chacune en 4,000 actions ordinaires de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mai 1958.L'Assistant-procureur général suppléant, 48063-o P.FRENETTE.Governor of the Province of Quebec, dated May thirteenth, 1958, to the company \"T.J.Moore & Company, Limited\", increasing its capital stock from $49,000 to $124,000, the additional capital stock being divided into 7,500 preferred shares of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11564-58) Wise Bros.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May twenty-sixth, 1958, to the company \"Wise Bros.Limited\", subdividing its 200 common shares of $100 each into 4,000 common shares of $5 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of May, 1958.P.FRENETTE, 48063 Acting Deputy Attorney General.Arrêté en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 660 Québec, le 19 juin 1958.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant une convention collective de travail relative à l'industrie du fer et du bronze (1 'ornament at i on dans la région de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: La Chambre de Construction, Inc.; dont le siège social est à Montréal, agissant pour et au nom des maisons suivantes: \"A.& S.Architectural Iron Works; Canadian Welding Works Limited; A.Faustin Co.Limited; Locweld & Forge Products Limited; Montreal Forged Products Limited; Montreal Iron Works Limited; Montreal Metalworked Products Limited; Tremblay & Boucley Enrg.\" toutes de la cité de Montréal, Et, d'autre part: Le local numéro 2366 de \"The United Steel Workers of America\" de la cité de Montréal, pour les employeurs et les salariés de l'industrie et des métiers visés, suivant les conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, édition du 10 mai 1958; Attendu que les dispositions de ladite convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement des conditions de travail dans l'industrie et les métiers visés et dans la juridiction territoriale indiquée dans ladite requête; Attendu que les dispositions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; Order in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 660 Quebec, June 19, 1958.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning a collective labour agreement relating to the ornamental iron and bronze industry in the district of Montreal.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties hereafter mentioned have petitioned the Minister of Labour to render obligatory the collective labour agreement entered into between: On the one part: The Builders' Exchange, with head office in Montreal, acting for and in the name of the following firms: A.& S.Architectural Iron Works; Canadian Welding Works Limited; A.Faustin Co.Limited; Locweld & Forge Products Limited; Montreal Forged Products Limited; Montreal Iron Works Limited; Montreal Metal-worked Products Limited; Tremblay & Boucley Enr'g.all of the city of Montreal.And, on the other part: Local No.2366 of the United Steel Workers of America of the city of Montreal, for the employers and the employees of the industry and the trades concerned, according to the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of May 10, 1958; Whereas the provisions of the said agreement have acquired a preponderant significance and importance towards the establishing of working conditions in the industry and the trades concerned and in the territorial jurisdiction indicated in the petition; Whereas the provisions of the Act have been duly observed as regards the publication of notices; 2298 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 21 Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ladite requête soit acceptée conformément aux dispositions de la Loi de la convention collection (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements) avec, toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, édition du 10 mai 1958; I.Juridiction: a) Juridiction industrielle: Le présent décret régit toute fabrication, transformation, opération et montage i.de métal ouvré pour fins industrielles et de construction, à l'exception des charpentes métalliques de bâtiments; ii.de constructions architecturales au moyen de métaux d'ornementation pouf fins architecturales ou utilitaires, comprenant, entre autres, les articles suivants: 1.Portes, chassis et seuils.2.Escaliers, échelles de sauvetage ou autres et coursives.3.Clôtures, barrières et balcons.4.Garde-fous, angles de bordure, charpentes et panneaux de trous et de fosses.5.Grilles, garde-fenêtres, cages et divisions.6) Juridiction professionnelle: Le décret régit les salariés travaillant dans les usines incluses dans la juridiction industrielle déterminée au paragraphe \"a\" du présent article.c) Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du présent décret comprend trois (3) zones dont la description est la suivante: Zone I: L'Ile de Montréal, l'Ile Bizard, les districts électoraux de Laval, Deux-Montagnes, Argenteuil, Soulanges, Vaudreuil, Beauharnois, Châteauguay, Laprairie, Chambly, Saint-Jean et Iberville.Zone II: Les districts électoraux de Terre-bonne, Trois-Rivières, Saint-Maurice, Cham-plain, Laviolette, Drummond, Arthabaska, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke.Zone III: Les districts électoraux de Maski-nongé, Berthier, Joliette, l'Assomption, Montcalm, Nicolet, Yamaska et Rouville.Nonobstant les dispositions du paragraphe \"a\" du présent article, le décret ne régit pas le travail de montage exécuté dans les zones U et III.IL Taux de salaires: Les taux minima de salaires pour chacune des classifications sont les suivants: Zone I Classifications: Mécanicien.Ajusteur.Forgeron.Aide (boutique ou chantier).Monteur.Taux horaires minima .$1.70 1.50 1.50 1.30 Whereas the objections set forth have been duly considered, as required by the Act; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour; That the petition be accepted in pursuance of the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments) with, however, the following new provisions to be substituted for the conditions described in the Quebec Official Gazette, issue of May 10, 1958; I.Juridiction: a) Industrial jurisdiction: This decree governs the manufacture, processing, fabrication and erection of: i.industrial and building metalwork with the exception of the structural steel framing for buildings; ii.architectural work in all metals used for ornementation, architecturally or for utilitarian purposes including, but not necessarily restricted to the following specific items in metal: 1.Doors, frames and sills; 2.Stairs, fire escapes, ladders and cat walks; 3.Railing, gates and balconies; 4.Protection guards, curb angles, hole and pit frames and covers; 5.Grilles, window guards, cages and partitions.6) Professional jurisdiction: This decree governs all employees in the shops comprised in the industrial jurisdiction determined in paragraph \"a\" of the present article.c) Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the present decree comprises three (3) zones described hereinbelow: Zone I: The Island of Montreal, Bizard Island, the electoral districts of Laval, Deux-Montagnes, Argenteuil, Soulanges, Vaudreuil, Beauharnois, Châteauguay, Laprairie, Chambly, St.John's and Iberville; Zone II: The electoral districts of Terrebonne, Trois-Rivières, St.Maurice, Champlain, Laviolette, Drummond, Arthabaska, St.Hyacinthe and Sherbrooke; Zone III: The electoral districts of Maskinon-gé, Berthier, Joliette, l'Assomption, Montcalm, Nicolet, Yamaska and Rouville; Notwithstanding the provisions of paragraph \"o\" of the present article, the decree does not govern erection work performed in Zones dz and m.II.Rates of icages: The minimum hourly rates of wages for each one of the following classifications shall be: Zone I Minimum, Classifications Hourly rates Mechanic.$1.70 Fitter.1.50 Blacksmith.1.50 Helper (shop or field).I 30 1.70 Erector.Zone II Zone II Mécanicien.Ajusteur.Forgeron.Aide.Zone III Mécanicien.Ajusteur.Forgeron.Aide, après 3 mois.Aide en probation, 1er trimestre.1.55 Mechanic.1.35 Fitter.1.35 Blacksmith.1.20 Helper.Zone III 1.40 Mechanic.-.1.30 Fitter.1.30 Blacksmith.1.15 Helper, after 3 months.1.00 Helper on probation, 1st 3 months.1.70 1.55 1.35 1.35 1.20 1.40 1.30 1*30 1.15 1.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2299 Clause conditionnelle: Les mécaniciens et les ajusteurs peuvent exécuter du travail de soudeur ou de forgeron sans avoir à se procurer un certificat de qualification dans ces métiers.Lorsqu'ils sont affectés à tel travail, ils reçoivent le taux du mécanicien ou de l'ajusteur, selon le cas.III.Durée du travail: a) La durée hebdomadaire du travail est de quarante-quatre (44) heures distribuées comme suit: Neuf (9) heures par jour du lundi au jeudi inclusivement et huit (8) heures le vendredi, entre 7.30 a.m.et 6.00 p.m.chaque jour; ou Huit (8) heures par jour du lundi au vendredi inclusivement entre 7.30 a.m.et 6.00 p.m.et quatre (4) heures le samedi entre 7.30 a.m.et midi.b) La durée hebdomadaire du travail des équipes de nuit est de quarante-quatre (44) heures distribuées comme suit: Neuf (9) heures par jour du lundi au jeudi inclusivement et huit (8) heures le vendredi, entre 6.00 p.m.et 6.00 a.m.de la journée qui suit; ou Huit (8) heures par jour du lundi au vendredi inclusivement entre 6.00 p.m.et 6.00 a.m.de la journée qui suit et quatre (4) heures entre 6.00 p.m.et minuit le samedi.IV.Travail supplémentaire: a) Le travail exécuté en plus des heures régulières ou en dehors des limites spécifiées à l'article III est considéré comme travail supplémentaire.6) Le travail supplémentaire doit être payé au taux de temps et demi.c) I>e travail exécuté le Premier de l'An, le Vendredi Saint, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération (1er juillet), la Fête du Travail, le jour d'Actions-de-Grâces, le jour de Noël et les dimanches doit être payé au taux de temps double.V.Équipe de nuit: Les salariés faisant partie de l'équipe de nuit doivent recevoir une prime de $0.05 rheure en plus des taux réguliers.Tout travail supplémentaire de l'équipe de nuit doit être payé sur la base de temps et demi du taux de l'équipe.VI.Jours de fêtes payés: Le Premier de l'An, le Vendredi Saint, la Confédération (1er juillet), la Fête du Travail et le jour de Noël sont des jours de fêtes payés au taux simple, pourvu qu'ils tombent un jour régulier de travail et pourvu aussi que le salarié ait été au travail le jour ouvrable qui précède et celui qui suit tels jours de fête.VIL Vacances payées: a) Dans le but d'établir des vacances payées, la période de prestations doit s'étendre sur douze (12) mois à partir du 1er mai d'une année jusqu'au 30 avril de l'année suivante.6) Un salarié qui a travaillé pour le même employeur pendant moins longtemps qu'une période complète de prestations doit avoir une demi-journée de vacances payée pour chaque mois de travail.c) Un salarié qui a travaillé pour le même employeur pendant au moins une période complète de prestations mais pendant moins que cinq a droit à une semaine de vacances payées.d) Un salarié qui a travaillé pour le même employeur pendant plus de cinq périodes de prestations doit avoir deux semaines de vacances payées.e) Les vacances sont données dans les périodes qui conviennent à l'employeur mais les salariés doivent en être avisé à l'avance.Provisio: Mechanics and fitters may execute such welding or blacksmithing work as may be necessary without obligation to possess a card of competency in such trades and, when so employed, they shall be remunerated as mechanics or fitters, as the case may be.III.Duration of labour: a) The weekly duration of labour shall be forty-four (44) hours distributed as follows: Nine (9) hours per day Monday to Thursday inclusive and eight (8) hours on Friday between 7.36 a.m.and 6.00 p.m.on each day; or Eight (8) hours per day Monday to Friday inclusive between 7.30 a.m.and 6.00 p.m.and four (4) hours between 7.30 a.m.and 12.00 noon on Saturday.b) The weekly duration of labour on night shifts shall be forty-four (44) hours distributed as follows: Nine (9) hours per day Monday to Thursday inclusive and eight (8) hours on Friday between 6.00 p.m.and 6.00 a.m.the following morning of each day; or Eight (8) hours per day Monday to Friday inclusive between 6.00 p.m.and 6.00 a.m.the following morning of each day and four (4) hours between 6.00 p.m.and 12.00 midnight Saturday.IV.Overtime trorfc: a) Work performed in excess of the regular hours or outside the limits determined in article III shall be considered as overtime work.b) Overtime work shall be paid at the rate of time and one-half.c) Work performed on New Year's Day, Good Friday, St.Jean Baptiste Day, Confederation Day (July 1), Labour Day, Thanksgiving Day, Christmas Day and Sundays shall be paid at the rate of double time.V.Night shifts: Employees working on night shifts shall be paid a premium of 5c per hour in excess of regular rates.All overtime on night shifts shall be paid on the basis of one and one-half times the shift rate.VI.Paid holidays: New Year's Day, Good Friday, Confederation Day (July 1), Labour Day and Christmas Day shall be holidays with pay at regular or single rates of pay, provided that such day falls on a regular work day, and provided further that the employee shall have been at his employment on the work day preceding and the work day following the Staturory Holiday.VII.Vacations with pay: a) For the purpose of establishing vacations with pay, the credit Seriod shall extend for twelve (12) months from lay 1st in one year to April 30th in the next year.b) An employee who has worked for the same employer for less than one full credit period shall be entitled to one-half day's vacation with pay for each month worked.c) An employee who has worked for the same employer for one credit period but less than five shall be entitled to one week's vacation with pay.d) An employee who has worked for the same employer for more than five credit periods shall be entitled to two weeks' vacation with pay.e) The vacation period will be arranged at the convenience of the employer but he will give the employees notice in advance of the time. 230Q GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 VIII.Apprentissage: a) Les apprentis-mécaniciens dans l'usine doivent recevoir le pourcentage suivant, basé sur les taux de salaires des mécaniciens: 1ère année, 1er semestre.25% 1ère année, 2ème semestre.30% 2ème année.45% 3ème année.60% 4ème année.75% b) Les apprentis-mécaniciens dans l'usine ne doivent pas commencer leur apprentissage avant d'avoir 16 ans ou après l'âge de 23 ans.Quatre (4) années constituent la période d'apprentissage, c'est-à-dire que chaque apprenti doit avoir travaillé pendant deux cent huit (208) semaines.U est permis d'avoir un (1) apprenti pour chaque groupe de sept (7) salariés travaillant dans un atelier.Si un employeur à moins de sept (7) salariés, il lui est quand même permis d'avoir un (1) apprenti.Les articles IV et V qui traitent du temps supplémentaire et des équipes de nuit s'appliquent aux apprentis.c) Au terme de sa période d'apprentissage, le Comité Paritaire détermine la catégorie à laquelle le salarié doit appartenir et un avis spécial est émis à cet effet.d) Les apprentis qui ont fréquenté une école régie par la Loi de l'Enseignement spécialisé doivent recevoir un crédit proportionné à la durée de leurs études et aux résultats de leurs examens.IX.Clauses spéciales: a) Le salarié requis de se présenter au travail a droit à une rémunération minimum équivalente à trois (3) heures de travail aux taux alors en vigueurs et ce, chaque fois qu'il est demandé lorsqu'il n'y a pas de travail à exécuter.b) L'heure normale ou avancée s'applique selon Je cas suivant l'heure alors en vigueur à l'endroit où le travail est exécuté.X.Classifications temporaires: Les salariés requis de travailler temporairement dans une classification dont le taux de salaire est inférieur à celui de leur classe habituelle doivent recevoir le taux de leur classe.XI.Travail à la pièce: Les contrats intervenus entre un employeur et un ou plusieurs salariés sur une base de travail à la pièce ou à contrat sont de nul effet et strictement défendus.XII.Paiement du salaire: Le salaire du salarié doit lui être remis dans une enveloppe scellée devant contenir les détails suivants: 1.les nom et prénom du salarié; 2.la date de la période de paie; 3.les déductions faites; 4.le montant contenu dans l'enveloppe.Si les salaires sont payés par chèque, les mêmes détails doivent être mentionnés sur le chèque ou sur un même approprié.XIII.Le présent décret abroge le décret numéro 1256 du 16 novembre 1950 et ses amendements.XIV.Durée du décret: Le présent décret est valable à compter du jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1959.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne ù l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) jours ni de moins VIII.Apprenticeship: a) Apprentice-mechanics in the shop shall receive the following percentage computed on the mechanic's rates of wages: 1st year, 1st six months.25% 1st year, 2nd six months.30% 2nd year.45% 3rd year.60% 4th year.4.75% b) Apprentice-mechanics in the shop shall not begin their apprenticeship before 16 years of age or after 23.Four (4) years shall constitute the complete apprenticeship period meaning that each apprentice must work during two hundred and eight (208) weeks.One (1) apprentice is allowed to each group of seven (7) employees in a shop.If an employer has less than seven (7) employees, he still may have one (1) apprentice.Articles IV and V concerning overtime work and night shifts shall apply to apprentices; c) On completion of his apprenticeship period, the Joint Committee shall determine in which category the employee is to be classified and a special notice shall be issued accordingly.d) Apprentices who have attended a school under the specialized Schools Act shall receive a credit in proportion to the duration of their studies and the result of their examinations.IX.Special provisions: a) An employee required to report to work shall be paid for a minimum of three (3) hours at prevailing rates, each time he is called when work is not available; b) The hours shall be Standard or Daylight Saving Time depending on which time is in force in the locality where the work is performed.X.Temporary classification: Employees required to work temporarily in a classification lower than their regular one shall be paid at the rate of their own classification.XL Piece-work: No employer shall make any arrangement whatsoever with any employee with piece-work as the basis for payment of labour performed.XII.Payment of xvages: Employee's wages shall be paid in a sealed envelope on which shall be indicated the following particulars: 1.the name and surname of the employee; 2.the date of the pay period; 3.the deductions made; 4.the amount contained in the envelope.If wages are paid by cheque the same particulars shall be given on the cheque or by other suitable memo.XIII.The present decree repeals the decree number 1256 of November 16, 1950 and its amendments.XrV.Duration of the decree: The present decree shall come into effect on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and shall remain effective until March 31, 1959.It shall be renewed automatically thereafter from year to year unless one of the contracting parties notifies the other party, in writing, to the contrary within sixty (60) days, (but not less than thirty (30) days) of the expiry of the regular QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2301 de trente (30) jours avant la date de son expiration originale ou de son renouvellement selon le cas.Un tel avis doit être également -adresse au Ministre du Travail.XV.Observance: L'observance du décret sera surveillée et assurée par le Comité Conjoint des Matériaux de Construction de Montréal.L.DÊSILETS, 48093-o Greffier du Conseil Exécutif.Avis divers term or renewal, as the case may be.Such notice shall also be sent to the Minister of Labour.XV.Administration: This decree shall be administered by the Building Materials Joint Committee of Montreal.L.DÊSILETS, 48083-o Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices (P.G.10969-57) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a, le vingt-trofe juin 1958, approuvé le règlement N° 38 de la corporation \"Hôpital La Visitation\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-cinq juin 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48063-o JEAN BRUÇHÊSI.Avis est par les présentes donné par les soussignés que le Lieutenant-gouverneur en conseil a adopté, en date du 7 mai 1958 un arrêté en conseil à l'effet de changer le nom de la municipalité du village de Bois-des-Filions en celui de \"Municipalité du village de Bois-des-Filion\", comté dè Terrebonne.Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom 'entre en vigueur à compter de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Bois-des-Filion, le 20 juin 1958.(lieu et date) Le Maire, EMILE PIGEON.Le Secrétaire-trésorier, 48071-o HENRI AUGER.(P.G.10422-56) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable secrétaire de la province a, le seize juin 1958, approuvé le règlement no I (règlements généraux) comprenant les articles I à IX inclusivement de \"Les Anciens de l'E.S.S.S.Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au buraeu du Secrétaire de la province le dix-sept juin 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48071-o JEAN BRUÇHÊSI.Avis de changement de nom (Loi des Syndicats Coopératifs de Québec) Avis est, par les présentes, donné que à une assemblée des membres de \"Longueuil Credit Union\", tenue le 5 mai 1958, le nom de ladite société a été changé en celui de \"Church of St.Clare Credit Union Limited\".Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 17e jour de juin 1958.\u2022 Le Sous-secrétaire de la province, 48075 JEAN BRUÇHÊSI.(A.G.10960-57) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has, on June twenty-third, 1958, approved by-law No.38 of the corporation \"Hôpital La Visitation\", and such, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary on June twenty-fifth, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48063 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council has adopted on May 7, 1958, an Order in Council for the purpose of changing, the name of the municipality of the village of Bois-des-Filions into that of \"Municipality of the village of Bois-des-Filion\", county of Terrebonne.Pursuant to the provisions of section 48 of the Municipal Code, this change of name will enter into effect from and after the date of the present notice in the Quebec Official Gazette.Bois-des-Filion, June 20, 1958.(Time and Place) ÊMILE PIGEON, Mayor.HENRI AUGER, 48071 Secretary-Treasurer, (A.G.10422-56) - .Notice is hereby give that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has, on June sixteenth, 1958, approved by-law No.I (general by-laws), comprising articles I to IX inclusive of \"Les Anciens de l'E.S.S.S.Inc.\", and such pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary on June seventeenth, 1958.*; JEAN BRUCHÉSI, 48072 Under Secretary of the Province.Notice of change of name (Quebec Cooperative Syndicates' Act) Notice is hereby given that, at a meeting of the members of \"Longueuil Credit Union\", held on May 5, 1958, the name of the said Society was changed to that of \"Church of St.Clare Credit Union Limited\".Given at the office of the Provincial Secretary this 17th day of June, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48075-o Undre-Secretary of the Province. 2302 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \u2022\"Syndicat Coopératif des Producteurs de Bleuets de St-Méthode\", en date du 9 juin 1958, dont le siège social est situé à Saint-Méthode, comté de Roberval, et que ce document a été déposé'dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le onze juin 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48076-o JEAN BRUCHÉSI.Val Royal Baptist Church \"Avis est, par les présentes, donné que \"Val Royal Baptist Church\", une congrégation baptis-te ayant son lieu de culte à 11905 rue (irenet, cité de Montréal, s'adressera au Lieutenant-gouverneur en conseil pour lui demander sa constitution en corporation sous le nom de \"Val Royal Baptist Church\" conformément aux dispositions du chapitre 311 S.R.Q.1941.\" Westmount, Que.23 juin 1958.Les Requérants, HUTCHESON, JOHNSTON, 48084-26-5 LAFERTÉ & TODD.(P.G.13438-56) Avis est, par les.présentes, donné que sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a, le 14 juin 1958, approuvé les règlements généraux Nos I à XIII inclusivement de \"Quebec Committee for Hungarian Relief Inc.\", tels qu'adoptés à une assemblée générale spéciale tenue le 5 octobre 1957, et ce, conformément aux dispositions des dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 17e jour de juin 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48086 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif des Producteurs de Bleuets de *St-Méthode\" under date of June 9^ 1958, whereof the head office is at Saint-Méthode, county of Roberval, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the*office of the Provincial Secretary, this eleventh day of June, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48076 Under Secretary of the Province.Val Royal Baptist Church ''Notice is hereby given that \"Val Royal Baptist Church\", a Baptist Congregation having its place of worship at 11905 Grenet Street, city of Montreal, shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for Incorporation under the name of \"Val Royal Baptist Church\" in conformity with the provisions of Chapter 311 R.S.Q.1941.\" Westmount, Que., June 23rd, 1958.HUTCHESON, JOHNSTON, LAFERTÉ & TODD, 48084-26-i-o Petitioners.(A.G.13438-56) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the General by-laws Nos.I to XIII inclusive of \"Quebec Committee for Hungarian Relief In c\", as adopted at a Special General Meeting held on October 5, 1957, have been approved oh June 14th, 1958 by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of.section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary this 17th day of June, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48086-o Under Secretary of the Province.Télédistribution Inc.Règlement N° U Concernant le partage des biens de la compagnie.Attendu que la compagnie a complètement cessé ses activités, sauf pour fins de liquidation, attendu qu'il a été pourvu au paiement de toutes les dettes que la compagnie a ou peut avoir, attendu que la compagnie est encore propriétaire de certains actifs après avoir ainsi payé tout ce qu'elle devait ou pouvait devoir, il est résolu: Que les actifs de la compagnie soient partagés ainsi qu'il 'suit: Messieurs Robert Henry et Marcel Létourneau se partageront en parts égales les actifs suivants: Mât d'entenne: $2,625.00 Poste de commande: $1,080.00 Équipement électronique Poste de commande: $2,250.00 Matériel et outillage: $240.00 ces chiffres étant tels qu'ils apparaissent au bilan présenté par M.Gilles D.Dallaire, C.A., vérificateur de la compagnie, en date du 28 septembre 1957; ceci étant tous les actifs réalisables de la compagnie, après que son passif a été éteint.Tous les actionnaires étant présents conviennent d'accepter ce partage et de renoncer chacun télédistribution INC.By-Law No.£ Concerning distribution of company assets Whereas the company has completely discontinued its activities, save for purposes of liquidation, whereas the company has provided for any debts it has or may have, whereas the company is still proprietor of certain assets after having thus paid all that it owed or may owe, it is resolved: That the assets of the company be distributed as follows: Messrs.Robert Henry and Marcel Létourneau shall share equally the following assets: Antenna pole: $2,625.00 Control Station: $1,080.00 Electronic equipment Control Station: $2,250.00 Material and equipment: $240.00 these figures being as they appear on the balance-sheet as presented by Mr.Gilles D.Dallaire, C.A., assessor for the company, dated September 28, 19*; these being all the realizable assets of the company, after elimination of the passive.All shareholders being present agree to accept this distribution and each one renounces his QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2303 pour leur part à toute réclamation qu'ils ont ou pourraient avoir contre la compagnie pour quelque raison que ce soit concernant la mise de fonds, le travail ou autres services qui auraient pu être rendus à la compagnie ou pour mise de fonds de quelque nature que ce soit.Copie certifiée du règlement numéro 4 de la compagnie adopté par les directeurs et les actionnaires de la compagnie \"Télédistribution Inc.\" le 13ème jour de juin 1958.(Sceau) Le Secrétaire, 48091-o M.LÉTOURNEAU.(P.G.10826-58) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a, le vingt-trois juin 1958, approuvé les règlements généraux de la corporation \"Comité Général de l'Année Samuel de Champlain\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-cinq juin 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48094-o JEAN BRUCHÉSI.Chartes \u2014 Abandon de Les Boiseries de Québec Ltée \"Les Boiseries de Québec Ltée\" donne avis par les présentes qu'elle présentera une requête conformément à la Loi des Compagnies de Québec afin que l'abandon de sa charte soit acceptée par le Procureur Général de la Province de Québec, qu'il en ordonne l'annulation et qu'il fixe une date à compter de laquelle la Compagnie sera dissoute.Québec, le 16 avril 1958.Le Président, BERTRAND LANGLOIS.Le Secrétaire-trésorier, 48073-o L.N.PAUL.AVIS Delta Investments Ltd.En vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, \"Delta Investments Ltd.\" donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera au Lieutenant-gouverneur de la province de Québec polir lui demander d'accepter l'abandon de sa charte et son annulation à compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Montréal, 24 juin 1958.Le Secrétaire, 48087 .JEAN McFARLANE.AVIS Stonemount Investment Corp.En vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, \"Stonemount Investments Corp.\", donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera au Lieutenant-gouverneur de la Îirovince de Québec pour lui demander d'accepter 'abandon de sa charte et son annulation à compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Montréal, 24 juin 1958.Le Secretaire, 48088 JEAN McFARLANE.share to any claim they had or may have had against the company for any reason whatsoever concerning the funds, the work or other services which may have been rendered to the company or for the outlay of funds of whatsoever nature it may be.Certified copy of by-law number 4 of the company adopted by the directors and shareholders of the company \"Télédistribution Inc.\" on* the 13th day of June, 1958.(Seal) M.LÉTOURNEAU, 48091 Secretary.(A.G.10826-58) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General the Honourable the Provincial Secretary has, on June twenty-third, 1958, approved and general by-laws of the corporation \"Comité Général de l'Année Samuel de Champlain\", and such pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act.Given at the office of the Provincial Secretary on June twenty-fifth, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48094 Under Secretary of the Province.Charters \u2014 Surrender of Les Boiseries de Québec Ltéb \"Les Boiseries de Québec Ltée\" hereby gives notice that it will make application under The Quebec Companies' Act asking that the surrender of its Charter be accepted by the Attoreny General of the Province of Quebec, that its cancellation be directed and that a date be fixed upon and from which the Company shall be dissolved.Quebec, April 16th, 1958.BERTRAND LANGLOIS, Président, L.N.PAUL, 48073-o Secretary-Treasurer.NOTICE Delta Investments Ltd.Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"Delta Investments Ltd.\", hereby gives notice that it will make application to the Lieutenant-Governor for acceptance of the surrender of its charter and its cancellation on and from a date to be fixed by him.Montreal, June 24th, 1958.JEAN McFARLANE, 48087-o Secretary.NOTICE Stonemount Investment Corp.Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"Stonemount Investment Corp.\", hereby gives notice that it will make application to the Lieutenant-Governor for acceptance of the surrender of its charter and its cancellation on and from a date to be fixed by him.Montreal, June 24th, 1958.JEAN McFARLANE, 48088-o Secretary. 2304 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juinWôà, Txme 90, N° 26 Département de l'Instruction Publique Department of Education N° 1282-57.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Bonsecours, dans le comté de Shefford, les lots 952 à 958 inclusivement et le lot 1050 du cadastre officiel du canton de Stukely, pour' les annexer à la municipalité scolaire du village de Lawrenceville, même comté.Québec, le 16 juin 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48032-25^-0 O.J.DÉSAULNIKRS.N° 222-57.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Sacré-Cœur-de-Jésus paroisse, dans le comté de Beauce, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire de: Sacré-Cœur-de-Jésus village, dans le même comté.Ce territoire comprend les lots suivants, tous inclusivement du cadastre officiel de Sacré-Cœur-de-Jésus paroisse, dans le canton Broughton, savoir: 14-A, 14-B, 14-C, 14-D, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 15-E, 15-F, 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1, 18-A; 18-B, 18-C, 18-D, 19-A du cadastre officiel du rang IV du canton de Broughton, comté de Beauce, et les lots 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 17-A, 17-E, 17-F, 17-B, 17-C, 17-D, 18-A, 18-B, 18-C, 18-D, les 13 arpents nord-est des lots 19-A, 19-B du cadastre du rang V du canton de Broughton, comté de Beauce.Québec le 17 juin 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48053-25-2-o O.J.DESAULNIERS.No.1282-57.Application is made to detach from the school municipality of Bonsecours, in the county of Shefford, lots 952 to 958 inclusive and lot 1050 of the official cadaster of the township of Stuke-ley, to annex them to the school municipality of the village of Lawrenceville, same county Quebec, June 16, 1958.O.J.DESAULNIERS, 48032-25-2 Sueprintendent of Education.No.222-57.Application is made to detach from the school municipality of Sacré-Cœur-de-Jésus, parish, in the county of Beauce, the territory herebelow described, to annex it to the school municipality of Sacré-Cœur-de-Jésus village, in the same county.This territory is comprised of the following lots, all inclusive in the official cadaster of the parish of Sacré-Cœur-de-Jésus, in the township of Broughton, to wit: 14-A, 14-B, 14-C, 14-D, Î5-A, 15-B, 15-C, 15-D, 15-E, 15-F, 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, I7-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1, 18-A, 18-B, 18-C, 18-D, 19-A of the official cadaster of range IV of the township of Broughton, county of Beauce, and lots 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 17-A, 17-E, 17-F, 17-B, 17-C, 17-D, 18-A, 18-B, 18-C, 18-D, the 13 arpents northeast of lots 19-A, 19-B, of the cadaster of range V of the township of Broughton, county of Beauce.Quebec, June 17, 1958.O.J.DESAULNIERS, 48053-25-2 Superintendent of Education.N° 397-58.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 11 juin 1958, de détacher de la municipalité scolaire de Mars-ton, dans le comté de Frontenac, les lots 25, 26, 27 et 28 des rangs VII et VIII du.canton de Marston, pour les annexer à la municipalité scolaire de Nantes, même comté.Ce changement prendra effet au ler-juillet 1958.Québec, le 18 juin 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48077-o O.J.DESAULNIERS.N° 1114-57.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 11 juin 1958, d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de la paroisse de l'Assomption à celui de la municipalité scolaire de la Ville de l'Assomption, même comté.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1958.Québec, le 19 juin 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48077-o O.J.DESAULNIERS.No.397-58.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated June 11, 1958, has been pleased to detach from the school municipality of Marston, in the county of Frontenac, lots 25, 26, 27 and 28 in ranges VH and VIII of the township of Marston, to annex them to the school municipality of Nantes, same county.This change will take effect on July 1st, 1958.Quebec, June 18, 1958.O.J.DESAULNIERS, 48077 Superintendent of Education.No.1114-57.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated June 11, 1958, has been pleased to annex the present territory of the school municipality of the parish of l'Assomption to that of the school municipality of the town of l'Assomption, same county.This change will take effect on July 1st, 1958.Quebec, June 19, 1958.O.J.DESAULNIERS, 48077 Superintendent of Education.N° 455-56.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Odile-sur-Rimouski, dans le comté de Rimouski, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer à la municipalité scolaire de la Ville de Rimouski, même comté.Un territoire situé dans la seigneurie de Rimouski, comprenant en référence au cadastre officiel de la paroisse de St-Germain-de-Rimous- No.455-56.Application is made to detach from the school municipality of St-Odile-sur-Rimouski, in the county of Rimouski, the territory herebelow described to annex it to the school municipality of the town of Rimouski, same county.A territory situated in the Seigniory of Rimouski, comprising, with reference to the official cadaster of the parish of St-Germain-de-Ri- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2305 ki, tous les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et à venir ainsi que les chemins, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: Partant au 2e rang nord-ouest, à la rivière Rimouski et englobant les lots 220 à 226, étant des îlots situés dans cette rivière; ensuite longeant la ligne separative entre les lots 218 et 219 jusqu'au 3e rang; de là en direction sud-ouest suivant la ligne separative entre les rangs 2 et 3 étant une ligne brisée, jusqu'à la ligne separative des lots 272, 273, 275; de là en direction nord-ouest, dans, la ligne separative des lots 273, 275-276 jusqu'à la rivière Rimouski; de là en direction nord longeant la rivière Rimouski, avec la rivière elle-même jusqu'au point de départ.Le tout étant l'arrondissement N° I de la municipalité scolaire de St-Odile-sur-Rimouski.Québec, le 20 juin 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique.48078-26-2-o O.J.DÉSAULNJERS.N° 360-58.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Anicet \"C\", dans le comté d'Huntingdon, les lots 790 à 813 inclusivement pour les annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Ste-Barbe, même comté.\u2022 Québec, le 18 juin 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 48079-26-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 1363-57.ERRATUM \"Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Robertson & Pope, dans le comté 8e Labelle, le territoire ci-dessous décrit Esur l'annexer à la municipalité scolaire de Mont-aurier, dans le même comté, savoir: Duns le canton Robertson, les lots 13 à 18 inclusivement du rang II; 13 à 42 inclusivement du rang III, 16 à 41 inclusivement et 50 à 59 inclusivement du rang IV; 15 à 59 inclusivement du rang V; 15 à 37 inclusivement du rang VI et les ties Nos 20 à 24 inclusivement, situées dans le Lac des Iles.Dans le canton Pope, les lots 1 à 24 inclusivement du rang U; 7 à 24 inclusivement du rang LU; 7 à 27 inclusivement du rang TV et 1 à 16 inclusivement du rang V\".Québec, le 23 juin 1958.Le Surintendent de l'Instruction publique, 48085-o O.J.DESAULNIERS.mouski, all lots or parts of lots and their present and future subdivisions, as well as the roads, water-courses or part of same enclosed within the following limits, to wit: Starting at the 2nd range, northwest, at the Rimouski River and encircling lots 220 to 226, being small islands situated in this river; thence, along the dividing line between lots 218 and 219 as far as the 3rd range; in a southwesterly direction following the dividing line between ranges 2 and 3 being a broken line, as far as the dividing line of lots 272, 273, 275; thence, in a northwesterly direction, in the dividing line of lots 273, 275-276 as far as the Rimouski River; thence, in a northerly direction bordering the Rimouski River, with the River itself, to the starting point.The whole being district No.I of the school municipality of St-Odile-sur-Rimouski.Quebec, June 20, 1958.O.J.DESAULNIERS, 48078-26-2 Superintendent of Education.No.360-58.Application is made to detach from the school municipality of St-Anicet \"C\", in the Huntingdon, lots 790 to 813 inclusive, to annex them, for the Catholic ratepayers only, to the school municipality of Ste-Barbe, same county.Quebec, June 18, 1958.O.J.DESAULNIERS, 48079-26-2 Superintendent of Education.No.1363-57.ERRATUM \"Application is made to detach from the school municipality of Robertson & Pope, in the county of Labelle, the territory hereiminder described to annex it to the school municipality of Mont-Laurier, in the.same county, to wit: In the Robertson township, lots 13 to 18 inclusive of range II; 13 to 42 inclusive of range HI; to 16 to 41 inclusive and 50 to 59 inclusive of range IV; 15 to 59 inclusive of range V; 15 to 37 inclusive of range VI and the islands Nos.20 to 24 inclusive, situated in the \"Lac des Iles\".In the Pope township, lots 1 to 24 inclusive of range II; 7 to 24 inclusive of range HI; 7 to 27 inclusive of range IV and 1 to 16 inclusive of range V\".Quebec, June 23, 1958.O.J.DESAULNIERS, 48085 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel du canton de Stanbridge division d'enregistrement de Missisquoi Avis est par la présente donné que les lots 1599 à 1604, 1617 à 1629, 1634 à 1639, 1643 à 1650, 1653 à 1656,1658 à 1661,1671 à 1673 et une partie des lots 1598, 1605, 1616 (rue), 1630 à 1633, 1640 à 1642, 1651, 1652, 1657 (rue, 1662, 1674 à 1677 sont annulés et les lots 3150 à 3155 sont ajoutés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 13 juin 1958.Le Département des Terres et Forêts, -Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 48064-o AVILA BÉDARD.NOTICE Officiai Cadastre of township of Stanbridge registration division of Missisquoi Notice is hereby given that lots 1599 to 1604, 1617 to 1629, 1634 to 1639, 1643 to 1650, 1653 to 1656, 1658 to 1661, 1671 to 1673 and part of lots 1598, 1605, 1616 (Street), 1630 to 1633, 1640 to 1642,1651,1652,1657 (Street), 1662,1674 to 1677 are cancelled and lots 3150 to 5155 are added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, June 13, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 48064-o ' Deputy-Minister. 2306 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28.juin 1958, Tome90, N° 26 .Cadastre officiel de la paroisse de St-Stanislas Officiai cadastre of the parish of St-Stanislas de de Kostka, division d'enregistrement de Beau- Kostka registration division of Beauharnois harneis Avis est par la présente donné que les lots 1-7-9 à 1-7-14 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 10 juin 195S.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre.48064-o AVTLA BÉDARD.Notice is hereby given that lots 1-7-9 to 1-7-14 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, June 10, 1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD.48064-o Deputy Minister.Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foye Officiai cadastre of the parish of Ste-Foye (muni -(municipalité de cité de Ste-Foy) division d'en- cipality of city of Ste-Foy) registration division registrement de Québec of Quebec Avis est par la présente donné que le lot 20-6 est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 9 juin 1958.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 48064-o AVILA BÉDARD.Notice is liereby given that lot 20-6 has been cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, June 9.1958.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 48064-o Deputy Minister.Examen du Barreau \u2014 Bar Examination BARREAU DE BEDFORD \u2014 BAR OF BEDFORD Candidat pour l'admission à l'étude du droit Candidate for the admission to the study of Law Nom Name\t\tPrénom Surname\tAge\tResidence Residence \t\t\t19\tGranby, Que.* \t\t\t\t Sweetsburg, 18 juin 1958 \u2014 Sweetsburg, June 18th, 1958.48074-O Le Secrétaire du Barreau de Bedford, GUY GENEST, Secretary of the Bar of Bedford.Ministère des Finances Assurances Department of Finance Insurance avis dï: mission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné, par les présentes, que \"American Reciprocal Insurers\", un échange* d'assurance réciproque enregistré sous le numéro 606, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 972 qui l'autorise à compter du 1er janvier 1958 à effectuer dans la province des contrats d'assurance relatifs aux genres suivants: Incendie, et accessoirement \u2014 agitation civile, choc de véhicules, fuite d'eau, grêle, intempéries, tremblement de terre; Biens immobiliers; Biens mobiliers; Bris de glace; Bris de machine; Chute d'aéronef; Défectuosité d'extincteurs automatiques; Explosion; Ouragan; Transport intérieur; Vol.Le siège social de l'échange est situé à 2, avenue du Parc, New York, New York, Etats-Unis d'Amérique.Cet échange a nommé monsieur George E.Dow, 620, rue Cathcart, Montréal, son procureur dans la province.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 14 juin 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Surintendant des assurances.Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is liereby given that \"American Reciprocal Insurers\", a reciprocal or inter-insurance exchange registered under number 606, has obtained the license and certificate of registry number 972 authorizing it.as from the 1st of January 1958, to undertake in this Province contracts of insurance of the following classes: Fire, and supplementary thereto \u2014 civil commotion, earthquake, hail, impact by vehicles, water damage, weather; Explosion; Falling aircraft; Inland transportation; Machinery; Personal property; Plate glass; Real property; Sprinkler leakage; Theft; Windstorm.The head office of the exchange is situate at 2 Park Avenue, New York, New York, United States of America.This exchange has appointed Mr.George E.Dow, 620 Cathcart Street, Montreal, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14th of June 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-0 Superintendent of Insurance. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2307 Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que \"Affiliated Underwriters\", dont le siège social était situé à New York, New York, États-Unis d'Amérique, s'est fusionné avec d'autres échanges réciproques, autorisés à faire des affaires dans la province de Québec, pour former \"American Reciprocal Insurers\", dont le siège social est situé i New York, New York, États-Unis d'Amérique, en vertu d'un contrat de fusion intervenu entre ces échanges réciproques le 31 décembre 1957; Attendu que \"Affiliated Underwriters\" s'est conformé aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de \"Affiliated Underwriters\" sont annulés à compter du 1er janvier 1958.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 14 juin 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Surintendant des assurances.Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que \"American Exchange Underwriters\", dont le siège social était situé à New-York, New-York, États-Unis d'Amérique, s'est fusionné avec d'autres échanges réciproques, autorisés à faire des affaires dans la province de Québec, pour former \"American Reciprocal Insurers\", dont le siège social est situé à New-York, New-York, États-Unis d'Amérique, en vertu d'un contrat de fusion intervenu entre ces échanges réciproques le 31 décembre 1957; Attendu que \"American Exchange Underwriters\" s'est'conformé aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de \"American Exchange Underwriters\" sont annulés à compter du 1er janvier 1958.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 14 juin 1958.* Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 48031 -25-2-o Surintendant des assurances.Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que \"Fireproof-Sprinklered Underwriters\", dont le siège social était situé à New-York, New-York, États-Unis d'Amérique, s'est fusionné avec d'autres échanges réciproques, autorisés à faire des affaires dans la province de Québec, pour former \"American Reciprocal Insurers\", dont le siège social est situé à New-York, New-York, États-Unis d'Amérique, en vertu d'un contrat de fusion intervenu entre ces échanges réciproques le 31 décembre 1957; Attendu que \"Fireproof-Sprinklered Underwriters\" s'est conformé aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de \"Fireproof-Sprinklered Underwriters\" sont annulés à compterdu 1er janvier 1958.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 14 juin 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Surintendant des assurances.Notice or Cancellation op License and Registration Whereas \"Affiliated Underwriters\", whose head office was situate in New York, New York, United States of America, was merged with pther reciprocal exchanges, licensed in the Province of Quebec, to form \"American Reciprocal Insurers\", whose head office is situate in New York, New York, United States of America, according to a merger agreement entered into by these reciprocal exchanges on the 31st of December 1957; Whereas \"Affiliated Underwriters\" has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"Affiliated Underwriters\" are cancelled as from the 1st of January 1958.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14th of June 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Superintendent of Insurance.Notice of Cancellation of License and Registration Whereas \"American Exchange Underwriters\", whose head office was situate in New-York, New-York, United States of America, was merged with other reciprocal exchanges, licensed in the Province of Quebec, to form \"American Reciprocal Insurers\", whose head office is situate in New-York, New-York, United States of America, according to a merger agreement entered into by these reciprocal exchanges on the 31st of December 1958; Whereas \"American Exchange Underwriters\" has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"American Exchange Underwriters\" are cancelled as from the 1st of January 1958.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14th of June, 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 4S031-25-2-0 Superintendent of Insurance.Notice of Cancellation of License and Registration Whereas \"Fireproof-Sprinklered Underwriters\", whose head office was situate in New-York, New-York, United States of America, was merged with other reciprocal exchanges, licensed in the Province of Quebec, to form \"American Reciprocal Insurers\", whose head office is situate in New-York, New-York, United States of America, according to a merger agreement entered into by these reciprocal exchanges on the 31st of December 1957; Whereas \"Fireproof-Sprinklered Underwriters\" has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"Fireproof-Sprinklered Underwriters\" are cancelled as from the 1st of January, 1958.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14th of June, 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-0 Superintendent of Insurance. 2308 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Notice or Cancellation or License and Registration Attendu que \"Individual Underwriters\", dont le siège social était situé à New York, New-York, États-Unis d'Amérique, s'est fusionné avec d'autres échanges réciproques, autorisés à faire des affaires dans la province de Québec, pour former \"American Reciprocal Insurers\", dont le siège social est situé à New-York, New-York, États-Unis d'Amérique, en vertu d'un contrat de fusion intervenu entre ces échanges réciproques le 31 décembre 1957; Attendu que \"Individual Underwriters\" s'est conformé aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de \"Individual Underwriters\" sont annulés à compter du 1er janvier 1958.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 14 juin 1958.Pour le Ministre des finances de !a province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Surintendant des assurances.Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que \"Metropolitan Inter-Insurers\", dont le siège social était situé à New York, New York, États-Unis d'Amérique, s'est fusionné avec d'autres échanges réciproques, autorisés à faire des affaires dans la province de Québec, pour former \"American Reciprocal Insurers\", dont le siège social est situé à New York, New York, États-Unis d'Amérique, en vertu d'un contrat de fusion intervenu entre ces échanges réciproques le 31 décembre 1957; Attendu que \"Metropolitan Inter-Insurers\" s'est conformé aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de \"Metropolitan Inter-Insurers\" sont annulés à compter du 1er janvier 1958; Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 14 juin 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Surintendant des assurances.Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que \"New York Reciprocal Underwriters\", dont le siège social était situé à New-York, New York, États-Unis d'Amérique, s'est fusionné avec d'autres échanges réciproques, autorisés à faire des affaires dans la province de Québec, pour former \"American Reciprocal Insurers\", dont le siège social est situé à New York, New York, États-Unis d'Amérique, en vertu d'un contrat de fusion intervenu entre ces échanges réciproques le 31 décembre 1957; Attendu que \"New York Reciprocal Underwriters\" s'est conformé aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de \"New York Reciprocal Underwriters\" sont annulés à compter du.1er janvier 1958.Whereas \"Individual Underwriters\", whose head office was situate in New-York, New-York, United States of America, was merged with other reciprocal exchanges, licensed in the Province of Quebec, to form \"American Reciprocal Insurers\", whose head office is situate in New-York, New-York, United States of America, according to a merger agreement entered into by these reciprocal exchanges on the 31st of December 1957; Whereas \"Individual Underwriters\" has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; ( Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"Individual Underwriters\" are cancelled as from the 1st of January, 1958.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14th of June, 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-O Superintendent of Insurance.Notice or Cancellation or License and Registration Whereas \"Metropolitan Inter-Insurers\", whose head office was situate in New York, New York, United States of America, was merged with other reciprocal exchanges, licensed in the Province of Quebec, to form \"American Reciprocal Insurers\",, whose head office is situate in New York, New York, United States of America, according to a merger agreement entered into by these reciprocal exchanges on the 31st of December 1957; Whereas \"Metropolitan Inter-Insurers\" has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; ^ Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"Metropolitan Inter-Insurers\" are cancelled as from the 1st of January 1958.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14th of June 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Superintendent of Insurance.Notice or Cancellation or License and Registration Whereas \"New York.Reciprocal Underwriters\", whose head office is situate in New York, New York, United States of America, was merged with other reciprocal exchanges, licensed in the Province of Quebec, to form \"American Reciprocal Insurers\", whose head office is situate in New York, New York, United States of America, according to a merger agreement entered into by these reciprocal exchanges on the 31st of December 1957; Whereas \"New York Reciprocal Underwriters\" has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"New York Reciprocal Underwriters\" are cancelled as from the 1st of January 1958. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2309 Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 14 juin 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Surintendant des assurances.Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que \"Underwriters Exchange\", dont le siège social était situé à New York, New York, États-Unis d'Amérique, s'est fusionné avec d'autres échanges réciproques, autorisés à faire des affaires dans la province de Québec, pour former \"American Reciprocal Insurers\", dont le siège social est situé à New York, New York, États-Unis d'Amérique, en vertu d'un contrat de fusion intervenu entre ces échanges réciproques le 31 décembre 1957; Attendu que \"Underwriters Exchange\" s'est conformé aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de \"Underwriters Exchange\" sont annulés à compter du 1er janvier 1958.Donné au bureau du Service des assurances,.Ministère des finances, le 14 juin 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Surintendent des assurances.Avis d'annulation de permis et d'enregistree ent Attendu que \"La Zénith, Compagnie d'Assurance Mutuelle \u2014 Zenith Mutual Insurance Company\", dont le siège social est situé à Montréal, province de Québec, a transporté ses avoirs, privilèges et obligations à \"La ZénithrCompagnie d'Assurances Générales \u2014 The Zenith General Insurance Company\", dont le siège social est situé à Montréal, province de Québec, en vertu d'un contrat de cession intervenu entre ces deux compagnies le 2 mai 1958, et qui a pris effet le 23 juin 1958; Attendu que \"La Zénith, Compagnie d'Assurance Mutuelle \u2014 Zenith Mutual Insurance Company\" s'est conformée aux autres dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de \"La Zénith, Compagnie d'Assurance Mutuelle \u2014 Zenith Mutual Insurance Company\" ont été annulés à compter du 23 juin 1958., Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 25 juin 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 48083-26-2-o Surintendant des assurances.Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné, par les présentes, que \"La Zénith, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Zenith General Insurance Company\", constituée en corporation par lettres patentes, en conformité des dispositions des articles 2 et suivants de la Loi des assurances (chapitre 299, S.R.Q.1941) et enregistrée sous le numéro 607, a obtenu le permis et certificat d'enregistrement numéro 1402 qui l'autorise à compter du 23 juin 1958, à effectuer dans la province des contrats d'assurance relatifs .Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14th of June 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Superintendent of Insurance.Notice of Cancellation of License and Registration Whereas \"Underwriters Exchange\", whose head office was situate in New York, New York, United States of America, was merged with other reciprocal exchanges, licensed in the Province of Quebec, to form \"American Reciprocal Insurers\", whose head office is situate in New York, New-York, United States of America, according to a merger agreement entered into by these reciprocal exchanges on the 31st ofDecember 1957; Whereas \"Underwriters Exchange\" has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"Underwriters Exchange\" are cancelled as from the 1st of January 1958.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14th day of June 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 48031-25-2-o Superintendent of Insurance.Notice lf Cancellation lf Licence and Registration Whereas \"Zenith Mutual Insurance Company \u2014 La Zénith, Compagnie d'Assurance Mutuelle\", whose head office is situate in Montreal, Province of Quebec, has transferred its assets, privileges and liabilities to \"The Zenith General Insurance Company \u2014 La Zénith, Compagnie d'Assurances Générales\", whose head office is situated in Montreal, Province of Quebec, according to a cession agreement entered into by these two compagnies on the 2nd of May 1958, and which has taken effect on the 23rd of June 1958; Wrhereas \"Zenith Mutual Insurance Company \u2014 La Zénith, Compagnie d'Assurance Mutuelle\" has otherwise complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is liereby given that the license and certificate of registration of \"Zenith Mutual Insurance Company \u2014 La Zénith.Compagnie d'Assurance Mutuelle\" have been cancelled as from the 23rd of June 1958.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 25th of June 1958.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 48083-26-2-o Superintendent of Insurance.Notice of Issue of Licence and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"The Zenith General Insurance Company \u2014La Zénith, Compagnie d'Assurances Générales\", incorporated by letters patent, pursuant to the provisions of section 2 and following of the Quebec Insurance Act (chapter 299, R.S.Q.1941) and regitsered under number 607, has obtained the license and certificate of registration number 1402 authorizing it, as from the 23rd of June 1958, to undertake in the Province contracts of insurance of the 2310 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 aux genres suivants: Automobile et accessoirement \u2014 accident; Bris de glace; responsabilité de garagiste sauf la responsabilité patronale; Vol.Le siège social de la compagnie est situé' à 7889 boulevard St-Laurent, Montréal, province de Québec.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 23 juin 1958.Pour le Ministre des finances de la province, GEORGES LAFRANCE, 48083-26-2-o Surintendnat des assurances.following classes: Automobile and supplementary thereto \u2014 accident; Garage liability excluding employers' liability; Plate glass; Theft.- The head office of the company is situate at 7889 St.Laurent boulevard, Montreal, Province of Quebec.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 23rd of June 1958.' For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 48083-26-2-o Superintendent of Insurance.Nominations Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, et par commission, de faire la nomination suivante: Québec, le 19 février 1958.M.Antoine Lévesque, cultivateur, de Sainte-Anne-do-la-Poati ère: commissaire pour tenir la Cour des commissaires de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dans le district électroral de Kamou-raska, et pour agir comme tel avec MM.Joseph Timmons, Louis-Philippe Anctil et Arthur Si-rois, nommés antérieurement.48063-o Avis est donné qu'il a plu au Lieutenant-gouverneur en Conseil de nommer, par arrêté en conseil numéro 424, en date du 1er mai 1958, M.Antonio Lamer, avocat, membre du Barreau de la province, et pratiquant comme tel dans la cité de Montréal, conseil en loi de la Reine.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-trois juin 1958.Le Sous-secrétaire de la province, 48063-o JEAN BRUCHÉSI.Appointments His Honour, the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, of make the following appointments: Quebec, February 19, 1958.> Mr.Antoine Lévesque, farmer, of Sainte-Anne-de-la-Pocatière: Commissioners to hold the Commissioners' Court of Sainte-Anne-de-la-Pocatière, in the electoral district of Kamouraska, and to carry on as such with Messrs.Joseph Timmons, Louis-Philippe Anctil and Arthur Sirois, previously appointed.48063 Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased by Order in Council number 424 dated May 1st.1958, to appoint Mr.Antonio Lamer, advocate, member of the Quebec Bar, and 'practising as such in the city of Montreal, Queen's Counsel.Given at the office of the Provincial Secretary on June twenty-third, 1958.JEAN BRUCHÉSI, 48063 Under Secretary of the Province.Sièges sociaux Panzini Ltée \u2014 Ltd Avis est donné que la compagnie \"Panzini Ltée \u2014 Ltd\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 mai 1958 et ayant son bureau principal à Montréal, district de Montréal, a établi son bureau au numéro 2515 Ave Map le wood.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Montréal, ce llième jour de juin 1958.Le Président, 48065-o HENRI WALTER PANZINI.Head Offices Panzini Ltée \u2014 Ltd Notice is hereby given that \"Panzini Ltée \u2014 Ltd\", a company incorporated by letters patent on May 20th, 1958, and having its head office in Montreal, district of Montreal, has established its office at 2515 Maplewood Ave.From and after the date of this notice, the said office shall he considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 11th day of June 1958.HENRI WALTER PANZINI, 48065-o President.Rapoport Investment Corp.i Cette compagnie a été constituée en corporation par lettres patentes émises par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec en date du 15 janvier 1958 et elle a établi son siège social à 9220 Boulevard St-Laurent, en les cité et district de Montréal, Québec.Montréal, 15 janvier 1958.^ Le Secrétaire, 48070 LÉO RAPOPORT.Rapoport Investment Corp.This company was incorporated by letters patent issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec on January 15, 1958, and has established its head office at 9220 St.Lawrence Boulevard, in the city and district of Montreal, Quebec.Montreal, January 15, 1958.LÉO RAPOPORT, 48070-o Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 .2311 Natural Gas Heating Installation Co.Ltd La Cie d'Installation de Chauffage au Gaz Naturel Ltée Avis -est donné que la compagnie \"Natural Gas Heating Installation Co.Ltd \u2014 La Cie d'Installation de Chauffage au Gaz Naturel Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 14 mai 1958 et ayant son bureau principal à Montréal, district de Montréal, a établi son bureau au numéro 10869 boulevard Lajeunes.se.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Montréal, ce 12ième jour de juin 1958.Le Président, 48066-o MICHEL D'AMBROSIO.Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Dans l'affaire de: St.Leonard Shopping ('entre Ltd.Centre d'Achat St.Leonard Ltée Avis de situation du siège social Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"St.Leonard Shopping Centre Ltd.\u2014 Centre d'Achat St.Leonard Ltée\" constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ec, le 2e jour de mai 1958, et ayant son siège social en la cité de Montréal, en ladite province de Quél>ec, a établi son siège social à 735 rue William, cité de Montréal, province de Québec.A compter de la date de cet avis ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté en la cité de Montréal, ce 12e jour de mai 1958.Le Secrétaire, 48067 HEDI C.FUERST.AVIS Avis est donné que la compagnie \"Gem Industries Ltd.\", constituée en'corporation par lettres patentes émises en vertu de la première partie de la Loi des compagnies en date du 17 avril 1958, ayant son principal bureau dans la cité de Granby, district de Bedford, établit son bureau-chef à Granby, susdit.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Granby, ce 12ièmc jour de juin 1958.Gem Industries Ltd., Le Président, 48068-o J.J.PICOT.J.L.Bizier Inc.Avis est donné que la compagnie \"J.L.Bizier Inc.\" constituée en corporation par lettres patentes émises en date du 19 février 1958, et ayant son siège social dans la cité de Québec, a établi son bureau au N° 146 avenue Belvédère, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Québec, P.Q., ce 1er mai 1958.(Seau) Le Président, 48069-o J.L.BIZIER.Natural Gas Heating Installation Co.Ltd La Cie d'Installation de .Chauffage au Gaz Naturel Ltée Notice is hereby given that \"Natural Gas Heating Installation Co.Ltd \u2014 La Cie d'Installation de Chauffage au Gaz Naturel Ltée\", company incorporated by letters patent on May 14th, 1958 and having its head office in Montreal, district of Montreal, has established its office at 10869 La jeunesse Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 12th day of June 1958.MICHEL D'AMBROSIO, 48066-o President.Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal In the matter of : St.Leonard Shopping Centre Ltd.Centre d'Achat St.Leonard Ltée Notice of location of head office Notice is hereby given that \"St.Leonard Shopping Centre Ltd.\u2014 Centre d'Achat St.Leonard Ltée\", incorporated under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act on the 2nd day of May, 1958, and having its head office in the city of Montreal, in the said Province, has established its office at 735 William Street, City of Montreal, Province of Queliec.\u2022 From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the comi>any.Dated at the city of Montreal, this 12th day of May, 1958.HEDI C.FUERST, 48067-o Secretary.NOTICE Notice is hereby given that \"(Jem Industries Ltd.\", compagny incorporated by letters patent issued on the part of the Qucl>ec Company's Act on the 17th day of April, 1958.and having its head office in the city of Granby, district of Bedford, has established its office at Granby.From and after the date of this notice, the said office be considered by the company as head office of the company.Dated at Granby, this 12th day of June, 1958.Gem Industries Ltd.J.J.PICOT, 48068-o President.J.L.Bizier Inc.Notice is hereby given that the company \"J.L.Bizier Inc.\", incorporated by letters patent issued on February 19.1958.and having its head office in the city of Quebec, has established its office at No.146 Belvedere Road, Quebec.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Queliec, P.Q., this first day of May, 1958.(Seal) « J.L.BIZIER, 48069 President. 2312 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 West Disinfecting Co.Ltd.Avis est donné que la compagnie \"West Disinfecting Co.Ltd.\" constituée en corporation par lettres patentes en date du 1er jour de décembre, 1945 et ayant son bureau principal à Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui à 2000 Aldred Building l'a transporté à 300 The Canada Building, 455 rue Craig Ouest.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 4ème jour d'avril 1958.Le Président, 48089-o M.M.MARCUSE.Natural Gas Units Distributors Co.Ltd La Cie de Distribution d'Unités de Gaz Naturel Ltée Avis est donné que la compagnie \"Natural Gas Units Distributors.Co.Ltd \u2014 La Cie de Distribution d'Unités de Gaz Naturel Ltée\", constituée en corporation par lettres patentes en date'du 14 mai 1958 et ayant son bureau principal à Montréal, district de Montréal, a établi son bureau au N\" 10869 Boulevard La jeunesse- A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Montréal; ce 20ième jour de juin 1958.Le Président, 48090-o MICHEL D'AMBROSIO.West Disinfecting Co.Ltd.Notice is hereby given that \"West Disinfecting Co.Ltd.\" incorporated by letters patent on the first day of December, 1945, and having its head office in Montreal where its office was heretofore situated at 2000 Aldred Building, has moved it to 300 The Canada Building, 455 Craig Street West.From and after the date of this notice the said offices shall be considered by the company as being its head office.Dated at Montreal, this 4th day of April, 1958.M.M.MARCUSE, 48089-o President.Natural Gas Units Distributors Co.Ltd La Cie de Distribution d'Unités de Gaz Naturel Ltée Notice is hereby given that \"Natural Gas Units Distributors Co.Ltd \u2014 La Cie de Distribution d'Unités de Gaz Naturel Ltée\", company incorporated by letters patent on May 14th, 1958 and having its head office in Montreal, district of Montreal, has established its office at 10869 Lajeunesse Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office to the company.Dated at Montreal, this 20th day of June 1958.MICHEL D'AMBROSIO, 48090-o President.Soumissions Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville BrOMPTONVILLE (Comté ce Richmond) Tenders _ Province of Quebec The school commissioners for the municipality OF THE TOWN OF BrOMPTONVILLE (County of Richmond) Avis public est par les présentes donné que Public notice is hereby given that sealed des soumissions cachetées et endossées \"Soumis- tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be sions pour obligations\" seront reçues par le received by the undersigned Aimé Benoit, soussigné, Aimé Benoit, secrétaire-trésorier, Hô- Secretary-Treasurer, Town Hall, 88 Laval St., tel de Ville, 88 rue Laval, Bromptonville, comté Bromptonville, county of Richmond, until 8.00 de Richmond, jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, o'clock p.m.Monday, July 14, 1958, for the le 14 juillet 1958, pour l'achat de $350,000.00 purchase of an issue of $350,000.00 of bonds of d'obligations des commissaires d'écoles pour la the school commissioners for the municipality municipalité de la ville de Bromptonville, comté of the town of Bromptonville, county of Rich-de Richmond, datées du 1er juin 1958 et rem- mond, dated June 1st, 1958, and redeemable boursables par séries du 1er juin 1959 au 1er serially from June 1st, 1959 to June 1st, 1978 juin 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux inclusively, with interest at a rate not less than non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, 4% nor more than 5% per annum, payable semi-payable semi-annuellement les 1er juin et 1er annually on June 1st and December 1st of each décembre de chaque année.Le- taux d'intérêt year.The rate of interest may be the same for peut être le même pour toute l'émission ou il the whole issue or it may vary according to peut varier suivant les échéances.maturities.Résolution d'emprunt en date du 14 mai Loan resolution dated May 14, 1958 \u2014 recon-1958 \u2014 reconstruction de l'école des garçons.struction of the boys' school.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul For purposes of adjudication only, interest d'intérêt sera fait à compter du 1er août 1958.shall be calculated as from August 1st, 1958 only.Le tableau d'amortissement est le suivant: The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 9350,000.00 \u2014 20 ans Table of redemption \u2014 $350,000.00 \u2014 20 years Année Capital ' Year Capital 1er juin 1959.x $39,500.00 June 1st, 1959.x.$39,500.00 1er juin 1960.x' 41,500.00 June 1st, 1960.x 41,500.00 1er juin 1961.x 43,500.00 June 1st, 1961.x 43,500.00 1er juin 1962.x 45,500.00 June 1st, 1962.x 45,500.00 1er juin 1963.x 48,000.00 June 1st, 1963.x 48,000.00 1er juin 1964 .6,000.00 June 1st, 1964.6,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2313 1er juin 1965.6,500.00 1er juin 1966.7,000.00 1er juin 1967 .7,000.00 1er juin 1968.7,500.00 1er juin 1969.8,000.00 1er juin 1970.8,000.00 1er juin 1971.8,500.00 1er juin 1972 .9,000.00 1er juin 1973.9,500.00 1er juin 1974.10,000.00 1er juin 1975.10,500.00 1er juin 1976.11,000.00 1er juin 1977.11,500.00 1er juin 1978.12,000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $220,-082.25, accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $44,016.45 chacun, de 1959 à 1963 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à 49 rue Wellington, Sherbrooke.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juin 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert com- (>rend ou ne comprend pas les intérêts courus sur es obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 14 juillet 1958, a 8.00 heures du soir, en l'Hôtel de Ville, 88 rue Laval, Bromptonville, comté de Richmond.' Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Bromptonville, (Comté de Richmond), ce 23 juin 1958.Le Secrétaire-trésorier, AIMÉ BENOIT.Adresse postale: C.P.69.Hôtel de Ville, 88 rue Laval, Bromptonville, (Comté de Richmond), P.Q.Téléphone: Victor 6-2726.48095-o June 1st, 1965.6,500.00 June 1st, 1966.7,000.00 June 1st, 1967.7,000.00 June 1st, 1968.7,500.00 June 1st, 1969.8,000.00 June 1st, 1970.8,000.00 June 1st, 1971.8,500.00 June 1st, 1972.9,000.00 June 1st, 1973.9,500.00 June 1st, 1974.10,000.00 June 1st, 1975.10,500.00 June 1st, 1976.11,000.00 June 1st, 1977.11,500.00 June 1st, 1978.12,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $220,082.-25, granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of $44,016.45 each, from 1959 to 1963 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at 49 Wellington St., Sherbrooke.Capital and interest arc payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure as well as the head office of the said bank at Toronto.The said bonds shall not be redeemable by anticipation before June 1st, 1968 inclusive; after this date, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Monday, July 14, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the Town Hall, 88 Laval St., Bromptonville, county of Richmond.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Bromptonville, (County of Richmond), June 23, 1958.AIMÉ BENOIT, Secretary-Treasurer.Postal address: P.O.C.69, Town HakV88 Laval St., Bromptonville, (County of Richmond), P.Q.Telephone: Victor 6-2726.48095 Province de Québec Ville de La Sarre (Comté d'Abitibi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Me Jules Lavigne, N.P., secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, La Sarre, comté d'Abitibi, jusqu'à 8.00-ïieures du soir, mardi, le 15 juillet 1958, pour l'achat de $125,000.00 d'obligations de la ville de La Sarre, comté d'Abitibi, datées du 1er juillet 1958 et remboursables par séries du 1er juillet 1959 au 1er juillet 1978 inclusive- Province of Quel>ec Town of La Sarre (County of Abitibi) Public notice is liereby \"given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Jules Lavigne, notary, Secretary-Treasurer, Town Hall, La Sarre, county of Abitibi, until 8.00 o'clock p.m., Tuesday, July 15th, 1958, for the purchase of an issue of $125,000.00 of bonds of the town of La Sarre, county of Abitibi, dated July 1st, 1958 and redeemable serially from July 1st, 1959 to July 1st, 1978 inclusively, with interest 2314 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 ment, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% pour les échéances de 1959 à T968 inclusivement, non inférieur ù 4^% pour les échéances de 1969 à 1978 inclusivement, et non supérieur à 5% pour le s *r h oui îeo s de 1959 à 1978 inclusivement, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er millet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.' Règlement d'emprunt N° 69 \u2014 travaux de voirie, trottoirs et aqueduc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er août 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: at a rate not less than 4% for the years 1959 to 1968 tnclusively, not less than 4^% for the years 1969 to 1978 inclusively, and not more than 5% for the years 1959 to 1978 inclusively, payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.69 \u2014 road works, sidewalks and waterworks.For the purposes of awarding the issue only, computation of interest will be made as from August 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 9125,000.00 \u2014 20 ans Table of redemption \u2014 $126,000.00 \u2014 20 year* Année Capital Year Capital 1er juillet 1959.$4,000.00 1er juillet 1960 .4,000.00 1er juillet 1961.4,000.00 1er juillet 1962.4,500.00 1er juillet 1963.4,500.00 1er juillet 1964.5,000.00 1er juillet 1965.5,000.00 1er juillet 1966.5,500.00 1er juillet 1967.5,500.00 1er juillet 1968 .6,000.00 1er juillet 1969 .6,000.00 .1er juillet 1970 .6,500.00 1er juillet 1971.6,500.00 1er juillet 1972 .7,000.00 1er juillet 1973 .7,500.00 1er juillet 1974.8,000.00 1er juillet 1975.8,500.00 1er juillet 1976 .8,500.00 1er juillet 1977 .9,000.00 1er juillet 1978 .9,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à La Sarre, comté d'Abitibi.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juillet 1968 inclusivement; après cette date.lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 15 juillet 1958, à'8.00 heures du soir, en l'Hôtel de Ville, La Sarre, comté d'Abitibi.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.La Sarre, (Comté d'Abitibi), ce 25 juin 1958.Le Secrétaire-trésorier, Me JULES LAVIGNE, N.P.Adresse postale: C.P.640, Hôtel de Ville, La Sarre.(Comté d'Abitibi), P.Q.Téléphone: 36.48096-o July 1st, 1959.$4,000.00 July 1st, 1960 .4,000.00 July 1st, 1961.4,000.00 July 1st, 1962 .4.500.00 July 1st.1963.4.500.00 July 1st, 1964 .5,000.00 July 1st, 1965.5,000.00 July 1st, 1966.5,500.00 July 1st, 1967.5,500.00 July 1st, 1968.6,000.00 July 1st, 1969 .6,000.00 July 1st.1970 .6,500.00 July 1st, 1971.6,500.00 July 1st, 1972.7,000.00 July 1st, 1973.7,500.00 July 1st, 1974 .8,000.00 July 1st, 1975 .8,500.00 July 1st, 1976.8,500.00 July 1st, 1977.9,000.00 July 1st, 1978 .9,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal rfhd accrued interest if any, by certified cheque payable at par at La Sarre, county of Abitibi.' Capital and interest are payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemed by anticipation before July 1st, 1968 inclusively; after the latter date, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied\" by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on July 15th, 1958, at 8.00 o'clock p.m., at the Town Hall, La Sarre, county of Abitibi.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.La Sarre, (County of Abitibi), this 25th of June, 1958.JULES LAVIGNE, Notary, Secretary-Treasurer.Postal address: P.O.Box 640, Town Hall, La Sarre, (County of Abitibi), P.Q.Telephone: 36.48096 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebed, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2315 , Province de Québec Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de mégantic (Comté de Mégantic) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-A.Ilernier, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, rue Frontenac, Lac Mégantic, comté de Frontenac, jusqu'à 7h.30 du soir, lundi, le 14 juillet 1958, pour l'achat de $410,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville de Mégantic, comté de Mégantic, datées du 15 juillet 1958 et remboursables par séries du 15 juillet 1959 au 15 juillet 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 23 mai 1958 \u2014 agrandissement de l'école des garçons.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 15 août 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $410,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 15 juillet 1959 .x$61,500.00 15 juillet 1960 .x 64,500.00 15 juillet 1961 .x 67,000.00 15 juillet 1962 .x 70,000.00 15 juillet 1963 .6,500.00 15 juillet 1964 .6,500.00 15 juillet 1965 .7,000.00 15 juillet 1966 .7,000.00 15 juillet 1967 .7,500.00 15 juillet 1968 .8,000.00 15 juillet 1969 .8,500.00 15 juillet 1970 .9,000.00 15 juillet 1971 .9,000.00 15 juillet 1972 .9,500.00 15 juillet 1973 .10,000.00 15 juillet 1974 .10,500.00 15 juillet 1975 .11,000.00 15 juillet 1976 -\u2022.11,500.00 15 juillet 1977 .12,500.00 15 juillet 1978 .13,000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $268,-125.00, accordé par le Secrétaire de la province et payable en quatre versements de $67,031.25 chacun, de 1959 à 1962 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Lac Mégantic, comté de Frontenac.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 15 juillet 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of the town of M eg antic (County of Megantic) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received, by the undersigned J.-A.Bernier, secretary-treasurer, Frontenac St., Lake Megan-tic, county of Frontenac, until 7.30 o'clock p.m.Monday, July 14, 1958, for the purchase of an issue of $410,000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of the town of Megantic, county of Megantic, dated July 15, 1958 and redeemable serially from July 15, 1959 to July 15, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semi-annually on January 15 and July 15 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated May 23, 1958 \u2014 enlargement of the boys' School.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from August 15, 1958 only.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $410,000.00 \u2014 20 years Year Capital July 15, 1959 .x$61,500.00 July 15, 1960 .x 64,500.00 July 15, 1961 .x 67,000.00 July 15, 1962 .x 70,000.00 July 15, 1963 .6,500.00 July 15, 1964 .6,500.00 July 15, 1965 .7,000.00 July 15, 1966 .7,000.00 July 15, 1967 .7,500.00 July 15, 1968 .8,000.00 July 15, 1969 .8,500.00 July 15, 1970 .9,000.00 July 15, 1971 .9,000.00 July 15, 1972 .9,500.00 July 15, 1973 .10,000.00 July 15, 1974 .10,500.00 July 15, 1975 .11,000.00 July 15, 1976 .11,500.00 July 15, 1977 .!.12,500.00 July 15, 1978 .13,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $268,125.00 granted by the Provincial Secretary and payable in four instalments of $67,031.25 each, from 1959 to 1962 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Lake Megantic, county of Frontenac.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank at Toronto.The said bonds shall not be redeemable by anticipation before July 15, 1968 .inclusive; after this date, the said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number. 2316 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N° 26 Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 14 juillet 1958 à 7 heures 30 du soir, en l'Hôtel de Ville, rue Frontenac, Lac Mégantic, comté de Frontenac.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Lac Mégantic, (Comté de Frontenac), ce 23 juin 1958.Le Secrétaire-trésorier, J.-A.BERNIKR.Adresse postale : Hôtel de Ville, C.P.40, Lac Mégantic, (Frontenac), P.Q.Téléphone: 165.48097-o Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissionres to be held on Monday, July 14, 1958 at 7.30 o'clock p.m., at the Town Hall, Frontenac St., Lake Megantic, county of Frontenac.The School Commissioners do not bind themselves to accept the hihgest or any of the tenders.Lake Megantic, (County of Frontenac), June 23, 1958.J.-A.BERNIKR, Secretary-Treasurer.' Postal address: Town Hall, P.O.B.40, Lake Megantic, (Frontenac), P.Q.Telephone: 165.48097 Province de Québec Les commissaires d'écoles pour municipalité de St-Constant (Comté de Napierville-Laprairie) la Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Romain Robidoux, secrétaire-trésorier, 183 rue St-Pierre, St-Constant, comté de Napier ville-Laprairie, jusqu'à 8.00 heures du soir, mercredi, le 16 juillet 1958 pour l'achat de $225,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Constant, comté de Napier-ville-Laprairie, datées du 1er août 1958 et remboursables par séries du 1er août 1959 au 1er août 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% ni supérieur à 5% par année, payable semi-annuellement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 16 mai 1958 \u2014 agrandissement de l'école du village.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er août 1958.Le tab cl au d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $225,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er août 1959.x$25,500.00 1er août 1960.x 26,500.00 1er août 1961.x 28,000.00 1er août 1962.x 29,500.00 1er août 1963.x 31,000.00 1er août 1964.4,000.00 1er août 1965.4,000.00 1er août 1966 .4,500.00 1er août 1967.4,500.00 1er août 1968.5,000.00 1er août 1969 .5,000.00 1er août 1970.5,000.00 1er août 1971.5,500.00 1er août 1972 .5,500.00 1er août 1973 .6,000.00 1er août 1974 .6,500.00 1er août 1975 .7,000.00 1er août 1976 .7,000.00 1er août 1977 .7,500.00 1er août 1978 .7,500.00 Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of St-Constant (County of Napierville-Laprairie) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Romain Robidoux, Secretary-Terasurer, 183 St-Peter St., St.Constant, county of Xapierville-Laprairie, until 8.00 p.m.o'clock Wednesday, July 16, 1958, for the purchase of an issue of $225,000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of St-Constant, county of Napierville-Laprairie, dated August 1st, 1958 and redeemable serially from August 1st, 1959 to August 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than 4% nor more than 5% per annum, payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated May 16, 1958 \u2014 enlargement of the village school.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from August, 1st, 1958 only.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $225,000.00 \u2014 20 years Year Capital August 1st, 1959 .x$25,500.00 August 1st, 1960 .x 26,500.00 August 1st, 1961 .x 28,000.00 August 1st, 1962 .x 29,500.00 August 1st, 1963 .x 31,000.00 August 1st, 1964 .4,000.00 August 1st, 1965 .4,000.00 August 1st, 1966 .4,500.00 August 1st, 1967 .4,500.00 August 1st, 1968 .5,000.00 August 1st, 1969 .5,000.00 August 1st, 1970 .5,000.00 \u2022 August 1st, 1971 .5,500.00 August 1st, 1972 .5,500.00 August 1st, 1973 .6,000.00 August 1st, 1974 .6,500.00 August 1st, 1975 .- 7,000.00 August 1st, 1976.7,000.00 August 1st, 1977 .7,500.00 August 1st, 1978 .7,500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles The letters \"x\" indicate the years during which les versements annuels d'un octroi total de annual payments of a total amount of $141,738.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 2317 $141,738.00 accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $28,347.60 chacun, de 1959 à 1963 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Constant, comté de Napierville-Laprairie.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt., Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er août 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations gouïront, sous l'autorité du chapitre 212 des tatuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert com- Erend ou ne comprend pas les intérêts courus sur ts obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 16 juillet 1958, à 8.00 heures du soir, en la salle de l'école du village, St-Constant, comté de Napierville-Laprairie.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumission.St-Constant, (Comté de Napierville-Laprairie), ce 23 juin 1958.Le Secrétaire-Trésorier, ROMAIN ROBIDOUX.Adresse: 183, rue St-Pierre, St-Constant, (Napierville-Laprairie), P.Q.Téléphone: OLympia 9-1547.48098-o Province de Québec Ville de Bagotville (Comté de Chicoutimi) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-E.Tremblay, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 9 rue Victoria, Bagotville, comté de Chicoutimi, jusqu'à 7.30 heures du soir, mercredi, le 16 juillet 1958, pour l'achat de $100,000.00 d'obligations de la ville de Bagotville, comté de Chicoutimi, datées du 1er août 1958 et remboursables par séries du 1er août 1959 au 1er août 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4% pour les échéances de 1959 à 1968 inclusivement, non inférieur à 4^£% pour les échéances de 1969 à 1978 inclusivement, et non supérieur à 5% pour les échéances de 1959 à 1978 inclusivement, payable se mi-annuel le ment les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 305 \u2014 travaux d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'électricité.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er août 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $100,000.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er août 1959.$3,000.00 1er août 1960.3,000.00 granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of $28,347.60, each from 1959 to 1963 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accured interest if any, by certified cheque payable at par at St.Constant, county of Napierville-Laprairie.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation before August 1, 1968 inclusive; after this date, the said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not.in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Wednesday, July 16, 1958, at 8.00 qlclock p.m., in the village school hall, St-Constant, county of Napierville-Laprairie.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St-Constant (County of Napierville-Laprairie), June 23, 1958.ROMAIN ROBIDOUX, Secretary-Treasurer.Address: 183 St.Pierre St., St-Constant, (Napierville-Laprairie), P.Q.Telephone: OLympia 9-1547.48098 Province of Quebec Town of Bagotville (County of Chicoutimi) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.-E.Tremblay, Secretary-Treasurer, Town Hall, 9 Victoria \" Street, Bagotville, county of Chicoutimi, until 7.30 o'clock p.m.Wednesday, July 16, 1958, for the purchase of an issue of $100,000.00 of bonds of the town of Bagotville, county of Chicoutimi, dated August 1st, 1958, and redeemable serially from August 1st, 1959 to August 1st, 1978 inclusively, with interest not less than 4% for the maturities from 1959 to 1968 inclusively, not less than 414% tor the maturities from 1969 to 1978 inclusively, and not more than 5% for the maturities from 1959 to 1978 inclusively, payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue ôr it may vary according to maturities.Loan by-law No.305 \u2014 work on aqueduct, sewers, roads and in electricity.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from August 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $100,000.00 \u2014 20 years Year Capital August 1st, 1959.$3,000.00 August 1st, 1960.3,000.00 2318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Québec, 28 juin 1958, Tome 90, N°- 26 1er août 1961.3,000.00 1er août 1962 .4,000.00 1er août 1963.4,000.00 1er août 1964.4,000.00 1er août 1965.4,000.00 1er août 1966 .4,000.00 1er août 1967.4,000.00 1er août 1968.5,000.00 1er août 1969.5,000.00 1er août 1970 .5,000.00 1er août 1971.5,000.00 1er août 1972 .6,000.00 1er août 1973.6,000.00 1er août 1974.6,000.00 1er août 1975 .7,000.00 1er août 1976.7,000.00 1er août 1977.7,000.00 1er août 1978 .8,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Bagotville, comté de Chicoutimi.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er août 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt;, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 16 juillet 1958, à 7.30 heures du soir, en l'Hôtel de Ville, 9 rue Victoria, Bagotville, comté de Chicoutimi.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Bagotville, (Comté de Chicoutimi), ce 25 juin 1958.Le Secrétaire-trésorier, J>E.TREMBLAY.Adresse'postale: C.P.140, Hôtel de Ville, Bagotville, (Comté de Chicoutimi), P.Q.Téléphone: 252.48099-o Province de Québec » Ville de Naudville (Comté de Lac St-Jean) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Roméo Dion, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, Naudville, comté de Lac St-Jean, jus-fiu'a 8.00 heures du soir, lundi, le 14 juillet 1958, pour l'achat de $250,000.00 d'obligations de la ville de Naudville, comté de Lac St-Jean, datées du 1er juillet 1958 et remboursables par séries du 1er juillet 1959 au 1er juillet 1978 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4-% pour les échéances de 1959 à 1968 inclusivement, non inférieur à 4^% pour.les échéances de 1969 à 1978 inclusivement, et non supérieur à 5% pour les échéances de 1959 à 1978 inclusi- August 1st, 1961.3,000.00 August 1st, 1962.4,000.00 August 1st, 1963.4,000.00 August 1st, 1964.4,000.00 August 1st, 1965.4,000.00 August 1st, 1966.4,000.00 August 1st, 1967.4,000.00 ' August 1st, 1968.5,000.00 August 1st, 1969 .5,000.00 August 1st, 1970.5,000.00 August 1st, 1971.5,000.00 August 1st, 1972.6,000.00 August 1st, 1973.6,000.00 August 1st, 1974.6,000.00 August 1st, 1975.7,000.00 August 1st, 1976.7,000.00 August 1st, 1977.7,000.00 August 1st, 1978.8,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable a*t par at Bagotville, county of Chicoutimi.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemably by anticipation before August 1st, 1968 inclusively; after this date, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday July 16, 1958 at 7.30 o'clock p.m., at the-Town Hall, 9 Victoria St., Bagotville, county of Chicoutimi.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Bagotville, (County of Chicoutimi), June 25, 1958.J.-E.TREMBLAY, Secretary-Treasurer.Postal address: P.O.B.140, Town Hall, Bagotville.(County of Chicoutimi), P.Q.Telephone: 252.48099 Province of Quebec Town op Naudville (County of Lake St-John) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will^be received by the undersigned Roméo Dion/Secretary-Treasurer, Town Hall, Naudville, county of Lake St-John, until 8.00 o'clock p.m.Monday, July 14, 1958, for the purchase for the purchase of an issue of $250,000.00 of bonds of Che town of Naudville, county of Lake St-John, dated July 1st, 1958, and redeemable serially from July 1st, 1959 to July 1st, 1978 inclusively, with interest not less than 4% for the maturities from 1959 to 1968 inclusively, not less than 4lA% for the maturities from 1969 to 1978 inclusively, and not more than 5% for the maturities from 1959 to 1978 inclusively, payable QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2319 vement, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt No.66 \u2014 travaux d'aqueduc et d'égouts, de voirie, construction de garage, trottoirs, etc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er août 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement Année $260,000.00 \u2014 20 ans Capital 1er juillet 1959.$ 7,500.00 1er juillet 1960.8,000.00 1er juillet 1961.8,500.00 1er juillet 1962 .9,000.00 1er juillet 1963./.9,000.00 1er juillet 1964.9,500.00 1er juillet 1965.10,000.00 1er juillet 1966.10,500.00 1er juillet 1967.11,000.00 1er juillet 1968.12,000.00 1er juillet 1969.12,500.00 1er juillet 1970.13,000.00 1er juillet 1971.13,500.00 1er juillet 1972.14,500.00 1er juillet 1973.15,000.00 1er juillet 1974.15,500.00 1er juillet 1975.16,500.00 1er juillet 1976.17,500.00 1er juillet 1977.18,000.00 1er juillet 1978.19,000.00 semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.66 \u2014 work on aqueduct and sewers, roads, construction of a garage, sidewalks, etc.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from August 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $250,000.00 \u2014 20 years Year Capital July 1st, 1959.$ 7,500.00 July 1st, 1960.8,000.00 July 1st, 1961.8,500.00 July 1st, 1962 .9,000.00 July 1st, 1963.9,000.00 July 1st, 1964.9,500.00 July 1st, 1965.10,000.00 July 1st, 1966.10,500.00 July 1st, 1967.11,000.00 July 1st, 1968.12,000.00 July 1st, 1969.12,500.00 July 1st, 1970.13,000.00 July 1st, 1971.13,500.00 July 1st, 1972.14,500.00 July 1st, 1973.15,000.00 \u2022 July 1st, 1974.15,500.00 ' July 1st, 1975.r.16,500.00 July 1st, 1976.17,500.00 July 1st, 1977.18,000.00 July 1st, 1978.19,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obliga- The successful tenderer agrees to pay for the tions, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par bonds, principal and accrued interest if any, by chèque visé, payable au pair à Naudville, comté certified cheque payable at par at Naudville, de Lac St-Jean.county of Lake St-Jo h ft.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er juillet 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations gourront, sous l'autorité du chapitre 212 des tut ut s refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur îes obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 14 juillet 1958, à 8.00 heures du soir, en l'Hôtel de Ville, Naudville, comté de Lac St-Jean.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Naudville, (Comté de Lac St-Jean), ce 25 juin 1958.Le Secrétaire-trésorier, ROMÉO DION.Adresse postale: Hôtel de ViUe, CP.100, NaudviUe, (Lac St-Jean), P.Q.Tél.: NOrmandie 2-5317, 48100-o Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation before July 1st, 1968 inclusively; after this date, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued oh the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, July 14, 1958 at 8.00 o'clock p.m., at the Town Hall, Naudville, county of Lake St.John.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Naudville, (County of Lake St-John), June 25, 1958.ROMÉO DION, Secretary-Treasurer.Postal address: Town Hall, P.O.B.100, Naudville, (Lake St-John) P.Q.Tel.: NOrmandie 2-5317, 48100 2320 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26 Province de Québec Paroisse de St-Joachim-de-Châteauguay (Comté de Châteauguay) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Armand Brisebois, secrétaire-trésorier, jusqu'à 7h.30 du soir,, à 27 rue Antoine, Châteauguay village (Châteauguay), ou jusqu'à 8.00 heures du soir, à la salle municipale, Châteauguay (Châteauguay), lundi, le 14 juillet 1958, pour l'achat de $120,000.00 d'obligations de la paroisse de St-Joachim-de-Châteauguay, comté de Châteauguay, datées du 1er août 1958 et remboursables par séries du 1er août 1959 au 1er août 1978 inclusivement, avec intérêt â un taux non inférieur à 4% pour les échéances de 1959 à 1968 inclusivement, non inférieur à 4^£% pour les échéances de 1969 à 1978 inclusivement, et non supérieur à 5% pour les échéances de 1959 à 1978 inclusivement, payable semi-annuellement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements d'emprunt Nos: 198: $40,000.00 \u2014 acquisition d'un puits et installation d'aqueduc; et 200: \"$80,000.00 \u2014 construction d'un égout collecteur.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er août 1958.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $120,000.00 \u2014 20 ans Annie Capital 1er août 1959.$3,000.00 1er août 1960.3,000.00 1er août 1961.3,000.00 1er août 1962.3,000.00 1er août 1963.4,000.00 1er août 1964.4,000.00 1er août 1965 .4,000.00 1er août 1966 .4,000.00 1er août 1967.5,000.00 1er août 1968 .5,000.00 1er août 1969 .5,000.00 1er août 1970 .5,000.00 1er août 1971.6,000.00 1er août 1972.6,000.00 1er août 1973.; 6,000.00 1er août 1974 .6,000.00 1er août 1975 .7,500.00 1er août 1976 .7,500.00 1er août 1977 .7,500.00 1er août 1978 .25,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts] courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Beauharnois.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans'la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.'Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er août 1968 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert com- Province of Quebec Parish of St-Joachim-de-Châteauguay (County of Châteauguay) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Armand Brisebois, Secretary-Treasurer, until 7.30 p.m.at 27 St.Antoine St., Châteauguay Village, (Châteauguay), or until 8.00 o'clock p.m.at the Municipal Hall, Châteauguay (Châteauguay), Monday, July 14, 1958, for the purchase of an issue of $120,000.00 of bonds of the parish of St-Joachim-de-Châteauguay, dated August 1st, 1958 and redeemable serially from August 1st, 1959 to August' 1st, 1978 inclusively, with interest at a rate not less than -4% for the maturities from 1959 to 1968 inclusively, not less than 4^% for the maturities from 1969 to 1978 inclusively, and not more than '5>% for the maturities from 1959 to 1978 incluse-vely, payable semi-annually onlebruary 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-laws Nos.198: $40,000.00 \u2014 acquisition of a well and installation of an aqueduct; and 200: $80,000.00 \u2014 construction of a sewer main.For purposes, of adjudication only,.interest shall be calculated as from August 1st, 1958.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $120,000.00 \u2014 20 years Year Capital August 1st, 1959 .$3,000.00 August 1st, 1960.3,000.00 August 1st, 1961 .3,000.00 August 1st, 1962 .3,000.00 August 1st, 1963 .4,000.00 August 1st, 1964 .4,000.00 August 1st, 1965 .4,000.00 August 1st, 1966 .4,000.00 August 1st, 1967 .5,000.00 August 1st, 1968 .5,000.00 August 1st, 1969 .5,000.00 August 1st, 1970 .5,000.00 August 1st, 1971 .6,000.00 * August 1st, 1972 .6,000.00 August 1st, 1973 .6,000.00 August 1st, 1974 .6,000.00 August 1st, 1975 .7,500.00 August 1st, 1976 .7,500.00 August 1st, 1977 .7,500.00 August 1st, 1978 .25,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Beauharnois.Capital and interest are payable, at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be redeemable by anticipation before August 1st, 1968, inclusively; after this date, the said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2321 f>rend ou ne comprend pas les intérêts courus sines obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 14 juillet 1958, à 8.00 heures du soir, en la salle municipale, Châteauguay, comté de Châteauguay.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumission.Châteauguay village, (Comté de Châteauguay), ce 25 juin 1958.Le Secrétaire-trésorier, ARMAND BRISEBOIS.Adresse postale: 27 rue Antoine, Châteauguay village (Châteauguay), P.Q/ Téléphone: UN 1-2631 à Montréal.4810l-o accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Councd to be held on Monday, July 14, 1958 at 8.00 o'clock p.m., at the Municipal Hall, Châteauguay, county of Châteauguay.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Châteauguay village, (County of Châteauguay), June 25.1958.ARMAND BRISEBOIS, Secretary-Treasurer.Address: 27 Antoine Street, Châteauguay village, (Châteauguay), P.Q.Telephone: UN 1-2631 at Montreal.48101 Vente \u2014 Loi de faillite Sale \u2014 Baferupcy \\ct -3-,-¦ Canada, province de Québec, district de Canada, province of Quebec, district of Quebec, Québec, Cour Supérieure, N°5399-F (En matière Superior Court, No.5399-F, (In bankruptcy), de faillite).Dans l'affaire de: J.-F.Reginald In the matter of: J.-F.Reginald Côté, merchant Côté, commerçant et hôtelier, Sayabec, P.Q., -and innkeeper, Sayabec, P.Q., debtor, failli.VENTE A L'ENCAN .AUCTION SALE' Avis est par les présentes donné que MARDI le Notice is hereby given that on TUESDAY QUINZIÈME jour de JUDLLET, 1958, à ONZE JJJLY FIFTEENTH, 1958, at ELEVEN o'clock heures a.m., seront vendus par encan public à la a.m., shall be sold by public auxtion at the door Krte de l'église paroissiale de Sayabec, comté de of the church of the parish of Sayabec,' county atapédia, P.Q., les immeubles ci-après décrits of Matapedia, P.Q., the immovables properties savoir: as follows: Item A.\u2014 Un emplacement de 44 pieds de Item A.\u2014 A piece of land of 44 feet in front front par environ 91 pieds de profondeur, connu by about 91 feet in deep, known and designated et désigné comme étant partie du lot No.623 as being part of lot number 623 of the official au cadastre officiel de la paroisse Ste-Marie de cadastre for the parish of Ste-Marie of Sayabec, Sayabec, borné au nord à J.-R.Bérubé, à l'est bounded to the north to J.-R.Bérubé to the à Philippe Pelletier, au sud à Dame H.Paradis east at Philippe Pelletier, to the south at Mrs.Côté,'ou représentants et à l'ouest à la rue de H.Paradis Coté or representatives, and to the l'Église, avec bâtisses dessus construites circons- west at the street of the church, with buildings tances et dépendances.thereon erected, circumstances and dépendances.Item B.\u2014 Un terrain, situé au village de Sain- Item B.\u2014 A piece of land, located in the village don, sur la rue M arche ter re, faisant partie et à of Saindon, on Marche terre Street, being part distraire du lot 659 du cadastre officiel du village and to subtract from the lot 659 of the official Saindon, paroisse de Sayabec, au rang B de la cadastre of the village Saindon, parish of Sayabec, Seigneurie du Lac Matapedia, avec les bâtisses y to the range B of the Seigniory of Lake Mata-érigées, à charge d'une rente annuelle de $6.25 pedia, with buildings thereon erected, to the payable à Les Prévoyants du Canada.charge of an annual rent of $6.25 payable to Les Prévoyants du Canada.Item C.\u2014 Un immeuble connu et désigné Item C.\u2014 A property known and designated comme étant partie du lot N° 476 du cadastre as being part of lot number 476 of the official officiel de la paroisse de Ste-Marie de Sayabec, cadastre of the parish of Ste-Marie of Sayabec, au rang B de la Seigneurie du Lac Matapedia, to the range B of the Seigniory of Lake Mata-mesurant environ 2 arpents en front au chemin pedia, measuring about 2 acres in front to the Matapedia par toute la distance qu'il y a depuis Matapedia Road by all the distance existing from le chemin public et le lac Matapedia, borné au the public road to the Lake Matapedia, bounded nord audit lac, à l'est à Oscar Bérubé, au sud en to the north to the said lake, at the east to Oscar front au chemin et à l'ouest à Pierre Pearson avec Bérubé, to the south in front to the road and to l'Hôtel Bel Air et le motel dessus construits, the west at Pierre Pearson with Bel Air Hotel circons tanceset dépendances.and the Motel thereon erected, circumstahces'and dépendances.Item D.\u2014 Tout l'ameublement de l'Hôtel Item D.\u2014 All the furniture of Bel Air Hotel Bel Air et des Motels pour être vendu en bloc and the Motels to be sold in bloc and if the offer et si l'offre reçue n'est pas jugée raisonnable, la submitted is nôt satisfactory, the sale will be vente se fera en détail à l'Hôtel Bel Air à 2.00 made in detail at Hotel Bel Air at 2.00 o'clock heures p.m., et pour se continuer le lendemain p.m., and to be continued the day after at 10.00 matin à 10.00 heures a.m.o'clock a.m.Les items ci-desus seront offerts séparément au The above items shall be sold separately to the plus haut et dernier enchérisseur, à la charge des last and highest bidder subject to municipal taxes municipales à compter du 1er janvier, 1958, taxes from January 1st 1958, and scholar taxes et des taxes scolaires à compter'du 30 juin, 1958, from June 30th 1958, and all impositions as et de toutes autres impositions foncières tant much for the past as for the future, pour le passé que pour l'avenir. 2322 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, tome 90, N° 26 Les titres peuvent être examinés en tout temps en s'adressant au syndic soussigné.Cette vente est faite conformément aux articles 716,717 et 719A du Code de procédure civile et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite.> Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: argent comptant.Québec, ce 9 juin 1958.Le Syndic, J.-P.BEDARD.Bureaux: .71, rue St-Pierre, Québec.47985-24-2-o VENTES PAR SHÉRIFS AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mention nés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ABITIBI Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Cour Supérieure, t A DRIEN LUSSIER, N° V-3774.Imarchand de St-\\ Edmond, district d'Abitibi, saisissant; vs ROGER GUILBERT, mineur, de St-Edmond, district d'Abitibi, saisi.AVIS DE VENTE L'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 47 du rang V, aux plan et livre de envoi officiel pour le canton Vassan, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Edmond de Vassan, le DIXIÈME jour de JUILLET 1958 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi, Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, 30 mai 1958.47919-23-2-o \u2022 Province de Québec District d'Abitibi Cour Supérieure', ( T\\ GOURD & FILS LTÉE, N° 11,121.\\ corps politique et incor-vporé, ayant une place d'affaires à Amos, district d'Abitibi, saisissante: vs LUCIEN HARVEY, domicilié à Amos, district d'Abitibi, saisi.AVIS DE VENTE Les immeubles connus et désignés comme étant les lots numéros seize et dix-sept du bloc sept aux plan et livre de renvoi du cadastré officiel pour la ville d'Amos, avec bâtisses dessus construites, circonstances etylépendances.Pour être vendus au bureau du shérif, Palais de justice, à Amos, le NEUF JUJXLET 1958 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi, Bureau du Shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, 27 mai 1958.T 47920-23-2-o BEAUHARNOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure, / T ÊO GEORGES PERRON N° 3366.< *-> & ÊMDLE PERRON, l tous deux garagistes, de la cité de Salaberry de Valleyfield, district de Beau-haniois, et y faisant affaires ensemble et de société Titles may be examined at the offices of the undersigned trustee.This sale is made in accordance with articles 716, 717 and 719A of the Code of civil procedure and also article 55 of the bankruptcy act.This sale is equivalent to a sale by Sheriff.Conditions of payment: cash.Quebec, June 9th, 1958.J.-P.BÉDARD, Trustee.Offices: 71, St.Peter Street, Quebec.47985-24-2 SHERIFFS SALES PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Superior Court, ( ADRIEN LUSSIER, No.V-3774.< merchant of St-l Edmond, district of Abitibi, distrainor; vs ROGER GUILBERT, miner, of St-Edmond, district of Abitibi, distrainee.NOTICE OF SALE The immoveable known and designated as being lot number 47 of range V, on the official plan and in the book of reference for the Vassan township, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of St-Edmond de.Vassan on the TENTH day of JULY, 1958, at TWO o'clock in the afternoon.J.A.GAUTHIER, Sheriff's Office, Sheriff of Abitibi.Amos, May 30, 1958.47919-23-2 Province of Quebec District of Abitibi Superior Court, f\"T\\ GOURD & FILS LTÉE, No.11,121.< a body politic and in- I corporate, having a place of business at Amos, district of Abitibi, distrainor, vs LUCIEN HARVEY, domiciled at Amos, district of Abitibi, seized.NOTICE OF SALE The immoveables known and designated as being lots numbers sixteen and seventeen of block seven on the official plan and in the book of reference for the town of Amos, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the office of the Sheriff, Court House at Amos, on JULY NINE, 1958, at TWO o'clock in the afternoon.J.A.GAUTHIER, Sheriff's Office, Sheriff of Abitibi.Amos, May 27, 1958.47920-23-2 BEAUHARNOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court, (J ÊO GEORGES PERRON No.3366.-j A-» & EMILE PERRON, (both garage-keepers, of the city of Salaberry of Valleyfield, district of Beau-harnois, and carrying on business together and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1968, Vol.90, No.26 .2323 sous les noms et raison sociale enregistrée, de \"Garage Z.Perron\", demandeurs vs LAURIER RENAUD, dé St.Chrysostôme, dit district, défendeur, A savoir: \"Une terre sise et située dans la paroisse de St.Jean Chrysostôme, dans le premier rang de Russeltown, connu et désignée sur le plan et dans le livre de renvoi officiels, de la dite paroisse de St.Jean-Chrysostôme, souaje numéro cinq cent soixante et un, (561), d'une contenance de' quatre-vingt-quinze arpents en superficie, avec les bâtisses y érigées, et tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.\" Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de St-Jean -Chrysostôme, le JEUDI, 'le TRENTE-UNIÈME, jour de JUILLET 1958, à DIX heures de l'avant-midi.associated under the name and style of \"Garage Z.Perron\", plaintifis, vs LAURIER RENAUD, of St.Chrysostôme, said district, defendant.To wit: \"A farm situated in the parish of St.Jean Chrysostôme, in the first range of Russeltown, known and designated on the official plan and in the book of reference of the said parish of St-Jean Chrysostôme, under number five hundred and sixty-one (561), containing ninety-five arpents in area, with the buildings thereon erect-ted, and as the whole is to be found presently, with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes attached to the said immoveable.\" \\ To' be sold at the parochial church door of St-Jean Chrysostôme, on THURSDAY, the THIRTY-FIRST day of JULY, 1958, at TEN o'clock in the forenoon.Le Shérif, ERNEST POIRIER, Bureau du Shérif, ERNEST POIRIER.Sheriff's Office, Sheriff.Salaberry de Valleyfield, Salaberry of Valleyfield, le 18 juin 1958.48080-26-2-o -June 18, 1958.48080-26-2 [Première publication: le 28 juin 1958] [First publication: June 28, 1958] BEDFORD Canada \u2014 Province de Québec District de Bedford Cour Supérieure, f tSame ALMA GILEAU, N° 7698 < U demeurant au N° 46 a (.rue Kinnear, dans la cité d'Ottawa, province d'Ontario, veuve de feu Aubrey L.Whorley, en .«on vivant des mêmes lieux et endroits, demanderesse; vs LES HÉRITIERS DE FEU DAME EUGÉNIE GIXEAU, en son vivant du village de Ste-Cécile de Milton, district de Bedford,- veuve-de feu Walter Odel Fuller.L'immeuble connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour la paroisse de Ste-Cécile de Milton, sous le numéro douze \"M\" (12 M) du deuxième rang du canton de Milton, avec bâtisses.Pour être vendu \"en bloc\" â la porte de l'église paroissiale de Ste-Cécile de Milton, district de Bedford, le DIXIÈME jour de JUILLET 1958, à DEUX heures de l'après-midi.BEDFORD Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford Superior Court, fTVAME ALMA GILEAU, No.7698.< residing at No.46 Kin-Inear Street, in the city of Ottawa, Province of Ontario, widow of Aubrey L.Whorley, in his lifetime of the same place and locality, plaintiff; vs THE HEIRS OF THE LATE DAME EUGENIE GILEAU, in her lifetime of the village of Ste.Cécile de Milton, district of Bedford, widow of the late Walter Odel Fuller.The immoveable known 'and designated on the official plan and book of reference of the cadastre for the parish of Ste.Cécile de Milton, under number twelve \"M\" (12 M) of range two of the township of Milton, with buildings.To be sold \"en bloc\" at the door of the parochial church of Ste.Cécile de Milton, district of Bedford, the TENTH day of JULY, 1958, at TWO o'clock in J|he afternoon.Bureau du Shérif, Sheriff's Office, Palais de Justice, Le Député-Shérif, Court House, ANTONIN BOURASSA, Sweetsburg, Que.ANTONIN BOURASSA.Sweetsburg, Que., Deputy Sheriff.Ce 3 juin 1958.47957-23-2-o This June 3, 1958.47957-23-2 CHICOUTIMI Fieri Facias District de Chicoutimi CHICOUTIMI Cour Supérieure, (J A CIE INDUSTRIELLE J-» DU SAGUENAY LTÉE, N° 23,102 j ( corporation légalement constituée ayant une place d'affaire en les cité et district de Chicoutimi, demanderesse; vs LOUIS-PHILIPPE LAROUCHE, domicilié à St-Am-broise, comté et district de Chicoutimi, défendeur.Un lopin de terre ou emplacement connu et désigné au cadastre officiel pour* le rang est (Rg.E.), du Canton Bourget, comme formant partie du lot numéro vingt-sept, (Ptie 27), lequel terrain mesure trente pieds (30') de largeur de l'est à l'ouest, sur trois cents pieds (300') de profondeur du nord au sud, et est borné vers le nord, par le chemin public, vers l'ouest, par le terrain de Fernand Larouche, vers le sud, par Fieri Fadas District of Chicoutimi Superior Court, / t A CIE INDUSTRIELLE No.23,102 -J ^ DU SAGUENAY LTÉE, (legally incorporated corporation having a place of business in the city and district of Chicoutimi, plaintiff; vs LOUIS-PHILIPPE LAROUCHE, domiciled at St-Am-broise, county and district of Chicoutimi, de-fendant.A strip of land or emplacement known and designated on the official cadaster for the East range (East Range) of Bourget Township, as forming part of lot number twenty-seven, (Pt.27), which lot of land measures thirty feet (300 in width from East to West, by three hundred feet (3000 in depth from North to- South, and is.bounded on the North the public road, on the West, by the land of Fernand Larouche, by 2324 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N° 26' le terrain de Auguste Larouche et ses représentants, et vers Test, par le terrain de Dame Clermont Décoste née Cécilia Larouche, avec ensemble les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, Un lopin de terre à l'emplacement connu et désigné au~ cadastre officiel, pour le rang est (rg £) du canton Bourget, comme formant partie du lot numéro vingt-sept (ptie 27) laquelle dite lisière du terrain mesure dix pieds (100 de largeur de l'ouest à l'est, sur trois cents pieds (3000 de profondeur du nord au sud, et est bornée vers le nord par le chemin public, vers l'ouest par une partie résiduelle dudit lot dont il forme partie, propriété de Louis-Philippe Larouche, vers le sud par une autre partie résiduelle dudit lot dont il forme partie, propriété d'Auguste Larouche ou ses réprésentants, et vers l'est par une autre partie résiduelle dudit même lot dont il forme partie, propriété de Dame Cécilia Larouche, avec ensemble les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Un lopin de terre à l'emplacement connu et désigné au cadastre officiel pour le rang est (rg E) du canton Bourget comme formant partie du lot numéro vingt-sept (Ptie 27) laquelle dite lisière du terrain mesure dix pieds (10') de largeur de l'ouest à l'est sur trois cents pieds (3000 de profondeur du nord au sud et est borné vers le nord par le chemin public, vers l'ouest par une partie résiduelle dudit lot dont il forme partie, propriété de Fernand Larouche, vers le sud par une autre partie résiduelle dudit lot dont il forme partie, propriété de Auguste Larouche ou ses représentants, et vers l'est par une autre partie résiduelle dudit même lot dont il forme partie, propriété de Louis-Philippe.La-rouche, avec ensemble les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus en bloc à la porte de l'église paroissiale de St-Ambroise, le TRENTE ET UNIÈME jour du mois de JUILLET 1958, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RfiNÊ DELISLE.Chicoutimi, le 21 juin 1958.48081-26-2-o GASPÉ Fieri Facias Cour Supérieure,/PROGRESSIVE INS.CO.Gaspé, 1 * OF CANADA, deman-N° 4002.) deurs contre JOSEPH KEI-' GHAN Newport, comté de Gaspé, défendeur.La propriété â vendre est la suivante: \"Un lot de terre situé à Newport, connu et désigné comme étant et composant les numéros 607, 608, 609, 610, 611 et 612 du premier rang, aux plan et livre de renvoi officiel, pour le cadastre du canton Newport, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances\".Pour être vendu à la porte de l'église de New-port MARDI le HUITIEME jour de JUILLET 1958 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.2 juin 1958.47926-23-2-o Larouche, on the South, by the lot of land of Auguste Larouche and his representatives, and on the East, by the land of Dame Clermont Decoste née Cécilia Larouche, together with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.A strip of land on the emplacement known and designated on the official cadaster, for the East Range (Range E) of the Bourget Township, as forming part of lot number twenty-seven (Pt.27) which said strip of land measures ten feet (100 in width from West to East, on three hundred feet (3000 in depth from North to South, and is bounded on the North by the public road, on the West by a residual part of the said lot of which it forms part, property of Louis-Philippe Larouche, on the South by another residual part of the said lot of which it forms part, property of Auguste Larouche or his representatives, and on the East by another residual part of the same said lot of which it forms part, property of Dame Cécilia Larouche, together with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.A strip of land on the emplacement known and designated on the official cadaster of the East Range (East Range) of the Bourget Township as forming part of lot number twenty-seven (Pt.27) which said strip of land measures ten feet (100 in width from West to East along three hundred feet (3000 in depth from North to South and is bounded on the North by the public road, on the West, by a residual part of the said lot of which it forms part, property of Fernand Larouche, on \"the South, try another residual part of the said lot of which it forms part, property of Auguste Larouche or his representatives, and on the East, by another residual part of the same lot of which it forms part, property' of Louis-Philippe Larouche, together with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold in block at the parochial church door of St-Ambroise, on the THIRTY-FIRST day of the month of JULY, 1958, at THREE o'clock in the afternoon.RENE DELISLE, Sheriff's Office, Sheriff.Chicoutimi, June 21, 1958.48081-26-2 GASPÉ Fieri Facias Superior Court, /PROGRESSIVE INS.CO.Gaspé, ; * ' OF CANADA, plaintiff; No.4002.) against JOSEPH KEIGHAN, 'Newport, county of Gaspé, defendant.Property for sale is the following: \"A lot of land situated at Newport, known and designated as being composed of number 607, 608, 609, 610, 611 and 612 of the first range, on the official plan and in the book of reference, for the cadaster of the township of Newport, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies\".To be sold at the church door of Newport, TUESDAY, the EIGHTH day of JULY, 1958, at TEN o'clock in the forenoon.' / J.F.MEAGHER, Sheriff's Office, Sheriff.June 2, 1958.47926-23-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, June 28th, 1958, Vol.90, No.26 2325 j HULL Canada \u2014 Province de Québec District de Hull Cour Supérieure, / TA CAISSE POPULAIRE N° 6137.1*-* NOTRE-DAME ( DE HULL, corporation civile dûment incorporée sous l'autorité de la Loi des Syndicats Coopératifs de la Province de Québec, ayant sa principale place d'affaires à Hull, dit district, demanderesse, vs Dame MARD3 THÉRÈSE PARENT, épouse contractuellement sé; parée de biens de Gérard Gauvreau, homme d'affaires domicilié et résidant à Hull, dit district, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes, défenderesse.\"Un immeuble sis à Hull, comté de Hull, province de Québec, consistant en toute cette propriété connue et désignée comme étant le lot quatre (4) de la re-sub-division officielle du lot un (1) de la sub-division officielle du lot original quatre (4) du quartier un (1), au plan et livre de renvoi dé la cité de Hull, avec- bfttisess dessus érigées, circonstances et dépendances, et telles bâtisses portant le numéro civique 169 de la rue Caron, en la cité de Hull.\" Pour être vendu à mon bureau, au Palais de Justice, en la cité de Hull, le TRENTE ET UNIÈME jour du mois de JUILLET 1958, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST-PIERRE.Ce 23 juin, 1958.48092-26-2-o HULL Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull \u2014\u2014 Superior Court, / T A CAISSE POPULAIRE No.6137.\\ L' N O T R E-D AME ( DE HULL, a civil corporation duly incorporated under the authority of the Cooperative Syndicates' Act of the Province of Quebec, 'having its head office at Hull, said district, Plaintiff, vs Dame MARH3 THÉRÈSE PARENT, wife contractually separate as to property of Gérard Gauvreau, business-man domiciled and residing at Hull, said district, and the latter to authorize his wife for these present purposes, defendant.\"An immoveable seized at Hull, county of Hull, Province of Quebec, consisting in all this property known and designated as being lot four (4) of the official re-sub-division of lot one (1) of the official subdivision of the original lot four (4) of Ward one (1), on the plan and in the book of reference of the city of Hull, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and such buildings bearing civic number 169 Caron Street, in the city of Hull.\" To be sold at my office, at the Court House, in the city of Hull, on the THIRTY-FHIST day of JULY, 1958, at THREE o'clock in the afternoon.R.ST-PIERRE, .Sheriff's Office, Sheriff.June 23, 1958.48092-26-2 MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure District de Montréal Montréal, à savoir: (J E PROMOTEUR DTN-N° 439749.< \u2022l' DUSTRIE LTÉE, de-( manderesse; vs JOACHIM HUNEAULT, défendeur.' Un emplacement ayant front sur la rue St-Alexandre, à St-Hubert, dans le comté de Cham-bly, connu et désigné comme étant les lots Nos 809, 810, 811 et 812 de la subdivision officielle du lot originaire N° 136 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse St-Hubert, avec toutes les bâtisses y érigées et notamment une maison portant le N° 66 de la rueSt-Alexandre, à St-Hubert.Pour être vendu, â la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St.Hubert, comté de Chambly, le ONZIÈME jour de JUILLET 1958, à ONZE, heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, CAISSE & LAURENCELLE.-Montréal, 30 mai 1958.47922-23-2-o MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court District of Montreal Montreal, to wit : (J E PROMOTEUR DTN-No.439749.{^ DUSTRIE LTÉE, I plaintiff; vs JOACHIM HUNEAULT, defendant.An emplacement having frontage on St.Alexandre Street, at St.Hubert, in the county of Chambly, known and designated as being lots 809, 810, 811 and 812 of the official subdivision of original lot No.136 on the official plan and in the book of reference of the parish of St-Hubert, with all the buildings thereon erected and especially a house bearing No.66 St.Alexandre Street, at St.Hubert.To be sold, at the parochial church door of St.Hubert, county of Chambly, on the ELEVENTH day of JULY, 1958, at ELEVEN o'clock in the forenoon.CAISSE & LAURENCELLE, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, May 30, 1958.47922-23-2 NICOLET Fieri Facias Canada \u2014 Province de Québec District de Nicolet Cour Supérieure, /\\yf GEORGES TUR-N° 2254.«J JVJL.MEL, cultivateur, , (domicilié et résidant à St-Léonard, district de Nicolet, demandeur; vs M.MARCEL DUHAIME, résidant à St-Léonard, district de Nicolet, défendeur.\"Une terre située en la paroisse de St-Wen-ceslas, dans le 9ième rang du canton d'Aston, connue et désignée comme étant le tiers sud-ouest du lot numéro 177 (1/3 S.O.N° 177) du cadastre officiel du comté de Nicolet, pour la paroisse de St-Wenceslas, moins et à distraire NICOLET Fieri Facias ' Canada \u2014 Province of Quebec District of Nicolet Superior Court, (\\/f GEORGES TUR-No.2254.< ^ya.MEL, farmer, domiciled and residing at St-Léonard, district of Nicolet, plaintiff; vs M.MARCEL DUHAIME, residing at St-Léonard, district of Nicolet, defendant.\"A farm situated in the parish of St-Wen* ceslas, in the 9th range of the township of Aston, known and designated as, being the southwest third of lot number 177 (1/3 S.W.No.177) of the official cadaster of the county of Nicolet, for the parish of St-Wenceslas, less and to with- 2326 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 juin 1968, Tome 90, N\" 26 la partie occupée par le chemin de fer C.N.R.qui la traverse sur la largeur:\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Wenceslas, le NEUVIÈME jour de JUILLET (1958) à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ANTONIO BLONDIN.Nicolet, 3 juin 1958.47958-23-2-o QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: ( THÉOPHILE C H R Ê -N° 79,419.< a TIEN commerçant, Des- 1 chaillons comté de Lotbinière, contre NOËL DESRUISSEAUX, cultivateur, Ste-Françoise, comté de Lotbinière.Avis est par le présent donné que l'immeuble qui devait être vendu en la présente cause au Bureau d'Enregistrement de Ste-Croix, comté de Lotbinière, le TREIZIÈME jour de JUILLET 1956 à DIX heures du matin, et qui ne l'a pas été, sera vendu au même endroit le VINGTIÈME jour de JUIN 1958 à DIX heures de l'avant-midi.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, ALBERT F.RACETTE.Québec le 2 juin 1958.47924-23-2-o [Première insertion: 7 juin 1958.] draw that part occupied by the C.N.R.Railway which crosses it on its width:\" To be sold at the parochial church door of St-Wenceslas, on the NINTH day of JULY, (1958) at TEN o'clock in the forenoon.ANTONIO BLONDIN, Sheriff's Office, Sheriff.Nisblet, June 3, 1958.47958-23-2 QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit : / npHE°pHILE CHRÉ-No.79,419.< TIEN; tradesman, Des-Ichaillons, county of Lotbinière, against NOËL DESRUISSEAUX, farmer, Ste.Françoise, .county of Lotbinière.Notice is hereby given that the immoveable which was to have been sold in the present case at the Registry Office of Ste.Croix, county of Lot-bjnière, on the THIRTEENTH day of JULY, 1956, at TEN o'clock in the morning, and which was not, shall be sold at the same place on the TWENTIETH day of JUNE, 1958, at TEN o'clock in the forenoon.ALBERT F.RACETTE, Sheriff's Office, Deputy-Sheriff.Quebec June 2, 1958.47924-23-2 [First insertion: June 7, 1958] Fieri Facias Québec, à savoir: / T} OBERT L'HEUREUX, N° 90,331.{ notaire, domicilié à Lo-l retteville, Que., en sa qualité d'administrateur de la succession de feu Gérard G.Bastien, nommé suivant la Loi des Indiens; contre LUCIEN SIOUI, domicilié au Village Huron, comté de Québec, district de Québec.\"Garage ou hangar situé dans la Réserve Huronne de Lorette, avec tous les droits d'occupation que possède Lucien Sioui sur la moitié ouest du terrain originairement concédé à Albert Sioui, senior.Ledit emplacement étant borné comme suit: vers le nord par la rue Principale, vers le sud par la Rivière Saint-Charles, vers l'ouest par le terrain occupé par Roméo Picard et vers l'est par le terrain occupé par Albert Sioui, jr., circonstances et dépendances.\" Pour être vendu au Bureau d'Enregistrement-à Québec, le PREMIER jour d'AOÛT prochain à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Dr J.R.GOBEIL.Québec, le 25 juin 1958.48102-26-2-p [Première insertion: le 28 juin 1958] [Deuxième insertion: le 19 juillet 1958] Fieri Facias îebec, to wit : / \"Q OBERT L'HEUREUX, No.90,331.< *v notary, domiciled at l Lorette vil le, Que., in his Quebec, to wit : ( OBERT L'HEUREUX, at his quality of administrator for the estate of the late Gérard G.Bastien, appointed according to Indian Law; against LUCIEN SIOUI, domiciled in the Huron Village, county of Quebec, district of Quebec.\"Garage or shed situated in the Huron Reserve of Lorette, with all the occupational rights which Lucien Sioui possesses on the western half of the originally owned land conceded to Albert Sioui, Senior.The said emplacement is bounded as follows: on the north by the main street, on the-south, by the St.Charles River, on the west, by the land occupied by Roméo Picard and on the east, by the land occupied by Albert Sioui, Jr., circumstances and dependencies.\" To be sold at the Registry Office at Quebec, on AUGUST FIRST next,* at TEN o'clock in the forenoon.Dr J.R.GOBEIL.Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, June 25, 1958.48102-26-2 [First insertion: June 28, 1958] [Second insertion: July 19, 1958] ROBERVAL s Fieri Facias ( Canada \u2014 Province de Québec District de Roberval Cour Supérieure, I JEAN MARIE BELLE Y, N° 19,033.< J courtier en assurance de I Naudville, ROLLAND SIMARD, marchand de St-Cœur de Marie, faisant affaires ensembles sous la raison sociale de \"Lac St-Jean Finance Enrg.\", de Naudville, demanderesse; vs DOMINIQUE LAPOINTE, avocat, rue Collard, Aima et PHILIPPE LAPOINTE, de Notre-Dame d'Hébertville, défendeurs.Avis public est par les présentes donné que les terres et héritages sous-mentionnés ont été ROBERVAL Fieri Facias Canada \u2014 Province of Quebec District of Roberval Superior Court, / JEAN MARIE BELLEY, No.19,033.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.