Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 21 (no 51)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1957-12-21, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 89, N#51 4599 Vol.89, No.51 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUEBEC Quebec, samedi 21 décembre 1957 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.10 Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine oses: To carry on business as contractors in electricity, heating and refrigeration; to operate the industry and business dealing in electrical apparatus and accessories, under the name of \"Alexandre Beaulieu Inc.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Notre-Dame-des-Laurentides, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1957.P.FRENETTE, 46659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13585-57) Artic Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November, 1957, incorporating: Roger Parisi, contractor, of Ste.Foy, V.-Jean Charrier, sales agent, of Beauport, and Jacques Perron, advocate, of Quebec, for the following purposes : To carry on business as general building contractors, under the name of \"Artic Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The hea I office of the company will be at 374 «les Chenaux Street, Sainte-Foy, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of November, 1957.P.FRENETTE, 46659 Acting Deputy Attorney General. 4602 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, £1 décembre 1957, Tome 89, N° 51 (P.G.13333-57) Atlantic Bag Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze novembre 1057, constituant en corporation: Jacques Robitaillc, industriel, de St-Laurent, J.-Claude Nolin, de Carticrville, Auguste Vincent, Maurice Lagacé, tous deux de St-Lambcrt, et René Talbot, de Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de sacs et autres produits d'emballage, sous le nom de \"Atlantic Bag Corporation\", avec un capital divisé en 100 actions communes sans valeur au pair et en 595 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $6,500.Le siège social de la compagnie sera 6316, rue Papineau, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659-0 P.FRENETTE.(P.G.13596-57) Auto Suspension Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf novembre 1957.constituant en corporation: André Sauvé, représentant manufacturier, Marc Crépin, gérant rie ventes, tous deux de Québec, et Robert-B.Lafrenière, avocat, de Ste-Foy, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles; faire affaires comme garagistes et loca-leurs d'automobiles, sous le nom de \"Auto Suspension Inc.\", avec un capital total de $15,000, divisé en 3,000 actions de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659-o P.FRENETTE.(P.G.13475-57) Barry Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du onze novembre 1957, constituant en corporation: Max Sidney Kaufman, de Westmount, Joseph Roy Hoffman, de Montréal, et Oscar Rcspitz, de Ville Mont-Royal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements et de portefeuille, sous le nom de \"Barry Holdings Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et 960 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège socinl de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(A.G.13333-57) Atlantic Bag Corporation Notice is hereby given that under Part I of tlic Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1957, incorporating: Jacques Robi-taille, industrialist, of St-Laurcnt, J.Claude Nolin, of Carticrville.Auguste Vincent, Maurice I.agacé, both of St-Lambert, and René Talbot, of Montreal, all four advocates, for the following purposes: To operate an industry and business dealing in bags and other wrapping products under the name of \"Atlantic Bag Corporation\", with a capital stock divided into 100 common shares of no par value and into 595 preferred share-; of $100 par value each, and the amount with which the company shall start its operations shall be $6.500.The head office of the company will be at 6316 Papineau St., Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1957.P.FRENETTE, 46659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13596-57) Auto Suspension Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have bees issued by the Lieutenant-Governor of the Prov* ince of Quebec, bearing date the nineteenth day of November 1957, incorporating: André Suive, manufacturing representative, Marc Crépin, galei manager, both of Quebec, and Robert B.La-frenière, advocate, of Ste.Foy, for the following purposes: To carry on the business of and deal in automobiles; carry on business as garage-keepers and deal in the renting of automobiles, under the name of \"Auto Suspension Inc.\", with a total capital of $15,000, divided into 3.(100 shares of $5 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of November 1957.P.FRENETTE.46659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13475-57) Barry Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of November, 1957, incorporating: Max Sidney Kaufman, of Westmount, Joseph Roy Hoffman, of Montreal, and Oscar Respil/ \"f the town of Mount Royal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investir ni and holding company, under the name of \"BarTJ Holdings Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 400 common shares of 110 each and into 960 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of November.1957.P.FRENETTE.46659-o Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 21st, 1957, Vol.89, No.51 4603 (P.G.13598-57) Cordial Land and Housing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze novembre 1957, constituant en corporal ion: John Simkovits, administrateur, Seymour Machlovitch, avocat, Samuel Moskovitch, avocat et conseil en loi de la Reine et Dorcen Shcre Gordon, secrétaire, fille majeure, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'im-inruhlcs, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"Cordial Land andHousirg Co.Ltd.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 48 act ions ordinaires d'une valeur au pair de $100 cune et 452 actions privilégiées d'une valeur BU pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(P.G.13701-57) Defrostomatic Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date \u2022 lu vingt et un novembre 1957, constituant en e poration: Julien Racine, industriel, Robert Bédard, comptable, tous deux de Granby, et Léonil Phancuf, commerçant, de St-Hyacinthe, peur les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de réfrigérateurs et congélateurs domestiques, commerciaux ou autres, ainsi que d'appareils destinés à la climatisation de l'air, sous le nom de \"Defrostomatic Co.Limited\", avec un capital total de 5150,000, divisé en 1,500 actions communes de 5100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 40059-0 P.FRENETTE.(P.G.13269-57) Diamond Holdings Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six novembre 1957, constituant en corporation : Leonard Liverman, Julius Briskin et Arthur Yanofsky, tous avocats, de Montréal, pour les oli jet s suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de \"Diamond Holdings Incorporated\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, 1,000 actions catégorie \"A\" d'une valeur au pair de $1 chacune et 980 actions catégorie \"B\" d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six novembre 1957.1/Assistant-procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(A.G.13598-57) Cordial Land and Housing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1957, incorporating: John Simkovits, executive, Seymour Machlovitch, advocate, Samuel Moskovitch, advocate and Queen's Counsel, and Dorcen Shere Gordon, secretary, spinster, all four of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Cordial Land and Housing Co.Ltd.\", with a total capital stock of $50.000.divided into 48 common shares of a par value of $100 each and into 452 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of November, 1957.P.FRENETTE, 46659-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13701-57) * Defrostomatic Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of November 1957, incorporating: Julien Racine, industrialist, Robert Bédard, accountant, both of Granby, and Léonil Phaneuf, merchant, of St.Hyacinthe, for the following purposes: To carry on the business of and deal in refrigerators and freezing-machines for domestic, commercial or other purposes as well as air-conditioning apparatus, under the name of \"Defrostomatic Co.Limited\", with a total capital of $150,000, divided into 1,500 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of November 1957.P.FRENETTE, 46659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13269-57) Diamond Holdings Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of November, 1957, incorporating: Leonard Liver-man, Julius Briskin and Arthur Yanofsky, all advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Diamond Holdings Incorporated\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each, 1,000 class \"A\" shares of a par value of $1 each and into 980 class \"B\" shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of November, 1957.P.FRENETTE, 46659-o Acting Deputy Attorney General. 4604 OAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, SI décembre 1957, Tome 89, N° 61 (P.G.13477-57) Ell-Jay Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze novembre 1057, constituant en corporation: Max Sidney Kaufman, de Westmount, Joseph Roy Hoffman, de Montréal et Oscar Respitz, de Ville Mont-Royal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Agir comme une compagnie de placements, sous le nom de \"Ell-Jay Holdings Ltd.\", avec un capital total de 5100,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et 960 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(P.G.13559-57) Ezra Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en date du quatorze novembre 1957, constituant en corporation: Ezra Shahmoon, constructeur, Sam Eklove, Irvirg Eklove, tous deux agents d'immeubles, tous trois de Montréal et Robert Eklove, vendeur, «le la Ville de Côte St-Luc, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, de construction, de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Ezra Corporation\", avec un capital total «le $100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(P.G.13547-57) Ferronnerie Pointe-Claire Hardware \u2022*^e Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt novembre 1957, constituant en corporation: Jacques Terriault, vemleur, Julien Co-meau, gérant, et Marie-Jeanne Cherrier Comeau, ménagère, épouse séparée de biens dudit Julien Comeau, tous trois de Lachine, pour les objets suivants: Faire affaires comme quincailliers, sous le nom de \"Ferronnerie Pointe-Claire Hardware Ltée \u2014 Ltd.\", avec un capital divisé en 2,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $25 chacune et en 2,000 actions ordinaires sans valeur au pair, et le montant initial avec lequel la compagnie devra commencer ses opérations sera de $15,000.Le siège social de la compagnie sera 319, Chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46650-0 P.FRENETTE.(A.G.13477-57) Ell-Jay Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issuer! by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1957, incorporating: Mas Sidney Kaufman, of Westmount, Joseph Roy Hoffman, of Montreal, and Oscar Respitz, of the town of Mount Royal, all three advocates, for the following purposes: To act as an investment company, under the name of \"Ell-Jay Holdings Ltd., with n total capital stock of $100,000, divided into 400 common shares of $10 each and into 960 preferred shares of $100 each.The head office of the company .will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1957.P.FRENETTE, 46659-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13559-57) Ezra Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Provnce of Quebec, bearing date the fourteenth day of November, 1957.incorporating: Ezra Shahmoon, builder, Sam Eklove, Irving Eklove, both real estate agents, all three of Montreal, an«! Robert Eklove, salesman, of the town of Côte St.Luc, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction, holding and investment company, under the name of \"Ezra Corporation\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 900 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of November.1957.P.FRENETTE, 46059-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.13547-57) Ferronnerie Pointe-Claire Hardware ^e Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the twentieth day of November 1957, incorporating: Jacques Terriault, salesman, Julien Comeau, manager, and Marie Jeanne Cherrier Comeau, housewife, wife sepnr\"te 9i to property of the said Julien Comeau all three of Lachine, for the following purposes: To carry on business as hardwaremen, under the name of \"Ferronnerie Pointe-Claire Hani-ware Ltée \u2014 Ltd.\", with a capital stock divided into 2,000 preferred shares of a nominal value of $25 each and 2,000 common shares without par value, and the initial amount with which the company shall commence its operations shall be of $15.000.The head office of the company will be at 319 Bord-du-Lac road, Pointe-Claire, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of November 1957.P.FRENETTE, 46659 ActingTJeputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 21et, 1957, Vol.89, No.51 4605 (P.G.13419-57) Goyer Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnie do Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente et un octobre 1957, constituant en corporation: Sydney Phillips, avocat, de la ville Côte St-Luc, Harry Stein, pharmacien, et Murrav Wavman, agent d'immeubles, tous deux de St-Laurent, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Goyer Investment Corp.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un octobre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 40659 P.FRENETTE.(P.G.13573-57) Granby Welding Supplies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieu tenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze novembre 1957, constituant en corporation: Rolland Légaré, forgeron, Cécile Monty Légaré, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Rolland Légaré, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Gilles-D.Dallaire, comptable agréé, tous trois de Granby, pour les objets suivants: Faire affaires cnmnio maîtres de forge, fondeurs, soudeurs et ouvriers en métaux; exercer l'industrie et le commerce de minerais, métaux, produits chimiques et autres préparations, sous le nom de \"Granby Welding Supplies Lie\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $50 chacune et en 35,000 actions privilégiées de $1 chacune.\\jc siège social de la compagnie sera 120, rue Cowie, Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 40659-O P.FRENETTE.(P.G.13533-57) Green Investments Limited Axis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date treize novembre 1957, constituant en corporation: Jacques I>cchelle, ingénieur civil, de Belœil, Joseph Bernath, médecin, d'Outremont, et Gilles Vihndré, architecte, de Westmount, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et agents d'immeubles, sous le nom de \"Green Investments Limited\", avec un capital total de $20,000, divisé en 400 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46059-O P.FRENETTE.(A.G.13419-57) Goyer Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of October, 1957, incorporating: Sydney Phillips, advocate, of the town of Côte St.Luc, Harry Stein, pharmacist, and Murray Waxman, real estate agent, both of St.Laurent, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Cover Investment Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 590 common shares of a par value of $10 each and into 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of October, 1957.' P.FRENETTE, 46659-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13573-57) Granby Welding Supplies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of November, 1957, i\"corporati\" g : Rolland Légaré, blacksmith, Cécile Monty Légaré, housewife, wife contractually separate as to property of the said Rolland Légaré, and duly authorized by him for the purposes therein, and Gilles D.Dallaire, chartered accountant, all three of Granby, for the following purposes: To carry on business as iron masters, founders, welders and metal workers; carry on the business of and deal in ore, metals, chemical products and other preprations, under the name of \"Granby Welding Supplies Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $50 each and 35,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at 120 Cowie Street, Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of November, 1957.P.FRENETTE.46659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13533-57) Green Investments Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth flay of November, 1957, incorporating: Jacques Lechelle, civil engineer, of Belœil, Joseph Bernath, physician, of Outremount, and Gilles Vilan-dré, architect, of Westmount, for the following purposes: To carry on as constructors and real estate agents under the name of \"Green Investments Limited\", with a total capital stock of $20,000, divi'led into 400 shares of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of November.1957.P.FRENETTE, 46659 Acting Deputy Attorney General. 4606 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 décembre 1957, Tome 89, N° 51 (P.G.13599-57) Harber Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la provirce de Québec des lettres patentes, en date du douze novembre 1957, constituant en corporation: Bernard Jack Shapiro, Harold Tafler Shapiro, tous deux restaurateurs, et Mary Shapiro, ménagère, épouse séparée de biens dudit Harold Tafler Shapiro, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Harber Investments Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actiors ordinaires de $50 chacune et 7.C00 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1449 rue St-Alexardre, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze rovembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(P.G.13586-57) J.H.Thibault & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze novembre 1957, constituant en corporation: Jean-Paul Jobin, Louis-André Trudcl, tous deux comptables, et Henri Chassé, notaire, tous trois de Ste-Foy, pour les objets suivants: Exploiter des magasins généraux; faire affaires comme garagistes et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de \"J.H.Thibault & Fils Ire\", avec un capital total de $40.000, divisé en 2C0 actiors communes de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $1C0 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Price, comté de Matar.e, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le onze rovembre 1957.L'Assistant-procureur gérerai suppléant.46659-0 P.FRENETTE.(P.G.13389-57) Kingsway Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été recordé par le Lieutenant-gouverneur de la provirce de Qrébcc des lettres patentes, en date du six novembre 1957, constituant en corporation: Hyman Eric Feigelson, avocat, de la ville Côte St-Luc, George Whclan, avocat.John Di Massiro, surir terdant.Harold Ashen mil.commis en Loi de Toshiko Nakatsekn, dactylo, fil h majeure, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Kingsway Investment Corp.\", avec un capital total de $40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'urc valeur nu pair de $1 chacune et 8.6QD actiors privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la ermpagnic sera a Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(A.G.13599-57) Harber Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1957.incorporating: Bernard jack Shapiro.Harold Tafler Shapiro, both restaurateur and Mary Shapiro, housewife, wife separate aa to property of the said Harold Tafler Shapiro, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an ina/estmenl company, under the name of \"Harber Invest ments Ltd.\".with a total capital stock of $49,00 .divided into 100 common shares of $50 each and into 7,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at 1449 St.Alexander Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Gecen I, this twelfth dav of November.1957.P.FRENETTE, 40659-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.13586-57) J.IL Thibault & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governo.* of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day f November 1957, incorporating: Jean-Paul Jobin, Louis André Trudcl, both accountants, and Henri Chassé, notary, all three of Ste.Foy, for the following purposes: To operate general stores; carry on busii i is as garage-keepers and general building contraint» under the name of \"J.IL Thibault & I ils I-c\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Price, county of Matanc, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of November 1957.P.FRENETTE.46659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13389-57) Kingsway Investment Corp.Notice is hereby given that under Part I \"f the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Provirce of Quebec, bearing dntc the sixth day of November, 1957, incorporating: Hyman Eric Feigelson, advocate, of the town of Côte St.Luc, George Whclan, advocate.John Di Massino, superintendent, Harold Ashenmil, law clerk, and Toshiko Nakatsukn, typist, spinster of the full age of majority, all four of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Kingsway Investment Corp.\".with a total capital stock of 140*000, divided into 4.000 common shares of a par valu of $1 each and into 3,600 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of November, 1957._ P.FRENETTE, 46659-0 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December Slat, 1957, Vol.89, No.51 4607 (P.G.13434-57) Les» Laiteries Lcclcrc Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi ii Noël, comptable agréé, d'Outremont, et Pauline Bélanger, secrétaire, célibataire, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce du lait et des produits r the following purposes: To deal in milk and the products and byproducts thereof, under the name of \"Les Laiteries Lcclcrc Inc.\", with a total capital stock of $300,000, divided into 10,000 Class \"A\" shares of $10 each, 100,000 Class \"B\" shares of $1 each and 10,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1957.P.FRENETTE, 40659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13583-57) Lida Enterprises Inc.Notice is hereby given that Under Part I of the Quebec Companies1 Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November, 1957, incorporating: Henry Zipes, manager, E I ward Oriel, merchant, and Seymour Machlovitch, advocate, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Li la Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divi led into 52 common shares of a par value of $100 each and into 348 preferred shares of a par value of $100 each.The bead office of tlx?company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of November, 1957.P.FRENETTE, 46059-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.13531-57) Li-Ri-Da-Ja Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1957, incorporating: Max Sidney Kaufman, of Westmount, Joseph Roy Hoffman, of Montreal, and Oscar Rcspitz, of the town of Mount Royal, all three advocates, for the following purposes: To act as an investment company, under the name of \"Li-Ri-Da-Ja Holdings Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $10 each and into 360 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelth day of November, 1957.P.FRENETTE, 46659-0 Acting Deputy Attorney General. 4608 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, tl décembre 1957, Tome 89, N° 51 (P.G.13499-57) Lynn Holdings Ltd.Avis est donné qu'on vertu de ln première partie de la Ix>i «les compagnies «le Québec, il a été accordé pnr le Lieutenant-gouverneur de la provirce «le Québec des lettres patentes, en date du treize novembre 1957, constituant en corporation: Eve Kiraly.ménagère, épouse séparée de biens de Stephen Kiraly et dûment autorisée par ce dernier aux fins «les présentes, Gloria Bell, sténographe, fille majeure et Daniel King- stone, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'immeubles, d'amélioration et «le «léveloppement, sous le nom de \"Lynn Holdings Ltd.\", avec un capital total de $40.000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d\"une valeur au pair de $100 chacune.Le sien social de la compagnie sera à Montréal, «listrict Judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur g«>ncral, le treize novembre 1957.L'Assistant -procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(P.G.13568-57) Meunerie Gamache Incorporée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «'es lettres patentes, en date du quatorze novembre 1957, constituant en corporation: Armand Gamache, cultivateur, de la paroisse «l'Iberville, Réal Gamache, de St-Jcan, et Normand Gamache, de Lacolle, tous deux industriels, pour les objets suivants: Faire affaires comme meuniers, sous le nom de \"Meunerie Gamache Incorporée\", avec un capital total de $150,000, divisé en 1,500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera A Saint-Jean, district judiciaire d'Rîcrville.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659-0 P.FRENETTE.(P.G.13578-57) Normat Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf novembre 1957, constituant en corporation: Gregory Charlap.Arthur Sbulman, tous deux avocats, et Harry Closner, gérant de crédit, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et amélioration, sons le nom de \"Normat Construction Co.Ltd.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera A Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le neuf novembre 1957.L'Assistant-procureur général sunnléant.46659 P.FRENETTE.(A.G.13499-57) Lynn Holdings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of November, 1957, incorporating: Eve Kiraly, housewife, wife separate as to property of Stephen Kiraly.a» d duly authorize! by him for the purpose of these presents, Gloria Bell, stenographer, spinster, and Daniel Kh'gstone, advocate, all of Montreal, for the following purposes: To earn.' on the business of a real estate, improvement and development company, under the name of \"Lynn Hoi li\"cs Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 prefer-red shares of a p»r value of $101 each and into 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «lis*rict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of November.1957.P.FRENETTE, 46659-0 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13588-57) Meunerie Gamache Incorporée Notice is hereby given that under Part f of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin* Province of Quebec, bearing «late the fourteenth day of November, 1957, incorporating: Armand Gamache, farmer, of the parish of Iberville, Real Gamache, of St.John's, and Normand Gamache, of Lacolle, both industrialists, for tl 1 following purposes: To carry on business as millers, under the name of \"Meunerie Gamache Incorporée'*, with a total capital stock of $150,000, divided into 1,500 shares of $100 each.The head office of the company will be at St.John's, judicial «listrict of Poerville.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of November.1957.P.FRENETTE, 46659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13578-57) Normat Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of November, 1957, incorporating: Gregory Charlap, Arthur Shulman, both advocates, an«l Harrv Closner, credit manager, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction an«l improvement company, under the name of \"Normat Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of 1100,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 900 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Date*! at the office of the Attorney General, tliii ninth day of November, 1957.P.FRENETTE.46659-0 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 21st, 1957, Vol.89, No.51 4609 (P.G.135S2-57) Oldfield Realty Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit novembre 1957, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Sarah Miller, sténocraphe, tous deux de Montréal, et Clarence Reuben Gross, avocat, de Westmount, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, construction et amélioration, sous le nom de \"Oilfield Realty Ltd.\", avec un capital total de S5.000, divisé en 5,000 actions de S1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(P.G.13545-57) Ontario 5c \u2014 $1.00 Store Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept novembre 1957.constituant en corporation : Philip Le vire, marchand, de St-Laurent, Jack Greenstein, avocat, de la ville Cote St-Luc.et Netty Mol, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner et faire le commerce de vêtements pour hommes, dames, et enfants, meubles, bijouterie, marchandises pour le sport, textiles et nouveautés, sous le nom de \"Ontario 5c \u2014 S1.no Store Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 250 actions privilégiées d'une valeur nu pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept novembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659 P.FRENETTE.(P.G.13560-57) Rosario Explorations, Ltd.(No Personal Liability) Avis f st donne qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize novembre 1957, constituant en corporation : Gordon Matthew Perder, Alfred Melmse West, tous deux avocats et Conseils en Loi de la Reine.David Gregory, étudiant en droit, Thomas Lawrence Hartley, comptable, tous quatre de Montréal, ft Wiliiam Maxwell Fonl, avocat, du village de Bouclierville, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et minerais et les négocier, Rous le nom de \"Rosario Explorations, Ltd.\" (Ne Personal Liability), avec un capital total de SâO.000, divisé en 50,000 notions d'une valeur au pair de $1 chacune.I-es actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront Cfiyé ou convenu de payer à la compagnie pour urs actions.(A.G.13582-57) Oldfield Realty Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November, 1957, incorporating: Samuel David Rudenko, advocate and Queen's Counsel, Sarah Miller, stenographer, both of Montreal, and Clarence Reuben Gross, advocate, of Westmount, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and improvement company, under the name of \"Oldfield Realty Ltd.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 shares of tl each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of November, 1957.P.FRENETTE, 46659-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13545-57) Ontario 5c \u2014 $1.00 Store Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of November, 1957.incorporating : Philip Lovine, merchant, of St.Laurent, Jack (ire?ns-tein, advocate, of the town of Côte St.L c, and Netty Mol.spinster of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in men's, la lies* and children's wearing apparel, furniture, jewellery, sporting goods, textiles and novelties, under the name of \"Ontario 5c \u2014 $1.00 Store Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 150 common shares of a par value of $100 each and into 250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of November.1957.P.FRENETTE, 46659-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13560-57) Ro«»nrio Explorations, Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quehec, bearing date the thirteenth day of November, 1957, incorporating: Gordon Matthew Pender.Alfred Melrose West, both advocates and Queen's Counsel, David Gregory law student, Thomas Lawrence Hartlnv.accountant, nil four of Montreal, and William Maxwell Ford, advocate, of the village of Bouclierville, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Rosnrio Explorations, Ltd.\" (No Personal Liability\"*, with a total capital stork of $50,000, divifled into 50,000 shares of a par value of $1 eaoh.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares. 4010 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 décembre 1957, Tome 89, N° 61 Le liège social f the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November fourteenth.1057.t«> the company \"The Commercial Ac«'eptance Corporation Limited La Corporation «lu Crédit Commercial Limitée\".I.reducing its capital stock from 8500,000 to 8304,000: the cancelled «-apital stock being divided into 1,960 preferred shares of 8100 each; 2.subdividing its 2,500 common shares of 8100 each into 62.500 common shares of 84 each; 3.subdividing and converting its remaining 540 pnderrcil shams of 8100 into 13.500 common shares of 81 each; 4.increasing its capital stock of 8304.0(H) to 81300,000: the additional capital stock being divided into 74.0(H) common shares of 84 each and into 20.000 preferres shares of 810 each.Date«l at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of November, 1957.P.FRENETTE.46659 Acting Deputy Attorney General.Applications to Legislature Public notice is hereby given that \"Les Commissaires d'écoles pour la municipalité «le l'Assomption, dani le comté de Heauce\", will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an act authorizing them to impose a sale's tax not exceeding one per cent.Ville Bt-GeorgeS, Heauce, November 30th, 1957.RODOLPHE LAFLAMME, .46591 -49-4-o Attorney for the petitioners.Public notice is hereby given that \"La Société Provinciale «l'Assurance Mutuelle \u2014 The Provincial Mutual Insurance Society\" will apply to the Legislature of the Provuicc of Quebec at its present Session for the passing of an Act replacing the Act 13 Georges VI, Chapter 125, changing the name of the company to \"Provincial General Insurance Societv\" authorizing a capital stock of one million dollars (81,000,000.00) for the company, defining the powers of the company, authorizing the company to issue insurance contracts, participing or non-participing for cash or for «leposit notes, and for other purposes.Montreal, December 3r«l, 1957.La Société Provincial «l'Assurance Mutuelle \u2014 The Provincial Mutual Insurance Society, Per D.M.CHARBONNEAU, President.Per J.J.MILORD, 46606-49-4-O Secretary. 4616 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 décembre 1957, Tome 89, N° 51 Avis public est présentement donné que la ville Montréal-Nord, dans la circonscription électorale de Laval, pétitionnera les Corps législatifs de la province de Québec à leur présente session, en adoption d'une loi la dégageant de l'application des articles la soumettant à l'autorité de la Commission métropolitaine de Montréal dans les lois organiques de celle-ci; interprétant l'art.72 du règlement N° 291; exigeant que les locataires aient acquitté leurs taxes pour leur cens électoral; reportant en novembre l'élection générale; et ajoutant certains officiers à ceux prévus à la Loi de la destitution de certains officiers municipaux; avec les autres fins accessoires ou relatives.Montréal, 22 novembre 1957.L'Avocat de la pétitionnaire, LOUIS-JOSEPH DE LA DURANTAYE.46519-48-4-0 Avis est par la présente donné que \"Larissa Development Corporation\" fera une demande à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, aux fins de faire adopter une loi pour établir clairement le titre à la propriété ci-après décrite! Un certain terrain également situé* dans la cité de Montréal et connu et désigné comme étant le lot N° trois cent vingt-cinq (N° 325) aux plan et livre de renvoi officiels de la parois.-r de Sault-au-Récollet, ledit lot étant borné au nord-ouest par partie «lu lot numéro trois cent vingt-trois (N° 323) du même cadastre, ou subdivision desdits lots, au nord-est par le lot N° trois cent vingt-quatre (N° 324) du même ceds tre, étant le parc Marcelin Wilson, an sud-est par les terrains de la paroisse de Saint-Laurent, étant les lots numéros deux cent soixante-deux, (N° 262) deux cent soixanle-un (N° 261) et deux cent soixante (N° 260) du cadastre ds ladite paroisse de Saint-Laurent, f the \"Quebec North Shore Paper Company'*, situated within its territory, to the amount of nine hundred am! seventy-five thousand dollars ($975,000.00); 3.Ami for all other purpose.Baie Comeau, November 21.1957.ROULEAU, PARADIS & ROULEAU, 46525-48-4 Attorneys for the petitioner.Public notice is hereby given that ''Windmill Point Inc.\" a corporation duly incorporated, having its IIcn«l-Officc in the district of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act on the following matters: 4018 GAZETTE OFFICIELLE DE QÛÊBEl \\ Québec, 21 décembre 1957, Tome 89, A ° 51 Ériger en municipalité «le ville sous le nom de \"Ville de Pointe du Moulin\", ce territoire décrit comme étant les lots 1, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et partie du lot 15, vorné au nord par le lot subdivisé 10 dudit lot originaire, partie du lot 17, borné au nord par le lot subdivisé 10 dudit lot originaire, partie du lot 20, borné au nord par le lot subdivisé 104 dudit lot originaire, et aussi partie du lot 21, borné au nord par les lots 21 -12-1, 21-12-2, 21-11-2, vers le sud-ouest par les lignes centrales du chemin public, comprenant aussi les mes, ruelles, chemins publics et autres places publiques existant sur ledit, territoire.Tous ces lots, faisant partie du cadastre officiel de la paroisse Sabitc-Jcanne de l'Ile Perrôt, sont détachés de la municipalité de la paroisse Notre-Dame de l'Ile Perrôt, dans le comté de Vaudreuil, déterminer le nombre des membres du conseil municipal; nommer les personnes qui agiront comme maire et échevins pour une période déterminée; déterminer l'éligibilité et la nomination ou le remplacement ties membres du conseil pour jusqu'à l'élection générale de février 1902; avoir le droit d'accorder des franchises pour les services publics, de gré à gré; réglementer les taxis et les endroits de stationnement; réglementer les subdivisions et les plans de subdivisions; réglementer la coupe de la glace dans les eaux limitrophes; réglementer l'usage des plages et des embarcations; réglementer la répartition du coût des rues et des places publiques; réglementer les restaurants ambulants, et pour autres fins.Montréal, le 22 novembre 1957.Les Procureurs de \"Pointe du Moulin Inc.\", 40526-48-4-O LACROIX, VIAU & POUPART.Avis public est par les présentes, donné que la Commission scolaire «le la cité île Bcauharnois, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à la présente session, pour l'adoption d'une loi aux fins suivantes: 1° Autoriser les commissaires en tout temps, «Jurant l'année scolaire, à changer «le fonction pédagogique, «le classe ou d'écoles, un instituteur ou une institutrice, pourvu «pie son traitement ne soit pas réduit; 2° Acconler des frais de représentation au président et aux commissaires; 3° Augmenter le taux «l'intérêt à six pour cent sur les arrérages «le taxes; 4° Annexer une partie «lu territoire «le la Commission scolaire de Saint-Clément; 5° Et pour toutes autres fins.Ib-.-i u ha mi ois, ce 26 novembre 1957.Le Procureur de la pétitionnaire, 46538-48-4-0 FRANÇOIS DORVAL.Avis public, est par les présentes, donné que la Corporation municipale de St-Émilicn, Desbiens, comté Lac St-.Iean, s'adressera à la Législature «le Québec, à sa présente session, pour l'adoption «l'une loi, en vue «l'annexer à son territoire actuel, une partie de la municipalité de Chamlxml, pour fin municipale scolaire et d'enregistrement, ou pour toutes autres fins.To erect into a town, under the name of \"Town of Windmill Point\" the territory being lots nos.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 18,19,22,23,24,25ami part of lot 15, limited to the north by subdivided lot 10 of the said original lot, part of lot 17, limited to the north by subdivided lot 10 of the said original lot, part of lot 20, limited to the north by the subdivided lot 104 of the said original lot, and also part of lot 21, limited to the north by the lots 21-12-1, 21-12-2, 21-11-2, at the south-west by the central lines of the public mad, including also the streets, lanes, public roads and publie places now existing on said territory.All these lots being part of the official cadastre of the parish of Sainte-Jeanne de l'Ile Perrôt, are detached of the municipality of the parish of Notre-Dame «le l'Ile Penot, in the county of Vau«lrcuil, to fix the number of the members of the municipal council, to appoint the persons who shall act as mayor and aldermen for a determined period; to determine the qualifications require*! for nomination or the replacement of the members of the Council up tt> the gsnejSJSJ election in the month of February, 1962; to have the right to grant franchises for public services, by mutual agreement; to regulate the taxis and the places where they can station, to regulate the subdivisions and subdivisions plans; to regulate the cutting of ice within the territorial waters; to regulate the beaches and the water boats; to determine the repartition of the cost of streets and public places; to regulate itinerant restaurants, am! for all other purposes, Montreal, November 22, 1957.LACROIX, VIAU & POUPART, Attorneys of 46526-48-4-0 \"Windmill Point Inc.\" Public notice is hereby given that the School Commission of the city of Beauharnois will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an Act for the following purposes: 1.To authorize the Commissioners, at any time during the school year, to change the pedagogical duties, class or school, of any teachers providing that his or her salary is not decreased; 2.Grant entertainment fees to the président an«l commissioners; 3.Increase to six per cent the rate of interest on taxation arrears; 4.Annex a portion of the territory of the School Commission of Saint Clément; 5.And for any other purposes, Beauharnois, this November 26th, 1957.FRANÇOIS DORVAL, 46538-48-4 Attorney for petitioner.Public notice is hereby given that the Muni cipal Corporation* of St.Émilicn, Dcsbicn-, county of Lake St.John, will apply to the Quebec Legislature, at its present session, for the adoption of an Act in order that there be annexe\"I to its present territory, a part of the municipality of Chambord, for municipal school and registration purposes, or for any other objects.Le Procureur et agent autorisé, GASTON HARVEY, 46539-48-4-0 GASTON HARVEY.46539-48-4 Attorney and authorized agent. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December .'1st.1967, Vol.89, So.51 4619 Avis public est présentement «lonné que La Municipalité Scolaire f Delisle; The Corporation of Hébert-ville; The Corporation of St.Bruno; The Corporation of St.Henri de Taillon; The Corporation of Ste.Monique.All of which are bodies politic legally constituted, having head offices in their respecti territories, all «>f which situated in the Provincial county of Lake St.John-East, hereby give notice that during the present Provincial Session, they shall submit a Bill, requesting the powi r create a zone in view of a sales tax.to be impost I throughout the municipal territory f the county of Like st.John-East, comprised of all the t< tories of the petitioners as w«dl as that of the town of Alma, town of Naudvillc.parish Alma, town of Riberbend and the town of Isle Maligne, in order that by collecting the sales tax of 2%.ami the portioning out thereof, increase the income wk.ich they are greatly in need of.Saint Joseph d'Alma, this December 7, 1057.(S) JOSEPH-ÉLIE MALTAIS, Prefect of county Council.duly authorize*!.(S) LAURENT PLOURDE, Secretary of county Council, dulv authorized.(S) J.-V.TREMBLAY, Q.C, HEN É LAMBERT, advocate, Attorneys and duly authorised 46670-51-4 Agents Avis publie est par l«'s présentes «lonné «pie lies Commissaires d'écoles pour la municipalité «le la paroisse de Saint-Félicien, dans le comté de Roberval s'adresseront à la législature de la province de Québec, au cours «le la présente session lui demandant l'adoption «l'une loi l'autorisant à imposer, dans les limites «le son territoire, une taxe d'éducation «le 1%, sur la vente au détail de tout bien mobilier vendu ou acheté dans ladite municipalité scolaire, et «le crmettre l'usage «le sirènes sur toutes les voitures-ambulances; Pour modifier la loi actuelle permettant la «'«\u2022n struct ion d'immeubles destinés à servir exclusivement de siège social à «les compagnies d'assurances sur les terrains de Mérmi; Pour demander la ratification «le certains contrats intervenus entre la cité de Québec et Terreau et Racine Limitée, entre la cité de Québec et Imperial Oil Limited, et entre la cité de Québec et Sa Majesté la Reine au «Iroit «lu Canada; Pour demander l'autorisation «le fixer l'évaluation des bâtisses appartenant à Lignosol Chemicals Limited et à Canadian Glassine *'ompany Limited; Pour demander une exemption partielle «le la taxe foncière cenéralt municipale pour une période «le cinq (5) ans sur les rampes de stationne- Public notice is hereby given that the Montreal Catholic School Commission will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session f«>r the adoption of an act to grant the Commission certain powers concerning the valuation of the immovable properties located hi the territory of the Commission but submitted, for municipal purposes, to the jurisdiction of a municipal corporation other than the city of Montreal ami also concerning the fixing of the tax rate; concerning the time when shall be DUUJle the census of the children domiciled within the territory of the Montreal Catholic School Commission; concerning the temporary loans made by the Commission; concerning its g«meral borrowing powers; concerning the signing of the bonds; concerning the expropriations made by the Commission; concerning the increase of the sales tax for educational purposes from 1 to 2% and also concerning the distribution of such tax; and for other purposes.Montreal, December 16th, 1057.GASTON POULIOT, 40702-51-4-O Attorney for the petitioner.Canada \u2014 Province of Quebec District of Gaspé Public notice is hereby given that the School Commissioners for the Municipality of Chandler, in the county of Gaspé-South, shall petition the Legislature «>f the Province of Quebec at its present session t«> obtain an amendment to the bill presented by the Corporation of the village of Chandler, so as to grant the said Commissioners the right to impose anil levy a special tax of I',' of the sunc nature, establihed on the same basis, with the same effects and subject to the same exemptions mutatis mutandis as the tax presently in force and provided by Section 4, Ch.88 of the Revised Statutes of Quebec 1941 and its amendments.Quebec, December 17th.1957*.MAURICE HUOT, q.< '.46713-5l-4-o Attorney f«>r Petitioners.Public notice is hereby given that the city of Quebec will apply to the Legislature, at its present Session, to request the power to borrow the sum of §1.000,000.00 for the extension of ('barest Boulevard, as from Boulevanl Langelier westwards; Borrow ¦ sum not exceeding S150.000.00 for the laying of permanent pavings; Bequest certain a mem I ment.s to its electoral law; To allow the using of sirens on all ambulance vehicles; To amend the existing law permitting the building of immoveables inlemled exclusively for bead offices of insurance conqiaiiies on the Mericl grounds; Request the confirmation of certaui contracts concluded lietween the city of Que!>cc an«l Terreau et Racine Limitée, the city of Quebec and Imperial Oil Limited, ami the city of Quebec and Her Majesty the Queen in the right of ( lanada; Request the authorization to fix the valuation of buildings Indonging to Lignosol Chemicals Limited and Canadian (ilassine Company Limited ; Request a partial exemption from the general municipal ground tax for a period «>f five (5) years oir parking ramps erected between May 4022 GAZETTE OFF H ' IELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 décembre 1957, Tome S9, S° 61 ment construites entra !«¦ 1er mai 1966 et le 30 avril I960; Pour demander L'autorisation de changer le site et li» direction «le la rue Octave; Pour demand* r un nouveau mode «le répartition de la taxe de vente imposée et» vertu «le la loi ô Geo.VI.chapitre 72: Pour demander enfin tous autres amendements nécessaires OU Utiles à la bonne administration de la cité.Les Procureurs r permits; c) require that no one can maintain an entreprise as funeral director ami or und< : taker, embalmcr.a funeral establishment or b morgue or any enterprise ami or establishment of this nature, or no morgue can operate, unless h«' is domiciled in the Province or that its head office is established ami it does operate in the Province, and that he is an inscribed membei of the Association or that it does employ sn inscribed member of the Association; «/) So member, as sttch, can.in regard to servie* -, rendered, after the expiration of three months from such services, be used for same; e) This lav, will not effect actual true Funeral Directors and Embalmers recognized as such by the Association; and/) And the dispositions of the Quebec Companies' Act, as far as they are applicable, arc governing the A.ss»>ciation.Quebec, 12th December, 1957.GRAVEL, THOMSON & GRAVEL, 46671-51-4-0 Attorneys for the petitioners.Actions en séparation de biens Canada.Province «!\\ accordant aux municipalités des pouvoirs spéciaux pour remédier à la crise «lu logement.3 Loi modinant'la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires «'t propriétaires.ti Loi modifiant la Loi de la prévention des incendies.s- I.ni concernant la juridiction de la Cour supérieure en matières criminelles.9 Loi modifiant l'article 37 f médical diagnosis centres in the Province.101 An Act respecting the estate f the town of Alma, of the town of Xaudville, of the municipality «>f the parish of Alma, in the county of Lake St.John.120 An Act respecting The school commissioners for the municipality of Saint-Michel «les Saints, in the county of Berthier.121 An Act respecting Theaschoo] commissioners for the municipality of the town of Nieolet, in the county of Nieolet, and The school board of the parish of Saint-Jean- Baptiste «le Nieolet.!¦\".! An Act to authorize the Bar «>f the Province of Quebec to admit Michael John Eawectt to the practice of the legal profession in the Province of Quebec.135 An Act to change the name «>f Jeanne Côté to that of Jeanne Hyland.141 Loi concernant la Société (iazifère «le Hull Incorporée.150 An Act to change the name of Jonas Sega- mogas to that of Jonas Semrtgas.151 An Act respecting Caisse Nationale d'Éco- nomie.152 An Act to amcml the Act to incorporate \"H«*>pital Général Saint-Vincent-«le-Paul «le Sherbrooke\".174 An Act respecting The school commissioners for the municipalities of Saint-Romuald d'Etchemin, Charny ami Bienville.199 An Act respecting the adoption and change of name of Ivan Rufus Williams.208 An Act to change the will of Télesphore Jeanson-La palme.209 An Act to authorise the dental surgeons of Quebec to admit Zofia Ortowska-Orny to the practice of the dental profession after examination.223 An Act to provide for the liquidation ami final partition of the estate of Dame Geor-gianna St-Gcorgcs, widow of «loctor C.A.Lortic.To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Legislative Council in the follow ui g words: 4628 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 21 décembre 1957, Tome 89, M* 51 \"Au nom «le Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.\" 17 T-oi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 195S, et pour d'autres fins.A ce bill, la sanction royale a été donnée dans les termes suivants: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur remercie ses loyaux sujets, accepte leur benevolence et sanctionne ce bill.\" 46G82-o (P.6.13787-67) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a, le treize décembre 1957, approuvé le règlement N° 1 de la \"Société d'Assistance Hospitalière\", tel qu'adopté à l'assemblée tenue le 15 septembre 1957, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec Donné au bureau du Secrétaire «le la province.le quatorze décembre 1957.Le Sous-secrétaire «le la province, 4Ô676-0 JEAN BRUCHESI.(P.G.13500-57) AniBTO CllAVAT isrCOBPORAfSD Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs de la compagnie ci-«lcssiis «le trois à quat rf the board of directors hell on November 2, 1957 ami that it was «luly approved on November s, 1957 unanimously by all the shareholders holding all the subscribed shares of the authorised capita] stock of the com* pany gathered in s special general meeting.(Seal) AIMÉ BAVARD.40091 (A.G.8943-51) Tiik Lac Maudis DlSTBICT AbbOCIATIOM Ixc.Bp-law No.! '¦¦ increasing the number of directors from eight to ten.\"The affairs of the Association shall be managed by a Board of directors of ten (10) persons ami By-law No.2 of the Association is hereby amended t«i accord herewith.\" Montreal, 19th November, 1957.Certified a true copy.A.G.THOM, 10094-o Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third Copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire «le Graiul-Hemous\" under date December 1, 1957.whereof the head office is at Grand-Remous, county of Gatineau ami that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary, Given at the office of the Provincial Secretary, this sixteenth dav of December, 1957.JEAN BRUCHÊSI, 40708 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de La Conception\" under date December 4.1957, whereof the hea«l office is at La Conception, county of Laludle and that the said document has been file«l in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this sixteenth day of December, 1957.JEAN BRUCHÊSI, 40709-O Under Secretary of the Province. 4630 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 décembre 1957.Tome 89, A'° 51 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de St-Chrysostémie\", en date «lu S décembre 1957, «lont le siège social est situé à Saint-Chrysostôme, comté de Châtcauguay, et «jue ce document a été déposé dans les archives «lu Secrétariat «le la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le seize décembre 1057.Le Sous-secrétaire «le la province, 40710-o JEAN BIUCIIESI.(P.G.4403-48) i.Guindon & Compagnie Limitée Règlement A'° .' réduisant le nombre des directeurs de cinq à trois.\"Bureau He direction: 1.Les affaires de la Compagnie seront administrées par un bureau «le «lirection composé de trois membres, dont deux formeront qUorum.\" Certifie vraie copie.Ste-Agathe-dos-Monts.ce 12 février 1957.Le Secrétaire-trésorier.40717-.RAY.GUINDON.(P.G.10160-56) Hôtel Kebec {mcobpobe Règlement N° % \"Le règlement N° 1 est modifié en amendant l'article 3 dudit règlement qui «levra se lire comme suit : 'La compagnie est administrée par un bureau «le «lirection de cpiatre membres, au lieu de trois «pi'il était auparavant.\" Certifie vraie copie «lu règlement N° 2.tel «pi'ailopté par les «lireeteurs et approuvé par les actionnaires le 28 février 1950.Le Secrétaire.40721-o PAUL THERRIEN.Chartes \u2014 Abandon de AVIS Thk Abundel Bottes & Chbsbe Mam KACTrmvc Company Limited Constituée en corporation par lettres patentes en «late du 27e jour «le février 1921 en vertu «h- la première partie «le la I/oi «les oompagnh s «!«\u2022 Québec).Conformément aux dispositions «le l'article 20 «h- la Loi «les compagnies «le Québec, \"The Arumhd Butter & Cheese Manufacturing Company Limited\" donnai par l«>s présentes, avis qu'elle s'adressera au Procun-ur général «le la province «le Québec p«»ur obtenir l'abandon «le sa charte et une directive quant à son annulation et qu'une «late soit fixée à compter «le laquelle la compagnie sera dissoute.Arundel, Québec, 10 novembre 1957.Le S«'< \u2022 ré t a irc-1 rés< trier, 46067 (Mme) M.F.COOKK.Notice is hereby given that t|ie Honourable the Provincial Secretary has duly received the thinl copy of the original of the declaration of foundation «>f the cooperative syndicate \"].& ( laisse Populaire «le St-Chrysostémie\" under date DecemberS, 1957, whereof the head office i- at Saint-Chrysostéime, county of ChAteauguay, and that the saiil document has been Hied in lin-archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary this sixteenth day of Incomber, 1957.JEAN BRUCHÊSI, 46710 Under Secretary of the Province.(A.G.4403-48) I.Guindon & Compagnie Limitée By-Law A'.-.decreasing the number of directors from five to three \"Board «»f Directors: 1.The affairs of the Company shall In- managed by a Board of Directors composed «>f three members, two of whom shall constitute a quorum.\" Certified true copy.Ste-Agathe-des-Monts, this February 12.lit:,;.RAY.GUINDON, 10717 Secretary-Treasurer.(A.G.10160-56) Ib'jTEi.hvEBEl IcNOBPOBE By-Law A'° .' \"By-law No.1 is modified by amending sectios 3 of the said by-law whiidi should rea96-o EUDES & DÈNYS Prenez avis que la compagnie \"Aima Tire Ltd.\", demandera au procureur général la permission d'abandonner sa charte.Le Procureur, 16711-0 RAYMOND LA POINTE, notaire.Prenez avis que la compagnie \"Les Cuirs Saguenay Ltée\" demandera au procureur général la permission «l'abandonner sa charte.Le Procureur, I0712-O RAYMOND LAPOINTE.notaire.Compagnies dissoutes (P.G.13463-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec.Statuts refondus «le Québec, 1941.chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 «le ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon «le la charte de la compagnie \"A.S.Johnson's Sons.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 août 1927.Avis est «le plus donné qu'à compter «lu seize décembre 1957.Ia«lite compagnie a été dissoute.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le dix-setH «lécembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, I 9-0 P.FRENETTE.(P.G.13842-56) Avis est «lonné qu'en vertu de la première partis «le la Loi «les compagnies «le Québec, Statuts refondus de Québec.1941.chapitre 276, NOTICE Please take notice that the Company \"Gauthier & Charron Constructions Inc.\" will apply to tht General Attorney for leave to surrender its charter and its cancellation after such date as he may deem fit to «letermine.PINARD & PINARD, 46677-o Attorneys for the Company.Landed Investments, Limited Notice is hereby given that Landed Investments, Limited, a corporation incorporated by letters patent dated July 13th, 1925 under the Quebec Companies' Act, under the original corporate name of Northern Lands, Limited, which corporate name was changed to Landed Investments, Limited by supplementary letters patent elated September 22nd, 1925 and having its head office at the city of Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 17th dav of December, 1957.CYRIL R.T.CUNNINGHAM, 46695-o Secretary-Treasurer.Take notice that the Company \"Western Taxi Association Limited\", will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.EUDES & DENYS, 46696 Attorneys for Company.Take notice that the company \"Alma Tire Ltd.\" wdll apply to the Attorney General for permission to surrender its charter.RAYMOND LAPOINTE, notary, 4671 l-o Attorney.Take notice that the company \"Les Cuirs Saguenay Ltée.\" will apply to the Attorney General for permission to surren«ler its charter.RAYMOND LAPOINTE, notary, 46712 Attorney.Companies Dissolved (A.G.13463-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276.R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the sai«l Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"A.S.Johnson's Sons, Lt«L\", incorporate*! bv letters patent dated August 22.1927.Notice is also given that from and after December sixteenth.1957, the sai«l company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of December, 1957.P.FRENETTE, 46659 Actbig Deputy Attorney General.(A.G.13842-56) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941.ami subject to the liability enacted 4632 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 21 décembre 1967, Tome 89, N° 61 article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Dominion Hat Mfg.Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 2 mai 1951.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659-0 P.FRENETTE.(P.G.12786-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Holly Security Company\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 septembre 192S.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1957.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659-o P.FRENETTE.(P.G.10430-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix)i des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1911, chapitra 270, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée, par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"J.C.Rogers & Company Limited\", constitutée en coiporation par lettres patentes en date du 31 mars 1937.Avis est de plus donné qu'à compter du quinze décembre 1957.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le seize décembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659-o P.FRENETTE.(P.G.13047-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec.Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"St.Maurice Valley Paper ('ompany, Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 13 août 1946.Avis est de plus donné qu'à compter du seize décembre 1957.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 46659-0 P.FRENETTE.(P.G.12051-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"The Rouyn-Noranda Publishing by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the chater of the company Dominion Hat Mfg.Co.Ltd.\", incorporated bv letters patent dated May 2, 1951.Notice is also given that from and after December fifteenth 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December 1957.P.FRENETTE, 46659 Acting Deputy Attorney General (A.G.12786-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Holly Security Company\", incorporated bv letters patent dated September 22, 1928.Notice is also given that from and after December fifteenth 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of December 1957.P.FRENETTE.46659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.10430-57) Notice is hereby given that under Part I i Quebec Companies' Act, section 20, chapter 276, R.S.Q.1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"J.C.Rogers & Company Limited\", incorporated bv letters patent dated March 31, 1937.Notice is also given that from and after December fifteenth 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of December 1957.P.FRENETTE, 46659 Acting Deputy Attorney General (A.G.13047-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 20, chapter 27li, R.S.Q.1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act.the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"St-Maurice Valley Paper Company, Inc.\", incorporated by letters patent dated August 13, 1946.Notice is also given that from and aller December sixteenth, 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of December, 1957.P.FRENETTE.46559 Acting Deputy Attorney General.(A.G.12051-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 27'i.R.S.Q., 1941.and subject to the liability enaele I by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the Surrender of the charter of the company \"The Rouyn Noranda Publishing Company Limited\", in- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 21st, 1967, Vol.89, No.61 4633 Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 juin 1933.Avis est de plus donné qu'à compter du seize décembre 1957, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 466604) P.FRENETTE.P.G.13244-57) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, Statuts refondue de Québec, 1941, chapitre 270.article 26.et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il u plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Welch Immeubles Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 octobre 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du seize décembre 1957.ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 166594) P.FRENETTE.corporated by letters patent dated June 30, 1933.Notice is also given that from and after December sixteenth, 1957, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of December, 1957.P.FRENETTE.46659 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13244-57) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.section 20, chapter 270, R.S.Q.1941.and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Welch Immeubles Limitée\", incorporated bv letters patent dated October 30, 1944.Notice is also given that from and after December sixteenth 1957.the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of December 1957.P.FRENETTE, 46659 Acting Deputy Attorney General.Département des Affaires municipale Le soussigné donne avis que, tel Que demandé par une résolution adoptée le 2 décembre 1957 par le conseil municipal de Is paroisse de Notre-Dame de la Providence, comté de Bcauce, et conformément eus dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a décrété, en date du 11 décembre 1957.une les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la corporation de la paroisse de Notre-Dame de la Providence, sauf celles requises dans la Gazette officielle de Québec, se feront, à l'avenir, dans la langue française seulement.I,e présent avis est publié en vertu de l'article 131 du Code municipal, (10 George VI.chapitre 5, section 2).Québec, le 11 décembre 1057.\\a' Ministre des Affaires municipales, 16660-0 PAUL DOZOIS.Département de l'Instruction Publique \\° 1182-56.Québec, le 5 décembre 1957.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Armand-Ouest, dans le comté de Missisquoi, les lots 74 et 75 du cadastre officiel de Philipsburg, pour les annexer, pour les contri-huables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de St-Philippe-de-Philipshurg, «lans le même comté.Le Surintendant «le l'Instruction publique.1M35-50-2-O O.J.DESAITLN1 ERS.\\° 1109-57.Québec, le 5 décembre 1957.Demande est faite «l'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire «le Côte «les Laçasse, dans le comté de Laval, à la municipalité scolaire I' Ville de Ste-Rose, dans le même comté.Le Surintendant «le l'Instruction publique, 46636-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS.Department of Municipal Affairs The undersigned gives notice that, as requested by a resolution adopted December 2, 1957 by the Municipal Council of the parish of Notre-Dame «le la Providence, county of Bcaucc.and pursuant l«> the provisions of article 130 of the Municipal Code, he has enacted, Under dak of December 11, 1957, that the publication of any public notice, by-law, resolution or order of the Corporation of the parish of Notre-Dame de la Providence, except such SS are required to be made in the Quebec Official Gazette, shall be ma«le hereafter in the French language only.This notice is published in accordance with article 131 of the Municipal C«xle (10 George VI.chapter 55, section 2).Quebec.December II, 1957.PAUL DOZOIS.46660 Minister of Municipal Affairs.Department of Education No.1182-56 Quebec, December 5, 1957.Application is made to detach from the school municipality of St-Armand-West, in the county of Missisquoi, lots 74 and 75 of the official ca«las-ter of Philipsburg, to annex them, for the Catholic ratepayers only, to the school municipality of St-Philippe-«le-Philipsburg, in the same county.O.J.DÉSAULNIERS, 46635-50-2 Superintendent of Education.No.1109-57.Quebec.December 5, 1957.Notice is made to annex the present territory of the School Municipality of Côte «les Laçasse, in the county of Laval, to the School Municipality of the town of Ste.Rose, in the same county.O.J.DÉSAULNIERS.46636-50-2 Superintendent of Education. 4634 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 décembre 1967, Tome S9, N° 61 N° 805-56.Québec, le 6 décembre 1957.Avis est par la présentes donné, que je me propose d'ériger en municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"La municipalité scolaire de Sanmaur, dans le comté de Laviolette\" le territoire des cantons Dessane et Lava liée, comté de Laviolette, moins toutefois la réserve indienne de Weymontachingue, située dans ce territoire.Le Surintendant de l'Instruction publique, 46644-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS, N° 1255-53.Québec, le 13 décembre 1967.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 6 décembre 1957, de corriger l'item 2 de l'arrêté en conseil N° 1009, en date du 10 octobre 1957, concernant la municipalité scolaire de LaBostonnais, dans le comté de Laviolette, de manière à ajouter au territoire attribué à cette municipalité scolaire, soit tout le canton Bourgeois, le territoire ci-dessous décrit qui avait été omis: \"Bloc \"H\", les lots 1 à 8 inclusivement des rangs nord-ouest et sud-est et les lo!s 1 à 17 inclusivement du rang II, tous du canton Mail-hot\".Ce changement prend effet immédiatement'.Le Surintendant de l'Instruction publique, 46683-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 778-57.Québec, le 16 décembre 1957.Il a plu au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 6 décembre 1957, de détacher le territoire ri-dessous déerit de la municipalité scolaire de Ste-Marie-dc-Monnoir, dans le comté de Rouville, pour l'annexer à la municipalité scolaire de Marieville, même comté.Une terre située en la paroisse de Ste-Marie-de-Monnoir, dans le rang du Ruisseau Barré, côté est, mesurant environ cent arpents en superficie, plus ou moins, composée des lots 281 et 281-A et d'une partie des lots P.279 et P.280 aux Slan et livre de renvoi officiels de ladite paroisse e Stc-Marie-de-Monnoir; avec la maison et les autres bâtisses y érigées.Cette partie du lot P.279 mesurant environ vingt et un arpents en superficie, est bornée à l'est par ledit lot N° 281-A, à l'ouest par le reste dudit N° P.279, appartenant à M.Laurent Boulais; du côté nord par le lot 278 desdits plan et livre de renvoi officiels appartenant a M.Femand Thébergc; et du côté sud par la partie ci-après décrite dudit lot P.280.Et cette partie dudit lot P.280 mesurant aussi vingt et un arpents en superficie est bornée à l'est par ledit lot P.281; à l'ouest par le reste dudit lot P.280 appartenant audit Laurent Boulais; au nord par la partie sus-décrite dudit lot P.279 et du côté sud par le lot N° 282 desdits plan et livre de renvoi officiels.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1958.Le Surintendant de l'Instruction publique, 46683-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 1302-57.Québec, le 16 décembre 1957.Demande est faire de charger le nom de la municipalité scolaire de bal idle canton, dans le comté de Labelle, en celui de \"La municipalité scolaire de Lac Labelle, dans le comté de Isabelle\".Le Surintendant de l'Instruction publique, 64684-51-2-o O.J.DÉSAULNIERS.No.805-56.Quebec, December 6, 1957.Notice is hereby given that I propose to erect into a separate school municipality, under the name of \"The school municipality of Sanmaur, in the county of Laviolette\", the territory of tin townships of Dessane and La vallée, county of Laviolette, less however, the Indian Reserve of Weymontachingue, situate in this territory.O.J.DÉSAULNIERS, 46644-50-2 Superintendent of Education No.1255-53.Quebec, December 13, 1957.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated December 6, 1957, has been pleased to correct item 2 of Order in Council No.1C09, dated October 10, 1957, concerning the school municipality of LaBostonnais, in the county of Laviolette, so sa to add to the territory attributed to the school municipality, i.e., all the township Bourgeois, the territory herebelow described which had been omitted: \"Block \"H\", lots 1 to 8 inclusively of rangea northwest and southeast and lots 1 to 17 inclusively of range II, all of the township of Mailhot\".This change will take effect immedialclv.O.J.DÉSAULNIERS.46683 Superintendent of Education.No.778-57.Quebec, December 16, 1957.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated December 6.1957.has been pleased to detach the School Municipality of Ste-Marie-de-Monnoir, in the county of Rouville, the territory herein under described in order that it be annexed t the School Municipality of Marieville, same county.\"A farm sit un ted in the parish of Ste.Marie ae Monnoir, in range Ruisseau Barré, east side, measuring some one hundred arpents in ana.more or less, composed of lots 281 end 281-A and of a part of lots P.279 and P.280 of the officiel plan and book of reference of said parish of 9te.Marie-de-Monnoir; with house ami other buildings erected thereon.This part of lot P._'7(J measuring some twenty-one arpents io ana.i> bounded easterly by said lot No.281-A, westerly by the balance of said lot No.P.279 belonging to Mr.Laurent Boulais; on the northerly side by lot 278 of said official plan and book of refe-rence, belonging to Mr.Fernand Thébergc; on the southerly side by that part hereinafter described of said lot P.280.And this part of said lot P.280 also measuring twenty-one arpenta in area is bounded easterly by said lot P.281; esterly by the balance of said lot P.280 belong-in g to said Laurent Boulais; northerly by that part described hereinabove of said lot P.27fl and southerly by lot No.282 of said official plan and book of reference.This change will take effect on July 1st, 1958.O.J.DÉSAULNIERS.46683 Superintendent of Education.No.1302-57.Quebec, December 16.1957.Application is made to change the name f the School Municipality of the township «>f Labelle, in the county of Labelle, to that of \"The School Municipality of Lake Labelle.in the county of Labelle\".O.J.DÉSAULNIERS.46684-51-2 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December S1st, 1957, Vol.89, No.51 4635 V 487-57.Québec, le 16 décembre 1957.Il a plus au Lieutenant-Gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 6 décembre 1967, de changer le nom de la municipalité scolaire protestante de McMasterville, dans le comté de Verchères, en celui de \"La municipalité -c-ilaire protestante «le McMasterville & Belœil, dans le comté de Verchères.Ce changement prendra effet le 29 «lécembre 1957.I.c Surintendant «le l'Instruction publique, 16683* O.J.DÉSAULNIERS.No.487-57.Quebec.December 16, 1957.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council, dated December 6, 1957, has been pleased to change the name of the Protestant School Municipality of McMasterville, in the county of Verchères, into that of \"The Protestait School Municipality of McMasterville & Belœil, in the county of Verchères.This change will take effect on December 29, 1957.0.J.DÉSAULNIERS, 46683 Superintendent of Education.Département des Mines Province «le Québec Ministère des Mines avis de revocation de droits de mine Conformément aux articles 50, 51, 51A et suivants de la Loi des Mines de Québec (S.R.Q.1941, ch.196) tels qu'amendés par 3-4 Elizabeth II, Ch.38, avis est présentement «lonné aux détenteurs des droits de mine sur les terrains ci-|i MOUS mentionnés qu'après un délai «le quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent avis, le Ministre des Mines recommandera au I.ieutenant-gouvemeur en conseil la révocation rpiant aux «Iroits «le \"mine de ces terrains, si l'exploitation d'iceux est demeurée inactive pendant les vingt et une années qui ont suivi le 1er mars 1934, à savoir: Dans le canton de Broughton Bang XI, lot 13.Dans le canton de Cranbourne Bang A.lots 22, 23 et 24.Dans le canton-de Dorset Bang XII.lots 1 et 2; Hang XIII.lots 1 et 2.Dam le canton de Garthby Rang III.lot 16.Dam le canton de Hartwell Hang II, lot B; Rang HI, lots A, B et 12.Dane le canton de Ireland Bang V, lots 19 (308 et 309 cadastre) et 20 (310, 311 et 312 cadastre); Rang VI, lot 18 (337 cadastre) (V* sud-est St \\4 nord-ouest de nord-ouest).Dans le canton de Mann Rang Rivière du Loup Nord, lots 3, 5, 6, 7 st 8.Québec, le 12 décembre 1957.Le Sous-ministre, 46073-61.2-0 A.0.DUFRESNE.Department of Mines Province of Quebec Department of Mines Notice of revocation of mining rights Pursuant to sections 50.51.51A and following of the Quebec Mining Act (R.S.Q.1941, ch.196) as amerded by 3-4 Elisabeth II.ch.38, notice is hereby given to the holders of mining rights on the parcels of land hereunder liste»! that after a delay of ninety days from the date of the present notice, the Minister of Mines will recommend to the Lieutenant-Governor in Council the revocation of the mining rights on these concessions of land, the working of which has remained inactive during the twenty-one years following the first of March 1934, to wit: In Broughton toicmhip Range XL lot 13.In Cranbourm toicrukip Range A, lots 22, 23 and 24.In Dorset toicmhip Range XII.lots 1 and 2; Range XIII.lots 1 and 2.In Garthby township Range III.lot 16.7m Hart well township Range IT lot B; Range III.I«>ts A.B and 12.7» Ireland towmhip Range V, lots 19 (308 and 309 cadastral lots) and 20 (310.311 and 312 cadastral lots); Range VI, lot 18 (337 cadastral lot) (Southeast and north-west ^ of north-west }^).7n Mann towmhip Range Rivière du Loup North, lots 3, 5, 6, 7 and 8.Quebec.December 12th, 1957.A.O.DUFRESNE, 40073-51 -2-o .Deputy Minister. 4636 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21 décembre 1957, Tome 89, A'0 61 Départements des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foye, (municipalité de cité de Ste-Foy), division \u2022 l'enregistrement «le Québec.Avis est par la présente donné que le lot 294-A cet annulé en vertu de l'article 2174A du Code isvil.Québec, le 5 décembre 1957.Département clés Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 46661-o AVILA BÉDARD.Cadastre officiel de la paroisse de St-Laurent, (municipalité de cité de St-Laurent), division £ 'd'enregistrement de Montréal.Avis est pa la présente donné que les lots 239-10 à 239-20 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 6 décembre 1957.Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 46661-0 AVILA BÉDARD.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the parish of Ste-Foye, (municipality of city of Ste-Foy), registration division of Quebec.Notice is hereby given that lot 294-A has been cancelled in virtue of article 2174A of the Civil Code.Quebec, December 5, 1957.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 46661 -o Deputy Minister Official cadastre of the parish of St-Laurent, (municipality of city of St-Laurent), registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 239-10 t
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.