Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 janvier 1957, samedi 19 (no 3)
[" Tome 89, N° 3 169 Vol.89, No.3 \t\t \ti\t \t¦\t *-\t\t Drapeau de la province de Québec adopté p*r la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by ihe Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Quebec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) ' PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 19 janvier 1957 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéresses, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc, sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, January 19th, 1957 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 170 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction : 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.\\ Abonnement: $7 par année.\\ N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion: le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the.first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) al double rate.Translation : 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: Si.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure referstoour document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502-1-52 Lettres patentes (P.G.13645-56) Big Nell Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un nomvembre 1956, constituant en corporation: John Austin Murphy, C.R., Pierre Décary, tous deux avocats, Francis Joseph Dolan, comptables, Mildred Murphy, ménagère et fille majeure, Eleanor Hart, Julie Thibault, toutes deux secrétaires et filles majeures et Arthur Quesncl, commis, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire des explorations et recherches pour découvrir des mines et minerais y compris des terrains et gisements d'huiles et de gaz et les négocier, sous le nom de \"Big Nell Mines Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de §5,000,000, divisé en 5,000.000 d'actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront Letters Patent (A.G.13645-56) Big Nell Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the.Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of Novemger, 1956, incorporating: John Austin Murphy, Q.C., Pierre Decary, both advocates, Francis Joseph Dolan, accountant, Mildred Murphy, housekeeper, and unmarried woman of the full age of majority, Eleanor Hart, Julie Thibault, both secretaries, and unmarried women of the full age of majority, and Arthur Quesnel, clerk, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals including oil and gas lands and deposits and deal with the same, under the name of \"Big Nell Mines Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 85,000,000, divided into 5,000,000 common shares of a par value of 81 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsiblityin excess of the amount QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.3 171 payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 14081 P.FRENETTE.(P.G.13562-56) Canada-Europe Hardware Import Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente novembre .1956, constituant en corporation: Nathan A.Lcvitsky, de ville Mont-Royal, Solomon Weber, d'Outrcmont et Harold Lande, de Wcstmounts tous trois avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de produits composés en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et sous-produits, sous le nom de \"Canada-Europe Hardware Import Ltd.\", avec un capital total de 850,000, divisé en 250 actions ordinaires de 8100 chacune et 250 actions provilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 14081 P.FRENETTE.(P.G.13542-56) Canadian Carmel Kosher Wine Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente novembre 1956, constituant en corporation: Leon David Crestohl, avocat, Abraham Harold Crestohl, gérant, et Donald William Seal, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de vins et produits d'iccux pour usage sacramentel et autres, sous le nom de \"Canadian Carmel Kosher Wine Co.Ltd.\", avec un capital total de 820,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 41081 P.FRENETTE.(P.G.13711-56) (li il» town Copper Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1956, constituant en corporation: Henri Crépeau, Jean Miquelon, tous deux avocats et Conseils en Loi de la Reine et Charles Edward Gibson, agent, tous de Montréal, pour les objets suivants : Faire des explorations et recherches pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Chibtown Copper Corporation\" (No Personal Liability), avec un capital total de of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13562-56) Canada-Europe Hardware Import Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November, 1956, incorporating: Nathan A.Levitsky, of the town of Mount Royal, Solomon Weber, of Outrcmont, and Harold Lande, of Westmount, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in products made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products, under the name of \"Canada-Europe Hardware Import Ltd.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 250 common shares of 8100 each and into 250 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13542-56) Canadian Carmel Kosher Wine Co.Ltd.\"Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November, 1956, incorporating: Leon David Crestohl, advocate, Abraham Harold Crestohl, manager, and Donald William Seal, advocates, all of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in v/ines and wine products for sacramental and other purposes, under the name of \"Canadian Carmel Kosher Wine Co.Ltd.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 2,000 common shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13711-56) Chibtown Copper Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1956, incorporating: Henri Crépeau, Jean Miquelon, both advocates and Queen's Counsels, and Charles Edward Gibson, agent, all of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Chibtown Copper Corporation\" (No Personal Liability), with a total capital stock of 85,000,000, 172 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 $5,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions de $1 chacune.T^es actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1950.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.13046-56) Cires Realty Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux novembre 1956, constituant en corporation: Harold S.Freeman, avocat, Dorothy Martel et Theresa Murray, toutes deux secrétaires, filles majeures, tous de Motnréal, pour les objets suivants: Négocier des propriétés immobilières, sous le nom de \"Cires Realty Co.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 600 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procuruer général, le vingt-deux novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.12182-56) Club Social St-Jean-Port-Joli Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Germain Verrcault, Lucien Verrcault, négociants, et Wilfrid'Richard, entrepreneur, tous trois de St-Jean-Port-Joli, pour les objets suivants: Procurer aux membres, à leurs parents et amis, des loisirs sains de toutes sortes; conférences, causeries, forums, théâtre, lectures et sports, sous le nom de \"Club Social St-Jean Port-Joli\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 830,000.Le siège social de la corporation sera à St-Jean-Port-Joli, district judiciaire de Montmagny.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13660-56) Connaught Inn Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un novembre 1956, constituant en corporation: Morgan Carlyle Johnston, avocat, Miriam D.Roberts, secrétaire, fille majeure et David James Dohan, avocat, de Westmount, pour les objets suivants: divided into 5,000,000 shares of 81 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13646-56) Cires Realty Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1956, incorporating: Harold S.Freeman, advocate, Dorothy Martel and Theresa Murray, both secretaries, spinsters of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To deal with immoveable properties, under the name of \"Circs Realty Co.\", with a total capital stock of 875,000,' divided into 1,500 common shares of the par value of 810 each and into 600 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.12182-56) Club Social St-Jean-Port-Joli Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Germain Verrcault, Lucien Verrcault, dealers, and Wilfrid Richard, contractor, all three of St-Jean-Port-Joli, for the following purposes: To procure for members, their relatives and friends, healthy recreations of all kinds; conferences, talks, forums, theatricals, lectures and sports, under the name of \"Club Social St-Jean Port-Joli\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 830,000.The head office of the corporation will be at St-Jcan-Port-Joli, judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13660-56) Connaught Inn Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of November, 1956, incorporating: Morgan Carlyle Johnston, advocate, Miriam D.Roberts, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, and David James Dohan, advocates, of Westmount, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.3 173 Exercer le commerce comme hoteliers, aubergistes, restaurateurs, propriétaires de café et garagistes, sous le nom de \"Connaught Inn Inc.\", \u2022avec un capital-actions divisé en 2,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et !)00 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à North Ilatley, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un novembre 1950.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.13850-56) David B.Granofshy & Sons Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1956, constituant en corporation: Jack Rudner, Joseph Mendclson, tous deux avocats et Celia Cohen, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des marchés, parcs à bestiaux et maisons de fonte des matières grasses; exercer le commerce de produits alimentaires, résidus métalliques et ferrailles, sous le nom de \"David IJ.Granofsky & Sons Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4758 avenue McAlear, ville de Côte St-Luc, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 11081 P.FRENETTE.(P.G.13540-56) Eastern Machinery & Equipment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept novembre 1956, constituant en corporation: Samuel Omit, Harry L.Aronovitch, tous deux avocats, Max Shcnker, étudiant en droit et John Hamilton, secrétaire, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme fondeurs en fer et fabriquer et faire le négoce de moteurs, machinerie, outils et instruments de toutes sortes, sous le nom de \"Eastern Machinery & Equipment Ltd.\", avec un capital total de 850,000, divisé en 40,000, actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune et 10,000 actions ordinaires (rune valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant.M081 P.FRENETTE.(P.G.13745-56) Edouard Robitaille Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dé Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf novembre 1956, constituant en corporation: Georges Bellerive, Gaston Durand, To carry on business as hotel, inn.restaurant, cafe and garage keepers, under the name of \"Connaught Inn Inc.\", with a capital stock divided into 2,000 common shares without nominal or par value and into 900 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will be at North Hatley.judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of November, 1956.P.FRENETTE, 440S1-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13850-56) David B.Granofsky & Sons Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1956, incorporating: Jack Rudner, Joseph Mendclson, both advocates, and Celia Cohen, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To operate markets, stockyards and rendering houses; to deal with food products, scrap metals and irons, under the name of \"David B.Granofsky & Sons Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of S100 each and into 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at 4758, McAlear Avenue, town of Côte St.Luc, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13540-56) Eastern Machinery & Equipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of November, 1956, incorporaitng: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, both advocates, Max Shcnker, law student, and John Hamilton, secretary, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as iron founders and to manufacture and deal in engines, machinery, tools and implements of all kinds, under the name of \"Eastern Machinery & Equipment Ltd.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 40,000 preferred' shares of the par value of SI each and into 10,000 common shares of the par value of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Tated at the office of the Attorney General, this twentv-scventh day of November, 1956.P.FRENETTE, 4408l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13745-56) Edouard Robitaille Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1956, incorporating: Georges Bellerive, Gaston Durand, laborers, and 174 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 journaliers, et Edouard Robitaille, industriel, tous de Shawinigan-Sud, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux, briqueteurs et poseurs de pierre, sous'le nom de \"Edouard Robitaille Inc.\", avec un capital divisé en 1,200 actions sans valeur au pair ou nominale et en 1,300 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1485, 5ième avenue, Shawinigan-Sud, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13740-56) Emile Séguin & Fils Limitée Emile Séguin & Sons Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf novembre 1956, constituant en corporation: J.-Emile Séguin, François Séguin, Gérald Séguin, Emilien Séguin, tous quatre plombiers, et Yvon Séguin, comptable, tous de Hull, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage, réfrigération et faire l'installation d'appareils d'arrosage, de climatisation de l'air et d'extincteurs d'incendie, sous le nom de \"Emile Séguin & Fils Limitée\u2014Emile Séguin & Sons Limited\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hull, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13716-56) Eugene Thérien & Jean-Guy Chartrand Incorporés Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1956, constituant en corporation: Eugène Thérien, évaluateur en immeuble, Jacqueline Gagné, secrétaire, tous deux de Montréal, et Jean-Guy Chartrand, courtier, de Laval-des-Rapides, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers en assurances; exercer le commerce d'appareils, machines, dispositifs et accessoires pour la prévention des incendies, sous le nom de \"Eugène Thérien & Jean-Guy Chartrand Incorporés\", avec un capital total de'$25,000, divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 84, rue Notre-Dame, ouest, suite 52, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13718-56) Garage Gemme & Alix Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Edouard Robitaille, industrialist, all of Shawini-gan-South, for the following purposes: To carry on business as general contractors, bricklayers and stone-setters, under the name of \"Edouard Robitaille Inc.\", with a capital stock divided into 1,200 shares without nominal or par value and into 1,300 preferred shares of $25 each.The head office of the company will be at 1485, 5th Avenue, Shawinigan-South, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-tinth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13740-56) Emile Séguin & Fils Limitée Emile Séguin & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quegec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1956, incorporating: J.-Emile Séguin, François Séguin, Gérald Séguin, Emilien Séguin, all four plumbers, and Yvon Séguin, accountant, all of Hull, for the following purposes: To carry on business as contractors in plumbing, heating, refrigeration and to install spraying apparatus, air-conditioning and fire extinguishers, under the name of \"Emile Séguin & Fils Limitée \u2014 Emile Séguin & Sons Limited\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of S100 each.The head office of the company will be at Hull, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13716-56) Eugène Thérien & Jean-Guy Chartrand Incorporés Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1956?incorporating: Eugène Tnérien, real estate appraiser, Jacqueline Gagné, secretary, both of Montreal, and Jean Guy Chartrand, broker, of Laval-des-Rapides, for the following purposes: * To carry on business as insurance brokers; deal in apparatus, machines, fire-protection devices and accessories, under the name of \"Eugène Thérien & Jean-Guy Chartrand Incorporés\", with a total capital stock of $25,000, divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at 84 Notre-Dame Street, West.Suite 52, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13718-56) Garage Gemme & Alix Inc.Notice is hereby given that imder Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 175 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1956, constituant en corporation: Gérard Alix, mécanicien, Alfred Gemme et Marcel Chapdelaine, comptables, tous trois de Granby, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et de véhicules de toutes sortes, de meu-l»les, d'appareils et accessoires électriques; faire affaire comme garagistes; exercer le commerce du transport, sous le nom de \"Garage Gemme & Alix Lie\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $50 chacune et en 600 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera 385, rue Dufferin, Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 4I081-o P.FRENETTE.(P.G.13615-56) Glemvood Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept novembre 1956, constituant en corporation: Jonathan J.Robinson, avocat, Jean Mcl-'arlane, réceptionniste, fille majeure, toirs deux de Montréal, et Theodore H.Shapiro, avocat, de ville Mont Royal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Glemvood Realties' Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montreal, district judiciaire de Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 4-1081 P.FRENETTE.(P.G.13748-66) Golden Triangle (Que.) Investment Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre 1956, constituant en corporation: Gregory Charlap, Max Slapack, Ions deux avocats, Harry Closner, gérant de crédit, Muriel Dyall et Sylvia Teitlebaum, toutes deux secrétaires, filles majeures, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et améliorations, sous le nom de \"Golden Triangle (Que.) Investment Company\", avec un capital-actions divisé en 1.200 actions sans valeur nominale ou au pair et 6,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1956, incorporating: Gérard Alix, mechanic, Alfred Gemme and Marcel Chapdelaine, accountants, all three of Granby, for the following purposes: To carry on>the business of and deal in automobiles and vehicles of every nature and kind, furniture, electrical apparatus and appliances; operate as garage-keepers; deal in forwarding, under the name of \"Garage Gemme & Alix Lie\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 850 each and 600 preferred shares of $50 each.The head office of the company will be at 385 Dufferin Street, Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13615-56) Glcnwood Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of November, 1956, incorporating: Jonathan J.Robinson, advocate, Jean McFar-lane, receptionist, spinster, both of Montreal, and Theodore H.Shapiro, advocate, of the town of Mount Royal, for the following purposes: To carry on the business of an investment ' company, under the name of \"Glcnwood Realties Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13748-56) Golden Triangle (Que.) Investment Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of November, 1956, incorporating: Gregory Charlap, Max Slapack, both advocates, Harry Closner, credit manager, Muriel Dyall and Sylvia Teitelbaum, both secretaries, spinsters of the full age of majority, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Golden Triangle (Que.) Investment Company\", with a capital stock divided into 1,200 shares having nonominal or par value and into 6,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.P.G.13735-56) Hav-A-Bite Cafeteria Inc.(A.G.13735-56) Hav-A-Bitc Cafeteria Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have 176 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1956, constituant en corporation: Jack Hudncr, Joseph Mendclson, tous deux avocats et Celia Cohen, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme restaurateurs, sous le nom de \"Havre-A-Bite Cafeteria Inc.\", avec un capital total de S40.000, divisé en 200 actions ordinaires de S100 chacune et 200 actions privilégiées de SI 00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 609 ouest, rue Notre-Dame, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.13056-56) Hôpital Saint-Michel Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Louis-Philippe Marcotte, industriel, Joscph-Ubald Touchette, commerçant, Joseph-Arsène Madore.contrôleur, Jean Archambault, anesthésiste, et Marcel Beau-champ, chirurgien, tous de Montréal, pour les objets suivants: Administrer un hôpital et tous les services organisés dans un hôpital, sous le nom de \"Hôpital Saint-Michel\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 8300,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13736-56) J.P.Bérubé Diamond Drilling Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf novembre 1956, constituant en corporation: Ulrie Gariépy, employé civil retraité, Gaston Duval, comptable et Claire-Hélène Duval, comptable, fille majeure, tous de Val-d'Or, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs généraux, foreurs et trouveurs de mines, sous le nom de \"J.P.Bérubé Diamond Drilling Co.Ltd.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,000 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val-d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.13752-56) J.P.Trépanier Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres^patentes, en date been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1956, incorporating: Jack Rudncr, Joseph Mendclson, both advocates, and Celia Cohen, secretary, spinster, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurant keepers, under the name of \"Hav-A-Bite Cafeteria Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 609, Notre-Dame Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13656-56) Hôpital Saint-Michel Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Louis-Philippe Marcotte, industrialist, Joseph Ubald Touchette.merchant, Joseph-Arsène Madore, controller.Jean Archambault, anaesthetist, and Marcel Beauchamp, surgeon, all of Montreal, for the following purposes: To manage a hospital and all departments organized in a hospital, under the name of \"Hôpital Saint-Michel\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8300,000.The head office of the corporation will be at Saint-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13736-56) J.P.Bérubé Diamond Drilling Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1956, incorporating: Ulric Gariépy, retired civil servant, Gaston Duval, accountant, and Claire-Hélène Duval.accountant, of full age, all of Val-d'Or, for the following purposes: To carry on business as general contractors, drillers and mine locators, under the name of \"J.P.Bérubé Diamond Drilling Co.Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Val-d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13752-56) J.P.Trépanier Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.3 177 du vingt-sept novembre 1956, constituant en corporation: Jean-Paul Trépanier, manufacturier, d'Oka, Paul Trépanier, avocat, de Lacbine, et Lucien Lacbapelle, étudiant, de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux; exercer le commerce du bois et de matériaux de construction, -sous le nom de \"J.P.Trépanier Limitée\", avec un capital total de S40,000, divisé en 2,000 actions communes de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social* de la compagnie sera à Oka, comté Deux-Montagnes, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13666-56) J.R.Deslauricrs Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettrse patentes, en date du vingt-six novembre 1956, constituant en corporation: J.-Rémi Deslauriers, entrepreneur de pompes funèbres, Angéline Descary, ménagère, épouse séparée de biens dudit J.-Rémi Deslauricrs, tous deux de Saint-Laurent, et Jean-M.Beyries, courtier en assurances, d'Outremont, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs de-pompes funèbres; exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"J.R.Deslauriers Ltée\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 790, boulevard Sainte-Croix, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13505-56) Justin Dallaire Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept novembre 1956, constituant en corporation: Justin Dallaire, industriel, Mme Antoinette Villeneuve Dallaire, ménagère, épouse séparée de biens, dudit Justin Dallaire, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Ville d'Alma, et Adrien Lachance, compatable, de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de la ferronnerie, de matériaux de construction, d'outillage, d'ustensiles, de machinerie et de meubles; faire affaires comme entrepreneurs en construction, sous le nom de \"Justin Dallaire Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 250 actions privilégiées de $100 chacune et en 750 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 11, rue Gagnon, Ville d'Alma, district judiciaire de Ro-berval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 4408l-o P.FRENETTE.seventh day of November, 1956, incorporating: Jean-Paul Trépanier, manufacturer, of Oka, Paul Trépanier, advocate, of Lachine, and Lucien Lachapclle, student, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors; to operate and deal in the lumber business and in building material, under the name of \"J.P.Trépanier Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Oka, county of Tow-Mountains, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13666-56) J.R.Deslauricrs Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1956, incorporating: j.-.Rémi Deslauriers, undertaker, Angéline Descary, housewife, wife separate as to property of the said J.-Rémi Deslauricrs, both of Saint Laurent, and Jean M.Beyries, insurance broker, of Outre-mont, for the following purposes: To carry on business as undertakers; deal in real estate under the name of \"J.R.Deslauriers Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will l>c at 790 Saint Croix Boulevard, Saint Laurent, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13505-56) Justin Dallaire Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of November, 1956, incorporating: Justin Dallaire, industrialist, Mrs.Antoinette Villeneuve Dallaire, housewife, wife separate as to property of the said Justin Dallaire, and duly authorized by him for these present purposes, both of the Town of Alma, and Adrien Lachance, accountant, of Quebec, for the following purposes: To carry on a business dealing in ironware, building material, equipment, utensils, machinery and furniture; to carry on business as contractors in construction, under the name of \"Justin Dallaire Ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 250 preferred shares of $100 each and into 750 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 11, Gagnon Street, Town of Alma, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General. 178 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 (P.G.13870-56) La Corporation de l'Ordre des Carmes Déchausses Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six décembre 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Louis Guillet, en religion, Père Louis de Ste-Thérèse, Robert Fabc, en religion, Père Dominique de St-Joseph, tous deux de l'Ordre des Carmes Déchaussés et tous deux aumôniers, de Montréal, et Jean Saclcy, contremaître, de Saint-Laurent', pour les objets suivants: Fonder et administrer des maisons de retraite, d'enseignement, d'entraînement et de centres éducatifs, et employer et payer des professeurs et des instituteurs à ces fins, sous le nom de \"La Corporation de l'Ordre des Carmes Déchaussés\".Le montant des revenus annuels des propriétés immobilières que la corporation peut détenir, ne pourra excéder 8100,000.Le siège social de la corporation sera à Nicolet, district judiciaire de Nicolet.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13655-56) Laprairic Shopping Centre Ltd.Centre d'Achat Laprairic Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1956, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, Melvin Leonard Rothman, avocats, tous deux de Westmount et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et développer une propriété immobilière dans ou dans les environs de la municipalité de Laprairic; exploiter un centre commercial et d'achat, sous le nom de \"Laprairie Shopping Centre Ltd.\u2014 Centre d'Achat Laprairie Ltée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.13628-56) Le Prêt d'Honneur LaSalIien Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Georges-H.Boutet, employé civil fédéral, Paul-E.Blond eau, garagiste, Jhonny Parent, gérant de manufacture, Robert Parent, Charles-Ernest Savard, agents d'assurances, et Edouard Gravel, instituteur, tous de Loretteville, pour les objets suivants: Par des prêts consentis sans but lucratif ou intérêt, aider tout élève, étudiant ou adolescent résidant dans les limites des municipalités de la ville de Loretteville et de la paroisse de St-Ambroise de la Jeune Lorette, comté de Québec, à parfaire leur instruction et leur formation mora- (A.G.13870-56) La Corporation de l'Ordre des Carmes Déchaussés Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1956, incorporating as a corporation without share capital: Louis Guillet, in religion, Father Louis de Ste-Thérèse, Robert Fabc, in religion, Father Dominique de St-Jo-seph, both of the order of des Carmes Déchaussés and chaplains, of Montreal, and Jean Sacley, foreman, of Saint Laurent, for the following purposes: To found and manage retirement homes, educational and training establishments and instructive centres, hire and pay professors and teachers for said purposes, under the name of \"La Corporation de l'Ordre des Cannes Déchaussés\".The amount to which the annual revenue issuing from the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8100,000.The head office of the corporation will be at Nicolet, judicial district of Nicolet.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1956.P.FRENETTE, 41081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13655-56) Laprairic Shopping Centre Ltd.Centre d'Achat Laprairic Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1956, incorporating: Philip Fischel Vineberg.Melvin Leonard Rothman, advocates, both of Westmount, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montreal, for the following purposes: To acquire and develop immoveable property in or in the vicinity of the municipality of Laprairie; to operate a commercial and shopping centre, under the name of \"Laprairie Shopping Centre Ltd.\u2014 Centre d'Achat Laprairie Ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13628;56) Le Prêt d'Honneur LaSalIien Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Georges II.Boutet, federal civil servant, Paul E.Blondcau, garage-keeper, Johnny Parent, factory manager, Robert Parent, Charles Ernest Savard, insurance agents, and Edouard Gravel, teacher, all of Loretteville, for the following puq>oses: By means of loans granted without pecuniary gain or interest, assist any pupil, student or adolescent residing within the limits of the municipalities of the town of Loretteville and the parish of St.Ambroise of Jeune Lorette, county of Quebec, to complete his studies as ewll as his moral QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.3 179 le et intellectuelle, sous le nom de \"Le Prêt d'Honneur LaSalIien Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Loretteville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13478-56) Les Immeubles Pro-Can Limitée Pro-Can Realties Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1956, constituant en corporation André Forget, avocat et Conseil de la Reine, d'Outremont, Joan Clark, avocat, célibataire, William Patrick Creagh, clerc, tous deux de ville Mont-Royal, Clifford George Meek et Guy Ambrose Miller, tous deux teneurs de livres, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles dans toutes ses branches, faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Les Immeubles Pro-Can Limitée \u2014 Pro-Can Realties Limited\", avec un capital total de §1,100.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 10,000, «actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social-de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 11081-o P.FRENETTE.(P.G.13801-56) Les Produits Cardinal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décember 1956, constituant en corporation: Maurice Cardinal, pomiculteur, de Mont Saint-Hilaire, Gérard- Vincent, agronome, de Saint-Hyacinthe, et Gervais Vincent, agronome, de la paroisse de Douville, Saint-Hyacinthe, pour les oh jets suivants: Exercer le commerce de produits agricoles, sous le nom de \"Les Produits Cardinal Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont Saint-Hialire, comté de Rouville, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 1 lOSl-o P.FRENETTE.(P.G.13734-56) Les Vingt Associés Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre 1956, constituant en corporation: Louis-Philippe Lauzon, Richard Lafon-taine, avocats, et Gérald Laniel, agent, tous trois de Valleyfield, pour les objets^suivants; and intellectual formation, under the anmc of \"Le Prêt d'Honneur LaSalIien Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Loretteville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13478-56) Les Immeubles Pro-Can Limitée Pro-Can Realties Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1956, incorporating: André Forget, advocate and Queen's Counsel, of Outremont, Joan Clark, advocate, unmarried, William Patrick Creagh, clerk, both of the town of Mount-Royal, Clifford George Meek and Guy Ambrose Miller, both book-keepers, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate in all its branches; act as general contractors, under the name of \"Les Immeubles Pro-Can Limitée\u2014 Pro-Can Realties Limited\", with a total capital stock of $1,100,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $100 each and 10,000 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13801-56) Les Produits Cardinal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1956, incorporating: Maurice Cardinal, fruit-grower, of Mont Saint Hilaire, Gérard Vincent, agronomist, of Saint Hyacinthe, and Gervais Vincent, agronomist, of the parish of of Douville, Saint Hyacinthe, for the following purposes: To deal in agricultural products, under the name of \"Les Produits Cardinal Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Mont Saint Hilaire, county of Rouville, judicial district of Saint Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1956.P.FRENETTE, 41081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13734-56) Les Vingt Associés Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1956, incorporating: Louis-Philippe LauzonJRichard Lafontaine, advocates, and Gérard Laniel, agent, all three of Valleyfield, for the following purposes: 180 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 Exercer les opérations d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de \"Les Vingt Associés Lie\", avec un capital total de S70,000, divisé en 700 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sala-berry-de-Valleyfield, district judiciaire de Iieau-harnois.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13712-56) L'Immeuble Trans-Québec Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1956, constituant en corporation: J.-Raymond Demers, Emile Ouellette et Germain Leblanc, tous trois agents d'immeubles, de Victoriaville, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents d'immeubles, sous le nom de \"L'Immeuble Trans-Québec Licorporée\", avec un capital total de $75,000, divisé en 500 actions communes de $25 chacune et en 625 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Victoriaville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 4408l-o P.FRENETTE.(P.G.13784-56) Magasin Raymond Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente novembre 1956, constituant en corporation: Raymond Beshro, commerçant, Camille Fecteau, comptable, tous deux de ville Saint-Georges, et Henriette, Poulin, secrétaire, célibataire, de Saint-Georges ouest, pour les objets suivants: Exercer le commerce de vêtements et de chaussures pour hommes, dames et enfants, sous le nom de \"Magasin Raymond Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ville Saint-Georges, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE, (P.G.13345-56) Manoir des Iles Incorporé Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treize novembre 1956, constituant en corporation: Maurice Thiffault, entrepreneur, Mine Geneviève Perron Thiffault, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Maurice Thiffault et Carroll Thiffault, gérant, tous trois de Sept-Iles, pour les objets suivants: Procureur toutes les facilités d'un centre récréatif pour pratiquer les sports, exercices, divertissements, représentations et récréations; exploiter un restaurant, salle à manger et de rafraîchissements, sous le nom de \"Manoir des Iles To carry on the operations of a holding company under the name of \"Les Vingt Associés Inc.\".with a total capital stock of $70,000, divided into 700 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Salabcrry-de-Valley field, judicial district of Beau-harnois.Dated'at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13712-56) L'Immeuble Trans-Québec Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December, 1956, incorporating: J.Raymond Deniers, Emile Ouellette and Germain Leblanc, all three real estate agents, of Victoriaville, for the following purposes: To carry on as real estate agents undec the name of \"L'Immeuble Trans-Québec Licorporée\", with a total capital stock of $75,000, divided into 500 common shares of $25 each, and into 625 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13784-56) Magasin Raymond Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November, 1956, incorporating: Raymond Beshro, dealer, Camille Fecteau, accountant, both of the town of Saint-Georges, and Henriette Poulin, secretary, bachelor, of Saint-Georges, West, for the following purposes: To carry on a business dealing in clothing and shoes for men, ladies and children, under the name of \"Magasin Ravmond Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at the town of Saint-Georges, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1956.P.FRENETTE, 440S1 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13345-56) Manoir des Iles Incorporé Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of November, 1956, incorporating: Maurice Thiffault, contractor, Mrs.Geneviève Perron Thiffault, housewife, wife contractually separate as to property of the said Maurice Thiffault.and Carroll Thiffault, manager, all three of Sepl-Iles, for the following purposes: To provide all the facilities of a recreational centre involving sports, exercise, amusements, performances and recreational activities; operate a restaurant dining and refreshment-room, under the name of \"Manoir des Iles Incorporé\", with QUEBEC OFFICIA LMAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol 89, No.3 181 Incorporé\", avec un capital total de 840,000, divisé en 3,500 actions ordinaires de 810 chacune et en 1,000 actions privilégiées de 85 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Ilcs, district judiciaire du Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le treize novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, llOSl-o P.FRENETTE.(P.G.13783-56) Mercury Shingle & Siding Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente novembre 1956, constituant en corporation: Harry Pinker, avocat, Sidney Greenfield, entrepreneur et Suzanne Gélincau, ménagère, épouse commune en biens de Sidney Greenfield et dûment autorisée par ce dernier, tous de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'entrepreneurs généraux; acquérir des propriétés immobilières aux fins de placements, sous le nom de \"Mercury Shingle & Siding Co.Ltd.\", avec un capital t otal de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 11081 P.FRENETTE.(P.G.13808-56) Mesy Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date «lu vingt-neuf novembre 1956, constituant en corporation: Jean-Marie Fortin, entrepreneur, d'Hé-iiertville, Camille Lavoie, négociant, et Louis-Jos,.Fortin, notaire, tous deux de ville d'Alma, pour les objets suivants: Faire' affaires comme entrepreneurs généraux en construction ; exercer le commerce de matériaux \u2022 le construction et machinerie, sous le nom de \"Mesy Construction Inc.\", avec un capital total do 825,000, divisé en 2,500 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ville d'Alma, comté Lac St-Jean, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 14081-o P.FRENETTE.(P.G.13476-56) Metallic Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept novembre 1956, constituant en corporation: Jean Filion, avocat, c.r., de ville Mont-Royal, Claude Behind, stagiaire, et Jcanne-l'rançoise Raymond, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de travailleurs de métal «'u feuille et de couvreurs; faire affaires comme plombiers et entrepreneurs, sous le nom de a total capital stock of $40,000, divided into 3,500 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Sept-Iles, judicial district of Saguenay.Dated at tîiç office of the Attorney General, this thirteenth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13783-56) Mercury Shingle & Siding Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November, 1956, incorporating: Harry Pinker, advocate, Sidney Greenfield, contractor, and Suzanne Gélineau, housewife, wife common as to property of Sidney Greenfield, and duly authorized by him, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors; to acquire immoveable property for the purpose of investment, under the name of \"Mercury Shingle & Siding Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.s Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13808-56) Mesy Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day .of November, 1956, incorporating: Jean-Marie Fortin, contractor, of Hébertville, Camille Lavoie, dealer, and Louis-Jos.Fortin, notary, both of the town of Alma, for the following purposes: To carry on business as genera building contractors; to operate a business dealing in building materials and machinery, under the anme of \"Mesy Construction Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 2,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at the town of Alma, county of Lake St.John, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13476-56) Metallic Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of November, 1956, incorporating: Jean Fillion, advocate, Q.C., of the town of Mount-Royal, Claude Belaud, law-clerk, and Jeanne-Françoise Raymond, secretary, of full age, both of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of sheet-metal works and roofers; to operate as plumbers and contractors under the name of \"Metallic Industries Ltd.\", 182 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 \"Metallic Industries Ltd.\", avec un capital total de 850,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13728-56) National Dried Fruit Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre 1956, constituant en corporation: Panfilo Pasquale, grossiste et manufacturier, Angelo Pasquale, gérant de la production, Lazzaro Pasquale, gérant, Louisa Pasquale, Annie Pasquale, toutes deux comptables, filles majeures, tous de Montréal et Caesar Pasquale, gérant des ventes, de St-Lambert, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fruits séchés, légumes, céréales et produits alimentaires, sous le nom de \"National Dried Fruit Co.Limited\", avec un capital total de 8600,000, divisé en 600 actions catégorie \"A\" de 8100 chacune, 3,000 actions catégorie \"B\" de $100 chacune et 2,400 actions provilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.13727-56) North Shore Fish and Fruits Inc.' Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1956, constituant en corporation: Adrien Bois, mécanicien, Henri-Paul Boudreau, pilote, et Louis Paradis, avocat, tous trois de Sept-Iles, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs de transport; exercer le commerce de viandes, produits laitiers, poissons et fourrures, sous le nom de \"North Shore Fish and Fruits Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Hes, district judiciaire du Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13596-56) Patrick Provencher Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept novembre 1956, constituant en corporation: Patrick Provencher, Denis Laliberté et Jules Laliberté, entrepreneurs de pompes funèbres, tous de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs de pompes funèbres, sous le nom de \"Patrick Provencher Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13728-56) National Dried Fruit Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November, 1956, incorporating: Panfilo Pasquale, wholesaler and manufacturer, Angclo Pasquale, Production manager, Lazzaro Pasquale, manager, Louisa Pasquale, Annie Pasquale, both accountants, spinsters of the full age of majority, all of Montreal, and Caesar Pasquale, sales manager, of St.Lambert, for the following purposes: To deal in dried fruits, vegetables cereals and food products, under the name of \"National Dried Fruit Co.Limited\", with a total capital stock of $600,000, divided into 600 shares class \"A\" of $100 each and into 3,000 shares class \"B\" of $100 each and into 2,400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13727-56) North Shore Fish and Fruits Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1956, incorporating: Adrien Bois, mechanic, Henri-Paul Boudreau, pilot, and Louis Paradis, advocat, all three of Sept-Iles, for the following purposes: To carry on business as contractors in transportation; to carry on a business dealing in meats, dairy products, fish and furs, under the name of \"North Shore Fish and Fruits Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sept-Iles, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13596-56) Patrick Provencher Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of November, 1956, incorporating: Patrick Provencher, Denis Laliberté and Jules Laliberté, undertakers, all of Montreal, for the following purposes : .To carry on business as undertakers under the name of \"Patrick Provencher Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th', 1957, Vol.89, No.3 183 en 100 actions communes de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 4-108l-o P.FRENETTE.(P.G.13551-56) Paul's Petroleum Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept novembre 1956, constituant en corporation: Luc Geoffroy, avocat, de Chambly, Robert Dulude, avocat, de Dorion et Réjanc Schmidt' secrétaire, fille majeure, de Verdun, pour les objets suivants: Faire le commerce d'huiles, graisses, pétrole et autres produits d'huile et de gaz naturel, sous le nom de \"Paul's Petroleum Inc.\", avec un capital-actions divisé en 2,000 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Chambly, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept, novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.13688-56) Pellatt's Food Market Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date \u2022 lu (piatre décembre 1956, constituant en corporation: Abraham Harold Crestohl, gérant, Donald William Seal, avocat, tous deux de Montréal et Harvey Crestohl, étudiant, d'Outremont, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme épiciers, bouchers el marchands de provisions, sous le nom de \"Pellatt's Food Market Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, '1-1081 P.FRENETTE.(P.G.13724-56) Produits Laitiers de la Côte Nord Ltée North Shore Dairy Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1956, constituant en corporation: Maurice Tessier, avocat, Lucien Sasse-ville, greffier de la cour de magistrat, et Paula Marmen, député-protonotaire, fille majeure, tous de Rimouski, pour les objets suivants: Exploiter une laiterie; exercer le commerce de machineries de toutes sortes, sous le nom de \"Produits Laitiers de la Côte Nord Ltée \u2014 North Shore Dairy Products Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay.shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13554-56) Paul's Petroleum Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of November, 1956, incorporating: Luc Geoffroy, lawyer, of Chambly, Robert Dulude, lawyer, of Dorion, and Réjane Schmidt, secretary, spinster of the full age of majority, of Verdun, for the following purposes: To deal with oils, grease, petroleum and other oil products and natural gas, under the name of \"Paul's Petroleum Inc.\", with a capital stock divided into 2,000 shares having no nominal or par value.The head office of the company will be at Chambly, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13688-56) Pellatt's Food Market Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, bearing date the fourth day of December, 1956, incorporating: Abraham Harold Crestohl, manager, Donald William Seal, advocate, both of Montreal, and Harvey Crestohl, student, of Outremont, for the following purposes: To carry on business as grocers, butchers, and provision merchants, under the name of \"Pellatt's Food Market Inc.\",-with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of December, 1956.P.FRENETTE, 4408l-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13724-56) Produits Laitiers de la Côte Nord Ltée North Shore Dairy Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of November, 1956, incorporating: Maurice Tessier, advocate, Lucien Sasseville, clerk of the Magistrate's Court, and Paula Marmen, deputy-Prothonotary, fille majeure, all of Rimouski, for the following purposes: To operate a dairy; deal in machinery of every nature and kind, under the name of \"Produits Laitiers de la Côte Nord Ltée \u2014 North Shore Dairy Products Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Sept-Iles, judicial district of Saguenay. 184 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13790-56) P.Scardere Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente novembre 1956, constituant en corporation: P.Scardere, entrepreneur, de ville St-Michcl, J.-Claude Bureau, avocat, Monique Couture, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal et Raymond Lette, avocat, de la ville de Hampstead, pour les objets suivants: Entreprendre la construction, réparation, reconstruction de ponts, tunnels, chemins, viaducs, pavage, aqueducs, égoûts, immeubles et bâtisses de toutes sortes, sous le nom de \"P.Scardere Limited\", avec un capital total de $80,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune et 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ville St-Michel, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.13804-56) Quebec Metal Window Ltd.(Fenêtre en Métal du Québec Ltée) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1956, constituant en corporation: Claire Laferrière, Denise Leroux, sténographes, célibataires majeures, et Louis-Philippe Guay, avocat, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer-l'industrie et le commerce de fenêtres en métal et autres marchandises semblables; exercer le commercé de matériaux de construction, sous le nom de \"Quebec Metal Window Ltd.\u2014 (Fenêtre en Métal du Québec Ltée)\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13218-56) Roger Electric Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1956, constituant en corporation : Roger Hachez, électricien, Corinne Hachez, marchande, célibataire, et Horace Boutin, comptable, tous de Saint-Jean, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et la réparation d'accessoires électriques, tubes et autres articles électriques, sous le nom de \"Roger Electric Inc.\", avec un capital total de $99,800, divisé en 499 actions privilégiées de $100 chacune et en 499 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean d'Iberville, district judiciaire d'iberville.Dated at the office of the Attorney General, twenty-sixth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13790-56) P.Scardere Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November, 1956, incorporating: P.Scardere, contractor, of ville St-Michel, J.-Claude Bureau, advocate, Monique Couture, secretary, spinster of the full age of majority, both of Montreal, and Raymond Lette, advocate, of the town of Hampstead, for the following purposes: To undertake the construction, repairing, rebuilding of bridges, tunnels, roads, viaducts, paving, aqueducts, sewers, immovables and buildings of all kinds, under the name of \"P.Scardere Limited\", with a total capital stock of $80,000, divided into 400 common shares of $100 each and into 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at ville Saint-Michel, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13804-56) Quebec Metal Window Ltd.(Fenêtre en Métal du Québec Ltée) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December 1956, incorporating: Claire Laferrière, Denise Leroux, stenographers, unmarried and of full age of majority, and Louis Philippe Guay, advocate, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of and deal in metal windows and other similar merchandise; deal in building materials, under the name of \"Quebec Metal Window Ltd.\u2014 (Fenêtre en Métal du Québec Ltée)\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13218-56) Roger Electric Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December 1956, incorporating: Roger Hachez, electrician, Corinne Hachez, merchant, unmarried and Horace Boutin, accountant,, all of Saint John, for the following purposes: To carry on the business of and repair electrical appliances, tubes and other electrical articles, under the name of \"Roger Electric Inc.\", with a total capital stock of $99,800 divided into 499 preferred shares of $100 each and 499 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint John, Iberville, judicial district of Iberville. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 185 Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1950.L'Assistant-procurcur général suppléant, 410S1-o P.FRENETTE.(P.G.13814-50) Rosa Lumber Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en1 date du trente novembre 1950, constituant en corporation: Camille Messara, avocat, Yolande Roy, - crétaire, célibataire, et André Trottier, comptable agréé, tous de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exercer le commerce du bois et de ses sous-produits, sous le nom de \"Rosa Lumber Lie\", avec un capital total de 820,000, divisé en 500 actions d'une valeur au pair de 840 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, llOSl-o P.FRENETTE.(P.G.13017-50) Roseglen Development Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a clé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date ¦ lu vingt-sept novembre 1950, constituant en corporation: Samuel Greenblatt, avocat, Theodore IL Polisuk, étudiant en droit et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure et usant de ses droits, tous de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de terrains, construction et améliorations, sous le nom de \"Roseglen Development Corp.\", avec un capital total de S10.000, divisé en 10,000 actions «le $1 chacune.be siège social de la compagnie sera à S235 avenue Birnam, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sepl novembre 1950.I.'Assistant-procureur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(P.G.13501-50) Snoc Lighting Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre 1950, constituant en corporation: Georges Sansoucy, industriel, Denise Daryeau, ménagère, épouse commune en biens dudit Georges Sansoucy, et dûment autorisée par iraux fins des présentes, et Noël Sansoucy.menuisier, tous de Saint-Hyacinthe, pour les.objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce du fer, de 1 acier, autres métaux et substances plastiques; installer des pièces en fer ornemental et.accessoires électriques, sous le nom de \"Snoc Lighting Limited\", avec un capital total de S40.000.divisé en SOO actions ordinaires d'une valeur au pair de S50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2950, rue Lafontaine, Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.\" Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1950.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.Dated at the office of the Attorney General, this third day of December 1950.P.FRENETTE, 440S1 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13814-50) , Rosa Lumber Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November, 1950, incorporating: Camille .Messara, advocate, Yolande Roy, secretary, bachelor, and André Trottier, chartered accountant, all of Sherbrooke, for the following purposes : To carry on a business dealing in lumber and its by-products, under the name of \"Rosa Lumber Inc.\", with a total capital stock of S20.000, divided into 100 shares of a par value of S40 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1950.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13017-50) Roseglen Development Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of November, 1950, incorporating: Samuel Greenblatt, advocate, Theodore H.'Polisuk, law student, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Roseglen Development Corp.\".with a total capital slock of 810,000, divided into 10,000 shares of 81 each.The head office of the company will be at 8235, Biinnm Ave, Montreal, judicial district of .Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of November, 1950.P.FRENETTE, \u2022I IDSl-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.13501-50) Snoc Lighting Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of November, 1950, incorporating: Georges Sancoucy, industrialist, Denise Darveau, housewife, wife common as to property of the said Georges Sansoucy, and duly authorized by him for the purposes therein, and Noël Sansoucy, carpenter, all of Saint Hyacinthe, for the following purposes: To carry on the business of and deal in iron, steel, and other metals, plastic substances; install ornamental iron castings and electrical accessories, under the name of \"Snoc Lighting Limited\", with a total capital stock of 840,000, divided into S00 common shares of a par value of 850 each.The head office of the company will be at 2950 Lafontaine Street.Saint Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1956.P.FRENETTE, 440S1 Acting Deputy Attorney General. 18G GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 (P.G.13723-5G) St.George Gardens Ltd.Jardins St.Georges Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-deux novembre 1956, constiautnt en corporation: John Richard Hyde, George\"Beverly Puddicombe, c.r., tous deux de Westmount et Bernard Tellier, d'Outrcmont, tous avocats, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de terrains, de construction et d'amélioration, sous le nom de \"St.George Gardens Ltd.\u2014Jardins St.Georges Ltée\", avec un capital total de 8300,000, divisé en 50,000 actions ordinaires de SI chacune et 2,500 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera «à 10 ouest, rue St-Jacqucs, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081 P.FRENETTE.(A.G.13723-56) St.George Gardens Ltd.Jardins St.Georges Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companiges' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of November, 1956, incorporating: John Richard Hyde, George Beverly Puddicombe, Q.C., both of Westmount, and Bernard Tellier, of Outremont, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"St.George Gardens Ltd.\u2014 Jardins St.Georges Ltée\", with a total capital stock of $300,000.divided into 50,000 common shares of $1 each and into 2,500 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 10, St.James Street, West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1950.P.FRENETTE, 4408l-o Acting Deputy Attorney General.(P.G.13774-50) S.Verdon Ltée S, Verdon Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1956, constituant en corporation: Jcan-H.Deslauriers, avocat, d'Outrcmont, Maurice Benoit, avocat, et Marie-Paule Chalifour, sténographe, fille majeure, tous deux de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de meubles et nouveautés de toutes sortes, sous le nom de \"S.Verdon Ltée \u2014 S.Verdon Ltd.\", avec un capital total de 850,000, divisé en 500 actions communes de 810 chacune et en 450 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Rose, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt* huit novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(A.G.13774-56) S.Verdon Ltée S.Verdon Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eight day of November 1956, incorporating: Jean II.Deslauricrs, advocate, of Outremont, Maurice Benoit, advocate, and Marie Paule Chalifour, stenographer, fille majeure, both of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of furniture and novelties of every nature and kind, under the name of \"S.Verdon Ltée \u2014 S.Verdon Ltd.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 500 common shares of 810 each and 450 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Saint Rose, judicial district of \\Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eight day of November 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(P.G.13753-50) Taverne Bélanger Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de.la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1956, constituant en corporation: Louis Laporte, Raymond Laportc, industriels, tous deux de Montréal, et Lionel Leroux, notaire, d'Outrcmont, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôteliers, restaurateurs et ta verniers, sous le nom de \"Taverne Bélanger Inc.\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 850 chacune et en 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de S50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(A.G.13753-56) Taverne Bélanger Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November, 1956, incorporating: Louis Laportc, Raymond Laporte, industrialists, both of Montreal, and Lionel Leroux, notary, of Outrcmount, for the following purposes: To carry on a business as hotel-keepers, restaurant-keepers and tavern-keepers, under the name of \"Taverne Bélanger Inc.\" with a total capital stock of 8100,000, divided into 500 common shares of a par value of 850 each and into 1,500 preferred shares of a par value of 850 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of November, 1956.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 187 (P.G.13950-56) The Lady Grey's Salvage Operations Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1956, constituant en corporation: René de Blois, agent d'assurance, de Beau-port, Çeorges Pelletier, avocat, et Louise Gagnon, secrétaire, célibataire, tous deux de Québec, pour les objets suivants: Procéder aux opérations de sauvetage, de renflouement, de touage et de récupération de l'épave du brise-glace \"Lady Grey\", sous le nom de \"The Lady Grey's Salvage Operations Ltd.\", avec un capital total de $150,000, divisé en 1,500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.(P.G.13558-56) Universal Metal Works Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze novembre 1956, constituant en corporation: Roland Thivicrge, industriel, Fernande Cantin Thivicrge, ménagère, épouse dudit Roland Thivicrge, tous deux de Ste-Foy, et St-Gcorges Wliite, comptable, de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de machineries, outils et instruments de toutes sortes, matériaux et métaux, équipements et accessoires pour incendie, sous le nom de \"Universal Metal Works Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 100 actions communes d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1956.L'Assistant-procurcur général suppléant, IlOSl-o P.FRENETTE.(P.G.13669-56) Universal Printing and Paper Box Co.Avis est donné qu'en .vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre 1956, constituant en corporation : Michael Greenblatt, Samuel Godin -sky, tous deux avocats et Daniel Kingstone, étudiant, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire des affaires comme imprimeurs et éditeurs et exercer le commerce de contenants, boîtes, papier et ses produits, sous le nom de \"Universal Printing and Paper Box Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 11081 P.FRENETTE.(A.G.13950-56) The Lady Grey's Salvage Operations Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1956, incorporating: René de Blois, insurance agent, of Beauport, Georges Pelletier, advocate, and Louise Gagnon, secretary, bachelor, both of Quebec, for the following purposes: To proceed on the operations of salvaging, the refloating, towing and the recuperation of the wreckage of the ice-breaker \"Lady Grey\", under the name of \"The Lady Grey's Salvage Operations Ltd.\", with a total capital stock of $150,000, divided into 1,500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1950.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13558-56) Universal Metal Works Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1956, incorporating: Roland Thivicrge, industrialist, Fernande Cantin Thivicrge, housewife, wife of said Roland Thivicrge, both of St.Foy, and St.Georges White, accountant, of Quebec, for the following purposes: To deal in machinery, tools and instruments of every nature and kind, materials and metals, fire-protection equipment and accessories, under the name of \"Universal Metal Works Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 400 preferred shares of a par value of $100 each and 100 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November 1956.P .FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.(A.G.13669-56) Universal Printing and Paper Box Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November, 1956, incorporating: Michael Greenblatt, Samuel Godinsky, both advocates, and Daniel Kingstone, student, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as printers and publishers and to deal with containers, boxes, paper and paper products, under the name of \"Universal Fruiting and Paper Box Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 preferred shares Having a par value of $100 each and into 100 common shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of November, 1956.P.FRENETTE, 4408l-o Acting Deputy Attorney General. 188 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1967, Tome 89, N° 3 (P.G.13511-5(5) Winkcl Diamonds (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre décembre 1950.constituant en corporation: Jules Ninclaus, Patrick Boisvert, tous deux entrepreneurs et Ubald Parent, manufacturier, tous de .Mont réal.pour les objets suivants: Exercer le commerce de bijoutiers, orfèvres, marchands de diamants, sertisseurs de pierres, horlogers et artisans sur des objets en or, sous le nom de \"Winkcl Diamonds (Canada) Ltd.\", avec un capital total de SôO.OOO, divisé en 2.500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège socio 1 de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre décembre 1950.L'Assistant-procureur général suppléant, 440S1 P.FRENETTE.(A.G.13511-56) Winkcl Diamonds (Canada) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of December, 1956, incorporating: Jules Ninclaus, Patrick Boisvert, both contractors, and Ubald Parent, manufacturer, all of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of jewellers, silversmiths, diamond merchants, stone setters, watchmakers and gold craftsmen, under the name of \"Winkcl Diamonds (Canada)' Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 2,500 preferred shares of a par value of $10 each and into 2,500 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of December, 1956.P.FRENETTE, 44081-o Acting Deputy Attorney General.Ventes pour taxes Province de Québec Municipalité du comté d'Yamaska Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Henri Niquct, secrétaire-trésorier du conseil municipal du Comté d'Yamaska, que les immeubles ci-dessous décrits seront vendus à l'enchère publique, dans la salle des sessions dudit conseil, au Palais de Justice à St-François du Lac, JEUDI le QUATORZIÈME jour de MARS mil neuf cent cinquante-sept, à DIX heures de Pavant-midi, pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires et des frais encourus, à moins que ces taxes et frais ne soient payés avant la vente.Municipalité de la paroisse de St-François du Lac Comme appartenant à Paul-André Gamelin.\u2014 Une île, dans la rivière St-François, décrite au cadastre officiel pour la paroisse de St-François du Lac, sous les Nos.867_et 868.Montant dû: taxes mun.$2.66, taxes scol.S9.99.Total $12.65.Municipalité de la paroisse de St-David de Guir Appartenant à Willie Côté.\u2014 Un terrain emplacement au village de St-David, concession Stc-Henriette, étant les lots Nos.602 et 603 du cadastre pour la paroisse de St-David de Guir.Montant dû: taxes mun.$6.97, taxes scol.82.60.Total $9.57.Municipalité Scolaire de St-Zéphirin de Courval Appartenant à Lucien et Rolland MaiHette.\u2014 Un emplacement au village de St-Zéphirin, côté nord-est, du chemin, borné en front à M.P.Jutras, du côté nord-ouest et au nord-est àZéphi-rin Bclletctc et du côté sud-est à Joseph Richard et Albert Lcmaire; étant partie du lot N° 277 du cadastre pour la paroisse de St-Zéphirin de Cour-val.Montant dû: taxes scolaires $24.78.Sales for Taxes Province of Quebec Municipality of the county of Yam ask a Public notice is hereby given by the undersigned, Henri Niquct, Secretary-Treasurer of the Municipal Council of the county of Yamaska.that the immoveables hereinundcr described shall be sold by public auction in the Council-room where sittings are held, at the Court House of St.François du Lac, THURSDAY the FOURTEENTH day of MARCH one thousand nine hundred and fifty-seven, at TEN o'clock in the forenoon, for non-payment of municipal and school taxes and costs incurred, unless said taxes and costs are paid before the sale.Municipality of the parish of St.François du Lac As belonging to Paul-André Gamelin.\u2014 An Island situated in the St.François River, described on the official cadastre for the parish of St.François du Lac, under Nos 867 and 86S.Amount due: Mun.taxes $2.66, School taxes, $9.99.Total 12.65.Municipality of the parish of St.David de Guir Belonging to Willie Côté.\u2014 A land emplacement in the Village of St.David, St.Henriette Concession, being lot Nos 602 and 603 of the cadastre for the parish of St.David de Guir.Amount due: Mun.taxes $6.97, School taxes $2.60.Total $9.57.* School Municipality of St.Zkpiiirin de Courval Belonging to Lucien and Rolland MaiHette.\u2014 An emplacement in the Village of St.Zéphirin.on the northeasterly side of the road; bounded in front by M-P.Jutras, on the northwesterly side and to the northeast, by Zéphirin Belletête and on the southeasterly side by Joseph Richard and Albert Lemaire; being part of lot No.277 of the cadastre for the Parish of St.Zéphirin de Courval.Amount due: School taxes $24.78. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 189 Municipalité de la pakoisse de St-Joseph de La Baie du Febvre Comme appartenant à Donat Crotftiu.\u2014 Un emplacement avec les bâtisses, étant partie du lot 0()() du cadastre pour la paroisse de St-An-toine de La Baie du Febvre.mesurant 282 pieds dans la ligne nord-ouest, 135 pieds dans la ligne sud-ouest, 15 pieds dans la ligne nord-est, la ligne sud-est étant constituée par une ligne courbe reliant les bouts sud-est des lignes nord-csl et sud-ouest de façon à ce qu'une ligne perpendiculaire imaginaire élevée sur le centre de la ligne nord-ouest coure sur une distance de 70 pieds avant d'atteindre cette ligne courbe, le tout mesure anglaise.Borné au nord-est au loi 665, au sud-est à l'assiette de la route Marie Victorin et au sud-ouest à la balance dudit lot N° 666 appartenant à Willie Caya.Montant dû: taxes mun.820.74, taxes scol.$51.40.Total $72.14.Municipalité Scolaire de Baie du Febvre Un emplacement au village de Baieville, au nord-ouest de la rue Principale, de 43 pieds de largeur sur 90 pieds de profondeur trottoir inclus, mesure anglaise.Borné en front à ladite rue.au sud-ouest à Roger Hamel, et des côtés ouest et nord-est, à Jérôme Pelletier; étant partie du lot N° 548 du cadastre de la paroisse de St-Antoine de La Baie du Febvre.Comme appartenant â Simon Lcfebvre.Montant dû: taxes scolaires $84.01.Comme appartenant à Donat Caya.\u2014 Un emplacement situé au nord-ouest de la rue Principale du village de Baieville, borné en Iront au chemin, nu nord-est â Julien Lemire, an sud-ouest â M.Bécotte et au nord-ouest à la concession des Seize; étant une partie du lot \\'° 103 du cadastre de la paroisse de St-Antoine même largeur en arrière, sur toute la profondeur du of same width in rear, along all tho depth of tho road by chemin à la rivière, connu et désigné sur le numéro 7 the river, known and designated on number 7 of the du cadastro officiel de la municipalité de St-Bonolt official cadaster of tho municipality of St.Bonoit Joseph Joseph Labre d'Amqui, avec bâtisses y érigées.Labre d'Amqui, with buildings thereon erected.Amqui (village).! P.1.1.1 S.B.J.L.A.1 Orner Ouellet.Il06.0oll85.65 Un terrain ayant 140 pieds de front au chemin, par A plot of land having 146 feecTn front, by the road, ¦ 0 pieds de profondeur, borné au nord par le terrain by 70 feet in depth, boundod on tho North by the land ¦le Ludger Gagnon, au sud, par le chemin, à l'est par lo of Ludger Gagnon, on the South, by tho road, on the ¦errain de Eug.Belzile, â l'ouest par le terrain do Ph.East, by the land of Eug.Belzile, on tho West, by the V aillancourt, avec bâtisses y érigéss.Ledit terrain fai- land of Ph.Vaillancourt, with buildings thereon erected. 224 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° S sant partie et à distraire du lot 1 du cadastre officiel do The said land forming part and to be withdrawn from la paroisse St-Benott Joseph Labre d'Amqui.lot 1 of the official cadaster of the parish of St.Benoit Joseph Labre d'Amqui.Municipalité\tNos\tRang\tCanton\tPropriétaires\tTaxes mun.\tTaxes scol.Municipality\t\tRange\tTownship\tOwners\tMun.taxes\tSch.taxes Amqui (village).\tP.32.\t\tS.B.J.L.A.\t\t84.00\t06.43 A plot of land having 60 x 75 feet, with buildings thereon erected, bounded on the North by the land of Gérard Proulx.on the South, by Lambert Street, on tho East, by tho land of Nazaire Founder, on the West, by the land of Romuald Bernatohez.The said land forming part and to bo withdrawn from lot 32 of tho official cadaster of the parish of St.Benoît Joseph Labre d'Amqui.Amqui (village).I P.89-4.1 1.| Lepage____I Mile-Miss Thérèse Gauthier.I 69.Go! 07.70 Un terrain ayant deux arpents on superficie, avec A plot of land having two arpents in area, with bâtisses y érigées, ledit terrain borné à l'avant par la buildings thereon erected, the said land bounded in rue Stc-Estcllc et sur les trois autres côtés par le reste front by St-Estclle Street and on the three other sides du lot 89-4.by the remainder of lot 89-4.Un terrain ayant 60 x 75 pieds, avec bâtisses y érigées, borné au nord par le terrain dc Gérard Proulx, nu sud par In rue Lambert, â l'est par le terrain de Nazairc Founder, a l'ouest par le terrain de Romuald Bernât chez.Ledit terrain faisant pnrtic et ft distraire du lot 32 du casastre officiel de la paroisse St-Bcnoît Joseph Lnbrc d'Amqui.P.102 1.St-Benoit J.Labre d'Amqui, paroisse \u2014 Parish Un terrain ayant 75 pieds de front par 75 pieds dc profondeur, borné au nord par Pierre Dnninis, S.Ouest par chemin, autres côtés par terrain dc Emile Labbé.Est -cast S.B.J.L.André Bouchard 14.46 09.90 A plot of land having 75 fect in front by 75 feet in depth, bounded on the North by Pierre Dumais, S-West by load, other sides by the land of Emile Labbé.St-Benoit J.Labre .1 P.86-B.1 Lepage Ronaldo Bélanger.I 3S.511145.45 Un terrain ayant 216 pieds de front au chemin par 184 pieds dc largeur ft l'arrière, par 100 pieds de profondeur, borné à l'avant par le chemin, à l'arrière et d'un côté par le terrain dc Paul Belzile ct de l'autre côté par la terre de Leopold Viens, avec bâtisses y érigées.A plot of land having 210 feet in front by the road by 184 feet in width in rear, by 100 foot in depth, bounded in front by the road, in rear and on one side by the land of Paul Belzile and on the other side by tho land of Leopold Viens,, with buildings thereon erected.St-Benoit J.Labre .18.2.St-Benoit J.Labre .15.2.St-Picrre du Lac____ P.207 .1.Paroisse \u2014 Parish Étant un terrain n distraire du lot no-207 du cadastre officiel pour la paroisse de St-Pierre du Lac, borné au nord nu Lac Matapédia ct dc la contenance dc un arpent de profondeur â partir dc la batture dudit Lac ct de la largeur de un arpent, avec bâtisses y érigées, avec Lepage Lepage S.P.L.Albert Lcclerc Louis Jomphe Ivanhoe Bossé.23.20 20.95 8.17 18.58 Being a plot of land to withdraw from lot No.207 of the official cadaster for the parish of St.Pierre du Lac, bounded on the North by Lake Matapédia and of the countenance of an arpent in depth starting from the shore of the said lake and of the width o\" an arpent, aussi un droit de passage pour bo rendre au chemin with buildings thereon erected, also with a right of way public.to get to the public road.St-Pierre du Lac- 47.1.S.P.L.St-Pierre du Lac____ 380.3.S.P.L.St-Pierre du Lac.66.7.Awantgish Lac-au-Snumon vill.39.1.Lepage .Bornes: N.Lucien Lavoie, S.Limites Causapscal Bounded N, Lucien Lavoie, S., Limits of tho Cau-paroisse, E.Rang 2 Lepage, O.Rivière Matapédia.sapscal parish, East, Range 2, Lepage, W., Matapédia River.Philippe Guy.Jean-Btc Castonguay.Antoine Dubé.Mme-Mrs.Antonio Gauthier .5.38 34.55 20.88 21.00 18.58 61.56 46.45 54.35 Lac-au-Snumon vill.| P.41.I 1.1 Lepage .| Philippo Lévesque.I 18.80| 12.75 Boines: N.Gérard Boudreau, S.& E.Arthur Bar- Bounded: N.Gérard Boudreau, S.& E., Arthur rett, O.Roure 6.Barrett.W., Route 6.Lac-au-Saumon vill.I P.49.| 1.| Lepage____[ Adéodat Gauthier.| 14.4o| 18.00 Bornes: N.Georges Cuyen, S.Route 0, E.Léo Hamil- Bounded: N.Georges Cuyen, W.Route 6, E., Léo ton, O.Lac-au-Saumon.Hamilton, W., Lac-au-Saumon.Lac-au-Saumon vill.| P.51.| 1.| Lepage____| Wilfrid Briand.|.| 59.83 Bornes: N.Auguste Bérubé, 8.Rang 2 Lepage, Bounded: N.Augusto Bérubé, S.Range 2, Lepage, E.Gustave Briand, O.Lac.E.Gustave Briand, W., Lake.Lac-au-Saumon vill.| P.30 Bornes: N.Rue Bérubé, Bérubé, O.Conseil Munie.| 1.| Humqui .| Mme-Mrs.Adélia Ouellet____| 85.60| 80.20 S.Ruisseau, E.Léonce Bounded: N.Street.Bérubé, S.Brook, E.Léonce Bérubé, W., Munie.Council.Lac-au-Saumon vill.| P.33.| 1.| Humqui .J Mme-Mrs Simon Côté .| 42.2o| 58.20 Bornes: N.Auguste Lavoie, S.David Bourgeois, Bounded: N.Auguste Lavoie, S.David Bourgeois, E.Rue principale, O.Justin Cormier.E.Principale Street, W., Justin Cormier.Ste-Irènc.St-Thnrsieius 19.34.20.28.48.47.7.G.42-B.33-P.N.O.37-A.40.5.2.5.4.3.5.3.4.4 N.O.1.2.2.Nctntnyé.Lepage Biais .Ovila Bélanger.Ovila Bélangor.Leopold Bélanger.Leopold Bélanger.Leopold Bélanger.Fortunat Potvin.Alphonse Ouellet.Leopold T rdjf.Succ-Est.Etienne Levasseur Adéodat Roy.Ange-Aimé Brochu.Albert Cassista.13\t25\t55.75 G\t30\t26.25 10.50\t\t35.25 20\t20\t71.35 4\t45\t11.80 19\t80\t52.83 \u2022 15\t85\t02.65 15\t26\t51.75 5\t30\t18.40 15\t75\t 21\t13\t84.10 6\t25\t32.70 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 225 Une maison seule, située sur le lot n.40 rang 2, Biais.One house only, situated on lot No.40, rango 2, Biais.Au cadastre officiel de la municipalité du villago de On the official cadaster of the municipality of Sayaboc Sayabec.Village.Municipalité Municipality Nos Rang Range Canton Township Propriétaires Owners Taxes\tTaxes mun.\tscol.Mun.\tSen.taxes\ttaxes 75.40\t31.21 Sayabec, Villago____ P.100.Un terrain do 50 pieds de front par 100 pieds de A plot of land of 50 feet in front by 100 feet in depth, profondeur, plus ou moins, borné au nord par la rue more or less, bounded on the North by St.Jean Street.St-Jean, à l'est par le lot 717, au sud par le reste du lot on the East, by lot 717, on the South, by tho remainder 100 et a l'ouest par la propiiété occupée par Emile of lot 100 and on the West, by the property occupied by Gagné.Emile Gagné.| 536-1 & 164 J B.|.| Josaphat Côté.|278.8l|s25.95 Terrain de 140 x 160 pieds environ, borné au nord A plot of land of 140 x 100 feet about, bounded on the par la rue de la Gare au sud et à l'est par le C.N.R., North by street of the Station, on the South and on tho a l'ouest par la rue de la Gare.East by the C.N.R., on the West, by tho Street of tho Station.| 538.1 B.I.Un terrain dc 34 x 90 pieds environ, borné à l'ouest par la rue Marcheterre.au nord par Lorenzo Audit, au end par Bcrtin Caron, i\\ l'est par le lot 538.| 653.| B.(.Un terrain de 65 x 90 pieds environ, borné au nord par Jean-Marie Lcfrançois, nu sud par la rue Ste-Marie, à l'est par la rue Marcheterre, à l'ouest par Eugène Bérubé, fils.| 607.| B.|.Yi partie nord du lot 623 étant un terrain de 59 x 113 pi\"ds plus ou moins, borné a l'ouest par la rue de l'Église, au nord par le lot 624, a l'est par le lot 511-1, et au sud par le reste du lot 623, propriété de Mme Antoinette Côté Savard.____| 654.1 B.(____ Terrain de 50 x 90 pieds environ, borné nu nord par Gérard Pearson, au sud par la rue Ste-Marie, à l'est par Ki 1 moud Marceau, i\\ l'ouest pai Aisène Gagnon.| 538.| B.|.Terrain de 50 x 90 pieds, borné au nord par L.A.J.Caron, au sud par Raoul Côté, à l'est par la Fabrique, à l'ouest par la rue Marcheterre.| Leopold Mainville.I 90.00l 30.81 A plot of 34 x 90 feet about, bounded on the West by Marcheterre Street, on tho North, by Lorenzo Audit, on the South, by Berlin Caron, on the East, by lot 538.I Edmond Marceau.|l00.6fi| 54.18 A plot of land of 65 x 90 feet about, bounded on tho North by Jean-Marie Lcfrançois, on the South by St.Marie Street, on the East, by Marcheterre Street, on the West, by Eugene Bérubé son.I Lucien Lizotte.Is51.6oll91.10 The North part of half of lot 623 baing a plot of land of 59 x 113 feet more or less, bounded on the West by the street de l'Eglise, on the North by lot 024, on tho East by lot 541-1, and on the South by the remainder of lot 623, property of Mrs.Antoinette Côté Savard.I Eugène Bérubé, fils-son.| 84.5o| 51.18 Plot of land 50 x 90 feet about, bounded on the North by Gérard Pearson, on tho South, by St.Marie Street, on the East, by Edmond Marceau, on the West, by Arsène Gagnon.I Léo Cormier.I1O6.O5I 39.15 Plot of land 50 x 90 feet, bounded on the North by L.A.J.Caron.on the South, by Raoul Côté, on the East, by the Fabrique, on the West, by Marcheterre Street.166-25.B Mme vve-Mrs Wid Honoré.231.24 103.42 Landry Terrain de 95 x 95 pieds environ, borné au nord par Plot of land 95 x 95 feet about, bounded on the la rue St-Antoine, au sud par Florido Audy.à l'est par North by St.Antoine Street, on the South by Florido Rita Ileppel, à l'ouest par Mme J.-A.Lévesque.Audy, on the East, by Rita Heppel, on the West by Mrs.J.A.Lévesque.124-39.Y P.O.-W.de of 166-45.B B Eugène Bérubé & Maurice .Lavoie.Mme-Mrs.Maria Campion- .Dubé 98.45 55.75 63.46 94.18 Étant un terrain de 54 pieds de front par 97 pieds de Being a plot of land of 54 feet in front by 97 feet in profondeur, plus ou moins, borné au sud par la rue depth, more or less, bounded on tho South by St.St-Antoine, à l'est par le reste du susdit lot, propriété Antoine Street, on the East, by the remainder of the de Léonidas Germain, au nord par le front dudit lot et said lot and on the West, by lot No.166-44.à l'ouest par le lot no 166-44.680.121.20 & 20-1.Napoléon Tremblay.Adrien Caron.Lionel Côté.98.50 120.75 63.15 38.75 137.75 157.47 Au Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Marie de In the official cadaster of the parish of St.Marie do Sayabec, Seigneurie du Lac Matapédia.Sayabec, Seigniory of Lake Matapédia.Ste-Marie de Sayabec Causapscal village.Bâtisse seule.Bâtisse et terrain.69.67.79.90.516.56.44-A 43.50.46.1-A-l 12.12.!.1.IN.Awantjish.McNcider.Causp8cull Build J.-Émilc Desjardins An .01 ne Côté.J.-Émile Desjardins Lucien Lamarre.;.Leopold Ouellet____ Antoine Côté.Antoine Marin.Antoine Marin.Roland St-Pierre.Alfred Parent.Marcel Biron.ng only.\t14.17\t21\t70 \t23.14\t66.07\t \t33.30\t73\t32 \t14.24\t79\t98 \t12.56\t52\t06 \t13.90\t\t \t3.87\t13\t91 \t7.52\t25\t22 \t13.79\t31\t32 \t7.50\t21\t29 \t170.20\t\t P.2-A-10 IN.I André D'Anjou.Building and land.14.15 54.40 226 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 Municipalité Municipality Nos Causapscal village.I P.5-A-2 Bâtisse seule Hang Range Bâtisse et terrain.Bâtisse seule.Bâtisse seule.Bâtisse seule.Bâtisse seule, n Bâtisse seule.St-Jacques-le-Majeur I 29.| Une terre seule.I 30.1 P.A-l-18 .| P.B-2-1-.I P.41.| P.9-1-9.| P.9-1-9.1 P.8-19 & 8-23- 1.IN.1.1.1.A.A .Canton Township Propriétaires Owners Une terre avec bâtisse.I 15.Une terre avec bâtisse.| 17.Une terre avec bâtisse.I 23.Une terre avec bâtisse.| 32.Une terre avec bâtisse.I 36.a.1.S.-E.1.8.-E.4 S.-E .4S-E.4 S.-E.Une terre seule.\" | 37.Une terre avec bâtisse.| 73a.Une terre avec bâtisse.Antonio Doiron.Building only.J Jean-Mario Lavoie Building and land.J Kdinond Couturier.Building only.| André Lévesque .Building only.Taxes mun.Mun.taxes Taxes scol.Sch.taxes Matalik.| Félix Boulay Building only.\" ____I Emile Potvin.Building ohly.Mme-Mrs Léon Saucier.Building only.54.301125.55 49.0s| 87.45 19.551 48.25 11.7ol 40.00 30.85] 80.05 32Go| 43.30 10.701 33.80 Lepago .| Cyrillo Valois.One farm only.I Cyrille Valois.One farm with building.I Wilbrod Gérard.One farm with building.I Antonio Gérard.One farm with building.\" .I André D'Anjou.One farm with building.Casupscull .1 Jos Pitre Lévesque.One farm with building.Casupscull .I Lucien Lcvnsseur One farm only.Casupscull .I Lucien Lovasseur One farm with building.|-62.Une terre avec bâtisse.I 53.Une terre avec bâtisse.I 57.Une terre avec bâtisse.I 62.Une terre avec bâtisse.I 67.Une terre avec bâtisse.I 54.Une terre avec bâtisso.I 61.Une terre avec bâtisse.I 34.Une terre seule.Ouest Kemp West.| Lionel Pelletier .One farm with building.\" \" \" .I Emile Pinard.One farm with building.I J.Claude Deschamps.One farm with building.Est Kempt East.I François Bernard One farm with building.'* .I Arthur Audit.One farm with building.Uno terre avec bâtisso.I 17.Une ter»o avec bâtisso.I 16.Une terre avec bâtisso.\" \" \" .I Pierre Charest.One farm with building.Ouest Kempt West.1 Paul Pelletier- One farm with building.\" \" \" .I Donat Gallant.One farm with building.4.1 Casupscull .| Midas Slater .One farm only.A.I Humqui .| Jos Chabot.One farm with building.B.\".,| Humqui .J Edouard Vallée.One farm with building.1.1 Humqui .I Armand Lapicrre One farm with building.13.701 24.79 40.79|l76.04 I6.27I.12.9o|.8.5o| 69.25 I6.85i 42.12 10.72i 10.20 54.431 65.10 34.55) 87.96 31.6o| 94.71 19.87| 41.71 23.14| 58.32 49.451136.23 27.5s|.4.351 11.40 19.5o|.2.0o| 11.40 27.05! 46.12 10.1o| 23.93 12.1o| 38.74 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 227 \t\t\t\t\tTaxes\tTaxes Municipalité\t\tHang\tCanton\tPropriétaires\tmun.\tscol.\u2014\tNos\t\u2014\t\u2014.\t\t_\t_ Municipality\t\tRango\tTownship\tOwners\tMun.\tSch.\t\t\t\t\ttaxes\ttaxes St-Jacques-lc-Magour\t24a.\tB.\tMatalik.\t\t51.85\t205.13 Une terre avec bâtisse.4.1.50.53.11.One farm with building.4 S.E.1.O.C.K.E.C.K.7.Lepage Matalik.Casapuseull Casupscull .Pinault Adrien Truchon.Jos C.Gagnon.André Lcfrançois.Jean Gallant.Michel Turcotte fils-son.1G.20 70.60 18.63 14.20 19.84 66.95 St-Zénon du Lac-Humqui Un emplacement, borné au sud par remplacement An emplacement bounded on the South by the de J.Z.St-Gelais, au nord, par remplacement de emplacement of J.Z.St.Gelais, on tho North by the Joseph Gagnon, fils de J.-Bte, à l'ouest par le chemin emplacement of Joseph Gagnon.son of J.Bte, on tho central et a l'est pai le terrain de Charles Rioux, inesu- West, by tho central road, and on the East, by tho rant environ 50 x 100 pieds.land of (maries Rioux, measuring about 50 x 100 feet.St-Raph::el d'Albertville.Stc-Floroncc.St-Cléophas 12.9.29.30.P.29 .P.42 .P.44L.51A .51A .9.P.10 .10.P.12 .P.12 .15B.41.45.34.28.46.57.36.46.19.28.32.46.47.52.31a.6 & P.5.Ste-Jeanne-d'Arc St-Antoine de Padouo de Kompt Lo lot no 6 ayant une superficie de 135 arpents.La partie du lot no 5, ayant 35 arponts en superficie, Matalik.Humqui Matabk.Casupscull Awantjish.Cabot Cabot Odina Chrétien.François Turcotte.Henri Larue.Henri Larue.Ernest Koussy.J.-Bte.Lavoie.Arthur Ouellet fils-son.Arsène Gjasson.Arsène Giasson.Michel Lévesque.M de Elzéar Lepage .Emile Lepage.Oscor Lettre.Edmond Malais.Paul E.Richard.Albeit Gagné.Joseph Chéncl.Orner Gagné.Léonard Vallières .André Gagnon.Adrien Caron.Ls-Philippe Gagnon .Christophe Chouinard Alphonse Pigeon.Christophe Chouinard Charles Lcclerc.Lucien Lelcerc.Joachim Leclerc.David Boulay.Armand Pinault.Joseph Côté.26.17 16.26 8.52 31.59 2.40 7.02 3.60 8.65 0.48 12.30 0.15 2.40 37.90 27.27 69.00 12.54 79 34 8.00 11.93 18.29 .9.14 3.14 18.30 6.35 57.31 95.00 25.84 118.02 25.88 61.31 32.03 82.53 6.82 62.58 28.02 28.86 64.18 25.34 20.04 48.60 60,90 00.20 125.18 49.00 28.84 39.22 71.00 52.04 24.72 47.86 79.40 34.37 102.19 80.50 Lot No.G having an area of 135 arpents.That part of lot No.5, having 35 arpents in area, bounded on tho bornée au nord par le rang G Seigneurie de Métis, ii North by range 6, Seigniory of Metis, on the East, by l'est par Lucien (\"été, â l'ouest par Léo Côté et au sud Lucien Côté, on the West by Léo Côté and on the par la rivière Tartigou.| 24.In.E.C.K.Une terre ayant 100 arpents en superficie.South, by the Tarigou River.Cabot.I François Lavoie., A farm having 100 arpents in area.Ste Marguerite-Marie\t26.\tE.C.K.\t27.\tE.C.K.\t31.\tO.C.K.\"\t40.\tO.C.K.\u2022\u2022\t25.\t5.»\t25.\t5.\u2022\u2022\t29.\t5.\u2022\u2022\t18.\t6.»\t1.\t9.\t14.\t7.\u2022¦\t10.\t9.\u2022\u2022\t2.\t10.\u2022\u2022\t15.\t9.\u2022\u2022\t14.\t9.\u2022i\t27.\t9.\u2022\u2022\t7.\t9.«\u2022\t7.\tE.C.K.\t24.\t9.\t1.\tE.C.K.«\t25.\t9.\"\t34.\tO.C.K.>¦\t35.\tO.C.K.\u2022¦\t28.\t9.\u2022\u2022\t4____\t10.\t9.\tE.C.K.\t3.\t9.\t12.\t6.La Rédemption.\t37.\t6.\t36.\t9.\u2022\u2022\t37.\t9.\t46.\t9.\"\t60.61 .\t9.\"\t02.\t9.\u2022\t43.\t8.\t\tCyprien Vignola, père-fathor\t\t '\u2022\t5.\t1.\tAwantjish.Matane.\t\t\t Whereas the wording used in the conclusion of the aforesaid Order in Council number 2600 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol 89, No.8 235 donné lieu à (les abus, attendu que dc grandes quantités d'huile désignées dans le commerce comme étant de l'huile à chauffage peuvent également servir et, en fait, servent à actionner certaines machines ou véhicules-automobiles; Attendu qu'il est dans l'intérêt public d'arrêter ces abus au moyen d'un contrôle sur les achats d'huile à chauffage faits par les personnes qui, dans leurs entreprises, sont les plus aptes ù se servir d'huile pour actionner leurs machines ou véhicules.Il est ordonné en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre des finances: Que, conformément à l'article 44 de la Loi .lu Contrôle du revenu, S.R.Q.1941, chapitre 73 et ses amendements, il soit décrété ce qui suit: 1° Les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs en opérations forestières, les entrepreneurs en excavation, les entrepreneurs en pavage, les entrepreneurs de carrières de pierre, les services dc transport par camions ou autobus (passagers ou marchandises) devront payer lors dc l'achat par eux d'huile à chauffage, la taxe prévue par la Loi de la gazoline, chapitre 83, S.R.Q., 1941 ; ces personnes pourront, cependant, soumettre au Bureau du revenu une demande de remboursement de l'impôt relatif à l'huile à chauffage qui aurait été employée par elles pour alimenter un système de chauffage ou pour fins dc nettoyage.La procédure à suivre dans le cas de ces remboursements sera la même que celle prévue à l'article 19 dc la Loi dc la gazoline.2° Toute autre personne employant de l'huile dite à chauffage pour une fin autre que celle de nettoyer ou d'alimenter un système de chauffage quelconque devra aussi se conformer aux prescriptions du paragraphe I.3° Toute personne autre que celles mentionnées aux paragraphes précédents, achetant de l'huile dite à chauffage et utilisant cette huile exclusivement comme combustible en vue d'alimenter un système de chauffage quelconque ou pour nettoyer, est.exemptée lors de l'achat par elle, du paiement de la taxe prévue par l'article 4 de la Loi de la gazoline, S.R.Q.1941, chapitre 83 et amendements.Le présent arrêté en conseil remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs à l'huile à chauffage, spécialement l'arrêté en conseil numéro 2G00, du 13 septembre 1935.Extrait (Signé) L.DÊSILETS, 44138-0 Greffier du Conseil Executif.has given rise to abuse in that large quantities of oil known in trade as fuel oil may equally be used and, in fact, arc used to operate various engines or motor-vehicles.Whereas it is in the public interest that such abuses be checked by way of a control over purchases of fuel oil made by those persons who, in their business, are more likely to use fuel oil to operate their engines or motor-vehicles.It is ordered therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Finance: That, in accordance with article 44 of the Provincial Revenue Act, R.S.Q.1941, chapter 73 and amendments, it be decreed as follows: 1.General contractors, forestry operation contractors, digging contractors, road-surfacing contractors, stone quarry contractors, truck or autobus transport line owners (passengers or goods) will pay, on their own purchase of fuel oil, the duly specified by the Gasoline Act, chapter 83, R.S.Q.1941; the aforesmentioned persons may, however, file, with the Revenue Department, a claim for refund of the tax paid on fuel oil which they used in the operation of a heating system or for cleaning purposes.Procedure to be followed for such refunds will be identical to that specified at article 19 of the Gasoline Act.2.Everyone else using oil known as fuel oil for other purposes than that of cleaning or feeding some kind of heating system will be recpiired to adhere to the regulations contained in paragraph I.3.With the exception of the afore-mentioned persons, all others, purchasing oil known as fuel oil and using such oil exclusively as a fuel for the purpose of feeding some kind of heating system or cleaning, are, on making their own purchase, exempt from payment of the duty specified at article 4 of the Gasoline Act, R.S.Q.1941, chapter S3 and amendments.This Order in Council supersedes all previous orders concerning fuel oil, especially Order in Council number 2000, of September 13th, 1935.Extract (Signed) L.DÉSILETS, 44138-0 Clerk of the Executive Council.Avis divers AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat des Producteurs de Sucre et de Sirop d'Érable dc Québec-Sud\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le vingt et un décembre 1956.Ixî siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Georges-Ouest, comté dc Beauce.Le Sous-secrétaire de la province, 44084-O JEAN BRUCHÉSI.Miscellaneous Notices NOTICE (Professional Syndicates' Act) The fofVnation of an association under the name of \"Le Syndicat des Producteurs de Sucre ct de Sirop d'Érable de Québec-Sud\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, lias been authorized by the Provincial Secretary, on December twenty-first 1956.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint-Georges-West, countv of Beauce.JEAN BRUCHÉSI, 44084 Under Secretary of the Province, 236 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 Avis est par les présentes donné cpie l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu lc troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Coopérative d'Habitation de Donnacona\", en date du 18 décembre 1956, dont le siège social est situé à Donnacona, comté de l'ortneuf, ct que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat dc la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-huit décembre 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 44093-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Coopérative dc Crédit dc St-Jacques\", en date du 16 novembre 1956.dont le siège social est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat dc la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le quatre janvier 1957.Le Sous-secrétaire de la province, 41094-o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Coopérative d'Habitation de Donnacona\", under date of December 18, 1956, whereof the head office is at Donnacona, county of Portneuf, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twentv-cighth day of December 1956.JEAN BRUCHÉSI, 44093 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Coopérative de Crédit dc St-Jacques\" under date November 16, 1956, whereof the head office is at Montreal, judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this fourth day of January, 1957.JEAN BRUCHÉSI, 44094 Under Secretary of the Province.(P.G.13192-56) (A.G.13192-56) L'Association' des Membres nu Personnel L'Association des Membres du Personnel Enseignant des Ecoles Spécialisées Enseignant des Écoles Spécialisées relevant du ministère du bien-être social relevant du ministere du bien-être social et de la Jeunesse, Incorporée et de la Jeunesse, Incorporée Extrait du règlement N° 1 (règlements généraux) dc la corporation ci-haut mentionnée, tel qu'adopté à rassemblée générale tenue le 17 octobre 1956, concernant l'augmentation du nombre des directeurs dc trois à neuf: \"5° Bureau des- directeurs.\u2014 L'administration ct la gouverne dc l'Association sont confiées à un Bureau des Directeurs composé de neuf (9) représentants.\" Pour copie conforme.Le Sécrétai re-t résorier, 14095-o GÉRARD NEPVEU.Excerpt from By-law No.1 (General By-laws) of the corporation hereinabove mentioned, as adopted at a general meeting held October 17.1956, concerning an increase in the number of directors from three to nine: \"5.Board of Directors'.\u2014 The management and direction of the Association are entrusted to a Board of Directors composed of nine (9) members.\" True copy.GERARD NEPVEU, 44095 Secretary-Treasurer.(P.G.12737-56) Selective Lumber Inc.Règlement N° 4 (A.G.12737-56) Selective Lumber Inc.By-law No.k \"Le nombre des directeurs de la compagnie The number of the directors of the company est changé de trois qu'il était auparavant à celui is changed from three as it was to this dale, de quatre, et le règlement N° 1 de la compagnie to four, and by-law No.1, of the company i> est modifié en conséquence.\" Trois-Rivières, le 15 décembre 1956.(Sceau) Le Président, GEORGES GARIÉPY.Le Secrétaire, 44096-o RAYMOND TANGUAY.amended accordingly.Trois-Rivières, December 15th, 1956.(Seal) GEORGES GARIÉPY, President.RAYMOND TANGUAY, 44096-o Secretary-Treasurer.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \" Syndicat Coopératif des Éleveurs de Chinchillas de la Mauricie\", en date du 11 décembre 1956, dont le siège social est situé à Yamachiche, comté de Saint-Maurice, et que ce document a été déposé dans les archives du secrétariat dc la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt et un décembre 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 44097-o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif des Éleveurs de Chinchillas de la Mauricie\" under date of December 11, 1956, wdiereof the head office is at Yamachiche, County of Saint Maurice and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-first day- of December 1956.JEAN BRUCHÉSI, 44097 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.3 237 (13432-56) The Canadian Import Company, Limited Règlement .spécial \"E\" in règlement pour changer la situation du siège social de la compagnie dc la cité de Québec à la cité de Montréal.(A.Cr.13432-56) The Canadian Import Company, Limited Special By-law \"E\" A By-law to Change the Location of the Head Office of the Company from the City of Quebec to the City of Montreal.La situation du siège social de la compagnie est, The location of the Head Office of the Coin-par les présentes, changée de la cité de Québec à la pany is hereby changed from the City of Quebec cité de Montréal, province de Québec.to the City of Montreal in the Province of Que- Certifié vraie copie.bec.Daté en la cité de Montréal, P.Q., le 2 novem- Certified true copy, bre 1956.Dated at the City of Montreal, P.Q., the (Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 2nd dav of November ,1956.11098 C.-W.COULSON.(Seal) C.-W.COULSON, 44098-o Sccrctary-Treasu rer.Avis de changement de nom (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a autorisé, lc vingt, et un décembre 1956, le changement de nom de l\"'Association des Instituteurs de la Cité de Rivière-du-Loup\" en celui de \"Association des Instituteurs & Institutrices Catholiques de la Région de Rivière-du-Loup\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et suivants de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162.La formation dudit syndicat professionnel a été autorisée lc douze février 1953, et le siège social d'icelui est situé à Rivière-du-Loup.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-huit décembre 1956.«Le Sous-secrétaire de la province, 44122-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.2813-51) Atlas Hoist & Body Inc.Règlement N° 25 \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de Atlas Hoist & Body Inc., ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de six à cinq de manière que le bureau de direction de la compagnie soit composé dorénavant de cinq directeurs.2° Quatre directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° T bus les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles a ieehii sont, par les présentes, amendés, modifiés, cl revisés pour donner effet au présent règlement.\" Montréal, 28 mai 1956.Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 44123 D.RICHLER.(PC 11533-56) Kenaston Corporation Règlement N° 21A \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement clé Kenaston Corporation ce qui suit: I Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté trois à six, de manière que le bureau de direc- notice of change of name (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that on the twenty-first day December 1956, the Honourable the Provincial Secretary authorized the changing of the name of \"Association des Institutrices de la Cité de Rivière-du-Loup\" to that of \"Association des Listituteurs & Institutrices Catholiques de la Région dc Rivière-du-Loup\", and such, pursuant to the provisions of sections 7 and the following of the Professional Syndicates Act, R.S.Q.1941, chapter 162.The formation of said professional syndicate had been authorized the twelfth day of February 1953, with head office located at Rivière-du-Loup.Given at the office of the Provincial Secretary, the twenty-eighth dav of December 1956.JEAN BRUCHÉSI, 44122 Under Secretary of the Province.(A.G.2813-51) Atlas Hoist & Body Inc.By-law No.25 \"Be it enacted and it is hereby enacted as a By-law of Atlas Hoist & Body Lie, as follows: 1.The number of Directors of the Company be and the same is hereby decreased from six to five so that the Board of Directors of the Company shall hereafter be composed of five Directors.2.Four Directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors., 3.All prior By-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this By-law.\" Montreal, May 28th, 1956.Certified true copy.D.RICHLER, 44123-0 Secretary.(A.G.11533-56) Kenaston Corporation By-laio No.21A \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of Kenaston Coqioration as follows: 1.The number of Directors of the Company be and the same is hereby increased from three to six so that the Board of Directors of the 238 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 tion de la compagnie soit composé dorénavant de six directeurs.2° Deux directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° Tous les règlements, résolutions ct procédures antérieurs dc la compagnie incompatibles à icclui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés pour donner effet à ce règlement.\" Décrété ce 15e jour dc mai 195G.Le Secrétaire, 44124 SAM LONN.(P.G.13457-56) Chidougamau Theatre Inc.Règlement Spécial \"A\" Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs dc trois à six.\"Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau dc direction de six directeurs, dont trois constitueront quorum.\" Certifie vraie copie., Montréal, 2 novembre 1956.Le Secrétaire, 44148 SARAH MILLER.(P.G.11553-56) La Corporation de l'Hôpital St-Ambroise de Loretteville Règlement N° 15 \"Sur motion dûment proposée, secondée et adoptée à l'unanimité, il est décrété: Que le règlement N° 15, soit amendé en changeant le chiffre \"cinq\" par le chiffre \"sept\" de manière à ce que le règlement ainsi amendé se lise comme suit: 15.Nombre: Les affaires dc la Corporation seront administrées par un bureau dc direction composé de sept membres.\" Certifié vraie copie.Daté à Loretteville, P.Q., ce 16ième jour d'octobre, 1956.Le Secrétaire-trésorier, 44149-0 GÉRARD RENAUD, C.A.AVIS (Loi des syndicats professionnels) .La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association Syndicale des Employés de Postes d'Essence et de Garages des Comtés de Trois-Rivières, St-Maurice, Maskinongé, Champlain et Laviolette\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par lc Secrétaire de la Province le seize janvier 1957.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Le Sous-sccrétaire dc la Province.44163-0 JEAN BRUCHÉSI.Chartes \u2014 Abandon de AVIS En vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie Burlington Dress Inc., donne par les présentes, Company shall hereafter be composed of six Directors.2.Two Directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this By-law.\" Enacted this 15th dav of Mav, 1956.' SAM LONN, 44124-0 Secretary.(A.G.13457-56) Chibougamau Theatre Inc.Special By-law \"A\" A By-law to increase the number of directors from three to six.\"The affairs of the Company shall be managed by a Board of six Directors, all of whom form a quorum.\" Certified a true copy.Montreal, November 2.1956.SARAH MILLER, 44148-Q Secretary.(A.G.11553-56) La Corporation de l'Hôpital St-Amiiroisf.de Loretteville By-law No.15 \"Upon motion duly proposed, seconded and unanimously adopted, it is enacted: That'by-law No.15 be amended by changing the number \"five\" for the number \"seven\" so that the by-law so amended shall read as follows.15.Number: The affairs of the Corporation shall be administered by a board of Directors composed of seven members.\" Certified true copy.Dated at Loretteville, P.Q., this 16th day of October, 1956.GÉRARD RENAUD, C.A.44149 Secretary-Treasurer.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under I lie name of \"Association Syndicale des Employés dc Postes d'Essence et de Garages des Comtés de Trois-Rivières, St-Maurice, Maskinongé, Champlain et Laviolette\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on January sixteenth 1957.The principal place of business of the said professional syndicate is at Trois-Rivières.judicial district of Trois-Rivières.JEAN BRUCHÉSI.44163 Under Secretary of the Province.Charters \u2014 Surrender of NOTICE Under the Provisions of the Quebec Companies Act, Part I, Burlington Dress Inc., hereby gives notice that it will make application to the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.3 239 avis qu'elle s'adressera au Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, pour obtenir l'abandon de sa charte et son annulation à compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Montréal, 31 décembre 1956.Burlington Dress Inc., par: Le Secrétaire, 11099 LOUIS STOTLAND.BoURLAMAQUE AsSAYERS & ClIEMISTS Limited I'ii vertu dc la Loi des compagnies de Québec, la compagnie Bourlamaque Assaycrs& Chemists Limited donne, par les présentes, avis qu'elle demandera à l'Honorable Procureur général de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté ce 3c jour de janvier 1957.Le Secrétaire-trésorier.1-1101 A.D.HELLENS.Saint-Pierre & Chartrand Compagnie Limitée Avis est par les présentes donné que \"Saint-Pierre & Chartrand Compagnie Limitée\", une corporation constituée sous les dispositions de la Loi des Compagnies, et ayant ses principal bureau et place d'affaires dans la Cité ct le District de Montréal, va faire une demande auprès du Procureur-Général de la Province de Québec pour permission d'abandonner sa charte, sons les dispositions dc la Loi des Compagnies.Signé à Montréal, ce lOième jour de Janvier 1957.Le Secrétaire, 11125-o JEAN-B.SAINT-PIERRE.Lieutenant-Governor of the Province of Quebec.for the acceptance of the surrender of its ('barter and its cancellation on and from a date to be fixed by him.Montreal, 31st December, 1956.Burlington Dress Inc., Per: LOUIS STOTLAND, 44099-o Secretary.Bourlamaque Assayers & Chemists Limited Under the Quebec Companies Act.Bourlamaque Assayers & Chemists Limited hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender the charter of the Company.Dated this 3rd dav of January 1957.A.D.HELLENS, 441.01-o Secretary-Treasurer.Saint-Pierre & Chartrand Compagnie Limitée Notice is hereby given that the \"Saint-Pierre & Chartrand Compagnie Limitée\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act, and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 10th day of January 1957.JEAN-B.SAINT-PIERRE, 44125-0 Secretary.Goyer Street Corporation Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Goyer Street Corporation\", une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 15e jour de janvier 1957.Les Procureurs de Goyer Street Corporation, LIVERMAN, LIVERMAN & BRISKIN.1435 rue St-Alexandre,-Montréal, Québec.\u20221-1139 Goyer Street Corporation Notice is hereby given that the \"Goyer Street Corporation\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 15th day of January 1957.LIVERMAN, LIVERMAN & BRISKIN, Attorneys for Goyer Street Corporation.1435 St.Alexander Street Montreal, Quebec.44139-0 Montreal Vinegar Company Limited La Compagnie de Vinaigre Montréal Limitée Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Montreal Vinegar Company Limited \u2014 La Compagnie de Vinaigre Montréal Limitée\" demandera au Procureur Général de la Province la permission d'abandonner sa charte.St-Jean, 8 janvier 1957.L'Avocat de la Compagnie, 44140-o STANISLAS DÉRY.Burnside Investments Ltd.En vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"Burnside Investments Ltd.\", donne, par les présentes, avis Montreal Vinegar Company Limited La Compagnie de Vinaigre Montréal Limitée Notice is hereby given that the company \"Montreal Vinegar Company Limited \u2014 La Compagnie de Vinaigre Montréal Limitée\" will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrentier its charter.St.John, Januarv 8, 1957.STANISLAS DÉRY, 44140 Attorney for the Company.Burnside Investments Ltd.Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"Burnside Investments Ltd.\", hereby gives notice that it will make application 240 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 qu'elle s'adressera au Lieutenant-gouverneur en Conseil pour obtenir l'abandon «le sa charte et son annulation à compter «le la date qu'il lui plaira de fixer.Montréal, 10 janvier 1957.Le Secrétaire, 44150 JACK REITMAN.to the Lieutenant-Governor in Council for acceptance of the surrender of its Charter and its cancellation on and from the date to be fixed by him.\u2022 Montreal, January 10th, 1957.JACK REITMAN, 44150-o Secret arv.Cumminqs Enterprises Inc.Avis est par les présentes donné que \"Cum-mings Enterprises Inc.\", a l'intention de demander au Procureur Général de la Province de Québec la permission d'abandonner sa charte.20 «lécembre, 1956.Le Secrétaire-trésorier, 44151-0 PHILIP F.VINEBERG.Adélard Pincince Automobile Inc.Avis est par les présentes donnés que \"Adélard Pincince Automobile Inc.\".une corporation constituée suivant les los des Compagnies du Québec ct ayant son bureau principal en la Cité de Magog, s'adressera au Procureur-Général «le la Province de Québec pour abandonner sa charte suivant les stipulations «le la Loi des Compagnies dc Québec.Daté à Magog, ce 14 janvier 1957.Le Secrétaire.44152-0 E.DUSSAULT.Cummings Enterprises Inc.Notice is hereby given under the Quebec Companies' Act and Amendments that \"Cummings Enterprises Inc.\", intends to make application to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.December 20th.1950.PHILIP F.VINEBERG, 44151 -o Secret ary-treasurer.Adélard Pincince Automobile Inc.Notice is hereby given that the \"Adélard Pincince Automobile Inc.\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act, and having its head office in the City of Magog, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Magog, this 14th of Januarv 1957.E.DUSSAULT, 44152-o Secretary.Commission du Salaire Minimum Minimum Wage Commission AVIS L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les prtsentes que l'ordonnance d'amendement, dont le texte suit, a été approuvée par l'arrêté en conseil numéro 34, du 10 janvier 1957.Commission du salaire minimum Ordonnance d'amendement La commission du salaire minimum, en exécution dc la Loi du salaire minimum (S.R.Q., 1941, c.164).Ordonne et décrète par la présente ordonnance d'amendement, ainsi qu'il suit, savoir: 1.Ordonnance n° 4, 1953 modifiée: L'ordonnance n° 4, 1953 adoptée par la Commission du salaire minimum le 18 mars 1953, approuvée par le Lieutenant-gouverneur en conseil le 26 mars 1953 par arrêté portant le numéro 373, publiée dans la Gazette officielle de Québec le 25 avril 1953 et subséquemment modifiée et renouvelée, est de nouveau modifiée tel que décrétée en la présente ordonnance; a) L'article 26 de la dite ordonnance est modifié en remplaçant au paragraphe 1 les mots ct chiffre \"n° 3, revisée\" par le mot et les chiffres \"n° 3, 1957.\" b) L'article 33 de la dite ordonnance est modifié en y ajoutant ce qui suit: \"Les établissmeents de pêche des Iles «le la Madeleine, ainsi que les établissmenets s'y trouvant où l'on apprête, conserve, fume, transforme ou met en conserve le poisson, les mollusques, les crustacés et tous autres fruits de mer\".NOTICE The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the following ordinance of amendment has been approved by Order in Council No.34 of January 10, 1957.Minimum wage commission Ordinance of amendment The minimum wage commission, under the Minimum Wage Act (R.S.Q., 1941, c.164)i Orders and decrees by the present Ordinance of amendment, the following, to wit: 1.Ordinance No.4, 1953 amended: Ordinance No.4, 1953 adopted by the Minimum Wage Commission on March 18, 1953, approve*! by the Lieutenant-Governor in Council on March 26, 1953 by Order in Council No.373, published in the Quebec Official Gazette on April 25, 1953, and subsequently amended ami renewed, is again amended as enacted by the present Ordinance: «) Section 26 of the said Ordinance is amended by replacing in paragraph 1 the words .ami number \"No.3, revised\" by the word ami numbers \"No.3, 1957\".b) Section 33 of the said Ordinance is amended by adding thereto the following: \"Fishing establishments of Magdalen Islands, as also the establishments situated therein where fish, mollusca, Crustacea (shellfishes) and all other sea foods are prepared, kept, smoked, converted or canned.\" QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 241 c) L'article 49 de la dite ordonnance est remplacé par le suivant: \"49.Congés: Les salariés des dits établissements et entreprises visés par l'ordonnance n° 3, 1957 ont droit aux avantages accordés par cette ordonnance.\" d) L'article 64 de la dite ordonnance est modifié en y remplaçant les mots et chiffre \"n° 3, revisée\" par le mot ct les chiffres \"n°'3, 1957\".e) L'article 79 de la dite ordonnance est modifié en y remplaçant les mots et chiffre \"n° 3, révisée\" par le mot et les chiffres \"n° 3, 1957\"./) L'article 88 de la dite ordonnance est modifié en y remplaçant les mots et chiffre \"n° 3, révisée\" par le mot et les chiffres \"n° 3, 1957\".g) L'article 104 de la dite ordonnance est modifié en y remplaçant les mots et chiffre \"n° 3, revisée\" par le mot et les chiffres \"n° 3, 1957\".2.Entrée en vigueur: La présente ordonnance d'amendement entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Fait et passé en la cité de Montréal, ce douzième jour du mois de décembre mil neuf cent cinquante-six.Commission du salaire minimum, Le Président, (Signé) MARC TRUDEL, m.d.Le Secrétaire-général, (Signé) PHILIPPE ROUSSEAU, c.r.(Sceau) ( 'opie conforme.PHILIPPE ROUSSEAU, C.R., 11102-o Le Secrétaire-général._ * AVIS L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes que l'ordonnance numéro 3, 1957, concernant les congés annuels payés, a été approuvée par l'arrêté en conseil numéro 34 du 10 janvier 1957.Commission du salaire minimum Ordonnance n° 8,1957 Congés annuels payés La commission du salaire minimum, en exécution de la Loi du salaire minimum (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 164).Ordonne et décrète par la présente ordonnance, ce qui suit savoir: PREMIÈRE PARTIE Préliminaires 1.Désignation: La présente ordonnance est désignée sous le nom de \"Ordonnance n° 3,1957\".2.Champ d'application: La présente ordonnance régit les salariés ci-après mentionés et leurs employeurs.3.Salariés régis: La présente ordonnance régit les salariés auxquels s'applique la Loi du salaire minimum et qui sont assujettis à une ordonnance de la Commission, sauf les salariés mentionés à l'article suivant.4.Salariés non régis: La présente ordonnance ne régit pas les salariés suivants: a) Le salarié assujetti à une convention collective prévoyant un plan de congés annuels pavés d'au moins une semaine; b) Le salarié assujetti à l'ordonnance n° 39, 1942 (Exploitations forestières); c) Section 49 of the said Ordinance is replaced by the following: \"49.Holidays: Employees of said establishments and undertakings contemplated by Ordinance No.3,1957 are entitled to the benefits granted by this ordinance.d) Section 64 of the said Ordinance is amended by replacing therein the words and number \"No.3, revised\" by the word and numbers \"No.3, 1957\".c) Section 79 of the said Ordinance is amended by replacing therein the words and number \"No.3, revised\" bv the word and numbers \"No.3, 1957\"./) Section 88 of the said Ordonance is amended by replacing therein the words and number \"No.3, revised\" by the word and number \"No.3, 1957\".g) Section 104 of the said Ordinance is a-mended by replacing therein the words and number \"No.3, revised\" bv the word and numbers \"No.3, 1957\".2.Coming into force: The present Ordinance of amendment shall come into force on the day of its publication in the Quebec Official Gazette.Signed and dated in the city of Montreal, this twelfth day of December in the year one thousand nine hundred and fifty-six.Minimum wage commission.(Signed): MARC TRUDEL, M.D.President.(Signed) PHILIPPE ROUSSEAU, Q.Ç.Secretary-general.(Seal) True copv.PHILIPPE ROUSSEAU, Q.C.44102-o Secretary-general.NOTICE The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the following Ordinance No.3, 1957, concerning annual vacations with pay, has been approved by Order in Council No.34 of January 10, 1957.Minimum wage commision Ordinance No.3,1957 Annual vacation with pay The minimum wage commission, under the Minimum Wage Act (R.S.Q., 1941, c.164).Orders and decrees by the present Ordinance, the following, to wit: PART ONE Preamble 1.Designation: The present Ordinance is designated by the name of Ordinance No.3, 1957.2.Application: The present Ordinance governs the employees hereinafter mentioned and their employers.3.Employees governed: The present Ordinance governs the employees to whom the Minimum Wage Act applies and who are subject to an ordinance of the Commission, except the employees mentioned in the following section.4.Employees not governed: The present Ordinance does not govern the following employees: a) The employee subject to a collective labour agreement providing for an annual vacation with pay plan of at least one week; b) The employee subject to Ordinance No.39, 1942 (Forest Operations); 242 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 c) Le salarié assujetti à l'ordonnance n° 41, 1953 (Corporations municipales et corporations scolaires); d) Le salarié bénéficiant, aux termes d'une ordonnance, d'une indemnité de congé onde congés annuels payés; e) Le salarié, vendeur ou agent qui, payé en tout ou en partie par commission ou part de profits ou boni et libre de travailler à son gré, travaille normalement en dehors de l'établissement de son employeur sans que ce dernier ne puisse exercer de contrôle sur son temps de travail; /) Le salarié préposé à la surveillance constante de l'établissmeent dc son employeur et logé gratuitement sur les lieux mêmes; g) Le conscierge d'une maison à appartements; h) Lc salarié travaillant à son domicile; i) Le salarié engagé à la semaine ou pour une plus longue période qui, régulièrement, ne travaille pas plus de trois heures par jour.DEUXIÈME PARTIE Salariés autres que les salariés manuels de l'Industrie de la Construction 5.Champ d'application: La présente partie régit les salariés visés par la présente ordonnance à l'exclusion des salariés manuels, tels que ci-après définis, de l'industrie de la construction.6.Droit au congé: Tout salarié régi par la présente partie a droit: o) après un an de service continu pour son employeur, à un congé annuel continu payé d'une durée minimum dc sept jours; et b) s'il n'a pas un an de service continu pour son employeur, à un congé annuel continu payé d'une durée minimum d'autant de demi-jours qu'il a dc mois dc calendrier dc service continu pour son employeur.7.Période de service continu donnant droit, au congé: Pour chaque congé annuel payé, la période de service continu pour un employeur donnant droit à tel congé, s'établit au premier mai d'une année au trente avril dé l'année subséquente.8.Services continus: La durée des services continus doit s'entendre de la période pendant laquelle le salarié régi par la présente partie est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompue sans qu'il y ait résiliation de contrat.Ne sauraient notamment être considérés comme interrompant la durée des services continus, les jours de maladie, si le contrat n'a pas été résilié, les jours de fermeture, les périodes de congé annuel, le délai-congé, les absences autorisées, si le salarié régi par la présente partie n'a pas occupé pendant ces journées un autre emploi rémunéré.Dans la durée des services, les mois de calendrier durant lesquels un salarié n'a pas en fait travaillé quoiqu'il n'y ait pas eu résiliation de son contrat de travail, ne sauraient être comptés.9.Rémunération: Le salarié régi par la présente partie a droit pour son congé à une rémunération équivalente, a) s'il est engagé ct payé à la semaine ou pour une plus longue période, au salaire auquel il aurait droit s'il travaillait pendant les jours de travail de sa période dc congé; b) s'il est payé suivant un autre mode, à deux pour cent (2%) du salaire gagné, en incluant l'indemnité pour vacances, durant la période s'étendant du premier mai au trente avril suivant et lui donnant droit à tel congé.c) The employee subject to Ordinance No.11, 1953 (Municipal corporations and school corporations) ; d) The employee entitled, under an ordinance, to a vacation indemnity or to an annual vacation with apy; e) The employee, salesman or agent paid in whole or in part by commission, share in profits or bonus and free to work as he chooses, who habitually works outside his employer's establishment and beyond such employer's control on his time of work; /) The caretaker continously supervising his employer's establishment who is provided with free lodgings on the premises; g) The apartment house janitor; h) The employee working at home; i) The employee hired by the week or for a longer period who, habitually, does not work more than three hours in a day.PART TWO All employees except the manual workers of the Building Construction Industry 5.Application: The present part governs the employees contemplated by the present Ordinance, except the manual workers as hereinafter described of the construction industry.6.Right to a vacation: Any employee governed by the present, part is entitled a) after one year's conlinous service in the employ of his employer, to a continous annual vacation with pay having a minimum duration of seven days; and b) if he has not yet completed a year's service in the employ of his employer, to a continous annual vacation with pay having a minimum duration of as many half-days as the number of calendar months during which he has been continously in the employ of his employer.7.Period of continuous service which gives right to aforesaid vacation: For each annual vacation with pay, the period of continuous service in the employ of an employer which gives right to such vacation, begins on the first day of May of one year and ends on the thirtieth day of April of the following year.8.Continuous service: By \"duration of continuous service\" is meant the period during which the employee is bound by a labour contract to work for his employer, even if the carrying out of the aforesaid contract has been interrupted without the contract being cancelled.Shall not be considered as interrupting tin-duration of continuous service, days of absence through illness, if the contract has not been cancelled, as also days on which the establishment remains closed, the annual vacation, the term of notice and authorized absences, provided that during such days the employee did not hold any other remunerated employment.Shall not be counted in the period of continuous service, the calendar months during which an employee has not effectively worked even though his labour agreement has not been cancelled.9.Remuneration: For his vacation the employee governed by the present part is entitled to remuneration equal to a) the wages to which he would be entitled il he were to work during the working days of his vacation period, if he is engaged and paid by the week or for a longer period; b) two per cent (2%) of the wages earned, including vacation indemnity, during the period extending from the 1st of May to the 30th of April next and entitling him to such vacation, if he is paid on any other basis. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol 89, No.3 243 10.Avantages additionnels: Durant le congé de son salarié régi par la présente partie, l'employeur doit continuer à lui procurer les.avantages en nature et autres auxquels il a droit, tels que la pension, la contribution à un fonds de pension, la contribution à une police d'assurance-groupe sur la vie, les bénéfices de soins médicaux, etc.11.Échéance de la rémunération: Avant le départ du salarié visé par le paragrahpe b de l'article 9, l'employeur doit lui payer sa rémunération pour congé.12.Période de prise de congé: Chaque congé doit être donné dans les douze mois de la daté à laquelle le droit à tel congé est acquis, i.e.au premier mai de chaque année.13.Fixation de la période de congé: Le salarié a le droit de connaître au moins quinze jours à l'avance, la période de son congé.14.Résilation du contrat de travail: Lors de la résilation de son contrat de travail, le salarié régi par la présente partie a droit à une indemnité a) représentant la rémunération payable lors de la prise de congé auquel il a un droit acquis, s'il n'a pas pris tel congé, et b) représentant deux pour cent (2% du salaire gagné depuis lc premier mai précédant la date de son départ.Le droit à cette indemnité n'appartient qu'au salarié et non à ses représentants.15.Congé obligatoire: Sauf lorsque la présente ordonnance l'autorise, il est interdit à un employeur de remplacer par une indemnité compensatrice le congé annuel payé prescrit par la présente partie.10.Conventions interdites: Est expressément interdite toute stipulation d'un contrat individuel de travail ou d'une convention o) à l'effet d'accorder à un salarié régi par la présente partie un congé annuel payé d'une durée moindre ou à des conditions moins avantageuses que celles fixées par la présente partie; ou b) à l'effet d'accorder à un tel salarié, lors de la résiliation de son contrat de travail, une indemnité compensatrice moindre que celle fixée par l'article 14 de la présente partie.17.Convention permise: Un employeur et son salarié régi par la présente partie peuvent convenir que les rémunérations et indemnités prévues à la présente partie soient acquittées en timbres de congés tel qu'établi en la troisième partie de la présente ordonnance.18.Mentions au registre: L'employeur, en plus des mentions obligatoires en vertu d'une ordonnance ou d'un règlement dc la Commission, doit mentioner dans son registre de travaij, pour chaque salarié régi par la présente partie, a) la date de son entrée en service; b) la durée de son congé annuel payé; c) la date de son départ en congé; d) le montant et la date du paiement de l'indemnité versée pour la durée de son congé.TROISIÈME PARTIE Salariés manuels de l'industrie de la construction d'immeubles 19.Définitions: Les termes ci-après, lorsque mentionés en la présente partie, ont, à moins d'incompatibilité, le sens qui leur est ci-après donné: 10.Additional advantages: During the vacation of his employee governed by the present part, the employer shall continue to procure for him the advantages to which he is entitled, whether in kind or of another nature, such as boarding, contribution to a pension fund, contribution to a group life insurance policy, sick benefits, etc.11.Date of payment of remuneration: The vacation pay shall be given by the employer to his employee governed by section 9, subsection 6, before the said employee's departure on vacation.12.Period during which vacation is to be taken: Every vacation shall be given within twelve months from the date on which the right to such vacation is acquired, i.e.the first of May of every year.13.Fixing the date of vacation: The employee has the right to know the date of his vacation at least fifteen days in advance.14.Cancellation of labour contract: At the time of the cancellation of his labour contract, the employee governed by the present part is entitled to an indemnity a) consisting of the remuneration payable to him at the time of his taking the vacation to which he has a right if he has not taken such vacation, and b) consisting of two per cent (2%) of the wages earned after the first of May preceding the date of his departure.The employee only, not his representatives, is entitled to such indemnity.15.Compulsory vacation: It is forbidden for an employer to replace by a compensating indemnity the annual vacation with pay prescribed by the present part, exept when the present Ordinance permits so to do.16.Forbidden agreements: Is strictly forbidden, any stipulation of an individual labour contract or of an agreement a) for the purpose of granting to an employee governed by the present part, an annual vacation with pay of a shorter duration or on conditions less advantageous than those fixed by the present part; or b) for the purpose of granting, at the time of the cancellation of the labour contract, a compensating indemnity inferior to the one prescribed by section 14 of the present part.17.Permitted agreement: The employer and his employee governed by the present part may agree that the remunerations and indemnities provided for in the present part be paid with vacation-with-pay credit stamps, as established by the third part of the present Ordinance.18.Recording of particidars in register: The employer, besides recording in his register the particulars required by an ordinance or a by-law of the Commission, shall record therein, for each employee governed by the present part,» o) the date of his entrance into the service of the employer; b) the duration of his annual vacation with pay; c) the date of his leaving on vacation; d) the amount and date of payment of the indemnity paid to him for the duration of his vacation.THIRD PART Manuel workers of the building construction industry 19.Definitions: In the present part, barring incompatibility, the following terms have the meaning hereinafter given: 244 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 a) Constructeur: Un employeur dont rentre-prise principale est l'exécution de t nivaux de construction d'immeubles; b) Construction d'immeubles: L'édification, la transformation, la démolition, l'aménagement ou la réparation d'édifices ou dc travaux dc génie, ce qui comprend tous les ouvrages dont normalement l'exécution est dirigée ou surveillée par un architecte ou un ingénieur professionnel; c) Commission: La Commission du salaire minimum; d) Livret de timbres dc congé payé: Un livret émis par la Commission aux fins d'y apposer durant une période de prestations, des timbres de congés payés; e) Période dc prestations: La période s'étendant du premier mai d'une année au trente avril de l'année suivante; /) Salarié: Un salarié ayant droit, aux termes de la présente partie, à une rémunération pour congés; g») Timbres: La marque imprimée ou vignette émise par la Commission pour représenter les prestations de congés dues par un constructeur.20.Champ d'application: La présente partie régit les constructeurs exécutant des travaux dc construction d'immeubles ct leurs salariés manuels y participant.21.Droits du salarié: a) Aux congés payés: Tout salarié régi par la présente partie, ayant été au service continu «l'un constructeur durant une période «le prestations, a «lroit, à la fin «le telle pério«le, à un congé d'une durée minimum «le sept jours consécutifs et à la rémunération pour congés ci-après fixée; b) A rémunération pour congt's: Tout salarié régi par la présente partie, n'ayant pas été au service continu d'un constructeur «lurant une pé-pt*rio«le dc prestations, a droit, à la fin de telle période, seulement à la rémunération pour congés ci-après fixée.22.Prise de congé: Le constructeur doit «lon-ncr à son salarié y ayant droit, le congé prévu par la présente partie, dans les douze mois qui suivent la date de la fin d'une période «le prestations.23.Rémunération pour congés: La rémunération pour congés à laquelle a droit un salarié régi par la présente partie représente, pour une période de prestations, la valeur des timbres apposés pour telle période dans son livret de timbres de congé payé.24.Apposition de timbres: .Tout constructeur doit apposer, à l'échéance «le chaque paie de son salarié régi par la présente partie, dans le livret «le timbres «le congé payé de ce dernier, des timbres pour une valeur égale à «leux pour cent (2%) du montant brut de telle paie.25.Obligations du constructeur: Tout constructeur doit: a) Se procurer de la Commission, avant le commencement d'une période «le prestations, un livret de timbres de congé payé pour chacun de ses salariés régis par la présente partie; b) exiger «le tout salarié régi par la présente partie, embauché au cours d'une période de prestations, la remise de son livret dc timbres de congé payé ct, s'il n'en possède pas, lui en procurer im; c) conserver jusqu'à la fin «l'une période de prestations ou, s'il y a résiliation antérieure du contrat de travail, «lurant le remps d'emploi, le livret de timbres «le congé payé de chacun dc ses salariés ré'gis par la présente partie; d) remettre à chacun de ses salariés ré'gis par la présente partie, à la fin d'une période de pres- a) Constructor: The employer whose principal business concern is the execution of building construction work; b) Building Construction Work: The erection, alteration, demolition, remodelling or repair of buildings, or engineering works, i.e.all work normally execute*! under the control or supervision of an architect or a professional engineer; c) Commission: The Minimum Wage Commission; d) Vacation with Pay Stamp Book: A book jssucd by the Commission for the purpose of affixing herein during a vacation-with-pay credit period, vacation-with-pay credit stamps; e) Vacation with Pay Credit Period: The period extending from the first of May of one year to the 30th of April of the next year; /) Employee: The employee entitled under the present part, to vacation-with-pay crc«lit; g) Vacation with pay Credit Stamp: The printed mark or stamp issued by the Commission, representing the vacation-with-pay credit payable by a constructor.20.Application: The present part governs all constructors carrying out building construction work, and their manual workers participating thereto.21.Right of the employee: a) To vacation with pay: Every employee governed by the present part whose work has been continuous with one constructor throughout a vacation-with-pay credit period is entitled, at the end of such a period, to a vacation having a minimum duration of seven consecutive days and to a vacation credit as hereinafter «letcrmined; b) to a vacation credit: Every employee governed by the present part whose work lias not been continuous with one constructor throughout a vacation-with-pay credit period is entitled, at the end of such a period, to a vacation credit only as hereinafter determined.22.Period during which vacation is to be taken: The constructor must give within twelve months from the date of expiration of a vacation-with-pay credit period, the vacation to which an employee is entitled according to the present part.23.Vacation credit: The vacation credit to which an employee governed by the present part is entitled represents, for a vacation-with-pay credit period, a sum of money equivalent to the face value of the stamps affixed in his vacation-with-pay stamp book for said credit period.24.Affixing of stamps: On each pay-day, every constructor must affix in his employee's vacation-with-pay stamp book vaaction-with-pay credit stamps in an amount equivalent to two per centum (2%) of the gross amount of the pay of said employee governed by the present part.25.Constructor's obligations: Every constructor must : a) Obtain from the Commission a vacation-with-pay stamp book for each of his employees governed by the present part, before the beginning of a vacation-with-pay credit period; b)' require from every employee governe*! by the present part, who is hired during a vacation-with-pay credit period, the delivery of his vacation-with-pay stamp book and, should be not possess such a book, give him one; c) keep the vacation-with-pay stamp book of each of his employees governed by the present part, till the end of a vacation-with-pay credit period or during the time of employment should the labour contract be previously cancelled; d) give back to each of his employees governed by the present part, at the*end of a vacation- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 245 tat ions on lors de la résiliation antérieure de son contrat de travail, son livret de timbres de congé payé.20.Obligations du salarié: Tout salarie régi par la présente partie doit a) remettre, sans délai, son livret de timbres de congé payé au constructeur qui rengage au cours «l'une période de prestations; b) réclamer du constructeur qui l'emploie, son livret de timbres de congé payé à la fin d'une période de prestations ou lors de la résiliation antérieure de son contrat de travail.27.Remboursement dc la rémunération: Tout salarié régi par la présente partie a le droit de réclamer de la Commission, à la fin d'une période de prestations, le remboursement des timbres apposés pour telle période, dans son livret de timbres dc congé payé.28.Propriété du livret de timbres de congé payé: Le livret de timbres de congé payé, bien qu'il puisse être en la possesion du constructeur est la propriété du salarie; la créance qu'il constate est incessible.29.Fourniture dc livrets et dc timbres: La Commission fournira, sur demande, à tout employeur d'un salarié régi par la présente partie, «) des livrets de timbres dc congé payé au prix fixé à l'occasion par la Commission; b) des timbres au prix de leur valeur nominale.30.Réclamation spéciale: Le salarié régi par la présente partie qui, au premier jour du mois de juin d'une année ou dans les trente jours de la résiliation de son contrat de travail, si elle est antérieure^ n'a pas reçu l'indemnité di-baut prévue en timbres de congé payé, peut réclamer dc son employeur une indemnité égale à la valeur des timbres de congé payé que ce dernier devait apposer dans le livret dc timbres de congé payé dc tel salarié.31.Convention interdite: Est expressément interdite toute stipulation d'un contrat accordant à un salarié régi par la présent partie, des conditions inoins avantageuses que celles fixées à la présente partie.QUATRIÈME PARTIE Dispositions générales 32.Fourniture de livrets et dc timbres: La Commission peut, aux conditions qu'elle détermine, fournir des livrets ct des timbres dc congé payé à un employeur ou à un salarié non régi par la deuxième partie de la présente ordonnance.33.Durée: La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu'au premier mai 1958.34.Ordonnances n° 3, revisée et numéro 8a abrogée: Sont abrogées a) l'ordonnance n° 3, revisée adoptée par la Commission le 12 août 1940, approuvée par lc Lieutenant-gouverneur en conseil le G septembre 1940 par arrêté portant le numéro 3575, publiée dans la Gazette officielle de Québec lc 14 septembre 1940 ct subséquemment modifiée ct renouvelée; b) l'ordonnance n° 3a adoptée par la Commission le 12 septembre 1949, approuvée par le Lieutenant-gouverneur en conseil le 20 octobre 1949 par arrêté portant le numéro 1101, publiée dans la Gazette officielle de Québec le 29 octobre 1949 et subséquemment modifiée et renouvelée.with-pay credit period or at the time of the previous cancellation of his labour contract, his vacation-with-pay stamp book.20.Employee's obligations: Every employee governed by the present part must: a) give back, without delay, to the constructor who hires him during a vacation-with-pay credit period, his vacation-with-pay stamp book; b) claim, at the end of a vacation-with-pay credit period or at the time of the previous cancellation of his labour contract, from the constructor who hires him his vacation-with-pay stamp book.27.Redemption of Stamps: Every employee governed by the present part, at the end of a vacation-with-pay period, has the right to claim from the Commission the redemption of the stamps affixed for such period hi his vacation-with-pay stamp book.28.Ownership of the vacation-with-pay stamp book: Though in the employer's hands, the vacation-with-pay stamp book belongs to the employee and the credit shown therein is untransferable.29.Supplying of vacation-with-pay stamp books and of a vacation-with-pay credit stamps: On request, the Commission will furnish to each employer of an employee governed by the present part, a) vacation-with-pay stamp books at the price fixed, from time to time, by the Commission; b) vacation-with-pay credit stamps at the price of thier face value.30.Special claim: The employee governed by the present part who, on the first day of the month of June of one year or within thirty days of the cancellation of his labour contract, should it be previous to, has not received the indemnity hereinabove provided for in vacation-with-pay credit stamps, may claim from his employer an indemnity equal to the value of the vacation-wit h-pay credit stamps the latter should have affixed in the vacation-with-pay stamp book of such an employee.31.Forbidden agreement: Any stipulation of a labour contract for the purpose of granting to an employee governed by the present part conditions iess advantageous than those fixed in the present part, is strictly forbidden.PART FOUR General provisions 32.Supplying of vacation-with-pay stamp books and of vacation-with-pay credit stamps: The Commission may furnish with vacation-with-pay stamp books and vacation-with-pay credit stamps, at the conditions it fixes, an employer or an employee not governed by the second part of the present Ordinance.33.Duration: The present Ordinance shall remain in force until May first 1958.34.Ordinances No.3; revised and No.8a repealed: Are repealed a) Ordinance No.3, revised adopted by the Commission on August 12,1940, approved by the Lieutenant-Governor in Council on September 0, 1940, by Order in Council No.3575, published in the Quebec Official Gazette on September 14, 1940, and subsequently amended and renewed; b) Ordinance No.3a adopted by the Commission on September 12, 1949, approved by the Lieutenant-Governor in Council on October 20, 1949, by Order in Council No.1101, published in the Quebec Official Gazette on October 29, 1949, and subsequently amended and rcniwed. 246 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 35.Entrée en vigueur: La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Fait et passé en la cité de Montréal, ce douzième jour du mois de décembre mil neuf cent cinquante-six.Commission du salaire minimum, Le Président, (Signé) MARC TRUDEL, m.d.Le Secrétaire-général, (Signé) PHILIPPE ROUSSEAU, c.r.(Sceau) Copie conforme.PHILIPPE ROUSSEAU, C.R., 44103-o Le Secrétaire-général.Compagnie dissoute (P.G.13608-56) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"The Claridge Realty Corporation, Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 8 janvier 1931.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un décembre 1956, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1957.L'Assistant-procureur général suppléant, 44081-o P.FRENETTE.Demandes à la Législature Commission scolaire St-Jean Vianney de Gatineau Avis est par les présentes donné que la Commission scolaire St-Jean Vianney de Gatineau s'adressera à la Législature de la province de Québec, durant la présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi spéciale amendant sa charte pour les fins suivantes: 1.Pour autoriser la Commission scolaire St-Jean Vianney pour fixer, par règlement, une indemnité au président et aux membres de la Commission scolaire; 2.Pour fixer l'évaluation aux compagnies suivantes: Canadian International Paper Company, Masonite Company of Canada Limited, International Fibre Board Limited, International Plywoods Limited.Gatineau, ce 21 décembre 1956.Le Président, ALFRED LAVICTOIRE.Le Secrétaire-trésorier, LÉO GIROUX.Contresigné: LIONEL MOUGEOT, Le Procureur de la Commission scolaire St-Jean Vianney.43963-52-4-o 35.Coming into force: The present Ordinance shall come into force on the day of its publication in the Quebec Official Gazette.Signed and dated in the city of Montreal, this twelfth day of December in the year one thousand nine hundred and fifty-six.Minimum Wage Commission.(Signed) MARC TRUDEL, m.d.(Seal) President.(Signed) PHILIPPE ROUSSEAU, Q.C., Secretary General.True copy, PHILIPPE ROUSSEAU, Q.C., Secreatry-General.44103-n Company Dissolved (A.G.13608-50) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the At-tomay General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Tho Claridge Realty Corporation, Limited\", incorporated by letters patent dated January 8, 1931.Notice is also given that from and after December thirty-first 1956, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January 1957.P.FRENETTE, 44081 Acting Deputy Attorney General.Applications to Legislature St-Jean Vianney of Gatineau School Commission * Notice is hereby given that the St-Jean Vianney of Gatineau School Commission will present a petition to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, to obtain the adoption of a special law, amending its charter for the following purposes: 1.To authorize the St-Jean Vianney School Commission to adopt a by-law to fix a salary for the president and members of the St-Jean Vianney School Commission; 2.To set an assessment for the following companies: Canadian International Paper Company, Masonite Company of Canada Limited, International Fibre Board Limited, International Plywoods Limited.Gatineau, this 21st day of December 1956.ALFRED LAVICTOIRE, ' President.LÉO GIROUX, Secretary-treasurer.Contersigned : LIONEL MOUGEOT, Attorney for the St-Jean Vianney School Commission, 43963-52-4-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.3 247 Avis public est par les présentes donné que les Commissaires d'écoles pour la municipalité du village de St-Félicien, Roberval, présenteront à la présente législature de Québec, un bill leur permettant d'imposer par résolution ct de prélever une taxe spéciale (dite d'éducation), de 1 pour cent du prix de vente ou d'achat en détail de tous bien meubles, effets mobiliers, toutes marchandises et tout article de commerce quelconque, vendus dans les limites de leur territoire.Québec, ce 20 décembre 1956.Le Procureur des requérants, 1305S-52-4-o W.IIIDOLA GIRARD, C.R.Avis est, par les présentes, donné que la \"Ville de LaPrairie\", dans le comté de Laprairie, s'adressera à la Législature de la Province de Québec à sa présente session pour obtenir l'adoption d'une loi pour annexer à son territoire les lois et parties de lots suivants: La totalité des lots numéros 316 à 363 inclusivement et leurs subdivisions; la totalité des lots numéros 364 à 456 inclusivement; la totalité des lots numéros 457 à 516 inclusivement; la totalité des lots numéros 517 à 542 inclusivement; les lots numéros 543, 544,-545, 546, la partie nord-ouest du lot 547, ct leurs subdivisions; la partie nord du lot 518; la totalité des lots numéros 550, 551, 552, 553, 554, 547A, et partie des lots numéros 555, 550, 557, 558, 559, 560, 070, 073, et leurs subdivisions, tous des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie de la Magdeleine, et pour redistribuer les quartiers, demander un fonds de roulement et autres pouvoirs additionnels.Montréal, 29 décembre 1956.Les Procureurs dc la requérante, 11006-1-4-o MONE1TE ET FILION.Avis est par les présentes donné que Henry Ballon Nevard, étudiant en droit de la cité de Westmount, district de Montréal, présentera un projet de loi à la présente session de la Législature de la Province de Québec pour autoriser son admission à l'étude et à l'exercice de la profession d'avocat dans la Province de Québec.Montréal, le 18 décembre 1956.Les Procureurs du Requérant, 1IUGESSEN, MACKLAIER, CHISHOLM, 14022-2-4-o SMITH & DAVIS.Avis public est, par les présentes, donné que la cité dc Lachine s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, la loi 9 Edouard VII, chapitre 86 et amendements, en sus des matières décrites à l'avis du 12 novembre 1956, sur les matières suivantes: pour décréter mie le terme d'office du maire et des échevins sera de trois ans, à compter de la prochaine élection générale; et pour autres fins.Montréal, le 8 janvier 1957.Les Procureurs de la Cité de Lachine, 44055-2-4-o LACROIX, VIAU & POUPART.Canada, \u2014 Province de Québec District de Québec Cité de Québec Avis public est par les présentes donné que la Cité de Québec s'adressera à la Législature, à sa présente session, pour obtenir sur les matières \u2022suivantes certaines modifications à sa charte, hi loi 19 George V, chapitre 95, de même qu'aux différents statuts généraux ou particuliers qui la modifient ou la concernent: Public notice is hereby given that the Schoo Commissioners for the municipality of the village of St.Félicien, Roberval, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act authorizing them to impose, by resolution, a special sale tax of 1 per cent, called education tax, on the retail or purchase price of all moveables, personal effects, merchandise and any commercial article whatsoever sold within the limits of their territory.Quebec, this December 20th., 1956.W.HIDOLA GIRARD, Q.C., 43958-52-4-0 Attorney for the petitioners.Notice is hereby given that the \"Town of LaPrairie\", county of Laprairic, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for an Act to annex to its territory the following lots and parts of lots: The totality of lots 316 to 363 inclusively and their subdivisions; the totality of lots 364 to 456 inclusively; the totality of lots 457 to 516 inclusively; the totality of lots 517 to 542 inclusively; lots 543, 544, 545, 546, the north-west part of lot 547, and their subdivisions; the north part of lot 548; the totality of lots 550, 551, 552, 553, 554, 547A, and part of lots 555, 556, 557, 558, 559, 560, 670, 673 and their subdivisions, of the official plan and book of reference of the parish of Laprairie de la Magdeleine, and to resubdivise the wards, ask for a working ^capital and other additional powers.Montreal, December 29, 1956.MONETTE & FILION, 44006-1-4-o Attorneys for the petitioner.Notice is hereby given that Henry Ballon Nevard, law student, of the city of Westmount, district of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session for a Bill to authorize its admission to the study and practice of law in the Province of Quebec.Montreal, December 18, 1956.HUGESSEN, MACKLAIER, CHISHOLM, SMITH & DAVIS, 44022-2-4-o Attorneys for Petitioner.Public Notice is hereby given that the City of Lachine will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 9 Edward VII, chapter 86 and amendments, in addition to the purposes described in the Notice of November 12,1956, for the following purposes: to decree that the term of office for the mayor and aldermen will be of three years, from the next general election; and for other purposes.Montreal, January 8, 1957.LACROIX, VIAU & POUPART, The Attorneys for the 44055-2-4-o City of Lachine.Canada, \u2014 Province of Quebec District of Quebec City of Quebec Public notice is given by these presents that the City of Quebec will apply to the Legislature, at its present session, to obtain on the following matters, certain modifications to its charter, the Act 19, George V, chapter 95, as well as to various other general or particular statutes which may modify or concern it: 248 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Torhe 89, N° 8 Le pouvoir d'emprunter: Annuellement : S200.000.00 pour la construction de nouveaux pavages permanents et $100,000.00 pour le remplacement de pavages permanents, cela pendant trois ans; §500,000.00 pour l'acquisition d'immeubles destinés à l'aménagement de terrains de stationnement et à l'amélioration dc la circulation dans les limites dc la cité; $250,000.00 pour le prolongement du boulevard Charest à l'ouest du boulevard Langeli'er; $125,000.00 pour prolonger l'égoût principal de la Cité, depuis la rue Louis Jette vers le nord jusqu'au boulevard Charest et de là jusqu'à l'Avenue Saint-Sacrement; S75.000.00 pour l'élargissement et le prolongement du boulevard Saint-Cyrille; S300.000.00 pour le déplacement des voies et de la gare du Chemin de Fer Canadien National ou autres établissements commerciaux dans le voisinage du terminus postal ct du Carré Parent; Pour fixer les modalités des emprunts ci-dessus et de ceux que la Cité a déjà été autorisée à contracter en vertu des lois antérieures; Pour modifier les limites territoriales des quartiers Limoilou-Est ct Limoilou-Ouest; Pour déterminer la composition du Bureau de Cotisation; Pour modifier la loi concernant l'exigibilité des intérêts sur les redevances municipales; ' Pour augmenter les contributions annuelles de la Cité à l'Oeuvre des Terrains dc Jeux; Pour augmenter les contributions de la Cité à la construction de trottoirs permanents; Pour déterminer la base sur laquelle la Cité devra payer les taxes municipales et scolaires dans les municipalités traversées par les tuyaux d'aqueduc dc la Cité; Pour imposer les restrictions à la construction de lacs artificiels, puisards ct dépotoirs dans le territoire de l'aqueduc, afin de protéger la santé publique; Pour augmenter le pouvoir d'emprunt annuel de la Cité pour l'installation de nouveaux services d'aqueduc et dc drainage et le remplacement de vieux tuyaux; Pour augmenter le traitement des juges de la Cour Municipale; Pour placer le greffier de la Cour Municipale sous la juridiction des juges de cette Cour; Pour autoriser la Cité à échanger certains immeubles; Pour autoriser la Cité à contracter pour faire disparaître la mitoyenneté d'un mur de séparation de deux immeubles; Pour limiter aux salaires et aux heures de travail la juridiction d'un conseil d'arbitrage ayant à décider des différends entre la Cité et ses employés; Pour fixer l'évaluation des immeubles acquis de Sa Majesté aux droits du Canada et situés dans la zone industrielle N° 5; Pour autoriser le Conseil Municipal à modifier le tarif des guides historiques; Pour permettre, à certaines conditions, l'érection d'édifices commerciaux dans le territoire qui appartient aux Ursulines de Mérici, au sud du Chemin Saint-Louis, entre le prolongement de l'Avenue Bougainville et de l'Avenue Delaune; Et toute autre matière ou chose jugée utile ou pertinente à la bonne administration de la Cité.Québec, 7 janvier 1957.Les Procureurs de la Cité de Québec, PELLETIER, GODBOUT & 44044-2-4-O LECLERC.The power to borrow : Annually: $200,000.00 for the construction of new permanent pavings and $100,000.00 for the replacement of permanent pavings, and this during three years; $500,000.00 to acquire immoveables for tlic purpose of setting out parking grounds and for the improvement of traffic circulation within the limits of the city; $250,000.00 for the prolongation of Charest Boulevard, west of Langelicr Boulevard; $125,000.00 to prolong the main sewer of the City from Louis Jette street on the north to the Charest Boulevard and from there to Saint-Sacrement Avenue; $75,000.00 for the widening and the prolongation of Saint-Cyrille Boulevard; $300,000.00 for the displacement of rails ami the Canadian National Railway Station or other commercial establishments in the neighborhood of the postal terminus of Parent Square; To fix the terms and conditions of the above loans and of those which the City has already been authorized to contract under previous acts; To modify the territorial limits of the Limoilou-East and Limoilou-West wards; To determine the members who shall compose the Assessment Board ; To modify the Act concerning the requirements of the interest on municipal sums due; To increase the annual contributions of the City to work on playgrounds; To increase the contributions of the City for the construction of permanent sidewalks; To determine the base upon which the City should pay municipal and school taxes in the municipalities which are crossed by the pipelines of the waterworks of the City; To impose restrictions in the construction of artificial lakes, cess-pools and dumps within the territory of the aqueduct, for the protection of the public health; To increase the annual loan power of the City for the installation of new aqueduct and drainage services and for the replacement of old pipelines; To increase the salary of the judges of the Municipal Court; To place the clerk of the Municipal Court under the jurisdiction of the Judges of this Court; To authorize the City to exchange certain immoveables; To authorize the City to enter into contract to do away with the common ownership of a dividing of two immoveables; To limit to salaries and working hours the jurisdiction of a Conciliation Board having to decide differences between the City and its Employees; To fix the valuation of immoveables acquired from Her Majesty from the Rights of Canada and situated in the industrial zone No.5; To authorize the Municipal Council to amend the tariff for Historical Guides; To allow, upon certain conditions, the erection of commercial buildings in the territory which is owned by the \"Ursulines of Mérici\", on the South side of the St.Louis Road, between the prolongation of Bougainville Avenue and Dclaunc Avenue; And any other matter or subject deemed useful or pertinent to the good administration of the City; Quebec, January 7, 1957.PELLETIER, GODBOUT & LECLERC, 44044-2-4 Attorneys for the City of Quebec. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 249 Avis est par les présentes donné que H.Ernest Godin, de la cité de Montréal et Rainald Godin de lv cité des Trois-Rivières s'adresseront à la Législ iture de Québec, à la présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi concernant certains droits civils des enfants dc Hector L.Go.lin aux termes d'une convention passée par acte authentique, aux Trois-Rivières, le 24 avril 1950 devant A.Lamy, notaire, et pour toutes autres fins.Les Pétitionnaires, H.ERNEST GODIN, 44143-3-4 RAINALD GODIN.Avis public est par les présentes donné que Nathan Cohen et Hvrain Zalkind, tous deux commerçants, de la Cité d'Outrcmont, district de Montréal, s'adresseront à la Législature Pro-viici dc, à sa présente session, pour demander que \"Lc Comité d'Habitation de Montréal\", cor-poration 1'-gaiement constituée ayant eu son siège social dans la Cité de Montréal, ait eu pendant son existence le pouvoir de vendre les immeubles qu'elle poss îi lait à toute personne ayant la possibilité légale de les acquérir.Montréal, ce 10 janvier 1957.Le Procureur des pétitionnaires, 44147-3-4-0 ROBERT HODGE, C.R.In re: Succession Charles Raymond Avis est par les présentes donné que Charles-Maurice Raymond, entrepreneur, de Ville Mont-Royal, en sa qualité de tuteur à son fils mineur Charles-Maurice Raymond, jr., s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi autorisant le remplacement de deux fiduciaires de la succession de feu Charles Raymond, en son vivant entrepreneur de la Cité d'Outremont, et pour établir la procédure de remplacement, et pour autres fins.Montréal, ce 14 janvier 1957.Le Procureur du pétitionnaire ès-qualité, 44157-3-4-0 MAURICE MERCURE.Notice is hereby given that H.Ernest'Godin, of the City of Montreal and Ralnald Godin of the City of Trois-Rivières will apply to the Quebec Legislature, at its present session, in order to obtain the adoption of an Act concerning certain civil rights of the children of Hector L.Godin in the terms of an agreement concluded by authentic deed, at Trois-Rivières, April 24th., 1950 bofore A.Lamy, Notary, and for all other purposes.H.ERNEST GODIN, RAINALD GODIN, 44143-3-4 Petitioners.Public notice is hereby given that Nathan Cohen and Hvman Zalkind, both merchant, of the City of O.itrcmont, District of Montreal, will apply to the Provhci il Legislature, at its present session, to request that \"Le Comité d'H ibitation de Montréal\", a eoq>oration legally constituted having had its head office in the City of Montreal, had had during its corporate existence the power to sell the immoveables that it held to any person having the legal possibility to acquire them.Montreal, this January 10, 1957.ROBERT HODGE.Q.C., 44147-3-4 Attorney for Petitioners.In re: Estate of the late Charles Raymond Notice is hereby given that Charles-Maurice Raymond, contractor, of the Town of Mount-Royal, in his capacity of tutor to his minor son Charles-Maurice Raymond, Jr., will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, to obtain the passing of an Act authorizing the replacement of two trustees of the Estate of the Late Charles Raymond, in his lifetime contractor of the City of Outremont, and to provide for the procedure of replacement of said trustees, and for other purposes.Montreal, this 14th day of January 1957.MAURICE MERCURE, Attorney for the Petitioner 44157-3-4-0 ès-qualité.Département de l'Instruction Publique N° 234-38.Québec, le 7 janvier 1957.Avis est par la présente donné que je me propose de procéder à l'annexion des lots 47 à 02 inclusivement des rangs VIII et IX du canton Duparquet, territoire non-organisé au point de vue scolaire, ù la municipalité scolaire de Rapide Danseur, dans le comté d'Abitibi-Ouest.Le Surintendant de l'Instruction publique, 41041-2-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 82-56.Québec, le 7 janvier 1957.Demande est faite de détacher dc la municipalité scolaire de Pont-Viau, dans le comté de bavai, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Ville de Laval-dcs-Rapides, même comté.Ce territoire comprend les lots et parties fie lots suivants du cadastre officiel de la municipalité civile de Laval-des-Rapides, savoir: I.2, 3P, 3-1-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 8-9-10-11-1-, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-25, 3-26, 3-28P, 3-3P, 27P, 293-4, 293-62, 293-1, 293-2, Department of Education No.234-38.Quebec, January 7, 1957.Notice is hereby given that I intend proceeding with the annexation of lots 47 to 62 inclusive of ranges VIII and IX of the township of Duparquet, a territory unorganized as yet for school purposes, to the School Municipality of Rapide Danseur, in the county of Abitibi-West.O.J.DÉSAULNIERS, 44041-2-2 Superintendent of Education.No.82-56.Quebec, January 7, 1957.Application is made to detach from the school municipality of Pont-Viau, in tho county of Laval, the territory herebelow described to annex same, for the Catholic ratepayers only, to the School Municipality of the town of Laval-des-Rapides, same county.This territory is comprised of the following lots and parts of lots of the official cadastre of the civil municipality of Laval-des-Rapides, \\o w'.t: 1, 2, 3P, 3-1-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7.8-9-10-11-12, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-25.3-26, 3-28P, 3-3P, 27P, 293-4, 293-62, 293-1, 293-2 250 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Qvébec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° S 293-3, 293-63, 293-64, 293-93, 293-101, 293-94, 293-95, 293-96, 293-97, 293-98, 293-99, 293-100, 293-121, 293-122, 293-123-1, 293-124, 293-122-1, 293-123-2, 293-134, 293-132-2, 293-132, 293-131, 293-130, 293-129, 293-128, 293-127, 293-' 26, 293-125, 293-5, 293-6, 293-60, 293-61, 293-91, 293-92, 293-102, 293-103, 293-118, 293-119, 293-120.Le Surintendant de l'Instruction publique, 44042-2-2-O o.j.DÉSAULNIERS.N° 135-56.Québec, le 7 janvier 1957.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Agricole, dans le comté de Terrebonne, le lot N° 62 du rang XI du cahton Archambault, pour l'annexer à la municipalité scolaire de Lac Carré, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 44043-2-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 1310-56.491-52.Québec, le 8 janvier 1957.Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de St-Henri-de-Brôme, dans le comté de Brome, comme ci-dessous mentionné, aux municipalités scolaires de St-Édouard-de-Knowlton et St-André-de-Sutton.et ceci pour les contribuables catholiques seulement.1.\" Le territoire qui serait annexé à la municipalité scolaire de St-Édouard-de-Knowlton est décrit comme suit: les lots primitifs suivants, tous inclusivement du canton de Brome, 1 à 15 du rang IV; 1 à 20 des rangs V, VI et VII et le tiers sud du lot 21 dc ce dernier rang, portant les nos de subdivisions 828 et 829; 1 à 7 du rang VIII et 1 à 6 des rangs IX, X ct XI.2.Le territoire qui serait annexé à la municipalité scolaire de St-André-de-Sutton comprend les lots 21 à 28 inclusivement des rangs X et XI du canton de Sutton.Lc Surintendant de l'Instruction publique.440G4-2-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 1072-50.Québec, le 9 janvier 1957.Demande est faire de détacher de la municipalité scolaire du canton de Compton, dans le comté de Compton, les lots 1 à 6 inclusivement des rangs I à X aussi inclusivement, pour les annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Coaticook, dans le comté de Stan stead.Le Surintendant de l'Instruction publique, 44089-3-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 1236-53.Québec, le 9 janvier 1957.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Brébeuf, dans lc comté de Terrebonne, les lots 26, 27 ct 28 du rang VIII du canton Arundel, pour les annexer à la municipalité scolaire d'Hiiberdeau, dans le comté d'Argenteuil.Le Surintendant de l'Instruction publique, 44090-3-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 830-55.Québec, le 9 janvier 1957.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-André-de-Sutton, dans le comté de Brome, le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer, pour les contribuables catholiques 293-3, 293-63, 293-64, 293-93, 293-101, 293-94, 293-95, 293-96, 293-97, 293-98, 293-99, 293-100.293-121, 293-122, 293-123-1, 293-124.293-122-1, 293-123-2, 293-134, 293-132-2, 293-132, 293-131, 293-130, 293-129, 293-128, 293-127, 293-126, 293-125, 293-5, 293-6, 293-60, 293-61, 293-91, 293-92, 293-102, 293-103, 293-118, 293-119, 293-120.^ O.J.DÉSAULNIERS, 44042-2-2 Superintendent of Education.No.135-56.Quebec, January 7, 1957.Application is made to detach from the School Municipality of St.Agricole, in the county of Terrebonne, lot No.52, range XI of the township of Archambault, in order that it be annexed to the School Municipality of Lac Carré, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 44043-2-2 Superintendent of Education.No.1310-56.491-52.Quebec, January 8, 1957.Application is made to annex the present territory of the School Municipality of St.Henri-de-Brôme, in the County of Brome, as hereinunder mentioned, to the School Municipalities of St.Edouard-de-Know It on and St.André-de-Sutton, for Catholic ratepayers only.1.The territory to be annexed to the School Municipality of St.Edouard-de-Knowlton is described as follows: the following original lots, all inclusive of the Township of Brome, 1 to 15, Range IV; 1 to 20, Ranges V, VI and VII and the southerly third of lot 21 of the latter Range, bearing subdivision numbers 828 and 829; 1 to 7, Range VIII and 1 to 6 of Ranges IX, X ans XL 2.The territory to be annexed to the School Municipality of St.André-de-Sutton comprises lots 21 to 28 inclusive, of Ranges X and XI of the Township of Sutton.O.J.DÉSAULNIERS, 44064-2-2 Superintendent of Education.No.1072-56 Quebec, January 9, 1957.Application is made to detach from the School Municipality of the Township of Compton, in the county of Compton, lots 1 to 0 inclusive, of Ranges I to X also inclusive, in order to annex them, for Catholic ratepayers only, to the School Municipality of Coaticook, in the county of Stanstead.O.J.DÉSAULNIERS, 44089-3-2 Superintendent of Education.No.1236-53.Quebec, January 9, 1957.Application is made to detach from the School Municipality of Brébeuf, in the county of Terrebonne, lots 26, 27, and 28 of Range VIII of the Township of Arundel, in order to annex them to the School Municipality of Huberdeau, in the county of Argenteuil.O.J.DÉSAULNIERS, 44090-3-2 Superintendent of Education.No.830-55.Quebec, January 9, 1957.Application is made to detach from the School Municipality of St.André-de-Sutton, in the county of Brome, the territory hereinder described in order to annex it, for Catholic rate- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1967, Vol.89, No.8 251 seulement, «à la municipalité scolaire de St-Simon-d'Abercorn.Le territoire en question comprend les lots 439 à 508 inclusivement du rang IV et la demie sud du rang V à partir du lot 509 jusqu'au lot 578 inclusivement, tous du cadastre officiel du canton de Sutton.ï>e Surintendant de l'Instruction publique, 44091-3-2-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 1156-56.Québec, le 9 janvier 1957.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 19 décembre 1956, d'annexer à la municipalité scolaire de Poularics, dans le comté d'Abilibi-Ouest, le territoire ci-dessous décrit, lequel n'est pas encore organisé au point de vue scolaire.Le territoire en question comprend les lots 16 à 49 inclusivement du rang I; 22 à 49 inclusivement du rang II; 22 à 56 inclusivement du rang III, tous du canton Destor.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1957.Ix; Surintendant de l'Instruction publique, 44092-o O.J.DÉSAULNIERS.N° 406-56.Québec, le 9 janvier 1957.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 6 décembre 1956, dc détacher de la municipalité scolaire de St-Clément-dc-Dudswell, dans le comté de Wolfe, les lots 28a, 286, 28c, 28d, 28e et 28/du cadastre officie] du rang II du canton de Dudswell, pour les annexer à la municipalité scolaire dc Wcedon, dans le même comté.Ce changement prendra effet au 1er juillet 1957.Lc Surintendant de l'Instruction publique, 41092-O O.J.DÉSAULNIERS.Nu 43-57.Québec, le 15 janvier 1957.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Petit Lac Magog, dans le comté de Sherbrooke, en celui de \"La municipalité scolaire de Village de Deauville, dans le comté de Sherbrooke\".Le Surintendant dc l'Instruction publique, 44144-3-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.Département des Terres et Forêts payers only, to the School Municipality of St.Simon-d'Abercom.The territory in question comprises lots 439 to 508 inclusive of Range IV and the southerly half of Range V as from lot 509 as far as lot 578 inclusive, all of the official cadastre of the township of Sutton.O.J.DÉSAULNIERS, 44091-3-2 Superintendent of Education.No.1156-56.Quebec, January 9, 1957.His Honour the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council dated December 19, 1956, has been pleased to annex to the School Municipality of Poularies, in the county of Abitibi-West, the territory hereinderdescribed, which territory is not as yet organized for school purposes.The territory in question comprises lots 16 to 49 inclusive of Range I; 22 to 49 inclusive of Range II; 22 to 56 inclusive, of Range III, all of the township of Destor.This change shall take effect on July 1st., 1957.O.J.DÉSAULNIERS, 44092 Superintendent of Education.No.406-56.Quebec, January 9, 1957.His Honour the Lieutenant-Gover in Council, by Order in Council dated December 6, 1956, has been ploased to detach from the School Municipality of St.Clément-de-Dudswcll, in the county of Wolfe, lots 28a, 28b, 28c, 28a', 28e and 28/ of the official cadastre of Range II of the township of Dudswell, in order to annex them to the School Municipality of Weedon, in the same county.This change will take effect on July 1st., 1957.O.J.DÉSAULNIERS, 44092 Superintendent of Education.No.43-57.Quebec, January 15, 1957.Application is made to change the name of the School Municipality of Petit I^ac Magog, hi the county of Sherbrooke, to that of \"The School Municipality of the Village of Deauville, in the county of Sherbrooke\".O.J.DÉSAULNIERS, 44144-3-2 Superintendent of Education.Department of Lands and Forests AVIS NOTICE Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine-de- Officiai cadastre of the parish of St.Antoine-de- Longucuil maintenant partie de la ville de Longueuil now \"part of the town of Greenfield Greenfield Park division d'enregistrement de Park, registration division of Chambly.Chambly.Avis est par la présente donné qu'une partie Notice is hereby given that part of lot 241-19 du lot 241-19 est annulée en vertu de l'article is cancelled in virtue of article 2174A of the Civil 2171A du Code civil.code.Québec, le 22 décembre 1950.Quebec, December the 22nd, 1956.\\aî Département des Terres et Forêts, Department of Lands and Forests, Service du Cadastre, Cadastral Branch, Le Sous-ministre, AVILA BÉDARD, 44082-O AVILA BÉDARD.44082-O Deputy Minister. 252 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 Cadastre officiel dc la paroisse de Bcauport (Beauport-ouest) division d'enregistrement*de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 442-1 à 442-0 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, lc 7 janvier 1957.Lc Département des Terres ct Forêts, Service du Cadastre, Lc Sous-ministre, 44082-O AVILA BÉDARD.Cadastre officiel dc la paroisse (maintenant ville) de Pointe-Claire division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 62-203, 02-213 à 02-239, 62-243 à 02-250, 02-252 à 02-259, 02-261 à 62-268, 63-1, 63-5, à 63-12, 63-14 à 63-18, 63-20 à 02-22, 03-30, 03-32 à 63-61.03-74 à 03-88, les lots 04-27 à 04-30 sont annulés en vertu dc l'article 21(4A du Code civil.Québec, le 8 janvier 1957.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 44082-O AVILA BÉDARD.Cadastre officiel dc la paroisse de St-Martin maintenant partie de la ville de St-Elzéar division d'enregistrement de Laval.Avis est par la présente donné que les lots 657-48 à 657-59, 657-67 à 657-74, 657-76 à 657-79 et partie du lot 657-60 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 20 décembre 1956.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 44082-O AVILA BÉDARD.Département du Travail Officiai cadastre of the parish of Beauport (Bcauport-ouest) registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 442-1 to 442-6 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, January 7, 1957.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 44082-O Deputy Minister.Official cadastre of the parish (now towp) of Pointe-Claire registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 02-203, 62-213 to 62-239, 62-243 to 62-250.62-252 to 62-259, 62-261 to 62-268, 63-1, 63-5 to 63-12, 63-14 to 63-18, 63-20 to 63-22, G3-30, 63-32 to 63-61, 63-74 to 63-88, lots 64-27 to 64-30 are car celled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, January the 8th, 1957.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 44082-O Deputy Minister.Official cadastre of the parish of St-Martin now part of the town of St-Elzéar registration division of Laval.Notice is hereby given that lots 657-48 to 657-59, 657-67 to 657-74, 657-76 to 657-79 and part of lot 657-60 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, December the 20th, 1956.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 44082-O Deputy Munster.Department of'Labour AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 103 et amendements), qu'une requête lui a été présentée par le Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Roberval, à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil la modification suivante au décret numéro 1283 du 15 novembre 1951, relatif aux métiers de barbier, coiffeur et.coiffeuse dans le comté de Roberval, savoir: 1° Au paragraphe \"a\" de l'article IV, l'alinéa 1 sera remplacé par les suivants: 1° Pour les barbiers: Le lundi: de 1.00 p.m.à 6.00 p.m.les mardi et jeudi: dc 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le mercredi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.Le vendredi: de 8.00 a.m.à 8.00 p.m.Le samedi et la veille des fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.2° L'item \"Ondulation permanente à froid .; $8.00\", apparaissant à l'article VII, sera remplacé par le suivant: NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, (R.S.Q.1941, chapter 103 and amendments), that the Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Roberval has petitioned him to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council the following amendment to the decree number 1283, of November 15th, 1951, relating to the barber and hairdresser trades in the county of Roberval, to wit: 1.In subsection \"a\" of section IV, paragraph 1 will be replaced by the following: 1.Barbers: Monday: 1.00 p.m.to 6.00 p.m.Tuesday and Thursday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Wednesday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Friday: 8.00 a.m.to 8.00 p.m.Saturday and holiday eves: 8.00 a.m.to 9.00 I.ra.2.The item reading \"Cold wave .$8.00\", contained in section VII, will be replaced by the following: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 253 \"Ondulation permanente à froid, y compris coupe de cheveux, shampooing et mise en plis: $5.00\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté ministériel peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté ministériel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 janvier 1957.44104-o \"Cold wave, including haircut, shampoo and water wave.$5.00\" The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Munster of Labour will consider the objections which the interested parlies may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, January 19, 1957.44104-O AVIS.L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions dc la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 ct amendements), (pic les parties contractantes ci-après mentionnées lui ont présenté une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une part: La Section des Patrons-Barbiers-Coiffeurs du Syndicat des Barbiers-Coiffeurs du District de Hull.Et, d'autre part: La Section des Employés-Barbiers-Coiffeurs du Syndicat des Barbiers-Coiffeurs du District de Hull.pour les employeurs et le s d rié d s métiers visés, suivant les conditions ci-après décrit, s: I.Définition des termes: Cf.Dispositions communes applicables à tous les décrets régissant les barbiers, coiffeurs pour hommes.IL Juridiction territoriale: La juridiction territoriale du présent décret comprend la cité de Hull, la ville de Buckingham et un rayon de dix (10) milles dc leurs limites.Pour les fins d'application, cette juri fiction est divisée en deux (2) zones de la façon suivante: Zone I: Cité de Hull et un rayon de dix (10) milles de ses limites.Zone II: Ville de Buckingham et un rayon de dix (10) milles de ses limites.III.Heures de travail: a) Dans la zone I, la semaine de travail est de quarante-sept heure et demie (47J^) ; dans la zone II, elle est de quarante-neuf (49) heures.Tout travail fait en plus de ces heures est considéré comme travail supplémentaire.b) Pour les barbiers ct les coiffeurs, les heures de travail sont réparties de la façon suivante: Zone I: Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 8.00 a.m.à 6.30 p.m.Le lundi doit être chômé toute la journée excepté, toutefois, les semaines dc N( ël et du I remier de l'An.Dans ce cas, les heures de travail du lundi sont de 8.00 a.m.à 0.30 p.m.Zone II: Les lundi, mardi, jeudi et samedi: ce 8.30' a.m.à 6.00 p.m.tes vendredi: 8.30 a.m.à 9.00 p.m.Les mercredis: de 8.30 a.m.à midi.e) Les jours de fêtes chômés sont les suivants: te Premier de l'An, le 1er juillet, la fête du Travail et Ncël.NOTICE The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.O., 1941, chapter 163 and amendments), that Ihs contracting parties hereafter mentioned have submitted to him a petition the purpose of which being the extension of the collective labour agreement entered into between: On the one part: \"La Section des Patrons-Barbiers-Coiffcurs\" of the \"du Syndicat des Barbiers-Coiffeurs du District de Hull\".And, on the other part: \"La Sec* ion des Employés-Barbiers-Coiffeurs\" of the \"Syndicat des Barbiers-Coiffeurs du District de Hull\", for the employers and the employees the trades concerned, according to the conditions hereafter described : I.Definition of terms: Ci.Standard provisions applying to all the decrees regulating men's barbers and hairdressers.II.Territorial jurisdiction: The territorial jurisdiction of the present decree comprises the city of Hull, the town of Buckingham and a radius of ten (10) miles from their limits.For the purposes of enforcement, the said jurisdiction is divided into two (2) zones as Zone I: The city of Hull and a radius of ten (10) miles from its limits.Zone II: The town of Buckingham and a radius of ten (10) miles from its limits.III.Hours of work: a) The work week, in zone I, consists of forty-seven hours and a half (47W); in zone II, it consists of forty-nine (49) \"hours.Any work performed in excess of these hours is considered as overtime work.b) For barbers and hairdressers, the hours of work are distributed as follows: Zone I: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday: from 8.00 a.m.to 6.30 p.m.No work shall be performed on Monday except, however, for Christmas and New Year's Day weeks.In such case, the hours of work on Monday are from 8.00 a.m.to G:30 p.m.Zone II: Monday Tuesday, Thursday and Saturday: from 8.30 a.m.to G.C0 p.m.Friday: from 8.30 a.m.to 9.00 p.m.Wednesday: from S.30 a.m.to 12.00 (noon).c) The holidays to be observed arc the following: New Year's Day, the 1st of July, Labour Day, and Christmas Day. 254 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 d) Une heure doit être accordée à tout salarié pour le repas «lu midi et une heure pour le repas du soir, le vendredi.e) Tout travail exécuté en dehors des heures ci-haut mentionnées par un employé régulier ou surnuméraire est considéré comme travail supplémentaire.Toutefois, n'est pas considéré comme travail supplémentaire, toute opération exécutée par le salarié pour finir le travail commencé sur un client avant l'expiration de la durée du travail.Remarque: Nonobstant les dispositions du présent décret, la durée des heures de travail dans les salons de barbiers-coiffeurs ne doit en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de la Loi des Établissements Industriels et.Commerciaux (Statuts refondus dc Québec, 1941, chapitre 175 et amendements), aux décrets faits sous son autorité et aux règlements établis par les municipalités compétentes.IV.Salaires minima: Le salaire minimum pour le travail régulier est lc suivant: a) Dans la zone I, les barbiers-coiffeurs doivent recevoir $35.00 par semaine plus 65% des recettes de leur travail excédant $10.00 au cours de la semaine.6) Dans la zone II, les barbiers-coiffeurs doivent recevoir $30.00 par semaine, plus 60% des recettes de leur travail au-dessus de $12.00 au cours dc la semaine.e) Aucun employeur n*a le droit dc réduire le salaire d'un salarié recevant plus que les minima ci-haut mentionnés lors de l'entrée en vigueur du présent décret.d) Dans la zone I, un salarié régulier qui ne fait pas sa semaine de travail complète est payé à raison de 70% des recettes de son travail et il n'a pas droit au taux de salaire régulier de $35.00 par .semaine.T>c même pourcentage s'applique aux salariés surnuméraires.e) Vacances payées: Tout salarié doit recevoir chaque année un montant équivalent à 2% du salaire de base gagné, à titre dc rémunération pour ses vacances.Si un salarié quitte le service de son employeur avant d'avoir complété douze (12) mois de service, il doit recevoir quand même, en tel cas, une rémunération équivalente à 2% du salaire dc base gagné à date.V.Prix minima des services: Les employeurs professionnels, les artisans et les salariés doivent charger au public, les prix minima suivants pour les services ci-dessous énumérés: Zones I II Barbe.$0.65 $0.50 \u2022 Coupe de cheveux: Pour adultes des deux sexes: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.85 0.75 Les vendredi, samedi et veille de Ncël et du Premier de l'An.1.00 0.85 Pour les enfants de moins de 14 ans: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.60 0.50 Les vendredi, samedi et veille de fêtes chômées.0.75 0.60 Coupe de cheveux en brosse: ¦ Pour adultes: Les lundi, mardi.'mercredi et jeudi.1.00 0.90 Les vendredi, samedi et veille de Noël et du Premier de l'An.1.15 1.00 Pour les enfants de moins de 14 ans: Les lundi, mardi, mercredi et jeudi.0.75 0.75 Les vendredi, samedi et veille de Ncël et du Premier de l'An.0.85 0.75 Flambage des cheveux.0.25 0.25 d) One hour shall be given to employees for the noon meal and, on Friday, one hour for the evening meal.e) All work performed outside the hours hereinabove mentioned by a regular or supernumerary employee is considered as overtime.However, the time taken by an employee to finish work commenced on a customer before the expiration of the duration of work, shall not be considered as overtime.Proviso: Notwithstanding the provisions of the present decree, the duration of the working hours in the barbcring and hairdressing shops or parlors shall, in no case, constitute a violation of the provisions of the Industrial and Commercial Establishments'Act (Revised Statutes of Quebec, 1911, chapter 175 and amendments), of the decrees enacted under its authority and of the regulation! established by the competent municipalities.IV.Minimum wages: The minimum wages for regular work are as follows: a) In zone I, barbers hairdressers shall receive $35.00 per week, plus 65% of the receipts of their work exceeding $46.00 during the week.b) In zone II, barbers shall be paid $30.00 per week, plus 60% of the receipts of their work exceeding $42.00 in the course of the week.c) No employer has the right to reduce the wages of an employee receiving more than the minimum rates hereinabove mentioned at the time of the coming into force of the present decree.d) h\\ zone I, a regular employee not working the entire week shall be paid 70% of the receipts of his work and will not be entitled to the weekly regular rate of $35.00.The same percentage applies to supernumerary employees (extras).e) Vacation with pay: Every employee shall receive, each year, as vacation pay, an amount equivalent to 2% of the basic wages earned.In the event of an employee leaving his employer before the completion of 12 months service, he is entitled to a remuneration equivalent to 2% of the basic wages earned to date.\u2022 V.Minimum prices of services: Professional employers artisans and employees shall charge the following minimum prices for the services hereinafter mentioned : Zones I II Shave.$0.65 $0.50 Haircut: Male and female adults: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.85 0.75 Friday, Saturday and Christmas and New Year's eves.1.00 0.88 Children under 14 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.0.60 0.50 Friday, Saturday and holiday eves 0.75 0.60 Brushcut: Adults: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.1.00 0.90 Friday, Saturday and Christmas and New Year's eves.1.15 1.00 Children under 14 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.0.75 0.75 Friday.Saturday and Christmas and New Year's eves.0.85 0.75 Singeing of the hair.0.25 0.25 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1967, Vol 89, No.8 255 Shampooing.0.50 0.35 Massage.0.75 0.50 Tonique et lotion.0.25 0.25 Aiguisage de rasoir.0.50 0.35 Est considéré comme coupe de cheveux tout travail de barbier qui nécessite l'emploi de la tondeuse et des ciseaux.Aucun objet d'une valeur quelconque pouvant servir â abaisser les taux ci-haut énumérés ne peut être donné au client.Il est inter lit d'offrir gratuitement des services faisant l'objet du présent décret ou de donner quelque objet que ce soit comme prime, en vue d'attirer la clientèle ou ayant pour effet de réduire les taux des services ordinairement chargés dans ces salons.VI.Apprentissage: CF.Dispositions communes applicables à tous les décrets régissant les barbiers, coiffeurs pour hommes.a) Les apprentis doivent recevoir le salaire hebdomadaire suivant: Après le premier semest re.$ 12.00 Après le deuxième semestre.14.00 Après le troisième semestre.16.00 Après le quatrième semestre.18.00 b) Dans aucun salon, il n'est permis d'avoir plus d'un (1) apprenti.VII.Durée du décret: Le décret sera valable à compter du jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeurera en vigueur pour une période de douze (12) mois.Il se renouvellera automatiquement d'année en année, par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas ôtre de plus de soixante (60) ni de moms de trente (30) jours avant l'expiration de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au ministre du Travail.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dins la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 19 janvier 1957.44104-O \u2022- Département de la Voirie Shampoo.0.50 0.35 Massage.0.75 0.50 Tonic, lotion.0.25 0.25 Razor setting.0.50 0.35 The operation carried out by a barber with a clipper and scissors shall be considered as a haircut.No object of any value whatsoever, may be given to a customer in order to reduce the rates hereinabove enumerated.No one shall offer, without charge, services governed by the present decree or give what article soever as a premium in order to attract customer or reduce the rates ordinarily charged in such parlos.VI.Apprenticeship: CF.Standard provisions applying to all the decrees regulating men's barbers and hairdressers.a) Apprentices shall receive the following weekly wages: After six months.$12.00 After twelve months.14.00 After eighteen months.10.00 After twenty-four months.18.00 b) No parlour is permitted to have more than one (1) apprentice.VII.Duration of the decree: The decree will come into for^e on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and will remain in force l Pontiac, until 8.00 o'clock p.m., Monday, February 4, 1957, for the purchase of an issue of $70,000.00 of bonds of the Village of Portage-du-Fort, county of Pontiac, dated November 1st, 1956, and redeemable serially from November 1st, 1957 to November 1st, 1971 inclusively, with interest at a rate not less than 4J^% nor more than 5Vj>% per annum, payable semiannually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary accord mg to maturities.Loan by-law No.197, as amended \u2014 work on aqueduct.For purposes of adjudication only, interest shall be computed as from March 1st, 1957.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $70,000.00 \u2014 15 years.Year Capital November 1st, 1957.$1.000.00 November 1 st, 1958.1,000.00 November 1st, 1959.1,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 259 1er novembre 1960.1,000.00 1er novembre 1961.1,000.00 1er novembre 1962.1,500.00 1er novembre 1963.1,500.00 1er novembre 1964.1,500.00 1er novembre 1965.1,500.00 1er novembre 1966.1,500.00 1er novembre 1967.1,500.00 1 er novembre 1908.2,000.00 1 er novembre 1969.2,000.00 1 er novembre 1970.2,000.00 1er novembre 1971.50,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Shawville, comté de Pontiac.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emorunt à Montréal, à Québec, à Shawville (Pontiac), à Toronto ou à Ottawa.Les dites obligations ne seront pas rachetables par anticipation avant le 1er novembre 1964; à partie de cette date, les lites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées ct les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagné d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 4 février 1957, à 8.00 heures p.m., en la salle municipale, Portage-du-Fort, comté de Pontiac.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Portage-du-Fort, (Comté de Pontiac), ce 15 janvier 1957.La Sécrétai re-trésorière, MADAME CECILIA C.BURNS.Adresse postale: CP.409, Portage-du-Fort, (Comté de Pontiac), P.Q.44154-o Province de Québec Paroisse de Notre-D ame-des-Laurbntides (Comté de Québec) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Camille Carraichael, secrétaire-trésorier, Notre-Dame-des-Laurentides, comté de Q îébec, jusqu'à 8.30 heures p.m., lundi, le 4 février 1957, pour l'achat de $155,000.00 d'obligations de la paroisse de Notre-Dame-des-Laurenti les, comté de Q îé-bec, datées du 1er février 1957 et remboursables par séries du 1er février 1958 au 1er février 1972 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 43^% ni simérieur à 5^% par année payable semi-annuellement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 116 \u2014 améliorations au réseau d'aqueduc.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul 'ntérêt sera fait à compter du 1er mars 1957.Le tableau d'amortissement est le suivant: November 1 st, 1960.1,000.00 November 1 st, 1961.] ,000.00 November 1 st, 1962.1,500.00 November 1 st, 1963.1,500.00 November 1 st, 1964.1,500.00 November 1 st, 1965.1,500.00 November 1 st, 1966.1,500.00 November 1 st, 1967.1,500.00 November 1 st, 1968.2,000.00 November 1st, 1969.2,000.00 November 1 st, 1970.2,000.00 November 1st, 1971 .50,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Shawville, county of Pontiac.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec, Shawville (Pontiac), Toronto or at Ottawa.The said bonds are not redeemable by anticipation before November 1st, 1964; from and after this date, the said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest acrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, February 4, 1957, at 8.00 o'clock p.m., at the municipal Hall, Portage-du-Fort, county of Pontiac.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Portage-du-Fort.(County of Pontiac), this January 15, 1957.MRS.CECILIA C.BURNS, S?cretary-Treasurer.Postal address: P.O.B.409.Portage-du-Fort, (County of Pontiac), P.Q.44154 Province of Quebec Parish of Notre-Dame-des-Laurenti des (County of Quebec) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will, be received by the undersigned Camille Carmichael, Secretary-Treasurer, Notre-D ame-des-Laurenti-des, county of Quebec, until 8.30 o'clock p.m., Monday, February 4, 1957, for the purchase of an issue of $155,000.00 of bonds of the parish of Notre-D ime-des-Laurentides, county of Quebec, dated February 1st., 1957, and redeemable serially from February 1st, 1958 to February 1st, 1972, inclusively, with interest at a rate of not less than 4)^% or more than 514% Per annum, payable semi-annually on February 1st, and August 1st, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.116 \u2014 improvements to the system of waterworks.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from March 1st, 1957.The table of redemption is as follows: 260 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 Tableau d'amortissement \u2014 $155,000.00 \u2014 15 ans Année Capital 1er février 1958.S 1,500.00 1er février 1959.1,500.00 1er février 1960.1,500.00 1er février 1961.2,000.00 1er février 1962.2,000.00 1er février 1063.2,000.00 1er février 1061.2.000.00 1er février 1965.2,000.00 1er février 1966.2.000.00 1er février 1967.2.000.00 1er février 190S.2.500.00 1er février 1969.2.500.00 1er février 1970.2.500.00 1er février 1071.2.500.00 1er février 1972.126,500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Charlesbourg, comté dc Québec.Le capital ct les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné, dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Charlesbourg.comté de Québec.Lesdites obligations ne seront pas rachetablcs par anticipation avant le 1er février 1965 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourrent, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus dc Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées ct les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt ct devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 4 février 1957.à 8.30 heures p.m., en la salle du collège, à Notrc-Damc-des-Laurcntidcs, comté de Québec.Lc conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Notre-Dame-des-Laurentides, (Comté de Québec), ce 17 janvier 1957.Le Secrétaire-trésorier, CAMILLE CARMICHAEL.Notre-Dame-des-Laurentides, (Comté de Québec), P.Q.44161-o Province de Québec Ville de St-Eustache (Comté dc Deux-Montagnes) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Henri Chaurette, secrétaire-trésorier, Hôtel-de-Ville, 192 rue St-Eustache, St-Eustache, comté de Deux-Montagr.es, jusqu'à 8.30 heures p.m., mercredi, le 6 février 1957, pour l'achat de 8460,000.00 d'obligations de la ville de St-Eus-tachc, comté de Deux-Montagnes, datées du 1er août 1956 ct remboursables par séries du 1er août 1957 au 1er août 1976 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4^% ni supérieur à 5]/>% par année payable scmi-annuelle-ment les 1er février ct 1er août de chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Table of redemption \u2014 $165,000.00 \u2014 15 years Year Capital February 1st, 1958.$ 1,500.00 February 1 st, 1959.1,500.00 February 1 st, 1960.1,500.00 February 1st, 1961.2,000.00 February 1 st, 1962.2,000.00 February 1 st, 1963.2,000.00 February 1st, 1964.2,000.00 February 1 st, 1965.2,000.00 February 1 st, 1966.2,000.00 February 1 st, 1967.2,000.00 February 1 st, 1968.2,500.00 Februa rv 1 st, 1969.2,500.00 February 1 st, 1970.2,500.00 Februa ry 1 st, 1971.2,500.00 February 1st, 1972.126,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable as par at Charlesbourg, county of Quebec.Capital and interest arc payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or Charlesbourg, county of Quebec.The said bonds shall not be redeemable by anticipation prior to February 1st, 1965, inclusive; following this date the said bords may, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, he redeemed by art ici-pat ion, in whole, or in part at par, at ory interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a cert ificd cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or rot in the price of the tender.The tenders will be opened and considered al a meeting of the council to be held on Monday, February, 4, 1957, at 8.30 o'clock p.m., at the College Hall, at Notre-Dame-des-Laurentides, county of Quebec.The council is not bound to accept the highest or any of the tenders.Not re-Da me-des-I.au rent ides, (County of Quebec), this January 17, 1957.CAMILLE CARMICHAEL, Secretary-Treasurer.Notre-Dame-des-Laurentides, (County of Quebec), P.Q.44161 Province of Quebec Town of St.Eustache (County of Two Mountains) Public notice is hereby given that sealed tenders, erdorscd \"Tenders for bords\" will be received by the urdcrsigrcd Henri Chaurette, Secretary-Treasurer, City Hall, 192 St.Eustache Street, St.Eustache, county of Two Mountains, until 8.30 o'clock p.m., Wednesday, February 6th, 1957 for the purchase of an issue of 54C0.CCO.C0 of bords of the town of St.Eustache, county of Two Mountains, dated August 1st, 1956, and redeemable serially from August 1st, 1957 to August 1st, 1976, inclusively, with interest at a rate of rot less than 4yi or more than 5}4% per annum, payable .semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the seme for the whole issue or it may vary according to maturities. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 261 -1-.\u2014___ Règlements d'emprunts Nos 311 \u2014 $131,000.00 \u2014 usine dc filtration; 329 \u2014 $21,000.00 travaux d'aqueduc; 331 \u2014$6,500.00 travaux d'aqueduc; 332 \u2014 820,000.00 travaux d'égouts; 333 \u2014$25,-000.00 protection contre l'incendie; 337, $142,-000.00 usine de filtration; 338 \u2014 $40,000.00 consolidation de dettes, réparations hôtel de ville, etc.; 341\u201485,000.00 détournement de cours d'eau; 342 \u2014 85,000.00 achat d'équipement et (livers travaux; 343 \u2014 $30,500X0 travaux d'égouts; 344 \u2014 811,000.00 travaux d'aqueduc; 346 -85,200.00 travaux d'aqcduc; et 347 \u2014$17,-SOO.CO travaux dïgouts.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mars 1957.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $46O,0O0.CO \u2014 SO ans Année Capital 1er a ût 1957.$13,010.C0 lr août 1958.13.OCO.00 L-raoû' 1959.13.0C0.CO 1er août 19 10.13.5C0.C0 1er août 1961.13.5C0.C0 iar août 1962.,'.14.5C0.C0 1er.-oit 19 13.14.5C0.C0 1er août 1964.14,500.C0 1er août 1905.14,500.00 1er a où tl 906.15,000.C0 1er août 1 £67.15,000.00 lerao\"tl9>8.15,000.00 1er acûï 1969.15,000.00 1er août 19.0.15,000.00 1er août 1971.16,000.00 lerao.lt 1972.16,000.00 1er août 1973.16,000.00 1er août 1974.16.OCO.00 1er août 1975.17,000.00 1er août 1976.1SO.000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Eustache, comté dc Deux-Montagnes.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec dc la banque dont le nom est mentionné dans lajjrocé-dure d'emprunt, ainsi qu'à la succursale de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne pourront, pas être rachetées par anticipation avant le 1er août 1966 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéances d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de 1 emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne coiuprcnd pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions serait ouvertes ct considérées a un?séance du conesil oui sera tenue mercredi, le 'i février 1957, à 8.30 heures p.m., en l'Hôtel de \\ die, 192 rue St-Eustache, St-Eustache, comté de Deux-Montagnes.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la pli s haute ni aucune des soumissions.St-Eustâche, (comté de Deux-Montagnes,) ce 17 janvier 1957.Le Se îrétaire-trésorier, HENRI.CHAURETTE.Adresse postale: Hôtel de Ville, CP.220, 192 rue St-Eustache, St-Eustache, (Comté de Deux-Montagnes,) P.Q.44162 Loan By-laws Nos 311 \u2014 $131,000.00 \u2014 filtration plant; 329 \u2014 $21,000.00 waterworks; 331 \u2014 S6.5C0 .00 waterworks; 332 \u2014 S20.OCO.00 sewage; 333 \u2014 $25,000.00 fire prevention; 337 \u2014$142,-OOO.CO filtration plant; 338 \u2014 $40,000.00 funding of debts, repairs to City Hall, etc; 341 \u2014 $5,000-.00 diverting of water-course; 342 \u2014 $5,000.00 purchasing of equipment and sundry operations; 343 \u2014 $30,500.00 sewage; 344 \u2014 Si\" 1,000.00 waterworks; 340\u2014S5.2C0.00 waterworks; and 347\u2014 $17,800.00 sewage.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from March 1st, 1957.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 8460,000.00 - SO years Year Capital August 1st, 1957 .S 13,000.00 August 1st, 1958 .13.0C0.00 August 1st, 1959 .13,000.00 August 1st, 1900 .13,500.00 August 1st, 1901 .13,500.00 August 1st, 1902 .14.5C0.00 August 1st, 1903 .14,500.00 August 1st, 1904 .14,500.00 August 1st, 1905 .14,500.00 August 1st, 1906 .15.CC0.00 August 1st, 1967 .15,000.00 .August 1st, 1968 .15,000.00 August 1st, 1969 .15,000.00 August 1st, 1970 .15.000.00 August 1st, 1971 .10,000.00 August 1st, 1972 .16.000.00 August 1 st, 1973 .16,000.00 August 1st, 1974 .16,000.00 August 1st, 1975 .17.0CO.00 August 1st, 1976 .180.0C0.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any.by certified cheque payable at par at St.Eustache, county of Two Mountains.Capital and interest are payable at all the branches, in the Province of Quebec, of the bank mentioned in the loan procedure including the branch of said bank in Toronto.The said bonds shall not be redeemable by anticipation prior to August 1st, 1966 inclusive; following said date the said bonds may.under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday.February fith.1957, at 8.30 o'clock p.m., at the City Hall, 192 St.Eustache Street, St.Eustache, county of Two Mountains.The council is not bound to accept the highest or any of the tender.1;.St.Eustache, ' (county of Two Mountains), this January 17th, .1957.HENRI CHAURETTE, Secrcta i y-Trcasu rcr.Post office address: City Hall, P'B.220, 192 St.Eustache street, St.Eustache (County of Two Mountains) P.Q.44162-0 262 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 3 Province dc Québec Les Commissaires d'Écoles pour la Municipalité du Village de Varennes (Comté de Vercbércs) Avis public est pnr les présentes donné que des soumissions caclictées ct endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Jules Pbaneuf, notaire, secrétaire-trésorier, Va-rennes, comté de Verclières, jusqu'à 8.C0 heures p.m., lundi, le 4 février 1957.pour l'achat de $150,000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Varennes, comté de Verchères, datées du 1er décembre 1956 et remboursables par séries du 1er décembre 1957 au 1er décembre 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 4J^% ni supérieur à 5,^2% par année payable semi-annuelle-ment les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émissions ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 22 octobre 1956, telle que modifiée \u2014 construction d'une école élémentaire de huit classes dans l'arrondissement N° 2.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mars 1957.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $150,000.00 \u2014 £0 ans.Année Capitul 1er décembre 1957 .x$10,000.00 1er décembre 1958 .x 16,500.00 1er décembre 1959 .x 17,500.00 1er décembre 1960 .x 18,000.00 1er décembre 1961 .x 19,000.00 1er décembre 1962 .3,000.00 1 er décembre 1963 .3,000.00 1er décembre 1964 .3,000.00 1 er décembre 1965 .3,500.00 1 er décembre 1966 .3,500.00 1 er décembre 1967 .3,500.00 1 er décembre 1968 .4,000.00 1er décembre 1969 .4,000.00 1er décembre 1970 .4,500.00 1er décembre 1971 .4,500.00 1 er décembre 1972 .5,000.00 1 er décembre 1973 .5,000.00 1 er décembre 1974 ____ 5,000.00 1er décembre 1975 .5,500.00 1 er décembre 1976 .6,000.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total dc $84,000.00 accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $16,S0O.OO chacun, de 1957 à 1961 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Varennes, comté de Verchères.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québçc ou à Varennes, comté de Verchères.Lesdites obligations ne seront pas rachetablcs par anticipation avant le 1er décembre 1966 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of the Village of Varennes (County of Verchères) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will he received by the undersigned Jules Phaneuf, notary, Secretary-Treasurer, Varennes, county of Verchères, until 8.00 o'clock p.m., Monday, February 4th.1957, for the purchase of an issue \" of $150,000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of the Village of Varennes, county of Verchères.dated December 1st, 1956 and redeemable serially from December 1st, 1957 to December 1st, 1976 inclusively, with interest nt a rate not less than 4%% \"or more than 5^% per annum payable semi-annuelly on June 1st and December 1st of each year.The date of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated October 22nd, 1956, as modified \u2014 construction of an elementary eight-classroom school in district No.2.For the purposes of awarding the issue only, computation of interest will be made as from March 1st, 1957.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $150,000.00 \u2014 SO years.Year Capital December 1st, 1957 .x $16,000.00 December 1st, 1958 .x 16,500.00 December 1st, 1959 .x 17,500.00 December 1st, 1960 .x 18,000.00 December 1st, 1961 .x 19,000.00 December 1st, 1962 .3,000.00 December 1st, 1963 .3,000.00 December 1st, 1964 .3,000.00 December 1st, 1965 .3,500.00 December 1st, 1966 .3,500.00 December 1st, 1967 .3,500.00 December 1st, 1968 .4,000.00 December 1st, 1969 .4,000.00 December 1st, 1970 .4,500.00 December 1st, 1971 .4,500.00 December 1st, 1972 .5,000.00 December 1st, 1973 .5,000.00 December 1 st, 1974 .5,000.00 December 1st, 1975 .5,500.00 December 1st, 1976 .6,000.00 The \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $84,000.00, granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of $16.800.00 each, from 1957 to 1961 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Varennes, county of Verchères.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure in Montreal, Quebec or Varennes, county of Verchères.The said bonds will not be callable prior to maturity before December 1st, 1966 inclusively; after the latter date, the said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Çvelec, Janvary l£th, JC67, Vet.S9, No.S 263 Choque soi mission devra être acccn-pagnée d'un chèque acetpté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou re ccncprcrd pas les intérêts courus sur les obligations nu n:cn~ert de leur livraison.Les soi;missicrs serert ouvertes et considérées à une séarce des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 4 février 1£57, à 8.C0 heures p.m., en la salle de l'école J.-P.Labarre, rue Youville, Varennes, comté de Verchères.Les commissaires d'écoles se réservent lc droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions, Varennes, (Comté de Verchères), ce 15 janvier 1957.Le Secrétaire-trésorier, JULES FHANEUF, notaire.Varennes, (Comté de Veiclières), P.Q.44156-o Province de Québec Les commissaires d'i coles catholiques tour la municipalité de la Cité de Longueuil (Comté de Chambly) Avis public est par les présentes donné que des (soumissions cachetées ct endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Roméo Bourdon, secrétaire-trésorier, 13 rue St-Charles Est, Longueuil, comté de Chambly, jusqu'à 8.30 heures p.m.mardi, le 5 février 1957, pour l'achat de S390.0C0.C0 d'obligations des commissaires d'écoles catholiques pour la municipalité de la cité de Longueuil, comté de Chambly, datées du 1er décembre 1956 ct remboursables par séries du 1er décembre 1957 au 1er décembre 1976 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à ni supérieur à °H% par année payable semi-annuellement les 1er juin ct 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut, varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 8 octobre 19.r)ti, telle que modifiée \u2014 Construction d'une école de seize classes dans la paroisse Sl-Pierre-Apêd re.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er mars 1957.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 S390,0G0.00 \u2014 20 ans Année Capital 1er décembre 1957.x$38,000.00 1er décembre 1958.x 39,500.00 1 er décembre 1959.x 41,500.00 1er décembre 1960.x 43,000.00 1er décembre 1961.x 45,000.00 1 er décembre 1962.9,000.00 1 er décembre 1963.9,000.00 1 er décembre 1964.9,500.00 1 er décembre 1965.10,000.00 1er décembre 1966.10,500.00 1 er décembre 1967.11,000.00 1 er décembre 1968.;.11,500.00 1 er décembre 1969.12,000.00 1 er décembre 1970.12,500.00 1er décembre 1971.13,000.00 1 er décembre 1972.13,500.00 1 er décembre 1973.14,500.00 1 er décembre 1974.15,000.00 1 er décembre 1975.15,500.00 1er décembre 1976.16,500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de ?188,388.00, accordé par le Secrétaire de la pro- Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bends to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Monday, February 4th, 1957, at 8.00 o'clock p.m., at the Hall of the J.-P.Labarre Schccl, Youville Street, Varennes, county of Verchères.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Varennes, (County of Verchères), this 15th of January, 1957.JULES PHANEUF, notary, The Secretary-Treasurer.Varennes, (County of Verchères), P.Q.44156-o Province of Quebec The School Catholic Commissioners for the municipality of the city of Longueuil (County of Chambly) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Roméo Bourdon, Secretary-Treasurer, 13 St.Charles Street, East, Longueuil, County of Chambly.until 8.30 o'clock p.m., Tuesday, February 5, 1957, for the purchase of an issue of S390.000.00 of bonds of the Catholic Scliool Commissioners for the Municipality of the City of Longueuil, county of Chambly, dated December 1st., 1956, and redeemable serially from December 1st., 1957 to December 1st., 1976 inclusively, with interest at a rate of notless than 4^% or more than 5M% per annum, payable semi-annually on June 1st.and December 1st.of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan Resolution dated October 8, 1956, as modified \u2014 Erection of \"a school of sixteen class-rooms in the Parish of St.Pierre-Apôtre.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from March 1st., 1957.The tabic of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $390,000.00 \u2014 20 years Year Capital December 1st., 1957.x$38,000.00 December 1st., 1958.x 39,500.00 December 1st., 1959____.x 41,500.00 December 1st., 1960.x 43,000.00 December 1st., 1961.x 45,000.00 December 1st., 1962.9,000.00 December 1st., 1963.9,000.00 December 1st., 1964.9,500.00 December 1st., 1965.10,000.00 December 1st., 1966.10,500.00 December 1st., 1967.11,000.00 December 1st., 1968.11,500.00 December 1st., 1969.12,000.00 December 1st., 1970.12,500.00 December 1st., 1971.13,000.00 December 1st., 1972.13,500.00 December 1st., 1973.14,500.00 December 1st., 1974.15,000.00 December 1st., 1975.15,500.00 December 1st., 1976.16,500.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $188,388.00 granted by the Provincial Secre- 2C4 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 vinee et payable en cinq versements dc $37,077.60 chacun, de 1057 à 1061 inclusivement, seront reçus ct appliques au service dc cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Longueuil, comté (ie Chambly.Le capital ct.les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation avant le 1er décembre 1966 inclusivement; après cette date, lesdites obligations pourront, sous l'autori'é du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetéds par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées ct les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égid à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 5 féviier 1957.à S.30 heures p.m., au bureau du secrétaire-trésorier, 13 rue St-Charlcs-Est, Longueuil, comté de Chambly.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Longueuil, (Comté de Chambly), ce 16 janvier 1957.Le Secrétaire-trésorier, ROMÉO BOURDON.13, rue St-Charles Est, Longueuil, (Comté de Chambly), P.Q.44155-o Vente par licitation tary and payable in five instalments of $37,677.60 each, from 1957 to 1961 inclusively, shall he received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any.by certified cheque payable at par at Longueuil, county of Chambly.Capital and interest arc payable at all branches, in the Province of Quebec, of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds shall not be re leemable by anticipation prior to December 1st.1966 inclusive,; following this date the said bonds may, under the authority of chapter 212.Revised Statutes of Quebec, 1941, be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par.at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be re loomed w;ll be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to'1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and consi lered at a meeting of the School Commissioners to be bel I on on Tuesday, February 5, 1957, at 8.30 o'clock p.m., at the office of the Secretary-Treasurer, 13 St.Charles Street, East, Longueuil, county of Chambly.The Scliool Commissioners are not bound to accept the highest or any of the tenders.Longueuil, (County of Chambly), this January 16, 1957.ROMÉO BOURDON, Secretary-Treasurer.13 St.Charles Street, East, Longueuil, (County of Chambly), P.Q.44155 Sale by Licitation Canada, Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 405-026, Dame Otylia Kulik, demanderesse vs Dame Danuta Grad défenderesse et Joseph Grad, défendeur ès qualité de tuteur à Aleksander Grad.AVIS DE LICITATION Le 21 février 1957 à dix heures du matin au bureau du Protonotaire au Palais dc Justice en la cité de Montréal, suivant jugement rendu par l'honorable Juge Roger Ouimet en date du 17 décembre 1956 dans la cause indiquée ci-dessus, il sera procédé à l'adjudication pour licitation par enchère publique d'une propriété immobilière décrite comme suit, à savoir: Un emplacement sur la rue De Buillion dans la cité de Montréal connu sous le lot numéro quarante-cinq de la subdivision du lot original numéro neuf cent dix-huit (918-45) sur les plan et livre de renvoi officiel pour le quartier St-Louis, dans la cité de Montréal.Avec la maison ci-dessus érigée portant le numéro civique 3,907, 3,907A et 3,909 de ladite rue De Bullion et ses dépendances.Sujet aux charges, clauses et conditions contenues dans le Cahier 'le charges déposé au bureau du Pnxonotaire de ladite Cour.Canada, Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court No.405-026, Dame Otylia Kulik, plaintiff vs Dame Danuta Grad, defendant and Joseph Grad, tutor to Aleksander Grad, defendant.NOTICE OF LICITATION On February 21st, 1957 at ten o'clock in the forenoon, at the Prothonotary's Office at the Court House in the City of Montreal, according to a judgment rendered by the Honourable Justice Roger Ouimet on December 17, 1956 in the above mentioned case, if shall be preceded to the adjudication for licitation, by public auction, of an immovable property, described as follows, to wit: An emplacement on De Buillion street in i:ic city of Montreal known as lot number fort five of the subdivision of original lot.number nine hundred and eighteen (918-45) on the plan in the book of reference for the St.Louis Ward, in the city of Montreal.With the house thereon erected beating civic number 3,907, 3.907A and 3,909 of said D2 Bullion street and dependencies.Subject to the charges, clauses and conditions contained in the list of charges deposited in t.ic Office of the Prothonotary of the said Court. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1951, Vol.89, No.8 265 Toute opposition afin d'annuler, afin dc charges ou afin de distraire à ladite licitation devra être déposée au greffe du Protonotaire de ladite Cour au moins douze (12) jours avant la date fixée comme susdite pour la vente ct adjudication et six (6) jours après l'adjudication.Et à défaut des parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par les présentes, elles seront forcloses du droit de la faire.Montréal, le 14 janvier 1957.Le Procureur de la demanderesse, 44121-3-2-0 L.R.Z.KOS.Any opposition to annul to secure charges or to withdraw, to be made to the said licitation must be filed in the Office of the Prothonotary of the said Court at least (twelve) 12 days before the date fixed as aforesaid for the sale and adjudication and any opposition for payment must be filed within six (6) days after the adjudication.And failing the parties to file such oppositions within the delays hereby limited, they will be forclosed from so doing.Montreal, January 14, 1957.L.R.Z.KOS, 44121-3-2-0 Attorney for Plaintiff.Ventes pour taxes Sales for Taxes Province de Quebec Province of Quebec Municipalité du comté de Gaspé-Est Municipality of the county of Gaspé-East Avis public est par le présent donné par le soussigné J.E.LeBoutillicr, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, que les immeubles ci-après désignés, y compris les bâtisses dessus construites, seront vendus à l'enchère publique au lieu où le Conseil de comté tient ses sessions, au Palais de Justice à Percé, JEUDI, le QUATORZIÈME jour de MARS prochain, à DIX heures de l'avant-midi, pour taxes municipales et scolaires, à moins que ces taxes et les frais encourus ne soient payés avant la vente, savoir: Public notice is hereby given by the undersigned J.E.LeBoutillier, secretary-treasurer of the aforesaid municipality, that the immoveables hereinafter described including the buildings thereon erected, shall be sold by auction at the place where the county council holds its sittings, in the Court House at Percé, on THURSDAY, the FOURTEENTH day of MARCH next, at TEN o'clock in the forenoon, for municipal and school taxes, unless these taxes and the costs incurred be paid before the sale, namely: Municipalité village de Chandler \u2014 Municipality village of Chandler \t\t\t\tTaxes\tTaxes\t Noms\tN° du lot\tHang\tCanton\tmun.\tscol.\tTotal \t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t Names\tLot No.\tRange\tTownship\tMun.\tSchool\t \t\t\t\ttaxes\ttaxes\t Pond, Roméo.\tP.72-B.\t1.\t\t$132.68 104.65 147.15\t$ 82.25 72.75 66.39 56.09 125.11 44.32 105.63 111.05 67.54 59.31 43.10\t$214.93 177.40 213.54 56.09 225.57 74.42 279.93 272.60 142.31 82.23 43.10 1 'muoau, Albert.\tP.77-A .\t1.\t\t\t\t Duguay, Hormidas.\tP.72-B.\t1.\t\u2022«\t\t\t Du clos, Paul-Emile .\tP.72-B.\t1.\t\u2022«\t\t\t Jouoas, Aimand.\tP.70-C.\t1.\t«\u2022\t100.40 30.10 174.30 161.55 74.77 22.92\t\t Lafontaine, Roger.\tP.72-B.\t1.\t\"\t\t\t Lcblano, Armand.\tP.77-A.\t1.\t\u2022, page 779, sous le numéro 13297, avec ensemble ber of the same year, reg.A.vol.15, page 779 under Jin diagramme dudit lopin de terre marqué \"A\" et number 13297, together with a diagram of the said \"B\" respectivement et signé par les parties et par tract of land marked \"A\" and \"B\" respectively and ledit notaire Angers pour identification, à savoir: signed by the parties thero to and by said notary a) partant d'un point \"A\" sur ledit diagramme (une Angers for indentification.Viz: a) starting from a copie photostat duquol est attaché ft l'acte do vente point \"A\" of said diagram (a photostat copy of which do Mme Alice Rathbono Bowditch Sturgis, épouse de is attached to the deed of sale from Mrs.Alice Rath-Arthur Douglas Dodge, au vendeur indiqué ci-après), bone Bowditch Sturgis, wife of Arthur Douglas Dodge dans une direction S.61° 30' O.allant sur une distance to the vendor, hereinafter recited) in a S.61°30'W.çe deux cent trente-quatre pieds, mesure anglaise, direction running a distance of two hundred and thirty-jusqu'au point F.indiqué sur ledit diagramme à un four feet, English measure, to a point \"F\" on the said poteau do pierre avec un vaisseau de terre cuite enterré diagram, at a stone post with earthern ware buried sous ledit poteau: Alors, dudit point A dans une direc- underneath; then from said point \"A\", in a N.61°30' tion N.61° 30' est allant sur une distance de cent east direction running one hundred and fifty-eight feet cinquante-huit pieds jusqu'au point \"B\" indiqué to the point \"B\" on said diagram, at another stone 8ur ledit diagramme à un autre poteau de pierre avec post, with earthern ware buried underneath; then from un vaisseau de terre cuite enterré sous ledit poteau; point \"D\" of said diagram running in a, S.61°30'W.alors, du point \"D\" sur ledit diagramme allant dans direction a distance of one hundred and sixty-two feet, une direction S.61° 30' O.sur une distance do cent english measure, to the point \"E\" of said diagram, at Boixnnte-deux pieds, mesure anglaise, jusqu'au point another stone post with earthern ware buried undor-E\" dudit diagramme à un autre poteau de pierre neath; then starting again from tho point \"D\" in a avec vaisseau de terre cuite enterré sous ledit poteau; direction N.61°30'E.running a distance of two hun-alors.partant de nouveau du point \"D\" dans une dred and thirty-eight foot, English mear-ure, to the direction N.61° 30' E.allant sur une distance de deux point \"C\" on said diagram, at another stone post with cent trente-huit pieds, mesure anglaise, jusqu'au earthern ware buried underneath the said lines \"B.F.\" point \"C\" dudit diagramme à un autre poteau de and \"E.C.\", measuring three hundred and ninety- Eierre avec un vaisseau de terre cuite enterré sous two feet and four hundred feet respectively and the dit poteau, lesdites lignes \"B.F.\" et \"E.C.\" mesu- line \"A.D.\" measuring one hundred and sixty-two rant trois cent quatre-vingt-douze pieds et quatre feet and the said lot of land this figured by the letters cent pieds respectivement et la ligne \"A.D.\" mesurant \"F.A.B.C.D.E.\" on said diagram having the form of cent soixante-deux pieds et ledit lot de terre ainsi montré a trapezium and containing in superficies sixty-four par les lettres \"F.A.B.C.D.E.\" sur ledit diagramme et thousand ono hundred and fifty-two feot.English ayant la forme d'un trapèze et contenant une super- measure; b) A lot of land situated in the village of la ficio do soixante quatre mille cent cinquante-deux Pointe-au-Pio county of Charlevob: of an are.* of twonty-Pjfjdfl.mesure anglaise; 6) Un lot do terre situé dans lo five thousand and seventy feet and a_ half, English villago de Pointeau-Pic, comté de Charlevoix, d'une measure on tho boulevard road or ch ¦ nin des Falaises 270 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 superficie de vingt-cinq mille soixante-dix pieds et demi, mesure anglaise, sur le chemin du Boulevard ou Chemin des Falaises formé et comprenant le lot décrit aux plan cadastral et livre de renvoi dudit village de Pointe-au-Pic, sous le numéro soixante-quinze-troia (75-3), aussi cette partie du lot soixante-dix-huit-quatorze (78-14) de la subdivision du lot soixante-dix-huit (78) des mêmes plan cadastral et livre dc renvoi dudit village de La Pointe-au-Pic, borné comme suit: En front par ledit Chemin du Boulevard sur une longueur de quatre-vingt-dix pieds, mesure anglaise, en arrière sur une longueur de cent soixante-seize pieds, mesure anglaise, par la portion du lot soixante-dix-huit décrit ci-dessus au paragraphe a), du côté nord par ledit lot numéro soixante-quinze-trois (75-3) Bur une distance de cent quatre-vingt-onze pieds (191'), mesure anglaise, ct du côté sud par une ligne separative tirée sur une longueur de cent quatre-vingt-six pieds, mesure anglaise, du coin sud do la propriété indiqué ci-dessus dans une direction qui rencontre la ligne basse dudit Boulevard a angle droit, à un point distant de quatre-vingt-dix pieds, mesure anglaise, du coin ouest de la propriété décrite dans la présente.Avec toutes les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.Avec ensemble et sujette à tous les droits ct servitudes indiqués dans l'acte d'acquisition du vendeur mentionné ci-après.Deuxièmement: Ce terrain morceau de terre étant une partie du lot numéro quatorze de la subdivision officielle d'une partie du lot originaire soixante-dix-huit (78-P.14) aux plan et livre de renvoi officiels du village de Pointe-au-Pic, comté de Charlevoix, dite province, sans aucune bâtisse dessus érigée, d'une forme triangulaire, mesurant sur son côté sud-est cent quatre-vingt-onze pieds (191'); sur son côté sud-ouest trente-cinq pieds (35') et sur son côté nord-ouest cent quatre-vingt-quatre pieds et trois dixièmes (184.3), ayant une superficie de trois mille deux cents pieds carrés (3,200'), mesure anglaise; borné comme suit: au sud-est par une partie dudit lot appartenant à F._Otway Byrd ou représentants, au sud-ouest par lo Boulevard ou Chemin des Falaises et au nord-ouest par la propriété décrite en premier lieu, le tout tel qu'indiqué sur le schéma préparé par Jacques Éthier, A.Q., daté à La Malbaie, le 17 septembre 1947 et expliqué par les lettres \"B.C.H.\" ledit schéma est annexé à l'acte d'acquisition du vendeur indiqué ci-après et enregistré sous le numéro 31297.Telle que ladite propriété se trouve présentement avec tous ses droits, membres et appartenances sans exception ou réserve d'aucune sorte de la part du vendeur.formed of and including tho lot described in the cadastral plan and book of reference of the said village of Pointe-au-Pic, under number seventy-five-three (75-3) also that part of lot seventy-eight-fourteen (78-14) of the subdivision of lot seventy-eight (78) of same cadastr:d plan and book of reference, of the said village of La Pointe-au-Pic bounded as follows: in front by the said Boulevard Road, on a lenght of ninety feet, English measure, in rear, on lenght of one hundred and seventy-six feet, English measure, by the portion of lot seventy-eight here in above described in paragraph \"a\", on the north side by tho said lot number seventy-five-three (75-3) on a distance of one hundred and ninety-one feet (191'), English measure, and on the south side by a division lino drawn in a lenght of one hundred and eighty-six feet, English measure, from the south corner of the above mentioned property in a direction to strike tho lower lino of tho said Boulevard at a right angle, at a point distant-of ninety feet, English mcasuro, from tho west corner of tho presently described property.With all tho buildings there on erected, circumstances and dependencies.Together with and subject to all rights and servitudes mentioned in tho vendor's deed of acquisition hereinafter mentioned.Secondly: That certain piece of land being part of lot number fourteen of the official subdivision of part of tho original lot seventy-eight (78-pt.14) upon the official plan and book of reference of the village of Pointe-au-Pic, in the county of Charlevoix, said Province, without any building thereon erected, of a triangular form, measuring on its southeastern side one hundred and ninety-one feet (191'); on its southwestern side thirty-five feet (35') and on its northwestern side on hundred and eighty-four feet and three-tenths of one foot (184.3), having and ar a of three thousand two hundred square feet (3,200'), English measure; bounded as follows: on the southeast by part of tlio said lot belonging to F.Otway Byrd or representatives, on the southwest by the Boulevard or Chemins des Falaises, and on the northwest by the property firstly described, the whole as shown on sketch prepared by Jacques Ethier, Q.L.S.dated at La Malbaie, 17 September 1947 and outlined by the letters \"B.C.H.\" which said sketch is annexed to tho vendor's deed of acquisition hereinafter recited and registered under number 31297.As the said property now subsists with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.Donné ù La Malbaie, ce septième jour du mois de janvier, mil neuf cent cinquante-sept.44145-3-2 Lc Secrétaire-trésorier, P.R.BOULIANE.Given at La Malbaie, this seventh day of I he month of January, one thousand nine hundred and fifty-seven.P.R.BOULIANE, 44145-3-2 Secretary-Treasurer.Province de Québec Municipalité du comté de Matane Avis public vous est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier du conseil de la municipaité du comté de Matane, que les immeubles ci-dessous décrits seront vendus par enchère publique,à Matane, au palais de justice, JEUDI, le QUATORZIÈME jour de MARS 1957, à DIX heures de l'avant-midi «à moins que les taxes, frais et autres charges, tel que ci-dessous mentionnés ne soient plus tôt payés avec les frais encourus, savoir: Province of Quebec Municipality ok the county of Matane Public notice is hereby given by me undersigned Secretary-Treasurer of the municipal council of the municipality of the county of Matane.that the immoveable properties hereinafter described will be sold by public auxtion at Matane, in I he Court House, at TEN o'clock in the morning, THURSDAY, the FOURTEENTH day of MARCH next, unless the taxes, costs and other charges dues as hereinafter mentioned, be paid with costs incurcd, to wit: Municipalité du village de Price \u2014 Municipality of the village of Price Noms et prénoms\tN° du cadastre\tCadastro et rang\tTaxes\tTaxes\t \t\t\tmunie.\tscol.\t \u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\tTotal \t\t\tMunie.\tSchool\t Names and surnames\tCadastre No.\tCadastre and rango\ttaxes\ttaxes\t \tP-92-6.\tFief Pachot.\t$23.38 47.64\t$9.73\t33.U 47.64 \t8-33.\tA, canton-township Cabot\t\t\t \t\t\t\t\t QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 19)7, Vol 89, No.S 271 Municipalité dc la paroisse de St-Ulric \u2014 Municipalité of the parish of St-Ulrio \t\t\tTaxes\tTaxes\t Noms et prénoms\tN° du cadastre\tCadastre et rang\tmunie.\tscol.\t \u2014\t\u2014\t\u2014 ¦\t\u2014\t\u2014\tTotal Names and surnames\tCadastro No.\tCadastre and range\tMunie.\tSchool\t \t\t\ttaxes\ttaxes\t \t4-b, 4c, 4d .10-A____\tSt-Ulric, 5.\t221.61 641.30 96.69\t\t221.61 64.13 170.85 \t\tSt-UIric, 3 (Revisé)\t\t\t \t18-D-l.\tSt-Ulric 3, (Revisé) .\t\t75.16\t \t15A, 15B.15C\tSt-Ulric, 5.\t\t\t \t\t\t\t\t Municipalité de In paroisso de St-Thomas do Cherbourg Municipality of the parish of St-Thomas de Cherbourg Dubé, Albert & L.Boulé.Bouchard, Albert .Bouchard, Henri.Couture.Joachim.Cyr, Philodo.Dcrov, Oneil.Chonel, Wilfrid.Chenel, Robert.Denis, René Gilles.Denis, Hervé.Dubé, Jean Baptiste .Dubé, Jean Baptiste .Dubé, Jean Baptiste .Gagnon, Wellie.lludon, Théodore.Levesque, Yvon.Labrie, Eugène.Lcrlere, Louis Marie.Lefrançois, Alfred.Leblanc, Dclphis .Levesque, Léonidas.Marceau, Hector.Mongcon, Rosaire.Marceau, Eli.Boudreau, Roger.Hoy, Adélard.Sirois, Louis.Sirois, Roland.Thibault.Napoléon .Roland Michaud.-22.Cherbourg.7 .Cherbourg, 8 .Dalibaire, 8 .Cherbourg, 9 .Cherl>ourg, 9 .Dalibaire, 9 .Cherbourg, 6 .Dalibaire, 9 .Cherbourg, 6 .Cherbourg, 9 .Dalibaire, 7 .Dalibaire, 6 .Dalibaire, 5 .Cherbourg, 11 Cherbourg, 10 Cherbourg, 8 .Cherbourg, 9 .Dalibaire, 7.Dalibaire, 10 .Cherbourg, 10 Cherbourg, 11 Cherbourg, 6 .Dalibaire, 6 .Cherbourg, 10 Cherbourg, 10 Dalibaire, 8 .Cherbourg, 9 .Cherbourg, 8.Dalibaire, 7 .Dalibaire 9.4\t31\t16\t42\t20.73 2\t21\t20\t30\t22.67 13\t71\t73\t76\t87.47 2\t67\t22\t83\t25.40 6\t80\t22\t51\t29.31 10\t18\t14\t62\t24.80 9\t17\t34\t20\t43.37 13\t91\t24\t98\t38.89 9\t39\t47\t91\t57.30 8\t75\t91\t88\t100.63 9\t68\t53\t48\t63.16 0\t56\t4\t45\t5.08 1\t13\t16\t42\t17.55 6\t79\t44\t30\t50.09 1\t28\t6\t75\t8.03 21\t20\t140\t49\t161.69 7\t03\t92\t23\t99.26 12\t68\t60\t34\t62.92 2\t00\t30\t39\t32.39 6\t40\t45\t39\t60.79 6\t92\t63\t78\t60.70 14\t72\t43\t59\t68.31 6\t17\t20\t48\t26.65 1\t67\t23\t88\t25.55 6\t76\t47\t39\t63.15 6\t19\t60\t54\t66.73 7\t67\t24\t15\t31.82 2\t87\t6\t98\t9.85 fi\t42\t33\t13\t38.55 18\t84\t79\t01\t97.85 Municipalité du comté de Matane territoire non organisé (St-Nil) Municipality of the county of Matane Unorganized territory (8t-Nil) Landry, Ls.Ph.Gentil, Joseph.(Jentil, Joseph.Si-Laurent, Omer.Ouellet, Joseph.Lavoie, J.Marie.Turcotte, René.M ignault, Rosaire .Lavoie, Sarto.Paradis, Léonard .Jean, Lionel.Cimon, P.Emile____ Dufour, Antoine.Michaud, Jo-cph .Tremblay, Thomas .Bérubé, Arma'd.Vaillancourt, Edouard (Jagnon, Lionel.Cimon, P.-Émilo____ Bérubé, Armand.Imbault, Georges .Tremblay, Thomas .Soucy, Uldéric.St-Pierre, Louis.Gagné, Jules.21.8.9.16.23.23.25.9.12.18.19.24.42.15.16.19.27.11.20.21.20.38-39 10-11 24.15.St-Denis.10.St-Denis, 11.St-Denis, 11.St-Denis, 11.St-Denis, 11.St-Denis, 12.St-Denis, 12.St-Denis, 13.St-Denis, 13.St-Denis, 13.St-Denis, 13.St-Denis, 13.Tessier, 10.Tessier, 13 .:.Tessier, 13.Tessier, 13.Tessier, 13.Tessier, 14.Tessier, 14.Tessier, 14.St-Denis, 10.St-Denis, 12.St-Denis, 13.St-Denis, 11.Tessier 14.12.43\t16.90\t28.33 2.76\t\t2.75 15.80\t3.00\t18.80 3.80\t4.40\t8.20 8.00\t29.50\t37.50 12.27\t16.70\t27.97 12.74\t16.32\t29.06 12.80\t10.40\t29.20 11.53\t14.70\t26.23 7.70\t9.60\t17.30 8.22\t10.30\t18.52 3.20\t22.80\t26.00 17.82\t23.10\t40.92 14.15\t18.20\t32.35 36.35\t\t30.35 28.02\t36.70\t64.72 11.53\t38.80\t60.33 15.80\t40.80\t66.60 23.23\t60.60\t83.83 9.35\t11.80\t21.15 8.62\t10.^0\t19.22 3.20\t.f.\t3.20 3.05\t3.40\t6.45 9.13'\t11.50\t20.63 15.80\t40.80\t56.60 Municipalité du comté do Matane territoire non organisé St-René Goupil.Municipality of tho county of Matane unorganized territory St-René Goupil Levasseur, Sylvain.Gagné, Roger.Oufour, Noël.paquet, Lucien ou Marc Fortin Murray, Marcel.St-Laurent, Alfred.St-Lnurent, Alfred.Bélanger, Ls.Ph.38.P-30 43.40.41.28-29 21-22 20.Tessier, N.E.R.M.Tessier, N.E.R.M.Tessier, S.O.R.M.Tessier, 9.Tessier, 9.Tessier, 11.Tessier, 110.Tessier, 9.1.32\t3.16\t4.48 1.78\t\t1.78 10.38\t64.15\t74.53 1.22\t\t1.22 4.40\t\t4.40 3.78\t\t3.78 3.74\t\t3.74 1.20\t4.60\t6.70 272 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1967, Tome 89, N° 8 Municipalité do la paroisao do Grosses Roches \u2014 Municipality of the parish of Grosses Roches Noma et prénoms Names and surnames Ouellet, Georges.I Desrosiers.Ernest .Imbault, Ovide.Imbnult, Ovide.Ouellet, Georges.\u2022.Thibault, Noël.Ouellet, Georges Albert Savard, Magclla.Savnrd, Magclla.Imbault, Aimé.St-Louis.Urbain.St-Loujs, Laurey.St-Louis, Urbain., Ouellot, Jean.Bouchard, Gérard .N.du cadastre Cadastro No.620.487.624.625____ 489____ 484.488.24 & 25 26.623____ 20.23.24.218-4.38-A-2 \t\tTaxes\tTaxes\t Cadastre et\trang\tmunie.\tscol.\t \u2014\t\t\u2014\t\u2014\tTotal Cadastre and\trango\tMunie.\tSchool\t \t\ttaxes\ttaxes\t Ste-Félicité.can\t-town.\t5.06\t17.51\t22.57 Cherbourg, 5\t\t\t\t \t4\t6.44\t41.97\t48.41 \u2022*\t5\t12.89\t148.70\t161.59 \"\t5\t2.48\t20.29\t22.77 \t4\t71.18\t\t71.18 \t4\t1.35\t41.09\t43 04 \"\t4\t6.61\t49.70\tôti.'Jl \t4\t11.81\t65.88\t77.69 \t6\t24.67\t77.60\t102.27 \t5\t7.42\t49.20\t58.12 \t5\t4.10\t20.98\t25.08 \t5\t11.52\t43.78\t55 30 \t\" 5\t26.81\t54.25\t94.58 Sto Fél.c.-t.Cherbourg, I\t\t22.05\t\t22.05 Revisé\t\t\t\t \t\" 1\t8.54\t130.70\t139.24 Municipalité de la paroisse de St-Adelme\u2014 Municipality of the parish of St-Adelmo Bouchard, Jean.D'Astous.Elie.Fournior, Joseph .Harrisson, Eustache.Harrisson, Georges.Harrisson.Raoul.Ouellet.Jos.Ouellet, Laurent.Les héritiers-hoirs de-of feu-late Char- 49.554.597.508.506.602.589.590.St-Denis 9.St-Denis.6 cad.Sto Félicit St-Denis.7 \" .St-Denis, 6 \" .St-Denis, 6 \" .St-Denis.7 \" .St-Denis.7 \" St-Denis, 7 \" .30.11\t102.80\t132.91 20.29\t78.23\t9*.52 25.47\t24.25\t49.72 30.24\t18.03\t48.27 14.78\t82.56\t97.34 46.80\t116.21\t163 01 34.32\t66.54\t100.86 38.02\t26.67\t64.69 4.75\t26.28\t31.03 les St-Gelais et-and de-of feue-late Dame Dionne: Bélone, Bruno.Alphée, Moïse, Gilbert, Derosa, Brigitte, Marthe, Alice, et-and Gilborte Sg-Gelaia, Eugène, Antoinette, Yvonne, Corona et-and Ida Michaud: Un terrain faisant partie du lot cinq cent trente-deux A piece of land heing part of lot five hundred and (P-532) du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Féli- thirty-two ( P-532) on the official cadastro for the parish cité, iang six canton St-Denis, mesurant quarante pieds of Ste Félicité range six, township St Denis, measiiiing (40') de front par soixante-dix pied* (70') de profondeur, forty feet (40'^ in width by seventy feet ^70') in depth, mesure anglaise, borné au nord au chemin de front, k english measure, hounded on the north side, by the Post, à l'ouest ot au sud au reste du lot cinq cent road, on tho east, west and south sides, by lot five hun-trente-deux (532) propriété d'Albert Truchon, avec dred thirty two (532) Albert Truchon's property, with maison dessus construite, appartenances et dépendan- house thereon erected, appartenances et dépendances.ces._ Municipalité de la paroisse de St-Léandre \u2014 Municipality of the parish of St Leandre Lamarre, Albert.|.|.Une terre située en la paroisse de St-Léandre contenant suc acres de front sur vingt-cinq acres de profondeur, et connue sous les numéros neuf-A, ncuf-B, neuf-o et neuf-d, du sixième rang du cadastre officiai de la Saroisso de St-Ulric de la Rivière Blanche, canton latane, aver les bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances.Lamarre, Albert.|.j, Une terre située en la paroisse de St-Léandre contenant trois a^rci» de front bur vingt-cinq acres de profondeur, bornée au nord et au sud, pai les fronteaux du rang, a l'est, par la propriété de Joseph Ouellet et à l'ouest, à celle de Léandre Levasseut, étant connue comme taisant partie du numéro sept-a (P-7-a) du septième rang du cadastre officiel dc la paroisse de St-Ulric de la Rivièire Blanche, canton Matane, avec les bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances.| 61.06 | 102.03 | 163.09 A piece of land situated in the paiish of St-Léandre, measuiing six (6) ncres in width, by twenty-five (25) acres in depth, being lots nino-a, nine-b nine-;C and nine-d (9-a, 9-b, 9-c & 9-d) six range on tho official cadastre for the parish of St-Ulric, township Matane, with buildings thereon erected, appartenances and dependencies.Lamarre, Albert.|.| Une terre située en la paroisse de St-Léandre, contenant cinq (5) acres do front sur vingt-cinq (25) acres de profondeur, bornée au nord et au sud, par les fronteaux du rang, à l'est ct à l'ouest, par des propriétés appartenant aux ayants droit do Ferdinand Bélanger, étant connue sous lo numéro huit-J^ c et comme faisant partie du lot nouf-a (P-9-a) du septième rang du cadastre offioiel de la paroisse de St-Ulric de la Rivière Blanche, canton Matane, avec les bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances.I 22.28 I 63.90 | 86 18 A piece of land situated in the parish of St Leandre, mesuring three ',3) acres in width by twenty-five (25) acres in depth bounded on tho south side, by the boundary of the range, on the east side, by Joseph Ouellct's property, on the north side by the boundery cf the range, and on the west side, by Léandre Levasseur's property, being pait of lot seven-a (P-7-a) seventh range on the official cadastro for the parish of St Ulric, township Matane, with buildings thereon erected, appartenances and dependancies.I 33.22 I 109.67 | 142.89 A piece of land situated in the parish ol St-Leandre, measuring five (5) acres in width by twenty-five (25) acres in depth, bounded on tho east and west side, l>y Ferdinand Bélanger's heirs, on the north and south sides, by the boundary of the range, being lot number eight-c (8-c) and being part of lot nine-a (P-9-a> seventh range on the official cadastre for tho parish of St Ulric, township Matane, with buildings thereon erected, appartenances and dependancies.Donné à Matane, ce quinzième jour de janvier Given at Matane this fifteenth day of January 1957.1957.Le Secrétaire-trésorier de la Corpora tion, Secretary-Treasurer of the Corporation of du comté de Matane, the County of Matane, 44158-3-2-0 C.ALEX LE BEL.44158-3-2-o G.ALEX LEBEL. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 273 Municipalité du comté de Shefford Avis public est par les présentes donné que le soussigné, secrétaire-trésorier que les terrains ou parties ci-après mentionnées seront vendu ou adjugés par ancan public au rabais à quiconque offrira de payer les montants à prélever et les frais encourus pour la moindre partie ou chacun des terrains qui seront mis à l'enchère à défaut de paiement avant la vente des taxes municipales scolaires et repartitions d'église ct des frais encourus pour parvenir à la vente an Palais de Justice «à Waterloo le QUATORZIÈME jour de MARS 1957 à DIX heures de l'avant-midi, savoir: Municipality of the county of Shefford Public notice is hereby given by the undersigned secretary-treasurer, that the lands or parcels hereinafter described will be sold by auction in abating to whomsoever will offer to pay the amounts due on such lots including costs for the least part of any lot auctioned the whole in default of previous payments of said amounts due and the whole including costs incurred leading to this sale hereby advertised and the whole including municipal school and church taxes at the Court House, at Wa'erloo, the sale to be held on MARCH the FOURTEENTH day 1957, at TEN o'clock in the forenoon, to wit: Cité de Granby \u2014 City of Granby \t\tTaxes\tTaxes\tTaxes\t Noms\tNos des lots\tmun.\tscol.\téglise\tTotal \u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t Names\tNos of lots\tMun.\tSchool\tChurch\t \t\ttaxes\ttaxes\ttaxes\t; \t117-119.\t$368.66 5).27 138.61 152.28 119.42 62.67 8.67\t$173.89 140.10 1J6.31 185.81 110.25 88.43 20.85 68.55\t\t$542.55 190.37 244.92 338.09 235.67 151.10 29.52 .68.55 \tP.506.\t\t\t\t \t126-24.\t\t\t\t \t314-p.16.\t\t\t\t P.E.St-Gcrmain.\tP.628.\t\t\t\t \t719-140.\t\t\t\t \t628-P.713 & 174.\t\t\t\t \t423.\t\t\t\t \t\t\t\t\t Municipalité du canton de Granby \u2014 Municipality of the township of Granby Arthur Allaire.Arthur Choquette, Omer Couture.Arthur Dumoulin.Yvon Desrochers.Armand Fournier.Leon Dusablon.Philippe Grondin.Paul Emile Hardy Poland Gagné____ Auguste Picard.19-Xrg.19-11 rg____ 3A, 122B, 124.127A.483 p.816-817 pt.11C-10 rg.150-155.239 pt.487-13-14-16-17.423 pt.321A-322A.472-473 Granby.451 Shefford.120.46 90.35 49.19 62.41 1.00 68.12 52.85 52.24 43.03 68.00 112.75 24.75 14.27 107.20 64.46 36.32 Municipalité du canton de Shefford \u2014 Municipality of the township of Shefford Armand Brousseau.Orpha Choinière.Ernest Lavallée.Jules Fortin.Mariland Ledoux.Hervé Martin.Dame-Mrs.Hector Monty.Augustin Choinière.Rapul Denis.Joseph Fortin.Pt.1020.Pt.481 & 482.709.865.6-7____ 523.608A.490-491 pts.438-40-37-pt.33.13.01 35.21 211.97 37.40 76.00 14.57 132.50 15.50 151.88 78.30 75.30 375.13 53.61 61.00 Municipalité do St-Joachim de Shefford \u2014 Municipality of St-Joachim of Shefford Emile Boyer.Ko^er Daigle.Telesphore Gagné Ledoux Leopold.Claude Viens_____ Lucien Papineau.209.306 pt.303____ Pt.426.266-267-272 pts 290.411.34.00\t21.00 53.00\t36.00 16.00\t22.00 20.00\t14.00 41.00\t27.00 60.00\t36.00 Municipalité d'Ely, partie ouest \u2014 Municipality of Ely, west part Roger Lalime .\t908.\t143.34\t78.99\t\t232.33 Entile Marois\t874.923.\t69.90\t\t\t69.90 \t\t\t\t\t 274 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 Municipalité do ia paroisso do Stukoly-Sud \u2014 Municipality of the parish of Stukely-South \t\tTaxes\tTaxes\tTaxes\t Noma\tNos des lots\tmum\tscol.\téglise\t \u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\tTotal Nain os\tNos of lots\tMun.\tSchool\tChurch\t \t\ttaxes\ttaxes\ttaxes\t \t399-400.\t269.02 134.25 16.25 45.50 9.50 20.75 69.00\t202.80\t\t471 82 134.25 16.25 45 50 9.50 20.75 169.65 119.03 182.15 114.45 198.00 \t229-230-223-124 pt.\t\t\t\t \tIll.\t\t\t\t \t150-152.\t\t\t\t \t200-377 Pt.\t\t\t\t \t290.\t\tiôi'.èo' 119.08 182.15 114.45 198.00\t\t \t282-284-280-285 pt.\t\t\t\t \t218.\t\t\t\t \t282-344.\t\t\t\t \tPt.132.\t\t\t\t \t273.\t\t\t\t \t\t\t\t\t Municipalité de 8tukely-Nord.partio est \u2014 Municipality of Stukely-North, east part\t\t\t\t\t \tPt.566.\t4.45 51.53\t\t\t4.45 51.53 \tPt.689.\t\t\t\t \t\t\t\t\t Donné à Waterloo, Que., ce 11 janvier 1957.Ia: Secrétaire-trésorier, 44146-3-2-0 C.H.LEFEBVRE.Given at Waterloo, Que., January 11.1957.C.H.LEFEBVRE, 44140-3-2-O «% Secretary -Treasurer.VENTES PAR SHÉRIFS SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC est par le present donné que PUBLIC NOTICE is lierebv Riven that the les TERRES ET HERITAGES sous-mentionnés undermentioned LANDS and TENEMENTS ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux have been seized, and will be sold at the respect-respectifs, tels que mentionnés plus bas.ive times and place.* mentioned below.ABITIBI Province de Québec \u2014 District d'Abitibi Cour de Magistrat, ( T E.BÊRARD.mar-Val d'Or, jj* chaud de meubles de N° 12,031.\"J Val d'Or, district d'Abitibi, \\ demandeur saisissant vs DAVID OUELLETTE.journalier, de St-Gérard de Berry, district d'Abitibi, défendeur saisi.AVIS DE VENTE Les droits acquis sur le lot 42 rang 7 du cadastre officiel pour le canton Berry, dans le district d'Abitibi, avec bâtisses dessus construites, * Circonstances ct dépendances.Pour être vendu a la porte dc Péclise paroissiale de St-GénH de Berry, le TRENTIEME jour de JANVIER 1957, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif d'Abitibi, Bureau du shérif, J.A.GAUTHIER.Amos, 22 décembre 1956.43967-52-2-o ARTHABASKA j Canada \u2014 Province de Québec ; District d'Arthabaska Cour Supérieure, I T^AME ALEXANDRINE ,.N° 11.642.< 'IS DESPAULT, veuve de V Êphrem Duquette, ménagère, de St-Germain de Grantham, et ÉLIE LAUZON, bourgeois, de même lien, district d'Arthabaska, demandeurs vs AURÈLE VALLIÈRES, de Victoriaville, district d'Arthabaska, défendeur.\"Un terrain mesurant cinquante pieds de largeur par cent pieds de profondeur, mesure an- ABITIBI Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Magistrate's Court, ( T E.BÊRARD, mer-Val d'Or.'J* chant dealing in fur-No.12,031.îiiture, of Val d'Or, dis-\\ trict of Abitibi, distainoi vs DAVID OUELLETTE, journeyman, of St.Gérard de Berry, district of Abitibi, distrainee.NOTICE OF SALE The acquired rights on lot 42, Range 7, of tlie official cadastre for the township of Berry, in t lie district of Abitibi, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold at the door of the Parochial Church of St.Gérard de Berry, the THIRTIETH day of JANUARY 1957, at TWO o'clock in the afternoon.J.A.GAUTHIER.Sheriff's Office, Sheriff of Abitibi.Amos, December 22, 1956.43967-52-2 ARTHABASKA Canada \u2014 Province of Quebec District of Arthabaska Superior Court, / T^AME ALEXANDRINE No.11,642.< *-s DESPAULT, widow of \\ Êphrem Duquette, housekeeper, of St.Germain de Grantham, and ELLE) LAUZON, gentlemen, of the same locality.District of Arthabaska, Plaintiffs vs AURÈLE VALLIÈRES, of Cictoriaville, District of Arthabaska, defendant.\"A piece of land measuring fifty feet in width by one hundred feet in depth, English measure. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 275 glaise, avec bâtisses dessus construites, situé du côté nord-ouest du chemin St-Cyrillc, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Wendovcr, comté de Drumtnond, comme étant une partie du lot numéro neuf (Ptie No.9), borné comme suit: en front au sud-est p>ir la route nationale; au nord-ouest ct sud-ouest par Domino Côté; au nord-est par Walter Côté.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Sf-Charles, comté de Drummond, le TRENTIÈME jour dc JANVIER 1957 à TROIS heures dc l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, FÉLIX HOULE.Arthabaska, 24 décembre 1956.43968-52-2-0 with buildings erected thereon, situated on the northwesterly side of St.Cyrille Road, known and designated on the official plan and book of reference of the cadastre of the Township of Wendover, County of Drummond, as being part of lot number nine (P.No.9), bounded as follows: in front to the southeast by the national highway; northwesterly and southwesterly by Domino Côté; northeasterly by Walter Côté.\" To be sold at the parochial church door of the parish of St.Charles, County of Drummond, on the THIRTIETH day of JANUARY, 1957, at THREE o'clock in the afternoon.FÉLIX HOULE, Sheriff's Office.Sheriff.Arthabaska, December 24, 1956.43968-52-2 BEAUHARNOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris District dc Beauharnois Cour Supérieure, I t-TERBERT J.BANNING, N° 2472.< AJ- fermier, du canton de I Godmanchcstcr, comté de Huntingdon, de Beauharnois, demandeur vs GERHARD HAMAN, fermier, auparavant du canton de Godmanchcstcr, comté dc Huntingdon, district de Beauharnois, maintenant de lieux inconnus et O.EDMOUR CASTAGNER, régis-trateur, dc la ville de Huntingdon, en sa qualité de régis\" ratcur des immeubles pour la division d'enregistrement de Huntingdon, mis-en-causc, défendeurs.A savoir: \"Une ferme située dans le canton de Godmanchester connue comme étant le lot numéro quatre cmt vingt-cinq (425) du plan cadastral pour ledit canton de Godmanchester, uvec bâtisses dessus érigées, ayant une superficie de cent acres, plus ou moins, mesure anglaise.\" Pour être vendue à la porte dc l'église paroissiale de St-Joscph d'Huntingdo», comté d'Huntingdo», le JEUDI, VINTG ET UNIÈME jour de FEVRIER 1957, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ERNEST POIRIER.Valleyfield, le 19 janvier 1957.44130-3-2 (Première insertion: 19 janvier 1957.) CASPÊ Fieri Facias de Terris District dc Rimouski Cour Supérieure, ( /CLAIRE GOSSELIN, de N° 15,687.< ^ Montréal, demanderesse (contre EDOUARD FOUR-NIER, de Ste-Anne-des-Monts, défendeur.\"Une certaine étendue de terrain de forme irrégulière sise et située en la paroisse de Ste-Anne-des-Monts, mesurant une largeur de cent pieds (100) à la ligne nord-ouest et dc cent trente-sept pieds (137) à celle sud-est, par une profondeur de quatre cent cinquante-cinq pieds (455), mesurée à la ligne sud-ouest, avec la maison dessus construite, appartenances et circonstances, ledit terrain désigné comme faisant partie du lot portant le numéro quarante-sept subdivision A resubdivision un (Ptie de 47-A-l) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour le premier rang du Fief Ste-Anne-des-Monts Notre-Dame et bornée comme suit: au nord-ouest par partie du lot 47-A-l) de Wilfrid Vallée, au nord-est par le lot 46-A-l, d'Edouard D.Dugas, au sud-est par le résidu du lot 47-A-l, appartenant à Romuald, Rioux, ladite ligne sud- BEAUHARNOIS Fieri Facias de Bonis et de Terris District of Beauharnois Superior Court, / TJTERBERT J.BANNING, No.2472.{ farmer, of the township lof Godmanchester, in the county of Huntingdon, district of Beauharnois, plaintiff, vs GERHARD HAMAN, farmer, formerly of the township of Godmanchester, in the county of Huntingdon, district of Beauharnois, now of parts unknown; and O.EDMOUR CASTAGNER, registrar, of the town of Huntingdon, in his quality of registrar of immoveables, for the Registration Division of Huntingdon, mis-en-cause, defendants.To wit: \"A farm situate in the township of Godmarehcster, known as lot number four hundred and twenty-five (425) of the cadastral plan for the said township of Godmanchcstcr, with buildings thereon erected, having a.superficial area of one hundred acres, more or less, English meausre.\" To be sold at the parochial church door of St.Joseph d'Huntingdon, countv of Huntingdon, THURSDAY the TWENTY-FIRST dav of FEBRUARY 1957, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, ERNEST POIRIER.Sheriff.Valleyfield, January 19, 1957.44130-3-2-O (First Lisertion: January 19, 1957.] CASPÊ Fieri Facias de Tenia District of Rimouski Superior Court, ( pLAIRE GOSSELIN, of No.15,687.< Montreal, plaintiff, (against EDOUARD FOUR-NIER, of Ste-Anne-des-Monts, defendant.\"A certain extent of land of irregular form located and situated in the parish of Ste-Anne-des-Monts, measuring a width, of one hundred feet (100) on the northwest line and one hundred and thirty-seven feet (137) to that of the southeast, by a depth of four hundred and fifty-five feet (455), measured at the southwest line, with house thereon erected, appurtenances and circumstances, the said plot of land designated as forming part of lot bearing number forty-seven subdivision A resubdivision one (Pt.of 47A-1) on the plan and in the book of reference of the official cadastre for the first range of the Fief Ste-Anne-des-Monts, Notre-Dame and bounded as follows: on the northwest by part of lot 47-A-l) of Wilfrid Vallée, on the northeast, by lot 46-A-l, of Edouard D.Dugas, on the southeast, by the residue of lot 47-A-l, belonging 276 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 est sise et située à cent douze pieds (112) du parement sud de la maison construite sur ledit terrain, fait angle droit avec les lignes nord est et sud-ouest et au sud-ouest par l'emprise nord-est d'un chemin de communication.Pour être vendus à la porte de l'église de Ste-Anne-des-Monts, comté de Gaspé, MERCREDI, le VINGTIÈME jour de FEVRIER 1957 à DIX heures de Pavant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.Percé, P.Q., le 12 janvier 1957.44131-3-2-o Fieri Facias de Bonis ct de Terris District dc Rimouski Cour Supérieure, / p ÉRARD SASSEVILLE N° 18,394.< vJ de Ste-Anne-des-Monts, ' P.Q., demandeur contre CYPRIEN RICHARD du même endroit défendeur: Une maison d'habitation mesurant 21' x 25' d'un étage et demi, construite ct sise sur partie du lot N° dix-huit (18), 1er rang, bloc \"A\", canton Tourelle, cette partie du lot étant la propriété de Louis-Charles Pelletier.Pour être vendue à la porte de l'église de Ste-Anne-des-Monts, P.Q., VENDREDI, le VINGT-DEUXIÈME jour de FÉVRIER 1957 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.F.MEAGHER.Percé, P.Q., le 14 janvier 1957.44142-3-2-o to Romuald Rioux, the said southeast line located and situated at one hundred and twelve feet (112) of the south façade of the house constructed on the said lot of land, makes a straight angle with the lines northeast and southwest and on the southwest by the northeast right-of-way of a communication road.\" To be sold at the church door of Ste-Anne-des-Monts, county of Gaspé, WEDNESDAY, the TWENTIETH day of FEBRUARY, 1957, at TEN o'clock in the forenoon.J.F.MEAGHER, Sheriff's Office, Sheriff.Percé, P.Q., January 12, 1957.44131-3-2 Fieri Facias de Bonis et de Terris District of Rimouski Superior Court, / p ÉRARD SASSEVILLE No.18,394.< vJ of St.Anne-dcs-Monts, I P.Q., plaintiff versus CYPRIEN RICHARD of the same locality, defendant: A'-dwelling-house measuring 21' x 25' of one story and a half, erected and situated on part of lot No.eighteen (18), range 1, block \"A\", township of Tourelle, said part, of lot being the property of Louis-Charles Pelletier.To be sold at the door of the church of St.Anne-dcs-Monts, P.Q., FRIDAY, the TWENTY-SECOND day of FEBRUARY 1957, at TEN o'clock in the forenoon.J.F.MEAGHER, Sheriff's Office, Sheriff.Percé, P.Q., January 14, 1957.44142-3-2 IBERVILLE Canada \u2014 Provirce de Québec District d'Iberville Cour de Magistrat, (\\/OGUE SHOE SHOP N° 11641.< V LTD., corps politi-v que et incorporé ayant sa principale place d'affaires en la cité de Montréal, district de Montréal, demandeur vs MARGUERITE BOURGEOIS, ci-devant de la cité de St-Jean, district d'Iberville, et maintenant de lieux irconnus, défenderesse.Comme appartenant à la défenderesse.Savoir: Le tiers indivis d'un emplacement connu et désigné comme étant les trois-quarts nord du lot N° trois-cent quarante-sept, (347) du cadastre officiel de la ville de St-Jean, contenant cinquante-quatre (54) pieds de largeur sur «ent quarante-quatre, (144) pieds de profondeur, borné à l'est par la rue Longueuil, au sud par le quart sud dudit lot N° trois cent quarante-sept, (347) au nord par le lot N° trois cent-cinquante, (350) et à l'ouest par le lot N° trois cent quarante-huit, (348) avec maison et constructions y érigées.Pour être vendus au bureau du Shérif, en la cité de Saint-Jean, district d'Iberville.JEUDI le VINGT-ET-UNIÈME jour de FÉVRIER 1957 à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RICHARD MERCIER.St-Jean le 15 janvier, 1957.44134-3-2-o IBERVILLE Canada \u2014 Province of Quebec District of Iberville Magistrate's Court, f\\/OGUE SHOE SHOP No.11641.< V LTD., a body politic v and corporate having its principal place of business in the City of Montreal, district of Montreal, plaintiff vs MARGUERITE BOURGEOIS, formerly of the City of St.John, district of Iberville, and now of unknown whereabouts, defendant.As belorgirg to the defendant.To wit: The undivided third of an emplacement known and designated as being the northerly three-quarters of lot No.three hundred and forty-seven, (347) of the official cadastre of the town of St.John, containing fifty-four (54) feet in width by one hundred and forty-four (144) feet in depth, bounded easterly by Longueuil Street, southerly by the southerly quarter of said lot No.three hundred and forty-seven, (347) northerly by lot No.three hundred and fifty, (350) and westerly by lot No.three hundred and forty-eight, (348) with house and structures erected thereon.To be sold at the Sheriff's Office, in the City of Saint John, district of Iberville, THURSDAY, the TWENTY-FIRST day of FEBRUARY 1957, at ELEVEN o'clock in the forenoon.RICHARD MERCIER, Sheriff's Office, Sheriff.St.John, January 15, 1957.44134-3-2 JULIETTE Fieri Facias de Terril Canada \u2014 Province de Québec District de Juliette Cour de Magistrat, / T A CORPORATION DE N° 21,628.< ¦L' LA VILLE DES LAU-( RENTIDES, (St-Lin), cor- JOLIETTE Fieri Facicui de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Joliette Magistrate's Court, / THE CORPORATION No.21,628.1 OF THE TOWN OF ( LAURENTIDES, (St QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 277 poration légalement constituée, ayant son principal établissement à St-Lin, district He Joliette, demanderesse vs NAPTALIE CÔTÉ, demeurant en la ville des Laurentides, (St-Lin) district de Joliette, défendeur.Comme appartenant au défendeur: \"Un emplacement bâti de maison et dépendances situé en la ville des Laurentides, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Lin, comme étant le lot 1051, à distraire cependant de ce lot un lopin de terre étant la partie ouest dudit lot, mesurant 44' de largeur par la profondeur de ce même lot et appartenant à Dame Alida Fournicr-Aumont, en vertu dc l'acte consenti le 26 septembre 1952 par Mme Laverdure passé devant le notaire Pauzé et enregistré sous le numéro 59,381.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de la Ville des Laurentides, (St-Lin) le MERCREDI, SIXIÈME jour du mois de FÉVRIER 1957, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ROLAND PERRAULT.Ce 27 décembre 1956.43969-52-2-o Lin), a corporation legally constituted, having its head office at St.Lin.District of Joliette, Plaintiff vs NAFrALIE CÔTÉ, residing in the Town of Laurentides, (St.Lin), District of Joliette, defendant.As belonging to the Defendant: \"An emplacement with house erected thereon and dependencies situated in the Town of Laurentides, known and designate.! on the official plan and book of reference of the Parish of St.Lin, as being lot 1951, save however a plot of land being the westerly part of said lot.measuring 44' in width by the depth of said lot and belonging to Dame Alida Fournicr-Aumont, according to Deed authorized the 26th.day of September 1952 by Mrs La verdure, passed before Notary Pauzé and registered under number 59,381.\" * To be sold at the door of the Parochial Church of the Town of Laurentides, (St.Lin) WEDNESDAY, the SIXTH dav of the month of FEBRUARY 1957, at TEN o'clock in the forenoon.ROLAND PERltAULT.Sheriff's Office, Sheriff.This December, 27th, 1956.43969-52-2 LABELLE Fieri Facias de Tern's Canada \u2014 Province de Québec District de Labelle Cour Supérieure, ( TV\\ME REBECCA KUSH-N° 4693.< U LEN, ménagère, de la \\ cité et du district dc Montréal, veuve, de feu Samuel Tarrofsky, dc son vivant, manufacturier dc la cité et du district de Montréal, demanderesse, vs A.BARRETTE & CO.LTD., corps politique dûment \" incorporé et ayant son Bureau chef et sa principale place d'affaires dans la ville de Mont-Laurier, district de Labelle, défendeur.LABELLE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Labelle Superior Court, / T\\AME BEBECCA KUSH-No.4693.< *f LEN, housewife, of the 'city and in the district of Montreal, widow, of the late Samuel Tarnofsky, in his lifetime, manufacturer of the citv and district of Montreal, plaintiff; vs A.BARRETTE & CO.LTD., a body politic, duly incorporated and having its head office a»d its principal place of business in the town of Mont-Lauricr, district of Labelle, defendant.AVIS DE VENTE \"Un lot situé dans la ville de Mont-Laurier, étant un emplacement formant partie du lot numéro quatre-cent-cinquante (pt.450) de la ville de Mort-Laurier, dans la province de Québec, district de Labelle, mesurant 50 pieds (50') en front sur la rue Frontenac, par l'entière profondeur dudit lot et borné comme suit: en front comme mentionné ci-haut, par ladite rue Frontenac, à l'arrière par une partie du lot numéro quatre cent quarante-neuf (pt.449) sur un côté par le lot quatre cent cinquante-et-un (451) et sur l'autre côté par le résidu dudit lot quatre cent cinquante (résidu 450) appartenant à la Canadian Business Finance Corporation, avec les bâtisses et dépendances dessus érigées.\" Pour être vendu au Bureau du Shérif, au Palais de Justice à Mont-Laurier, dans le district de Labelle, le VINGT-HUITIÈME jour de FÉVRIER 1957, à DIX heures dc l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ADRIEN LAROSE.Mont-Laurier, 11 janvier 1957.44141-3-2-o NOTICE OF SALE \"A lot situate in the town of Mont-Laurier, being an emplacement forming part of lot number four hundred and fifty (Pt.450) of the town of Mont-Laurier, in the Provirce of Quebec, district of Labelle, measurirg 50 feet (50') in front on Frontenac Street, by the entire depth of the said lot and bounded as follows: in front, as above mentioned, by the said Frontenac Street, in rear, by a part of lot number four hundred and forty-nine (Pt.449) on ore side by lot four hundred and fifty-one (451) and on the other side, by the residue of the said lot four hundred and fifty (residue 450) belonging to the Canadian Business Finance Corporation, with the buildings and dependencies thereon erected.\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House in Mont-Laurier, in the district of Labelle, on the TWENTY-EIGHTH day of FEBRUARY, 1957, at TEN o'clock in the forenoon.ADRIEN LAROSE, Sheriff's Office Sheriff.Mont-Laurier, January 11, 1957.44141-3-2 QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: f \"Q ENÉ TALBOT LIMI-N° 82,619.< *V TÉE, corporation léga-l lement constituée, ayant son siège social au N° 205 rue St-Paul.cité et district de Québec, contre YVON LETOURNEAU, domicilié à St-Romuald, comté de Lévis, district de Québec.QUEBEC Fieri Facias Quebec, to wit : / T3 ENÉ TALBOT LIMI-No.82,619.< TÉE, corporation legal-( ly constituted having its head office at No.205 St.Paul Street, city and district of Quebec, versus YVON LETOURNEAU, domiciled at St.Romuald, county of Levis, district of Quebec. 278 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° 8 Lot N° 367-1-8 \u2014 Dc figure trapézoïdale, borné au nord-est par une partie du lot trois cent soixante-sept-un (367-1) non-subdivisé, au sud-est par la route Trans-Canada, au sud-ouest par le lot numéro trois cent soixante-sept-un-trois (367-1-3) et au nord-ouest par lc lot numéro trois cent soixante-sept-un-sept (367-1-7), mesurant au nord-est cent vingt-pieds et huit dixième (120.8), au sud-est cent deux pieds (102') au sud-ouest cent pieds (100-') et au nord-ouest cent pieds (100') contenant en superficie onze mille quarante pieds carrés (11,040 pi.car.) plus ou moins, mesure anglaise.Lot N° 367-1-13 \u2014 De figure irrégulière, borné au nor'-est par le lot numéro trois cent soixante-six (366) au sud-est par la route Trans-Canada, au sud-oue \"t par le lot numéro trois cent soixante-sept-un-huit (367-1-8) au nord-ouest par le lot numéro trois cent soixante-sept-un-douze (367-1-12) mesurant cinq pieds (5') de largeur et au nord-est cent vingt-et-un pieds et huit dixième (121 '.8) et au su l-ouest cent vingt pieds et huit dixième (12C.8) et contenant en superficie six cent sept pied - carrés (6n7 pi.car.) plus ou moins, mesura anglaise, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Po-r être vendu à la porte de l'église paroissi-de dc S'-P'muald, comté de Lévis, le VINGT-DEUXIÈME jour de FÉVRIER prochain à DEUX heures dc l'rprès-midi.Le Deputé-Shérif, B r a u du Shérif, ALBERT F.RACETTE.Q élrc, le 16 janvier 1057.44159-3-2 [Pr.mière insertion: 19 janvier 1957.J [Daixicmc insertion: 9 février 1957.) Fiiri Facias Québec, à savoir: / T A SALLE ASPHALT N° 77,559.< ¦L' LTÉE, corporation lé-l gaiement constituée nyant son sièse sochl à 1.143, rue Notre-Dame O'.test, Montréal, et un bureau d'affaires rue du Parc.Stc-Foy.P.Q., outre J.-C.BEGIN, de 196 avenue Phntc, Québec-Ouest.P.Q.Un lopin de terre situé en la paroisse de St-Sauvcur de Québec, comnrenant les hts connus et désignés sous les numéros (2436-110) cent dix de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-six et (2436-111) cent onze de.la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-six sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre officiel de la iite paroisse.Ledit ht (2436-110) cent dix de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-six est borné au nord-est par le lot numéro (2439-154) cent cinquante-quatre de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf, borné au sud-est par le ht numéro (2436-109) cent neuf de la subdivision du ht deux mille quatre cent trente-six, au sud-ouest par le ht numéro (2436-89) quatre-vingt-neuf de h subdivision du.lot deux mille quatre cent trente-six (rue McGill).borné au nord-ouest par le ht numéro (2436-111) cent onze de la subdivision du lot deux mille quatre-cent trente-six, mesurant en front une largeur de vingt-cinq pieds (25') sur une profondeur de cinquante pieds (50') et contenant en superficie mille deux cent cinquante pieds (1,250') mesure anglaise.Ledit lot (2436-111) cent onze de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-six est borné au nord-est par le lot numéro (2439-155) Lot No.367-1-8.\u2014 Of trapezoidal form, bounded northeasterly by a part of lot three hundred and sixty-seven-one (367-1) non-subdivided, southeasterly by the Trans-Canada Highway, southwesterly by lot number three hundred and sixty-seven-one-three (367-1-3) and northwesterly by lot number three hundred and sixty-seven-one-seven (367-1-7).measuring northwesterly one hundred and twenty feet and eight tenths (120.8) southeasterly one hundred and two feet (102') southwesterly one hundred feet (100') containing an area of eleven thousand and forty square feet (11,040 sq.ft.) more or less, English measure.Lot No.307-1-13.\u2014 Of irregular form, bounded northeasterly by lot number three hundred and sixty-six (366) southeasterly by the Trans-Canada Highway, southwesterly by lot number three hundred and sixty-seven-1-8 (367-1-8) northwesterly by lot number three hundred and sixty-seven-1-12 (367-1-12) measuring five feet (5') in width and northeasterly one hundred and twenty-one feet and eight tenths (121'.8) and southwesterly one hundred and twenty and eight tenths (120'.S) and containing an area of six hundred and seven square feet (697 sq.ft.) more or less, English measure, with buil lings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sol 1 at the door of the Parochial Church of St.Romual I, countv of Levis, the TWENTY-SECOND day of FEBRUARY next at TWO o'clock in the afternoon.ALBERT F.RACETTE, Sheriff's Office, Deputy Sheriff.Quebec, January 16, 1957.44159-3-2-0 [First insertion: January 19, 1957.] [Second insertion: February 9, 1957.] Fieri Facias Québec, to wit :(TA SALLE ASPHALT No.77,559.< -L* LTÉE, a corporation je-' gaily constituted having its head office at 1,143 Notre-Dame street, West, Montreal, and a business office on Pare Street, Stc-Foy, P.Q., against J.-C.BEGIN, of 196 Plante Avenue, Quebec-West, P.Q.A strip of land situated in the parish of St-Sauveur of Quebec, comprising lots known and designated under numbers (2436-110) one hundred and ten of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six and (2436-111) one hundred and eleven of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six on the official plan and in the book of reference of the said parish.The said lot (2436-110) one hundred and ten of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six is bounded on the northeast by lot number (2439-154) one hundred and fifty-four of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine, bounded on the southeast by lot number (2436-109) one hundred and nine of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six, on the southwest by lot number (2436-89) eighty-nine of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six (McGill Street), bounded on the northwest by lot number (2436-111) one hundred and eleven of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six, measuring in front a width of twenty-five feet (25') upon a depth of fifty feet (50') and containing in area one thousand two hundred and fifty feet (1,250') english measure.The said lot (2436-111) one hundred and eleven of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six is bounded on the north- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 1957, Vol.89, No.8 279 cent cinquante-cinq de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf, borné au sud-est par le lot numéro (2-136-110) cent dix de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-six, borné au sud-ouest par lc lot numéro (2436-89) quatre-vingt-neuf dc la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-six (étant l'avenue McGill) borné au nord-ouest par le lot numéro (2436-112) cent douze de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-six, mesurant en front une largeur de vingt-cinq pieds (25') sur une profondeur de cinquante pieds (50') contenant en superficie mille deux cent cinquante pieds (1,250') mesure anglaise; avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Un lopin de terre situé en la paroisse de St-Sauveur de Québec, comprenant les lots connus et désignés sous les numéros (2439-154) cent cinquante-quatre de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf et (2439-155) cent cinquante-cinq de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre officiel de ladite paroisse.Ledit lot (2439-154) cent cinquante-quatre tie la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf est borné au nord-ouest par le lot numéro (2439-133) cent trente-trois de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf (une ruelle) borné au sud-est par le lot numéro (2439-153) cent cinquante-trois, de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf, borné au sud-ouest par le lot numéro (2436-110) cent dix de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-six, au nord-ouest par le lot numéro (2439-155) cent cinquante-cinq de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf, mesurant en front une largeur de vingt-cinq pier's (25') sur une profondeur de cinquante pieds .(50') et contenant une superficie de mille deux cent cinquante pieds (1,250') mesure anglaise.Ledit lot (2439-155) cent cinquante-cinq de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf est borné «au nord-ouest par le lot numéro (2439-133) cent trente-trois dc la subdivision du lot deux iridié quatre cent trente-neuf (une ruelle), au sud-est par le lot (2439-154) cent cinquante-quatre dc la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf, au sud-ouest par le lot numéro (2436-111) cent onze de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-six, au nord-ouest par le lot numéro (2439-156) cent cinquante-six de la subdivision du lot deux mille quatre cent trente-neuf, mesurant en front une-largeur de vingt-cinq pieds (25') sur une profondeur de cinquante pieds (50') cçntenant en superficie mille deux cent cinquante pieds (1,250'), mesure anglaise; avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à mon bureau au Palais de Justice de Québec, le VINGT-DEUXIÈME jour de FÉVRIER prochain à DIX heures de l'avant-midi.Le Député-Shérif, Bureau du Shérif, ALBERT F.RACETTE.Québec, le 16 janvier 1957.44160-3-2-o [Première insertion: 19 janvier 1957.] [Deuxième insertion: 9 février 1957.] east by lot number (2439-155) one hundred and fifty-five of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine, bounded on the southeast by lot number (2436-110) one hundred and ten-of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six, bounded on the southwest by lot number (2436-89) eighty-nine of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six (being McGill Avenue) bounded on the northwest by lot number (2436-112) one hundred and twelve of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six, measuring in front a width of twenty-five feet (25') by a depth of fifty feet (50') containing in area one thousand two hundred and fifty feet (1,250') english measure; with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.A strip of land situated in the parish of St-Sauveur of Quebec, comprising lots known and designated under numbers (2439-154) one hundred and fifty-four of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine and (2439-155) one hundred and fifty-five of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine on the official plan and in the book of reference of the cadaster of the said parish.The said lot (2439-154) one hundred and fifty-four of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine is bounded on the northwest by lot number (2439-133) ore hundred and thirty-three of the subdivision of lot two thousand fourhundredandthir'y-nire (a lane) bounded on the southeast by lot number (2439-153) one hundred and fifty-three of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine, bounded on the southwest by lot number (2436-110) one hundred and ten of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six, on the northwest by lot number (2439-155) one hundred and fifty-five of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine, measuring in front a width of twenty-five feet (25') by a depth of fifty feet (50') and containing an area of one thousand two hundred and fifty feet (1,250') english measure.The said lot (2439-155) one hundred and fifty-five of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine is bounded on the northwest by lot number (2439-133) one hundred and thirty-three of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine (a lane), on the southeast by lot (2439-154) one hundred and fifty-four of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine, on the southwest by lot number (2436-111) one hundred and eleven of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-six, on the northwest by lot number (2439-156) one hundred and fifty-six of the subdivision of lot two thousand four hundred and thirty-nine, measuring in front a width of twenty-five feet (25') by a depth of fifty feet (50') containing an area of one thousand two hundred and fifty feet (1,250') english measure; with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at mv office at the Court House of Quebec, the TWENTY-SECOND day of FEBRUARY next at TEN o'clock in the forenoon.ALBERT F.RACETTE, Sheriff's Office, Deputy-Sheriff.Quebec, January 16th, 1957.44160-3-2 [First insertion: January 19th, 1957] [Second insertion: February 9th, 1957.J 280 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89, N° S ROBERVAL Canada \u2014 Province de Québec District de Roberval Cour Supérieure,/pOCKSHUTT FARM N° 18,467 < v-1 EQUIPMENT LTD., (.corporation légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires dans les cité et district dc Montréal, demanderesse vs MARCELLIN DUFOUR et ROSAIRE DUFOUR, domiciliés et résidants dans Notre-Dame de Lorette, comté de Roberval, défendeurs.Saisis comme appartenant à Rosaire Dufour: 1° Un emplacement le long du chemin public, dans le village de Notre-Dame de Lorette, de forme irrégulière, faisant partie des lots numéros vingt-A et vingt-B (20-A et 20-B), du rang un (1) aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre du canton Antoine, lequel terrain mesure soixante pieds (60') de front sur le chemin public; cent trois pieds (103') suivant une ligne brisée du côté nord-ouest, cent pieds (100') dans sa ligne nord-est et cent quarante-quatre pieds (144') dans sa ligne sud-est; ledit terrain borné en front, à l'ouest au chemin public, au nord-ouest au terrain de Philippe Larouche, au nord-est au terrain de Marcellin Dufour et au sud-est à une rue proposée; avec bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances; 2° Un terrain de forme irrégulière faisant partie du lot numéro dix-neuf (partie 19) du rang un (1) du cadastre officiel du canton Antoine, contenant environ dix (10) à douze (12) acres en superficie; borné à l'ouest en front, au chemin de front; au nord-est à la rivière \"Loup-Cervier\", et du côté sud à la coulée qui s'y trouve, avec maison et dépendances, sauf servitudes en faveur de la Compagnie Électrique du Saguenay.Saisis comme appartenant à Marcellin Dufour: 1 ° Les lots de terre connus et désignes sous les numéros vingt-A et vingt-J (20-A et 20-J) du premier rang du cadastre officiel du canton Antoine, sauf à distraire desdits lots la servitude en faveur de la Compagnie Électrique du Saguenay et aussi à distraire dudit lot N° virgt-A(20-A) les empluc m nts vendus suivant titr s enregistrés, avec tous bâtiments dessus érigés, circonstances et dépendances.Pour être vendus à la porte de l'église de Notre-Dame de Lorette, comté de Roberval, Province de Québec, le VINGT ET UNIÈME (21) jour de FÉVRIER, (1957) mil neuf cent cinquante-sept, à DEUX (2) heures de l'après-midi.Le Shérif du district de Roberval, LÉON-MAURICE LAVOIE.Bureau du Shérif, Palais de Justice, district de Roberval, Ce 9 janvier 1957.44132-3-2-0 (Première insertion: le 19 janvier, 1957-] ROBERVAL Canada \u2014 Province of Quebec District of Roberval Superior Court, fpOCKSHUTT FARM No.18,467.< EQUIPMENT LTD., \\ corporation legally constituted, having its principal place of business in the city and district of Montreal, plaintiff vs MARCELLIN DUFOUR and ROSAIRE DUFOUR, domiciled and residing in Notre-Dame de Lorette, county of Roberval, defendants.Seized as belonging to Rosaire Dufour: 1.An emplacement along the public highway, in the Village of Notre-Dame de Lorette, of irregular shape, forming part of lots number twenty-A and twenty-B (20-A and 20-B), range one (1) of the official plan and book of reference of the cadastre for the township of Antoine, which piece of land measuring sixty feet (60') in front along the public highway; one hundred and three feet (103') along a broken line on the northwesterly side, one hundred feet (100') along the northeasterly line and one hundred and forty-four feet (144') along the southeasterly line; the said piece of land is bounded in front, westerly by the public highway, northwesterly by the land of Philippe Larouche, northeasterly by the land of Marcellin Dufour ond southeasterly by a proposed street; with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies; 2.A piece of land of irregular shape forming part of lot number nineteen (P.19) of Range one (1) of the official cadastre for the township of Antoine, containing an area of some ten (10) to twelve (12) acres; bounded westerly in front, by the front road; northeasterly by the \"Loup Cervier\" River, and on the southerly side by a ravine, with house and dependencies, save and except the servitude in favour of the Saguenay Electric Company.Seized as belonging to Marcellin Dufour: 1.The lots of land known and designated as numbers twenty-A and twenty-J (20-A and 20-J) of range one of the official cadastre for the township of Antoine, save and except the servitude in favour of the Saguenay Electric Company and also to be deducted from said lot No.twenty-A (20-A) the emplacements sold according to registered deeds, with all buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold at the door of the church of Notre-Dame de Lorette.county of Roberval, Province of Quebec, the TWENTY-FIRST (21) day of FEBRUARY (1957) one thousand nine hundred and fifty-seven, at TWO (2) o'clock in the afternoon.LEON-MAURICE LAVOIE, Sheriff for the district of Roberval.Sheriff's Office, Court House, district of Roberval, This January 9, 1957.44132-3-2 (First insertion: January 19, 1957.] Index de la Gazette officielle Index of the Quebec Official de Québec, N° 3 Gazette, No.3 Arrêté; en Conseil: Order in Council: 19\u2014Concernant l'huile à chauffage et la 19\u2014Concerning fuel oil and gazoline taxe sur la gazoline.234 tax.234 Avis aux intéressés: 169 Notice to Interested Parties: 169 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January Î9th, 1957, Vol.89, No.8 281 Avis divers: Association des Instituteurs et Institutrices catholiques de la Région de Rivière-du-Loup (Nom changé).237 Atlas Hoist & Body Inc.(Directeurs).237 Chibougamau Theatre Inc.(Directeurs) 238 Coopérative d'Habitation de Donnacona (Fondation).236 Kenaston Corporation (Directeurs).237 La Caisse Coopérative de Crédit de St-Jacques (Fondation).236 La Corporation de l'Hôpital de St-Ambroise de Loretteville (Directeurs).238 L'Association des Membres du Personnel Enseignant des Écoles Spécialisées Relevant du Ministère du Bien-Etre Sooinl ct dc la Jeunesse, Incorporée.(Directeurs)____.236 L'Association Syndicale des Employés de Postes d'Esserce et de Garages des comtés de Trois-Rivières, St-Maurice, Maskinongé, Champlain et Laviolette (Formation).238 Le Syndicat des Producteurs de Sucre et de Sirop d'Érable de Québec-Sud.(Fondation).235 Selective Lumber Inc.(\"Règlement).236 Syndicat Coopératif des Eleveurs de Chinchillas de la Mauricie (Fondation).236 The Canadian Import Company, Limited (Siège social).237 Chartes \u2014 Abandon de: Adélard Pincince Automobile Inc.240 Bourlamaque Assoyers & Chemists Limited.239 Burlington Dress lue.238 Burnside Investments Ltd.239 Cummings Enterprises Inc.240 Goyer Street Corporation.239 Montreal Vinegar Company Limited \u2014 La Compagnie de Vinaigre Montréal Limitée.v 239 Saint-Pierre et Chartrand Compagnie Limitée.239 Commission du Salaire Minimum: Ordonnance d'amendement.240 Ordonnance No 3 1957 .241 Compagnie dissoute: The Claridge Realty Corporation, Limited.246 DUMandes X la législature: Cohen et al.249 Godin et al.249 Lachine, cité.247 La Prairie, ville.247 Nevaid, Henry Ballon.247 Québec, cité.247 St-P'élicien, commission scolaire.;.247 St-Jean-Vianney de Gatineau, commission scolaire.246 Succession Charles Raymond.249 DÉPARTEMENTS \u2014AVIS DES: Instruction pjbmque: Municipalité scolaire de: Coaticook.250 Miscellaneous Notices: Association des Instituteurs et Institutrices catholiques dc la Région de Rivière-du-Loup (Name change 1).237 Atlas Hoist & Body Inc.(Directors).237 Chibougamau Theatre Inc.(Directors) 238 Coopérative d'Habitation dc Donnacona.(Foundation).236 Kenaston Corporation (Directors).237 La Caisse Coopérative de Crédit de St-Jacques (Foundation).236 La Corporation de l'Hôpitf] de St-Am- broise de Loretteville (Directors).238 L'Association des membres du Personnel Enseignant des Êcelcs Spécialisées Relevant du Ministère du Bien-Etre Social ct «le la Jeunesse, Incorporée (Directors).236 L'Association Syndicale des Empl yés de Postes d'Essence et dc Garages des comtés de Trois-Rivières, St-Maurice, Maskinnngé, Champlain et Lavic lette (Formation).238 Le Syndicat des Producteurs de Sucre et de Sirop d'Érable de Québec-Sud.(Foundation).235 Selective Lumber Inc.(By-Law).236 Syndicat Coopératif des Eleveurs de Chinchillas de la Maurice (Foundation).236 The Canadian Import Company, Limited (Head Office).237 Charters \u2014 Surrender of: Adélard Pincince Automobile Ire.240 Bourlamaque Assoyers & Chemists Limited.239 Burlington Dress Inc.238 Burnside Investments Ltd.239 Cummings Enterprises Inc.240 Goyer Street Corporation.239 Montreal Vinegar Company Limited \u2014 La Compagnie de Vinaigre Montréal Limitée.239 Saint-Pierre & Chartrand Compagnie Limitée.239 Minimum Wage Commission: Ordinance of amendment.240 Ordinance No.3 1957 .241 Company Dissolved: The Claridge Realty Corporation, Limited.246 Applications to Legislature: Cohen et al.*.249 Godin et al.249 Lachine, city.247 La Prairie, town.247 Nevard, Henry Ballon.247 Quebec, city.247 St-Félicien, school commission.247 St-Jean-Vianney de Gatineau, school commission.246 Charles Raymond Estate.249 DEPARTMENTAL NOTICES: Education: School Municipali'y of: Coaticook.250 282 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 19 janvier 1967, Tome 89, N° 3 Dean ville, village.251 Huberdeau.250 Lac Carré.250 Laval-dcs-Rapides, ville (Catholique) 249 Poularies.251 Rapide Danseur.249 St-Edouard-de-Knowlton (Cath.) et St-André-de-Sutton (Cath.).250 St-Simon d'Abercorn.250 Weedon.251 Terres et Forêts: Service du Cadastre: Beauport, paroisse.252 Pointe-Claire, paroisse.252 St-Antoine-de-Longueuil, paroisse.251 St-Martin, paroisse.252 Travail: Industrie ou métiers de: Barbiers, coiffeurs et coiffeuses du comté de Roberval (Modification).252 Convention collective de travail relative aux barbiers ct coiffeurs du district de Hull.253 Voirie: Entretien de certaines routes discontinué .255 Lettres patentes: Big Nell Mines Limited.170 Canada-Europe Hardware Import Ltd.171 Canadian Carmel Kosher Wine Co.Ltd.171 Chibtown Copper Corporation.171 Cirea Realty Co.172 Club Social St-.Iean-Port-Joli.172 Connaught Inn Inc.172 David B.Granofsky & Sons Inc.173 Eastern Machinery & Equipment Ltd.173 Edouard Robitaille Inc.173 Emile Séguin & Fils Limitée \u2014 Emile Séguin & Sons Limited.174 Eugène Thérien & Jean-Guy Chartrand Incorporés.174 Garage Gemme & Alix Lie.174 Glenwood Realties Ltd.175 Golden Triangle (Que) Investment Company.175 Hav-A-Bite Cafeteria Lie.175 Hôpital Saint-Michel.176 J.P.Bérubé Diamond Drilling Co.Ltd.176 J.P.Trépanier Limitée.176 J.R.Deslauricrs Ltée.177 Justin Dallaire Ltée.177 La Corporation de l'Ordre des Carmes Déchaussés.178 Laprairie Shopping Centre Ltd.\u2014 Centre d'Achat Laprairie Ltée.178 Le Prêt d'Honneur Lasallien Inc.178 Les Immeubles Pro-Can Limitée \u2014 Pro-Can Realties Limited.179 Les Produits Cardinal Lie.179 \"Les Vingt Associés Lie.179 L'Immeuble Trans-Québec Licorporée.180 Magasin Raymond Ltée.*.'.180 Manoir des Iles Incorporé.180 Mercury Shingle & Siding Co.Ltd.181 Mesy Construction Inc.181 Metallic Industries Ltd.181 National Dried Fruit Co.Limited.182 North Shore Fish and Fruits Inc.182 Patrick Provencher Inc.182 Deanville, village.251 Huberdeau.>.250 Lac Carré.250 Laval-des-Rapides, town (Catholic) .249 Poulirics.251 Rapide Danseur.249 St-Edouard-de-Knowlton (Cath.) and St-André-de-Sutton (cath.).250 St-Simon d'Abercorn.250 Weedon.251 Lands and Forest: Cadastral Branch: Beauport.parish.252 Pointe-Claire, parish.252 St-Antoine-dc-Longucuil, parish.251 St-Martin, parish.252 Labour: Industry or Trades of: Barbers and hairdressers of the County of Roberval (Amendment).252 Collective agreement of labour relating to the barbers and hairdressers of the District of Hull.253 Roads: Maintenance of certain roads discontinued .255 Letters Patent: Big Nell Mines Limited.170 Canada-Europe Hardware Import Ltd.171 Canadian Carmel Kosher Wine Co.Ltd.171 Chibtown Copper Corporat ion.171 Cires.Realty Co.172 Club Social St -Jean-Port-Joli.172 Connaught Inn Inc.172 David B.Granofsky & Sons Inc.173 Eastern Machinery & Equipment Ltd.173 Edouard Robitaille Inc.173 Emile Séguin & Fils Limitée \u2014 Emile Séguin & Sons Limited.174 Eugène Thérien & Jean-Guy Chartrand Licorporés.174 Garage Gemme & Alix Inc.17-1 Glcnwood Realties Ltd.175 Golden Triangle (Que) Investment Company.175 Hav-A-Bitc Cafeteria Lie.175 Hôpital Saint-Michel.176 J.P.Bérubé Diamond Drilling Co.Ltd.176 J.P.Trépanier Limitée.176 J.R.Deslauricrs Ltée.177 Justin Dallaire Ltée.17< La Corporation de l'Ordre des Carmes Déchaussés.178 Laprairic Shopping Centre Ltd.\u2014 Centre d'Achat Laprairic Ltée.178 Le Prêt d'Honneur Lasallien Inc.178 Les Immeubles Pro-Can Limitée \u2014 Pro-Can Realties Limited.179 Les Produits Cardinal Inc.179 Les Vingt Associés Inc.179 L'Immeuble Trans-Québec Incorporée.180 Magasin Raymond Ltée.180 Manoir des Iles Incorporé.180 Mercury Shingle & Siding Co.Ltd.181 Mesy Construction Inc.181 Metallic Industries Ltd.181 National Dried Fruit Co.Limited.182 North Shore Fish and Fruits Inc.182 Patrick Provencher Inc.182 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 19th, 19Ô7, Vol.89, No.S 283 Paul's Petroleum Inc.183 Pellatt's Food Market Inc.183 Produits Laitiers de la Côte Nord Ltée\u2014 North Shore Dairy Pioducts Ltd.183 P.Scarderç Limited.184 Quebec Metal Window Ltd.(Fenêtre en Métal du Québec Ltée).184 Roger Electric Inc.184 Rosa Lumber Inc.185 Roseglen Development Corp.185 Snoc Lighting Limited.185 St.George Gardens Ltd.\u2014 Jardins St.Georges Ltée.186 S.Verdon Ltée \u2014 S.Verdon Ltd.186 Taverne Bélanger Inc.186 The Lady Grey's Salvage Operations Ltd.\u2022.187 Universal Metal Works Inc.187 Universal Printing and Paper Box Co.187 Winkcl Diamonds (Canada) Ltd.188 Ministère des Finances: Assurances: British Merchants' Lisurance Company Limited (Permis).256 La Mutuelle-Vie de l'U.C.C.(Société-annulée).256 La Mutuelle-Vie de l'U.C.C.(Compagnie-Permis) .256 The Canadian Equity Insurance Company (Permis).257 The British and European Insurance Company (Annulation).257 Sièges sociaux: Construction Renaud Ltée.Granby K-tchcn Equipment Inc.Lucien Charbonneau Limitée.Soumissions: Longueuil, Comm.scolaire Cath.Notre-Dame des Laurentides, paroisse Portage-du-Fort, village.St-Eustache, ville.Varennes, Comm.scol., village.Vente pas lï citation: Kulik vs Grad ct al.Ventes pour taxes: Arthabaska, comté dc.202 Barvillè, Corporation municipale.214 Chambly, comté de.106 Champlain, comté dc.221 ('harlevoix-Est, comté de.268 Deux-Montagnes, comté de.210 Drummond, comté de.197 ( iaspé-Est, comté de.265 Huntingdon, comté de.191 Iberville, comté de.213 Lac St-Jean-Ouest, comté de.203 L'Assomption, comté de.217 L'IsIct, comté de.228 Lotbinière, comté de.229 Maskinongé, comté de.231 Matane, comté de.270 Matapédia, comté de.223 Montcalm, comté de.192 Montmagny, comté de.199 Papineau, comté de.215 Portneuf, comté de.232 Québec, comté de.\u2022.211 Richelieu, comté.201 Paul's Petroleum Inc.183 Pellatt's Food Market Lie.183 Produits Laitiers de la Côte Nord Ltée\u2014 North Shore Dairy Products Ltd.183 P.Scardere Limited.184 Quebec Metal Window Ltd.(Fenêtre en Métal du Québec Ltée).184 Roger Electric Inc.184 Rosa Lumber Inc.185 Roseglen Development Corp.185 Snoc Lighting Limited.185 St.George Gardens Ltd.\u2014 Jardins St.Georges Ltée.186 S.Verdon Ltée \u2014 S.Verdon Ltd.186 Taverne Bélanger Inc.186 The Lady Grey's Salvage Operations Ltd.187 Universal Metal Works Lie.187 Universal Printing and Paper Box Co.187 Winkel Diamonds (Canada) Ltd.188 Department of Finance: Insurance: British Merchants' Insurance Company Limited (License).256 La Mutuelle-Vie de l'U.C.C.(Society-Cancellation) .256 La Mutuelle-Vie de l'U.C.C.(Company-License) .256 The Canadian Equity Insurance Company (License).257 The British and European Insurance Company (cancellation).257 Head Offices: 258 257 258 263 259 258 260 262 264 Arthabaska.county of.202 Barville, Municipal Corporation.214 Chambly', county of.196 Champlain, county of.221 Charlevoix-Est, county of.268 Two Mountains county of.210 Drummond, county of.197 Gaspé-Est, county of.265 Huntingdon, county of.191 Iberville, county of.213 Lake St.John West county of.203 L'Assomption, county of.217 LTslet.county of.228 Lotbinière, county of.229 Maskinongé, county of.231 Matane, county of.270 Matapédia, county of.223 Montcalm, county of.192 Montmagny, county of.199 Papineau, county of.215 Portneuf, county of.232 Québec, county of.211 Richelieu, county of.201 258 Construction Renaud Ltée.257 Granby Kitchen Equipment Inc.258 Lucien Charbonneau Limitée.Tenders: 263 Longueuil, Cath.School Coram.259 Notre-Dame des Laurentides, parish.258 Portage-du-Fort, village.260 St-Eustache, town.262 Varennes, Village scliool Coram.Sale by Li citation: 264 Kulik vs Grad ct al.Sales for Taxes: 284 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 19 janvier 1957, Tome 89.N° S Québec: \u2014 Imprimé par Rédemptï Pahadw, Quebec: \u2014 Printed by Rédkmpti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer Richmond, comte «le.191 Richmond, county of.190 Rimouski.comté dc.206 Rimouski, county of.200 Shefford, comté de.273 Shefford, county of.273 Terrehonnc comté de.218 Terrebonne, county of.218 Yamaska.comté de.188 Yamaska, county of.188 VENTES PAR SHÉRIFS: SHERIFFS' SALES: Abitibi: Abitibi: Bérard vs Ouellette.274 Bérard vs Ouellette.274 Arthabaska: Arthabaska: Despault et al vs Vallières.274 Despault et al vs Vallièrcs.274 Beauharnois: Beauharnois: Banning vs Haman et al.275 Banning vs Haman et al.275 Gaspé: Gaspé: Gossclin vs Foumicr.275 Gossclin vs Founder.27ô Sasseville vs Richard.276 Sasseville vs Richard.276 Iberville: Iberville: Vogue Shoe Shop Ltd vs Bourgeois.277 Vogue Shoe Shop Ltd vs Bourgeois- 277 Joliette: Joliette: Ville des Laurentides vs Côté.276 Town of Laurentides vs Côté.276 Labelle: Labelle: Kushlen vs A.Barrette et Co.Ltd____ 277 Kushlen vs A.Barrette & Co.Ltd.277 Quebec: Quebec: La Salle Asphrlt Ltée, vs Begin.278 La Salle Asphalt Ltée vs Begin.278 René Talbot Limitée vs Létourneau.277 René Talbot Limitée vs Létourneau.277 Roberval: Roberval: Coekshutt Farm Equipment Ltd vs Cockshutt Farm Equipment Ltd vs Dufour etal.280 Dufour et al.280 44081-O 44081-O "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.