Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 3 mars 1956, samedi 3 (no 9)
[" Tome 88, N* 9 849 Vol.88, No.9 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (M Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 3 mars 1956 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 'ont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, March 3rd, 1956 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe.Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 850 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mari, 1966, Tome 88, N\" 9 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire h midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Iteine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 206 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.* La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, \"figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: St.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502 \u2014 1-52 Lettres patentes (P.O.10060-50) .Admiration Clothes Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1950.constituant en corporation: Conrad Shatner.Harry Blank, tous deux avocats et (ïloria Williams, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vêtements, sous le nom de \"Admiration Clothes Ltd.\", avec un capital total de S 100.000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1956.- L'Assistant-procureur général, 41 f-'8S C.E.CANTIN.Letters Patent (A.G.10000-50) Admiration Clothes Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the'Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January.1950, incorporating: Conrad Shatner.Harry Blank, both advocates, and Gloria Williams, secretary, spinster of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and ileal in clothing, under the name of \"Admiration Clothes Ltd.\".with a total capital stock of $100,000, divided into 500 common shares having a par value of $100 each and into 500 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 851 (P.G.10139-56) Aero Enterprises Limited Avis est donné qu'en vertu de là première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf janvier 1956, constituant en corporation: Jean Goulet, avocat, Puulette Panneton, secrétaire, épouse séparée de biens de Paul Panneton et Gisèle Gélinas, opératrice de téléphone, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Créer, établir, monter et maintenir une organisation de vente ou d'achat pour la promotion, la vente, la publicité', la distribution ou la présentation d'aéroplanes, hydroplanes et machines aériennes de toute catégorie et description, sous le nom de \"Aero Enterprises Limited\", avec un capital-actions divisé en 200 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf janvier 1950., L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.10042-56) Agence d'Assurances Rouville Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1956, constituant en corporation: Robert Daigneault, comptable agréé, Roger Marion, agent d'assurances, et Gaston Rondeau, avocat, tous de Marieville, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Agir comme agent et courtier d'assurances, sous le nom de \"Agence d'Assurances Rouville Inc.\", avec un capital total de §5,000, divisé en 5,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Marie-ville, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13580-55) Alf.Marquette & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1955, constituant en corporation : J.-Elias Biais, marchand, de Saint-Joseph-sur-Vamaska, Roland Frégeau, marchand, de Sainte-Rosalie, tous deux du district judiciaire de Saint-Hyacinthe, et Almanzar Laberge, comptable, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de grains, céréales, moulées, farines, graines de semence et autres produits agricoles, sous le nom de \"Alf.Marquette & Fils Inc.\", avec un capital total de $125,000, divisé en 000 actions privilégiées classe A de $100 chacune, 500 actions privilégiées classe B de $100 chacune et en 150 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Rosalie, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(A.G.10139-56) Aero Enterprises Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of January, 1956, incorporating: Jean Goulet, advocate, Paulette Panneton, secretary, wife separate as to property of Paul Panneton, and Gisèle Gélinas, telephone operator, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To create, establish, build up and maintain a selling or purchasing organization for the promotion, sale, advertisement, distribution or introduction of aeroplanes, hydroplanes and aircraft of every class and description, under the name of \"Aero Enterprises Limited\", with a capital stock divided into 200 shares having no nominal or par value.The head oifice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.10042-50) Agence d'Assurances Rouville Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January, 1950, incorporating: Robert Daigneault, chartered accountant, Roger Marion, insurance agent, and Gaston Rondeau, advocate, all of Marieville, judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To operate as an insurance agent and broker, under the name of \"Agence d'Assurances Rouville Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 5,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Marieville, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13580-55) Alf.Marquette & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1955, incorporating: J.-Elias Biais, merchant, of Saint-Joseph-sur-Yamaska, Roland Frégeau, merchant, of Saint Rosalie, both of the judicial district of Saint Hyacinthe, and Almanzar Laberge, accountant, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in grain, cereals, mixed-feeds, flour, seeds, and other agricultural products, under the name of \"Alf.Marquette & Fils Inc.\", with a total capital stock of $125,000, divided into 600 Class A preferred shares of $100 each, 500 Class B preferred shares of $100 each and 150 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint Rosalie, judicial district of Saint Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December.1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General. 852 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1966, Tome 88, No 9 (P.G.13605-55) Associated Commercial Photographers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1955, constituant en corporation: Richard Dale Weldon, John William Durnford, avocats.Frank Writgh, gérant de bureau, de Montréal et Edmond Jacques Courtois, avocat, de West mount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme photographes, sous le nom de \"Associated Commercial Photographers Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4.000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de West mount, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.13313-55) Association des Résidents de l'Ile Ste-Thérèse Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des, lettres patentes, en date du douze janvier 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Wilfrid Laçasse, manufacturier, Léo Guay, garagiste, Pierre Bienvenue, propriétaire de taxis, Jean-A.Croteau, menuisier, Albert Prévost, barbier, Gérard Morin, pompier, Guy Bourgon, voyageur, tous de Montréal, et Jean-Guy Doiron, représentant de l'Union, de Montréal-Sud, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Réunir en association des résidents de l'Ile Ste-Thérèse, dans le district judiciaire d'^berville, et les autres personnes qui désireront se joindre à ce groupement, pour la pratique des sports, l'étude des questions artisticpies, culturelles et économiques, sous le nom de \"Association des Résidents de l'Ile Ste-Thérèse\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $50.000.Le siège social de la corporation sera à l'Ile Ste-Thérèse, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10088-50) Béliveau & Frères, Ltée .Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1950, constituant en corporation: Irenée Béliveau, Oscar Béliveau et Gérard Béliveau, tous commerçants, de ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'articles et commodités faits d'acier ou autres métaux et alliages de métaux, de machinerie, essence, huile, lubrifiant, outillage et équipement, sous le nom de \"Béliveau & Frères, Ltée\", avec un capital total de $45,000, divisé en 15,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en (A.G.13605-55) Associated Commercial Photographers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December, 1955, incorporating: Richard Dale Weldon, John William Durnford, advocates, and Frank Writht, Office manager, of Montreal, and Edmond Jacques Courtois, advocate, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as photographers, under the name of \"Associated Commercial Photographers Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at the city of Westmount, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13313-55) Association des Résidents de Pile Ste-Thérèse Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the day of January 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Wilfrid Laçasse, manufacturer, Léo Guay, garage-keeper, Pierre Bienvenue, taxi owner, Jean A.Croteau, joiner, Albert Prévost, barber, Gérard Morin, fireman.Guy Bourgon, traveller, all of Montreal, and Jean-Guy Doiron, Union representative, of Montreal-South, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To unite into an association the residents of Ile Ste-Thérèse, in the judicial district of Iberville, and other persons who might care to join this group, for the practice of sports, the study of artistic, cultural and economic questions, tinder the name of \"Association des Résidents de l'Ile Ste-Thérèse\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited is $50,000.The head office of the corporation will be at Ile Ste-Thérèse, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10088-56) Béliveau & Frères, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January, 1956, incorporating: Irénée Béliveau, Oscar Béliveau and Gérard Béliveau, all merchants, of the town of Jacques Cartier, judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in articles and commodities into the fabrication of which enters steel or other metals and alloys, machinery, gazoline, oil, lubricants, tools and equipment, under the name of \"Béliveau & Frères, Ltée\", with a total capital stock of $45,000, divided into 15,000 common shares of a par value of $1 each QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 853 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1079, Coteau Rouge, ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13687-55) Birchwood Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1955, constituant en corporation: l'iiilip Fischel Vineberg, avocat, de Westmount, Rita Estelle Wise, secrétaire, fille majeure, d'Outremont et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Birchwood Investments Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 6,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1955.L'Assistant-procureur général, \u202211888 C.E.CANTIN.(PG.13473-55) Botticelli Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur, de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1955, constituant en corporation: Samuel \"Chait, Harry L.Aronovitch, Abraham Shuster, avocats et Freda Pomerance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de sacoches, ceintures, sacs, porte-feuilles, porte-monnaie et articles et nouveatutés de genres semblables, sous le nom de \"Botticelli Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 360 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.13341-55) B.Patenaude Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première par-t ie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente novembre 1955, constituant en corporation: Jean-Paul St-Louis, Marcel Belleville, avocats, et Myrto Brasseur, secrétaire, célibataire majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de placements, sous le nom de \"B.Patenaude Ltée\".avec un capital total de $156,000, divisé en 6 and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 1079 Coteau Rouge, town of Jacques Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January 1950.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13087-55) Birchwood Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1955, incorporating: Philip Fischel Vineberg, advocate, of Westmount.Rita Estelle Wise, secretary, fillc majeure, of Outremont, and Yvonne Bélanger, secretary.fille majeure, of Montréal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Birchwood Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 100 common shares of S100 each and into 6,000 preferred shares of $5 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13473-55) Botticelli Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec; bearing date the thirtieth day of December, 1955, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, Abraham Sinister, advocates, and Freda Pomerance, secretary, spinster of the full age of majority, all of the cit^v and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in handbags, belts, bags, billfolds, wallets, and similar style items ami novelties, under the name of \"Botticelli Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40 common shares of the par value of $100 each and into 300 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13341-55) B.Patenaude Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November 1955.incorporating: Jean-Paul St-Louis, Marcel Belleville, advocates, and Myrto Brasseur, secretary, unmarried having reached the age of majority, all of the city and judicial district of Montreal for, the following purposes: \u2022 To carry on the operations of an investment company, under the name of \"B.Patenaude Ltée\", with a total capital stock of $156,000, 854 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 actions classe \"A\" de SI,000 chacune, 750 actions classe \"B\" de SI00 chacune et en 750 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10060-56) Broadway Knitting Mills Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf janvier 1956, constituant en corporation: Jacob Berliner, manufacturier, Izydore Horn, David Wimisner et Abraham Roseman, marchands, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de tissus, textiles, vêtements et accessoires, sous le nom de \"Broadway Knitting Mills Ltd.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège «social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.13684-55) L Canadian Tire & Repair (Thetford Mines) Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois janvier 1956, constituant en corporation: J.-Elzéar Turcotte, industriel, de Charlesbourg, Georges-L.Dupont, voyageur de commerce, de Québec, et J.-Êmilien Simard, avocat, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'iiîMiistric et le commerce de pneus et autres produits et sous-produits du caoutchouc, sous le nom de \"Canadian Tire & Repair^ (Thetford Mines) Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Thetford -Mines, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13516-55) Centre Récréatif de Sept Iles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze janvier 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard Lepage, ingénieur, Valmont Blanchette, agent et Louis \" Paradis, avocat, tous de Sept Iles, district judiciaire de Saguenay, pour les objets suivants: Entretenir, exploiter et diriger un centre communautaire et promouvoir les meilleurs intérêts de la localité en général, sous le nom de \"Centre Récréatif de Sept Iles Inc.\".divided into 6 Class \"A\" shares of $1,000 each, 750 Class \"B\" shares of $100 each and 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10066-56) Broadway Knitting Mills Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of January, 1956, incorporating: Jacob Berliner, manufacturer, Izydore Horn, David Wimisner and Abraham Roseman, merchants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in fabrics, textiles, clothing and accessories, under the name of \"Broadway Knitting Mills Ltd.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 5,000 preferred shares ôf $10 each.The head office of the.company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of January, 1955.C.E.CANTIN, 41S88-o Deputy Attorney General.(A.G.13684-55) Canadian Tire & Repair (Thetford Mines) Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January 1956, incorporating: J.Elzéar Turcotte, industrialist, of Charlesbourg, Georges L.Dunont, commercial traveller, of Quebec, and J.Emilicn Simard, advocate, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of and deal in tires and other rubber products and by-products, under the name of \"Canadian Tire & Repair (Thetford Mines) Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Thetford Mines, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this third day of January 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13516-55) Centre Récréatif de Sept Iles Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of January, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Gérard Lepage, ingeneer, Valmont Blanchette, agent, and Louis Paradis, advocate, all of Sept lies, judicial district of Saguenay, for the following purposes: To maintain, operate and conduct a community centre and to promote the bests interests of the community generally, under the name of \"Centre Récréatif de Sept Iles Inc.\". QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Mardi 3rd, 1956, Vol.88, No.9 855 I a* montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 82.000,000.Le siège social de la corporation sera à Sept [les, district judiciaire de Sagucnay.Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, lisss C.E.CANTIN.(P.G.10134-56) Chic Parisien Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1950, constituant en corporation: Nathan Abraham Levitsky.avocat, de Ville Mont-Royal, Solomon W.Wcber, avocat, d'Ou-tremont et Sylvia Nitkin, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre l'importation, la fabrication et la vente d'habits, chandails, vêtements et acces-soires, sous le nom de \"Chic Parisien Ltd.\", avec un capital total de .$40,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.I*c siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C E.CANTIN.(P.G.12847-55) Chinook Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept octobre 1955, constituant en corporation: Roy Fraser Elliott, avocat, Mary Elizabeth Spracklin et Margot Mary Quinn, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Chinook Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 751 Carré Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept octobre 1955.L'Assistant-procureur général, \u202211S88 C.E.CANTIN.(P.G.^ 13343-55) Comité Protecteur des Scouts de St-Sauveur, Val d'Or \u2014 Bourlamaque Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze janvier 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Marc Laforest, Clément Morin, marchands, de Val d'Or, et Joseph-Aurèle LeBlanc, greffier, de Bourlamaque, tous du district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Fournir les moyens nécessaires au bon fonctionnement du Groupe Scout de la Paroisse Saint-Sauveur-les-Mines (qui est comprise actuellement dans les limites des villes de Val The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited, is $2.000,000.The head office of the corporation will be at Sept lies, judicial district of Sagucnay.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January, 1950.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.10134-56) Chic Parisien Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1956, incorporating: Nathan Abraham Levitsky, advocate, of the town of Mount Royal.Solomon VV.Weber, advocate, of Outre-mont.and Sylvia Nitkin, secretary, fille majeure.of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To engage in the import, manufacture and sale of clothing, sweaters, apparel and accessories, under the name of \"Chic Parisien Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1950.C.E.CANTIN, 4I8S8-0 Deputy Attorney General.(A.G.12S47-55) Chinook Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of October, 1955, incorporating: Roy Fraser Elliott, advocate, Mary Elizabeth Spracklin and Margot Mary Quinn, secretaries, spinsters, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Chinook Ltd.\", with a total capital stock of 840,000.divided into 40,000 shares of the par value of 81 each.The head office of the company will be at 751 Victoria Square, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-seventh day of October, 1955.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13343-55) Oèmité Protecteur des Scouts de St-Sauveur, Val d'Or \u2014 Bourlamaque Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of January 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Marc Laforest, Clément Morin, merchants, of Val d'Or, and Joseph Aurèle LeBlanc, clerk, of Bourlamaque, all of the judicial district of Abitibi, for the following purposes : To provide the necessary means of furthering the efficient administration of the \"Group Scout de la Paroisse Saint Sauveur-les-Mines (actually within the limits of the towns of Val d'Or and 856 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 d'Or et Bourlamaque), sous le nom de \"Comité Protecteur des Scouts de St-Sauveur, Val d'Or-Bourlamaque\".£ Le montant auquel sont limites les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $40,000.Le siège social de la corporation sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10002-56) Cor val Corporation Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq janvier 1956, constituant en corporation: John McGlin-chey Home, C.B., avocat, de Westmount, Claude Wagner, avocat, de Ville St-Laurent et Enid Mary Roberts, secrétaire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Corval Corporation Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de $1,000,000, divisé en 1,000.000, d'actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à 44 Boulevard St-Joseph, Dorval, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.13Q51-55) C.Simmonds & Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq janvier 1950, constituant en corporation: Maurice Steinberg, avocat, Thomas Gavin, comptable, et France O'Dell Morrison, secrétaire, veuve, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de métaux et de tous leurs sous-produits, sous le nom de \"C.Simmonds & Company Limited\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 155 rue Wellington Nord, appartement 206, Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, le cinq janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.13421-55) Dominion Electrical Works Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1956, constituant en corpora- Bourlamaque) under the name of \"Comité Protecteur des Scouts de St-Sauveur, Val d'Or-Bourlamaque\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $40,000.The head office of the corporation will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of Januarv 1950.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10002-50) Corval Corporation Ltd.(No Personal Liability) \\Toticc is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1956, incorporating: John McGlinchcy Home, Q.C., lawyer, of West-mount, Claude Wagner, lawyer, of the town of St.Laurent, and Enid Mary Roberts, secretary, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Corval Corporation Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $1,000,000, divided into 1,000,000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at 44 St.Joseph Boulevard, Dorval, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13051-55) C.Simmonds & Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of January, 1956, incorporating: Maurice Steinberg, advocate, Thomas Gavin, accountant, and France O'Dell Morrison, secretary, widow, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in metals and all of their by-products, under the name of \"C.Simmonds & Company Limited\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 155 Wellington Street North, Apartment 200.Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13421-55) Dominion Electrical Works Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January, 1956, incorporating: Marcel QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol 88, No.9 857 Hon: Marcel Archambault, agent, Denise Poirier, sténographe, et Françoise Poirier, comptable, ces deux dernières filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneur-électricien et exploiter un commerce d'accessoires électriques et de meubles, sous le nom de \"Dominion Electrical Works Co.Limited\", avec un capital total de S 10,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1950.L'Assistant-p rocurcur généra 1, 41S88-0 C.E.CANTIN.(P.G.10032-56) Kastern Canada Construction Co.Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1956, constituant en corporation: Joseph Parisi, entrepreneur, Gabrielle Pari-si, ménagère, épouse séparée de biens dudit Joseph Parisi, et Philomène Parisi, sténographe, tous de Sainte-Foy, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Eastern Canada Construction Co.Ltd\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1956.L'Assistant-procureur général, \u2022Il 888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13590-55) E.Shcppard Fur Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze janvier 1956, constituant en corporation: Max S.Kaufman, Harriet Beutel, tencu-se de livres, tous deux de Westmount et Joseph H.Hoffman, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de fourrures, sous le nom de \"E.Sheppard Fur Mfg.Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune \u2022\u2022l 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatrpze janvier 1956.L'Assistant-procureur général, ¦11888 C.E.CANTIN.(P.G.10169-56) Fédération des Oeuvres Paroissiales de St-Pierre Apôtre de Longueuil Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit janvier 1956, constituant en corporation sans capital-actions: A^ndré Boisvert, commerçant, Alphonse Déry, entrepreneur, et Orner Archambault, agent, Denise Poirier, stenographer, and Françoise Poirier, accountant, the latter two of full age, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as electrical contractor and to deal in electrical accessories and in furniture, under the name of \"Dominion Electrical Works Co.Limited\", witlr a total capital stock of $40.000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of Januarv, 1950.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10032-50) Eastern Canada Construction Co.Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January, 1956, incorporating: Joseph Parisi, contractor, Gabrielle Parisi, housewife, wife separate as to property of the said Joseph Parisi, and Philomène Parisi, stenographer, all of Sainte-Foy, judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate as general contractors, under the name of \"Eastern Canada Construction Co.Ltd\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 shares of 8100 each.The head office of the company will be at.Sainte-Foy, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13590-55) E.Shcppard Fur Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of January, 1956, incorporating: Max S.Kaufman, Harriet Beutel, bookkeeper, both of Westmount, and Joseph II.Hoffman, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furs, under the name of \"E.Sheppard Fur Mfg.Co.Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.10109-56) Fédération des Oeuvres Paroissiales de St-Pierre Apôtre de Longueuil Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of January, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: André Boisvert, dealer, Alphonse Déry, contractor, and Omer Lalonde, 858 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 1.956, Tome 88, N° 9 Lalonde, chef de bureau, tous de Longueuil, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Coordonner, organiser et maintenir en existence les différentes œuvres paroissiales existant en la paroisse de Saint-Pierre Apôtre de Longueuil, sous le nom de \"Fédération des Oeuvres Paroissiales de St-Picrre Apôtre de Longueuil Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Longueuil, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.K.CANTIN.(P.O.13077-55) Fonderie Minette Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1955.constituant en corporation: Roland Binette, industriel.Jean-Marie Binette, contramaître.et André Trot tier, comptable agréé, tous de Laurierville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Exercer l'industrie de la fonderie et le commerce d'agent distributeur d'instruments aratoires et de machines agricoles, sous le nom de \"Fonderie Binette Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions,, ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Laurier-ville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13610-55) Gabriel Lucas Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenantrgouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf décembre 1955, constituant en corporation: Albert-Laurent Bissonnette, avocat, Lillian Viola Armstrong, et Cordelia Leclerc, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme bijoutiers et orfèvres, sous le nom de \"Gabriel Lucas Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1470, rue Sherbrooke, ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10117-56) Garmaise Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1956, constituant en corpora- office-manager, all of Longueuil, judicial district of Montreal, for the following purposes: To coordinate, organize and maintain in existence the different parochial works existing in the parish of Saint-Pierre Apôtre de Longueuil, under the name of \"Fédération des Oeuvres Paroissiales de St-Pierre Apôtre de Longueuil Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Longueuil, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 4188S Deputy Attorney General.(A.G.13077-55) Fonderie Binette Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December 1955, incorporating: Roland Binette, industrialist, Jean-Marie Binette, foreman, and André Trotticr, chartered accountant, all of Laurierville, judicial district of Arthabaska.for the following purposes: To carry on the trade of founding and the business of distributing agent for farm implements and agricultural machinery, under the name of \"Fonderie Binette Inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Laurierville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this, twenty-ninth day of December 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13010-55) Gabriel Lucas Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of December 1955, incorporating: Albert.Laurent Bissonnette, advocate, Lillian Viola Armstrong, and Cordelia Leclerc, secretaries, filles majeures, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of jewellers and goldsmiths, under the name of \"Gabriel Lucas Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 1470 Sherbrooke street, west, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of December 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10117-56) Garmaise Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, ftearing date the thirteenth day of January, 1956, incorporating: Mortimer QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol 88, No.9 859 lion: Mortimer Dolman, Maurice Jonathan Garmaisc, notaires et Avram II.Garmaisc, comptable agréé, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Garmaisc Holdings Inc.\".avec un capital\"total de S 10.000, divisé on 1.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1956.L'Assistant-procureur général, I1SS8 C.E.CANTIN.(P.G.10078-50)^ Geo.Martin Investments Corp.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1950, constituant en corporation: Georges Martin, Lionel Dupré, courtiers en immeubles, de Montréal, et Louis Leblanc, courtier en immeubles, de Laval-des-Rapides, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme compagnie de placements, sous le nom de \"Geo.Martin Investments Corp.Ltd.\".avec un capital total de 820,000.divisé en 2.000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1432, rue Aylwin, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 11SS8-0 C.E.CANTIN.(P.G.10031-50) Godin & Guyon Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze janvier 1950, constituant en corporation: Paul B.Godin, Armand Guyon, industriels, Antoinette Godin, épouse séparée de biens dudit Paul B.Godin, et Marie-Thérèse Guyon, épouse dudit Armand Guyon, tous de Saint-Raymond, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de bois ou matériaux de construction, sous le nom de \"Godin & Guyon Limitée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées' de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Raymond, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze janvier 1956.L'Assistant-procureur général, \u2022 41888-o C.E.CANTIN.(P.G.13676-55) Harvey & Racine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1956, constituant en corporation: Leslie Lawrence Harvey, marchand, J.-Antonio Racine, voyageur, et Fernand Morin, comptable, Dolman, Maurice Jonathan Garmaisc, notaries, and Avram H.Garmaisc, chartered accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Garmaise Holdings Inc.\", with a total capital sotkc of 810,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of Januarv, 1950.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.10078-56) Geo.Martin Investments Corp.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant -Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January 1956.incorporating: Georges Martin, Lionel Dupré, real estate brokers, of Montreal, Louis Leblanc, real estate broker, of Laval-des-Rapides, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as an investment company, under the name of \"Geo.Martin Investments Corp.Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 1432 Aylwin Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of January 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10031-50) Godin & Guyon Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of January, 1956, incorporating: Paul B.Godin, Armand Guyon, industrialists, Antoinette Godin, wife separate as to property of the said Paul B.Godin, and Marie-Thérèse Guvon, wife of the said Armand Guyon, all of Saint-Raymond, judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in wood or building materials, under the name of \"Godin & Guyon Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Raymond, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13676-55) Harvey & Racine Inc.Notice is hereby\" given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January 1956, incorporating: Leslie Lawrence Harvey, merchant, J.Antonio Racine, traveller, and Fernand Morin, accountant, all of Granby, 860 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 1956, Tome 88, N° 9 tous de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de meubles, appareils électriques et accessoires, sous le nom de \"Harvcv & Racine Inc.\", avec un capital total de $50,000.divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1956.L'Assistant-procureur général.41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10005-50) \u2022 Héroux, Thibodeau Automobile Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I>oi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze janvier 1950, constituant en corporation: Raoul Héroux, comptable, Armand Thibodeau, marchand, et Antoine Biron, avocat, tous de Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Exercer le commerce de véhicules automobiles, de leurs parties et accessoires, sous le nom de \"Héroux, Thibodeau Automobile Ltée\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 750 actions communes de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera Boulevard Bernard, Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13638-55) Highland Knitting Mills Inc.Avis-est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze janvier 1956, constituant en corporation: Hyman Kamichik, Nathan Bernstein, manufacturiers, Irving Buller, étudiant et Sureka Wasserman, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'habits et vêtements de sport tricotés, sous le nom de \"Highland Knitting Mills Inc.\", avec un capital total de $100.000, divisé en 50,000 actions ordinaires de $1 chacune et 50,000, actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 4188S CE.CANTIN.(P.G.13661-55) Hydro Stone Incorporated Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1956, constituant en corporation: Albert Rolbin, administrateur, Donald Kujan, étudiant, Leona Green, fille majeure, teneuse de livres et Michael Greenblatt, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: judicial district of Bedford, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture, electrical apparatus and accessories, under the name of \"Harvey & Racine Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Granby; judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January 1956.C.E; CANTIN, ¦I 1SSS Deputy Attorney General.(A.G.10005-50) Héroux, Thibodeau Automobile Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of January, 1950, incorporating: Raoul Héroux, accountant, Armand Thibodeau, merchant, and Antoine Biron, advocate, all of Drummondville.' judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To carry on a business dealing in motor vehicles, their spare-parts, and accessories, under the name of \"Héroux, Thibodeau Automobile Ltée\", with a total capital stock of $100,000.divided into 750 common shares of $100 each, and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Bernard Boulevard, Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888 ¦ Deputy Attorney General.(A.G.13638-55) Highland Knitting Mills Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of January.1956, incorporating: Hyman Kamichik.Nathan Bernstein, manufacturers, Irving Buller.student, and Sureka Wasserman.secretary, spinster of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: ¦ To manufacture and deal in knitted apparel and sportswear, under the name of \"Highland Knitting Mills Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 50,000 common shares of 81 each and into 50,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13661-55) Hydro Stone Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1956, incorporating: Albert Rolbin, executive, Donald Kujan, student, Leona Green, spinster, bookkeeper, and Michael Greenblatt.advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol 88, No.9 861 Exercer le commerce de grès, gravier, brique, matériaux de construction et de pavage, accessoires, unité et fournitures de quelque sorte et description que ce soit utilisés par les constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Hydro Stone Incorporated\", avec un capital total de 540,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.10129-56) Intercontinental Mines Ltd (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze janvier 1956, constituant en corporation: Lloyd H.Evaskewich, importateur, Emery Morin, ingénieur, Marius Doye, agent d'affaires, Nicolas Papason, gérant et George Rocket t, bourgeois, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: l'aire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Intercontinental Mines Ltd\" (No Personal Liability), avec un capital total de $4,000,000, divisé en 4,000,000 d'actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.11217-55) Italo-Canadian Social and Recreational Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois janvier 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Gentile Dieni, restaurateur, Aldo Fcrro, agent d'assurances, Pasquale Batista, entrepreneur retraité.Marco Buscio, barbier, Antonio Dermo, retraité et Guerino Giampirini, entrepreneur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir, organiser, diriger et administrer un club athlétique et social et promouvoir le bient-être de ses membres, sous le nom de \"Italo-Canadian Social and Recreational Association\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $50.000.Le siège social de la corporation sera à 209 rue Dante, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1956.L'Assistant-procureur général.41888 C.E.CANTIN.To deal in sandstone, gravel, brick, building and paving material, builders' and contractors' supplies, plant and accessories of whatsoever kind and description, under the name of \"Hydro Stone Incorporated\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 'common shares having a par value of $100 each and into 300 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1950.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.10129-50) Intercontinental Mines Ltd (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1950, incorporating: Lloyd R.Evaskewich, importer, Emery Morin, engineer, Marius Doye.business agent, Nicolas Papason, manager, and George Rockett, gentleman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Intercontinental Mines Ltd\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $4,000,000, divided into 4,000,000 shares of a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of Januarv, 1950.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.11217-55) halo-Canadian Social and Recreational Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of Januray, 1956, to incorporate as a corporation without share capital: Gentile Dieni, restaurateur, Aldo Ferro, Insurance Agent, Pasquale Batista, retired conctractor, Marco Buscio, barber, Antonio Dremo, retired, and Guerino Giampirini, contractor, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote, organize, conduct and manage an athletic and social club, and to promote the welfare of the members thereof, under the name of \"Italo-Canadian Social and Recreational Association\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may possess, is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at 209 Dante Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third date of Januarv, 1950.C.E.CANTIN, ^41S88-o Deputy Attorney General. 862 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 (P.G.13682-55) Jack Polansky Construction Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1956, constituant en corporation: Cyril E.Schwisberg, avocat, Sonya Scbneyer et Anne Zifkin, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de construction et d'immeubles, sous le nom de \"Jack Polansky Construction Co.Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200actions ordinaires de $100 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagniesera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1956.L'Assistant-procurcur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.13602-55) J.A.Marmen Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois janvier 1956, constituant en corporation: J.-Adéodat Marmen, Guy Marmen et Paul-André Marmen, tous marchands, de Chandler, district judiciaire de Gaspé, pour les objets suivants: Exeerccr le commerce de peinture, vernis, pigments, polis, huiles, quincaillerie, accessoires électriques, matériaux de construction, épicerie, farine, grains, provisions et lingerie, sous le nom de \"J.A.Marmen Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chandler, district judiciaire de Gaspé.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1956.L'Assistant-procu reur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13567-55) Joseph Tremblay Cartage Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois janvier 1956, constituant en corporation: Edward Tremblay, Adélard Tremblay, rouliers publics et Dora Finn Tremblay, ménagère, veuve de feu Joseph Tremblay en son vivant roulier public, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer, en général, le commerce de camionnage et de transport, sous le nom de \"Joseph Tremblay Cartage Co.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(A.G.13682-55) Jack Polansky Construction Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1956, incorporating: Cyril E.Schwisberg; advocate, Sonya Schneyer and Anne Zifkin, secretaries, filles majeures, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction and real estate company, under the name of \"Jack Polansky Construction Co.Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 200 common shares of $100 each and into2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of Januarv, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13602-55) J.A.Marmen Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January 1950, incorporating: J.-Adéodat Marmen, Guy Marmen and Paul-André Marmen.all merchants, of Chandler, judicial district of Gaspé, for the following purposes: To deal in paints, varnishes, pigments, polishes, oils, hardware, electrical appliances, building materials, groceries, flour, grain, provisions and lingerie, under the name of \"J.A.Marmen Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Chandler, judicial district of Gaspé.Dated at the office of the Attorney General, this third day of January, 1950.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13507-55) Joseph Tremblay Cartage Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of January, 1950, incorporating: Edward Tremblay, Adelard Tremblay, carters, and Dora Finn Tremblay, housewife, widow of the late Joseph Tremblay, in his liletime carter, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the business of trucking and transporting, under the name of \"Joseph Tremblay Cartage Co.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of Januarv, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 863 (P.G.13662-55) La Cie Dumas & Lamontagne, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du dix janvier 1956, constituant en corporation: Alfred Dumas, facteur, Françoise Lamontagne, secrétaire, et Maurice Lamontagne, notaire, tous de Saint-Félicien, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de quincaillerie, ferronnerie, matériaux de construction, sous le nom de \"La Cie Dumas & Lamontange, Ltée\", avec un capital total de §150,000, divisé en 1,200 actions communes de 8100 chacune et en 1,200 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera àChibou-gamau, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10100-50) La Compagnie J.A.Vachon Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur delà province de Québec, des lettres patentes, en date du trente décembre 1955, constituant en corporation: J.-Arthur Vachon, commerçant.Lucienne l'oulin Vachon, ménagère, épouse séparée de biens dudit J.-Arthur Vachon, et Jules-André Vachon, commerçant, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de vaisselle, de batteries et autres accessoires employés en cuisine, sous le nom de \"La Compagnie J.A.Vachon Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 335, rue St-Joseph, est, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13285-55) Lampron & Ferron Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du premier décembre 1955, constituant en corporation: Jacques Ferron.agent-distributeur, Fernand Lampron, industriel, et Estelle Therricn Lampron, épouse de Fernand Lampron, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce de liqueurs douces gazeuses, sous le nom de \"Lampron & Ferron Ltée\", avec un capital total de $49,000, divisé en 490 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cap-de-la-Madeleine, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(A.G.13662-55) La Cic Dumas & Lamontagne, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1950, incorporating: Alfred Dumas, postman, Françoise Lamontagne.secretary, and Maurice Lamontagne, notary, all of Saint-Félicien, judicial district of Roberval, for the following purposes: To operate a business dealing generally in hardware, ironware, building materials, under the name of \"La Cie Dumas & Lamontagne, Ltée\", with a total capital stock of $150,000, divided into 1,200 common shares of $100 each and into 1,200 preferred shares of $25 each.The head office of the Company will be at Chibougumau, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of Januarv, 1950.\" C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10100-50) La Compagnie J.A.Vachon Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December 1955, incorporating: J.-Arthur Vachon.merchant, Lucienne Poulin Vachon, housekeeper, wife separate as to property of the said J.-Arthur Vachon, and Jules-André Vachon, merchant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in plates and dishes, kitchen utensils and other cooking accessories, under the name of \"La Compagnie J.A.Vachon Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of a par value of $100 each and 100 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the Company will be at 335 St.Joseph Street, East, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13285-55) Lampion & Ferron Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December 1955, incorporating: Jacques Ferron, distributing agent, Fernand Lampron, industrialist, and Estelle Therrien Lampron, wife of Fernand Lampron, and duly authorized by him for the purposes herein, all of the city and judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To deal in sparkling soft drinks, under the name of \"Lampron & Ferron Ltée\", with a total capital stock of 849,000, divided into 490 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this first dav of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General. 864 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 1956, Tome 88, N° 9 (P.G.10040-56) L.C.Quenneville Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1956, constituant en corporation: Léo Colbert Quenneville, négociant, Yvonne Carrier Quenneville, ménagère, épouse séparée de biens dudit Léo Colbert Quenneville, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Paul Quenneville, vendeur à commission, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de la bière et du porter et tous autres produits connexes à ce commerce, sous le nom de \"L.C.Quenneville Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10081-50) Le Centre des Naturalistes de Québec Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze janvier 1950, constituant en corporation sans capital-actions.Charles-Antoine Ki-rouac, médecin, Raymond Cayouette, employé civil, de Charlesbourg, André Doyle, entomologiste, Jean Lcchevalier, professeur U.L., André Simard, é.e.pharmacie, Marcel Drolet, auteur, René Pomerleau, pathologiste, Lionel Boisseau, marchand, de Québec, Gérard Paquin, gérant d'assurances, de Charly, et René Béique, entomologiste, de Sainte-Foy, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Grouper les personnes qui s'intéressent aux sciences naturelles, sous le nom de \"Le Centre des Naturalistes de Québec\".Le montant auquel sont limités les biens imr mobiliers que la corporation peut posséder, est de $200,000.Le siège social de la corporation sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10019-50) Le Club de Canotage Radisson des Trois-Rivicres Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1956, constituant en corporation sans capital-actoins \"Le Club de Canotage Radisson des Trois-Rivières Inc.\", déjà constitué en corporation en vertu des dispositions de la Loi des clubs de récréation, le ou vers le 18 mai 1934, pour les objets suivants: Former un cercle dans un but de récréation et d'instruction pour l'esprt et de délassement pour le corps.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers de la corporation est de $250,000.(A.G.10040-56) L.C.Quenneville Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1956, incorporating: Léo Colbert Quenneville, dealer, Yvonne Carrier Quenneville, housewife, wife separate as to property of the said Léo Colbert Quenneville, and duly authorized by him for the purposes herein, and Paul Quenneville, salesman on commission, all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on the business of beer and porter and all other products connected therewith, under the name of \"L.C.Quenneville Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1950.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10081-50) Le Centre des Naturalistes de Québec Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of January, 1956.to incorporate as a corporation without share capital: Charles-Antoine Kirouae, physician, Raymond Caouette, civil employee, of Charlesbourg, André Doyle, cntomologisl.Jean Lechevalier, professor L.U., André Simard, e.e.pharmacy, Marcel Drolet, author, René Pomerleau, pathologist, Lionel Boisseau, merchant, of Quebec, Géard Paquin, manager in insurance, of Charny, and René Béique, entomoligist, of Sainte-Foy, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To group people who are interested in natural science under the name of \"Lc Centre des Naturalistes de Québec\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $200,000.The head office of the corporation will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10019-56) Le Club de Canotage Radisson des Trois-Rivibres Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1956.to incorporate as a corporation without share capital: \"Le Club de Canotage Radisson des Trois-Rivières Inc.\", ahead incorporated under the provisions of the Amusement Clubs Act, on or about May 18, 1934, for the following purposes: To form a circle for recreational and educational purposes and the relaxation of mind and body.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $250,000. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 865 Le siège social de la corporation est situé en la cité des Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10008-56) Le Comité d'Embellissement de St-Jérôme Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1956, constituant en corporation sans capital-actions: Maurice Kirouac, ingénieur forestier, Paul Simard, gérant de la Caisse Populaire, et Albert Métivier, instituteur, tous de Saint-Jérôme, district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Promouvoir l'embellissement selon les règles de l'art et du bon goût dans les municipalités du village et de la paroisse de Saint-Jérôme du Lac St-Jean, sous le nom de \"Le Comité d'Embellissement de St-Jérôme Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $10,000.Le siègee social de la corporation sera à Saint-Jérôme, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 4188S-0 .C.E.CANTIN.(P.G.10095-56) Le Moyne Ungava Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1950, constituant en corporation: Claire Miquc-lon, secrétaire, fille majeure, de Beauport, Charlotte Risi, secrétaire, fille majeure, André Gagnon, avocat, de Sillery, Claude Gagnon, avocat et Henriette Pouliot, secrétaire, fille majeure, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Le Moyne Ungava Mines Limited\" (No Personal Liability), avec un capital total de $5,003,000, divisé en 5,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.13696-55) Les Agences ('ara, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1955, constituant en corpo- The head office of the corporation will be at in the city of Trois-Rivières judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10008-56) Le Comité d'Embellissement de St-Jérôme Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January.1956 to incorporate as a corporation without share capital: Maurice Kirouac.forestry-engineer, Paul Simard, manager for the Caisse-Populaire, and Albert Métivier, teacher, all of Saint-Jérôme, judicial district of Roberval, for the following purposes: To promote the embellishment, in accordance with the rules of art and good taste, in the municipalities of the village and of the parish of Saint-Jérôme of Lake St.John, under the name of \"Le Comité d'Embellissement de St-Jérôme Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation mav hold is to be limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at Saint-Jérôme, judicial district of Roberval.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of Januarv.1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10095-50) Le Moyne Ungava Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January, 1956, incorporating: Claire Miquelon, secretary, spinster, of Beauport, Charlotte Risi, secretary, spinster, André Gagnon, advocate, of Sillery, Claude Gagnon, advocate, and Henrittte Pouliot, secretary, spinster, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Le Moyne Ungava Mines Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $5,000,000, divided into 5,000,000 shares of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January, 1950.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13090-55) Les Agences Cara, Ltée ' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December 1955, incorporating: Jacques de 866 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 ration: Jacques de Billy, c.r., avocat, de Lévis, Gilles de Billy, avocat, de Sillery, et Charlotte Risi, secrétaire, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de machinerie, équipement, réfrigérateurs, accessoires électriques, moteurs et de marchandises s'y rapportant; agir comme agents pour tout manufacturier, producteur, fabricant de produits et articles de métal, papier, cuir, bois, caoutchouc, porcelaine, plastique, tous produits cosmétiques, textiles, comestibles, matériaux de construction, diamants, bijoux, montres, sous le nom de \"Les Agences Cara, Ltée\".avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lévis, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 4188S-0 C.E.CANTIN.(P.G.10102-50) Les Fourrures Chinchilla Ltée (Chinchilla Furs Limited) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze janvier 1956, constituant en corporation: Laurent Molini, René Thomas, entrepreneurs, des cité et district judiciaire de Montréal, et Guy Blanchard, notaire, de Sainte-Thérèse, district district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Faire l'élevage et exercer le commerce de chinchillas et toutes espèces d'animaux à fourrure, sous le nom de \"Les Fourrures Chinchilla Ltée (Chinchilla Furs Limited)\", avec un capital total de $100.000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Rose, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1950.L'Assi st an t -p rocu reu r général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13434-55) Les Placements Modèles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trente décembre 1955, constituant en corporation: Emé Lacroix, C.R., avocat, de Ville Mont-Royal, Armand Poupart, fils, avocat, et Monique Couture, secrétaire, célibataire majeure, ces deux derniers de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; faire affaires comme entrepreneur général et constructeur; agir comme agent, vendeur et courtier en valeurs de placement, sous le nom de \"Les Placements Modèles Inc.\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.Billy, Q.C., advocate, of Levis, Gilles de Billy, advocate, of Sillery, and Charlotte Risi, secretary, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in machinery, equipment, refrigerators, electrical appliances, motors and merchandises connected therewith; act as agents for any manufacturer, producer, maker of products, and articles in metal, paper, leather, wood, rubber, china all cosmetic, textile and edible products, building materials, diamonds, jewellery, watches, under the name of \"Les Agences Cara, Ltée, with a total capital stock of 820,000, divided into 200 shares of S100 each.The head office of the Company will be ;ii Levis, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December 1955.C.E.CANTIN.11 Sss Deputy Attorney General.(A.G.10102-50) Les Fourrures Chinchilla Ltée (Chinchilla Furs Limited) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January 1950, incorporating: Laurent Molini, René Thomas, contractors, of the city and judicial district of Montreal, and Guy Blan-chand, notary, of Saint Thérèse, judicialdistricl of Terrebonne, for the following purposes: To carry on the business of and deal in Chinchillas and fur-bearing animals of every nature and kind, under the name of \"Les Fourrures Chinchilla Ltée (Chinclilla Furs Limited\"), with a total capital stock of 8100,000, divided into 1.000 shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Saint Rose, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of January 1950.C.E.CANTIN.41888 Deputy Attorney Genera 1.(A.G.13434-55) Les Placements Modèles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, hearing date the thirtieth day of December 1955, incorporating: Emé Lacroix, Q.C., advocate, of the town of Mount Royal, Armand Poupart, jr.advocate, and Monique Couture, secretary, unmarried having rae-ched the age of majority, the two latter of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate; to carry on business as general contractor and builder; act as investment agent, salesman ami broker, under the name of \"Les Placements Modèles Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 common shares of a par value of S10 each and 900 preferred shares of a par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.\u2022 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 867 (P.G.13551-55) Loignon Transport Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première par-lie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze janvier 1956, constituant en corporation: Gabriel Loignon, Paul Lanthier, Claude Mongrain, camionneurs, et Rita Rocheleau.ménagère, épouse commune en biens de Gabriel Loignon et dûment autorisée per ce dernier aux lins des présentes, tous des cité et district judiciaire ae Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de transport de marchandises, sous le nom de \"Loignon Transport Ltée\", avec un capital total de $25,000, divisé en 2,500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 418SS-0 C.E.CANTIN.(P.G.10110-56) Louis Quilicot & Cie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept janvier 1950, constituant en corporal ion: Louis Quilicot, marchand, Edo Farnesi, commis, et Paul-Henri Lafleur, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, poulies objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'articles de sport ; tenir une maison de chambres et louer lesdites chambres à la journée où à la semaine, sous le nom de \"Louis Quilicot & Cie Ltée\", avec un capital total de $60,000, divisé en 000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.10122-56) Ludovic Montpctit Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze janvier 1956, constituant en corporation: Ludovic Montpctit, vendeur autorisé, de Melocheville, Jean-Paul Cossette et Lionel Cossette, avocats, de Salabcrry-dc-Valleyficld, tous du district judiciaire* de Beauharnois, pour les objets suivants: Exercer le commerce de véhicules automobiles, de leurs parties et accessoiers: exploiter et gérer des garages, sous le nom de \"Ludovic Montpctit Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Salaber-i.-de-Valleyfield, district judiciaire de Beauhar-nois.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41S88-0 C.E.CANTIN.(A.G.13551-55) Loignon Transport Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of January, 1956, incorporating: Gabriel Loignon, Paul Lanthier, Claude Mongrain, trucksters, and Rita Rochcleau, housewife, wife common as to property of Gabriel Loignon and duly authorized by the latter for these present purposes, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a carrying company dealing with merchandise, under the name of \"Loignon Transport Ltée\".with a total capital stock of $25,000.divided into 2,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of Januarv.1956.CE.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.10110-50) Louis Quilicot & Cie Ltée Notice is hereby given that under Past I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of January, 1956, incorporating: Louis Quilicot, merchant, Edo Farnesi, clerk, and Paul-Henri Leflciir.accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in articles of sport; to keep a rooming-house and rent rooms by the day or week, under the name of \"Louis Quilicot & Cie Ltée\".with a total capital stock of $00.000, divided into 000 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of Januarv, 1950.C.E.CANTIN, 41888 .Deputy Attorney General.(A.G.10122-56) Ludovic Montpctit Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of January, 1956, incorporating: Ludovic Montpctit, authorized salesman, of Melocheville.Jean-Paul Cossette and Lionel Cossette, advocates, of Salaberry-de-Valleyfield, all of the judicial district of Beauharnois, for the following purposes: To operate a business dealing in motor vehicles, their spare parts and accessories; to operate and manage garages, under the name of \"Ludovic Montpctit Inc.\", with a total capital stock of $50.000, divided into 500 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Salabcrry-dc-Vallcyfield, judicial district of Beauharnois.Dated at the oflice of the Attorney General, this fourteenth dav of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General. SfiS GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 8 mars 1966, Tome 88, N° 9 (P.G.13524-55) L'Union Commerciale Mauricienne Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province f the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in wool, cotton fabrics, woollens, silks, linens anc clothing, under the.name of \"Penny Wise Sportswear Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares having a par value of 8100 each ami into 300 preferred shares having a par value of S100 each.The head office -of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13517-55) Pizzagalli Terrazzo Tile & Marble Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of December, 1955, incorporating: Angelino Pizzagalli, contractor.François Leblanc, accountant, both of Outremont, Henri Valade, bookkeeper, of St.Laurent, Pio Cobetto, superintendant, Raymond Champagne, asst.superintendant, Bernard DeSerre, estimator, of Montreal, and Peter Short eno, advocate, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the businesses of general contractors and builders; to operate terrazzo and marble quarries and deal in building materials, supplies and equipment, under the name of \"Pizzagalli Terrazzo Tile & Marble Inc.\", with a total capital stock of $300,000, divided into 50,000 common shares of $1 each and into 2,500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 105 Jean Talon St.West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.13603-55) P.Laporta Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth 872 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 1956, Tome 88, N° 9 du quatorze janvier 1956, constituant en corporation: Albert Malouf, Peter Shortcno, avocats et Lily Malouf, secrétaire, fille majeure, tous de ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des terrains ou des intérêts en iceux; construire, transformer et entretenir des propriétés; négocier des biens fonciers et des propriétés immobilières, sous le nom de \"P.Laporta Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5155 avenue Park, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze janvier 195G.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.10010-56) Queen Chibougamau Mines Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre janvier 1956, constituant en corporation: Philip Joseph, Rowan Joseph, tous deux administrateurs, Mcrvin Aizer, gérant, Donald Kujan, avocat et Lcona Green, teneuse de livres, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Queen Chibougamau Mines Ltd.\" (No Personal Liability), avec un capital total de $4,000,000, divisé en 4,000,000 d'actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront, aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.10038-56) Renée Galland Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix janvier 1956, constituant en corporation: Renée Zoë Van Cauwenberghe, chanteuse, mariée en séparation de biens avec I^éo Forgeron, Gérard Léveillé, représentant commercial, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, Edouard Guay, marchand et Gabrielle Lussier, secrétaire, tous deux des cité et district judiciaire de St-Hyacinthe, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de produits de beauté, nécessaires de toilette et produits semblables, sous le nom de \"Renée Galland Ltée\", avec un capital total de $40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.day of January, 1956, incorporating: Albert Malouf, Peter Shorteno, advocates, and Lily Malouf, secretary, spinster of the full age of majority, all of the town of Mount Royal, judicial district of Montreal, for the following purposes : To acquire lands or interests therein; to construct, alter and maintain properties; to deal in real estate and immovable property, under the name of \"P.Laporta Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of .the company will be at 5155 Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.10010-50) Queen Chibougamau Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of January, 1956, incorporating: Philip Joseph, Rowan Joseph, both executives, Mervin Aizcr, manager, Donald Kujan, advocate, and Lcona Green, bookkeeper, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Queen Chibougamau Mines Ltd.\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $4,000,000.divided into 4,001,000 shares having a par value of $1 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.10038-56) Renée Galland Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of January, 1956, incorporating: Renée Zoë Van Cauwenberghe, singer, married, separate as to property of Léo Forgeron, Gérard Léveillé, commercial representative, both of the city and judicial district of Montreal, Edouard Guay.merchant, and Gabrielle Lussier, secretary both of the city and judicial district of St.Hyacinthe, for the following purposes: To manufacture and deal in beauty products, toilet requisites and similar products, under the name of \"Renée Galland Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 873 (P.G.10023-56) Richelieu Petroleum Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze janvier 1956, constituant en corporation : Madeleine L.Normandcau, secrétaire, fille majeure, Albert Noël, notaire, Jean Paul Verscbel-den, conseil en loi de la Reine, Maurice Denis Godbout et Joseph Edward O.Brien, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général d'un marchand, commerçant et distributeur d'huile, combustible, lubrifiants, engrais et désinfectants liquides, sous le nom de \"Richelieu Petroleum Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Otterburn Heights, district judiciaire de St-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le onze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.10116-56) Roger Bureau Ltée Roger Bureau Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1956, constituant en corporation: Roger Bureau, diamantaire, Roger Sabourin, comptable, tous deux des cité et district judiciaire de Montréal, et Paul Lemieux, entrepreneur, de Saint-Eustache-sur-le-Lac, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de bisous le nom de \"Roger Bureau Ltée \u2014 Roger bureau Ltd\", avec un capital total de $100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie srea 5018, rue Papineau, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13232-55) Ross-Ellis Development Corporation Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1956, constituant en corporation: Kenneth Charles Mackay, avocat, de Westmount, Robert Charles Legge, avocat, de Ville Mont-Royal et Murray Churchill Magor, avocat, de la ville de Dorval, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles; ériger des bâtisses et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Ross-Ellis Development Corporation Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1009 rue côté, Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.10023-50) Richelieu Petroleum Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of January, 1950, incorporating: Madeleine L.Normandeau, secretary, spinster, Albert Noël, Notary, Jean-Paul Verschelden, Queen's Counsel, Maurice Denis Godbout and Joseph Edward O'Brien, lawyers, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a wholesale and retail merchant, dealer and distributor generally in oil, fuel, lubricants, liquid fertilizers and liquid disinfectants, under the name of \"Richelieu Petroleum Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Otterburn Heights, judicial district of St.Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of January, 1950.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.10110-50) Roger Bureau Liée Roger Bureau Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Licuetnant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January 1950, incorporating: Roger Bureau, diamond cutter, Roger Sabourin, accountant, both of the city and judicial district of Montreal, and Paul Lemieux, contractor, of Saint Eustache-sur-le-Lac, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To manufacture and deal in jewellery, under the name of \"Roger Bureau Ltée \u2014 Roger Bureau Ltd\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at 5018 Papineau Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of January 1956.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13232-55) Ross-Ellis Development Corporation Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January, 1956, incorporating: Kenneth Charles Mackay, advocate, of Westmount, Robert Charles Legge, advocate, of the town of Mount Royal, and Murray Churchill Magor, advocate, of the town of Dorval, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate; to erect buildings and deal in building materials, under the name of \"Ross-Ellis Development Corporation Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,500 common shares of a par value of $10 each and into 150 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 1009 Côte Street, Montreal, judicial district of Montreal. 874 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888 C.E.CANTIN.(P.G.10015-56) Rouleau Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze janvier 1956, constituant en corporation: Roland G.Lefrançois, Jean Goulet, avocats, et Pavdette Panneton, secrétaire, épouse majeure séparée de biens de Paul Panneton, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneur général, constructeur et couvreur, sous le nom de \"Rouleau Construction Inc.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10chacune.Le siège social de la compagnie sera en la municipalité de la paroisse de Laprairie, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13435-55) R.P.Vézina Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize janvier 1956.constituant en corporation: Jacques Perrault, avocat et docteur en droit.d'Outremont, Raymond G.Decary et Charles A.Lussier, avocats, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: ' Exercer le commerce de la bijouterie comme grossiste et détaillant, sous le nom de \"R.P.Vézina Limitée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur nu pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize janvier 1950.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13059-55) Siklos Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du vingt-neuf 'décembre 1955, constituant en corporation: Max Slapack, avocat, de Côte St-Luc, Gregory Charlap, avocat, Harry Closner, gérant de crédit et Sylvia Teitlebaum, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de métaux et leurs composés; exercer le commerce, dans toutes ses spécialités, de la fabrication d'articles devant être utilisés à des fins de publicité ou d'étalage, sous le nom de \"Siklos Products Ltd.\", avec un capital total de $40,000, diviséen Dated at the office of the Attorney Genera], this thirteenth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41888-0 Deputy Attorney General.(A.G.10015-56) Rouleau Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of January, 1950, incorporating: Roland G.Lefrançois, Jean Goulct.advocates, and Paulette Panneton, secretary, wife, separate as to property of Paul Panneton, and duly authorized by him for these present purposes, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractor, builder and roofer, under the name of \"Rouleau Construction Inc.\", with a total capital stock of $10.000, divided into 1.000 shares of $10 each.The head office of the company will he in the municipality of the parish of Laprairie.judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January.1950.C.E.CANTIN.41888 Deputy Attorney General.(A.G.13435-55) R.P.Vézina Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of January, 1950.incorporating: Jacques Perrault, advocate ami doctor at-Law, of Outre-mount, Raymond G.Decary and Charles A.Lussier.advocates, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes : To operate a wholesale and retail jewellery business under the name of \"R.P.Vézina Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a par value of Slim each and into 200 preferred shares of a.par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of January.1950.C.E.CANTIN.41888 Deputy Attorney General.;;.changeant son nom en celui de \"Immeubles Imperial Cie Ltée \u2014 Imperial Realties Co.Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1955.L'Assistant-procureur général, $8-o C, E.CANTIN.(P.G.13408-55) Imprimerie Bourguignon Limitée Bourguignon Printing: Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quatorze décembre 1955, à la compagnie \"Imprimerie Bourguignon Limi- Bourguignon Printing Limited\", augmentant son capital de $20,000 à $95.000: le capital-actions additionnel étant divisé en 750 actions privilégiées île $100.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze décembre 1955.L'Assistant-procureur général.U888-0 ('.E.CANTIN.P.G.13094-55) Larochelle X Frères Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première i tie de la Loi des compagnies de Québec, il a '\u2022lé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la 10 1945: a) changing its name to that of \"Fano Mining & Exploration Inc.\" (No Personal Liability; b) increasing its capital from the sum of $3.000,000 to $5.000.000: the additional share capital being divided into 2,000,000 shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General, this thritieth dav of December 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13620-55) Fontmiu Mines (1913) Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining Companies' Act and Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the thirtieth day of December 1955, to the company \"Fontana Mines (1945) Limited\" (No Personal Liability), increasing its capital from the sum of $3,500,000 to $5.000,000: the additional share capital being divided into 1,500.000 shares of $1 each.Dated at.the office of the Attorney General, this thirtieth dav of December 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13340-55) Immeubles Imperial Cie Ltée Imperial Realties Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issue I by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the sixth day of December 1955, to the company \"Immeubles Imperial Compagnie Limitée\" incorpora?ted under said Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent dated October 28, 1953, changing its name to that of \"Immeubles Imperial Cie Ltée \u2014 Imperial Realties Co.Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of December 1955.C.E.CANTIN.4 1SSS Deputy Attorney General.(A.G.13408-55) Imprimerie Bourguignon Limitée Bourguignon Printing Limited Notice is hereby given thai under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province f Quebec, dated the fourteenth day of December 1955.t the company \"Imprimerie Bourguignon Limitée \u2014 Bourguignon Printing Limited1', increasing its capital from the sum of $20,000 t $95,000: the additional share capital being divided into 750 preferred shares of $100.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of December 1955.C.E.CANTIN.11888 Deputy Attorney General.(A.G.13094-55) Larochelle & Frères Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant- 882 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 195G, Tome 88, N° 9 province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du treize décembre 1955, à la compagnie \"Larochelle & Frères Ltée\", augmentant son capital de 850,000 à $150,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000 actions privilégiées de $100.Daté du bureau du Procureur général, le treize décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.12058-55) Lévis Mushroom Farm Inc.Ferme de Champignons de Lévis Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du douze décembre 1955, à la compagnie \"Lévis Mushroom Farm Inc.\u2014 Ferme de Champignons de Lévis Inc.\", a) réduisant son capital de $100.000 à $10,000: le capital-actions annulé étant divisé en 900 actions ordinaires de $100; b) augmentant le capital ainsi réduit de $10.000 à $100,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 900 actions privilégiées de $100.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.e.CANTIN.(P.G.13150-55) Lorric Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix janvier 1956, à la compagnie \"Bonville Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 21 mars 1955, sous le nom originaire de \"Fern's Fashions Inc.\", et par lettres patentes supplémentaires du 15 décembre 1955, changeant ledit nom originaire en celui ci-haut mentionné de \"Bonville Inc.\", changeant de nouveau son nom en celui de \"Lorrie Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le dix janvier 1956.L'Assistant-procureur général, 41888-q C.e.CANTIN.(P.G.6977-53) Métropole Parking Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du quinze décembre 1955, à la compagnie \"Show-Mart Parking Inc.\u2014 Stationnement du Palais du Commerce Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 15 avril 1953, changeant son nom en celui de \"Métropole Parking Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.e.CANTIN.Governor of the Province of Quebec, dated December thirteenth, 1955.to the company \"Larochelle & Frères Ltée\" increasing its capital stock from $50,000 to $150,000: the additional capital stock being divided into 1,000 preferred shares of $100.Dated at the office of the Attorney General, tins thirteenth day of December, 1955.C.e.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.12058-55) Levis Mushroom Farm Inc.Ferme de Champignons de Levis Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December twelfth, 1955, to the company \"Levis Mushroom Farm Inc.\u2014 Ferine de Champignons de Levis Inc.\", a) reducing its capital stock from $100,000 to $10,000: the cancelled capital stock being divided into 900 common shares of $100; b) increasing the capital thus reduced from $10,000 to $100,000: the additional capital stock being divided into 900 preferred shares of $100.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13150-55) Lorrie Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of January 1956, to the company \"Bonville Inc.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent March 21, 1955, under the original name of \"Fern's Fashions Inc.\", and by supplementary letters patent dated December 15, 1955, changing the said original name to that mentioned hereinabove of \"Bonville Inc.\", once again changing its name to that of \"Lorrie Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of January 1956.C, e.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.6977-53) Métropole Parking Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December , fifteenth, 1955, to the company \"Show-Mart Parking Inc.\u2014 Stationnement du Palais du Commerce Inc.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of April 15, 1953, changing its name into that of \"Métropole Parking Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December.1955.C.e.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1950, Vol.88, No.9 883 (P;G.11382-54) Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du six décembre 1955, à la compagnie \"Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.\", augmentant son capital de $12,000 à 82,012,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 20.000 actions privilégiées de $100.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 .('.E.CANTIN.(P.G.13328-55) Morissel Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du six décembre 1955, à la compagnie \"Morisset Limitée\", a) réduisant son capital de $49,000 à $30,000: le capital-actions annulé étant divisé en 190 actions privilégiées de $100; b) augmentant le capital ainsi réduit de 830,000 à $155,000: le capital-actions additionnée étant divisé en 25,000 actions privilégiées de $5.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.12104-55) Mortgage and Discount Corporation of Canada Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du six décembre 1955, à la compagnie \"Mortgage and Discount Corporation of Canada\", réduisant son capital: le capital-actions annulé étant divisé en 2,240 actions privilégiées de $5.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13155-55) Mount Bruno Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trois décembre 1955, à la compagnie \"H.H.Farley & Co.Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 20 juillet 1955, changeant son nom en celui de \"Mount Bruno Realties Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(A.G.11382-54) Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December sixth, 1955, to the company \"Montreal Construction Supply & Equipment Ltd.\", increasing its capital stock from $12,000 to $2,012,-000: the additional capital stock being divided into 20,000 preferred shares of $100.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13328-55) Morisset Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December sixth, 1955, to the company \"Morisset Limitée\" a) reducing its capital stock from $49,-000 to $30,000: the cancelled capital stock being divided into 190 preferred shares of $100; b) increasing the capital stock this reduced from $30,000 to $155,000: the additional capital stock being divided into 25,000 preferred shares of $5.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1955.C.E.CANTLN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.12104-55) Mortgage and Discount Corporation of Canada Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December sixth, 1955, to the company \"Mortgage and Discount Corporation of Canada\", reducing its capital stock: the cancelled capital stock being divided into 2,240 preferred shares of $5.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13155-55) Mount Bruno Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the third day of December 1955, to the company \"H.H.Farley & Co.Inc.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated July 20, 1955, changing its name to that of \"Mount Bruno Realties Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, this third day of December 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General. 884 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 (P.G.10138-55) Nsu of Cunadu \\.u\\.Avis est donné qu'on vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix décembre 1955, à la compagnie \"Nsu of Canada Ltd.\", augmentant son capital de $109,000 à 8200,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000 actions privilégiées de $100.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le dix «lécembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13198-55) Sagucnuy Power Company, Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la provir.ee «le Québec des lettres patentes supplémentaires, en w«-r Company, Ltd.\", réduisant son capital: le capital-actions annulé étant divisé eu 50,000 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf décembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13118-55) Sol Heitner & Sons Incorporated Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date «lu six décembre 1955, à la compagnie \"Sol Heitner & Sons Incorporated\", augmentant son capital de $15,01)0 à 855.000: le capital-actions additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées «le $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1955.L'Assistant-procureur général.4188S-0 C.E.CANTIN.(P.G.13172-55) S.W.llowarth Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du prendre décembre 1955, à la compagnie \"S.VY.Howàrth Limited\", augmentant sou capital «le 83.000 à $53,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 500 actions privilégiées de 8100 chacune.Daté du bureau «lu Procureur général, le premier décembre 1955.L'Assistant-procureur général.4IS88-0 C.E.CANTIN'.(P.G.13370-55) The Ar?ny and Navy Veterans, Quebec Unit No 33, Building Association Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes supplémentaires, en date «lu cinq décembre 1955.à la (A.G.10138-55) Nsu of Canada Ltd.Notice is hereby given that under Part I of »lic Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of December 1955, to the company \"Nsu of Canada Ltd.\", increasing its capital from the sum of 8100,000 to $200,000: the additional share capital being divided into 1.000 preferred shares of $100.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13198-55) Saguenay Power Company, Ltd.Notice is'hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the nineteenth day of December 1955, to the company \"Saguenay Power Company, Ltd.\", decreasing its capital: the cancelled share capital being divided into 50.000 \\%% preferred shares «>f $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth dav of December 1955.C.E.CANTIN.41888 Deputy Attorney General.(A.G.13118-55) Sol Ileitner & Sons Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, «lated December sixth, 1955, to the company \"Sol Ileitner & Sons Incorporated\", increasing its capital Stock from 815.000 to 855.000: the additional capital stock being divided into 400 preferred shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of December, 1955.C.E.CANTIN.41888 Deputy Attorney General (A.G.13172-55) S.W .Ilowarlh Limited Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Liculcn nt-Governor «>)' the Province of Quebec, dated the first day of December 1955.to the company \"S.W.Howarth Limited\", increasing its capital from the sum of $3,000 to $53,000: the additional share capital being divided into 500 pref« rrcd shares of SI00 each.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December 1955.C.E.CANTIN.11888 .I )eputy Attorney Genen (A.G.13376-55) The Army ami Navy Veterans, Quebec Unit No 33, Building Association Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December fifth, 1955, to the corporation \"The Army QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.March Srd, 1056, Vol.88, No.9 885 corporation \"The Army and Navy Veterans, Quebec Unit N° 33, Building Association Inc.\", augmentant le montant des biens immobiliers que telle corporation peut accéquérir et posséder de $500,000 à S2.000.000.Date du bureau du Procureur général, le cinq décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.12973-55) The Gartside Co.Ltd.Avis est dénué qu'en vertu de la première partie de In Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes supplémentaires, en date du «lix décembre 1955, à la compagnie \"The Gartside Supply Company Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 22 août 1949, changeant son nom en celui de \"The Gartside Co.Ltd.\".Daté du bureau «lu Procureur général, le dix décembre 1955.L'Assistant-procureur général.41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13599-55) Three Star Film Inc.Les Films Trois Étoiles Inc.' Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-trois décembre 1955.à la compagnie \"Three Star Films Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 26 avril 1954.sous le nom originaire de \"Les Publications Excel Ltée\", et par lettres patentes supplémentaires du 14 mars 1955, changeant, inter alia, le«lit nom originaire en celui de \"Three Star Films Inc.\", ti) changeant de nouveau son nom en celui «le \"Three Star Film Inc.\u2014 Les Films Trois Étoiles J ne\"; b) augmentant son capital de S 100.000 à £500,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 2,500 actions ordinaires «le §10 et en 375.000 actions privilégiées de SI.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-trois décembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(P.G.13309-55) Vistarchi Building Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du douze décembre 1955.à la compagnie \"Vistarchi Building Corporation\", augmentant son capital de S 19.900 à $51.9,900: le capital-actions additionnel étant divisé en 5.000 actions privilégiées de $100.Daté «lu bureau du Procureur général, le douze décembre 1955.L'Assistant-procureur général.' 11888-0 C.E.CANTIN.and Navy Veterans, Quebec Unit No.33, Building Association Inc.\", increasing the amount of the immoveable property that said corporation may acquire an«l own from $.500,000 to $2,000,000.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.12973-55) The Gartside Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of September 1955, to the company \"The (iartside Supply Company Limited\", incorporated mxlcr said Part.1 of the Quebec Companies' Act, by letters patent date»! August 22, 1949, changing its name to that of \"The (iartside Co.Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13599-55) Three Star Film Inc.Les Filins Trois Etoiles Inc.v Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December twenty-third, 1955, to the company \"Three Star Films Inc.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of April 26, 1954, under the original name of \"Les Publicaticns Excel Ltée\", and by supplementary letters patent of March 14, 1955, changing, inter alia, the said original name into that of \"Three Star Films Inc.\", a) again changing its name into that of \"Three Star-Film Inc.\u2014 Les Films Trois Étoiles Inc.\"; b) increasing its capital stock from $100,000 to $500.000: the additional capital stock being divided into 2,500 common shares of $10 and into 375,000 preferred shares of $1.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-third day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.(A.G.13309-55) Vistarchi Building Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated December twelfth, 1955, to the company \"Vistarchi Building Corporation\", increasing its capital stock from $19,900 to $519.900: the additional capital stock being divided into 5,000 preferred shares of $100.jtf Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General. 886 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 1956, Tome 88, A'° 9 (P.G.13581-55) Weedon Pyrite & Copper Corporation Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du trente décembre 1955, à la compagnie \"Weedon Pyrite & Copper Corporation Limited\" (No Personal Liability), augmentant son capital de 84,000,000 à 85,000,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000,-000 actions de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le trente décembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41888-0 C.E.CANTIN.(A.G.13581-55) Weedon Pyrite & Copper Corporation Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining Companies' Act, and Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Govenor of the Province of Quebec, dated the thirtieth day of December 1955, to the company \"Weedon Pyrite & Copper Corporation Limited\" (No Personal Liability), increasing its capital from the sum of 84.000,000 to 85,000.000: the additional share capital being divided into 1,000,000 shares of 81 each.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth day of December 1955.C.E.CANTIN, 41888 Deputy Attorney General.Action en séparation de biens Canada province de Québec, district de Montréal, cour Supérieure N° 390,032.Thérèse Moricr, épouse commune en biens de Roger Lamoureux, vendeur, tous deux des cité et district de Montréal, demanderesse vs Roger Lamoureux, vendeur, des cité et district de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été instituée en cette cause le 22èmc jour de février 1950.Montréal, le 23 février 1956.Les Procureurs de la demanderesse, LACHANCE, BOISVERT & CUTLER, 41913-Ô 4 Est, rue Notre-Dame, Montréal.Avis divers AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que le conseil de la municipalité du village de Maniwaki s'adressera au Lieutenant-Gouverneur en conseil, pour demander l'érection du territoire de la municipalité du village de Maniwaki en municipalité de ville, sous l'empire de la Loi des Cités et Villes, sous le nom de la municipalité de la ville de Maniwaki.Ledit territoire, ayant une population de 6,327 personnes, est borné comme suit, à savoir: Au Nord-ouest par la rivière de l'Aigle; à l'ouest par le comté de Pontiac, au sud par le canton de Bouchettc; à l'est par la rivière Gati-neau; au nord-est par la rivière Désert, avec en plus: Un territoire situé dans le canton d'Egan, comprenant en référence au cadastre officiel dudit canton, tous les lots, parties de lots et leurs subdivisions présentes et à venir, ainsi que tous les chemins, rues, ruelles, rivières, cours d'eau ou partie d'iceux, compris dans les limites suivantes, à savoir: Partant du coin d'intersection de la rive Nord du lac Gilmour avec la ligne separative des lots 4 et 5 du rang A; delà, passant par les lignes et démarcations suivantes en continuité des unes des autres: ladite ligne separative des lots 4 et 5 du rang A jusqu'à la ligne separative des Rangs A et II; en allant vers l'est jusqu'au sud d'un chemin; ledit côté Sud d'un chemin en allant vers l'est jusqu'à la ligne séparant le lot 1 des lots 2A et 2-1 du rang A; cette dernière ligne prolongée jusqu'à l'axe de la rivière Désert; ledit axe de la rivière Désert en descen- Action for separation as to property Canada Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court No.390,032.Thérèse Morier, wife common as to property of Roger Lamoureux, salesman, both of the city and district of Montreal, plaintiff vs Roger Lamoureux, salesman, of the city and district of Montreal, defendant.An action for separation as to property has been instituted in this case on the 22nd dav of February 1956.Montreal, 23rd day of February 1956.LACHANCE, BOISVERT & CUTLER, Attorneys for Plaintiff.41913-o 4 Notre-Dame street, East, Montreal.Miscellaneous Notices PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the Council of the municipality of the village of Maniwaki will apply to the Lieutenant-Governor in Council to request the erection of the territory of the municipality of the village of Maniwaki as a town under the Cities and Towns Act, under the name of the Municipality of the Town of Maniwaki.The said territory having a population of 6,327 persons, and being bounded as follows: \"On the North-west by the Eagle River; on the West by the County of Pontiac; on the South by the Township of Bouchette; on the East by the Gati-neau River; on the North-east by the Desert River, and including an area situated in the Township of Egan, including with reference to the official cadastre of the township of Egan, all lots, parts of lots and their present and future subdivisions, as well as all roads, streets, lanes, rivers, streams or parts thereof, included in the following limits, to wit: starting from the point of intersection of the northern bank of Lake Gilmour with the deviding line of lots 4 and 5 of Range A; from thence, running along the following lines and demarcations uninterruptedly; the said dividing line of said lot 4 and 5 of Range A as far as the dividing line of Range A and Range H; the said dividing line of Ranges A and n, running easterly as far as the south side of a road; the said south side of a road running easterly as far as the line dividing lot 1 from lots 2A and 2-1 of Range A; this latter line QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 19.56, Vol.88, No.9 887 dant le cours de ladite riviere jusqu'au prolongement d'une ligne intersectant la rive gauche ou rive nord-ouest de ladite rivière en un point situé à une distance perpendiculaire de 495.6 pieds à l'est de la ligne separative des lots 4 et 5 du rang A; ledit prolongement et ladite ligne en dernier lieu nommés en allant vers le nord-ouest jusqu'à un point de la ligne separative des lots 4 et 5 du rang A à une distance de 2,975 pieds de la rivière Désert; une ligne perpendiculaire à la ligne separative des lots 4 et 5 du rang A et traversant le lot 5 jusqu'à la rive Est du lac Gil-mour, et enfin, ladite rive Est du lac Gilmour en allant vers le nord jusqu'au point de départ.Et un autre territoire situé dans le canton d'E-gan, comprenant en référence au cadastre officiel dudit canton tous les lots, parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rues, ruelles, cours d'eau, rivières ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection du prolongement de la ligne separative des lots originaires 1 et 2 du rang A avec le côté nord-ouest d'un chemin public; de là, passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: ledit côté nord-ouest du chemin public en allant vers le nord-est sur une distance de mille dix-huit pieds (1018'); 'me perpendiculaire dudit côté nord-ouest dudit chemin public en allant vers le sud-est jusqu'au côté ouest de la route nationale N° 11; une perpendiculaire dudit côté ouest et traversant ladite route en allant vers le sud sur une distance approximative de deux cent soixante-quinze pieds (275') jusqu'à la ligne nord de la subdivision 1-1 du rang I; cette dernière ligne et la ligne nord des lots de subdivision 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9 et 1-10; la ligne de subdivision du lot 1-10 prolongée jusqu'à la ligne separative des rangs À et I; la ligne est du lot de subdivision 1-53 (une rue); et enfin ladite ligne separative des lots originaires 1 et 2 du rang A et son prolongement jusqu'au point de départ\".Donné à Maniwakj, ce troisième jour de février 1956.Le Procureur des pétitionnaires, 41846-7-4-o MALCOLM MILLAR.(P.G.11217-55) Avis est, par les présentes, donné que sur la recommandation de l'Assistant-procurcur général, l'Honorable Secrétaire de la province a, le 22 février 1956, approuvé les règlements de \"Italo-Canadian Social and Recreational Association\", tels qu'adoptés à une assemblée spéciale tenue le 10 janvier 1956, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 23e jour de février 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 41889 JEAN BRUCHÊSI.(P.G.13182-55) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procurcur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le dix-sept février 1956, les règlements généraux de la \"Ligue de Hockey Progression Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt février 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 41897-o JEAN BRUCHESI.extending .os far as the axis of Desert River; the said axis of the Desert Hiver following the course of the said river as far as the extension of a line intersecting the left bank or northeastern bank of the said river at a point situated at a perpendicular distance of 495.6 feet east of the dividing line of lots 4 and 5 of Range A; the said extension and the said line lastly mentioned running north-westerly as far as the point of the dividing line of lots 4 and 5 of Range A at a distance of 2,975 feet from the Desert River; a line perpendicular to that of the dividing line of lots 4 and 5 Range A and crossing lot 5 as fa.r as the East bank of Lake Gilmour and finally, the said East bank of Lake Gilmour running towards the north as far as the starting point; And another territory situated in the township of Egan comprising with reference to the official cadastre of the said township, all lots or parts of lots and their present and future subdivisions, as well as the roads, streets lanes, water-courses or part thereof enclosed within the following limits, to wit: Starting from a point of intersection from the prolongation of the dividing line of the original lots 1 and 2 of Range A with the northwest side of a public road; thence, passing successively by the following lines and demarcations: the said northwest side of the public road going towards the northeast upon a distance of one thousand eighteen feet (1018'); a perpendicular line on the said northwest side of the said public road going toward the southeast to the west side of the National Highway No.11; a perpendicular line of the said west side and crossing the said road to its east side; the said cast side of the said route going towards the south upon an approximative distance of two hundred and seventy-five feet (275') to the north line of subdivision lot 1-1 of Range I; this latter line and the north line of subdivision lots 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9 and 1-10; the east line of subdivision lot 1-10 prolonged to the dividing line of Ranges A and I; the east line of subdivision lot- 1-53 (a street) and finally the said dividing line of original lots 1 and 2 of Range A and its prolongation to the starting point.\" Given at Maniwaki, this third day of February 1956.MALCOLM MILLAR, 41846-7-4-o Attorney for the petitioners.(A.G.11217-55) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the By-laws of \"Italo-Canadian Social and Recreational Association\", as adopted at a special meeting held on January 10th, 1956, were approved on February 22nd, 1956, by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary this 23rd day of February, 1956.JEAN BRUCHÊSI, 41889-o Under-Secretary of the Province.(A.G.13182-55) Notice is given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved, under date of February seventeenth 1956, the general by-laws of the \"Ligue de Hockey Progression Inc.\", and such, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.(iiven at the office of the Provincial Secretary, the twentieth dav of February 1956.JEAN BRUCHÊSI, 41897 Under Secretary of the Province. 888 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 Discouhs du Trône Prorogation Honorables messieurs du Conseil législatif.Messieurs de l'Assemblée législative, La quatrième session de la vingt-quatrième Législature se termine aujourd'hui.Particulièrement remarquable par la qualité et la quantité des lois qui ont été adoptées et par de multiples initiatives bienfaisantes, cette session témoigne, une fois de plus, du désir sincère du gouvernement «pie notre législation soit parfaitement adaptée à nos excellentes traditions religieuses et nationales et corresponde aux meilleurs intérêts de la province et de la confédération canadienne.A nouveau, je formule l'espoir que les problèmes constitutionnels à l'ordre du jour reçoivent une solution qui assure le respect intégral des prérogatives et des droits provinciaux et fédéraux.Messieurs de l'Assemblée législative.Je vous remercie d'avoir voté les subsides nécessaires à l'administration de la province.Honorables messieurs du Conseil législatif, Messieurs de l'Assemblée législative, En prorogeant la session de notre Législature, je prie le Bon Dieu de combler notre chère province de Ses dons les meilleurs et d'assurer au monde une paix juste et durable, basée sur les enseignements du Christ.41894-o (P.G.2108-40) Hall Corporation of Canada Règlement LL Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs de six à sept.Qu'il soit décrété comme le règlement LL de Hall Corporation of Canada que: 1° Le nombre des directeurs soit et il est.par les présentes, augmenté de six à sept, et 2° Le règlement N° II et tous les autres règlements incompatibles à icclui sont, par les présentes, amendés et revisés pour donner effet au présent règlement.Certifié vraie capie.Montréal.13 février 1050.Le Secrétaire.11800 JAMES IL McDOUGALL\".(Sec.P.815-43) Avis dr changement de nom (L )i des clubs de récréation) Avis est donné que, lors d'une assemblée régulière de \"La Chambre de Commerce des Jeunes du Cap-de-la-Madeleine\", tenue au Cap-de-la-Madeleine, h* deux février 1956.le nom de ladite société a été.par une résolution dû ruent adoptée à cette fin, changé en celui de \"Le Jeune Commerce du Cap-de-la-Madeleine, Inc.\".Donné au bureau du Secrétaire de la province le seize février 1950.Le Sous-secrétaire de la province, 41S90-o JEAN BRUCHÊSI.Speech from the Throne Prorogation Honourable Gentlemen of the Legislative Council.Gentlemen of the Legislative Assembly.The fourth session of the twenty-fourth Legislature is closing today.Particularly noteworthy for the quality and the quantity of laws which were adopted and for mimerons new constructive projects, this session demonstrates once more the Government's sincere desire that our legislation should be perfectly adapted to our excellent religious and national traditions and should correspond to the highest interests of the Province and of the Canadian Confederation.Once more.I express the hope that the constitutional problems under discussion will be solved in a manner which will completely safeguard provincial and federal rights and prerogatives.Gentlemen of the Legislative Assembly, I thank you for having voted the credits necessary for the administration of the Province.Honourable Gentlemen of the Legislative Council, Gentlemen of the Legislative Assembly, In proroguing the session of our Legislature, I pray Almighty God to bestow His most bountiful gifts upon our dear Province and to ensure to the world a just and enduring peace founded upon Christ's teachings.41894-o (A.G.2108-40) Hall Corporation of Canada By-law LL Being a By-law to increase the number of Directors from six to seven: \"Be it enacted as By-law LL of the Hall Corporation of Canada that: 1.The number of Directors be ant it is hereby increased from six to seven, and; 2.By-law No.II and all other By-laws inconsistent herewith are hereby amended and revised in order to give effect to this By-law.\" Certified a true copy.Montreal, February 13th, 1950.JAMES II.McDOUGALL, \u202211890 Secretary.(P.Sec.815-43) Notice of change of name (Amusement Clubs' Act) Notice is given that at a regular meeting''oi \"La Chambre de Commerce des Jeunes du Cap-de-la-Madeleiiie\", held at Cap-dc-la-Madcleine, the second day of February 1950, the name of the said association, has.by a résolution adopted for said purposes, been changed to that of \"Le Jeune Commerce du Cl p-de-la-Madeleine, Inc.\".Given at the office of the Secretary of the Province, the sixteenth dav of February 1956.JEAN BRUCHÊSI, 41899 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 ' -889 (P.G.12103-55) Commercial Investments Corp.Règlement Spécial \"A\" Qu'il soit décrété et il est.par les présentes, décrété comme un règlement de Commercial Investments Corp., (ici nommée la \"compagnie\") comme suit: 1° Que le nombre des directeurs soit et il est, pur les présentes, diminué de six (6) à quatre (4) de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de quatre (4) directeurs.2° Tous règlements, résolutions et procédures antérieures de la compagnie, incompatibles à icelui, sont par les présentes, amendés, modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.Certifié vraie copie du règlement spécial \"A\" décrété par un vote unanime du bureau de direction de la compagnie, le 25e jour de janvier 1956.et sanctionné et confirmé par le vote unanime des actionnaires de la compagnie donné à une assemblée générale spéciale des actionnaires dûment convoquée aux fins de considérer ce règlement.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 41898 ABE PINSKY.(P.G.9330-49) J.H.Morin & Fils Limitée Règlement N° 1 \"Qu'il soit constitué et il est par les présentes résolu règlement de J.H.Morin & Fils Limitée que: 1° Le nombre des directeurs de la compagnie soit et est par les présentes augmenté de trois à quatre, de façon que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de quatre directeurs; 2° Deux directeurs constitueront le quorum à toute assemblée du bureau «le direction; 3° Tous règlements antérieurs, résolutions et procédures de la compagnie en opposition au règlement susdit sont, par les présentes, amendés, modifiés et revisés de façon à donner effet audit règlement.\" Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 41903-o FERNAND MORIN.(P.G.13414-55) Aero Mining Corporation (No Personal Liability) Règlement N° V \"1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est.par les présentes, augmenté «le trois à neuf «le manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de neuf directeurs.2° Cinq directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3° Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la 'Compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes] amendés, modifiés et révisés «le manière à donner effet à ce règlement.\" Certifié vraie copie.(Sceau) Ia.' Secrétaire, 41907-o I.A.MORGULIS.(AG.12103-55) Commercial Investments Corp.Special By-law \"A\" Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of Commercial Investments Corp., (herein called \"the Company\") as follows:« 1.The number of the directors be and the same is hereby decreased from six (6) to four (4) so that the Board of Directors of the Company shall hereafter be composed of four (4) directors.2.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this By-law.Certified to be a true copy of Special By-law \"A\" enacted by unanimous vote of the Board of Directors of the Company on the 25lh day of January.1956, and sanctioned and confirmed by unanimous vote of the shareholders of the Company cast at a Special General meeting of shareholders duly called for considering the By-law.(Seal) ABE PINSKY, 41898-o Secretary-Treasurer.(A.G.9336-49) J.H.Morin & Fils Limitée By-law No.1 \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of J.H.Morin & Fils Limitée, that: 1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three to four, in order that the Board of Directors of the company shall hereafter be composed of four directors; 2.Two directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors; 3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to said by-law.\" Certified true copy.FERNAND MORIN, 41903 Secretary.(A.G.13414-55) Aero Mining Corporation (No Personal Liability) By-law No.V \"I.The number of directors of the company be an«l the same is hereby increased from three to nine so that the board of directors of the company shall hereafter be composed of nine directors.2.Five directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.\" Certified true copy.(Seal) I.A.MORGULIS, 41907 Secretary. 890 \u2022 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars I960, Tome 88, N° 9 (P.G.11880-55) Thiiee Hundred Decarie Ltd.Règlement N° 12 concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à neuf: \"r^es affaires de la compagnie seront administrées par un bureau composé de neuf (9) directeurs dont trois (3) formeront quorum.\" Adopté par les actionnaires le 19 décembre 1955.Pour copie conforme.La Secrétaire.41908-o JACQUELINE LAPIERRE.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 102, l'honorable Secrétaire de la province a décrété, le vingt-sept février 1950, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Le Syndi-dicat National Catholique des Employés du Textile (Wabasso) de Trois-Rivières Inc.\", dont la constitution avait été autorisée le 11 août 1948, avec son siège social aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-huit février 1956.lie Sous-secrétaire de la province, 41909-o JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Montreal Armature Works Industrial Employees' Association\", pour l'étude, la défense et le développement ries intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le dix-sept février 1956.lie siège social du syndicat professionnel précité est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, 41912-o JEAN BRUCHÊSI.(P.G.11357-55) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant .-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le vingt-sept février 1956, les règlements de \"L'Assistance Maternelle de Laprairie\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire «le la province, le vingt-huit février 1956.lie Sous-secrétaire «le la province, 41921-o JEAN BRUCHÊSI.(P.G.4412-43) Avis est, par les présentes, donné que sur la recommandation «le l'Assistant-procurcur général, l'Honorable Secrétaire «le la province a, le 27 février 1956, approuvé le règlement \"F\" de \"Quebec Brewers Association \u2014 L'Association des Brasseries de la province «le Québec\", et ce conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Qu«:bec.(A.G.11380-55) Three Hundred Decarie Ltd.By-law No.12 concerning an increase in the number oil directors from three to nine: \"The affairs of the company shall be managed by a board composed of nine (9) directors of whom three (3) shall form a quorum.\".Adopted by the shareholders on December 19, 1955.True Copy.JACQUELINE LAPIERRE, 41908 Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary, on February twenty-seventh, 1956, enacted the termination of the corporate existence of \"lie Syndicat National Catholique des Employés «lu Textile (Wabasso) «le Trois-Rivières Inc.\", whose constitution had been authorized on August 11, 1918, with its head office at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162.Given at the office of the Provincial Secretary, February twenty-eighth 1956.JEAN BRUCHÊSI.41909 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Montreal Armature Works Industrial Employees' Association\", for the study, «lefencc and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on the seventeenth day of February 1956.The principal place of business of the said professional syndicate is at Montreal, judicial district of Montreal.JEAN BRUCHÊSI, 41912 Under Secretary of the Province.(A.G.11357-55) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy-Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved, on February twenty-seventh, 1950, the bylaws of \"L'Assistance Maternelle de Laprairie\", and such, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, February, twenty-eighth, 1956.JEAN BRUCHÊSI, 41921 Under Secretary of the Province.(A.G.4412-43) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, by-law \"F\" of \"Quebec Brewers Association \u2014 L'Association des Brasseries «le la province de Québec\" was approve*! on February 27th, 1956, by the Honourable the Provincial Secretary, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 891 Donné au bureau du Secrétaire de la province' ce 28e jour de février 1956.Le Sous-secrétaire de la province.41922 JEAN BRUCHÊSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse d'Épargne des Employés Municipaux de Québec\", en date du 6 février 1950, dont le siège social est situé à Québec, district judiciaire de Québec, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le treize février 1950.Le Sous-secrétaire de la province.11923-0 JEAN BRUCHÊSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Société des Vingt\", en date du 1er décembre 1955, dont le siège social est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le dix décembre 1955.Le Sous-secrétaire de la province, 41925-0 JEAN BRUCHÊSI.(Sec.P.189-50) Avis d'autorisation (Loi des Compagnies minières de Québec) Avis est donné que la compagnie \"Atlas Chibougamau Mines Limited\" a été autorisée à vendre ou autrement aliéner dans la province de Québec, ses actions, titres, certificats-actions, debentures et autres valeurs.IiC siège social dans la province est à chambre 725, 132 ouest, rue St-Jacques, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans toutes procédures prises contre elle, est M.J.Austin Murphy, Cit., de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 27c jour de février 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 41888 JEAN BRUCHÊSI.(Sec.P.180-56) Avis d'autorisation (Loi des Compagnies minières de Québec) Avis est donné que la compagnie \"Bandowan Mines Limited\" a été autorisée à vendre ou autrement aliéner dans la province de Québec, ses actions, titres, certificats-actions, debentures et autres valeurs.Le siège social dans la province est à chambre 725, 132 ouest, rue St-Jacques, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans toutes procédures prises contre elle, est M.J.Austin Murphy, Cit., de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 27e jour de février 1956.Le Sous-secrétaire de la province.41888 JEAN BRUCHÊSI.Given at the office of the Provincial Secretary* this 28th day of February, 1956.JEAN BRUCHÊSI, 41922-o Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse «l'Epargne des Employés Municipaux de Québec\", under dale of February 6, 1956, whereof the head office is at Quebec, judicial district of Quebec, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this thirteenth dav of February, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 41923 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the* Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Société des Vingt\" under date December 1st, 1955, whereof the head office is at Montreal, judicial district of Montreal and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this tenth dav of December, 1955.JEAN BRUCHÊSI.41925 Under Secretary of the Province.(P.Sec.189-56) Notice of authorization (Quebec Mining Companies' Act) Notice is hereby given that \"Atlas Chibougamau Mines Limited\" has been authorized to sell or otherwise alienate in the Province of Quebec its shares, stocks, stock-certificates, debentures and other securities.The head office in the Province is at room 725, 132 St.James street, west, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against it is Mr.J.Austin Murphy, Q.C., of the said city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary this 27th dav of February, 1956.JEAN BRUCHÊSI, 41888-0 Under-Secretary of the Province.(P.Sec.180-56) Notice ok authorization (Quebec Mining Companies' Act) Notice is hereby given that \"Bandowan Mines Limited\" has been authorized to sell or otherwise alienate in the Province of Quebec its shares, stocks, stock-certificates, debentures and other securities.The head office in the Province is at room 725, 132 St.James street, west, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against it is Mr.J.Austin Murphy, Q.C., of the said city of Montreal.Given at the officeiof the Provincial Secretary this 27th day of February, 1950.JEAN BRUCHÊSI.41888-0 Under-Secretary of the Province. 892 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 (Sec.P.187-50) Avis d'autorisation (Loi des compagnies minières de Québec) Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Cavalier Mining Corporation Limited\" a été autorisée à vendre ou autrement aliéner dans la province de Québec, ses actions, titres, certificats-actions, debentures et autres valeurs.Le siège social dans la province sera à chambre 725, 132 ouest, rue St-Jacques, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures prises contre elle, est M.J.Austin Murphy, CH., de ladite cité de Moid réal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 1er jour de mars 1950.IiC Sous-secret a ire de la province, 41888 JEAN BRUCHÊSI.(P.G.13070-55) Togmaster Inc.Règlement N° 7 \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Togmaster Inc.\" (ici nommée la \"compagnie\") comme suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de cinq à trois de manière que le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé tic trois directeurs.2.Deux directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3.Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et revises de manière à donner effet à ce règlement.\" Certifié vraie copie.(Sceau) Le Secrétaire, 41934 JACK LOBEL.(P.G.10152-54) Meteor Homes Ltd.Règlement A\"0 2Jt \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de Meteor Homes Ltd.ce qui suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, diminué de cinq à trois, de manière (pie le bureau de direction de la compagnie soit dorénavant composé de trois directeurs.2.Trois directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3.Tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés, modifiés et.revisés pour donner effet au présent règlement.\" Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 41930 BENJAMIN ANZARUT.Bills, Assemblée législative Cm amure nu Conseil législatif Québec, 23 février I960.Aujourd'hui, à quatre heures et demie de l'après-midi, l'honorable lieutenant-gouverneur (P.Sec.187-50) Notice of autorization (Quebec Mining Companies' Act) Notice is hereby given that \"Cavalier Mining Corporation Limited\" has been authorized to sell or otherwise alienate in the Province of Quebec its shares, stocks, stock-certificates, debentures and other securities.The head office in the Province to be at Boom 725, 132 St.James Street.West, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against it is Mr.J.Austin Murphy.Q.C.of the said City of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary this 1st day of March, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 41888-0 Under-Secretary of the Province.(A.G.13070-55) Togmaster Inc.By-Law No.7 \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of \"Togmaster Inc.\" (herein called the \"Company\") as follows: 1.The number of directors of the Company be and the same is hereby decreased from five to three so that the Board of Directors of the Company shall hereafter be composed of three directors.2.Two directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.\" Certified a true copy.(Seal) JACK LOBEL.41934-o Secretary.(A.G.10152-54) Meteor Homes Ltd.By-Law number 2Jt \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of Meteor Homes Ltd.as follows: 1.The number of directors of the company be and the same is hereby decreased from five to three, so that the Board of Directors of the Company shall hereinafter be composed of three directors.2.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.\" Certified a true copy.BENJAMIN ANZARUT, \u202211930-o Secretary.Bills, Legislative Assembly Legislative Council Chamrer Quebec, 23rd February, 1956.This day, at half past four o'clock in the afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1966, Vol.S8, No.9 893 s'est rendu à la chambre du Conseil législatif, proceeded to the Legislative Council Chamber, au Palais législatif.in the Legislative Building.Les membres du Conseil législatif étant asscm- The members of the Legislative Council being blés, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur assembled, the Honourable the Licutenant-Gov- d'y faire requérir la présence de l'Assemblée ernor was pleased to command the attendance of législative et, cette chambre s'y étant rendue, the Legislative Assembly, and, that House being le greffier de la couronne en chancellerie a lu les present the Clerk of the Crown in Chancery read titres des bills à être sanctionnés comme suit: the titles of the bills to be sanctioned as follows: 33 Loi modifiant la Loi concernant les valeurs mobilières.37 T/Oi\" concernant les contribuables municipaux et scolaires de la cité de Québec et Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills, Limited.39 Loi modifiant le Code de procédure civile.43 Loi modifiant la Loi de l'hygiène publique de Québec.¦14 Loi établissant un Office provincial pour aider «à la vente des produits agricoles.\u202215 Loi concernant l'aménagement des forces hydrauliques de la rivière Outaouais et connues sous le nom de Cave & Fourneaux.\u202216 Loi facilitant davantage les progrès scolaires dans la province.47 Loi concernant l'Université de.Montréal et l'Ecole Polytechnique, de Montréal.48 Loi modifiant la Loi des cités et villes.49 Loi modifiant le Code municipal et concer- nant certaines municipalités.50 Loi modifiant la Loi des dettes et des em- prunts municipaux.51 Loi concernant les modalités de certains emprunts municipaux.54 Loi modifiant la Loi accordant aux municipalités des pouvoirs spéciaux pour remédier à la crise du logement.05 Loi concernant le ministère des finances.56 Loi modifiant la Loi pour protéger l'indus- trie laitière du Québec.57 Loi facilitant l'établissement de nouvelles industries dans la région de Baie Comeau.comté de Saguenay.58 Loi facilitant, le développement industriel de la province et concernant Aluminum Company of Canada, Limited.59 Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le tabac.i modifiant la loi 15 George V, chapitre 45, concernant les écoles protestantes dans la cité de Montréal et ses environs.N 235 Loi concernant le testament de Cécile Marchildon.237 Loi concernant la succession de John Louis Sabbath.239 Loi autorisant le barreau de la province de Québec à admettre Akos de S.Muszka au nombre de ses membres, après examen.240 Loi concernant le titre de Paul-Émile La- perrière à la propriété d'un immeuble dans la cité de Saint-Laurent.241 Loi modifiant la charte du Bishop's College.242 Loi confirmant le titre de Léonard Dulude à certains immeubles.practice of the dental profession on certain conditions.183 An Act respecting the town of Montreal-North.187 An Act to amend the charter of the city of Montreal.194 An Act to amend the charter of the town of Bedford.197 An Act to amend the charter of the city of Jacques-Cartier and to grant it certain powers.203 An Act respecting the estate of Robert Clark Hastings.204 An Act respecting the immoveables of Canada Steamship Lines Limited in the village of Tadoussac, county of Saguenay.206 An Act to amend the charter of the city of Trois-Rivières.207 An Act to incorporate the town of Anjou.209 An Act to amend the charter of the city of Sherbrooke.212 An Act to amend the charter of the city of Sainte-Foy.218 An Act to incorporate \"Jewish Convalescent Centre\".219 An Act respecting the town of Hauterive.225 An Act to amend the charter of the city of Lachine.227 An Act to amend the charter of the city of St.Johns.228 An Act to amend the charter of the city of Sillery.229 An Act respecting the wills of Lactance Bouthillette and Dina Trahan.232 An Act respecting the Quebec Dietetic Association.234 An Act to amend the act 15 George V, chapter 45, respecting Protestant schools in and around the city of Montreal.235 An Act respecting the will of Cécile Mar- childon.237 An Act respecting the estate of John Louis Sabbath., 239 An Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit Akos de S.Muszka among its members, after examination.240 An Act respecting the title of Paul-Émile Laperrière to the ownership of an immoveable in the city of Saint-Laurent.241 An Act to amend the charter of Bishop's College.242 An Act to confirm the title of Léonard Dulude to certain immoveables. 896 GAZETTE OFFICIALISE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 1956, Tome 88, N° 9 244 Loi exemptant André Langlais de la quatrième année d'études d'ordre pratique et autorisant le Barreau de la province de Québec à l'admettre à l'exercice de la profession d'avocat, après examens.246 Loi concernant la radiation d'une servitude établie sur le lot numéro 27 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, comté de Jacques-Cartier.La sanction royale est prononcée sur ces bills par le greffier du Conseil législatif, comme suit: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.\" 40 Loi octroyant à Sa .Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1957, et pour d'autres fins.A ce bill, la sanction royale a été donnée dans les termes suivants: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur remercie ses loyaux sujets, accepte leur benevolence et sanctionne ce bill.\" 41905-o Chartes \u2014 Abandon de 244 An Act to exempt André Langlais from the fourth year of practical studies and to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit him to the practice of the legal profession, after examination.246 An Act respecting the cancellation of a servitude established on lot number 27 of the cadastre for the parish of Saint-Laurent, county of Jaeques-Carticr.To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Legislative Council in the following words: \"In Her Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor assents to these bills;\" 40 An Act granting to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the financial year ending on the 31st of March, 1957, and for other purposes.To this bill the Royal assent was signified in the following words: \"In Her Majesty's name the Honourable the Lieutenant-Governor thanks his loyal subjects, accepts their benevolence and assents to this bill.\" 41905-o Charters \u2014 Surrender of Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Greater Montreal.Enterprises & Real Estate Ltd., demandera au Procureur General d'abandonner sa Charte.Montréal, le 24 février 1950.Les Procureurs de la Compagnie, 41900-o JOHNSON & FORME Y.Notice is hereby given that Greater Montreal Enterprises & Real Estate Ltd., will apply to the Attorney General for permission to abandon its Charter.Montreal, February 24th.1950.JOHNSON & FORMEY, 41900-o Attorneys for the Company.(P.G.S479-51 ) (A.G.8479-51 ) Avis est donné conformément, à la loi des Notice is hereby given in conformity with Compagnies de Québec que la compagnie the Quebec Companies' Act, that the company \"'Garage Cabru Limitée\" demande la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 23 février, 1950.(Sceau) Le Secrétaire, 41901 -o (S) A.DENYS.\"Garage Cabru Limitée\" asks permission to surrender its charter.Montreal, this 23rd dav of February, 1956.(Seal) \" (S) A.DENYS, 41901 Secretary.Avis est par les présentes donné (pic \"Godard Notice is hereby given that \"Godard & & Laçasse Inc.\" demandera permission d'aban- Laçasse Inc.\", shall apply for leave to surrender donner sa charte conformément aux dispositions its charter pursuant to the provisions of section de l'article 20 de la Loi des Compagnies de Québec.Montréal, le 10 février 1950.Godard & Laçasse Inc., Le Président.41902-o ROGER LAÇASSE.26 of the Quebec Companies' Act.Montreal.February 16, 1950.Godard & Laoasse Inc., ROGER LAÇASSE.41902 Preside! Compagnies autorisées à faire des affaires Companies Licensed to do Business (Sec P.692-55) Avis est.par les présentes, donné que la compagnie \"Luria Brothers & Company, Inc.\" (auparavant Bayou Metals, Inc.) a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères.S.R.Q.1911.chapitre 279.(P.Sec.692-55) Notice is hereby given that \"Luria Brothers & Company, Inc.\" (formerly Bayou Metals.Inc.) has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provi ins of the Extra-Provincial Companies' Act, H 1941, chapter 279. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 897 Le bureau principal de ladite compagnie dans la province, est à 2000 édifice Aldred, 507 Place d'Armes, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures prises contre elle, , M.W.IL Laidley, à l'adresse ci-dessus mi rationnée.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 24e jour de février 1950.Le Sous-Secrétaire de la province, 41888 JEAN BRUCHÊSI.(Sec.P.119-56) Avis est, par les présentes donné que la compagnie \"The Tiinkcn Roller Bearing Company\" a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, S.B.Q.1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est à 027 Côte Vertu, St-I.anient, Montréal, district judiciaire de Montréal.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures prises contre elle, est M.Théodore Êlidoros, de la cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 28e jour de février 1950.Le Sous-Secrétaire de la province, isvs JEAN BRUCHÊSI.Compagnie dissoute (P.G.12228-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270.article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu nu Piocureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Desroches Construction Inc.\", cons-tiée en corporation par lettres patentes en date du 11 décembre 1953.Avis est de plus donné qu'à compter du vingt-sept février 1956, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit février 1956.L'Assistant-procureur général suppléant, 41888-0 P.FRENETTE.The principal Office of the said company in the Province is at 2000 Aldred Building, 507 Place d'Armes, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.W.H.Laidley, of the above given address.Given at the office of the Provincial Sccretarv this 21th dav of Fcbruarv.195(1.JEAN BRUCHÊSI, 41888-0 Assistant Provincial Secretary.(P.Sec.119-50) Notice is hereby given that \"The Timken Roller Bearing Company\" has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies' Act.R.S.Q.1941.chapter 279.The principal office of the said company in the Province is to be at 027 Côte Vertu.St.Laurent.Montreal, in the judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services-in proceedings against it is Mr.Théodore Êlidoros, of the city of Montreal.Given at the office of the Provincial Sccretarv this 28th day of Fcbruarv.195li.JEAN BRUCHÊSI, 41888-0 Assistant Provincial Secretary.i Company Dissolved (A.G.12228-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q.1941.ami subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the sur-rendci of the charter of the company \"Dcsroches Construction Inc.\".incorporated by letters patent dated December 11.1953.Notice is also given that from and after February twenty-seventh 1956, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of February, 1956.P.FRENETTE, llsss Acting Deputy Attorney General.Département de l'Agriculture Industrie Laitière (\\imission de l'Industrie Laitière de la Province de Québec Department of Agriculture Dairy Industry The Dairy Industry Commission ok the Province of Queuec Ordonnance N° 15-51A Order No.15-51A (Région de Saint-Jérôme) (Region of«6aint-Jérôme) Extrait des procès-verbaux des séances de la Excerpt from the proceedings of the meetings Commission de l'Industrie Laitière de la Pro- of the Dairy Industry Commission of the Province de Québec.vince of Quebec.Séance du jeudi, le 23 février 1956, tenue au Meeting of Thursday, February 23, 1950, bureau de la Commission de l'Industrie Laitière held in the office of the Dairy Industry Com- à Montréal, à 10 heures du matin.mission in Montreal, at 10 o'clock in the morning.Présents: MM.Omer-E.Milot, président, Present: Messrs.Omer-E.Milot, President, Joseph Hébert, Adrien Angers et J.-A.Chartrand, Joseph Hébert.Adrien Angers and J.-A.Char- commissaircs, et Alphonse Savoie, secrétaire.trand, Commissioners, and Alphonse Savoie, Secretary. 898 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 1956, Tome 88, N° 9 La Commission décrète ce qui suit: 1° L'article 3 de l'ordonnance N° 15-51 publiée dans la Gazette officielle de Québec le 27 octobre 1951 est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: \"Le paiement du lait aux fournisseurs-producteurs se fera sur une base de 3.5% de matières grasses: a) Plus une prime de trois cents par cent livres de lait, pour chaque dixième de 1% au-dessus de ce pourcentage; b) Moins un rabais de trois cents par cent livres de lait, pour chaque dixième de 1% au-dessous de ce pourcentage.\" 2° La présente ordonnance entrera en vigueur le lGième jour de mars 1956.Le secrétaire de ladite Commission est chargé de la publication de la présente ordonnance dans la Gazette officielle de Québec.Signé: Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert, commissaire, Adrien Angers, commissaire, J.-A.Chartrand, commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire.41904-o Département de l'Agriculture Avis est donné que le ministre de l'Agriculture a autorisé la formation d'un cercle agricole dans le district électoral d'Abitibi-Est.sous le nom de \"Cercle agricole de la paroisse de St-Benoît de La Corne\", confoimément à la loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118).Daté du bureau du ministre de l'Agriculture, le 28 février 1956.Le Sous-ministre de l'Agriculture.41904-o B.TRÊPANIER.Département de l'Instruction Publique X° 182-56.Québec, le 22 février 1956.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Ditton, dans le comté de Compton, en celui de \"La Patrie\", même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 41930-9-2-O 0.J.DÉSAULN1ERS.Département des Mines Province de Québec Ministère des Mines Avis de révocation de droits de mine Conformément aux articles 50, 51, 51A et suivants de la Loi des Mines de Québec (S.R.Q., 1941, ch.196) tels qu'amendés par 3-4 Elizabeth II, ch.38, avis est présentement donné aux détenteurs de droits de mine sur les terrains ci-dessous mentionnes qu'après un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent avis, le Ministre des Mines recommandera au Lieutenant-Gouverneur en conseil la révocation quant aux droits de mine de ces terrains, si l'exploitation d'iceux est demeurée inactive ït is enacted as follows : 1° Article 3 of Order No.15-51 published in the Quebec Official Gazette of October _7, 1951, is modified by adding the following paragraph: \"The payment of milk to the product rs-suppliers shall be made on a basis of 'A.j , butterfat: a) A premium of three cents per hundred pounds of milk shall be added for each I 10 of 1% over this percentage; b) A deduction of three cents per hundred pounds of milk shall be made for each 1,10 of 1% below this percentage.\" 2° The present Order shall come into force on the 10th day of March 1950.The Secretary of said Commission is charged with the publication of the present Order in the Quebec Official Gazette.Signed: Omer-E.Milot, President; Joseph Hébert, Commissioner.Adrien Angers, Commissioner.J.-A.Chartrand, Commissioner.Certified: Alphonse Savoie, Secretarv.41904-o Department of Agriculture Notice is given that the Minister of Agriculture has authorized the formation of a Fanner's Club in the electoral district of Abitibi-Easl, under the name of \"Cercle agricole de la paroisse de St-Benoît de La ('orne\", pursuant to the Farmers' Clubs Act (B.S.Q.1941, chap.118).Dated at the office of the Minister of Agriculture, February 28, 1950.B.TRÊPANIER, 41904 Deputy Minister of Agriculture.Department of Education No.182-50.Quebec.February 22, 1950.Application is made to change the name of the school municipality of Ditton, in the county of Compton.into that of \"La Patrie\", same county.O.J.DÉSAULNIERS, 41930-9-2 Superintendent of Education.Department of Mines Province of Quebec Department of Mines Notice of revocation of mining rights Pursuant to sections 50, 51, 51A and following of the Quebec Mining Act (R.S.Q., 1941, ch.190) as amended by 3-4 Elizabeth II, ch.3S.notice is hereby given to the holders of mining rights on the parcels of land here under listed that after a delay of ninety days from the dale of the present notice, the Minister of Mines will recommend to the Lieutenant-Governor in Council the revocation of the mining rights on these concessions of land, the working of which has remained inactive during the twenty-one QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 899 pendant les vingt et une années qui ont suivi le premier mars 1934, à savoir: Dans le canton d'Eardley: Les lots 6B cadastre (A O.lot 6) rang VII; 6A cadastre (A E.lot 6) rang VII; 7A cadastre (A E.lot 7) rang VII; 7B cadastre (A O.lot 7) rang VII; 4 rang VII; ô rang VII; 4B cadastre (A S.lot 4) rang VIII; 5A cadastre (A E.lot 5) rang VIII; 5C cadastre (A S.de A S.O.lot 5) rang VIII.Les lots 1 et 2, rang IX; le lot 2, rang X; les lots 1, 3, 4 rang XI; les lots 1 et 2, rang XII.Dans le canton de Hull: Les lots 26.27, rang XI; les lots 24, 25, 26, 27A {A N.27) et 28, rang XIII; le lot 28, rang XIV.Dans le canton de Price: Les lots 9A, 9B, 9C et 10A, rang I.Dans le canton de Tring: Les lots 77, 78, 79, 80, 81 (étant parties des lots primitifs 23 et 24) rang I.Les lots 271, 272, 273, 274, 275 (étant parties des lots primitifs 23 et 24) rang IL Les lots 310, 317, 318 (étant parties du lot primitif 24) rang III.Dans le canton d'Ascot: Les lots 7, 8, OA, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G et A E.10, rang X.Dans le canton de Dudswell; A N.O.lot 20, rang VII (107 cadastre).Québec, le 17 février 1956.Le Sous-ministre, llS64-S-2-o A.O.DUFRESNE.years following the first of March 1934, to wit: In Eardley township: Cadastral lots 6B (A W.lot 0) range VII; 6A (A E.lot 6) range VII; 7A (A E.lot 7) range VII; 7B (A W.lot 7) range VII; 4 range VII; 5 range VII; 4B OA S.lot 4) range VIII; 5A OA E.lot 5) range VIII; 5C (A S.of A S.W.lot 5) range VIII.Lots 1 and 2, range IX; lot 2, range X; lots 1, 3 and 4, range XI; lots 1 and 2, range XII.In Hull township: Lots 26 and 27, range XI; lots 24,25,26,27A (J^N.27) and 28, rang XIII: lot 28, range XIV.In Price township: Lots 9A, 9B, 9C and 10A, range I.In Tring township: Lots 77, 78, 79, 80, 81 (being parts of original lots 23 and 24), range I.Lots 271, 272, 273, 274, 275 (being parts of original lots 23 and 24) range II.Lots 310, 317, 318 (being parts of original lot 24), range III.In Ascot township: Lots 7, 8, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9Ct and A E.10, range X.In Dudswell township: A N.W.lot 20, range VII (cadastral lot 107).Quebec, February 17th, 1950.A.0.DUFRESNE, 41864-8-2-0 Deputy Minister.Liquidation, avis de: (Sec.P.149-17) Avis est donné que, lors d'une assemblée spéciale des actionnaires de la compagnie \"Lan-glois & Paradis, Limitée\", tenue le 11 février 1956, il a été résolu à l'unanimité que les affaires de ladite compagnie soient liquidées volontairement, et que celle-ci soit dissoute, conformément aux dispositions de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, et que MM.C.Paradis, L.-A.Langlois et R.-S.Langlois ont été nommés liquidateurs.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le vingt-quatre février 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 41932-o JEAN BRUCHÊSI.Winding up Notice; (P.Sec.149-17) Notice is hereby given that at a special meeting of the shareholders of the company \"Langlois & Paradis, Limitée\", held on February 11, 1956.it was unanimously resolved that the affairs of the said company be wound up voluntarily, and that it be dissolved, in accordance with the provisions of the Winding-up Act, and for such purposes, that Messrs.C.Paradis, L.-A.Langlois and R.-S.Langlois have been appointed liquidators.Given at the office of the Provincial Secretary, Fcbruarv twenty-fourth, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 41932 Under Secretary of the Province.Ministère des Finances Assurances Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Avis est par les présentes donné que \"La Compagnie Bonnier Frères Assurance Funéraire, Limitée\" a adopté à une assemblée générale spéciale de ses actionnaires, tenue le 15 août 1955, une résolution décrétant sa mise en liquidation volontaire en conformité des dispositions de l'article 276 de la Loi des assurances de Québec, et qu'en conséquence les permis et certificat d'enregistrement de ladite compagnie sont annulés conformément aux dispositions de l'article 123 de ladite loi.Donné au bureau du Service des assurances.Ministère des finances, le 27 février 1956.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRANCE, 11906-o Surintendant des assurances.Department of Finance Insurance Notice of Cancellation of License and Certificate of Registry Notice is hereby given that \"La Compagnie Bonnier Frères Assurance Funéraire, Limitée\" has adopted at a special general meeting of its shareholders, held on the 15th of August 1955, a resolution providing for its voluntary liquidation in accordance with the provisions of section 270 of the Quebec Insurance Act, and that consequently the license and certificate of registry of the said company are cancelled pursuant to the provisions of section 123 of the said act.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, this 27th day of February 1956.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 41906-o Superintendent of Insurance. 900 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 Avis d'annulation d'enregistrement Attendu que \"The Central Insurance Company Limited\", dont le siège social est situé à Londres, Angleterre, a cessé de faire affaires dans la Province le 1er janvier 1956; Attendu que ladite compagnie a réassuré toutes ses affaires dans la Province auprès de \"The Liverpool and London and Globe Insurance Company Limited\", dont le siège social est situé à Liverpool, Angleterre, en vertu d'un contrat de réassurance en date du 30 décembre 1955 et prenant effet à compter du 1er janvier 1950; Attendu que \"The Central Insurance Company Limited\" s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné (pic les permis et certificat (fenregistrement the \"Central Insurance Company Limited\" sont annulés à compter du 1er janvier 1956.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 27 février 1956.Pour le Ministre des finances de la Province.GEORGES LA FRANCE, 41906-o Surintendant des assurances.Avis d'annulation d'enregistrement Attendu que \"United National Indemnity ( \"ompany\", dont le siège social est situé à New-York, État de New-York, États-Unis d'Amérique, a été fusionnée avec \"Transcontinental Insurance Company\", dont le siège social est situé à New-York, Etat de New-York, États-Unis d'Amérique, en vertu d'un acte de fusion en date du 18 octobre 1955, et ayant pris effet le 14 novembre 1955; Attendu que \"Transcontinental Insurance Company\" est la corporation subsistante, et est dûment autorisée à faire dans la province de Québec; Attendu que \"United National Indemnity Company\" s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que les permis et certificat d'enregistrement de \"United National Indemnity Company\" sont annulés à compter du 14 novembre 1955.Donné au Bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 27 février 1950.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRANCE, 41906-o Surintendant des assurances.Avis d'annulation de permis et d'enregistrement Attendu que la Commission de transport de Montréal a.conformément aux dispositions de la loi 2-3 Elisabeth II, chapitre 126, adopté un règlement établissant un fonds de pension, prenant effet à compter du 1er mars 1956; Attendu qu'en vertu de l'article 4 de ladite loi, l'Association Mutuelle de Bienfaisance de la Compagnie des Tramways de Montréal sera dissoute à toutes fins, à la date d'entrée en vigueur dudit règlement, En conséquence, avis est par les présentes donné que les permis et certificat d'enregistrement de l'Association Mutuelle de Bienfaisance de la Compagnie des Tramways de Montréal seront annulée à compter du 1er mars 1956.Notice of Cancellation of Registration Whereas \"The Central Insurance Company Limited\", whose head office is situate in London, England, has ceased to do business in this Province as from the 1st of January 1950; Whereas the said company has reinsured all its business in this Province with \"The Liverpool and London and Globe Insurance Company Limited\", whose head office is situate in Liverpool, England, under a reinsurance agreement dated December 30, 1955, and taking effect as from the 1st of January 1950; Whereas \"The Central Insurance Company Limited\" has complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"The Central Insurance Company Limited\" is cancelled as from the 1st of January 1956.Given at the office of the Insurance Branch.Department of Finance, on the 27th of February 1956.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 41906-o Superintendent of Insurance.Notice of Cancellation of Registration Whereas \"United National Indemnity Company\", whose head office is situate in New York.State of New York, United States of America, has been merged into \"Transcontinental Insurance Company\", whose head office is situate in New York, State of New York, United States of America, under an agreement of merger dated October 18, 1955, and that has taken effect on the 14th of November 1955; Whereas \"Transcontinental Insurance Company\", a company duly authorized to do business in this Province, is the subsisting corporation: Whereas \"United National Indemnity Company\" has complied with the provisions of section 103 of the Quebec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"United National Indemnity Company\" is cancelled as from the 14th of November 1955.Given at the office of the Insurance Branch.Department of Finance, on the 27th of February 1956.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 41906-o Superintendent of Insurance.Notice of cancellation of licence and registration Whereas the Montreal Transport Commission has, in accordance with the provisions of the act 2-3 Elisabeth II, chapter 126, adopted a by-law establishing a pension fund, coming into force on the 1st of March 1956; Whereas under section 4 of the said act, the Montreal Tramways Mutual Benefit Association shall be dissolved for all purposes, as from the date of the coming into force of the said by-law, Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registry of the Montreal Tramways Mutual Benefit Association will be cancelled as from the 1st of March 1956. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 901 Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 29 afévrier 1956.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRANCE, 11906-O Surintendant des assurances.Given at the office of the Insurance Branch.Department of Finance, the 29th of Fcbruarv 1956.For the Minister of Finance of the Province.GEORGES LAFRANCE, 41906-o Superintendent of Insurance.Nominations Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, et par commissions, de faire les nominations suivantes: .Québec, le 15 décembre 1955.Docteur Nathaniel Chassé, médecin-chirurgien à Saint-Jean-Port-Joli, comté de LTslet: coroner conjoint pour le district judiciaire de Montma-gny, avec juridiction seulement sur le district électoral de LTslet.Québec, le 18 janvier 1956.M.Roger Deshaies, avocat, membre du Oarreau de la province de Québec, conseil en loi de la Reine, domicilié en la cité de Grand'Mère : nommé, à compter du 15 février 1956 inclusivement, en vertu de l'article 267 de la Loi des tribunaux judiciaires, juge de district avec domicile et résidence dans la cité des Trois-Kivières et avec juridiction dans toute la province, mais, particulièrement et sans restriction, dans les districts judiciaires des Trois-Rivières et de Nicolet, et pour agir, dans la province, selon l'article 21 de la Loi 1-2 Elizabeth II, chapitre 29, comme magistrat de district en ce qui concerne les juridictions attribuées par les lois du Parlement du Canada aux magistrats de district, que ces juridictions leur soient attribuées sous le titre de \"magistrat\" ou sous celui de Mmagistrat de district\", ledit monsieur Roger Deshaies, vu sa présente nomination par le Lieutenant-gouverneur en conseil comme juge de district, étant en outre autorisé, sous l'autorité du paragraphe b) de l'article 466 du Code criminel, à exercer, à compter du 15 février 195b inclusivement, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI de ce Code criminel.I18S8-0 Appointments His Honour the Lieutenant-Governor, with the consent and andvice of the Executive Council, and by Commission, has been pleased to make the following appointments; Quebec, December 15, 1955.Doctor Nathaniel Chassé, physician and surgeon, at Saint-Jean-Port-Joli, county of LTslet, Joint Coroner for the judicial district of Montmagny, with jurisdiction over the electoral district of LTslet only.Quebec, January 18, 1956.Mr.Roger Deshaies, advocate, member of the Bar of the Province of Quebec, Queen's Counsel, residing in the city of Grand'Mère: appointed, as from February 15, 1950 inclusively, by virtue of section 207 of the Courts of Justice Act, district Judge, with domicile and residence in the city of Trois-Rivières, and with jurisdiction throughout the Province, but more especially and without restriction, in the judicial district of Trois-Rivières and Nicolet, and to act, in the Province, jn accordance with section 21, Act 1 -2 Elizabeth II, chapter 29 as district Magistrate in that which concerns jurisdictions conferred by Acts of the Parliament of Canada upon district magistrates, whether such jurisdictions be conferred under the title of \"magistrate\" or \"district magistrate\", the said Mr.Roger Deshaies, in view of the said nomination by the Lieutenant-Governor in Council as district Judge, being moreover authorized under the authority of paragraph 6) of article 466 of the Cirminal Code, to exercise, as from February 15, 1950 inclusively, the jurisdiction of a magistrate in accordance with Part XVI of said Criminal Code.41888 Sièges sociaux Avis est donné (pie Aero Enterprises Limited constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la Loi des compagnies de Québec, en date du 19 janvier 1950, et ayant son siège social à Montréal, province de Québec, a établi son bureau au N° 31 ouest, rue St-Jacques, à Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 14e jour de février 1956.Le Président, 41890-o P.LARIVIÈRE.\"Harvey & Racine Inc.\" Avis est donné que la Compagnie \"Harvey & Racine Inc.\" constituée en compagnie par lettres patentes acceptées par le Lieutenant-gouverneur Head Offices Notice is hereby given that the Aero Enterprises Limited Company Incorporated by letters patent, on the 19th day of January,.1950, and having its Head Office in the city of Montreal, has established its office at 31 St.James street West.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the Head Office of the Company.Dated at Montreal, this 14th dav of February, 1956.P.LARIVIÈRE, 41890-o President.\"Harvey & Racine Inc.\" Notice is hereby given that the Company \"Harvey & Racine Inc.\", incorporated into a company by letters patent accepted by the 902 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 1956, Tome 88, N° 9 de la province de Québec, en date du dix janvier mil neuf cent cinquante-six (1950) et ayant son bureau principal en la cité de Granby, Québec, a établi son bureau au N° 22 rue Centre, à Granby, Québec.A compter du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Granby, Québec, ce premier février, mil neuf cent cinquante-six.Le Président, 41801-O LESLIE L.HARVEY.Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated January tenth, on thousand nine hundred and fifty-six (1950) and having its head office in the city of Granby, Quebec, as established its office at No.22 Centre street, at Granby, Quebec.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the Company as being its head office.Given at Granby, Quebec, this first day of February, one thousand nine hundred and fifty-six.LESLIE L.HARVEY, 41891 President.Avis est donné que la Cie de Plomberie & Chauffage Suprême Ltée \u2014 Suprême Plumbing & Heating Co.Ltd., constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la Loi des Compagnies de Québec, en date du 18 octobre, 1955 et ayant son principal siège social à Montréal, Province de Québec, a établi son bureau au N° 8027 Boulevard St-Laurcnt, Montréal, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 25ème jour de janvier, 1950.La Présidente, 41892-0 IMELDA ST-HILAIRE.Bli-Biv Uranium & Copper Corporation Limited .(No Personal Liability) Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Bli-Riv Uranium & Copper Corporation Limited (No Personal Liability), constituée en corporation par lettres patentes émises conformément à la Loi des compagnies minières de Québec, le lie jour de mai 1955, ayant son siège social en la cité de Montréal, province âhQuébec, où jusqu'à ce jour, son bureau était situé à 359 ouest, rue St-Jacques, Montréal, l'a transporté à chambre 912, N° 037 ouest, rue Craig, Montréal, Québec.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 21e jour de février 1950.(Sceau) Le Secrétaire, 41895 B.G.MCLAUGHLIN.(P.G.11380-55) Three Hundred Decarie Ltd.Règlement N° 39 \"Que la compagnie, Three Hundred Decarie Ltd., constituée en corporation par lettres patentes émises par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, en date du 24 mai 1955, et, ayant son siège social en la cité de Montréal, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui à la chambre 902 du numéro 60 ouest de la rue St-Jacques, le transporte à partir de ce jour au numéro 757 côte de la Place d'Armes.\" Adopté par les actionnaires le 19 décembre 1955.Pour copie conforme, La Secrétaire, 41908-o JACQUELINE LAPIERRE.Notice is hereby given that La Cie de Plomberie & Chauffage Suprême Ltée \u2014 Suprême Plumbing & Heating Co.Ltd., incorporated by letters patent under the Quebec Companies' Act on the 18th of October, 1955, and having its head office in the Province of Quebec, at Montreal, has established its office at 8027 St.Lawrence Boulevard, Montreal, Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 25th day of Januarv, 1950.IMELDA ST-HILAIRE, 41892-0 President.Bli-Riv Uranium & Copper Corporation Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that Bli-Riv Uranium & Copper Corporation Limited (No Personal Liability), incorporated by letters patent issued pursuant to the Quebec Mining Companies' Act on the 11th day of May 1955, having its head office in the city of Montreal, Province of Quebec, where its office was situated up to today at 359 St.James Street West, Montreal, has moved it to room 912, No.* 637 Craig Street West.Montreal, Quebec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 21st day of February 1956.(Seal) B.G.MCLAUGHLIN, 41895-o Secretary.(A.G.11380-55) Three Hundred Decarie Ltd.By-law No.39 \"That the company, Three Hundred Decarie Ltd., incorporated by letters patent issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated May 24, 1955, and, having its head office in the city of Montreal, where it had its office situated until today in room 902 at number 60 St.James street, west, will have it transferred as from to-day at number 757 Côte de la Place d'Armes.\" Adopted by the shareholders on December 19, 1955.True copy.JACQUELINE LAPLERRE, 41908 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 903 (P.G.10093-50) Suzor Copper Mixes Limited (No Personal Liability) Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Suzor Copper Mines Limited, constituée en corporation par lettres patentes, le 12 janvier 1956, et ayant son bureau à Montréal, aura son adresse à 10080 rue St-Charles, Montréal.'.compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 25e jour de janvier 1950.Suzor Copper Mixes Limited, Le Président.41893 IL A.MARCHESSAULT.Colborne Terminals Limited Avis d'adresse du siège social Avis est donné que la compagnie Colborne Terminais Limited, constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, en date du 20e jour de décembre 1955, a établi son siège social à 1010, rue Common, Montréal, province de Québec.Donné à Montréal, province de Québec, ce 27e jour de février 1956.Ixî Président, 41910 JOAN L.GRAY.Canada, province de Québec, district de Québec \"Les Entreprises Roy Inc.\" La compagnie, \"Les Entreprises Roy Inc.\", a été constituée en corporation dans la province de Québec par lettres patentes accordées le 28 septembre 1955.Sa principale place d'affaires dans la province de Québec est au numéro 825 Est, Boulevard (barest, Québec, P.Q.Le Président, .4191 l-o (Signé) R.ROY.(P.G.6310-46) Lin dys Recreation Inc.Règlement N° 11 concernant le changement du bureau principal de Lindy's Recreation Inc.Le bureau principal de la compagnie \"Lindy's Recreation Inc.\", est transporté de Montréal où il était auparavant au numéro 322 Chemin St-Charles, Greenfield Park.Certificat Copie certifiée du règlement N° 11, dûment adopté à une assemblée des directeurs tenue le deuxième jour du mois de février 1956, et approuvé à l'unanimité à une assemblée générale spéciale de la compagnie tenue le deuxième jour du mois de février 1956, par les membres étant tous présents.(Sceau) Le Secrétaire, 41933-0 R.GRIFFITH.(A.G.10093-50) Suzor Copper Mines Limited (Xo Personal Liability) Notice is hereby given that Suzor Copper Mines Limited, incorporated by letters patents of January 12, 1950, having its office in Montreal, will, in the future, have its adress at: 10080 St.Charles Street, Montreal.From and after the date of this notice, this said office will be considered by the company as being the Head Office of the Company.Dated at Montreal, this 25th of January, 1950.Suzor Copper Mines Limited, H.A.MARCHESSAULT.41893-0 President.Colborne Terminals Limited Notice of address of head office Notice is given that Colborne Terminals Limited, incorporated by letters patent issued pursuant to Part I of the Quebec Companies' Act and bearing date the 20th day of December, 1955, has established its head office at 1010 Common street, Montreal, Province of Quebec.Given at Montreal, Province of Quebec, this 27th day of February, 1950.JOAN L.GRAY, 41910-o \u2022 President.Canada, Province of Quebec, district of Quebec \"Les Entreprises Roy Inc.\" The company, \"Les Entreprises Roy Inc.\", was incorporated in the Province of Quebec by letters patent issued on September 28, 1955.Its head office in the Province of Quebec is at number 825 ('barest Boulevard, East.Quebec, P.Q.(Signed) R.ROY, 41911 President.(A.G.6310-46) Lindys Recreation Inc.By-law No.11 concerning the changing of the principal office of Lindy's Recreation Incorporated.The head office of \"Lindy's Recreation Inc.\", is transferred from Montreal where it was previously to Greenfield Park, 322 St.Charles Road.Certificate Certified copy of by-law No.11 duly adopted at the meeting of the directors held the second day of February 1956 and unanimously approved at a special general meeting of the company held the second day of February 1956 by the members being all present.(Seal) R.GRIFFITH, 41933-0 Secretary. 904 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 3 mars 1956, Tome 88, N° 9 Soumissions Tenders Province de Québec Ville de Sainte-Rose (Comté de Laval) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, L.Labonvillc, secrétaire-trésorier, C.P.890, Hôtel de Ville, 210, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, comté de Laval, jusqu'à 8.30 heures p.m., lundi, le 19 mars 1956.pour l'achat de §780,000.00 d'obligations de la ville de Sainte-Rose, comté de Laval, datées du 1er avril 1950 et remboursables par séries du 1er avril 1957 au 1er avril 1970 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% de 1957 à 1901 inclusivement, non inférieur à 33-^% de 1902 à 1976 et non supérieur à 4J^% par année payable semi-annuellement les lei avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements d'emprunt Nos 317 \u2014 875,000.00 \u2014 travaux d'égouts; 327 \u2014 SI05.000.00 \u2014 travaux d'égouts; 334 \u2014 S105.000.00 travaux d'égouts et d'aqueduc; 33S \u2014 830,000.00 acquisition d'outillage; 339 \u2014 8105,000.00 \u2014 travaux d'égouts et de pavage; et 344 \u2014 8300,000.00 \u2014 construction de trottoirs et travaux de pavage.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er avril 1950.Le tableau d'amortissement est le suivant : Tableau d'amortissement \u2014 $780,000.00 \u2014 20 ans.Année Capital 1er avril 1957.S 10,000.00 1er avril 1958.10,000.00 1er avril 1959.10,000.00 1er avril 1960.5,000.00 1er avril 1961.15,000.00 1er avril 1962.20,000.00 1er avril 1963.20,000.00 1er avril 1964.20,000.00 1er avril 1965.25,000.00 1er avril 1966.25,000.00 1er avril 1967.30,000.00 1er avril 1968.30,000.00 1er avril 1909.40,000.00 1er avril 1970.45,000.00 1er avril 1971.50,000.00 1er avril 1972.55,000.00 1er avril 1973.05,000.00 1er avril 1974.105,000.00 1er avril 1975.100,000.00 1er avril 1976.110,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les igations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Sainte-Rose, comté de Laval.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'à la succursale de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Province of Québec Town of St.Rose (County of Laval) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned J.Labonville, Secret nry-Treasurer, P.B.890, City Hall, 210 St.Rose Boulevard, St.Rose, county of Laval, until 8.30, o'clock p.m., Monday, March 19, 1956, for the purchase of an issue of 8780,000.00 of bonds of the town of St.Rose, county of Laval, dated April 1st, 1950, and redeemable serially from April 1st, 1957 to April 1st, 1970 inclusively, with interest at a rate of not less than 3% from 1957 to 1901 inclusive, not less than 3j-^% from 1902 to 1970, and not more than 4J4% I^r annum payable semi-annually on April 1st, and October 1st, of each year.The rale of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-laws Nos.317 \u2014 S75.000.00 Sewage; 327 \u2014 8105,000.00 \u2014 sewage; 331 SI05.000.00 \u2014 sewage and waterworks; 338 \u2014 S30.000.00 \u2014 acquisition of equipment ; 339 \u2014 SI05.000.00 \u2014 sewage and paving; and 344 \u2014 S300.000.00 \u2014 building of sidewalks and paving.For adjudication purposes only; interest shall be calculated as from April 1st, 1950.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 S780.000.00 \u2014 20 yean.Year Capital April 1st, 1957.S 10,000.00 April 1st, 1958.10,000.00 April 1st, 1959.10,000.00 April 1st, 1960.5,000.00 April 1st, 1961.15,000.00 April 1st, 1902.20,000.00 April 1st, 1903.20,000.00 April 1st, 1904.20,000.00 April 1st, 1905.25,000.00 April 1st, 1966.25,000.00 April 1st, 1907.30,000.00 April 1st, 1968.30,000.00 April 1st, 1909.40,000.00 April 1st, 1970.45,000.00 April 1st, 1971.50,000.00 April 1st, 1972.55,000.00 April 1st, 1973.05,000.00 April 1st, 1974.105,000.00 April 1st, 1975.110,000.00 April 1st, 1970.110,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at St.Rose, county of Laval.Capital and interest are payable at all branches, in the Province of Quebec, of the bank mentioned in the loan procedure, as well as the branch of said bank at Toronto.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 905 Chaque soumission devra être accompagnée rl'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 19 mars 1950, à 8.30 heures p.m., en l'Hôtel de Ville, 210, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, comté de Laval.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sainte-Rose,.(comté de Laval), ce 28 février 1950.Le Secrétaire-trésorier, L.LABONVILLE.CP.890, Hôtel de Ville.210, Boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, (Comté de Laval), P.Q.41928-o Province de Québec Les Commissaires d'écoles pour la Municipalité du village de Saint-Dominique (Comté de Bagot) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussignée, Mme Lionel Loiselle, St-Dominique, comté de Bagot, jusqu'à 8.15 heures p.m.jeudi, le 22 mars 1956, pour l'achat de $117.000.00 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Saint-Dominique, comté de Bagot, datées du 1er février 1956 et remboursables par séries du 1er février 1957 au 1er février 1976 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4}4% par année payable semi-annuellement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 12 décembre 1955 \u2014 Construction d'une école primaire élémentaire.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er avril 1956.Le tableau d'amortissement est le suivant: Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday, March 19, 1956, at 8.30 o'clock p.m., at the Citv Hall, 210 St.Rose Boulevard, St.Rose, county of Laval.The Council is not bound to accept the highest or any of the tenders.St.Rose, (County of Laval), this Fcbruarv 28, 1956.L.LA BONVILLE, Secret arv-Treasu rer.P.B.890, City Hall, 216 Boulevard St.Rose, St.Rose, (County of Laval), P.Q.41928 Province of Quebec School Commissioners for the Municipality of the village of St.Dominique (County of Bagot) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Mrs.Lionel Loiselle, St.Dominique, county of Bagot.until 8.15 o'clock p.m.Thursday.March 22.1950, for the purchase of an issue of SI 17,000.00 of bonds of the School Commissioners for the municipality of the village of St.Dominique, county of Bagot, dated February 1st, 1956 and redeemable serially from February 1st.1957 to February 1st, 1970, inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4^% per annum, payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated December 12, 1955 \u2014 Erection of a primary elementary school.For purposes of adjudication only, computation of interest shall be made as from April 1st, 1956.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 SU Année 1er février 1957.1er février 1958.1er février 1959.1er février 1900.1er février 1901.1er février 1962.1 er février 1963.1er février 1964.1er février 1905.1er février 1966.1er février 1967.1er février 1968.1er février 1969.1er février 1970.1er février 1971.1er février 1972.1er février 1973.1er février 1974.1er février 1975.1er février 1976.',000.00 \u2014 20 ans \tCapital\t x\tSI 0,000\t00 x\t10,500\t00 \t17,500\t00 \t18,000\t00 x\t19,000\t00 \t1,500\t00 \t1,500\t00 \t1,500\t00 \t1,500\t00 \t2,000\t00 \t2,000\t00 \t2.000\t00 \t2,000\t00 \t2,000\t00 \t2,000\t00 \t2,000\t00 \t2,500\t00 \t2,500\t00 \t2,500\t00 \t2,500\t00 Table of redemption \u2014 8117,000.00 \u2014 20 years Year Capital February 1st.1957.x 810.000.00 February 1 St.1958.x 10,500.00 February 1 st.1959.x 17.500.00 February 1 st.1960______ x 1 S.000.00 February 1st, 1901.x 19.000.00 February 1 st, 1902.* 1.500.00 February 1 st, 1903.1,500.00 February 1 st, 1904.1.500.00 February 1st, 1965.1,500.00 February 1 st, 1966.2,000.00 February 1st, 1907.2.000.00 February 1st, 1908.2,000.00 February 1st.1969.2.000.00 February 1st, 1970.2.000.00 February 1st, 1971 .2.000.00 February 1st, 1972.2.000.00 February 1 st, 1973.2,500.00 February 1st, 1974.2,500 00 February 1st, 1975.2.500.00 February 1st, 1976.2,500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles The letters \"x\" indicate the years during which les versements annuels d'un octroi total de annual payments of a total amount of 890,000.00 S90,000.00 accordé par le Secrétaire de la pro- granted by the Provincial Secretary and payable vinceet payable en cinq versements de S18.000.00 in five instalments of SI 8.000.00 each, from 1957 906 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 chacun, de 1957 à 1901 inclusivement, seront reçus et appliques au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Saint-Dominique, comté de Hagot.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec, à Saint-Hyacinthé ou à Saint-Dominique, comté de Bagot.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue jeudi, le 22 mars 1950, à 8.15 heures p.m., dans le soubassement de l'église, Saint-Dominique, comté de Bagot.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Dominique, (Comté de Bagot).ce 28 février 1950.La Sécrétai rc-trésorière, Mme LIONEL LOISELLE.Saint-Dominique, (Comté de Bagot), P.Q.41927-0 to 1901 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at St.Dominique, county of Bagot.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec, St.Hyacinthe or at St.Dominique, county of Bagot.The said bonds arc.under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941.subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Thursday, March 22, 1950, at 8.15 o'clock p.m., in the basement of the church.St.Dominique, county of Bagot.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St.Dominique, (County of Bagot).February 28, 1950.Mrs.LIONEL LOISELLE.Secretary-Treasurer.St.Dominique.(County of Bagot), P.Q.41927 .Province de Québec Ville de Chibougamau (Comté d'Abitibi-Est) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Jean-Marie Couture, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, Chibougamau, comté d'Abitibi-Est, jusqu'à 8.00 heures p.m., lundi, le 19 mars 1956, pour l'achat de 8200,000.00 d'obligations de la ville de Chibougamau, comté d'Abitibi-Est, datées du lejr avril 1956 et remboursables par séries du 1er avril 1957 au 1er avril 1976 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 414% Par année payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement d'emprunt N° 11\u2014Organisation d'un réseau électrique.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er avril 1956.La tableau d'amortissement est le suivant : Province of Quebec Town of Chibougamau (County of Abitibi-East) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Jean-Marie Couture, Secretary-Treasurer, Town Hall, Chibougamau, county of Abitibi-East, until 8.00 o'clock p.m.Monday, March 19, 1956, for the purchase of an issue of 8200,000.00 of bonds of the town of Chibougamau, county of Abitibi-East, dated April 1st, 1956, and redeemable serially from April 1st, 1957, to April 1st, 1976 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4%% per annum, payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-law No.11\u2014Organization of an electrical system.For purposes of adjudication only, computation of interest shall be made as from April 1st, 1956.The table of redemption is as follows: Tableau d'amortissement \u2014 $200,000.00 \u2014 20 am Table of redemption \u2014 5200,000.00 \u2014 20 years Année Capital Year Capital 1er avril 1957.S 6,500.00 April 1st, 1957.$ 6,500.00 1 er avril 1958.6,500.00 April 1 st, 1958 .6,500.00 1er avril 1959.7,000.00 April 1st, 1959 .7,000.00 1 er avril 1960.7,000.00 April 1 st, 1960 .7,000.00 1er avril 1961 .7,500.00 April 1st, 1961.7,500.00 1er avril 1962.8,000.00 April 1st, 1962.8,000.00 1 er avril 1963.8,000.00 April 1 st, 1963.8,000.00 1er avril 1964.8,500.00 April 1st, 1964 .8,500.00 1 er avril 1965.9,000.00 April 1 st, 1965.9,000.00 1er avril 1966 .9,500.00 April 1st, 1966 .9,500.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 907 1er avril 1907.10,000.00 1er avril 1908.10,500.00 1er avril 1969.11,000.00 1er avril 1970.11,500.00 1er avril 1971.12.000.00 1er avril 1972.12,500.00 1er avril 1973.13,000.00 1er avril 1974.13,500.00 1er avril 1975.14,000.00 1er avril 1970.14.500.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, pavablc au pair à Chibougamau, comté d'Abitibi-Est.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1911, être rachetées par anticipation, en toutou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 19 mars 1956, à 8.00 heures p.m., en l'Hôtel de Ville.Chicougamau, comté d'Abitibi-Est.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Chibougamau, (Comté d'Abitibi-Est).ce 27 février 1956.Le Secrétaire-trésorier, JEAN-MARIE COUTURE.Hôtel de Ville, Chibougamau, (Comté d'Abitibi-Est), P.Q.41926-o April 1st, 1967.10,000.00 April 1st, 1968.10,500.00 April 1st, 1909.11.000.00 April 1st, 1970.11,500.00 April 1st, 1971.12,000.00 April 1st.1972.12.500.00 April 1st.1973.13,000.00 April 1st, 1974.13,500.00 April 1st, 1975.14.000.00 April 1st, 1970.14,500.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any.by certified cheque payable at par at.Chicougamau, county of Abitibi-East.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds are.under the authoritv of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is oncluded or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to he held on Mondav, March 19, 1950.at 8.00 o'clock p.m., at the Town Hall, Chibougamau, county of Abitibi-East.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Chibougamau, (County of Abitibi-East), February 27.1956.JEAN-MARIE COUTURE, Secretary-Treasurer.Town Hall, Chibougamau, (County of Abitibi-East), P.Q.41926 Province de Québec Les Commissaires d'Écoles pour la Municipalité de la cité de St-Hyacinthe (Comté de St-Hyacinthe) Avis public est par les présentes donné que «les soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Jacques Lafontaine, secrétaire-trésorier, jusqu'à 7.30 hrs p.m.à 1695 rue Girouard, Édifice Caisse Populaire, St-Hyacinthe, Québec, ou jusqu'à 8.00 hrs.p.m., à l'Hôtel de Ville, 700 rue de l'Hôtel de Ville, St-Hyacinthe, Québec, mardi, le 20 mars 1956, pour l'achat de $310,000 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de la cité de St-Hyacinthe, comté de St-Hyaçinthe, datées du 1er février 1956 et remboursables par séries du 1er février 1957 au 1er février 1976 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur 11 4^2% par année payable semi-annuellement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 14 novembre 1955 approuvée par le Secrétaire de la province le 10 février 1956 \u2014 Construction de deux écoles élémentaire de huit classes chacune.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er avril 1956.Le tableau d'amortissement est le suivant: Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of the city of St-Hyacinthe (County of St.Hyacinthe) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Jacques Lafontaine, Secretary-Treasurer, until 7.30 o'clock p.m., at 1695 Girouard street, Caisse Populaire Building, St.Hyacinthe, or until at the town Hall, 700 town Hall street, St.Hyacinthe, until 8.00 o'clock p.m., Tuesday, Marcy 20, 1956, for the purchase of an issue of $310,000 of bonds of the School Commissioners or the municipality of the city of St.Hyacinthe, county of St.Hyacinthe dated February 1st, 1956 and redeemable serially from February 1st, 1957 to February 1st, 1976 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4J^% per annum, payable semi-annually on February 1 and August 1st of each year.The rate of interest may be same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution dated November 14, 1955.approved by the Provincial Secretary on February 10, 1956 \u2014 Erection of two elementary school of eight classrooms each.For purposes of adjudication only, interest shall be calculated as from April 1st, 1956.The table of redemption is as follows: 908 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 Tableau d'amortissement \u2014 $310,000.00 \u2014 20 ans.Année Capital 1er février 1957.x $37,000.00 1 er février 1958.x 38,500.00 1 er février 1959.x 40,000.00 1er février 1900.x 41,500.00 1er février 1901.x 43,500.00 1er février 1962.5,500.00 1er février 1963.5,500.00 1er février 1904 .0,000.00 1er février 1965.6,000.00 1er février 1966.6,500.00 1er février 1967.6,500.00 1er février 1968.7,000.00 1er février 1969.7,000.00 1er février 1970.7,500.00 1er février 1971 .8,000.00 1er février 1972.8,000.00 1er février 1973.8,500.00 1er février 1974.9,000.00 1er février 1975.9,000.00 1er février 1970 .9,500.00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de $200,000, accordé par le Secrétaire de la province et payable en cinq versements de $40.000 chacun, de 1957 à 1901 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Hyacinthe, Québec.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec, à St-Hyacinthe, ainsi qu'à la succursale de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 20 mars 1956, à 8.00 heures p.m., en l'Hôtel de Ville, 700, rue de l'Hôtel de Ville, St-Hyacinthe, Québec.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Hyacinthe, ce 27 février 1950.Le Secrétaire-trésorier, JACQUES LAFONTAINE.adresse postale: 1095 rue Girouard, Edifice Caisse Popidaire, St-Hvacinthc, P.Q.41914-0 Table of redemption \u2014 $310,000.00 \u2014 20 years.Year Capital February 1st, 1957.x $37,000.00 February 1 st, 1958.x 38,500.00 February 1st, 1959.x 40,000.00 February 1st, 1900.x 41,500.00 February 1st, 1961.x 43,500.00 February 1 st, 1962.5,500.00 February 1st, 1963.5,500.00 February 1st, 1904.0,000.00 February 1 st, 19G5.0,000.00 February 1st, 1906.6,500.00 February 1 st, 1967.6.500.00 February 1 st, 1908.7,000.00 February 1st, 1969.7,000.00 February 1st, 1970.7,500.00 February 1st, 1971 .8,000.00 February 1st, 1972.8,000.00 February 1st, 1973.8,500.00 February 1 st, 1974 .9,000.00 February 1st, 1975.9,000.00 February 1st, 1976.9,500.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $200,000, granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of 840,000 each, from 1957 to 1901 inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at St.Hyacinthe, Quebec.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal.Quebec, St.Hyacinthe, as well as at the branch of the said bank in Toronto.The said bonds are, under the authority of chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1911.subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, March 20th, 1950, at 8.00 o'clock p.m.at the Town Hall, 700 Town Hall street, St.Hyacinthe, Quebec.The school Commissioners, do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St-Hyacinthe, February 27, 1956.JACQUES LAFONTAINE, Secretary-Treasu rer.Postal address: 1695 Girouard street, Caisse Populaire Building, St.Hvacinthc, P.Q.41914 Province de Québec Ville de Mackayville (Comté de Chambly) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, Henri Brabant, secrétaire-trésorier, 1959 Boule- Province of Quebec Town of Mackayville (County of Chambly) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Henri Brabant.Secretary-Treasurer, 1959 Edouard Boulevard QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 909 vard Edouard, Hôtel de Ville, Mackayville, comté de Chambly, jusqu'à 8.00 heures p.m., mardi, le 20 mars 1950, pour l'achat de $145,000.00 d'obligations de la ville de Mackayville, comté de Chambly, datées du 1er avril 1956 et remboursables par séries du 1er avril 1957 au 1er avril 1976 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4%% par année payable semi-annuellcment les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements d'emprunt Nos 57 \u2014 $35,000.00 \u2014 service de l'eau aux écoles; 59 \u2014 $35,000.00 \u2014 éclairage de rues; et 00 \u2014 $75,000.00 \u2014 nouvel hôtel de Ville.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er avril 1956.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $145,000.00 \u2014 20 ans Armée Capital 1er avril 1957.$ 2,000.00 1er avril 1958.2,000.00 1er avril 1959.2,000.00 1er avril 1900.3,000.00 1er avril 1961.3,000.00 1er avril 1902.3,000.00 1er avril 1903.3,000.00 ¦ 1er avril 1904.3,000.00 1er avril 1965.3,000.00 1er avril 1966.3,000.00 1er avril 1967.3.000.00 1er avril 1908.3,500.00 1er avril 1909.3,500.00 1er avril 1970.3,500.00 1er avril 1971.4,000.00 1er avril 1972.4,000.00 1er avril 1973.4,500.00 1er avril 1974.4,500.00 1er avril 1975.4,500.00 1er avril 1976.83,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Mackayville, comté de ( 'hambly.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 20 mars 1950, à 8.00 heures p.m., en l'Hôtel de Ville, 1959 Boulevard Edouard, Mackayville, comté de Chambly.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Mackayville, (Comté de Chambly), ce 29 février 1956.Le Secrétaire-trésorier, HENRI BRABANT.Hôtel de Ville, 1959 Blvd Edouard, Mackayville, (Comté de Chambly), P.Q.41935-0 Town Hall, Mackayville, county of Chambly, until 8.00 o'clock p.m., Tuesday, March 20, 1956, for the purchase of an issue of $145,000.00 of bonds of the town of Mackayville, county of Chambly, dated April 1st, 1956 and redeemable serially from April 1st, 1957 to April 1st, 1976 inclusively, with interest at a rate not less than 3 % nor more than 4>£ % per annum, payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan by-laws Nos.57 \u2014 $35,000.00 \u2014 Water service to schools; 59 \u2014 $35,000.00 \u2014 Street lighting; and 60 \u2014 $75,000.00 \u2014 new town hall.For purposes of adjudication only, interest shall be computed as from April 1st, 1956.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $145,000.00 \u2014 20 years Year Capital April 1st, 1957.$ 2,000.00 April 1st, 1958.2,000.00 April 1st, 1959.2,000.00 April 1st, 1960.3,000.00 April 1st, 1961.3,000.00 April 1st, 1902.3,000.00 April 1st, 1963.3,000.00 April 1st, 1964 .3,000.00 April 1st, 1965.3,000.00 April 1st, 1966.3,000.00 April 1st, 1967 .3,000.00 April 1st, 1968 .3,500.00 April 1st, 1969.3,500.00 April 1st, 1970 .3,500.00 April 1st, 1971.4,000.00 April 1st, 1972.4,000.00 April 1st, 1973.4,500.00 April 1st, 1974 .4,500.00 April 1st, 1975.4,500.00 April 1st, 1976.83,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Mackayville, county of Chambly.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.' The tenders, will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Tuesday, March 20, 1956, at 8.00 o'clock p.m., at the Town Hall, 1959 Edouard Boulevard, Mackayville, county of Chambly.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Mackayville, (County of Chambly), February 29th, 1956.HENRI BRABANT, Secretary-Treasurer.Town Hall, 1959 Edouard Boulevard, Mackayville, (Co.Chambly), P.Q.41935 910 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 Vente \u2014 Loi de faillite Canada, Province de Québec, district de Québec, Cour Supérieure, (En Matière de Faillite).Dans l'affaire de la faillite de: Jean-Louis St-Gelais, hôtelier, (Hôtel Bellevuc) 131, Boulevard Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré, coin-té de Montmorency, débiteur; - AVIS DE VENTE Avis est par les présentes donné que : JEUDI, le CINQ AVRIL 1950, à 2.00 heures p.m.seront vendus par encan public, sur les lieux à la place d'affaires du débiteur, 131, Boulevard Ste-Anne à Ste-Anne-de-Beaupré, les item ci-après : Item A) Fonds de commerce de restaurant, $833.82.Item B) Ameublement, installation et ustensiles de restaurant, de l'hôtel, des motels, etc., $13.995.22.Item C) Caisse-enregistreuse National (lien $118.25) $500.00.Item D ) Enseigne \"Néon\" (lien $275.00) $400.00.Item E) Un magnifique terrain situé sur le Boulevard Ste-Anne.à Ste-Anne-de-Beaupré, comté de Montmorency, avec un hôtel et motels dessus construits; le tout décrit comme suit: \"Le lot N° trois de la subdivision treize du lot originaire cent quatre-vingt-quatre (184-13-3) du cadastre officiel du village de Ste-Anne-de-Beaupré, mesurant cent cinq pieds de front (105') par toute la profondeur qu'il y a entre le Boulevard Ste-Anne et le fleuve St-Laurent, à marée basse, avec toutes bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances et sujet aux servitudes qui peuvent exister\".Les item (A, C et D) seront offerts en vente au plus haut et dernier enchérisseur.L'item (B) sera offert en vente en bloc et si le prix n'est pas trouvé suffisant, cet item sera vendu par lots et en détail.L'item (E) sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes et répartitions d'église pouvant exister ainsi qu'aux servitudes actives et passives.Les titres, certificats ainsi que l'inventaire peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux des Syndics soussignés.Cette vente est faite conformément aux articles 710, 717 et 719A du C.P.C.et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite 1949.Cette vente équivaut à la vente faite par le Shérif.Conditions de paiement: argent comptant.Québec, ce 24 février 1950.Les Syndics, R.ERNEST LEFAIVRE, JOSEPH MARMETTE & RENÉ LEFAIVRE.111, Côte de la Montagne, Québec.41915-9-2-0 Ventes par licitation Canada, Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de Sale \u2014 Bankruptcy Act Canada, Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court, sitting in Bankruptcy.In the matter of Bankruptcy of Jean-Louis St-Gclais, hotel-keeper, (Hôtel Bellevue), 131 St.Ann Boulevard, St.Anne-de-Beaupré, county of Montmorency, debtor.NOTICE OF SALE Notice is hereby given that: THURSDAY, the FIFTH day of APRIL 1906, at TWO o'clock p.m., shall be sold by public auction on the premises of the Debtor's place of business, 131 St.Ann Boulevard, at St.Anne-de-Beaupré, the following items: Item A) Stock-in-trade of restaurant, $833.82.Item B) Furniture, installations and utensils of restaurant, hotel, motels, etc., $13,995.22.Item C) National cash-register (lien of $118.25).$500.00.Item D) Neon sign (lien of $275.00).$400.00.Jtem E) A beautiful piece of land situated on St.Ann Boulevard, at St.Anne-de-Beaupré, county of Montmorency, withhotel and motels erected thereon; all of which described as follows: \"Lot No.three of subdivision thirteen of original lot one hundred and eighty-four (184-13-3) of the official cadastre of the village of St.Anne-de-Beaupré, measuring one hundred and live feet in front (105') by all the depth that exis the between St.Ann Boulevard and the River St.Lawrence, at low tide, with all buildings erected thereon, circumstances and dependencies, subject to the servitudes which may be attached thereto\".Items (A, C and D) shall be offered for sale to the last and highest bidder.Item (B) shall be offered for sale \"en bloc\" and if the price is not sufficient, said item shall be sold in lots or retailed.Item (E) shall be offered for sale to the last and highest bidder subject to rents and Church apportionments if any as well as servitudes both active and passive, Titles and certificates as well as the invetory may be examined at all times by applying to the offices of the undersigned Trustees.This sale is made pursuant to articles 710, 717 and 719A of C.C.P.and section 55 of the Bankruptcy Act 1949.This sale shall have the same effect as a sale by Sheriff.Conditions: Cash.Quebec, Febmarv 24, 1956.R.ERNEST LEFAIVRE, JOSEPH MARMETTE & RENE LEFAIVRE, Trustees.Ill Mountain Hill, Quebec.41915-9-2 Sales by Licitation Canada, Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court.NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that under and by QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 911 la Cour supérieure, siégeant à Montréal, dans le district de Montréal, le 17 février 1956, dans une cause dans laquelle Henri Girard, employé civique, de la ville de Lévis, district de Québec, est demandeur, Armand Girard, Dame Germaine Girard, épouse séparée de biens de Ubald Lespé-rance, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes: Mlle Fernande Girard, célibataire majeure; Dame Antoinette Girard,, épouse séparée de biens de Émilien Dagcnais, et ce dernier pour autoriser son épouse aux fins des présentes; et ledit Émilien Dagenais es-qual.de curateur à Emile Girard, interdit, tous des cité et district de Montréal, sont défendeurs, et le Trust General du Canada, en sa qualité d'agent financier de Émilien Dagenais, curateur de Emile Girard, des cité et district de Montréal, est mis-en-cause, ordonnant la licitation de certains immeubles désignés comme suit, savoir: \"Un emplacement composé de deux lots de terre situés sur la rue Mont-Royal est, en la cité de Montréal, connus et désignés sous les numéros six cent soixante-treize et six cent soixante-quatorze de la subdivision du lot connu et désigné sous le numéro trois cent trente-neuf des plan et livre de renvoi officiels du cadastre du village de la Côte St-Louis (Nos 339-673 et 674) avec maison et autres bâtisses dessus construites; à distraire cependant desdits lots la portion d'iceux expropriés pour l'élargissement de la rue Mont-Royal.\" Les immeubles ci-dessus désignés seront mis à l'enchère et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur le QUATRIÈME jour d*AVRIL 1956, Cour tenante à DIX heures ET TRENTE a.m., dans la salle d'audience du Palais de justice de Montréal, chambre N° 31 ou toute autre chambre qui pourrait être indiquée par le Tribunal, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de ladite Cour; et que toute opposition à fin d'annuler, à la fin de charge ou à fin de distraire à la dite licitation, devra être déposée au greffe du pronotaire de ladite Cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et, à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.Lesdits immeubles seront vendus \"en bloc\" comme étant une seule et même exploitation, suivant jugement de cette honorable Cour en date du 23 février 1956.Tout enchérisseur devra au préalable consigner la somme de $10,000.00 entre les mains du protonotaire.Montréal, le 22 février 1956.Le Procureur du demandeur, 41880-8-2-o CHARLES H.DESJARDINS.Province de Québec, district de Montréal, Cour supérieure, 383,944, Marguerite McGregor, demanderesse, vs Jacques McGregor et al, défendeurs.AVIS DE LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour supérieure siégeant à Montréal, dans le district de Montréal, et rendu par l'honorable juge Hector Perrier, le 7 février 1950, dans une cause dans laquelle Marguerite McGregor, ménagère, des cité et district de Montréal, épouse con- virtuc of a judgment of the Superior Court sitting at Montreal, in the district of Montreal, on the 17th day of February 1956, in a cause in which Henri Girard, civic employee, of the town of Levis, district of Quebec, is plaintiff; Armand Girard, Dame Germaine Girard, wife separate as to property of Ubald Lespérance, and the latter to authorize his wife to these presents: Miss Fernande Girard, unmarried and of the full age of majority; Dame Antoinette Girard, wife separate as to property of Émilien Dagenais, and the latter to authorize his wife to these presents; and the said Émilien Dagenais es-qual.of curator of Emile Girard, interdicted, all of the city and district of Montreal, are defendants, and the General Trust^f Canada, in his quality of financial agent of Emilien Dagenais, curator of Emile Girard, of the city and district of Montreal, is mis-en-causc, ordering the licitation of certain immoveables described as follows, to wit: \"An emplacement consisting of two lots of land situated on Mount Royal St., East, in the city of Montreal, known and designated as numbers six hundred and seventy-three and six hundred and seventy-four of the subdivision of the lot known and designaged under the number three hundred and thirty-nine upon the official plan and book of reference of the cadastre of the village of Cote St.Louis (Nos.339-673 and 674) together with the dwelling and other buildings erected thereon; however, having withdrawn from these said lots, the part thereof expropriated for widening Mount Royal St.\" The properties above described will be put up to auction and adjudged to the last and highest bidder on the FOURTH dav of APRIL 1956, sitting the Court, at A HALF PAST TEN o'clock a.m., in the court room of the Court House in Montreal, Room No.31, or any other room as may be designated by the Court, subject to the charges, clauses and conditions contained in the list of charges, deposited in the office of the prothonotary of the said Court; and that any opposition to annul, to secure charges, or to withdraw, to be made to the said licitation, must filed in the office of the prothonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale ami adjudication, and that any apposition for payment must be filed within six days after the adjudication; and failing the parties to file such oppositions, within the delays hereby limited they will be foreclosed from so doing.The said properties will be sold \"en bloc\" as though they were a one and only undertaking in accordance with the judgment of the Superior Court rendered in this case on February 23rd 1956.Eevery bidder must beforehand deposit the sum of $10,000.00 in the hands of the prothonotary.Montreal, February 22nd 1956.CHARLES H.DESJARDINS, 41880-8-2-o Attorney for the plaintiff.Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, N° 383,944, Marguerite McGregor, Plaintiff, vs Jacques McGregor et al, defendants.NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court sitting in Montreal, in the district of Montreal, and rendered by the Honourable Justice Hector Perrier, on the 7th day of February 1950, in a case in which Marguerite McGregor, housewife, of the city and district 912 d.iZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S mars 1956, Tome 88, N° 9 tractuellemcnt séparée de biens de Antoine Pilon, facteur, du même endroit, et ce dernier en autant que besoin est pour assister et autoriser son épouse aux fins des présentes, est demanderesse, et Jacques McGregor, Roger McGregor, Jean Pierre McGregor.Mariette McGregor, épouse commune en biens de Matthew Montemiglio, et ce dernier en autant que besoin est pour assister et autoriser son épouse aux fins des présentes, tous cinq des cité et district de Montréal, et Lucie McGregor, épouse commune en biens^de René Rondeau et ce dernier en autant que besoin est pour assister et autoriser son épouse aux fins des présentes, tous deux ce McMnsterville, district de Richelieu, et Cécile McGregor, tie Repcntigny, district de Joliette, veuve de LucierTlioisscau, en son vivant du même endroit, Jules McGregor, de St-Odilon, district des Trois-Rivières, et Charles-Emile Bruchési en sa qualité de curateur public, des cité et district de Montréal, curateur à la succession vacante de feu Georges McGregor et à la succession vacante de feu Dame Gcorgiana McGregor, sont défendeurs, ordonnant la licitation de l'immeuble désigné comme suit: \"L'emplacement situé sur la rue Chatham, en la cité de Montréal, connu et désigné comme étant la partie nord-ouest du lot de terre connu et désigné sous le numéro deux cent vingt (Ptie N.O.220) des plan et livre de renvoi officiels du quartier Saint-Antoine, en la cité de Montréal, mesurant cinquante pieds de largeur par cent trente et un pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, et borné en front par la me Chatham, en arrière par le lot N° 210 et partie du lot 215, d'un côté au nord-ouest, par le lot 218 et 219 et de l'autre côté, au sud-est par le résidu dudit lot 220 des plan et livre de renvoi officiels du quartier St-Antoine; avec droit de passage en commun dans la partie sud-est du lot numéro 219 tel qu'établi par un acte d'accord intervenu aux minutes du notaire W.B.S.Reddy.le dix mars mil huit cent quatre-vingt-seize et enregistré au bureau d'enregistrement de Montréal-ouest, sous le numéro 128070, avec bâtisse y érigée et portant les numéros civiques 840, 842, 844, 840 et 848 de la nie Chatham à Montréal\".L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, le VINGT-HUIT MARS 1950, à DIX heures et TRENTE de l'avant-midi, à la salle d'audience N° 31 au Palais de Justice de Montréal ou à toute autre salle, tel que requis par les circonstances, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du Protonotaire de la Cour supérieure, et toute opposition afin d'annuler, afin de charge, ou afin de distraire à la dite licitation devra être déposée au greffe du Protonotaire de la dite Cour au moins 12 jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication et toute opposition afin de conserver devra être déposée dans les 8 jours après l'adjudication; et à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par les présentes, elles seront forcloses du droit de le faire.Un dépôt de deux mille dollars (82,000.00) sera exigé avant la vente de tout offrant ou enchérisseur.Montréal, le 21 février 1950.Les procureurs de la demanderesse, DURANLEAU, DUPRÉ et DURANLEAU.41881-8-2-o of Montreal, wife contractually separated as to property of Antoine Pilon, Postman, of the same place, and the latter as need be to assist and authorize his wife for the purposes of these presents, is Plaintiff, and Jacques McGregor, Roger McGregor, Jean Pierre McGregor, Mariette McGregor, wife common as to property of Matthew Montemiglio, and the latter as need be to assist and authorize his wife for the purposes of these presents, all five of the city and district of Montreal, and Lucie McGregor, wife common as to property of René Rondeau and the latter as need be to assist and authorize his wife for the purposes of these presents, both of McMasterville.District of Richelieu, and Cécile McGregor, of Repcntigny, district of Joliettc, widow of Lucien Boisseau, in his lifetime of the same place, Jules McGregor, of St.Odilon.district of Trois-Rivic-' res, and Charlcs-Émile Bruchési, in his capacity as Public Curator, of the city and district of Montreal, curateur to the vacant estate of the late Georges McGregor and to the vacant estate of the late Dame Gcorgiana McGregor, are Defendants, ordering the licitation of the immoveable described as follows: \"The emplacement situated on Chatham Street, in the city of Montreal, known and disi-gnated as being the north-west part of the lot of land known and designated under number two hundred and twenty (Pt.N.W.220) on the Ofli cial Plan and in the Book of Reference of St.Antoine Ward, in the city of Montreal, measuring fifty feet in width by one hundred and thirty-one feet in depth, English measure and more or less, and bounded in front by Chatham Street, in rear by lot No.210 and part of lot 215, on one side, on the northwest, by lot 218 and 219 and on the other side, on the south-east, by the residue of said lot 220 on the Official Plan and Book of Reference of the St.Antoine Ward; with right of passage in common in the south-east part of the lot Number 219 as established by an Act of Agreement incorporated in the minutes of W.B.S.Reddy, Notary, on the tenth of March one thousand eight hundred and ninety-six and registered at the Registry Office of Montreal West, under Number 128070, with building thereon erected and bearing civic numbers 840, 842, 844, 846 and* 848 of Chatham Street in Montreal\".The above described immoveable will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder, on the TWENTY-EIGHT day of March 1956, at HALF past TEN o'clock in the forenoon, in Court Room No.31, in the Court House of Montreal, or in any other room as circumstances may require, the said sale to be made subject to the charges, clauses and conditions mentioned in the list of charges filed in the Office of the Prothonotary of the Superior Court.Any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to he made to the said licitation must be filed in the Office of the Prothonotary of the said Court at least 12 days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication and any opposition for payment must be filed within 6 days following the adjudication; and failing the interested parties to file the said opposition within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.A deposit of two thousand dollars ($2,000.00) shall be exacted before the sale, from each and every bidder.Montreal, February 21st, 1956.DURANLEAU, DUPRÊet DURANLEAU, 41881-8-2-o Attorneys vor Plaintiff. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, March 3rd, 1956, Vol.88, No.9 913 VENTES PAR SHERIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEAUHARNOIS Canada \u2014 Province de Québec District de Beauharnois Cour Supérieure, ( A RISTIDE BEAUCHES-N°2263.< -
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.