Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 janvier 1956, samedi 28 (no 4)
[" Tome 88, N° 4 283 Vol.88, No.4 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 28 janvier 1956 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, January 28th, 1956 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to : The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec OfficialGazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter 284 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° h délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement : $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.41502 \u2014 1-52 Lettres patentes (P.G.13169-55) American Stainless Steel Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1955, constituant en corporation: Paul M.Gervais, avocat, Fernande B.Thibault, sténographe, épouse séparée de biens de Jules M.Thibault, tous deux de Sherbrooke et David J.Crockett, comptable agréé, de Danville, tous des cité et district judiciaire de St-François.pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises et articles fabriqués d'acier inoxydable, sous le nom de \"American Stainless Steèl Co.Limited\", avec un capital total de 870,000, divisé en 200 actions ordinaires de SI00 chacune et 2,000 actions privilégiées de S25.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41661 C.E.CANTIN.receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning : The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.41502 \u20141-52 Letters Patent (A.G.13169-55) American Stainless Steel Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November.1955.incorporating: Paul M.Gervais, lawyer, Fernande B.Thibault, stenographer, wife separate as to property of Jules M.Thibault, both of Sherbrooke, and David J.Crockett, chartered accountant, of Danville, all of the judicial district of St.Francis, for the following purposes: To manufacture and deal in merchandise manufactured from and articles of stainless steel, under the name of \"American Stainless Steel Co.Limited\", with a total stock of 870,000, divided into 200 common shares of S100 each and into 2,000 preferred shares of 825.each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of November.1955.C.E.CANTIN, 41661 -o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956.Vol.88, No.4 285 (P.G.13383-55) Armand Hébert Lumber Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1955, constituant en corporation: Armand Hébert, marchand de bois, Gabriclle Malo Hébert, ménagère, épouse commune en biens dudit Armand Hébert, et dûment autorisée aux fins des présentes, et Charlemagne Durivage, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et l'industrie de marchand de bois et de constructeur, sous le nom de \"Armand Hébert Lumber Inc.\", avec un capital total de $75,000, divisé en 750 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41001-o C.E.CANTIN.(P.G.13251-55) Autorex Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf novembre 1955, constituant en corporation: Bernard Diamond, J.Steven Bless, avocats, de Montréal et Louis Orenstein, avocat.d'Outremont, tous du district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'automobiles et véhicules-moteurs de toute sortes et leurs accessoires, sous le nom de \"Autorex Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 995 ouest, me Notre-Dame, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41601 .C.E.CANTIN.(A.G.13383-55) Armand Hébert Lumber Inc.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December 1955, incorporating: Armand Hébert, lumber merchant, Gabrielle Malo Hébert, housewife, wife common as to property of the said Armand Hébert, and duly authorized for these presents, and Charlemagne Durivage, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and industry of lumber merchant ami builder, under the name of \"Armand Hébert Lumber Inc.\", with a total capital stock of $75.000, divided into 750 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of December.1955.C.E.CANTIN, 41001 Deputy Attorney General.(A.G.13251-55) Autorex Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of November, 1955.incorporating: Bernard Diamond.J.Steven Bless, advocates, of Montreal, and Louis Orenstein, advocate, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in automobiles and motor vehicles of all kinds and accessories, under the name of \"Autorex Limited\", with a total capital stock of $40.000, divided into 200 common shares of S100 each and.into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 995 Notre Dame St.West.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41G01-o Deputy Attorney General.(P.G.13212-55) Balit Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1955, constituant en corporation: Charles H.Desjardins, Paul Emile I>ejour, Edward G.Tannage, avocats et Jeannette Desjardins, sténographe, célibataire et fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir, administrer, développer ou disposer de terrains et immeubles, sous le nom de \"Balit Realties Ltd.\", avec un capital total de $135,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41601 C.E.CANTIN.(A.G.13212-55) Balit Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November, 1955, incorporating: Charles H.Desjardins.Paul-Emile Lejour, Edward CL Tannage, advocates, and Jeannette Desjardins.stenographer, unmarried ami of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire, manage, develop or dispose of lands ami real estate, under the name of \"Balit Realties Ltd.\", with a total capital stock of 8135,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 1.250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-eighth dav of November.1955.C.E.CANTIN, 41G01-o Deputy Attorney General. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° 4 (P.G.13278-05) Boulanger & Tremblay, Limitée Avis est donné «m'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec «les lettres patentes, en «late du premier décembre 1955, constituant en corporation: Jean-Paul Jobin, L«>uis-André Trudel, comptables, et Henri Chassé, imtaire, tous «le Sainte-Foy, district judiciaire «le Québec, pour les objets suivants: Exploiter «les garages; exercer le commerce de véhicules automobiles, sous le nom de \"Boulanger & Tremblay, Limitée\", avec un capital total «le 810,000, divisé en 100 actions «le §100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 5, boulevard St-Germaih, Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41001-o C.E.CANTIN.(A.G.1327S-55) Boulanger & Tremblay, Limitée Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issue«l by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the first day of December, 1955, incorporating: Jean-Paul Jobin, Louis-André Trudel, accountants, and Henri Chassé, notary, all of Sainte-Foy, judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate garages; to deal in motor vehicles under the name of \"Boulanger & Tremblay, Limitée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 shares of 8100 each.The head office «>f the company will be at 5, St-Germain Boulevard, Rimouski, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this first day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41001 Deputy Attorney General.(P.G.13274-55) Catherine Lund Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été acconlé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1955, constituant en corporation: Barnett Newman, Frances Newman, ménagère, épouse séparée de biens dudit Barnett Newman et Phyllis Frecdman, marchande, épouse séparée de biens de John Frecdman, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'articles vestimentaires et accessoires, sous le nom de \"Catherine Lund Co.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $10 chacune et 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41601 C.E.CANTIN.(P.G.13250-55) Cécile Valois Lingerie Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf novembre 1955, constituant en corporation: Paul (ialt Michaud, avocat, Thérèse Paradis et Thérèse Servant, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vêtements et accessoires, sous le nom de \"Cécile Valois Lingerie Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 150 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 350 actions privilégiées d'une videur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf novembre 1955.1 L'Assistant-procurcur général, 41001 CE.CANTIN.(A.G.13274-55) Catherine Lund Co.Notice is hereby given that umler Part.I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-eighth f Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in building materials under the name of \"E.W.Corner Limited\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 shares of $10 each.The head office of the company will be at 103 Park Avenue, Sainte-Rose, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of November 1955.C.E.CANTIN, 41001 Deputy Attorney General.(A.G.13275-55) Fifteen Hundred and Fifty-nine McGregor Street Investment Corp.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November, 1955, incorporating: Charles Brownstein, Gregory Charlap, Moe Moscovitch and John Liberman, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To improve, develop and maintain a certain immoveable property bearing number 1559 McGregor street, umler the name of \"Fifteen Hundred and Fifty-nine McGregor Street Investment Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each and into 200 preferre«l shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41661-») .Deputy Attorney General.(A.G.13248-55) Filion & Frères Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the thirtieth day of November 1955, incorporating: Fernand Filion, Berthier Filion, Real Filion.Ange Aurel Filion, contractors, and Maurice Léveillé, accountant, all of Saint Jérôme, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 88th, 1956, Vol.88, No.4 289 Faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Filion \u2022& Frères Inc.\".avec un capital total de 875.000.divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 550 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la paroisse de Saint-Jérôme, district judiciaire dé Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1955.L'Assistant-procurcur général.41661-0 C.E.CANTIN.To carry on business as general contractors, under the name of \"Filion & Frères Inc.\", with a total capital stock of 875.000.divided into 200 common shares of a par value of 8100 each, and 550 preferred shares of a par value of 8100 each.The head ollice of the company will be in the parish of Saint Jérôme, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of November 1955.C.E.CANTIN, 41061 Deputy Attorney General.(P.G.13245-55) Fontainebleau Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre 1955, constituant en corporation: Jean-Armand Aubry, Médéric Desjardins, marchands, tous deux de Ville Mont* Royal et Gaston Lachapclle, industriel, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Construire, acquérir, entretenir, exploiter et administrer (.'es salles de rafraîchissements, salles de repas légers, de café, cafétarias et comptoirs à sandwichs, sous le nom de \"Fontainebleau Inc.\".avec un capital total de $30,000, divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41001 C.E.CANTIN.(P.G.13337-55) Grandes Piles Lumber Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux décembre 1955, constituant en corporation: Auguste Désilets, Roger Deshaies, avocats, et Rolande Lacroix, sténographe, fille majeure, tous de Grand'Mère, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de bois, sous le nom de \"Grandes Piles Lumber Ltd.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Grandes Piles, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41661-0 C.E.CANTIN.(P.G.13208-55) Grondin & Grondin Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre novembre 1955, constituant en corporation: Cast on Pouliot, avocat, de Ville Mont-Royal, Marcel-G.Robitaille, avocat, André Bourdon, secrétaire, célibataire, de Montréal.Marin Dion, avocat, d'Outremont, et Marguerite Day Boulay, secrétaire, épouse séparée de biens de Philippe Boulay, de Longueuil, tous du district (A.G.13245-55) Fontainebleau Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November, 1955.incorporating: Jean-Armand Aubry, Mederie Desjardins, merchants, both of the town of Mount Royal, and Gaston Lachapclle, industrialist, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To build, acquire, maintain, operate and manage refreshment rooms, lunch rooms, coffee rooms, cafeterias and sandwich bars, under the name of \"Fontainebleau Inc.\".with a total capital stock of $30.000, divided into 300 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fourth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41661-0 Deputy Attorney General.(A.G.13337-55) Grandes Piles Lumber Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of December, 1955, incorporating: Auguste Désilets, Roger Deshaies, advocates, and Rolande Lacroix, stenographer, bachelor, all of Grand'Mère, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes : To carry on the lumber business and industry, under the name of \"Grandes Piles Lumber Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Grandes Piles, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December.1955.C.E.CANTIN.41661 Deputy Attorney General.(A.G.13208-55).Grondin & Grondin Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies* Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November, 1955, incorporating: Gaston Pouliot, advocate, of the town of Mount-Royal, Marcel G.Robitaille, advocate, Andrée Bourdon, secretary, bachelor, of Montreal, Marin Dion, advocate, of Outremount, and Marguerite Day Boulay.secretary, wife separate as to property of Philippe Boulay.of Longueuil, all of the 290 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° /, judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers en assurances, sous le nom de \"Grondin & Grondin Inc.\", avec un capital total de 81,000, divisé en 1.000 actions de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41661-0 C.E.CANTIN.(P.G.13270-55) Ilarnor Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1955, constituant en corporation: Harold Pascal, marchand.Samuel Leon Mendelsohn, avocat et conseil en loi de la Reine, tous deux de West mount et Léo Rosentz-veig, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Effectuer des placements sur des biens fonciers et posséder des terrains et des immeubles, sous le nom de \"Harnor Holdings Inc.\", avec un capital total de 810.000.divisé en 1.000 actions ordinaires de 810 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1955.L'Assistant-procurcur général.41061 C.E.CANTIN.(P.G.13234-55) J.E.Létourneau Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1955, constituant en corporation: Grant Hall Day, avocat, Charles Shaw Bradeen jr, étudiant en droit et Lois Marie Perry secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un magasin général, sous le nom de \"J.E.Létourneau Ltd.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 59,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Schcffer-ville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41061 C.E.CANTIN.(P.G.12913-55) Jos.Le Bel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-trois novembre 1955, constituant en corporation: Adhémar G.Munich, avocat.Al-manzor Laberge, comptable, et Fernande Langlois, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers umler the name of \"Grondin & Grondin Inc.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 1,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of November 1955.C.E.CANTIN, 41661 Deputy Attorney General.(A.G.13270-55) Ilarnor Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November, 1955.incorporating: Harold Pascal, merchant, Samuel Leon Mendelsohn, advocate and Queen's Counsel, both of Westmount, and Leo Rosentzveig, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To invest in and hold land and real estate, umler the name of \"Ilarnor Holdings Inc.\", with a total capita] stock of $40.000.divided into 1000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-eighth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41661-0 Deputy Attorney General.(A.G.13234-55) J.E.Létourneau Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November, 1955, incorporating: Grant Hall Day, advocate, Charles Shaw Bradeen Jr.student at law, and Lois Marie Perry, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a general store, under the name of \"J.E.Létourneau Ltd.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $1 each and into 59,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company will be at Schcfferville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-eighth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41661-0 Deputy Attorney General.(A.G.12913-55) Jos.Le Bel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-third day of November, 1955, incorporating: Adhémar G.Munich, advocate, Almanzor Laberge, accountant, and Fernande Langlois, secretary, of full age, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956.Vol.88, No./, 291 Faire affaires comme quincaillier et ferblantier, sous le nom de \"Jos.I*e Bel Inc.\",' avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général.le vingt-trois novembre 1955.L'Assistant-procurcur général.41661-0 , C.E.CANTIN.(P.G.13115-55) J.W.Beau lac &.J.Denis Lambert Assurances Générales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a i'té accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en dale «lu trente novembre 1955, constituant en corporation: J.-Wellie Beau lac, courtier en assurance, de Sliawinigan-Falls, .1.-Denis Lambert, courtier en assurance, et Paul-E.Dugré, comptable agréé, ces deux derniers de Shawinigan-sud, tous du district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtiers en assurance, sous le nom de \"J.W.Beaulac & .1.-Denis Lambert Assurances Générales Inc.\".avec un capital total de $15.000, divisé en 150 actions de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera 003, Place du Marché.Shawinigan-Falls, district, judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le trente novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41661-e C.E.CANTIN.(P.G.13221-55) L'Aide aux Étudiants de l'École St-Édouard de Plcssisville Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Lôkdes compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du trois décembre 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Alcide Tessier (Frère Samuel-Marie), J.-Aimé Gosselin, acheteur, Adélard Dubois, tanneur, Alfred-Donat Poisson, vendeur, Armand Marchand, pharmacien, Jean-Paul Langevin, comptable, et Marius Bertrand, commis, tous de Plessisville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Grouper en association les anciens élèves et les amis de l'École St-Édouard de Plessisville, sous le nom de \"L'Aide aux Étudiants de l'École St-Édouard de PlessisvilIeJnc\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 850.000.Le siège social de la corporation sera à Plessisville, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général, le trois décembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41661-o C.E.CANTIN.(P.G.13110-55) L'Association des Ophtalmologistes de la Province de Québec Inc.The Association of the Ophtalmologists of the Province of Quebec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la To carry on business as a hardware dealer and tinsmith under the name of \"Jos.I a.* Bel Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third dav of November 1955.C.E.CANTIN, 41001 Deputy Attorney General.(A.G.13115-55) J.W.Beau lac & J.Denis Lambert Assurances Générales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirtieth day of November 1955, incorporating: J.Wellie Beaulac.insurance broker, of Shawinigan Falls.J.Denis Lambert, insurance broker, and Paul E.Dugré.chartered accountant, the two latter of Shawinigan-South, all of the judicial district of Trois-Rivières.for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers, under the name of \"J.W.Beaulac & J.Denis Lambert Assurances Générales Inc.\".with a total capital stock of 815.000.divided into 150 shares of $100 each.The head office of the company will be at 003 Market Place Shawinigan-Falls.judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this thirtieth dav of November 1955.C.E.CANTIN, 41001 Deputy Attorney General.(A.G.13221-55) L'Aide aux Étudiants de l'École St-Édouard de Plessisville Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of December, 1955, to incorporate as a corporation without share capital : Alcide Tessier, (Frère Samuel-Marie), J.Aimé Gosselin, purchaser, Adélard Dubois, tanner, Alfred-Donat Poisson, salesman, Armand Marchand, pharmacist, Jean-Paul Langevin, accountant, and Marius Bertrand, clerk, all of Plessisville, judicial district of Artha-baska, for the following purposes: To group into an association the graduates and friends of the \"École St-Édouard de Plessisville'*, under the name of \"L'aide aux Etudiants de l'Ecole St-Édouard de Plessisville Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Plessisville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of December.1955.C.E.CANTIN, 41661 Deputy.Attorney General.(A.G.13110-55) L'Association des Ophtalmologistes de la Province de Québec Inc.The Association of the Ophtalmologists of the Province of Quebec Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the 292 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql ÊllEC.Québec.28 janvier 1956.Tome 88, N° /, province île Québec des lettres patentes, en date du deux décembre 1955, constituant en corporation sans capital-actions: René Cbarbonncau, médecin de l'hôpital Notre-Dame.John W.Nichols, médecin «le l'hôpital Royal Victoria, et Michel Mathieu, médecin «le l'hôpital Maison-neuve, tous «les cité et district judiciaire de Montréal, p«>ur les objets suivants: Grouper en association les médecins spécialisés en ophtalmologie, sous le nom «le \"L'Association «les Ophtalmologistes «le la Province «le Québec Inc.\u2014 The Association of the Ophtalmologists of the Province «>f Quebec Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers «pic la corporation peut posséder, est de $25.0(10.Le siège social de la corporation sera à Montréal district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux décembre 1955.L'Assistant-procureur général.41001-o C.E.CANTIN.(P.G.13381-55) Leniro Stcecl Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six décembre 1955, constituant en corporation: Richard Dorais, Georges C.Lacbance, avocats, et Marguerite Ducharme, secrétaire, célibataire, tous des cité et district judiciaire «le Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires en structures spécialistes en béton armé; agir comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Lcmro Steel Limited\", avec un capital total «le $40.000, divisé en 4.000 actions de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, dis*rict j idiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le six «lécembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41601-o C.E.CANTIN.(P.G.13200-55) Les Editions Schola Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1955.constituant en corporation: Emé Lacroix, avocat, de Ville Mont-Royal, Armand Poupart.fils, avocat, et Monique Couture, secrétaire, célibataire, ces deux derniers de Montréal, tous «lu district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme commerçants, manufacturiers, agents dans tous les articles qui se rapportent à l'enseignement général ou au commerce de libraire, sous le nom de \"Les Éditions Schola Inc.\".avec un capital total de $150,000.divisé en 6,000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $10 chacune et en 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41661-0 C.E.CANTIN.Province of Quebec, bearing «late the second day to December 1955.to incorporate as a corporation without share capital: René Charbonneau, physician of the Notre Dame Hospital, John W.Nichols, physician of the Royal Victoria Hospital, and Michel Mathieu, physician of the Maison-neuve Hospital, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To group into an association, the physicians specialized in Ophtalmology, ninder the name of \"L'Association «les Ophtalmologistes «le la Province de Québec Inc.\u2014, The Association of the Ophtalmologists «>f the Province of Quebec Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $25.000.The hea«l office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of December 1955.C.E.CANTIN, 41001 Deputy Attorney General.(A.G.13381-55) Lemro Stccel Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the sixth day of December 1955, incorporating: Richard Dorais, Georges C.Lachancc, advocates, and Marguerite Ducharme, secretary, spinster, nil of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in structures, carry on the business of specialists in reinforced concrete; act as general contractors, umler the name of \"Lemro Steel Limited\", with a capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of December 1955.C.E.CANTIN, 41661 Deputy Attorney General.(A.G.13260-55) Les Éditions Schola Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November.1955, incorporating: Emé Lacroix, advocate, of the town of Mount Royal, Armand Poupart, son, advocate, ami Monique Couture, secretary, bachelor, the latter two of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes : To operate as dealers, manufacturers, agents in all articles which have to «lo with general teaching or dealing with a library, under the name of \"Les Éditions Schola Inc.\", with a total capital stock of $150,000, divided into 6.000 common shares of a par value of $10 each and into 900 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41061 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No.', 293 (P.G.13246-55) Lombard Insurance Agency Ltd.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1955, constituant en corporation: John Henry Ernest Colby, Marc Brière, avocats et Galen Lee Prime, gérant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, poulies objets suivants: Exercer des commerces comme courtiers et agents d'assurances dans toutes leurs spécialités respectives, sous le nom de \"Lombard Insurance Agency Ltd.\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1.000 actionso rdinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41001 C.E.CANTIN.(P.G.13122-55) Marc Bourgîe Ltéc Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des lettres patentes, en date du dix-huit novembre 1955, constituant en corporation: Marc Bourgie, directeur de funérailles, Monique Couture, secrétaire, célibataire, tous deux de Montréal, et Emé Lacroix, avocat, «le ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs de pompes funèbres, embaumeurs, directeurs de funérailles, sous le nom «le \"Marc Bourgie Ltée\", avec un capital total «le $150,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 1,250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du b:ircau du Procureur général, le dix-huit novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41661-0 C.E.CANTIN.(P.G.12856-55) Mining Publications Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par la Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date «lu vingt-quatre novembre 1955, constituant en corporation : Murray B.Siegcl, Harry Pinker, avocats et Nina Schlesinger, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de propriétaires «le journaux, imprimeurs et publicistes, sous le nom de \"Mining Publications Limitée!\", avec un capital total de $40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1955.L'Assistai11-procureur général, 41601 C.E.CANTIN.(A.G.13246-55) Lombard Insurance Agency Ltd.Notice is hereby given that under Part I «)f the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-eighth day of November, 1955, incorporating: John Henry Ernest Colby, Marc Brière, a«l-voCates, ami Galen Lee Prime, manager, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the businesses of insurance brokers and agents in all their respective brain-lies, umler the name of \"Lombard Insurance Agency Ltd.\", with a total capital stock of $10.01)6, divided into 1.000 common shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth dav of November, 1955.C.E.CANTIN.41061-O Deputy Attorney General.(A.G.13122-55) Marc Bourgie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November 1955, incorporating: Marc Bourgie, undertaker, Monique Couture, secretary, spinster, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal for the following purposes: To act as morticians, embalmers, and undertakers, umler the name of \"Marc Bourgie Ltée\", with a total capital stock of $150,000, divided into 2,500 common shares of a par value of $10 each and 1,250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Date«l at the office of the Attorney General, this eighteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN.41661 Deputy Attorney General.(A.G.12856-55) Mining Publications Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of November, 1955, incorporating : Murray B.Siegel, Harry Pinker, advocates, and Nina Schlesinger, secretary, spinster, all of the city ami judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on generally the business of newspaper proprietors and general printers and publishers, under the name of \"Mining Public-actions Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and into 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fourth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41661-0 Deputy Attorney General. 294 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° J, (P.G.13137-55) Montrose Beauty Products Ltd.Avis est donne qu'en vertu de lu première partie de lu Loi des compagnies de Québec, il u été accordé par le Lieutenant-gouverneur de lu province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf novembre 1955, constituant en corporation: John DiMassino, surintendant.Richard DiMassino, opérateur d'ascenseur et Tos-biko Nakatsuka, dactylo, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de produits de beauté, sous le nom de \"Montrose Beauty Products Ltd.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 1,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.\\a.' siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le vingt-neuf novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41001 C.E.CANTIN.(P.G, 13302-55) Moro Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en date du six décembre 1955, constituant en corporation: Ernest William Mockridgc, gérant, «le St-Lambcrt, Clifford George Meek, teneur de livres, Alexander Gordon Yeoman, John Lawrence McCrory, commis en loi «le Montréal.Guy Ambrose Miller, teneur «le livres, de Verdun.William Patrick Crengh, commis en Loi, «le ville Mont-Royal, tous du district judiciaire «le Montréal, pour les objets suivants:.: Exercer le commerce «l'une compagnie «le placements et «le portefeuille, sous le nom de \"Moro Investments Ltd.\", avec un capital total de $1,000,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $1 chacune et 998,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1955.L'Assistant-procurcur général, \" 41001 C.E.CANTIN.(P.G.13400-55) Norac Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six décembre 1955, constituant en corporation: Richard Dorais, Georges Lachance.avocats, et Marguerite Ducharme, secrétaire, célibataire, tous «les cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom «le \"Norac Construction Inc.\", avec un capital total «le $200,000, divisé en 2,000 actions de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Mlontréal.Daté du bureau du Procureur général, le six «lécembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41601-o C.E.CANTIN.(A.G.13137-55) Montrose Beauty Products Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, bearing date the twenty-ninth clay of November, 1955, incorporating: John DiMassino.superintendent.Richard DiMassino.elcvatror operator, and Toshiko Nakatsuka, typist, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in beauty products, umler the name of \"Montrose Beauty Products Ltd.\", with a total capital stock of $20.000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and into 1.500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41661-0 Deputy Attorney General.(A.G.13302-55) Moro Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1955.incorporating: Ernest William Mockridge, manager, of St.Lambert, Cliffonl George Meek, bookkeeper, Alexander Gordon Yeoman, John Lawrence McCrory, law clerks, of Montreal, Guy Ambrose Miller, bookkeeper, of Verdun, William Patrick Creagh, law clerk, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment and holding company, under the name of \"Moro Investments Ltd.\", with a total capital stock of 81.000.000, divided into 2.000 common shares of a par value of $1 each and into 998,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41G01-o Deputy Attorney General.(A.G.13400-55) Norac Construction Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the sixth day of December 1955, incorporating: Richard Dorais, Georges Lachancc, advocates, ami Marguerite Ducharmc.secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Norac Construction Inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 2,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1955.C.E.CANTIN, 41601 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1950, Vol.88, No./, 295 (P.G.13237-55) N.V.Clou tier Inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-huit novembre 1955, constituant en corporation: Noël V.Cloutier, Guy Cloutier, commerçants, et Y von Sirois, comptable, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de véhicules automobiles; exploiter des garages, sous le nom de \"N.V.Cloutier Inc.\", avec un capital total de §350,000, divisé en 7,000 actions communes d'une valeur au pairde 85 chacune et en 03,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 85 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41661-0 C.E.CANTIN.(P.G.12313-55) Parent & Randoux Taxi Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date au premier décembre 1955, constituant en corporation: Jules Dupré.c.r., avocat, d'Outre-mont, Hélène Gélinas, avocat, célibataire majeure, et J.-Claude Bureau, avocat, ces deux derniers* de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de garagiste et d'exploitant de taxis, sous le nom de \"Parent & Randoux Taxi Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions communes de 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4000, Chemin de la Reine-Marie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier décembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41G01-o C.E.CANTIN.(P.G.13127-55) Roger Dernier Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit novembre 1955, constituant en corporation: Abraham Feincr, Albert Marcus et Isidore Reuben Prazoff, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchands de meubles, fournitures de maison, appareils de télévision, de radio et accessoires d'iceux, sous le nom de \"Roger Bernier Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 200actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Raw-don, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41001 C.E.CANTIN.(A.G.13237-55) N.V.Cloutier Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of November 1955, incorporating: Noël V.Cloutier, Guy Cloutier, merchands, and Yvon Sirois, accountant, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To manufacture and deal in motor vehicles; operate garages,- under the name of \"N.V.Cloutier Inc.\", with a total capital stock of 8350,000, divided into 7,000 common shares of a par value of 85 each and 03,000 preferred shares of a par value of 85 each.The head office of the Company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eighth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41001 Deputy Attorney General.(A.G.12313-55) Parent & Randoux Taxi Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, .letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of December 1955, incorporating: Jules Dupré, Q.C., advocate, of Outremont, Hélène Gélinas, advocate, spinster having reached the age of majority, and J.Claude Bureau, advocate, the two latter of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of garage-keeper and operator of taxis, under the name of \"Parent & Randoux Taxi Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 2.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 4000 Queen Mary Road, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this first day of December, 1950.C.E.CANTIN, 41001 Deputy Attorney General.(A.G.13127-55) Roger Bernier Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1955, incorporating: Abraham Feincr, Albert Marcus and Isidore Reuben Prazoff, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of marchands of furniture, house furnishings, television sets, radio sets and accessories, under the name of \"Roger Bernier Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided, into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Raw-don judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41001-o Deputy Attorney General. 296 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.28 janvier 1956.Tome 88, A'° J, (P.G.13268-55) Roger Carrière Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six novembre 1955, constituant en corporation: Roger Carrière, industriel, Renée La-douceur, ménagère, épouse séparée de biens dudit Roger Carrière et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Arthur Gagnon, comptable, tous d'Amos, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Exercer dans toutes et aucune de ses spécialités, le commerce de bûcherons, exploiteurs des forêts, marchands de bois, et propriétaires de scieries, de moulins à planer et moulin de pulpe, sous le nom de \"Roger Carrière Inc.\", avec un capital total de 880,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune et 4.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Amos, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six novembre, 1955.L'Assistant-procureur général, 41001 C.E.CANTIN.(P.G.13397-55) Ste.Adèle Lodge Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf décembre 1955.constituant en corporation: Kenneth Simpson Howard, avocat, de la ville de Hampstead, Clifford George Meek, teneur de livres, «le Montréal, et Guy Ambrose Miller, teneur de livres, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal pour les objets suivants: Exploiter «les hôtels, sous le nom de \"Ste.Adèle .Lodge Inc.\", avec un capital total de $40.000,divisé en 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ville Ste-Adèle, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau «lu Procureur général, le neuf décembre 1955.L'Assistant-procurcur général, 41001 C.E.CANTIN.(P.G.13190-55) Stc-Rose Construction, Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes, en «late du vingt-neuf novembre 1955, constituant en corporation: Gérard Ernest Bellivcau, plomb-bier, Edward Whitfield Corner, manufacturier, et Roger Mivillc.comptable, tous «le Sainte-Rose, district judiciaire «le Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce «le matériaux de construction, sous le nom de \"Stc-Rose Construction, Limited\", avec un capital total de $5,000, divisé en 500 actions «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 159, St-François, Sainte-Rose, district judiciaire de Mont irai.(A.G.13208-55) Roger Carrière Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth .\t\t9-13-1.\t0.38 0.63\t1.50 1.50 26.02 33.22 75.01 21.00 11.04 6.00 31.01 53.25 6.50 11.00 2.00 2.00\t\t1.88 2.13 26.02 33.22 75.01 27.25 15.29 10.25 31.01 53.25 13.26 15.38 3.00 3.00 19.71 \t7.\t12-C.\t\t\t\t I >ainnse Garneau.\t7.,6.\t12-A, 12-B, 12-C, 12-G.\t\t\t\t \t\t12-B, 12-C\t\t\t\t Ovila Nadcau .\t5.\t24-A, 24-B,.17-B.\t6.25 4.25 4.25\t\t\t \t7.\t\t\t\t\t (ieorges Nadeau\t7.\t18-B.\t\t\t\t \t8.\t8____.\t\t\t\t Noël Lagacé.\t7.\t7.\t\t\t\t Wilfrid Martin.\t3.\t15-B.\t6.76 4.38 1.00 1.00 19.71\t\t\t François Marcotte .\t6.\t7.\t\t\t\t \t6.\t14 Est-East 8.14 Est-East 9.8-9.\t\t\t\t François Marcotte\t6.\t\t\t\t\t Adélard Richer.\t3.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Canton Campbell (Mité de Lac Des Écorces) \u2014 Campbell Township (Mly.Lac Des Écorces)\t\t\t\t\t\t Roland Latreille\t1, N.O-N.W.\tP.41.\t24.87\t40.00\t\t64.87 \t\t\t\t\t\t Cantons Wells, McGill et Bigelow (Mité Notre-Dame du Laus) Wells, McGill and Bigelow Townships (Mly.Notre-Dame du Laus)\t\t\t\t\t\t Donat Lajoie .\tA, (Wells).\t49-11.\t1.00 37.79 4S.61 10.94 2.00\t\t\t1.00 135.53 119.98 66.97 2 00 Joseph Provost .Hormidas Gravel\t3, (McGill).5, (McGill).2, (Wells).2, (Bigelow).\t15.13.16, 17.15-B, 15-C, 15-D\t\t91.49 67.97 53.43\t6.26 3.35 2 60\t \t\t\t\t\t\t 416 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2S janvier 1966, Tome 88, N° /, Canton Décarie (Mité do Sainte-Anne du Lac, village)\u2014Dccarie Township (Mly.of Sainte-Anne du Lac, village) Propriétaires Owners\tHang Range\tLot No.\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFabrique Church\tTotal \t7.\tP.20A, 3 acres P.29-A.\t84.00 60.00\t257.59 254.48\t17.00 10.00\t358.59 324.48 \t7.\t\t\t\t\t Suivani acte enregistré 29382.According title registred 29382.Canton Moreau (Commission scolaire do Lac St-Paul) \u2014 Moreau Township (School Corporation Lac St-Paul) Rémi Paquin.4.21-A.21-B.15.91 .15.91 Rémi Faquin.4.19, P.20____.\u2022.32.20 .32.20 Jean Lagacé.3.38-A.38-B.54.84 .54.84 Adrien Joan notte.3.41.21.88 .21.88 Canton Pérodeau (Commission scolaire de Lac Saint-Paul) Township Pérodeau (School corporation of Lac Saint-Paul) Rosaire Meilleur.\t6.\t11.\t\t52.55 18.72 7.79 30.48 24.54\t\t52.55 18.27 7.79 30.48 24.54 49.60 \t5.\t4.\t\t\t\t Conrad Dagcnais.\t0.\t4.\t\t\t\t \t4.\t12.\t\t\t\t \t4.\t10.\t\t\t\t \t8.\tP.9.\t\t49.60\t\t Pt.9, mesurant 306 pieds de longueur, par 100 pieds Pt.9, measuring 306 feet, by 100 feet of depth, de profondeur, le long de la ligne du lot 8 et 130 pieds, along tho division line of lot 8 and 130 feet of depth le long du côté sud.Borné à l'est par le Lac; ouest: along the south line.Bounded east by the lake; west: par le chemin public; nord: par le lot numéro 8; sud: by tho public road; north: lot number 8; south: residue résidu du lot numéro 9.of lot 9.Cantons Moreau, Wurtele, Gravel (Commission scolaire des Cantons Unis) Township Moreau, Wurtele, Gravel (School corporation of Cantons Unis) Camille Morin.5, Moreau.4 Hervé, Crépeau.3, Wurtele Borné au sud: lot 34; nord: lot 37; ouest: rang 2; est: canton Moreau.Contenant 114 acres.P.35.P.36 27.63\t19\t95 \t24\t95 47.58 24.95 Henri Lafantaisie.Viatour Vaudry et-and Henri Morin.Paul Kmile Boivin Florian L'Heureux Lionel Joly.Êmilo Provost.4, Wurtele 5, Wurtelo 5, Wurtele 3, Wurtele 2, Gravel .2, Pope.Bounded south: lot 34; west: range 2; east: Moroau Township.Containing 114 acres.29, 30 .7, 8, 9 .19.7.22, 23, 24 33, 34 .55.46 29.25 12.84 64.07 ' *9*.ô4* 317.47 08.69 37.14 149.87 624.16 241.48 372.93 97.84 49.98 213.94 624.16 250.52 Corporation luunicipale do village de Ferme-Neuve \u2014 Municipality of village of Ferme-Neuve Julien Piché.Village.Camille Giroux.Village.Lucien-Paquet te.Village.Rosaire Deniers.Village.Mme-Mrs Théodore Nadon .Village.Pt.65, mesurant 50 x 120 pieds, dame Joseph Courtemanche; sud et du lot 65; est: par rue St-Joseph.Armand Poudrier.] Village.Suivant titre enregistré numéro 40780.179.\t33.99\t82.45\t8.67\t125.11 142.\t258.68\t147.20\t20.31\t420.19 P.4.\t11.50\t20.60\t3.21\t35.31 94 .\t78.25\t211.08\t11.14\t290.47 P.65.\t34.60\t71.40\t4.01\t110.01 Borné nord : ouest; résidu Pt.65, measuring 50 x 120 feet.Bounded north: Mrs Joseph Courtemanche; south and west: residuo lot 65; east: street St-Joseph.P.226 .1.39.63 I 88.39 I 7.06 I 135.08 According title registered under tho number 40780.Napoléon Bolduc Denis Levcsque.Village.Village.3-60.P.226.14.40 129.53 121.30 4.54 5.68 134.07 141.38 Suivant titro enregistré numéro 39824.According title registered under the number 39824.Canton Pope (Mité des Cantons Unis) \u2014 Pope Township (Mly.Cantons Unis) Joseph Bolduc.Bruno Bcauchamp.Aurèle Guénotte et-and Cécile Page.Joseph Lachaine.Henri Giguèro.Laurent Béloc.Camillo Boucher, fils .Camille Boucher, fils .Camille Boucher, fils .Camillo Boucher, fils .Athanasa Parent.10.2.17.24.7.23.11.20.21.22.P.Nord-North 11.3.75 10.63 15.87 8.97 8.51 22.44 100.09 2.50 1.89 1.89 4.09 \t \t \t \t \t 88.90 41.95 43.99 33.25 33.25\t \t \t \t \t \t 3.75 10.63 15.87 8.97 8.51 111.34 142.04 46.49 35.14 35.14 4.09 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol 88, No.4 417 Pt.nord 11, de forme triangulaire, mesurant 146 Pt.north 11, triangular figure, measuring 146 feet pieds de largeur, par 120 pieds de profondeur, l'hypo- of width bo 120 feet of depth, hypothcnuse having thénuse ayant 189 pieds.Borné nord: par la ligne 189 feet.Bounded north: by the division lino of the separative dee lots 11 et 12; est: par le chemin public; lots 11 and 12; east: public road; southeast and south- sud-est et sud-ouest: par io résidu du lot 11.west: résidu lot 11.Canton Robertson (Mité des Cantons Unis) \u2014 Robertson township (Mly.Cantons Unis) Propriétaires Owners\tRang Rango\tLot No.\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tFabrique Church\tTotal Roland Valiquette.\t1.\t4.\t8.91 6.50 14.18 3.81 174.08 3.31 5.01 40.13 12.90 18.93 5.83 14.40 8.36 17.65 17.80 3.55 12.07 3.04 14.40 18.91 9.73 14.49 20.94 4.86 1.16 4.84 3.30 4.60 4.99\t\t\t8.91 6.50 14.18 3.81 174.08 3.31 37.01 180.79 40.52 18.93 41.83 105.82 33.46 73.00 115.00 3.55 79.48 6.58 48.85 65.18 25.23 14.49 20.94 4.86 1.16 4.84 3.30 4.60 12.99 \t1.\t8.\t\t\t\t \t1.\t9.\t\t\t\t \t2.\t2.\t\t\t\t Mme-Mra Joseph Boisclair .Rosaire Grenier.\t3.\t4.\t\t\t\t \t3.\t11.\t\t\t\t \t3.\tP.Est-East 17 21.\t\t32.00 140.66 27.62 ''36.66' 91.42 25.10 55.35 97.20\t\t Mme-Mrs Georges Yale.\t4.\t\t\t\t\t Mme-Mrs Georges Yale.\t4.\t22.\t\t\t\t Mme-Mrs Georges Yale.\t6.\t16w.\t\t\t\t \t4.\t51, Est-East.52, Est-East.36.\t\t\t\t \t4.\t\t\t\t\t \t6.\t\t\t\t\t Armand Lanthier.\t6.\t37.\t\t\t\t \t5.\t45.\t\t\t\t Gilbert Gareau.\t7.\t21.\t\t\t\t Alexis Ouimet.\t5.\t47.\t\t67.41 3.54 34.45 46.27 15.50\t\t Damase Larocque.\t8.\t41-Est-East .47.\t\t\t\t André Hétu.\t8.\t\t\t\t\t André Hétu.\t8.\t48.\t\t\t\t \t8.\t51-C.\t\t\t\t Isidore Lajeunessc.\t9.\t31._.\t\t\t\t \t9.10.\t35.*.49.\t\t\t\t Wilfrid Roy.\t\t\t\t\t\t Zotique Lauzon.\t10.\t51-A.\t\t\t\t Roméo Peterson.\t11.\t52.\t\t\t\t Roméo Peterson.\t11.\t55.\t\t\t\t Jean-Noël Cloutier.\t14.\t46.\t\t\t\t \t6.\tP.20.\t\t8.00\t\t \t\t\t\t\t\t Canton Marchand (Mité du canton Marchand) \u2014 Marchand township (Mly.of township Marchand) Robert Brisebois.Il.I 33.1 22.28 1 36.82 |.I 59.10 Moins emplacement appartenant à Maxime La- Less part belonging to Maximo Laframboiso (0.75 framboise.(0.75 acres).acres).Robert Brisebois.Arthur Brisebois.Robert Brisebois.Gérard Brisebois.Inconnu \u2014 unknown.34.35.36.37.13.89.45 47.35 9.96 24.40 45.23 94.90 36.58 9.01 27.04 56.94 184.35 83.93 18.97 51.44 102.17 Moins parties appartenant à l'abbé J.E.Fafard Less parts belonging to J.E.Fafard and Lionel et Lionel Morissette.Morissette.Arthur Brisebois.Arthur Brisebois.\tN.O.-N.W.Riv.\t91.\t22.27 68.82\t31.74 109.18\t\t54.31 178.00 \tN.O.-N.W.Riv.Rouge.\t92.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Canton Montigny (non organisé) \u2014 Montigny township (un-incorporatod)\t\t\t\t\t\t Succ.-Est Jean-Bapt.Vachet .Marcotte.\t2.\t31.\t1.00 45.92 14.49\t\t\t1.00 45.92 14.49 \t1.\t6.\t\t\t\t \tNord-North Ch.\t48.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \u2022L'Annonciation, ce 10 janvier 1956.Le Secrétaire-trésorier du comté de Labelle.41591-3-2-o Me LUCIEN CYR, notaire.L'Annonciation, this January 10, 1956.Me LUCIEN CYR.noatary, Secretary-Treasurer of the 41591 -3-2-o County of Labelle.Province de Québec Province of Quebec Municipalité: du comté de Gaspé-Est Municipality of the county of Gaspé-East Avis public est par le present donné par le Public notice is hereby given by the under- soussigné J.E.LeBoutillier, secrétaire-trésorier signed J.E.Le Bout il lier, Secretary-treasurer of de la susdite municipalité, que les immeubles ci- the aforesaid municipality, that the immoveables après désignés, y compris les bâtisses dessus hereinafter described including the buildings 41S GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2S janvier 1956, Tome 88, N\" /, construites, seront vendus à l'enchère publique au lieu ou le Conseil «le comté tient ses sessions, au palais de justice à Percé, JEUDI, le HUITIEME jour de MARS prochain, à DIX heures de l'nvant-midi, pour taxes municipales et scolaires, à moins que ces taxes et les frais encourus ne soient payés avant la vente, savoir: thereon erected, shall he sold by auction at the place where the county council holds its sittings, in the Court House at Percé, on THURSDAY, the EIGHTH day of MARCH next, at TEN o'clock in the forenoon, for municipal and school taxes, unless these taxes and the costs incurred he paid before the sale, namely: Municipalité village de Chandler\u2014 Municipality villago of Chandler \t\t\t\tTaxes\tTaxes\t Noms\tN° du lot\tRang\tCanton\tmun.\t8C0l.\tTotal \u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t Nan lea\tLot No.\tIt ange\tTownship\tMini.\tSchool\t \t\t\t\ttaxes\ttaxes\t \tp.77-A.\t1.\t\t$25.88\t828.29\t854.17 Albert (\"oiiicuu\tP.77-A.\t1.\t\t45.09\t01.30\t106.39 \t\t1.\t\t40.25\t58.55\t98.80 \tP.09.\t1.\tPabos .\t78.05\t49 52\t127.57 \tP.77-A.\t1.\t\t57.11\t84.92\t142.03 Vvc-Wid.Jos Scnechal.\tp.82.\t1.\t\t28.48\t113 79\t142.27 \t\t\t\t\t\t Municipalité scolaire Grande Rivière\t\t\u2014 School Municipality of Grand River\t\t\t\t \tP.362.\t2.\tOr.Riviere.\t3.CO\t28.33\t31.83 \t\t1.\t\t0.75\t40.00\t40.75 Arthur Cauvier.\tP.52.\t1.\t\t82.22\t252.00\t334.22 \tP.181.\u201e.\t1.\t\t\t40.00\t40.00 \tP.2(18.\t1.\tOr.Rivière.\t7.00\t27.50\t34.50 Jenn & Pierre M et hot.\tP.207, P.451____\t2.\t\t20.25\t140.00\t172.25 \tP.417.\t2.'\tGr.ltivièro.\t19.05\t41.00\t00.05 \tP.435.\t2.\tGr.Rivière, ,\t7.20\t48.00\t55.20 \tP.100.\t1.\t\t27.75\t73.00\t100.75 \tP.12-D.\t2.\t\t3.02\t57.00\t00.02 \t\t\t\t\t\t Municipalité do Cap d'Espoir \u2014 Municipality of Cap d'Espoir Mine-Mrs Yvonne Couture Le-\tP.241.\t1.\tPerce.\t39.40\t47.80\t87.20 \t\t\t\t\t\t Municipalité scolaire Val d'Espoir \u2014 School Municipality of Val d'Espoir Inhn Oorairho fî 1 s Alfred\tP.1201, P.1202 .P.1198, P.1199, P.1200.\t5\tPercé.\t\t32.52\t32.52 \t\t\t\t\t\t \t\t5.\t\t\t27.50\t27.50 \tP.1179.\t6.\tPercé.\t\t118.12\t118.12 \tP.1166.\t6.\tPercé.\t\t33.83\t33.83 \tP.1150, P.1149 .1146.\t5.\tPercé.\t\t34.02\t34.02 \t\t5.\tPercé.:.\t\t81.95\t81.95 \t1048.\t3.\t\t\t222.42\t222.42 \tp.1032.\t3.\t\t\t47.27\t47.27 \tP.1028.\t3.\tPercé.\t\t72.82\t72.82 \tP.10.\t4-Sud.\t\t\t50.16\t50.16 \t8.,\t4-Sud.\t\t\t128.90\t128.90 \t\t\t\t\t\t Municipalité dc Barachois \u2014 Municipality of Barachois Succ-f^st.Edmund Boucher .\tP.39.P.40 .\t1-N.\tMalbiûo.\t2.31\t10.68\t12.99 Succ.-Est.Mme-Mrs Octave\t\t\t\t\t\t \tP.44.\t1-N.\t\t1.66\t69.59\t71.25 Succ.-lCst.John G.Hotton\tP.26.\t1-N____\t\t16.98\t68.10\t85.08 Succ.-Est.Edward Lenicsurior .\tP.44.\t1-N.\t\t1.68\t9.93\t11.61 \t\t\t\t\t\t Municipalité scolaire de Barachois \u2014 School Municipality of Barachois Héritiers-Heirs Clément Gérard\t17.4.\t1-N .2.\t\t2.18\t20.06\t22.84 Municipalité canton Douglas \u2014 Municipality township of Douglas\t\t\t\t\t\t Walter White.\t1-A.\t1 B.B.2 B.B.1 B.B.\t\t38.60\t38.60\t77.26 \t1-A .43.\t\t\t\t\t QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol, 88, No./, 419 Municipalité do Sydenham-Sud \u2014 Municipality of Sydenham-South.\t\t\t\tTaxes\tTaxes\t Noma\tNuméro du lot\tRang\tCanton\tmunie.\tscol.\tTotal \u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t Names\tNumber of lot\tRange\tTownship\tMunie.\tSchool\t \t\t\t\ttaxes\ttaxes\t \tP.4.\t1.\tSyd.\t18.30 11.02 12.08 31.71 24.38\t\t18.30 11.02 12.68 31.71 131.52 \t7.\t2.\tSvd.\t\t\t Mme-Mrs Virginie Fortin Jac-\tP.2.\t1.\tSyd.\t\t\t \tP.4.\tFox 0.1.\tSyd.\t\t\t Amédéc Lavoie.\tP.5.\t\tSyd.\t\t\t \tP.17.\t1.\tSvd.\t\t107.14\t \t\t\t\t\t\t Donné-à Percé, ce septième jour de janvier Given at Percé, this seventh day of January' 190(5.1956.Le Secretaire trésorier, J.E.LEBOUTILLIER, 11633-3-2-0 J.E.LEBOUTILLIER.41633-3-2-o Secretary-Treasurer.Canada \u2014 Province de Québec District de Saguenay Canada \u2014 Province of Quebec District of Stiguenay Ml NICIPALITK DE COMTÉ DE Cil AULEVOIX-EsT COUNTY MUNICIPALITY OF ChAHLKVOIX-EaST Avis public est par les présentes donné, par le soussigné, Pierre René Bouliane.de La Malbaie, secrétaire-trésorier, que les propriétés ci-après décrites, y compris les bâtisses dessus érigés, seront vendues à l'enchère publique, dans la salle de l'École Supérieure en le village dc La Malbaie, JEUDI, le HUITIÈME jour de MARS, 1956 à DIX heures de l'avant-midi, pour les taxes non payées et mentionnées dans l'état ci-dessous, en plus des frais qui ont clé ou pouvent être encourus, à moins que lesdites taxes, intérêts et frais soient payés .antérieurement.Public notice is hereby given by the undersigned.Pierre René Bouliane of La Malbaie, secretary-treasurer, that the properties hereinafter described, including the buildings erected thereon, shall be sold by public auction, in the Superior School Hall, in the village of La Malbaie, THURSDAY, the EIGHTH day of MARCH 1956, at TEN o'clock in the forenoon, for unpaid taxes mentioned in the statement hereinunder, plus the costs which have or may have been incurred, unless the said taxes with interest and costs shall have been prior to the sale.Municipalité de la paroisse de Sainte-Agnès \u2014 Municipality of the parish of Sainte Agnès \tNoms Names\t\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal \t\t\t$33.21\t$48.50\t$81.71 Lots numéros cent soixante et treize et cent soixante Lot numbers one hundred and seventy-three and one ct quatroze (173 et 174) du cadastre de la paroisse de hundred and seventy-four (173 and 174) of the cadastre Sainte-Agnès.of the parish of Sainte Agnès.Municipalité de La Malbaie \u2014 Municipality of La Malbaie Camille R.Hébert, 3050 Ave Dunmore, Montréal____ Le lot numéro cinq cent quatre-vingt-douze (592) du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Etienne de La Malbaie, à distraire: 1) la partie appartenant au C.N.R.; 2) la partie aux commissaires d'écoles, avec bâtisses dessus construites, 3) la partie appartenant à la Corporation du village dc La Malbaie; 4) un certain lopin de terre avec bâtisses dessus construites, situé au nord-est du chemin public du dit rang Sud-Ouest de la Rivière Murray, et comprenant tout le terrajn au nord-est et au sud-est du terrain de l'école, ce lopin est séparé de l'acquéreur au nord-ouest par une ligne pa-ralèle à la ligne separative du lot 593 du dit cadastre à une distance de 220 pieds au sud-est de ladite ligne separative du dit lot 593, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Succession-Estate David Otis, La Malbaie.Un certain emplacement sis en le village de La Malbaie, du côté sud-ouest de la rivière Malbaie, contenant environ 109 pieds anglais de front sur la profondeur qu'il peut y avoir depuis le chemin public jusqu'au pieds de la Côte qui se trouve à la profondeur tel que ledit emplacement est actuellement clôturé avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances; borné par devant au chemin public, et par derrière à la profondeur ci-dessus indiqués, joignant au .I.I 204.50 I 204.50 Lot number five hundred and ninety-two (592) of the official cadastre for the parish of Saint Etienne de La Malbaie, save and except:- 1) that part belonging to the C.N.R.; 2) that part belonging to the School Commissioners, with buildings erected thereon, 3) that part belonging to the village corporation of La Malbaie; 4) a certain plot of land with buildings erected thereon, situated to the northeast of the public highway of said range south-west of the Murray River, and comprising all the land northeast and southeast of the school land, said plot is separated from the purchaser northwesterly by a parallel line along the dividing line of lot 593 of said cadastre at a distance of 220 feet to the southeast of the said dividing line of said lot 593, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.I 99.98 I 66.00 I 105.98 A certain emplacement situated in the village of La Malbaie, on the southwest side of the Malbaie river, containing some 109 feet, english measure, of frontage by a depth that may exist as from the public highway as far as the foot of the Hill at is depth, such as the emplacement is actually fenced-in with all buildings erected thereon, circumstances and dependencies; bounded in front by the public highway, and in the rear by the depth hereinabove indicated, adjacent north- 420 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° 4 nord-ouest au ruisseau et au sud-est aux représentants de feu Joseph McLean, étant et composant le lot N° cinq cent vingt-deux A et partie du lot N° cinq cent vingt-deux (522-A & P, 522) au cadastre officiel pour la paroisse de La M al haie.Un certain terrain ou emplacement situé en le village de La Malbaie, pouvant mesurer 74 pieds de largeur à la ligne sud-ouest de division avec le terrain du Ministère de La Voirie par une largeur moindre i\\ la rivière Malbaie, au nord-est, par une profondeur de 108 pieds du côté nord-ouest dc division avec le terrain de David Otis, au nord-ouest, par une profondeur plus considérable dans la ligne de division sud-est avec l'emplacement dc Gonzague Dufour, le tout plus ou moins, mesures anglaise, étant et composant environ les deux tiers du lot de terre N° cinq cent dix-neuf (I*.519) au cadastro officiel pour la paroisso de Saint-Etienne de La Malbaie, le tout sans bâtisses, ct borné comme suit; savoir: En front, au nord-est, à la rivière Malbaie; à la profondeur (laquelle donne directement sur partie du même lot, propriété du ministère de la Voirie), au sud-ouest à partie du même lot propriété du ministère de la Voirie pour la confection de la route nouvelle et son élargissement; tenant d'un côté, au nord-ouest à la propriété de M.David Otis, tenant d'autre côté, au sud-est, à partie du lot 518 audit cadastre, propriété de M.Gonzague Dufour.westerly to the brook, and southwesterly by the representatives of the late Joseph McLean, being and forming lot No.five hundred and twenty-two and A purt of lot No.five hundred and twenty-two (522-A & i\\ 522) of the official cadastre for the parish of La Malbaie.A certain piece of land or emplacement situated in the village of La Malbaie, measuring approximately 74 feet in width at the southwest line dividing it from line of the land of the Department of Roads, by a smaller wid that the Malbaie river, northeastwards, by a depth of 108 feet to the northeast, dividing same from the land of David Otis, northwestwards, by a greater depth at the southeast line dividing it from the emplacement of Gonznguc Dufour, all of which more or less, English measure, being and forming part of some two thirds of lot of land No.five hundred and nineteen (P.519) of the official cadastre for the parish of Saint Etienne de La Mulbaie, all of which minus buildings, uud bound-ded as follows; to wit: in front, north-easterly, by the Malbaie river; at the depth (which river directly fronting part of the same lot, property of the Department of Roads), southwesterly by part of same lot belonging to tho Department of Roads for the building of the new road and the widening thereof; adjacent on one side, north westerly, the property of David Otis; on the other side, southwesterly to that part of lot 518, of said cadastre, property of Mr.Gonzague Dufour.Municipalité du village de Cap à l'Aigle \u2014 Municipalité of the village of Cap à l'Aigle \tNoms Names\t\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal \t\t\t19.25\t33.25\t51.50 Un emplacement en la paroisse de Saint-Étiennc do La Malbaie, en le rang du Cap à l'Aigle contenant 9 perches de front, sur cent cinquante pieds de profondeur, borné, au nord-ouest, par le chemin public, au sud-est, par les héritiers do Dame Hunter Robb, médo-oin, au nord-est par le lot 98 et au sud-ouest, par le lot N° 100 du cadastre do La Malbaie, lo dit emplacement connu sous le N° 99 et partie du lot numéro 101 du cadastre officiel de la paroisso de La Malbaie, ensemble avec toutes les bâtisses dessus construites, dépendances et circonstances, déduction faite cependant de la partie dudit terrain N° 99 et des parties donnés par le donateur François Lajoie à Gonzague Lajoie, un autre de ses fils: An emplacement in the parish of Saint Etienne de La Malbaie, in Cap à l'Aigle range, containing 9 rods in front, by one hundred and fifty feet in depth, bounded northwesterly, by the public highway, southeasterly by the heirs of Dame Hunter Robb, physician, northeasterly by lot 98 and southwesterly by lot No.100 of the cadastre of La Malbaie, the said emplacement known as number 99 and part of lot number 101 of the official cadastre of the parish of La Malbaie, together with all buildings erected thereon, dependencies and circumstances, save and except however, that part of said land No.99 and parts donated by donor François Lajoie to Gonzague Lajoio, another of his sons: Donné à La Malbaie, ce septième jour du mois de janvier, mil neuf cent cinquante-six.41610-3-2-o Le Secrétaire-trésorier, P.R.BOULIANE.Given at La Malbaie, this seventh day of the month of January, one thousand nine hundred and fiftv-six.P.R.BOULIANE, 41610-3-2 Secretary-Treasurer.Province de Québec Municipalité du comte de Lotbiniere Avis public vous est par le présent donné, par moi soussigné, Joseph Bédard, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté de Lotbiniere, résidant en la paroisse de Ste-Croix; que JEUDI, le HUITIÈME jour du mois de MARS 1956, à DIX heures de l'avant-midi, au lieu ordinaire des sessions dudit conseil, à Ste-Croix; les terrains ci-après désignés seront vendus à l'enchère, au rabais, à quiconque offrira de payer le montant des deniers à prélever, compris les frais faits pour la moindre partie desdits terrains qui seront mis à l'enchère, à défaut de paiement avant la vente, des taxes municipales et cotisations scolaires ci-après mentionnées et des frais encourus pour parvenir à ladite vente.Province of Quebec Municipality of the county of Lotbiniere Public notice is by the present given, by me the undersigned, Joseph Bédard, secretary-treasurer of the municipal council of the county of Lotbiniere, residing in the parish of Ste-Croix, that THURSD AY.the EIGHTH day of the month of MARCH 1956, at TEN o'clock in the forenoon, at the ordinary place of the sittings in the council hall of the said county, in the parish of Ste-Croix; the lands hereinafter described will be sold by public auction, in abating, to whoever will offer to pay the amounts to be-levied, including costs, for the lest part of the said lands, which will be auctioned in default of payment before the auction, of the municipal taxes and school assessments hereinafter mentioned and the costs incured to effect the said sale QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No.4 421 La municipalité do Villeroy \u2014 The municipality of Villeroy Noms des propriétaires Names of owners\tNuméros du cadastre Cadastral numbers\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal Jacques, L.-A.\t450-723.577-723.,.\ts 49.04 35.67\t$ 36.45 41.10\t$ 85.49 76.77 \t\t\t\t La Municipalité scolaire de Villeroy \u2014 The scholar municipality of Villeroy\t\t\t\t \tP.52-597.\t\t12.90 82.30 7.90\t12.90 82.30 7.90 \t096.\t\t\t \t25-719, 723.\t\t\t \t\t\t\t La municipalité do Val-Alain \u2014 The municipality of Val-Alain\t\t\t\t \t61 sub.67-A, 67-B-192.\t8.24\t36.12\t44.36 La municipalité de la paroisse de St-Louis de Lotbiniere The municipality of the parish of St-Louis of Lotbiniere\t\t\t\t \t305-306.\t82.52 14.41\t89.70 15.53\t172.22 29.94 \tP.581.\t\t\t \t\t\t\t La municipalité de la paroisse de St-Flavien \u2014 The municipality of the parish of St-Flavion\t\t\t\t \t429.\t39.77 130.07\t56.70 66.15 24.06\t96.47 196.22 24.06 \t302.\t\t\t \tP.419.\t\t\t \t\t\t\t La municipalité de la paroisso de St-Agapit \u2014 Tho municipality of the parish of St-Agapit\t\t\t\t \tIll, 241.\t99.33 23.45\t\t99.33 23.45 \t130, P.131.\t\t\t \t\t\t\t La municipalité de la paroisse de N.-D.du Sacré-Cœur d'Issoudun The municipality of the parish of N.-D.du Sacré-Cœur d'Issoudun\t\t\t\t \tP.484.\t13.50\t17.60\t31.10 \t\t\t\t Signé à Ste-Croix, ce 7 janvier 1956.Signed at Ste-Croix, this January 7th 1956.Le Secrétaire-Trésorier, C.M.C.L., JOSEPH BÉDARD, 41612-3-2-0 JOSEPH BÉDARD.41612-3-2-0 Secretary-treasurer, M.C.L.C.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 47 Québec, le 18 janvier 1956.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"A\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie du camionnage dans l'Ile de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amende- Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 47 Quebec, January 18, 1956.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"A\" Concerning amendments to the decree relating to the cartage industry in the Island of Montreal.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the 422 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.28 janvier 1956, Tome S6, N° U incuts), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du camionnage dans l'Ile de Montréal, rendue obligatoire par le décret numéro 913 du 1G juin 1948 amendé par les arrêtés en conseil numéros 971-F du 30 juin 1948, 514-E du 12 mai 1949, 368-B du G avril 1950, 93-A, 1282-A et 1396-C des 25 janvier, 15 novembre et 13 décembre 1951, 1174-C du G novembre 1952.129G-A du 2G novembre 1953 et 10GG-C du 3 novembre 1954, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de s mmettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil certaines ino ifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 19 novembre 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail?Que ledit décret, numéro 913, soit modifié comme suit: 1 ° Le nom de L'Association du Transport routier du Québec, Inc.section régionale de Montréal, apparaissant dans le décret comme partie contractante ('e première part, ayant été changé, il est remplacé par le suivant : \"L'Association du Camionnage du Québec.Inc.\".2° Le paragraphe 'V de l'article IV est remplacé par le suivant: \"a) Les taux de salaires minima suivants doivent être payés aux salariés ci-après: A Vem- Apr h bouchage 3 mois Aide-junior.SO.45 $0.50 Aide-général.0.83 0.99 Manutentcur de fret.0.97 1.13 Homme d'entrepôt.0.97 1.13 Vérificateur.0.97 1.13 Chauffeur____.0.98 1.19 Chauffeur semi-remorque.1.03 1.24 A compter du 1er octobre 1956.les taux ci-haut seront majorés de §0.06 l'heure pour tous les salariés, à l'exception des aides-juniors; une augmentation semblable sera accordée à tous les salariés, à l'exception des aides-juniors, à compter du 1er octobre 1957.\" (Document \"A\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 41671-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 47 Québec, le 18 janvier 195G.Présent: Ix?Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"H\" Concernant une modification au décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Rimouski.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Status refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil, une modification au décret numéro 802 du 8 contracting parties to the collective Labour agreement relating to the cartage industry in the Island of Montreal, rendered obligatory by the decree number 913 of June ,16, 1948, amended by Orders in Council numbers 971-F of June 30, 1948, 514-E of May 12, 1949.368-B of April Ii, 1950, 93-A, 1282-A and 1396-C of .January 25 November 15, and December 13, 1951, 1174-C of November G, 1952, 1296-A of Novemher 26, 1953 and 1066-C of November 3, 1951.have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree; Whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of November 19.1955; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 913 be amended as follows: 1.The name of The Automotive Transport Association of Quebec.Inc.Regional Division of Montreal, contracting party of the first part to the collective labour agreement rendered obligatory by the said decree No.913, having been changed, it shall hinccforth read as follows: \"Trucking Association of Quebec, Inc.\".2.Subsection \"a\" of section IV is replaced by the following: \"a) The following minimum rates of wages shall be paid to the employees hereafter mentioned: .S7ar/ After at 3 months Junior Helper.$0.45 $0.50 Helper (General).0.83 0.99 Dockman.0.97 1.13 Warehouseman.0.97 1.13 Checker.0.97 1.13 Chauffeur.0.98 1.19 Chauffeur Semi-Trailer.1.03 1.24 On October 1st, 1956, an increase of $0.06 per hour over the above rates for all employees, except for junior helpers, will be granted and a similar increase will be awarded to all employees, except for junior helpers, on October 1st, 1957.\" (Document \"A\" annexed to the Order) L.DÉSILETS, 41671 -o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 47 Quebec.January 18, 1956.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"B\" Concerning an amendment to the decree relating to the construction industry and trades in the region of Rimouski.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to submit to the consideration and deicision of the Lieutenant-Governor in Council, an amendment to the decree number 802 of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No.J, 423 juillet 1953, amendé par les arrêtés en conseils numéros 1202-A du 28 octobre 1953, 472-C et 775-B des 6 mai et 28 juillet 1954, 522-D et 990 des 11 mai et 11 septembre 1955, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Rimouski; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 26 novembre 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 802, soit modifié comme suit: Le paragraphe \"k\" suivant est ajouté à l'article IX: \"k) I^es apprentis qui ont fréquenté une école régie par la loi de l'enseignement spécialisé doivent recevoir un crédit proportionné à la durée dc leurs études et au résultat de leurx examens.\" (Document \"B\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 41671-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 47 Québec, le 18 janvier 1956.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"C\" Concernant des modifications au décret relatif aux travailleurs en fourrure, commerce de gros, dans la région dc Montréal.Attendu que, conformément à la procédure prévue à l'article S de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941.chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil certaines modifications au décret numéro 524 du 11 mai 1955, relatif aux travailleurs en fourrure, commerce dc gros, dans la région de Montréal; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 3 décembre 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 524, soit modifié comme suit: 1° A l'article II (Juridiction professionnelle et industrielle), la phrase suivante est ajouté à la fin du premier paragraphe: \"Le décret régit également les marchands et vendeurs de peaux qui donnent du travail de fourrure aux manufacturiers.\" 2° Le paragraphe \"c\" de l'article VII est biffé et remplacé par le suivant: \"c) Tout travail est interdit les dimanches et le jour de la Fête du Travail, quel que soit le salaire payé.\" 3° Le paragraphe \"d\" de l'article X est biffé et remplacé par le suivant: \"d) Il est interdit à un salarié travaillant déjà pour le compte «l'un employeur «lu commerce de la fourrure assujetti au décret, d'exécuter July 8, 1953, amended by Orders in Council numbers 1202-A of October 28, 1953, 472-C and 775-B of May 6 and July 28, 1954, 522-D and 996 of May 11 and September 14, 1955, relating to the construction industry and trades in the region of Rimouski; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of November 26.1955; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendment; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 802, be amended as follows: The following subsection \"k\" is added to section IX: \"/r) Apprentices who attended a school governed by the Specialized Schools Act shall receive a credit in proportion to the duration of their studies and to the result of their examinations\".(Document \"B\" annexed to the Order) L.DÉSILETS, 41671-Q Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 47 Quebec, January 18, 1956.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part.\"C\" Concerning amendments of the decree relating to fur workers, wholesale trade, in the Montreal district.Whereas, pursuant to the procedure provided for under section 8 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941.chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the decree number 524 of May 11.1955.relating to fur workers, wholesale trade, in the Montreal district; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of December 3, 1955; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 524, be amended as follows: 1.In section II (Professional and industrial jurisdiction) the following sentence is added at the end of the first subsection : \"The decree also applies to skin dealers who give fur work to manufacturers.\" 2.Subsection \"e\" of section VII is deleted and replaced by the following: \"e) No work shall bo permitted on Sundays and Labour Day, irrespective of the wages paid.\" 3.Subsection \"d\" of section X is deleted and replaced by the following: \"d) No employee already employed by an employer of the fur trade subject to the decree shall have the right to perform any work or part 424 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec.28 janvier 1956, Tome 88, N° 4 tout travail ou quelque partie de travail du métier de la fourrure à domicile, pour le compte de toute personne, que cette personne soit un employeur professionnel, un employeur ou un client au sens de la Loi de la convention collective.Il est aussi interdit à un employeur professionnel de faire exécuter à domicile du travail de la fourrure par un salarié.\" (Document \"C\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 41671-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 47 Québec, le 18 janvier 1956.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"I\"' Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie des accessoires de mode dans l'Ile de Montréal et un rayon de 10 milles de ses limites.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie des accessoires de mode dans l'Ile de Montréal et un rayon de 10 milles de ses limites, rendue obligatoire par le décret numéro 99 du 29 janvier 1948.amendé par les arrêtés en conseil numéros 748-C du 27 mai 1948.1198-D du 27 octobre 1949, 406-E du 12 avril 1950 et 329-H du 19 mars 1953, ainsi que le Comité paritaire chargé d'en surveiller l'application, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 3 décembre 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 99, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe \"a\" de l'article IV7 est remplacé par le suivant: \"a) I>es salariés des métiers ci-après énumé-rés doivent recevoir les taux horaires minima suivants: L'heure Mécanicien \"bonnaz\".$1.32^2 Plisseur et faiseur de patrons.1.00 Étampeur.0.60 Mécanicien de machines spéciales.0.60 Assistant plisseur.0.60 Perleur au crochet.0.55 Brodeur à la main.0.50 Employé général.0.50 Faiseur de boucles et de boutons recouverts.0.50\" 2° Les paragraphes \"c\" et \"d\" suivants sont ajoutés à l'article IV : \"c) A compter dc l'entrée en vigueur du présent décret d'amendement, chaque employeur doit verser à chaque salarié des métiers de mécanicien de machines spéciales, étampeur, plisseur, assis- thereof in the fur trade at home for any person, whether such person be a professional employer, an employer or a customer, as defined in the Collective Agreement Act, nor shall a professional employer have fur trade work executed at home by an employee.\" (Document \"C\" annexed to the Order) L.DÉSILETS, 41671-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 47 Quebec, January 18, 1956.Present: The Lieutenant-Governor in Council.l'art \"E\" Concerning amendments of the decree relating to the fashion accessories industry in the Island of Montreal and a radius of 10 miles from its limits.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the fashion accessories industry in the Island of Montreal and a radius of 10 miles from its limits, rendered obligatory by decree No.99 of January 29, 1948, amended bv Orders in Council numbers 748-C of May 27, 1948, 1198-D of October 27, 1949, 406-E of April 12, 1950 and 329-H of March 19, 1953, and the Parity Committee entrusted with the administration thereof, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree; Whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of December 3, 1955; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour; That the said decree, number 99, be amended as follows: 1.Subsection \"a\" of section IV, is replaced by the following: \"a) The employees of the trades hereinafter enumerated shall receive the following hourly minimum rates: per hour \"Bonnaz\" operator.$1.32^ Pleater and Pattern Maker.1.00 Stamper.0.60 Special Machine Operator.0.60 Pleater's Assistant.0.60 C rochet Bcader.0.55 Hand Embroidery worker.0.50 Floor help.0.50 Covered Button and Buckle Maker.0.50\" 2.The following subsections \"c\" and \"d\" are added to section IV: \"c) From the date of enforcement of the present decree of amendment, every employer shall pay to every employee employed in the following skilled crafts, to wit: Special Machine Ope- Ql Eli EC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th.19,50, Vol.88, No.4 425 tant, plisseur, pcrleur ou crochet, brodeur à la main, employé général, faiseur de boucles et de boutons recouverts, une augmentation de cinq cents ($0.05) l'heure en plus du taux actuel payé à chaque tel salarié.Les taux payés aux salariés qualifiés ne doivent jamais être inférieurs aux taux minima établis par le présent décret.\" \"d) Il ne doit y avoir de travail à la pièce dans aucun métier si ce n'est celui du mécanicien \"bonnaz\" (manette enclanchée) alfectée à la fabrication de sacoches en tissu cordé et ce dernier doit être assuré d'un taux à la pièce qui ne lui rapporte jamais moins que le taux minimum établi pour telle fonction.\" 3° Les paragraphes \"c\", \"d\" et \"/\" de l'article XI sont radiés et remplacés par les suivants: \"c) Les taux minima de salaires des apprentis employés généraux sont les suivants: L'heure I«e commençant reçoit.$0.373^ Après six mois.0.40 Après neuf mois.0.42^ Après douze mois.0.45 Après quinze mois.0.473^ Après dix-huit mois, temps à compter duquel ils deviennent ouvriers qualifiés dans leur métier respectif.0.50\" \"d) L'apprenti mécanicien de machines ou l'apprenti étampeur est qualifié après deux ans et demi comme mécanicien de machines ou étampeur.Le salaire minimum des apprentis mécaniciens dc machines ou étampeurs est le suivant: L'heure Le commençant reçoit.,.$0.373i> Après six mois.0.40 Après neuf mois.0.42^ Après douze mois.0.45 Après quinze mois.0.47^2 Après dix-huit mois.0.50 Après vingt et un mois.0.52^fL^fter twenty-one months.Après vingt-quatre mois.0.55 Après vingt-sept mois.0.hlYi Après trente mois, temps à compter duquel ils deviennent ouvriers qualifiés dans leur métier respectif.0.60\" \"/) Un apprenti \"mécanicien bonnaz\" est un salarié qui apprend à travailler sur une machine \"bonnaz\".Il est promu comme \"mécanicien bonnaz\" qualifié après trois (3) ans Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Section \"F\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec.Attendu que.conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie dc la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, rendu obligatoire par le décret numéro 142 du 22 janvier 1947, amendé par les arrêtés en conseil numéros 1156-B du 17 juillet 1947, 385-E du 14 avril 1949, 120-C du 1er février 1951 et 1295-F du 15 décembre 1952, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 5 novembre 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 142, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe 'V de l'article I est remplacé par le suivant: \"c) Préposé à la couture des tissus: Le terme \"préposé à In couture des tissus\" désigne tout salarié du sexe masculin ou féminin qui fait en tout ou en partie, la couture de la calotte (crowns), la piqûre des bords, le posage du tissu sur les bords (pulling brims), la couture des cuirs, le montage des chapeaux ou tout autre travail à l'aide des différentes machines à coudre, peu importe le tissu.Cependant, les préposés à la couture des tissus auxquels on confie la couture des cuirs et n'ont aucune expérience dans tout autre genre de travail exécuté dans le département de la couture des tissus \"fabric operating\" et qui sont embauchés pour l'exécution do ce travail à l'exclusion de tout autre, recevront un taux de salaire déterminé par une entente des deux parties et approuvée avec ou sans modification par le Comité paritaire.Pour l'arrondissement des chapeaux à la machine, le système d'emploi actuellement en vigueur dans chaque fabrique demeure inchangé, mais l'employeur ou le contremaître ne doivent en aucun temps, faire ce travail au lieu et au détriment des ouvriers qui y sont habituellement affectés.\" 2° Le paragraphe \"«-1\" suivant est ajouté après le paragraphe \"o\" de l'article III: \"a-1) Les taux déterminés pour les commerçants dans les différentes classifications, s'appliquent aux apprentis qui débutent et qui, jusqu'à leur qualification, doivent être rémunérés selon les taux ci-après mentionnés, exception faite des dispositions suivantes: Le Comité paritaire doit aviser chaque employeur par écrit au moins deux (2) semaines avant l'entrée en vigueur de chaque augmenta- ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 48 Quebec, January 18th, 1956.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"F\" Concerning! amendments of the decree relating to the women's and children's head wear industry in the province of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the women's and children's headwear industry in the province of Québec, rendered obligatory by the decree number 142 of January 22nd, 1947, and amended by Orders in Council number 1156-B of Julv 17th, 1917, 385-E of April 14th, 1949, 120-C of'February 1st.1951.and 1295-F of December 15th, 1952, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments lo the said decree; Whereas the petition has .been published in the Quebec Official Gazette, issue of November 5th, 1955; Whereas no objection has been raised against the approval of the proposed amendment; Therefore, it is ordered, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour.That the said decree, number 142, be amended as follows: 1.Subsection \"c\" of section I is replace! by the following: \"c) Fabric operator: The words \"fabric operator\" mean any male or female employee who is engaged in whole or in part in sewing crowns, stitching brims, pulling brims, sewing sweats, setting up hats, or making any operation on the various sewing machines from any material shatsoevcr.In the case of fabric operators who are employed for sewing sweats and who have no experience in any other type of work in the fabric operating department, and who are employed exclusively for sewing bands on hats, a special rate of wanes will be fixed by miftual agreement and approved or finally determined through the Parity Committee.In the case of rounding hats by power machine, the system of employment presently prevailing in each factory shall continue for the future, but at not time shall the foreman or employers perform this operation and thus deprive the workers generally engaged in it of any portion of their employment.\" 2.The following subsection \"a-1\" is added after subsection \"a\" of section III: \"a-1) The following starting rate schedules for the various classifications shall apply to apprentices who are beginners and who shall work until graduation on the basis of the following schedules for each classification in which such worker is employed save as hereinafter provided: The Parity Committee shall advise each employer by written notice as least two (2) weeks prior to the effective date of increase of each pc- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No.4 427 tion périodique «levant être accordée à chaque apprenti pendant la période de son apprentissage.Sur réception de tel avis, l'employeur doit accorder cette augmentation à la date qui correspond à la période mentionnée dans l'échelle dc salaires pour les commerçants.Toutefois, dans les cas spéciaux, si l'employeur juge qu'un apprenti ou un ouvrier handicapé n'a pas augmenté la somme de son travail proportionnellement à sa période d'apprentissage, il peut alors demander un permis spécial qui l'autorise à payer un taux inférieur à celui fixé dans l'échelle de salaires, conformément aux dispositions du paragraphe \"d\" de l'article III.Dans les circonstances ci-haut énumérées, il est permis à un manufacturier de différer le paiement d'une augmentation jusqu'à ce que le cas ait été apprécié et décidé par le Comité paritaire.Si le Comité décide que tel apprenti a, en fait, augmenté la somme de son travail selon sa période d'apprentissage et mérite l'augmentation à la date prévue, ladite augmentation doit alors être payé par l'employeur avec effet rétroactif à compter de la date de son entrée en vigueur.Taux des commençants \u2014Préposés aux garnitures: lers quatre mois.80.50 de4à8mois.0.55 de 8 à 12 mois.0.60 de 12 à 16 mois.0.65 de 16 à 20 mois.0,70 de 20 à 24 mois.0.75 24 mois et plus.0.79% Taux des commençants \u2014 Drapcu.scs préposée aux garnitures: 1 ers quatre mois.0.50 de 4 à 8 mois.0.55 de 8 à 12 mois.0.60 de 12 à 16 mois.0.65 del6à20mois.0.70 de 20 à 24 mois.0.75 de 24 à 30 mois.0.80 30 mois et plus.0.87 Taux des commençants \u2014 D râpeuse: 1 ers quatre mos.0.50 de 4 à 8 mois.0.55 de 8 à 12 mois.0.60 de 12 à 16 mois.0.65 de 16 à 20 mois.0.70 de 20 à 24 mois.0.75 de 24 à 28 mois.0.80 de28à32mois.0.90 32 mois et plus.0.97M Taux des commettants \u2014Préposé à la couture des tissus et des pailles: 1 ers quatre mois.0.70 dc 4 à 8 mois.0.80 de8àl2mois.0.90 de 12 à 16 mois.1.00 del6à20mois.1.10 de20à24mois.1.20 de 24 à 28 mois.1.30 28 mois et plus.1.39% Employés généraux: 1 ers trois mois.0.50 de3à6mois.0.55 de6à9mois.0.60 de9àl2mois.0.65 de 12 à 15mois.0.70^ 15 mois et plus.0.75\" rioilic increase which has to be made effective with respect to each apprentice during the term of such worker's apprenticeship.Upon receipt of such notice, the employer shall be obliged to implement the wage increase on its effective date as provided for in the starting rates schedules governing the various classifications.However, if the employer deems, in special cases, that an apprentice or handicapped worker has not increased his or her productivity in accordance with his or her period of training, then the employer may exercise the right to claim a special permit authorizing a lower rate than that fixed in the schedule, all as provided for in subsection \"d\" of section III.Under the foregoing circumstances, the manufacturer may withhold the increase from its effective date until such time as the case is heard and decided by the Parity Committee.If the Parity Committee finds that such apprentice has increased his or her productivity in accordance with his or her period of training, and is justified in the increase from the effective date thereof then and in such event such increase shall be paid by the employer retroactively from the effective date of the said periodic increase.Starting rate schedule or trimmers: First4months____\".SO.50 4 to 8 months.0.55 8 to 12 months.0.60 12 to 16 months.0.65 16 to 20 months.0.70 20 to24 months.0.75 24 months and over.0.79% Starting rate for trimmer-drapers: Firs I months.0.50 4 to8 months.0.55 8 to 12 months.0.60 12 to 16 months.0.65 16 to 20 months.0.70 20 to 24 months.0.75 24 to 30 months.0.80 30 months and over.0.87 Starting rate schedule for drapers: Firs4 months.0.50 4 to S months.0.55 8 to 12 months.0.60 12 to 16 months.0.65 16 to 20 months.0.70 20 to 24 months.0.75 24 to 28 months.0.80 28 to 32 months.0.90 32 months and over.0.97^2 Starting rate schedule for fabric and straw operators: Firs 4 months.0.70 4 to 8 months.0.80 8 to 12months.:.0.90 12 to 16 months.1.00 16 to 20 months.1.10 20 to 24 months.120 24 to 28 months.1.30 28 months and over.1 \u2022 39% General hands: First 3 months.0.50 3 to 6 months.0.55 6 to 9 months.0.60 9 to 12 months.0.65 12 to 15 months.0.70 ^ 15 months and over.0.75 428 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÈIlEi.'.Québec, 2S janvier 1950, Tome 88, N° /, 3° Les mots \"nu moins six mois\" apparaissant au premier alinéa du paragraphe \"o\" de l'article III, sont remplacés par les mots \"au moins deux mois\".(Documents \"F\" annexé à l'arrêté).L.D KSI LETS.41571-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTE EN CONSEIL CHAMBRE DC CONSEIL EXÉCUTIF Number 48 Québec, le 18 janvier 1950.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil Section \"G\" Concernant une modification au déerçt relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Québec.Attendu que, conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil, une modification au décret numéro 44 du 14 janvier 1954, amendé par les arrêtés en conseil numéros 001 -E et 773-C des 9 juin et 28 juillet 1954, 100-1), 101-B et 005-A des 20 janvier et 15 juin 1955, relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour daines dans la région de Québec, à l'effet d'ajouter à la zone IX de sa juridiction territoriale les municipalités de paroisse de Saint-Ephrem et dc Saint-Ephrem-de-Tring: Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 10 décembre 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro -14, soit modifié comme suit: \"Aux articles 55 et 94., les municipalités de Saint-Êphrem et de Saint-Ephrcm-de-Tring sont ajoutées et deviennent assujetties audit décret.\" (Document \"G\" annexé à l'arrêté).L.DÉSILETS.41071-o Greffier du Conseil Exécutif.3.The words \"at least six months\" appearing in the first paragraph of subjection \"g\" of section III are replaced by the words \"at least two month\".(Document \"F\" annexed to the Order).L.DÉSILETS, 410\" 1 -o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 48 Quebec, January 18th, 195G.Present: The Lieutenant Governor in Council Part \"G\" Concerning an amendment of the decree relating to the men's and ladies' hairdressing trades in the district of Quebec.Whereas, pursuant to the procedure provided in section 8 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council an amendment to the decree No.14 of January 14th, 1954, amended by Orders in Council numbers 001-E and 773-C of June 9th and July 28th.1954, 100-D, 101-B and 005-A of January 20th, and June 15th.1955.relating to the men's and ladies' hairdressing trades in the district of Quebec, the purpose of which being to add to zone IX of its territorial jurisdiction the parish municipalities of St.Ephrem and St.Ephrem-de-Tring; Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of December 10th, 1955: Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendment; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 44, be amended as follows: In sections 55 and 94, the municipalities of St.Êphrem and St.Ephrem-de-Tring, are added and consequently become subject to the provisions of the said decree.(Document \"G\" annexed to the Order).L.DÉSILETS, 41671-0 Clerk of the Executive Council.Action en séparation de biens Action for Separation as to Property Canada, district d'Arthabaska, Cour Supérieure, N° 11156, dame Jeanne Prévost, ménagère, épouse commune en biens de Robert Bel it, avec qui elle demeure à Warwick, demanderesse, vs Robert Betit, domicilié à 35, rue Notre-Dame, Warwick, défendeur.AVIS Dame Jeanne Prévost, épouse de Robert Betit, mécanicien de Warwick, a formé contre son mari une demande en séparation dc biens.Victoriaville, le 24 janvier 1950.Le Procureur de la demanderesse, 41686-0 LAURENT TROTTIER.Canada, district of Artbabaska, Superior Court, No.11156, daine Jeanne Prévost, housekeeper, wife common as to property of Robert Betis, with whom she residing at Warwick, plaintiff vs Robert Betit, domiciled at 35 Notre-Dame street, Warwick, defendant.NOTICE Dame Jeanne Prévost, wife of Robert Betit, mechanic of Warwick, has instituted an action in separation as to property against her husband.Victoriaville, January 24, 1956.LAURENT TROTTIER.11686 Attorney for Plaintiff. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol 88, No.U 429 Avis divers Miscellaneous Notices Avis concernant l'aménagement de Forces Hydrauliques sur la rivière Bazin, a 8 milles du village de parent, comté de La violette.Notice concerning tue development of hydraulic power of the Bazin River, at 8 miles distance from the village of Parent, county of La violette.Conformément au régime des eaux courantes, In accordance with the Water Course Act, the la corporation du village de Parent, comté de Village Corporation of Parent, county of Lavio- Laviolette, après avoir obtenu par odre en conseil lette, after having obtained by Order in Council du gouvernement de la province de Québec, daté of the Government of the Province of Quebec, du 21 août 1954, lequel ordre autorise le ministre dated August 21st, 1954, which Order authorizes des Ressources Hydrauliques ù louer à la corpora- the Minister of Hydraulic Resources to lease to turn municipale dudit village, les forces hydrau- the Municipal Corporation of the said village, liqucs de la rivière Bazin, cantons Landry et the hudraulic power resources of the Bazin Bazin, entre le pont du 8 milles du chemin qui River, Townships of Landry and Bazin, between conduit de Parent à Clova, et la rivière Pitch- the bridge at 8 miles from the road leading from pine, demande au lieutenant-gouverneur en Parent to Clova, and the Pitchpinc River, prays conseil la permission de construire, de maintenir the Lieutenant-Governor in Council for permis- ct d'exploiter un barrage en béton et une usine sion to build, maintain and develop a concrete génératrice d'électricité à environ 300 pieds en dam and electric generating station at some 300 amont du site dudit pont.feet above the site of said bridge.- Les originaux des plans et devis ont été déposés The original plans and specifications have au Département des Ressources Hydrauliques been deposited with the Department of Hydrau- de la province de Québec, et copies desdits plans .lie Resources of the Province of Quebec, and copy et devis ont été déposés au bureau dc la division of said plans and specification has been deposited d'enregistrement du comté à Amos comté d'Abi- at the Registry Office of the Registration Divi- tihi.sion of the county of Abitibi at Amos.La demande contenue dans cette requête sera The application contained in this petition will prise en considération le ou après les jours sui- be taken into consideration on or about the days vants la date de la dernière publication du pré- following the date of the last publication of this sent avis dans la Gazette officielle de Québec.notice in the Quebec Official Gazette.Québec, 10 Janvier 195G.Quebec, January 16th, 1956.Les Ingénieurs-conseils, ZACHÉE & PIERRE LANGLAIS, ZACHÉE & PIERRE LANGLAIS.Consulting Engineers.41621-3-4-0 41621-3-4 (Sec.P.657-55) (P.Sec.657-55) Avis est, par les présentes, donné que sur la Notice is hereby given that, upon the re- reeommandation de l'Assistant procureur général, commendation of the Deputy Attorney General, l'Honorable Secrétaire de la Province a.le IS the By-laws of \"Ionian Islands Club\", as adopted janvier 1956, approuvé les règlements de \"Ionian at a General Meeting held on December 19th, Islands Club\" tels qu'adoptés à une assemblée 1955 and amended at a meeting held on January générale tenue le 19 décembre 1955 et amendés 3rd, 1956.were approved by the Honourable the à une assemblée tenue le 3 janvier 1950.et ce.Provincial Secretary on January 18th, 1956, conformément aux dispositions de l'article 225 pursuant to the provisions of section 225 of the de la Loi des compagnies de Québec.Quebec Companies' Act.Donné au bureau du Secrétaire de la province, Given at the office of the Provincial Secretary ce 19e jour de janvier 1956.this 19th day of January, 1956.Le Sous-secrétaire de la province.JEAN BRUCHÉSI, 11007 JEAN BRUCHÉSI.41667-0 Under-Secretary of the Province.Avis est par les présentes donné que l'honorable Notice is hereby given that the Honourable Secrétaire de la province a dûment reçu le the Provincial Secretary has duly received the troisième original de la déclaration de fondation third copy of the original of the declaration of du syndicat coopératif \"Jean Caboto Coopéra- foundation of the cooperative syndicate \"Jean tive\", en date du 4 janvier 1950, dont le siège Caboto Coopérative\", under the (late of January social est situé à Montréal, district judiciaire de 4, 1956.whereof the head office is at Montreal, Montréal, et que ce document a été déposé judicial district of Montreal, and that the said dans les archives du Secrétariat de la province, document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Donné au bureau du Secrétaire de la province Given at the office of the Provincial Secretary, le dix Janvier 1956.this tenth day of January 1956.Le Sous-secrétaire de la province, JEAN BRUCHÉSI, 41G68-0 JEAN BRUCHÉSI.41668 Under Secretary of the Province.Avis est donné que l'honorable Secrétaire de Notice is hereby given that the Honourable the la province a émis, le vingt-huit décembre 1955, Provincial Secretary has issued, on December un certificat constituant en corporation la twenty-eighth, 1955, a certificate incorporating \"Société Saint-Jean-Baptiste Locale de Ste- the \"Société Saint-Jean-Baptiste Locale de Ste- Famille\", dont le siège social est situé en la Famille\", Whose head office is situated in the paroisse de Sainte-Famille de Cap-dc-la-Made- parish of Sainte-Famille of Cap-de-la-Madeleine, leine, dans le district judiciaire des Trois-Rivières, in the judicial district of Trois-Rivières, and such, et ce, conformément aux dispositions des articles pursuant to the provisions of sections 15 and 430 GAZETTE OFFICIELLE DE 01TÈBÈC, Québec, 88 janvier 1956, Tome 88, N° J, 15 et suivants de la Loi concernant la Société Saint-Jean-Baptjste de la région des Trois-Rivières, 3-4 Elizabeth II, chapitre 161.Donné au bureau du Secrétaire de la province le cpiatre janvier 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 41670-O JEAN BRUCHÉSI.(Sec.P.733-55) Avis est, par les présentes, donné que.par Ordre en Conseil, en date du 21 décembre 1955, il a plu à son Honneur le Lieutenant-gouverneur d'autoriser la compagnie \"Federal Insurance Company\" de se porter caution en justice, conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies de garanties, S.R.Q., 1941, chapitre 285.Donné au bureau du Secrétaire île la province, ce 21e jour de janvier 1950.Le Sous-sccrctaire de la province.41001 JEAN BRUCHÉSI.(Sec.P.861-55) Avis est donné que, par arrêté ministériel en date du 18 janvier 1950, il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur d'autoriser la compagnie \"National Fire Insurance Company of Hartford\", à se porter caution en justice dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de garantie, chapitre 285 des Statuts refondus de Québec 1941.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-trois janvier 1950.Le Sous-secrétaire de la province, llGGl-o JEAN BRUCHÉSI.(Sec.P.534-55) Avis est, par les présentes, donné que par Ordre en Conseil en date du 21 décembre 1955, il a plu à son Honneur le Lieutenant-gouverneur d'autoriser la compagnie \"Scottish Canadian Assurance Corporation\" de se porter caution en justice, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de garantie, S.R.Q.1941, chapitre 285.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 21e jour de janvier 1950.Le Sous-secrétaire dc la Province, 41001 JEAN BRUCHÉSI.(Sec.P.066-55) Avis est donné que, par arrêté ministériel en date du 18 janvier 1950, il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur d'autoriser la compagnie \"The Canadian Indemnity Company\" à se porter caution en justice dans Ja province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de garantie, chapitre 285 des Statuts refondus de Québec 1941.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-trois janvier 1950.Le Sous-secrétaire de la province, 41661 -o JEAN BRUCHÉSI.(Sec.P.535-55) Avis est, par les présentes, donné que.par Ordre en Conseil, en date du 21 décembre 1955, il a plu à son Honneur le Lieutenant-gouverneur d'autoriser la compagnie \"The General Accident Assurance Company of Canada\" de se porter caution en justice, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de garantie, S.R.Q.1941, chapitre 285.Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 21e jour de janvier 1956.Le Sous-secrétaire de la province, 41661 JEAN BRUCHÉSI.following of the Act concerning the Société Saint-Jean-Baptiste of the region of Trois-Rivières, 3-4 Elizabeth II, chapter 161.Given at the office of the Provincial Secretary on January fourth, 1956.JEAN BRUCHÉSI, 41670 Under Secretary of the Province.(P.Sec.733-55) Notice is hereby given that, by Order in Council dated December 21st, 1955, His Honour the Lieutenant-Governor was pleased to author ize the \"Federal Insurance Company\" to become judicial surety, pursuant to the provisions of the Guarantee Companies' Act, R.S.Q.1941, chapter 285.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of January, 1956.JEAN BRUCHÉSI.41661-0 Under Secretary of the Province.(P.Sec.861-55) Notice is hereby given that, by Order in Council dated January 18th, 1950, His Honour, the Lieutenant-Governor has been pleased to authorize the company, \"National Fire Insurance Company of Hartford\" to become judicial surely in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Guarantee Companies' Act, chapter 285, of the Revised Statutes of Quebec, 1941.Given at the office of the Provincial Secretary on January twenty-third, 1950.JEAN BRUCHÉSI.41661 Under Secretary of the Province.(P.See.534-55) Notice is hereby given that, by Order in Council dated December 21st, 1955, His Honour the Lieutenant-Governor was pleased to authorise the \"Scottish Canadian Assurance Corporation\" to become judicial surety, pursuant to tin-provisions of the Guarantee Companies' Act, R.S.Q.1941, chaptc 285.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st dav of January, 1956.JEAN BRUCHÉSI, 41661-0 Under Secretary of the Province.(P.Sec.666-55) Notice is hereby given that, by Order in Council dated January 18, 1956, His Honour, the Lieutenant-Governor has been pleased to authorize the company \"The Canadian Indemnity Company\" to become judicial surety in tin-Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Guarantee Companies' Act, chapter 285 of the Revised Statutes of Quebec, 19-11.Given at the office of the Provincial Secretary on January twenty-third, 1956.JEAN BRUCHÉSI, 41661 Under Secretary of the Province.(P.Sec.535-55) Notice is hereby given that, by Order in Council dated December 21st, 1955, His Honour the Lieutenant-Governor was pleased to authorize \"The General Accident Assurance Company of Canada\" to become judicial surety, pursuant to the provisions of the Guarantee Companies' Act, R.S.Q.1941, chapter 285.Given at the office of the Provincial Secretary this 21st day of January, 1956.JEAN BRUCHÉSI, 41661-Q Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No.U 431 (Sec.P; 800-05) Avis est donne que, par arrêté ministériel en date du 18 Janvier 1956, il a plu à Son Honneur |ç Lieutenant-gouverneur d'autoriser la compagnie \"Transcontinental Insurance Company\" à se porter caution en justice dans la province dc Québec, conformément aux dispositions «le la Loi des compagnies de garantie, chapitre 285 des Statuts rcfomlus de Québec 1941.Donné au bureau du Secrétaire de la province le vingt-trois janvier 1956.Le Sous-secrétaire de la province, U661-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.11307-55) Hahvev & Fils Limitée Harvey & Sons Limited Règlement N° IV Changeant le nombre «les directeurs \"Attendu «pie le nombre «les requérants pour l'obtention d'une charte suivant la Loi des Compagnies «le Québec a fixé à cinq (5) le nombre des directeurs «le la compagnie; Attendu qu'il est de l'intérêt de la compagnie de réduire ce nombre dc cinq (5) à trois (3) directeurs; Attendu qu'un règlement à cet effe est nécessaire; Il est résolu à l'unanimité de réduire «le cinq (5) à trois (3) le nombre des directeurs de la compagnie.\" Règlement adopté le 28 décembre 1955.( 'opie conforme.Le Secrétaire, 11687-0 LÉONCE HARVEY.(P.G.1000-42) Deschênes & Fils, Limitée Règlement N° 18 \"Le règlement N° 5 de la compagnie est amendé en remplaçant le mot \"trois\" dans la première ligne par le mot \"cin«i\", et le nombre des directeurs constituant le bureau de direction «le la compagnie est en conséquence augmenté de trois à cinq.\" ( Certifié copie véritable d'un règlement adopté par les directeurs de Deschênes & Fils, Limitée à leur assemblée tenue le 14 septembre 1954 et approuvé par les actionnaires.Le Secrétaire.U694-0 AUGUSTIN LECLERC.(P.G.7354-46) Globe Processing Limited Règlement spécial \"A\" Augmentant le nombre des directeurs de la compagnie de trois à cinq.\"Que le règlement II des règlements dc la compagnie soit et il est, par les présentes, amendé pour se lire comme suit: IL Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de direction «le cinq directeurs, trois desquels formeront quorum.\".\u2022le.A.C.Howatson, secrétaire-trésorier de Globe Processing Limited, certifie, par les présentes, que le précédent est une copie véritable et conforme du règlement spécial \"A\" décrété par le bureau «les directeurs à son assemblée tenue le 28c jour de décembre 1955.en la cité de Montréal, province de Québec et ratifié et confirmé à une assemblée générale spéciale des actionnaires «le la (P.Sec.860-55) Notice is given that by Order in Council «lated January 18, 1956, His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased to authorize the company \"Transcontinental Insurance Company\" to become surety before the courts in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Guarantee Companies' Act, chapter 285 of the Revised Statutes of Quebec 1941.Given at the office of the Provincial Secretary, the twenty-third day of January 1956.JEAN BÏIUCHÉSI, 41001 Under Secretary of the Province.(A.G.11307-55) Harvey & Fils Limitée Harvey & Sons Limited By-law No.IV Changing the number of directors.\"Whereas the number of petitioners required for the obtaining of a charter under the Quebec Companies' Act had fixe«l at five (5) the number of directors of the company; Whereas it is in the interest of the company to «lecrease said number of five (5) directors to three (3) directors; Whereas a by-law to this effect is necessary; It is unanimously résolve»! to decrease from five (5) to three (3) the number of the company's directors.\" By-law adopted December 28, 1955.True copy.LÉONCE HARVEY, 41687 Secretary.(A.G.4000-42) Deschênes & Fils, Limitée By-law No.18 \"Company's By-law No.5 is amended by replacing the word \"three\" in the first line by the word \"five\", and the number of directors constituting the Board of Directors of the company is therefore increased from three to five.\" Certified true copy of a by-law adopted by the directors of Deschênes & Fils, Limitée at their meeting held September 14, 1954 and confirmed by the shareholders.AUGUSTIN LECLERC, 41694 Secretary.(A.G.7354-46) Globe Processing Limited Special By-law \"A\" Increasing the number of the Directors of the Company from three to five.\"That by-law number II of the Company's by-laws be and the same is hereby amended to read as follows: II.The affairs of the Company shall be managed by a Board of five Directors, three of whom shall form a quorum.\" I, A.C.Howatson, Secretary-Treasurer of Globe Processing Limited, do hereby certify the foregoing to be a true and exact copy of special by-law \"A\" enacted by the Board of Directors at its meeting heltl on the 28th day of December, 1955, at the city of Montreal, Province of Quebec, and ratified and confirmed at a special general meeting of the shareholders of the company 432 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° 4 compagnie tenue le 28c jour de décembre 1955 à laquelle étaient présents en personne ou par procuration les détenteurs de toutes les actions émises de la compagnie qui votèrent à l'unanimité en faveur de la sanction et ratification dudit règlement.Montréal.Québec, 3 janvier 1956.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 41696 A.C.IK)WATSON, Avis est par les présentes donné (pie l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Oeuvres paroissiales de Stc-Margucritc-Marie\", en date du 11 décembre 1955, dont le siège social est situé à Sainte-Marguerite-Marie, comté de Roberval, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le quatre janvier 1956.Le Sous-sccrétaire dc la province, 41695-o JEAN BRUCHÉSI.held on the 28th day of December, 1955, at which were present in person or represented by proxy the holders of all the issued shares of the company who voted unanimously in favour of sanctioning and ratifying the said by-law.Montreal, Quebec, January 3rd, 1956.(Seal) A.C.HO WATSON, 41696-o Secretary-Treasurer.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Oeuvres paroissiales de Stc-Margueritc-Marie\" under date December 11, 1955, whereof the head office is at Sainte-Margucrite-Maric, county of Roberval.and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this fourth dav of January.1956.JEAN BRUCHÉSI.41695 Under Secretary of the Province.Chartes \u2014 Abandon de Prenez avis que la compagnie \"Le Club Colomb de Farnham Incorporé\", demandera au procureur général la permission d'abandonner sa charte.I^e Procureur dc.la Compagnie, 41669-0 Me.MAURICE ARCHAMBAULT, c.r.MoNTiticoT Mills Ltd.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Montricot Mills Ltd., s'adressera à l'Honorable Procureur général et l'Honorable T\\ 1 inist re des Affaires Municipales de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément à la Loi.Montréal, 23 janvier 1956.Le Procureur de Montricot Mills Ltd.GREGORY CHARLAP.660 ouest, rue Ste-Catherinc, Montréal.41688 Compagnie dissoute (P.G.12633-55) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plus au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Lady Fair Dress Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 juin 1944.Avis est de plus donné qu'à compter du neuf janvier 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le douze janvier 1950.¦ » L'Assistant-procureur général, 41661-0 C.E.CANTIN.Charters \u2014 Surrender of Take notice that the company \"Le Club Colomb de Farnham Incorporé\", will apply to the attorney general for leave to surrender its charter.Me.MAURICE ARCHAMBAULT, Q.C., 41609-o Attorney for the Company.- Moxtricot Mills Ltd.Notice is hereby given that Montricot Mills Ltd., will apply to the Honourable the Attorney General, and the Honourable the Minister of Municipal Affairs of Quebec, for leave to surrender its Charter according to law.Montreal, January 23, 1950.GREGORY CHARLAP, Solicitor for Montricot Mills Ltd.GOO St.Catherine West, Montreal.41088-O Company Dissolved (A.G.12033-55) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, section 20, chapter 276.R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Lady Fair Dress Inc.\", incorporated by letters patent dated June 10, 1944.Notice is also given that from and after January ninth, 1950, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of January, 1956.C.E.CANTIN, 41661 Deputy Attorney General.Demandes à la Législature Applications to Legislature Avis est par les présentes donné que la cité de Notice is hereby given that the city of St, Ste-Foy a I'intention^de présenter à l'Assemblée Foy intends submitting a draft bill to the Legis- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No.4 433 Législative, lors de la présente session, un projet de bill dont l'objet sera de demander les pouvoirs additionnels suivants: une pension annuelle dc §3,600.00 au greffier de la cité de Stc-Foy et advenant son décès, une pension annuelle de* $1,800.00 ù sa veuve; le réajustement du rôle d'évaluation au moment d'une transaction immobilière; la définition des termes \"officier municipal\" pour désigner le trésorier; la consolidation de certaines dépenses capitales; l'abrogation des articles 110 et 111 dc la Loi des cités et villes pour la cité de Ste-Foy; le remplacement du paragraphe 3 dc l'article 520 de la Loi des cités et villes; l'imposition d'une taxe spéciale sur certaines transactions immobilières; la remise d'un certificat d'hypothèque en remettant le bulletin de présentation; la répartition des taxes entre la municipalité et les propriétaires riverains pour, la construction et l'entretien des trottoirs; le pouvoir de conclure des ententes avec le gouvernement de Sa Majesté la Reine pour les fins de sendees publics; la formatiion d'un commission d'urbanisme.Ste-Foy, le 25 octobre 1955.Le Procureur de la cité de Ste-Foy, 11531-2-4-0 ROBERT B.LAFRENIÊRE.Avis public est par les présentes donné que Monsieur Conrad Lavcrdurc, Ing.P., demeurant à 2525 est, rue Sherbrooke, app.45\u201e à Montréal, demandera aux Corps législatif dc la province de Québec, à leur présente session, l'adoption d'une loi tendant à radier une servitude consistant en un droit de passage pour aller puiser de l'eau à'la rivière et établie sur le lot originaire numéro 27 du cadastre hypothécaire de la paroisse de St-Laurent, comté de Jacques-Cartier, et actullement connu et désigné comme étant les subdivisions 5, G, 7, S, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 17, 18, 19, 20 et 21 du lot originaire numéro 27 des plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse de St-Laurent, en vertu (l'un acte de vente passé devant Me J.Henri Olivier, notaire, en date du 0 avril 1892, par lequel Dame Malvina Duckett, épouse contractuellemcnt séparée de biens de Henri P.Pepin-Ecuicr, notaire, a vendu à Hormisdas Meunier dit La-gacé une partie du lot de terre comme étant partie du lot numéro 20 du cadastre hypothécaire de la paroisse de St-Laurent, comté de Jacques-Cartier, et enregistré sous le numéro 42,504 du bureau de la division d'enregistrement d'IIochelaga et de Jacques-Cartier.Montréal, le 4 janvier 1950.Le Procureur du pétitionnaire, JEAN ARCHAMBAULT, C.R., 370 ouest, rue Craig, Montréal, P.Que.41532-2-4-0 Avis est par les présentes donné que \"Pierre Otto Oscar Marie de Charmant\", étudiant, des cité et district de Montréal, s'adressera à la Législature de la Province de Québec à sa présente session pour demander l'adoption d'une loi aux fins de faire reconnaître l'équivalence dc sa première année d'études de droit faite à l'Université de Genève, en Suisse, et pour d'autres fins.Montréal, le 5 janvier 1956.\u2022 , Les Procureurs du Requérant HUGESSEN.MACKLAIER, CHISHOLM, SMITH 41563-2-4-0 & DAVIS.lative Assembly, at its present session, with the object of requesting the following additional powers: to grand annual pension of $3,600.00 to the Clerk of the city of St.Foy, and in the event of his death, an annual pension of $1,800.00 to his widow; to readjust the valuation roll at the time of a real estate transaction; define the term \"Municipal Officer\" to designate the treasurer; consolidate capital expenditures; to repeal section 110 and 111 of the Cities and Towns Act for the city of St.Foy; replace paragraph 3 of section 520 fo the Cities and Towns Act; levy a special tax on certain real estate transactions; hand over a mortgage certificate when nomination-paper is returned; assessment of taxes between the municipality and riverside property owners for the building and maintenance of sidewalks; the power to enter into agreements with Her Majesty's Government respecting public services; establish a town-planning commission.St.Foy, October 25th, 1955.ROBERT B.LAFRENIÊRE, 41534-2-4-0 Attorney for the city of St.Foy.Public notice is hereby given that Mr.Conrad Laverdure, P.Eng., residing at 2525 Sherbrooke Street East, Apt.45, Montreal, will petition the Legislative Bodies of the Province of Quebec, at their present session, for an Act purporting to radiate a servitude consisting in a right of way to draw water from tfie river and established on the original lot number 27 of the hypothecary cadastre of the parish of St-Laurent, county of Jacques-Cartier, and actually known and designated as subdivisions 5, 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 of the original lot number 27 of the official plan and book of reference of the parish of St-Laurent, in virtue of a deed of sale executed before Me J.Henri Olivier, notary, dated April 6th 1892, by which Dame Malvina Duckett of the city of Montreal, wife didy separate as to property in virtue of her marriage contract with her husband Henri P.Pepin-Ecuicr, notary, sold to Hormisdas Meunier dit Lagacé a part of lot known and designated as lot number 26 of the hypothecary cadastre of the parish of St-Laurent, county of Jacques-Cartier, and registered under number 42,504 in the office of the registration of Hoche-laga and Jacques-Cartier.Montreal, January 4th, 1956.JEAN ARCHAMBAULT, Q.C., Attorney for the petitioner.370 Craig Street West, Montreal, P.Que.41532-2-4-0 Notice is hereby given that \"Pierre Otto Oscar Marie de Charmant\", law student, of the city and district of Montreal will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session for the passing of an Act to recognize the equivalence of his first year of law studies at the University of Geneva, Switzerland, and for other purposes.Montreal, January 5th, 1956.HUGESSEN, MACKLAIER, CHISHOLM, SMITH & DAVIS, 41563-2-4-0 Attorneys for Applicant. 434 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N* 4 Avis public est par les présentes donné que \"La Corporation des Sœurs de Sainte-Croix et des Sept Douleurs\", corps politique et incorporé, ayant son siège social à ville St-Laurent, dans le district de Montréal, s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à la présente session, pour l'adoption d'une loi lui conférant la pleine propriété avec droit d'en disposer, des biens de la Succession de feu Marie-Ida Grenier, en religion Sœur Marie de St-David.Montréal, le 9 janvier 1956.Les Procureurs dc la requérante, PATENAUDE & PATENAUDE.41564-2-4-0 Public notice is hereby given that \"La Corporation des Sœurs de Sainte-Croix et des Sept Douleurs\", a body politic and corporate, having its Head Office in the city of St.Laurent, district of Montreal, will apply at the present session of the Quebec Legislature for an act giving full ownership and full right of disposal of the assets of the late Marie-Ida Grenier, in religion Sister Marie de St.David.Montreal, January 9th, 1956.PATENAUDE & PATENAUDE, Solicitors for Applicant.41564-2-4-0 Département de l'Agriculture Industrie Laitière Commission* de l'Industrie Laitière de la Province de Québec Ordonnance N° 1-51C Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mardi, 24 janvier 1956, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Québec, à 10 heures de l'a vaut-midi.Présents: MM.Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert, Adrien Angers, J.-Albert Chartrand, Walter D.Lowe, commissaires et Alphonse Savoie, secrétaire.La Commission décrète ce qui suit: L'ordonnance N° 1-51, publiée dans la Gazelle officielle de Québec du 0 octobre 1951, est amendée et l'article 2 est remplacé par le suivant: 2° La région de Montréal comprend les municipalités suivantes, situées dans le district judiciaire de Montréal, savoir: la cité de Montréal, la cité d'Outremont, la cité dc West mount, la ville de Montréal-Ouest, la cité de Verdun, la cité dc Lachinc, la cité de Longueuil, la cité de Saint-Lambert, la ville dc Dorval, la ville de Pointe-Claire, la ville de Montréal-Est, la ville de Mont-Royal, la ville de Hampstead, la municipalité du village de la Côte Saint-Luc, là ville de Saint-Laurent, la ville dc Saint-Michel, la ville de Montréal-Nord, la ville de Saint-Pierre, la ville de Lasalle, la ville de Greenfield Park, la ville de Montréal-Sud, la ville dc Pointc-aux-Trembles, le Port de Montréal, la ville de Beaconsfield.la ville de Baie d'Urfé, la ville dc Saint-Anne de Bellevue, la paroisse dc Notre-Dame-de-Liesse, la ville de Jacques-Cartier, la ville Lcmoync, la ville de Maekayville, le village de Boucherville, la paroisse de Stc-Famille-de-Bouchcrvillc, la municipalité de St-Hubcrt et celle de Notrc-Dame-du-Saeré-Cçeur.La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Signé: Omer-E.Milot, président, Joseph Hébert, commissaire, Adrien Angers, commissaire, J.-A.Chartrand, commissaire, Walter D.Lowe, commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire.41690-0 Department of Agriculture Dairy Industry Dairy Industry Commission of the Province of Quebec Order No.1-51C Excerpt from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Tuesday.January 24th, 1950, held in the office of the Dairy Industry Commission in Quebec, at 10 o'clock in the morning.Present : Messrs.Omer-E.Milot, President, Joseph Hébert, Adrien Angers, J.-Albert Chartrand, Walter I).Lowe, Commissioners and Alphonse Savoie, Secretary.It is enacted as follows: Order No.1-51/ published in the Quebec Official Gazette of October 6th, 1951 is amended and article 2 is replaced by the following: 2.The region of Montreal includes the following municipalities situated in the judicial district of Montreal, namely : the city of Montreal the city of Outremont, the city of Wcstmount, the town of Montreal-West, the city of Verdun, the city of Lachine, the city of Longueuil, the city of Saint-Lambert, the town of Dorval, the town of pointé-Claire, the town of Montreal-East, the town of Mount Royal, the town of Hampstead, the municipality of the village of Côte Saint-Luc, the town of Saint-Laurent, the town of Saint-Michel, the town of Montreal-North, the town of Saint-Pierre, the town of Lasalle, the town of Greenfield Park, the town of Montreal-South, the town of Pointe-aux-Trembles, the Harbour of Montreal, the town of Beaconsfield, the town of Baie d'Urfé, the town of Sainte-Anne de Bellevue, the parish of Notre-Dame-de-Liesse, the town of Jacques-Cartier, the town of Lemoyne, the town of Maekayville, the village of Boucherville, the parish of Ste-Famille-de-Boucherville, the municipality of St-Hubert and that of Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.The present order shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Signed: Omer-E.Milot, President, Joseph Hébert, Commissioner, Adrien Angers, Commissioner, J.-A.Chartrand, Commissioner, Walter D.Lowe, Commissioner.Certified: Alphonse Savoie, Secretary.41690-o QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No.4 435 Département de l'Instruction Publique NT0 531-55.Québec, le 17 janvier 1956.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Jules, dans le comté de Beau-ce, les lots 46 à 48 inclusivement du rang I [du canton Broughton, pour les annexera la municipalité scolaire de Saint-Frédéric, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.41658-3-2-0 O.J.DÉSAULNIERS.N° 949-55.Québec, le 24 janvier 1956.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 18 janvier 1956, de former en municipalité scolaire, pour les catholiques seulement, sous le nom de \"La municipalité scolaire catholique de Schefferville, Nouveau-Québec\" le territoire de la corporation municipale de la Ville de Schefferville, tel que décrit dans l'arrêté en conseil numéro 768 en date du 14 juillet 1955.Cet arrêté ministériel prendra effet 15 jours après sa passation, soit le 2 février 1956.Le Surintendant de l'Instruction publique, 41691-0 0.J.DÉSAULNIERS.N° 949-55.Québec, le 24 janvier 1956.Il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 18 janvier 1956, de former en municipalité scolaire, pour les protestants seulement, sous le nom de \"La municipalité scolaire protestante de Schefferville, Nouveau-Québec\" le territoire de la corporation municipale de la Ville de Schefferville, tel que décrit dans l'arrêté en conseil numéro 768 en date du 14 juillet 1955.Cet arrêté ministériel prendra effet 15 jours après sa passation, soit le 2 février 1956.Le Surintendant de l'Instruction publique, I1091-o O.J.DÉSAULNIERS.Department of Education No.531-55.Quebec, January 17th, 1956.Application is made to detach from the School Municipality of Saint Jules, in the county of Beauce, lots 46 to 48 inclusive, of range I, township of Broughton, in order to annex them to the school municipality of Saint Frédéric, same County.O.J.DÉSAULNIERS, 41658-3-2 Superintendent of Education.No.949-55.Quebec, January 24, 1956.His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council dated January 18, 1956, to form into a school municipality, for Catholics only, under the name of \"The Catholic School Municipality of Shefferville, New-Quebec\", the territory of the municipal corporation of the Town of Schefferville, as described in Order in Council 768 dated July 14,1955.This Order in Council shall take effect 15 days following its enaction, that is on February 2.1956.O.J.DÉSAULNIERS, 41691 Superintendent of Education.No.949-55.Quebec, January 24, 1956.His Honour, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated January 18, 1956, to form into a school municipality, for Protestants only, under the name of \"The Protestant School Municipality of Schefferville, New-Quebec\", the territory of the municipal corporation of the town of Schefferville, as described in Order in Council number 768 dated July 14.1955.This Order in Council will become effective 15 days after it has been passed, i.e.February 2.1956.0.J.DÉSAULNIERS, 41691 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts Department of Lands and Forests AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg (Ville de Charlesbourg) division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 689-8 (rue) est annulé en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 11 janvier 1956.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 41662-0 AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Polycarpe (municipalité de Coteau-Station) division d'enregistrement de Soulanges.Avis est par la présente donné que les lots NOTICE Officiai cadastre of the parish of Charlesbourg (town of Charlesbourg) registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots GS9-8 (street) has been cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, January 11,1956.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 41662-o .Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the parish of St-Polycarpe (municipality of Coteau-Station) registration division of Soulanges.Notice is hereby given that lots 172-47 to 436 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° 4 172-47 à 172-76 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 28 décembre 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 41662-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du canton de Parent division d'enregistrement dc Lae-St-.Jean-Ouest.Avis est par la présente donné que l'Ile N° 58 de la rivière Ashuapniouchouan, est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 4 janvier 1956.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 41662-o AVILA BÉDARD.172-76 are cancelled in virtue of Article 2171A of the civil Code.Quebec, December 28.1955.Department of Lands and Forests.Cadastral Branch.' AVILA BÉDARD.41662-0 Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the township of Parent registration division of Lake St.John-West.Notice is hereby given that Island No.58 in Ashuapmouchouan river is added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, January the 4th, 1956.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD, 41662-0 Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitra, 163 et amendements), que le Comité paritaire, des barbiers et coiffeurs des comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, Laval (Ile Jésus) et Terrebonne, établi en exécution du décret numéro 140 du 27 février 1952, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 47 du 18 janvier 1950 (section \"D\"), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites: 1.Cotisation La période dc cotisation s'étend du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1956; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 140 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 140 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% du salaire moyen fixé par le Comité, soit $60.00 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 140 et amendements doivent verse au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leur rémunération.2.M ode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent ê.tre indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de cfîaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.Department of Labour NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Acl (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the Barbers' and Hairdressers' Parity Committee of Argenteuil, Deux-Montagnes, Laval (Jesus Island) and Terrebonne counties, formed under decree No.140 of February 27, 1952, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 47 of January 18, 1950 (part \"D\"), to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the following conditions: 1.Assessments The period of levy extends from January 1.1950, to December 31, 1950; the levy shall be laid as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 140, and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y of 1% of their payroll as regards the employees governed by the said decree.b) The artisans governed by the said decree, number 140 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Yi of 1% of the average wage determined by the Committee, i.e., $00.00 per week.c) The employees governed by the said decree, number 140, and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Yi of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all particulars required by the Parity Committee shall be given.The professional employer shall complete his report, sign and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each w-eek, in the name of the Committee, the assessments of his employees by means of a deduction from the latter's wages. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No./, 437 L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le lOième jour du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le comité a le pouvoir d'exiger l'asser-mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un «employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou dc donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (ô) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel dc ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, ^30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés probables du Comité paritaire des Barbiers et Coiffeurs des comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, Laval (Ile Jésus) et Terrebonne, pour la période comprise entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1956.Le Comité paritaire des Barbiers et Coiffeurs des comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, LavXl (Ile Jésus) et Terrebonne (Siège social : St-Eustache) État «les recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1956.Recettes: Cotisations (Lg de 1%): Employeurs professionnels.S 350.00 Artisans.4,500.00 Salariés.350.00 Honoraires d'examens.190.00 Recettes diverses.10.00 S5.400.00 Déboursés: Salaires: Secrétaire.S 060.00 Trésorier.660.00 Inspecteur.550.00 Frais de déplacement \u2014 inspecteur.630.00 Frais de déplacement et de représenta- tation du président et des membres.1.000.00 Bureau d'exam natcurs.650.00 Jetons de présence.300.00 Administration: timbres, téléphone, papeterie.450.00 Frais dc vérification.100.00 Frais légaux.300.00 Divers.100.00 S5.400.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 28 janvier 1956.41671-o The professional employer shall submit his monthly report to the Parity Committee on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which it is requirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employers and those of his employees.The Committee is empowered to exact sworn reports when deemed advisable.The assessments laid by the present by-law are payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Five days' notice shall be given to any professional employer or artisan refusing to pay or to give the necessary information to the Parity Committee.3.Financial report In pursuance of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour a quartely report of its financial activities on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Barbers' and Hairdressers' Parity Committee of Argenteuil, Deux-Montagnes, Laval (Jesus Island) and Terrebonne counties for the period between January 1, 1956 and December 31, 1956.' The Barbers' and Hairdressers' Parity Committee of Argenteuil, Deux-Montagnes, Laval (Jesus Island) and Terrebonne Counties (Head office: St.Eustache) Estimate of the receipts and disbursements for the period between January 1, 1956 and December 31, 1956.Receipts: Assessments (% of 1%): Professional employers.S 350.00 Artisans.4,500.00 Employees.350.00 Examination fees.190.00 Various receipts.10.00 S5.400.00 Disbursements: Salaries: Secretary.S 660.00 Treasurer.660.00 Inspector.550.00 Inspector's travelling expenses.030.00 Travelling and entertainment cxpen- of president and members.1,000.00 Board of Examiners.650.00 Attendance fees.300.00 Administration: stationery, postage, telephone, printing, etc.450.00 Audition.100.00 Legal fees.300.00 Miscelleneous.100.00 S5.400.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, January 28, 1956.41671-0 438 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° 4 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire des barbiers-coiffeurs de Montréal, établi en exécution du décret numéro 21G2 du 20 août 1941, et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'Arrêté en Conseil numéro 48 du 18 janvier 1950, section \"C\", le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés; 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er février 1950 au 31 janvier 1957; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 2102 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% de la liste des salaires, commissions et allocations qu'ils versent à leurs salariés assujettis audit décret.b) Les artisans assujettis au décret numéro 2162 et amendements doivent également verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% du salaire moyen de $25.00 par semaine.c) Les salariés régis par le décret numéro 2102 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% des salaires, commissions et allocations reçues.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception dc ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués les nom, prénom et adresse de chaque salarié à leur emploi, leur qualification, les heures de travail ainsi que les salaires payés, y compris la proportion des commissions gagnées et les sommes versées au Comité paritaire.L'employeurs professionnel doit voir à ce (pic ces rapports soient remplis et retournés au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même la rémunération de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire et les faire parvenir lui-même audit comité.Le rapport dc l'employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au Comité paritaire.Ce Comité a le pouvoir d'exiger l'asser-mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le rapport, accompagné des cotisations, doit être adressé au Comité paritaire le ou avant le mercredi suivant la date d'expiration de la période pour laquelle ledit rapport est exigible.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état, des recettes et des déboursés prévus par la Comité paritaire des Barbiers-Coiffeurs de Montréal pour la période com- NOTICE OE LEVY The Honourable Antonio Barrette.Minister of Labour, hereby gives notice that the Parity Committee of Barbers and Men's Hairdressers of Montreal, formed under decree No.2102, of August 20th.19-11, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.18 of January 18th, 1950, part \"(\"' in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 103 and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned:.1.Assessments \u2022 The period of levy extends from February 1st.1950 to January 31st.1957: it is laid in the following manner: a) The professional employers governed by the decree No.2102, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Y of 1% of the wages, commissions and allowances paid to their employees governed by the said decree.b) The artisans subject to decree No.2102 and amendments, shall also pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yi of 1% of the average wage of $25.00 per week.c) The employees governed by the decree No.2102 and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yl °f 1% °' the wages, commissions and allowances received.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee shall supply the professional employers with report froms indicating the name in full and addrcsse of every employee in their employ, his competency, the hours of labour, the wages paid (including the proportion of the commissions earned) and the sums sent to the Parity Committee.The professional employer shall have the reports completed and sent to the Parity Com-mitee every mouth.The professional employer shall retain, at the end of each week, from the wages of every one of his employees, the sums owed to the Parity Committee and forward them himself to the said Committee.The report of the professional employer shall be signed before it is sent to the Parity Committee.The Commit lee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The report, together with the assessments, shall be sent to the Parity Committee on or before the Wednesday following the date of expiration of the period for which it is requirable.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial operations on the following dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Parity Committee of Barbers and Men's Hairdressers of Montreal QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No.4 439 prise entre le 1er février 195G et le 31 janvier for the period between February 1st, 1956, and 1057.January 31st, 1957.( .imité Paritaire des Barbiers-Coiffeurs Parity Committee of Barbers and Men's de Montréal Hairdressers of Montreal Estimé budgétaire pour la période comprise Estimated budget for the period between Feb-eiitrc le 1er février 1956 et le 31 janvier 1957.ruary 1st, 1956 and January 31st, 1957.Recettes: Cotisations (l/2 ('e *%): Receipts: Assessments: (% of 1%): Employeurs professionnels.S 9,000.00 Professional employers.$ 9,000.00 Salariés.9,000.00 Employees.9,000.00 Artisans.5,300.00 Artisans.5,300.00 Examens, pénalités, etc.500.00 Examinations, penalties, etc.500.00 Déboursés: Salaires.! Frais d'auto et de déplacements pour exécution du décret.liais de de déplacements et jetons de présence aux assemblées régulières et spéciales.;.Loyer et éclairage.Taxes et assurances.frais de poste et de banque.Vérification et rapports trimestriels.Papeterie et impression.Entretien du bureau et ménage.frais d'examens.Frais d'enquêtes.frais judiciaires et extrajudiciaires.Mobilier de bureau.frais de voyage, publicité.Octroi à la Commission d'apprentissage.Diverse! imprévus.S23.800.00 8,500.00 4,750.00 2,300.00 1,210.00 300.00 575.00 400.00 750.00 725.00 1,200.00 980.00 650.00 500.00 400.00 500.00 00.00 S23.S00.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 28 janvier 1950.41671 -o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail donne avis par les présentes, que le ( 'omité conjoint du \u2022commerce dc détail de M agog, -tabli en exécution du décret numéro 1268 du lô décembre 1955, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 48 du 18 janvier 1956.section \"B\", le tout d'accord avec les dispositions dc la Loi dc la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend dc la date de publication du présent règlement dans la Gazette officielle de Québec au 30 septembre 1956; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: d) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 1268 'doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à % de 1% de leur liste dc paye pour les salariés assujettis audit décret (salaires fixes, pourcentages, allocations, commissions ou bonis payés).b) Les artisans régis par ledit décret numéro 1268 doivent verser au Comité paritaire une §23,800.00 Disbursements: Salaries.Car ami travelling expenses re: Committee's work.Members' transportation and meeting regular and special meetings.Rent and lighting.Taxes and insurance.Postage and bank charges.Audition and quarterly reports.Stationery and printing.Office upkeep.Examination expenses.Investigations.Judicial and extra-judicial fees.Office furniture.Travelling expenses, publicity.Subvention to Apprenticeship Commission .Miscellaneous and unforeseen expenses .S 8,500\t00 4,750\t00 2,300\t00 1,210\t00 300\t00 575\t00 400\t00 750\t00 725\t00 1,200\t00 980\t00 650\t00 500\t00 400\t00 500\t00 60\t00 S23.800.00\t GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, January 28th, 1956.41671-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Retail Trade of Magog, formed under decree number 1268 of December 15, 1955, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 48 of January 18, 1956, part \"B\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter given: 1.Levy The period of levy extends from the date of publication of this by-law in the Quebec Official Gazette until September 30, 1956, and this levy shall be established as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 1268, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to % of 1% of their payroll for the employees governed by the ' said decree (regular wages percentages, allowances, commissions or bonuses).b) The artisans governed by the said decree, No.1268, shall pay to the Parity Committee an \u2022110 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1950, Tome 88, N° h 'somme équivalente à \\A ('e \"¦% du salaire moyen d'un commis fixé par le comité à S40.00 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 1208 doivent verser nu Comité paritaire une somme équivalente à Y> dc 1% de leur rémunération (salaire fixe, pourcentages, allocations, commissions ou bonis).2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules dc rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation dc l'employeur professionnel et «les sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire du Commerce de Détail de Magog, pour la période comprise entre le 3 janvier 1950 et le 30 septembre 1956.Le Comité paritaire du Commerce de Détail de Magog Siège social : Magog, P.Q.Etat des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 3 janvier 1956 et le 30 septembre 1950.Recettes: Cotisations (Y dc 1%): Employeurs professionnels.S 500.00 Artisans.200.00 Salariés.500.00 81,200.00 Déboursés: Salaire du secrétaire.S 780.00 Frais de déplacement de l'inspecteur.50.00 Frais légaux.Q0.00 Papaterie, impressions, timbres, téléphone et télégrammes.100.00 Vérification des livres.30.00 Assurances et frais de cautionnement.5.00 amount equivalent to Y of 1% of the average wage for clerks, i.e.$-10.00, as established by the Committee.c) The employees governed by the said decree, number 1208, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Yi of 1% of their remuneration (regular wages, percentages, allowances, commissions or bonuses).2.Mode of Collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee shall furnish the professional employers with report forms on which all the particulars required by the said Parity Committee shall be given.The professional employer shall complete and sign his report, and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of his employees by means of a deduction from the hitter's pay.The professional employer shall forward his monthly report to the 1'arity Committee on or before the 15th of the month following the date of expiration of the period for which it is requirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and those of his employees.The Committee lias the right to exact sworn reports when deemed advisable.The assessments laid by the present by-law are payable every month by the professional employer the artisan and the employee, without notice.Should a professional employer refuse to pay or to give the particulars required, he shall be given five days' notice to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In pursuance of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of his financial operations to the Minister of Labour on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Retail Trade of Magog for the period between January 3, 1956 and September 30, 1950, The Joixt Committee of the Retail Trade of Magog Head Office: Magog, P.Q.Estimate of the receipts and disbursements for the period between January 3, 1956 and September 30, 1950.\u2022 Receipts: Assessments (Y of 1%): Professional employers.$ 500.00 Artisans.200.00 Employees.500.00 $1,200.00 Disbursements: Salary of the secretary.$ 780.00 Inspector's travelling expenses.50.00 Legal fees.00.00 Stationery, printing, postage, telephone and telegrams.100.00 Audition.30.00 Insurance and fidelity bond.5.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 1956, Vol.88, No.4 441 Jetons de présences aux membres du Committee members' meeting expen- comité.125.00 ses.125.00 Dépenses diverses et imprévus.50.00 Miscellaneous and unforeseen expenses 50.00 $1,200.00 $1,200.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, \u2022GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 28 janvier 1956.4167I-0 Quebec, January 28, 1956.41671-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes que le ( '.unité paritaire du commerce de détail de Richmond et Melbourne, établi en exécution du décret N° 1379, du 23 décembre 1953, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil N° 48 du 18 janvier 1956, section \"D\", à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après: 1.Cotisation NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Richmond and Melbourne Retailers Joint Committee, formed under decree No.1379 of December 23, 1953, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.48 of January 18, 1956, part \"D\" to levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereafter given : 1.Assessments La période de cotisation s'étend de la date «le publication du présent règlement dans la Gazette officielle de Québec au 31 décembre 1956; celte cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 1379 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% de leur liste dc paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 1379 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y de 1% du salaire moyen déterminé par le Comité, soit $20.00 par semaine (prélèvement de $0.10 par semaine).c) Les salariés régis par ledit décret numéro 1379 doivent, verser au Comité paritaire une somme équivalente à 3^ de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le dix (10) du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements The period of levy extends from the date of publication of the present by-law in the Quebec Official Gazette to December 31, 1950; such levy shall be applied as follows: a) Professional employers governed by the said decree, No.1379, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to % of 1% of their payroll for employees governed by the said decree.b) Artisans governed by the said decree, No.1379, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Yi °f 1% of the average wage rate determined by the Committee, i.e., $20.00 per week (assessment of $0.10 per week).c) Employees governed by the said decree.No.1379, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to % of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee will furnish the professional employers with report forms on which all particulars required by the Parity Committee shall be given.The professional employer shall complete and sign the report and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Parity Committee, the assessments of his employees by means of a deduction from their wages.The professional employer shall submit his monthly report to the Parity Committee on or before the 10th of the month following the date of expiration of the period for which it is re-quirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and those of his employees.The Committee has the right to require that the reports be sworn to whenever it deems it advisable.The said assessments shall be payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Should a professional employer or an artisan refuse to pay or to give the necessary informa- 442 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° 4 nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec lu Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire du Commerce de Détail de Richmond et Melbourne pour la période comprise entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1956.Le Comité Paritaire du Commerce de détail de Richmond et Melbourne Richmond, Que.Etat des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1950.Recettes: Cotisations i}/2 de 1%): Employeurs professionnels.S 500.00 Artisans.150.00 Salariés.500.00 Recettes diverses.50.00 SI,200.00 Déboursés: Frais de déplacement, inspecteur, administration .$605.00 Loyer de bureau.50.00 Frais légaux.100.00 Papeterie, impressions, timbres, téléphone et télégrammes.100.00 Vérification des livres.40.00 Assurance et frais de cautionnement.5.00 Jetons de présence aux membres du Comité.100.00 Divers et imprévus.200.00 §1,200.00 Le Sous-Ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 28 janvier 1956.41671-0 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité paritaire de l'Industrie de la Boîte dc Carton gaufré de Québec, établi en exécution du décret numéro 728 du 6 juillet 1955, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 47 du 18 janvier 1956, (Section \"E\"), le tout conformément aux dispositions dc la Loi dc la convention collective à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret suivant la méthode et le taux ci-après.1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1956; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 728 doivent verser au Co- tion, he shall be given five days' notice to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report In pursuance of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following dates: Mardi 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Richmond and Melbourne Retailers Joint Committee for the period comprised between January 1st, 1956 and December 31, 1956.The Richmond and Melbourne Retailers Joint Committee Richmond, Que.Estimate of the receipts and disbursements for the period between January 1st, 1956 and December 31, 1956.Receipts: Assessments CA.of 1%): Professional employers.$ 500.00 Artisans.150.01) Employees.500.0(1 Various receipts.50.00 $1,200.0(1 Disbursements: Travelling expenses; Inspector; administration.$605.00 Office rent.50.00 Legal fees____.100.00 Stationery, printing, stamps, telephone, telegrams.100.00 Audition.40.00 Insurance and fidelity bond.5.00 Committee members' attendance fees 100.00 Miscellaneous and unforeseen expenses.200.00 $1,200.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy-Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, January 28, 1950.41671-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Corrugated Paper Box Industry of Quebec, formed under decree number 728 of July 6th, 1955, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 47 of January 18th, 1956, (Part \"E\"), in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act, to levy assessments upon the professionnal employers and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned.1.Assessments The period of levy extends from January 1st.1956, to December 31st, 1956; such levy shall be laid in the following manner: c) The profesional employers governed by the decree No.728 shall pay to the Parity Com- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, January 28th, 195G, Vol.88, No.U 443 mité paritaire une somme équivalente à Yl de 1% de leurs listes de paye.b) Les salariés régis par le décret numéro 728 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leur rémunérai ion.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels, des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par le Comité paritaire.L'employeur professionnel doit voir à ce \" du paragraphe \"a\" de l'article V est remplacé par le suivant: \"r) Tout établissement doit chômer et payer au taux régulier à ses salariés trois (3) fêtes parmi les suivantes: la Toussaint.LTmmaeulée-Conception, l'Epiphanie, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la Saint-Jean-Baptiste, la fête de la Confédération (1er juillet), la fête du Travail.Toutefois les salariés ont droit à ces fêtes chômées et payées à la condition d'avoir été au travail la journée ouvrable qui précède le congé payé et la journée ouvrable qui le suit.\" 7° Le paragraphe \"d\" de l'article VI est remplacé par le suivant: \"d) Les salariés ont droit pour leur congé à une rémunération équivalente à deux pour cent (2%) du salaire gagné en incluant l'indemnité pour vacances durant la période du premier mai au trente av.il suivant et à 4% du salaire.gagné et le double de jours de congé prévus au paragraphe \"a\", pour les salariés ayant dix (10) années (t plus de services continus pour un même employeur.\" (Document \"G\" annexé à l'arrêté).L.DÉSILETS.4M371-0 Greffier du Conseil Exécutif.d) Gang foremen: Gang foremen shall receive $0.10 more per hour than their regular rate of P«y.e) Night work: Every night-shift employee shall receive $0.05 more per hour than his regular rate of pay./) Every employee who performs or plies simultaneously more than one operation or trade governed by the present decree shall receive the wages determined for the best-paid operation or trade.However, when the said employee performs or plies but one operation or trade for at least seven (7) consecutive working days, he shall receive the rate established for that operation or trade.g) When three are there or more storemen in a metal working establishment, the third and following ones are considered as storemen's helpers and paid the helper's rate.h) All work done by female workers in a metal working establishment may be remunerated at a rate 20% lower than those mentioned in section IV, subsections \"a\" and \"6\" of the present decree.\" 5.Paragraph \"i\" of subsection \"a\" of section V is replaced by the following: \"j) Work performed after 10.00 p.m.by day shifts shall be paid double time except for zone III.\" 6.Paragraph \"r\" of subsection \"a\" of section V is replaced by the following: \"») Every establishment must close on three (3) of the following holidays ami pay straight time to its employees: All Saints Day, Immaculate Conception Day, Epiphany Day, Good Friday, Ascension Day, St.John the Baptist Day, Confederation Day (July 1st).Labour Day.However, employees shall be entitled to such holidays with pay only on the condition that they have worked the working day preceding such holidays and the one following them.\" 7.Subsection \"d\" of section VI is replaced by the following: \".Hull, comté de.Huntingdon, comté de.Iberville, comté de.Joliette.comté de.Kamouraska, comté de.Labelle, comté dc.Lac St-Jean-Oucst, comté de.L'Assomption, comté de.Lévis, comté de.L'Islet.comté dc.Lotbiniere.comté de.Maskinongé, comté de.Matane, comté de.\u2022.Matane, comté de (correction).Matapédia, comté de.Missisquoi, comté dc.Montcalm, comté de.Montmagny, comté de.Montmorency, N° 1, comté de.Miroirs Victoriaville Limitée \u2014 Victo- 299 riaville Mirrors Limited.300 Northeast Theatres Ltd.300 Sanguinct Automobile Limitée.390 St.Lawrence Cement Co.Appointment: 444 Returning-Officcr.Head Offices: 445 Gare Autobus St-Roch Limitée.444 Grondin & Grondin Inc.444 Lombard Insurance Agency Ltd.Tenders: 449 Bourlamaque, school comm.446 L'Abord-à-Plouffe, school comm.451 Pont-Viau, school comm.452 Rimouski, town.445 Salaberry-de-Vallcyfield, city.447 St-Picrre-aux-Liens, school comm.450 St-Charles, school comm.village.Sale of Unclaimed Baggage: 453 Canadian Pacific Railway Company.Sale.Bankruptcy Act: 454 Legault, Maurice.Sale by Licitation 455 Giroux vs Giroux ct al.Sales for Taxes: 323 - Artbabaska, county of.314 Bagot, county of.354 Beauce, county of.352 Bellechasse, county of.354 Berthier, county of.324 Bonaventure, county of.300 Brome, county of.335 Chambly, dbunty of.317 Chambly.School Munie, of the town of 407 Champlain, county of.419 Charlevoix-East, county of.352 Châtcauguay.county of.308 Chicoutimi, county of.319 Compton, county of.397 Two-Mountains, county of.331 Dorchester, county of.375 Drummond, county of.347 Frontenac, county of.417 Gaspé-East, county of.380 Gatineau, county of.406 Hull, county of.373 Huntingdon, county of.412 Iberville, county of.406 Joliette, county of.353 Kamouraska, county of.413 Labelle, county of.340 Lake St.John West, county of.398 L'Assomption, county of.322 Levis, county of.402 I/Islet, county of.420 Lotbiniere, county of.339 Maskinongé, county of.409 Matane, county of.457 Matane, county of (correction).363 Matapédia, county of.313 Missisquoi, county of.346 Montcalm, county of.349 Montmagny, county of.335 Montmorency, No 1, county of.299 300 300 300 444 445 444 444 449 446 451 452 445 447 450 453 454 455 323 314 354 352 354 324 300 335 317 407 419 352 308 319 397 331 375 347 417 380 406 373 412 406 353 413 340 398 322 402 420 339 409 457 363 313 346 349 335 484 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 28 janvier 1956, Tome 88, N° J, Nicolet, comté de.'.320 Papineau, comté de.392 Pontiac, comté de.303 Portneuf, comté de.103 Québec, comté de.100 Richelieu, comté de.405 Richmond, comté de.318 Rimouski, comté dc.370 Rimouski, comté (corrections).456 Rouville, comté de.327 Saguenay, comté dc.456 Shefford, comté de.394 Sherbrooke, comté de.372 Soulanges, comté de.355 Stanstead, comté de.310 Terrebonne, comté de.3(58 Témiscamingue, comté de.343 Témiscouata, comté dc.333 Verchères, municipalité, comté de.412 Vaudreuil, comté dc.330 Wolfe, comté de.327 Yamaska, comté de.395 VENTES PAR SHÉRIFS : Chicoutimi: Lemieux vs Néron.457 Gaspé: Pichettc vs Laflamme.458 William Hyman & Sons Ltd vs Pipon 457 Joliette : Banque Provinciale du Canada vs Lavigne 458 Langevin vs Paulin.458 Kamouraska: Michaud vs Michaud.459 Montmagny: Beaulieu vs Robichaud.459 Montréal: United Agency Inc.vs Dillon.459 Nicolet: L'Office du Crédit agricole du Québec vs Faucher.4G0 Pontiac: La municipalité des Cantons-Unis dc Sheen, Esher & Malakoff vs Pouporc.461 Québec: Union des Carrières et Pavage Limitée vs Bégin et al.461 Richelieu: E.W.Caron & Fils Limitée vs Catien.463 Terrebonne: Cantin vs Guay ct vir.463 Champagne (Sr) vs Paquette.464 41661-0 Nicolet, county of.320 Papineau.county of.392 Pontiac, county of.303 Portneuf, county of.403 Québec, county of.400 Richelieu, county of.405% Richmond, county of.318 Rimouski, county of.376 Rimouski, county of (corrections).456 Rouville, county of.327 Saguenav, county of.456 Shcfford\".county of.391 Sherbrooke, County of.372 Soulanges, county of.355 Stanstead, county of.310 Terrebonne county of.368 Témiscamingue, county of.34:5 Témiscouata, county of.333 Verchères, municipality, county of .412 Vaudreuil, county of.330 Wolfe, county of.327 Yamaska, county of.395 SHERIFFS' SALES : Chicoutimi: Lemieux vs Néron.457 Gaspé: Pichette vs Laflamme.458 William Hyman & Sons Ltd vs Pipon.457 Joliette : Provincial Bank of Canada vs Lavigne 45S Langevin vs Paulin.458 Kamouraska: Michaud vs Michaud.459 Montmagny: Beaulieu vs Robichaud.459 Montreal : United Agency Inc.vs Dillon.459 Nicolet: The Quebec Farm Credit Bureau vs Faucher.460 Pontiac: The municipality of the United-Townships of Sheen.Eshcr & .Malakoff vs Poupore.461 Quebec: Union Quarries and Paving Limited vs Begin et al.401 Richelieu: E.W.Caron & Fils Limitée vs Catien.463 Terrebonne: Cantin vs Guay et vir.463 Champagne (Sr) vs Paquette.464 41661-0 Québec: \u2014Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer."]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.