Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 24 (no 51)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1955-12-24, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 87, N° 51 3919 Vol.87, No, 51 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 24 décembre 1955 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.\u2022 5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, December 24th, 1955 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 3920 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2J, décembre 1956, Tome 87, N° 51 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas.l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.S° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant là seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 20(5 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement : 87 par année.N.15.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à not re numéro d'or-dre; le deuxième ;'i celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion: le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.3S933 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires.at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover I he Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money arc subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parlies are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 260 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: Si.per dozen.Subscriptions: S7.per year.N.15.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.38933 \u2014 1-52 Lettres patentes (P.C.12278-55) Abias Pépin Automobiles Ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première parlie de la Loi des compagnie* de Québec, il a clé accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec des Ici 1res patentes, en date du sept novembre 1955, constituant en corporation: Jules DUpré, c.r., avocat, d'Ontremont.Raymond Letle.clerc, de Hampstead et Jean-Claude Bureau, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'automobiles et des accessoires qui s'y rapportent, sous le nom de \"Abias Pépin Automobiles Ltée\".avec un capital total de $250,000, divisé en 1,500 actions communes de $100 chacune et en 1.000 actions privilégiées de -SI(10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à lôô, rue Saint-Charles, ouest.Longueuil, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept novembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41108-o C.E.CANTIN.Letters Patent (A .G.12278-55) Abias Pépin Automobiles Lté»' Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing elate the seventh day of November.1955, incorporating: Jules Dupré, Q.C., advocate, of Outremount.Raymond Let te, clerk, of Hampstead, and Jean-Claude Bureau, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in automobiles and accessories pertaining thereto under the name of \"Abias Pépin Automobiles Ltée\", with a total capital stock of §250.000.divided into 1,500 common shares of §100 each and into 1,000 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at 155, Saint-Charles Street, west, Longueuil, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 24th, 1955, Vol.87, No.51 3921 (P.G.12914-55) Acme Stone Cie Ltée \u2014 Acme Stone Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en-date du neuf novembre 1955, constituant en corporation: Jean E.Badcaux, avocat, Margaret E.Cox et Pauline Frenetic, sténographes, filles majeures usant de leurs droits, tous des cité et district judiciaire de .Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matériaux de construction et de fabrication de pierre artificielle, sous le nom de \"Acme Stone Cie Ltée \u2014 Acme Stone Co.Ltd.\", avec un capital total de $60,000, divisé en 600 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à ville St-Pierre, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf novembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41408-o C.E.CANTÎN.(P.G.12192-55) A.& M.Weîs Household Furniture Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onzième jour de novembre 1955, constituant en corporation: John Michael Schlesinger, Jack Lighlstone, avocats, Norma Barbarash, secrétaire, fille majeure, et Shirley Taviss, majeure, secrétaire, épouse séparée de biens de Norman Taviss et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'ameublements de maison, marchandises sèches et vêtements, sous le nom de \"A.& M.Weis Household Furniture Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce onzième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41408 C.E.CANTIN.(P.G.12903-55) Artmar Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six octobre 1955, constituant en corporation: Arthur Spino.Roland Jean, excavateurs, et Albert Jean, sculpteur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs, excavateurs et constructeurs généraux, sous le nom de \"Artmar Construction Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 10161, rue Clark, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six octobre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408-o C.E.CANTIN.(A.G.12914-55) Acme Stone Cie Ltée \u2014 Ac me Stone Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of November 1955, incorporating: Jean E.Badeaux.advocate, Margaret E.Cox, and Pauline Frenette, stenographers, of the full age of majority making use of their rights, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in building materials and to manufacture artificial stone, under the name of \"Acme Stone Cie Ltée \u2014 Acme Stone Co.Ltd.\", with a total capital stock of 860,000, divided into 000 shares of 8100 each.The head office of the company will be at the town of St.Pierre, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.12192-55) A.& M.Weis Household Furniture Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of November.1955, incorporating: John Michael Schlesinger, Jack Lightstone, advocates, Norma Barbarash, secretary, spinster of the full age of majority, and Shirley Taviss, secretary, of the full age of majority, wife separate as to property of Norman Taviss and duly authorized by him for the purpose of these presents, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in household furniture, dry goods and clothing, under the name of \"A.& M.Weis Household Furniture Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and into 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of November, 1955.C.E.CANTIN, 1140S-o Deputy Attorney General.(A.G.12903-55) Artmar Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of October, 1955, incorporating: Arthur Spino, Roland Jean, excavators, and Albert Jean, sculptor, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as contractors, excavators and general builders, under the name of \"Artmar Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at 10161 (Mark street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of October, 1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General. 3922 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 décembre 1955, Tome 87, N° 61 (P.G.12713-55) Beaurcpnire Beauty Bar Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-sept octobre 1955, constituant en corporation: Joseph Taylor, ingénieur.Lillian Roger Taylor, coiffeuse de style, épouse séparée de biens dudit Joseph Taylor, tous deux de Stc-Anne de-Bellevue, et Gérard Tardif, notaire, de Pointe-Claire, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme coiffeurs à la mode et propriétaires d'un salon de beauté dans la ville de Beaconsfield et environs, sous le nom de \"Beaurepaire Beauty Bar Inc.\", avec un capital total de $40.000, 'divisé en 100 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 454 Boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-sept octobre 1955.L*Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(P.G.13072-55) Belle Fleur Construction Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit novembre 1955, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat.Harriet Beutel, teneuse de livres, tous deux de West-mount et Joseph IL Hoffman, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des terrains et tout immeuble ou aucun intérêt en iceux, sous le nom de \"Belle Fleur Construction Corp.\", avec un capital total de §40,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1955.L'Assistant -procureur général.41408 C.E.CANTIN.(P.G.12963-55) Bernard Bros, Outfitters Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres, patentes en date du deux novembre 1955.constituant en corporation: Leon Bernard, Morris Bernanrd, marchands et Esther Torontour, marchande, épouse séparée de biens dudit Morris Bernard et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'articles vestimentaires, marchandises sèches, tissus textiles, appareils électriques, nouveautés, articles en cuir, bijouterie, habits et vêtements, sous le nom de \"Bernard Bros, Outfitters Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.(A.G.12713-55) Beaurepaire Beauty Bar Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of October, 1955, incorporating: Joseph Taylor, engineer, Lillian Roger Taylor, hair stylist, wife separate as to property of the said Joseph Taylor, both of Ste-Anne-de-Bcllevue, and Gérard Tardif, notary, of Pointe-Claire, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as hair stylist and beauty salon in the town of Beaconsfield, and surroundings, under the name of \"Beaurepaire Beauty Bar Inc.\".with a total capital sotck of 840,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 454 Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield.judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of October.1955.C.E.CANTIN, 4I408-o Deputy Attorney General.(A.G.13072-55) Belle Fleur Construction Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November.1955, incorporating: Max S.Kaufman, advocate, Harriet Beutel, bookkeeper, both of Westmount, and Joseph R.Hoffman, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire land and any estate or interest therein, under the name of \"Belle Fleur Construction Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN.41408-o Deputy Attorney General.(A.G.12963-55) Bernard Bros, Outfitters Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, beating date the second day of November.1955, incorporating: Leon Bernard, Morris Bernard, merchants, and Esther Torontour, merchant, wife separate as to properly of the said Morris Bernard, and duly authorized by him for the purpose of these presents, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing, dry goods, textile fabrics, electric appliances, novelties, leather goods, jewellery, garments and wearing apparel, under the name of \"Bernard Bros, Outfitters Inc.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 200 common shares of a par value of 8100 each and into 200 preferred shares of a par value of 8100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2#h, 1955, Vol.87, No.61 3923 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(P.G.13077-55) Brotherhood Centre Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit novembre 1955, constituant en corporation: Norman Genser.avocat, de Hampstead, Sydney Phillips, avocat, de Montréal, John YVasserman, avocat, de West mount, Tessy Frankel et Rose-Marie Bourgoing, secrétaire, célibataire, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter et posséder des propriétés et, en particulier, une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Brotherhood Centre Inc.\", avec un capital de 800,000.divisé en 59,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 81 chacune et 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(P.G.13052-55) Cartiervillc Shopping Centre Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze novembre 1955, constituant en corporation: David Goodman, avocat, de Hampstead, Neil Phillips, Melvin Rothman, avocats, de West mount, et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir, développer et améliorer une certaine propriété immobilière, sous le nom de \"Cartier-ville Shopping Centre Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(P.G.12846-55) Champion and Company Limited Champion et Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-deux octobre 1955, constituant en corporation: Lloyd Rogers Champion, financier, Frank Mattews Wells et John G.McDonald Brown, administrateurs, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands d'obligations, souscripteurs éventuels à forfait, courtiers de placements et courtiers d'actions dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Champion and Company Limited \u2014 Champion et The head office of the company will be at Montreal, judicial'district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.(A.G.13077-55) Brotherhood Centre Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1955, incorporating: Norman Genser, advocate, of Hampstead, Sydney Phillips, advocate, of Montreal, John Wasserman, advocate, of Westmount, Tessy Frankel and Rose-Marie Bourgoing, secretary, unmarried, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To purchase and to hold property and in particular a certain immoveable property, under the name of \"Brotherhood Centre Inc.\", with a total capital stock of 800,000, divided into 59,000 preferred shares having a par value of $1 each and into 1,000 common shares having a par value of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 4140S-o Deputy Attorney General.(A.G.13052-55) Cartierville Shopping Centre Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1955, incorporating: David Goodman, advocate, of Hampstead, Neil Phillips, Melvin Rothman, advocates, of West-mount, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire, develop and improve a certain immoveable property, under the name of \"Cartierville Shopping Centre Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.(A.G.12846-55) Champion and Company Limited Champion et Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of October, 1955, incorporating: Lloyd Rogers Champion, financier, Frank Mattews Wells and John G.McDonald Brown, executives, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of bond dealers, underwriters, investment brokers and share brokers in all its branches, under the name of \"Champion and Company Limited \u2014 Champion et Compagnie Limitée\", with a total capital stock 3924 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, décembre 1955, Tome 87, N° 61 Compagnie Limitée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux octobre 1955.L'Assistant-procureur général.41408 C.E.CANTIN.(P.G.13114-55) Coltex Trading Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date «lu quatorze novembre 1955, constituant en corporation: Samuel IL Shriar.Abraham Jacob Rosenstein et Frank Frederick Hubscher, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de marchandises fabriquées en tout ou en partie de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et leurs sous-produits, animaux, minéraux, pierres précieuses, liqueurs douces, livres et revues, objets d'art, produits chimi«|ues et de beauté ainsi «pie les produits de la terre, de la mer et de la forêt, sous le nom de \"Coltex Trading Company Limited\", avec un capital total de 850.000 divisé en 250 actions ordinaires de 8100 chacune et 250 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le quatorze novembre 1955.L'Assis! an t -procureur généra 1.41408 C.E.CANTIN.(P.G.12940-55) Comfort Regal & Wilco Fashions Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huitième jour «l'octobre 1955.constituant en corporation: Jack Lightstone, Marvin Riback, avocats et Elie M.Solomon, notaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce «le textiles, marchandises à la verge, vêtements, articles vestimentaires et articles de ménage, sous le nom de \"Comfort Regal & Wilco Fashions Inc.\", avec un capital total «le 810.000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-huitième jour «le novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(P.G.13067-55) Confection Sainte-Agathe Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la provnce de Québec, des lettres patentes, en date du dix novembre 1955, constituant en corporation: Alcide Nadeau, marhand et industriel, J.-Alyre Coté, marchand, et Alonzo Dronin, com- of $40,000, divided into 20,000 common shares of the par value of 81 each and into 20,000 preferred shares of the par value of 81 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of October.1955.C.E.CANTIN, 11408-o Deputy Attorney General.(A.G.1311 1-55) Coltex Trading Company Limite«l Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of November, 1955, incorporating: Samuel IL Shriar.Abraham Jacob Rosenstein and Prank Frederick Hubscher, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur.textiles, glass, and by-products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books and periodicals, works of art, chemical and beauty products.laud, sea and forest products, under the name of \"Coltex Trading Company Limited\", with a total capital slock of 850.000.divi«le«l into 250 common shares of $100 each and into 250 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of November.1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.(A.G.12910-55) Comfort Regal & Wilco Fashions Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of October.1955.incorporating: Jack Light-stone.Marvin Riback, advocates, and Elie M.Solomon, notary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in textiles, yard goods, clothing, wearing apparel and household wares, under the name of \"Comfort Regal & Wilco Fashions Inc.\".with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of 8100 each.The hca«l office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office «>f the Attorney General, this twenty-eighth dav of October.1955.C.E.CANTIN.41408-o Deputy Attorney General.(A.G.13067-55) Confection Sainte-Agathe Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth flay of November, 1955, incorporating: Alcide Na-deau, merchant and industrialist, J.-Alyre Côté, merchant, and Alonzo Drouin, wood merchant, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec December QAth, 1965, Vol.87, No.61 3925 tnercant de bois, tous de Sainte-Agathe, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce «le vêtements, sous le nom «le \"Confection Sainte-Agathe Limitée\", avec un capital total «le $25.000, divisé en 150 actions communes d'une valeur au pair «le $100 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sainte-Agathe, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix novembre 1955.L'Assistant-procureur général, \u2022Il-lOS-o C.E.CANTIN.(P.G.1 .'5110-55) Crémazie Automobile Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par I«- Lieutenant-gouverneur «!«\u2022 la province «le Québec des lettres patentes, en date du dix-huit novembre 1955, constituant en corporation: Gérard Barabé, Gérard DesLauriers, vendeurs, de Laval-des-Rapidcs, et Gilles Le Blanc, avocat.«l'Ontremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce «le véhicules automobiles, sous le nom de \"Crémazie Automobile Inc.\", avec un capital total de $10.-000.divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «lislrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, le «lix-huit novembre 1955.L'Assistant -procureur général, Il lOS-o C.E.CANTIN.(P.G.12985-55) Crête et Champoux Equipements Ltée Crête and Champoux Equipments Ltd Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec «les lettres patentes, en date «lu quatre novembre 1955.constituant en corporation: Charles Champoux, industriel, «le La Tuque, district judiciaire de Québec, -lean J.Crête et Jean-Paul Crête, industriels, de Gruud'-Mère, district judiciaire des Trois-Rivières, poulies objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'accessoires «le fonderies et de toutes sortes de machineries, accessoires de machines et ateliers de réparations, fournitures f Sainte-Agathe, judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and carry on a business deal ing in clothing, under the name of \"Confection Sainte-Agathe Limitée\", with a total capital stock of 825.000.divided into a 150 common shares of a par value of $100 each, and into 100 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of tin* company will be at Sainte-Agathe, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN.41408 Deputy Attorney General.(A.G.13116-55) Crémazie Automobile Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November 1955, incorporating: Gérard Barabé.Gérard DesLauriers.salesmen, of Laval «les Rapides, and (idles Le Blanc, advocate, «>i Out reinont.all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in motor vehicles, under the name «)f \"Crémazie Automobile Inc.\", w'th a total capital stock of 810.000.divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of November.1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.12985-55) Crête et Champoux Equipements Ltée Crête and Champoux Equipments Ll«I Notice is hereby given that under Part I of the QuiOice Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of November 1955, incorporating: Charles Champoux, industrialist, of La Tuque, judicial district of Quebec, Jean J.Crête and Jean-Paul Crete, industrialist, of Grand'Mère.judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To manufacture and deal in foundry accessories and machinery of every nature and kind, machine accessories and repair shops, railroad supplies and generally those required by steel, iron, bronze ami aluminium dealers, under the name l \"Crête et Champoux Equipements Ltée \u2014 Crete and Champoux Equipments Ltd\", with a total capital stock of 810.000, divided into S00 shares of 850 each.The head office of the company will be at La Tuque, judicial district of Quebec.Dated at the ofiic«- of the Attorney General, this fourth dav of November 1955.C.E.CANTIN, 11 pis Deputy Attorney General.(A.G.12916-55) Cyr Auto Body Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November.1955.incorporating: Roger Lajeunessc.advocate, of Montreal.Rachel Bon- 3926 GAZETTE OFFICIELLE DE QVFAiEC, Québec, 24 décembre 1955, Tome 87, N °51 real, Rachel Bouchard, .sténographe, fille majeure, de Saint-Basile-le-Grand, tous deux du district judiciaire de Montréal, et Jean-Charles Biais, avocat, de Varennes, district judiciaire de Biche-lieu, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'automobiles, de leurs parties et accessoires; faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Cyr Auto Body Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41408-o C.E.CANTIN'.(P.G.11182-55) Danford Lake District Property Owners Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze mai 1955, constituant en corporation: sans capital-actions: W.Robert Cunningham souscripteur éventuel à forfait, de Rockcliffe Park, Ralph Edward McBurncy, gérant, Clarence Cecil Gibson, procureur, Herbert Hugh John Nesbitt, zoologiste, Edwin Foster May, employé civil, Joseph Howe, rc|K>rtcr, William Norman McCormick, grossiste, David Wesley Evans, bourgeois, Andrew K.Davics, vendeur et Henri Roy, entrepreneur, d'Ottawa, tous de la province d'Ontario, pour les objets suivants: Promouvoir et encourager la récréation, l'instruction et le divertissement des résidents et lieux avoisinants du Lac Danford, dans le canton d'Aylwin, comté de Gatineau, sous le nom de \"Danford Lake District Property Owners Association\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de 820,000.Le siège social de la corporation sera au Bureau du Lac Danford, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1955.L'Assistant-procureur général.41408 C.E.CANTIN.(P.G.13032-55) David Transport & Cie Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix novembre 1955, constituant en corporation: Albert David, cultivateur, Jacqueline David, fille majeure, tous deux de Montréal-est, René Castonguay, camionneur, de Pointeaux-Trembles, et Edmond Robin, fils, cultivateur, de Saint-Léonard-de-Port-Maurice, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une entreprise de transport pour le charroyage de pierre concassée, pierre des champs, terre, sable et gravier; faire des placements sur biens meubles et immeubles, sous le nomde \"David Transport & Cie Ltée\", avec un capital total de 875,000, divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 11165, Chemin St-Léonard-de-Port-Maurice, en la ville chard, stenographer, bachelor, of Saint-Basile-le-(îrand, both of the judicial district of Montreal, and Jean-Charles Biais, advocate, of Varennes, judicial district of Richelieu, for the following purposes: To manufacture and carry on a business dealing in automobiles, spare-parts and accessories; to operate as garage-keepers, under the name of \"Cyr Auto Body Ltd.\", with a total capital stock of $10.000, divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.11182-55) Danford Lake District Property Owners Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1955, to incorporate as a corporation without share capital: W.Robert Cunningham, underwriter, of Rockcliffe Park, Ralph Edward McBurney, manager, Clarence Cecil Gibson, barrister, Herbert Hugh John Nesbitt, zoologist, Edwin Foster May, Civil servant, Joseph Howe, reporter, William Norman McCormick, wholesaler, David Wesley Evans, gentleman, Andrew K.Davics, salesman, and Henri Roy, contractor, of Ottawa, all of the Province of Ontario, for the following purposes: To provide and encourage recreation, instruction and amusement for the residents of the vicinity of Danford Lake in the township of Aylwin and county of Gatineau, under the name of \"Danford Lake District Property Owners Association\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 820,000.The head office of the corporation will be at Danford Lake Post Office, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of May, 1955.C.E.CANTIN, 4140S-o Deputy Attorney General.(A.G.13032-55) David Transport & Cie Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1955, incorporating: Albert David, farmer, Jacqueline David, bachelor, of full age, both of Montreal-East, René Castonguay, trucker, of Pointe-aux-Trembles, and Edmond Robin, son, farmer, of Saint-Léonard-de-Port-Maurice, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a transportation company for the carrying of crushed stone, field stone, earth, sand and gravel; to make investments on moveable and immoveable property, under the name of \"David Transport & Cie Ltée\", with a total capital stock of $75,000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at 11165 St-Léonard-de-Port-Maurice Road, in the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec, December 24th, 1955.Vol.s?\\ Xo.51 3927 «le Montréal-est, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le dix novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408-o C.E.CANTIN'.(P.G.13065-05) Doby Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «lucd by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November.1955, incorporating: Marcus Meyer Sperber, Queen's Counsel, advocate, of West-mount.Alan Bernard Gold, advocate, of Mont-real, and Murray Lapin, advocate, of Hampstead, all of the judicial «listrict of Montreal, for the following purposes: To acquire a certain immoveable property for the purpose of constructing industrial, commercial or residential buildings thereon, and of deriving a revenue therefrom, under the name of \"Doby Realties Inc.\", with a total capital stock of 810.000, f Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.(A.G.13038-55) Domaine l'Achigan Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing f October, 1955, incorporating: Arthur Bergeron, manager, of Farnham, judicial «listrict of Bedford, Louis P.Picard, chartered accountant, Robert Lévesque, Jean Fontaine, industrialists, ami Jean Paul St-Louis, advocate, the last four from the city and judicial district of Montreal, for the billowing purposes: To manufacture and deal in articles into the fabrication of which enters wood, glass, plastic, iron, aluminium and other metals, under the name of \"Les Industries Farnham Ltée \u2014 Farnham Industries Ltd\", with a total capital stock of 8150,000.divided into 750 common shares of 8100 each and 750 preferred shares of 8100 each.The head ofhVe of the company will be at Farnham.judicial «listrict of Be«lford.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-seventh dav of Oct«>ber 1955.C.E.CANTIN, 4140S Deputy Attorney General.(A.G.12905-55) 1.11 o|)i i a I St-Joseph de Sept-lles Iiworporce Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have 3936 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2A décembre 1955, Tome 87, N° 51 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Roger Smith, médecin, de Clarke city, Armand Boissinot, secrétaire municipal, et Honoré Dionne.avocat, ces deux (lenders de Sept-lles, tous du district judiciaire de Saguenay, pour les objets suivants: Établir, maintenir et administrer un hôpital général, sous le nom de \"L'Hôpital St-Joseph de Sept-lles Incorporée\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut, posséder, est de S2.000.000.Le siège social de la corporal ion sera à Sept-lles, district judiciaire de Saguenay.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre.1955.L'Assistant-procureur général, 41408-o C.E.CANTIN.(P.G.12636-55) Limary Builders Supply Ltd La Cie de Matériaux de Contraction Limary Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre octobre 1955, constituant en corporation: Augustine Charette Morissette.ménagère, épouse séparée de biens de Lionel Morissette.J.-Alfred Dussault, avocat, de l'Annonciation, district judiciaire de Lahellc.et Amary Morissette, médecin, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'effets ou matériaux employés dans la construction en général, sous le nom de \"Limary Builders Supply Ltd \u2014 La Cie de Matériaux de Construction Limary Ltée\".avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre octobre 1955.L'Assistant-procureur général, 4140S-o C E.CANTIN.(P.G.12758-55) Luxor Millinery Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-huit octobre 1955, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat, Harriet Beutel.teneuse de livres, fille majeure, tous deux de Westmount, et Joseph R.Hoffman, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce qui consiste à fabriquer des articles de modes dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Luxor Millinery Ltd.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et 300 actions privi-I égiées de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-huit octobre 1955.L'Assistant -procureur général, 41408 C.E.CANTIN.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November.1955, to incorporate as a corporation without share capital: Roger Smith, physician, of Clarke city, Armand Boissinot, municipal secretary, and Honoré Dionne, advocate, the latter two of Sept-lles, all of Unjudicial district of Saguenay, for the following purposes: To establish, maintain and administer a general hospital, under the name of \"L'Hôpital St-Joseph de Sept-lles Incorporée\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 82.000.000.The head office of the corporation will be at Sept-lles, judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN.41408 Deputy Attorney General.(A.G.12030-55) Limary Builders Supply Ltd La Cie de Matériaux de Contraction Limary Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of October 1955, incorporating: Augustine Charctte Morissette, housewife, wife separate as to property of Lionel Morissette.J.Alfred Dussault.advocate, of l'Annonciation, judicial district of Labelle, and Amary Morissette.physician, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in materials or supplies required in building operations generally, under the name of \"Limary Builders Supply Ltd \u2014 La Cie de Matériaux de Construction Limary Lté\", with a total capital stock of 825,000.divided into 250 shares of 8100 each.The head ofliee of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fourth dav of October, 1955.C.E.CANTIN.41408 Deputy Attorney General.(A.G.12758-55) Luxor Millinery Ltd.i Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of October, 1955, incorporating: Max S.Kaufman, advocate.Harriet Beutel.bookkeeper,,////*:' majeure, both of Westmount, and Joseph R.Hoffman, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on in all its aspects a millinery manufacturing business, under the name of \"Luxor Millinery Ltd.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 100 common shares of S100 each and into 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the ofliee of the Attorney General, this twenty-eighth dav of October, 1955.C.E.CANTIN, 4140S-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2/,th, 1955, Vol 87, No.51 3937 (P.G.12807-55) Man-!.en Building Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huitième jour d'octobre 1955, constituant en corporation: John L.Liherman, Irving L.Adessky et Moses Moscovitch, avocat, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Man-Len Building Corp.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de S10 chacune et 250 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-huitième jour d'octobre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(A.G.12S07-55) Man-Lcn Building Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of October, 1955, incorporating: John L.Liberman, Irving L.Adessky and Moses Moscovitch, advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Man-Len Building Corp.\".with a total capital stock of 840.000.divided into 1,500 common shares of $10 each and into 250 preferred shares of 8100 each.The head ofliee of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of October, 1955.C.E.CANTIN.41408-o Deputy Attorney General.(P.G.128S5-55) Maxwell LTpholstering Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huit novembre 1955, constituant en corporation: Max Aisenthal, Joseph Aisenthal, manufacturiers et Seymour Maehlovitch, étudiant en droit, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce «le meubles, boiserie et articles domestiques, fournitures et accessoires, sous le nom de \"Maxwell l'p-holstering Co.\", avec un capital total «le 830,000, divisé en 300 actions ordinaires «le S5 chacune, 100 actions privilégiées catégorie \"A\" et 5.600 actions privilégiées catégorie \"B\" de$5chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le «lix-huit novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(P.G.12771-55) Mercury Land & House Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes en date «lu treize octobre 1955, constituant en corp«>ra-tion: Mclvin Salmon, Moe Moscovitch et Irving, Adessky avocats, des cité et «listrict judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Diriger et exercer le commerce «le constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Mercury Laïul & House Corp.\", avec un capital total «le $40,000, «liviséen 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le S100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le treize octobre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(A.G.12SS5-55) Maxwell Upholstering Co.Notice is hereby given that un«ler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issin-d by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1955, incorporating: Max Aisenthal, Joseph Aisenthal manufacturers, ami Seymour Maehlovitch, law student, all of the city ami judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture ami deal in furniture, woodwork and household articles, furnishing and equipment, under the name of \"Maxwell Upholstering Co.\", with a capital stock of $30,000, divided into 300 common shares of 85 each ami into 100 Classe \"A\" preferred shares and 5,000 Class \"B\" preferred shares of 85 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Date«l at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.(A.G.12771-55) Mercury Lain! & House Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of October, 1955.incorporating: Mclvin Salmon, Moe Moscovitch ami Irving Adessky, advocates, of the city anil judicial district of Montreal, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Mercury Land & House Corp.\", with a total capital stock «>f 840,000.divided into 100 common shares of the par value of $100 each and into 300 preferre«l shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Date«l at the office of the Attorney General, this thirteenth day of October, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General. 393S GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'ÈliEA\\ Québec, décembre 1055, Tome 87, N° 51 (A.G.12776-55) IVIid-Towil Service Station Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie île la Loi ,th, 1955, Vol.87, No.51 3941 Le siège social delà compagnie sera à Roberval, district judiciaire de Roberval.Daté du bureau du Procureur général, le quatre novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 11408-o C.E.CANTIN.(P.G.12912-55) Raymond Transport Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du (piator/.e novembre 1955, constituant en corporation: Adhémar (î.Munich, avocat, Ahnanzor Laberge, comptable, et Fernande Langlois, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Fxcrcer les opérations «l'une compagnie «le transport, sous le nom «le \"Raymond Transport Inc.\", avec un capital total «le $50,000, divisé en 500 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 11 lOS-o C.E.CANTIN.(P.G.12790-55) Kedbrooke Fstates Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes en «late «lu dix-huit octobre 1955, constituant en corporation: Louis Mortimer Bloomfield, avocat et «\u2022«mscil en loi de la Reine.Pierre de,Charmant, étudiant en droit.«4 Carol Ann Dienst, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets .suivants: Transiger les affaires «l'une compagnie de placements, sous le nom «!«\u2022 \"Redbrooke Estates Ltd.\", avec un capital total de S100.000.divisé en 1,000 actions «le 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Mont-real, «listrict judiciaire de Montréal.Daté «lu bureau «lu Procureur général, le «lix-huit octobre 1955.L'Assistant-procureur général.41408 C.E.CANTIN.(P.G.12989-55) Riviera Espresso Coffee Bar Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a t*té accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes en date du huitième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Harold Lan«le, C.R., avocat, «le Westmount, Joseph Samuel Caplan, avocat et Sylvia Nitkin.sténographe, fille majeure, de Montréal, touf* du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Posséder, exploiter et administrer des restaurants, hôtels et salles à manger publiques, sous 'e nom de \"Riviera Espresso Coffee Bar Inc.\", avec un capital-actions de 840,000, divisé en 5,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair de SI chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de novembre 1955.L'Assistant -procureur général, 41408 C.E.CANTIN.The head office of the company will be at Roberval.judicial district of Roberval.Dated at the offu-c of the Attorney General, this fourth ilav of November 1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.12912-55) Raymond Transport Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of November, 1955.incorporating: Adhémar G.Munich, advocate, Almanzor Laberge, accountant, and Fernande Langlois.secretary, bachelor, all of the city and judicial «listrict of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a transportation company under the name of \"Raymond Transport Inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 500 common shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.12790-55) R ci 11.1 nuke Estates Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of October, 1955, incorporating: Louis Mortimer Bloomfield, advocate ami Queen's Counsel, Pierre de Charmant, student at law, and Carol Ann Diensl, secretary, all of the city and judicial «listrict of Montreal.f«>r the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Redbrooke Estate Ltd.\".with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 shares of SI00 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district, of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighh'enth dav of October, 1955.C.E.CANTIN, 4I408-o Deputy Attorney General.(A.G.129S9-55) Riviera Espresso Coffee Bar Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November, 1955, incorporating: Harold Lande, Q.C., advocate, of Westmount, Joseph Samuel Caplan, advocate, and Sylvia Nitkin, stenographer, spinster of the full age of majority, of Montreal, all of the judicial «listrict of Montreal, for the following purposes: To own operate ami manage restaurants, hotels and public eating houses, under the name of \"Riviera Espresso Coffee Bar Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 5,000 common shares of the par value of 81 each and into 3,500 preferred shares of the par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General. 3912 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2/, décembre 1955, Tome 87, N° 51 (P.G.12887-55) Rubyco Mills Ltd.Avis esl donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douzième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Benjamin Robinson, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, Theodore IL Shapiro, avocat, de Aille Mont-Royal et Ethel Yussem.secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de fils, filaments, textiles, tissus, articles vestimentaires, vêtements, marchandises de fantaisie, marchandises sèches, sous le nom de \"Rubyco Mills Ltd.\", avec un capital total de 850.000, divisé en 200 actions ordinaires de 850 chacune et S00 actions privilégiées de 850 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41408 C.E.CANTIN.(P.G.13000-55) Rupert's Land Trading Company (Quebec) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinzième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Rodney Alexander Patch, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Constance Garner Short, Austin Stuart Hyndman, Robert Charles Legge et Murray Churchill Magor, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Rupert's Land Trading Company (Quebec) Ltd.\", avec un capital total de 850.000, divisé en 10,000 actions d'une valeur au pair de 85 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 751 carré Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(P.G.12845-55) Speedy Tailors Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dixième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat.Harriet.Beutel, tencuse de livres, tous deux de Westmount et Joseph R.Hoffman, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce général de vêtements et tous autres articles vestimentaires pour hommes et garçons, sous le nom de \"Speedy Tailors Inc.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dixième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(A.G.12887-55) Rubyco Mills Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1955, incorporating: Benjamin Robinson, advocate and Queen's Counsel, of West-mount.Theodore II.Shapiro, advocate, of the town of Mount Royal, and Ethel Yussem, secretary,' spinster of the full age of majority, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in yarns, threads, textiles, fabrics, wearing apparel, clothing, fancy goods, dry goods, under the name of \"Rubyco Mills Ltd'.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 200 common shares of 850 each and into 800 preferred shares of 850 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.(A.G.13000-55) Rupert's Land Trading Company (Quebec) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1955, incorporating: Rodney Alexander Patch, advocate and Queen's Counsel, Constance Garner Short, Austin Stuart Hyndman Robert Charles Legge and Murray Churchill Magor.advocates, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real and immoveable property, under the name of \"Rupert's Land Trading Companv (Quebec) Ltd.\".with a total capital stock of'850,000.divided into 10.000 shares of the par value of 85 each.The head office of the company will be at 751 Victoria Square.Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the ofliee of the Attorney General, this fifteenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 4140S-o Deputy Attorney General.(A.G.12845-55) Speedy Tailors Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing dale the tenth day of November.1955.incorporating: Max S.Kaufman, advocate, Harriet Beutel, bookkeeper, both of Westmount.and Joseph R.Hoffman, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in general clothing and all other articles of men's and boys' wear, under the name of \"Speedy Tailors Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the ofliee of the Attorney General, this tenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, Ihccmbcr ,i.',lh, 1055, Vni.S7, Xn.51 3943 (P.G.12836-65) Style Pads Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatre novembre 1!).\").\"), const it uanl en corporation: Abraham Zlotnik, marchand.Sam Zlot-nîk, contremaître, tous deux de Montréal et Solomon W.Weber, avocat, d'Outremont, tous du «listrict judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de bourrelets en toile et garnitures, sous le nom de \"Style Pads Inc.\".avec un capital total de $40',000, divisé en -100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Daté «lu burt'au «lu Procureur général, le «piatre novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 4140S C.K.CANTIN.(P.G.1.'} Il 2-55) Suburban Auto Service Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes en date du onzième jour «le novembre 1955, constituant en corporation: W.LeM.Owen Carter, avocat.Norma Lee.secrétaire, tous deux de Sillery et Catherine Woodley.secrétaire, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Acquérir, administrer et exploiter des garages, sous le nom «le \"Suburban Auto Service Ltd.\".avec un capital total «le $15,000, divisé en 1,501) actions «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Sillery, district judiciaire «le Québec.Daté «lu bureau du Procureur général, ce onzième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, \u2022Il408 C.K.CANTIN.(P.G.13078-55) Super Realties Inc.Avis est donné «m'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «h- Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze novembre 1955.constituant en corporation: Louis-Philippe-R.Thibodeau, courtier en immeubles, Gilles Guilbault, agent, et Louis Duguay, commis, tous des «-ilé «4 district judiciaire «le Montréal, pour les bojets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Super Realties Inc.\".avec un capital total de 8 10.000.divisé en 400 actions «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Daté «lu bureau du Procureur général, le quinze novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41408-o C.K.CANTIN.(P.G.11219-55) The Reuben Ross Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres (latentes en date «lu quatorze mai 1955.constituant en corpora- (A.G.12S30-55) Style Pads Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth ck of S500.000, divided into 10,000 common shares of 810 each and into 4,000 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.(A.G.13017-55) Traders Realties (Montreal) Inc.Avis est «lonné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies' Act, letters patent have been été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- province de Québec, des lettres patentes en «late ince of Quebec, bearing date the ninth day of du neuvième jour de novembre 1955, constituant November, 1955, incorporating: Samuel Chait, QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, December 2/,th, 1055, Vol.87, No.51 3945 en corporation: Samuel ('liait, Harry L.Arono-vitch et Abraham Sinister, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles et propriétés immobilières, sous le nom de \"Traders Realties (Montreal) Inc.\", avec un capital total de S 10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de .Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce neuvième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général.41408 C.E.CANTIN.(P.G.12992-55) Turnabout Shop, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize novembre 1955, constituant en corporation: John Fitzwilliam Stairs, Patrick Fmmet Kierans et Pierre Jacques Guay, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de vêtements et accessoires, sous le nom de \"Turnabout Siiop, Inc.\".avec un capital total de $2,000, divisé en 2,000 actions d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Westmount, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(P.G.13015-55) Twin Mountain Holding Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de novembre 1955, constituant en corporation: Samuel (\"huit.Harry L.Arono-vitch, Abraham Sinister, avocats et Freda Pomcrance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de courtiers en immeubles, sous le nom de \"Twin Mountain Holding Company\", avec un capital-actions divisé en 400 actions ordinaires sans valeur au pair et 10,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 85 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.(P.G.12776-55) U.Marcoux & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre 1955, constituant en corporation: Doris Robert, Jean Marquis, avocats, Denise Ménard, Gertrude Meunier et Suzanne Fischer, secrétaires, filles majeures, tous de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Harry L.Aronovitch and Abraham Sinister-advocates, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate and immoveable property, under the name of \"Traders Realties (Montreal) Inc.\", with a total capital stock of 810.000, divided into 1.000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.(A.G.12992-55) Turnabout Shop, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1955.incorporating: John Fitzwilliam Stairs, Patrick Emmet Kierans and Pierre Jacques Guay, advocates, of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To generally deal in wearing apparel and equipment, under the name of \"Turnabout Shop.Inc.\", with a total capital stock of 82.000.divided into 2.000 shares of the par value of 81 each.The head office of the company will be at Westmount.judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN.41408-o Deputy Attorney General.(A.G.13015-55) Twin Mountain Holding Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of \u2022 November, 1955, incorporating: Samuel Chait, Harry L.Aronovitch, Abraham Sinister, advocates, and Freda Pomcranec, secretary, spinster, fille majeure, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the general business of realty brokers, under the name of \"Twin Mountain Holding Company\", with a capital stock divided into 400 common shares of no par value and into 10,000 preferred shares of the par value of S5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.(A.G.12776-55) U.Marcoux & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1955, incorporating: Doris Robert, Jean Marquis, advocates, Denise Ménard, Gertrude Meunier and Suzanne Fischer, secretaries, bachelors, all of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes: 3946 GAZETTE OFFII1ELLE DE QUÉBEC, Quebec, 2.', décembre 1955, Tome 87, N° 51 Manufacturer et exercer le commerce de meubles, jouets et articles de sport en bois, sous le nom de \"l \u2022 Marcoux & Fils Ltée\", avec un capital total de $25,000, divisé en 1,250 actions communes de S10 chacune et en 1,250 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à (iranby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408-o C.E.CANTIN.(P.G.13014-55) Vaudreuil Shopping Center Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et un novembre 1055, constituant en corporation : Samuel ('hait.Harry L.Aronovitch, Abraham Sinister, avocats et Freda Pomerance, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Vaudreuil Shopping (\"enter Inc.\".avec un capital-actions divisé en -100 actions ordinaires sans valeur au au pair et 10.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 85 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408 C E.CANTIN.(P.G.12873-55) Viens & Vallée Automobiles Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sept novembre 1955.const it liant en corporation: Jacques Viens, Alphonse Vallée, vendeurs, de Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville, et Béai Garneau, gérant, de Snowdôn, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de véhicules automobiles et faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Viens & Vallée Automobiles Ltée\".avec un capital total de 820.000, divisé on 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Iberville, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le sept novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 4140S-o C E.CANTIN.(P.G.12330-55) Went wort h Home Owners\" Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuvième jour de novembre 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Daniel D.Roscnbloom, Leonard Rasberry, tous deux administrateurs, Murray Spiegel, gérant, James E.Craig, vendeur, Ronald Edward Hindle, comptable, A.Donald Taylor, dessinateur, Siegfried Katz, fourreur et Cyrill Finestone, propriétaire To manufacture and carry on a business dealing in furniture, toys ami articles of sport in wood, under the name of \"U.Marcoux & Fils Ltée\", with a total capital stock of 825.000.divided into 1.250 common shares of 810 each and into 1.250 preferred shares of 810 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1955.C.F.CAN TIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.1301 1-55) Vaudreuil Shopping Center Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of November.1955, incorporating: Samuel (\"bait.Harry L.Aronovitch, Abraham Sinister, advocates, and Freda Pomerance, secretary, spinster of the full age of majority, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Vaudreuil Shopping Center Inc.\", with a capital stock divided into 400 common shares of no par value, and into 10.000 preferred shares of the par value of 85 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of November, 1955.C.E.CANTIN.41408-o Deputy Attorney General.(A.G.12X73-55) Viens «S: Vallée Automobiles Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventh day of November 1955.incorporating: Jacques Viens, Alphonse Vallée, salesmen, of Saint John, judicial district of Iberville, and Real Garneau, manager, of Snowdon, judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in motor vehicles and carry on business as garage-keepers, under the name of \"Viens & Vallée Automobiles Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Iberville, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of'September 1955.C.E.CANTIN.41408 Deputy Attorney General.(A.G.12330-55) Went wort h Home Owners' Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of November, 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Daniel D.Rosen-bloom, Leonard Rasbcrry, both Executives, Murray Spiegel, manager, James E.Craig, salesman, Ronald Edward Hindle, accountant, A.Donald Taylor, Design Draughtsman, Siegdfried Katz, furrier, and Cyril Finestone, Service St a- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2/,th, 1955, Vol 87, No.51 3947 de poste «le service, tous «les cité et district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Étudier, protéger et promouvoir les intérêts «'¦conomiques, sociaux, culturels et moraux «le ses membres, sous le nom «le \"Wentworth Home (hvners' Association\".Le montant auquel est limitée la valeur «le la propriété immobilière «pie la corporation peut posséder est 850,000.Le siège social de la compagnie sera à 5010 avenue «lu Parc.Mont irai, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général, ce neuvième jour de novembre 1950.L'Assistant-procureur général, 41408 C.E.CANTIN.tion owner, all of the City and judicial district of Montreal, for the following purposes: Study, protection and development of the economic, social, cultural and moral interests of its members, under the name of \"Wentworth Dome Owners' Association\".The amount of which the value of the immoveable property which the company may possess, is to be limited, is 800,000.The head office of the corporation will be at 5616 Park Avenue, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Dated at the ofliee of the Attorney General, this ninth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408-o Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires (P.G.13134-55) Men loin Beef Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du seize novembre 1955, à la compagnie \"Cumula Beef Co.Ltd.\", constituée en corporation en vertu «le ladite première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, par lettres patentes «lu 29 août 1947, changeant son nom en celui de \"Bentom Beef Co.Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général,le seize novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408-o C.E.CANTIN.(P.G.12971-55) Les Entreprises de J.Emile Langlois Liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province «le Québec «les lettres patentes supplémentaires, en date du dix novembre 1955.à la compagnie \"Canada Flushwood Door, Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, par lettres patentes «lu 27 novembre 1930, et par lettres patentes supplémentaires en date, respectivement, «lu 17 août 1932, du 22 février 1940 et du 20 février 1951: a) changeant son nom en celui de \"Les Entreprises «le J.Emile Langlois Ltée\"; b) modifiant ses pouvoirs de la manière prévue dans son règlement adopté à cette fin.Daté du bureau «lu Procureur général, le dix-novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408-6 C.E.CANTIN.(P.G.10708-55) McCord Street Sites Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur «le la province de Québec «les lettres patentes supplémentaires, en date du onze novembre 1955, à la compagnie \"McCord Street Sites Limited\": a) réduisant son capital: le capital-actions annulé étant divisé en 20.000 actions privilégiées de 85; b) augmentant son capital ainsi réduit: le capital-actions addittionnel étant divisé en 100,000 actions privilégiées «le 85.Supplementary Letters Patent (A.G.13134-55) Bentom Beef Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, «lated the sixteenth day of November 1955, to the company \"Canada Beef Co.Ltd.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated August 29th.1947.changing its name to that of \"Bentom Beef Co.Ltd.\".I)ate«l at the ofliee of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.12971-55) Les Entreprises «le J.Emile Langlois Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November tenth, 1955, to the company \"Canada Flushwood Door.Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent of November 27th, 1930.and by supplementary letters patent dated, respectively, from August J7th, 1932, from February 22n«l, 1940 ami from February 26th, 1951: a) changing its name into that of \"Les Entreprises «le .1.Emile Langlois Ltée\"; b) amending its powers in the manner provided for in its bylaw adopted for this purpose.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of November.1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.10708-55) McCord Street Sites Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Qluebec, dated the eleventh day of November 1955, to the company \"McCord Street Sites Limited\": a) decreasing its capital: the cancelled share capital being divided into 20,000 preferred shares of 85; b) increasing the said decreased capital: the additional share capital being divided into 100,000 preferred shares of 85. 3948 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2/, décembre 1955, Tome 87, N° 61 Daté du bureau du Procureur général, le onze novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408-o C.E.CANTIN.(P.G.12974-55) Rachel Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du huit novembre 1955, à la compagnie \"Rachel Realties Inc.\".étendant ses pouvoirs aux autres objets mentionnés dans son règlement numéro 22 adopté à cette fin.Daté du bureau du Procureur général, le huit novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 41408-o C.E.CANTIN.(P.G.12632-55) Rôtisserie C Si Ron Bar-B-Q, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec de» lettres patentes supplémentaires, en date du deux novembre 1955, à la compagnie \"Rôtisserie (' Si Bon Bar-B-Q, Inc.\", créant et émettant 350 actions ordinaires de 8100 de son capital-actions autorisé sous forme de 350 actions privilégiées de 8100.Daté du bureau du Procureur général, le deux novembre 1055.L'Assistant-procureur général.41408-e C.E.CANTIN.(P.G.12931-55) Sillery Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix novembre 1955, à la compagnie \"Sillery Investment Corporation\", augmentant son capital de $60,000 à 8210,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,500 actions privilégiées de 8100.Daté du bureau du Procureur général, le dix novembre 1955.L'Assistant-procureur général, 4140S-o C.E.CANTIN.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.12974-55) Rachel Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November eighth, 1955.to the company \"Rachel Realties Inc.\", extending its powers to other objects mentioned by-law number 22nd adopted for this purpose.Dated at the office of the Attorney General, this eighth dav of November, 1955.C.E.CANTIN, 41408 Deputy Attorney General.(A.G.12632-55) Rôtisserie C Si Bon Bar-B-Q, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act., supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November second.1955, to the company \"Rôtisserie C Si Bon Bar-B-Q, Inc.\", creating and issuing 350 common shares of 8100 of its authorized capital stock in the from of 350 preferred shares of 8100.Dated at the ofliee of the Attorney General, this second dav of November, 1955.C.E.CAN\"PIN, 11408 Deputy Attorney General.(A.G.12931-55) Sillery Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the tenth day of November 1955, to the company \"Sillery Investment Corporation\", increasing its capital from the sum of 800,000 to 8210,000: the additional share capital being divided into 1,500 preferred shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of November, 1955.C.E.CANTIN.4140s Deputy Attorney General.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1200 Québec, le 15 décembre 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \".4\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1200 Quebec, December 15th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"A\" Concerning amendments of the decree relating to the construction industry and trades in the region of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2J,th, 1955, Vol.87, No.51 3949 refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amcnd-dements), les parties contractantes à lu convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 700 du 30 juin 1953, amendé par les arrêtés en conseil numéro SOI et 1157-B des S juillet et 23 octobre 1953.419-E et 775-A des 29 avril et 28 juillet 1951, 17S-A et 522-A des 5 mai et 11 mai 1955, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 22 octobre 1955: Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 700, soit modifié comme suit: 1° L'article IV-A suivant est jouté: \"IY-A.Dispositions S inviolés et co m piemen -taires relatives à l'industrie du métal d'ornementation et d'utilité de la construction: a) Définitions: Pour les fins d'application du décret les termes suivants ont la signification qui leur est.ci-après donnée: 1° Le terme \"mécanicien de métal\" désigne tout salarié qui fait le tracé, la coupe, la préparation et l'assemblage, au moyen de machines, d'outils ou de soudure, de toutes pièces de métal et qui en fait le montage et l'installation.2° Le mot \"forgeron\" désigne tout salarié capable d'exécuter le travail appartenant au métier de forgeron.3° Le terme \"compagnon junior mécanicien de métal ou forgeron\" désigne tout salarié qui en est à sa première année de pratique, après avoir complété ses quatre (4) année d'apprentissage dans le métier.\u20221° Le mot \"apprenti\" désigne tout salarié qui apprend l'un ou l'autre des métiers ci-dessus et pour lesquels un apprentissage est requis.b) Juridiction industrielle: Le présent décret régit toute fabrication, transformation, opération, assemblage, montage et installation de tout métal d'ornementation et d'utilité pour fins de construction comprenant entre autres les articles suivants: Portes, chassis et encadrements de portes et chassis; Escaliers intérieurs ou extérieurs, garde-corps, rampes; Appareils de sauvetage; Clôtures, barrières, balcons et marquises; Grilles, garde-fenêtres, cages et divisions; Trappes de cave ou d'inspection et chutes à charbon; Portes de voûtes et portes coupe-feu.Le décret ne s'applique pas à la fabrication en série des articles suivants: portes, chassis, encadrements de portes et chassis, divisions de toutes sortes et recouvrements de calorifères.Pour fins d'application du décret, la fabrication en série doit couvrir un minimum de 25 unités semblables.\" c) Juridiction professionnelle: Le décret régit les salariés travaillant dans les ateliers inclus dans la juridiction industrielle déterminée au paragraphe \"6\" du présent article.d) Taux de salaire: Les taux minima de salaire suivant doivent être payés: Quebec, 1941 chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the construction industry in the region of Quebec, rendered obligatory by the decree No.700 of June 30, 1953.as amended by Orders in Council Nos SOI and 1157-B of July S and October 23.1953.419-E and 775-A of April 29 and July 28, 1954 .478-A and 522-A of May 5 and May II, 1955.have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration ami decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree; Wiikheas the petition was published in the Quebec Official Gazette, issue of October 22.1955; Whereas the objections thereto have been duly considered, as required by the Act; It is ordered, therefore, en the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 700, be amended as follows; 1.The following section IV-A is added: \"IV-A.Special and complementary provisions respecting construction ornamental and utility metal: a) Definitions: Forth* purposes of enforcement of the decree, the following terms shall have the meaning hereafter given to them: 1.The term \"metal mechanic\" means any employee whose work is concerned with the tracing, cutting, preparation and assembling of all kinds of metal with machines, tools or welding machine, and with the erection and installation thereof.2.The term \"blacksmith\" means any employee capable of executing the work appertaining to the blacksmith's trade.3.The term \"junior metal mechanic or blacksmith\" means any employee who is in his first year of practice following the completion of the four years of apprenticeship in the trade.4.The term \"apprentice\" means any employee who learns any one of the trades above mentioned ami for which an apprenticeship must be served.b) Industrial jurisdiction: The present decree applies to any fabrication, transformation operation, assembling, erection and installation of any construction ornamental and utility metal including, but not restricted to the following: Doors, windows and frames thereof; Inside or outside staircases, rails, guards; Escape apparatus; Fences, gates, balconies and marquises; Grillework, window guards, cages and partitions; Cellar or inspection trap-doors and coal pits: Vault doors ami fire-doors.The decree docs not apply to the series production of the following articles: doors, windows and frames thereof, partitions of all kinds and radiator exclosures.For the purposes of enforcement, the series production shall comprise a minimum of 25 similar units.\" c) Professional jurisdiction: The decree applies to the employees working in the shops comprised in the industrial jurisdiction determined in subsection \"b\" of the present section.d) Wage rates: The minimum wage rates shall be as follows: 3950 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 2L décembre, 1955, Tome 87, N° 51 Zones 1 II III Mécanicien ou forgeron.SI .50 81 .40 SI .30 Compagnon junior (1 an).1.40 1.30 1.20 Manœuvre ou journalier.1.20 1.05 0.95 Apprentis: Zones I, II et III Année 1ère 2cme Sème .'finie Mécanicien ou forgeron.SO.00 80.75 80.90 81.00 e) Nombre d'apprentis: Le nombre d'apprentis ne doit pas être supérieur à un (1) par trois (3) compagnons mécaniciens ou forgerons ou fraction de ce nombre.Note: Les clauses générales du décret s'appliquent également aux salariés couverts par le présent article.\" 2° Le paragraphe \"m\" «le l'article I est radié.3° L'alinéa intitulé \"Note\", apparaissant à la fin du paragraphe \"a\" de l'article II (Juridiction professionnelle), est radié et remplacé par le suivant : \"Note: Le décret régit toutes les opérations du métier de ferblantier-couvreur, que «'es opérations soient exécutées sur un chantier ou dans une boutique; il s'applique également à tous les travaux de fabrication, de réparation d'outillage et à tout ouvrage de quelque nature que ce soit, exécute par le salarié durant le temps et la «luire du travail.\" 4° Dans l'échelle de salaire de l'article IV, tout l'item concernant le fer et bronze d'ornementation est radié.5° Le sous-paragraphe \"j-4\" de l'article X est radié.0° Dans l'échelle «le salaire «le l'article X.paragraphe \"k\", l'item concernant le mécanicien en fer et bronze d'ornementation, est radié.(Document \"A\" annexé à l'arrêté) L.DÊSILF/rS, 41422-0 Greffier «lu Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF Numéro 1200 Québec, le 15 décembre 1955.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Section \"B\" Concernant des modifications au décret relatif aux métiers de barbiers, coiffeur et coiffeuse «lans les comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, Terrebonne et Laval (Ile Jésus seulement).attendu que, conformément aux dispositions de la Loi «le la convention collective (Statuts refondus «le Qut'bee 1941.chapitre 103 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans les comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes, Terrebonne et Laval (Ile Jésus seulement), rendue obligatoire par le «lécret numéro 140 du 27 février 1952.amendé par les arrêtés en conseil numéro 805-B du 30 juillet 1952, 1378-B du 23 décembre 1953 et 100-C du 26 janvier 1955, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil certaines modifications ayant pour but d'étendre la juridiction dudit «lécret au comté «le Labellc; Zones I II III Mechanic or blacksmith.SI .50 SI .40 SI .30 Junior journeyman ( 1 year).1.40 1.30 1.20 Common worker or labourer.1.20 1.05 0.95 Apprentices: \u2022 Zones 1, II and III Year 1st 2nd Srd !,th Mechanic or blacksmith.80.60 SO.75 SO.90 81.00 .e) Number of apprentices: The number of apprentices shall not exceed one to three journeymen mechanics or blacksmiths, or fraction thereof.Note: The general clauses of the decree also apply to the employees covered by the present section.2.Subsection \"m\" of section I is deleted.3.The paragraph headed \"Note\", appearing at the end of subsection \"«/\" of section II (Professional jurisdiction), is deleted and the following substituted therefor: \"Note: The decree applies to all operations of the tinsmith-roofer trade, whether such operations be executed on the job or in a shop; it also extends t.all toolmaking and repair operations and to any work of any nature whatever, carried out by the employee during working hours.\" 4.In the wage scale of section IV, the entire item concerning the ornamental iron and bronze worker is deleted.5.Paragraph of section X is deleted'.0.In the wage scale of section X, subsection \"k\" the item concerning the ornamental iron and bronze mechanic is «leletetl.(Document.\"A\" annexed to the Order) L.DÉSILETS, 41422-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1266 Quebec, December 15th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"B\" Concerning amendments of the decree relating to the barber and hainlressing trades in the counties of Argenteuil.Deux-Montagnes, Terrebonne and Laval (Jesus Island only).Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941.chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hainlressing trades in the counties of Argenteuil, Deux-Montagnes, Terrebonne and Laval (Jesus Island only), rendered obligatory by the decree No.140 of February 27th, 1952, and amended by Orders in Council Nos 805-B of Julv 30th, 1952, 1378-B of December 23rd, 1953, and 100-C of January 26th, 1955, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the said decree for the purpose of extending its jurisdiction to the county of Labelle; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 24th, 1955, Vol.87, No.51 3951 Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 22 octobre 1955; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro MO, soit modifié comme suit: 1° A l'article II (juridiction territoriale), l'alinéa suivant est ajouté: \"Le présent décret s'applique également au comté de Labellc, divisé pour fins d'application en deux (2) zones comme suit: Zone A: La ville de Mont-Laurier et la municipalité de Lac-des-Êcorces et un rayon de trois (3) milles de leurs limites.Zone B: Les municipalités de Ferme-Neuve, Labellc, L'Annonciation et Val-Barctte et le territoire compris dans un rayon \"de trois (3) milles de leurs limites.\" 2° A l'article IV (durée du travail), les dispositions suivantes sont ajoutées: \"bb) Dispositions concernant le comté de Labellc: Les heures régulières de travail sont les suivantes: 1.Pour les barbiers Zone A: Du lundi au jeudi inclusivement: de 8.00 a.m.à 0.00 p.m.; Les vendredi, samedi et veilles de fêtes chômées ainsi que 15 jours avant le Premier jour de l'An et la fête de Pâques: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.Zone H: Les lundi, mercredi, vendredi et samedi: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.; Les mardi et jeudi: de 8.00 a.m.à 0.00 p.m.; Les veilles de fêtes chômées ainsi que 15 jours avant le Premier jour de l'An et la fête de Pâques: mêmes heures que le samedi.Exceptions: i.Toutefois, à Ferme-Neuve, le travail peut se continuer jusqu'à minuit les vendredi et samedi.ii.A Labellc et l'Annonciation, le travail doit se terminer à midi le jeudi.2.Pour les coiffeurs et coiffeuses Zone A: Le lundi: de 1.00 p.m.à 9.00 p.m.; Les mardi, jeudi et samedi: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m.; Le mercredi: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.; Les vendredi: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.; Les veilles de fêtes chômées ainsi (pie 15 jours avant le Premier de l'An et la fête «le Pâques: de 8.00 a.m.à 10.00 p.m.Zone B: Les lundi, mercredi et vendredi:«le 8.00 a.m.à 9.00 p.m.; Les mardi, jeudi et samedi: «le 8.00 a.m.à 0.00 p.m.; Les veilles de fêtes chômées ainsi que 15 jours avant le Premier «le l'An et la fête «le Pâ«pies: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.\" 3P A l'article VII (Prix minima «les services), le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe \"b\": \"bb) Dans le comté de Labelle: Nonobstant les dispositions des paragraphes \"a) 1e\", \"o) 2°\" et \"6\" du présent article, les prix minima sont les suivants: 1.Service des barbiers Zones \"A\" \"B\" Coupe de cheveux pour adultes: Du lundi au jeudi inclusivement.S0.-60 80.50 Vendredi, samedi et veilles de Whereas the petition has been published in the Quebec Officiul Gazette, issue of October 22nd, 1955; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordained, therefore on.the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said «lecree, No.1-10, be amen«lc«l as follows: 1.In section II (Territorial jurisdiction), the following paragraph is added: \"The present «lecree also applies to the county of Labellc which is divided into two (2) zones, for purposes of enforcement of the decree, as follows: Zone A: The city of Mont-Laurier and the municipality of Lac-d«'s-Ecorces anf the Province of Quebec, at its present or next session for a passing of an Act for the fallowings purposes, besides those already published since October 20th, 1955.t«> with the following lots appearing as public roads, streets, or lanes on the official plan and book of reference of the cadastre of the parish of Longue l'ointe and situated in the limits of the Municipality will be dcclare«l the town's property: «) 428 \u2014 1, 20, 40, 64, (55, 73 and 85; b) 427 \u20141.15.30.58, 59.05.09, 77, 91, 105.130, 140.111.150.100, 108, 183, 198.230.231.235.202.200.274.301.328, 372, 370, 377.395.3!'!).107.125.113.478, 179.483, 501.505, 515.531.51!».5S1.5SS.5S9.009.(ill, 019, 633, 647.tils.070.077.- With the power for the town to close these public roads, streets and lanes ami consents to persons or corporation a valided title to these lots in exchange with other lots destined to serve as public roads, streets ami lanes.YVES LAURIER, 41395-50-4-o Attorney for the petitioner.Public notice is hereby given that the city 0' Lachine will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption «>f an act amending its charter, the Act 9 Edward VII.chapter 80, in addition to the purposes described in the notice of November 10th, 1955.for the following purposes: valuation, for municipal purposes, of the Third factory of the Northern Electric Company Limited; to amend by-law number 1003, concerning the zoning, without referendum, in order to allow certain types of indust ries on certain lots situated within the zone II; to repeal artk-le 52 of chapter SO of the Acl 9 Edward VIT; to adopt a zoning by-law for any territory to be annexed, without referemlum; and forother purposes.Montreal.December 12th.1955.LACROIX.VIAU & POUPART, The Attorneys, for the city of Lachine.41390-50-4-o Notice is hereby given that the town of Rivière des Prairies will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present or a next session, for the passing of an Act granting certain powers and amending its charier, on the following matters: 1.To obtain the power to abrogate a zoning by-law and a building by-law and to adopt new ones without referendum; 2.To have the properly assigned to the town, under certain conditions, of streets, lanes, public roads, public places and sidewalks now open to the use of the public in the limits of the town, or indicated as such on Subdivision Plans, on the Official Plan and Book of Reference deposited at Registry Office of Montreal and on the valuation roll of the town before January 1st.195GV, 3.To authorise the town to set for a parioil of lime, a fixed taxation on the land buildings ol the factory which J.A.Levine has undertaken to build in the limits of the*town; 4.And for other purposes.Montreal, December 9th 1955.LABELLE & LABELLE, 41398-50-4-o Attorneys for the petitioner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2/,th, 1955, Vol.87, No.51 3967 AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE Avis est, par les présentes, donné epic \"Le Notice is hereby given that \"The Protestant Bureau Métropolitain des Ecoles Protestantes School Board of Greater Montreal\" will apply de Montréal\" demandera à la Législature de la to the Legislature of the province of Quebec, Province de Québec, à sa présente session, l'adop- at its present session, for the passing of an act.tion d'une Loi, amendant la Loi 15, George V, amending the Act 15, George V, chapter 45, chapitre 45 et différentes lois l'amendant, aux and various acts amending same, for the purpose fins de modier sa charte, étendant et définis- of amending its charter, extending and further saut plus amplement ses pouvoirs, et pour defining its powers, and for other purposes, d'autre fins.Montréal, ce 13c jour de décembre 1955.Montreal, this 13th dav of December 1955.Le Procureur des pétitionnaires.ALFRED M.WEST, Q.C., 41406-50-4 * ALFRED M.WEST, C.R.41406-50-4-o Attorney for the petioners.AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE Le soussigné donne avis qu'il s'adressera à la The undersigned gives notice that he will Législature de la province de Québec, à la pré- apply to the Legislature of the Province of sente session, pour la passation d'une loi auto- Quebec at its present session for the passing of risant le Barreau de la province de Québec à an Act to authorize the Bar of the Province of l'admettre à la pratique du droit.Quebec to admit him to the practice of law.Montréal, le 12 décembre 1955.Montreal.December, the 12th.1955.AKOS DE S.MUSZKA.AKOS DE S.MUSZKA.4141S-51-4-0 41418-51-4-0 Département de l'Instruction Publique Department of Education N° 824-55.Québec, le 13 décembre 1955.Demande est faite de rectifier les limites de la municipalité scolaire protestante d'Onslow, dans le comté de Pontine, afin qu'elle comprenne le territoire ci-dessous décrit: \"Toute cette partie de territoire borné au sud par la ligne limitative intcrprovinciale, à l'est par la ligne entre les comtés de Pontiac et de Gatineau, au nord par celle entre la municipalité d'Onslow et le Canton Aldfield et à l'ouest par la ligne entre la municipalité d'Onslow et la municipalité du canton de Bristol, en ajoutant dans les rangs V, VI et VII du canton de Bristol tous les lots à l'est du lot N° 13 inclusivement; dans le rang IV, les lots 14-B, 15-C, 16-B, 17-B, 17-C et 18 à 25 inclusivement et dans le rang III, les lots 25 à 27 inclusivement\".\u2022V; Le Surintendant de l'Instruction publique, 41399-50-2-o O.J.DÉSAULNIERS.No.824-55.Quebec, December 13th, 1955.Application is made to rectify the limits of the Protestant School municipality of Onslow, in the county of Pontiac, so as to comprise the territory hereinunder described; \"All that part of territory bounded on the south by the interprovincial line limit, on the east, by the line between the counties of Pontiac and of Gatineau, on the north, by that between the municipality of Onslow and the Aldfield township and on the west, by the line between the municipality of Onslow and the municipality of the township of Bristol, by adding in the ranges V, VI, and VII of the township of Bristol, all the lots east of lot No.13 exclusivelv; in range IV, lots 14-B, 15-C, 16-B, 17-B.17-C and 18 to 25 inclusively and in range III, lots 25 to 27 inclusively\".0.J.DÉSAULNIERS, 41399-50-2 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Beau port (Municipalité de Villeneuve) division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné (pie les lots 238-7, 238-9, 238-10.239-1-1, 339-1-2.239-1, 239-2, 239-3-1, 239-3.239-4, 239-5, 239-6-1.239-6-2, 239-6, 239-7, 239-8.239-9.239-14.242-1, 242-2-1, 242-2, 242-3, 242-4.242-5.242-13, 246-1, 247-2, 249-2 et une partie des lots 237.238, 239, 242, 246, 247, 249-1, 249, 249-5, 252, 254-A, 257, 259, 260, 267, 268, 269.279.280.285, 286, 328.329, 332, 340, 341 et 342 sont annulés et les lots 1529 à 1532 sont ajoutés en vertu des dispositions de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 20 décembre 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre.Le .Sous-Ministre, 41409-o AVI LA BÉDARD.Department of Lands and Forests NOTICE Official Cadastre of the parish of Beauport (Municipality of Villeneuve) registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 238-7, 238-9, 238-10.239-1-1.2*39-1-2.239-1, 239-2, 239-3-1, 239-3, 239-4.239-5, 239-0-1.239-6-2.239-6, 239-7.239-8.239-9.239-14.242-1.242-2-1.242-2.242-3.242-4.242-5.242-13.246-1, 247-2.249-2.and part of lots 237.238.239, 242.240.247.249-1.249, 249-5.252.254-A, 257, 259, 260, 207, 208.209, 279, 280, 285.280, 328, 329.332, 340, 341 and 342 are cancelled and lots 1529 to 1532 are added in virtue of Article 2I74A of the civil ('ode.Quebec.December the 20th, 1955.Department of bands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD.41409-o Deputy Minister. 3968 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 décembre 1955, Tome 87, N° 51 Cadastre officiel revise de l'Ile Allright (Muniei- Officiai cadastre revised of Allright Island, palité de Hâvre-aux-Maisons), division d'enre- (Municipality of Havre-aux-Maisons), regis-gistrement des Ues-de-la-Madeleine.tration division of Ilcs-dc-Ia-Madeleine.Avis est par la présente donné que les lots 6, 13-B, lô-A, 26-11, 26-C, 27, 32-A, 32-B, 36-A, 36-B, 38, 39, 10, 46, 48-A, 48-B, 49-A, 49-B, 51-A, 53-C, 53-E.54-A, Ô4-B.57-A-l, 57-B-2, 57-E, 57-G, 57-N, 57-0.58-B, 59-A, 60-1, 60-2, 60-A-l, 60-B, 61.62.63-B, 01-C.05-A, 65-B.70-A, 71-B, 73-3-A, 73-4-A.73-4-B.73-5-A, 73-6, 73-7-C, 73-10.73-11, 73-13-B.73-28-A.73-28-B.73-29-A, 73-29-B, 73-34.73-35.73-38-B, 73-20, 73-21, 73-22.75-1), 75-E, 75-G.75-H, 75-K, 75-L, 75-M.70-B.77-A.77-B, 77-C, 79, 80, 82, 83, M.S0-C, S7-1), 88-C, 89-A, 91, 92-A, 92-B, 95-A, 95-B, 95-C, 95-1), 96, 97-A, 97-C, 97-D, 97-F, 98, 102-A, 103-A-l.104-B, 104-C, 109-B, 113-A, 119-B, 120-A.120-B, 122-A, 124-A, 124-B, 126-B, 126-C, 128-A-l, 128-A-2.132, 135-B, 135-C, 136, 140.141-A.143-A.143-B, 145-A.146-2, 146-3, 147-B.147-D, 148-A.148-D, 148-E, 148-F, 148-G, 149-C, 149-E, 149-H.150-1, 150-A-l, 151-1, 152-B.152-D, 154-E-2.154-E, 154-G, 154-H, 154-1.154-.!.154-K, 154-L.157-1, 157-5, 161-B, 162-A, 162-B, 163-A, 103-B, J66-B, 169-A, 170-A, 170-C, 172-A, 176-2, 176-A-l, 176-A-4, 178-B, 182-A, 1S2-B, 183-A, 184-D.184-E, 187, 188-2, 188-4-A, 188-5-A, 188-5-B, 188-5-C, 188-7, 188-8-A, 188-8-B, 188-9-A, 188-9-B, 188-9-E, 18S-10-A, 188-11-B, 188-12-B, 188-14-A, 188-15-A.1S8-15-B, 188-15-1), 188-20, 188-22-A, 188-22-C, 188-22-E, 188-24, 188-27-A, 188-37, 188-42.1S8-43-A, 188-43-B.188-44, 188-45-A, 1SS-15-B.191-B.192-C.194-D, 195-C, 197-A, 197-B.197-C, 197-1), 202-B, 203-B-2.204-C, 206-B, 200-1), 207-A, 207-B, 209-A, 209-B, 210-3.210-5, 210-0.210-A-3, 210-A-4, 211-B, 211-F.211-11, 211-1, 214-B, 215-A, 215-B, 216-B.218-B.218-C, 219-A, 219-C, 220-2, 220-3, 220-4, 221-A-l, 222-E, 223-7-A.223-18, 223-20.223-21-A.223-21-B.223-21-C.223-21-D, 223-27.225 et 226 sont corrigés et les lots 81-A, 81-B, 126-A, 152-E, 203-B-3, 221-A-3, sont annulés et les lots 81, 2I0-A-5, 223-28 sont ajoutés, en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 28 novembre 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Ix» Sous-ministre, 41409-o A VILA BÉDARD.Notice is hereby given that lots 0, 13-B, 15-A, 20-B,26-C,27, 32-A, 32-B, 36-A, 36-B, 38, 39, 40.40, 48-A, 48-B.49-A, 49-B.51-A, 53-C, 53-E, 54-A.54-B, 57-A-l.57-B-2.57-F, 57-G, 57-N, 57-0, 58-B.59-A.00-1.00-2.00-A-1, 00-B, 01, 62, 63-B.64-C, 65-A, 65-B, 70-A.71-B, 73-3-A.73-4-A, 73-4-B, 73-5-A.73-0, 73-7-C, 73-10.73-11.73-13-B, 73-28-A, 73-28-B, 73-29-A.73-29-B, 73-34, 73-35, 73-38-B, 73-20.73-21, 73-22, 75-1), 75-E, 75-G, 75-H, 75-K, 75-L, 75-M, 70-B, 77-A, 77-B, 77-C, 79, 80.82, 83.84, 86-C, 87-1), 88-C, 89-A, 91, 92-A, 92-B.95-A.95-B, 95-C, 95-1), 96.97-A, 97-C.97-1), 97-F, 98.102-A, 103-A-l.104-B.104-C, 109-B.113-A, 119-B.120-A.120-B, 122-A, 124-A, 124-B, 120-B, 126-C, 128-A-l, 128-A-2.132.135-B.135-C, 136, 140.141-A.143-A.143-B, 145-A.146-2, 146-3, 147-B, 147-D.148-A, 148-D.148-E, 148-F, 147-G, 149-C, 149-F, 149-H.150-1.150-A-l.151-1, 152-B, 152-D, 154-E-2, 154-F.154-G.154-H, 154-1, 154-.I, 154-K.154-L, 157-1, 157-5, 161-B, 162-A, 162-B, 163-A, 103-B.100-B, 169-A, 170-A, 170-C, 172-A, 176-2.176-A-l, 170-A-4.178-B.182-A.182-B, 183-A.184-D, 184-E, 187, 188-2, 188-4-A, 188-5-A.1ss-5-B.1S8-5-C, 188-7, 18S-S-A, 188-8-B.188-9-A, 188-9-B, 188-9-E, 188-10-A.188-11-B.18S-12-B, 188-14-A, 188-15-A.188-15-B.188-15-1).1S8-20.18S-22-A.188-22-C.188-22-E.188-24, 188-27-A, 188-37, 188-42.188-43-A, 188-43-B.188-44, 188-45-A.188-45-B.191-B.192-C.194-1).195-C, 197-A, 197-B, 197-C.197-1), 202-B.203-B-2, 204-C, 206-B, 200-1).207-A, 207-B.209-A, 209-B.210-3.210-5, 210-0.210-A-3, 210-A-l, 211-B.211-F, 211 -II.211-1, 214-B.215-A.215-B.216-B, 218-B.218-C.219-A, 219-C, 220-2, 220-3, 220-4, 221-A-l.222-E.223-7-A.223-18.223-20, 223-21-A, 223-21-B, 223-21-C, 223-21-1), 223-27, 225 and 226 are corrected, lots 81-A, 81-B, 120-A.152-E, 203-B-3, 221-A-3, are cancelled and lots 81, 210-A-5.223-2S are added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, November the 28th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, A VILA BÉDARD, 41409-o Deputy Minister.AVIS NOTICE Cadastre officiel du canton Ascot (Cité de Slier- Official cadastre of the township of Ascot.(City hrooke).division d'enregistrement de Slier- of Sherbrooke), registration division of Sherbrooke, brooke.Avis est par la présente donné que les lots 15-i-l à J5-i-39, 15-1-43 à 15-i-128 du rang X, le lot 15-E sont annulés et le lot 15-i est corrigé, en vertu de l'article 2174A du Code eivil.Québec, le 5 décembre 1955.I^e Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 41409-o A VILA BÉDARD.Notice is hereby given that lots 15-i-l to 15-i-39, 15-Î-43 to 15-Î-128 of range X and lot 15-E are cancelled and lot 15-i is corrected in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, November the 5th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVI LA BÉDARD, 41409-o Deputy Minister.AVIS NOTICE Cadastre officiel de la cité d'Arvida \u2014 division Officiai Cadastre of the city of Arvida \u2014 legist-d'enregistrement de Chicoutimi.ration division of Chicoutimi.Avis est par la présente donné qu'une partie Notice is hereby given that part of lot 3000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2/,th, 1955, Vol 87, No.51 3969 du lot 3000 et 1c lot 3000-9 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 22 novembre 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-minisl re, 41409-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du canton de Bollon division d'enregistrement de Brome.Avis est par la présente donné que les lots 1307-1 à 1307-9 sont annulés en vertu de l'article 2174A du ('ode civil.Québec, le 15 novembre 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 41409-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du canton de Neintaye, division d'enregistrement de Malapédia.Avis est par la présente donné que dans le rang VI le lot N est annulé et le lot M est amendé, en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 25 novembre 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 41409-o AVILA BÉDARD.and lot 3000-9 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, November the 22nd, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 41409-o Deputy Minister.NOTICE Official Cadastre of the township of Bolton registration division of Brome.Notice is hereby given that lots 1367-1 to 1307-9 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, November the 15th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 41409-o Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the township of Nemtaye, registration division of Matapédia.Notice is hereby given that in range VI lot N is cancelled and lot M is amended in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, November the 25th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 41409-o Deputy Minister.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foy, (Cité de Ste-Foy).division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 157-1 ; les lots 157-A-2 (rue), 157-1-2 (rue).157-1-1, 157-1-3 et 157-A-3; une partie des lots 157-A et 157 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil, et remplacés par le lot 402.Québec, le 7 décembre 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 41409-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Stc-Foye, (Cité de Ste-Foy), division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 221, 222, une partie des lots 220 et 223 et les lots 220-2 à 220-120, 221-1 à 221-198, 222-1 à 222-68, 223-2 à 223-158 sont annulés et remplacés par le lot 403 en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 14 décembre 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 41409-o AVILA BÉDARD.NOTICE Officiai cadastre of the parish of Ste.Foy, (City of Ste.Foy), registration division of Quebec.Notice is hereby given that lot 157-1; lots 157-A-2 (Street), 157-1-2 (Street), 157-1-1, 157-1-3, 157-A-3; part of lots 157A and 157 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code and replaced by lot 402.Quebec, December the 7th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 41409-o Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the parish of Ste-Foyc, (City of Stc-Foy), registration division of Quebec.Notice is hcrebv given that lots 221, 222, part of lots 220 and 223 and lots 220-2 to 220-120, 221-1 to 221-198,222-1 to 222-08,223-2 to 223-158 are cancelled and replaced by lot 403 in virtue of Article 2I74A of the Civil code.Quebec, December 14th, 1955.Department of Lands and F'orests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 41409-o Deputy Minister.AVIS NOTICE Cadastre officiel de la paroisse de St-Vincent-de- Officiai cadastre of the parish of St-Vincent-de-Paul, (Ville de Pont-Viau), division d'enregis- Paul, (Town of Pont-Viau), registration divi-trement de Laval.sion of Laval. 3970 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 24 décembre 1955, Tome 87, N° 51 Avis est par la présente donné que les lots Notice is hereby given that, lots 41-1-79 to 41-1-79 à 41-1-87 sont annulés en vertu de l'article 41-1-87 are cancelled in virtue of Article 2174A 2174A du Code civil.of the Civil code.Québec, le 28 novembre 1955.Quebec.November 28th, 1955.Le Département des Terres et Forêts, Department of Lands and Forests, Service du Cadastre, Cadastral Branch.Le Sous-ministre, AVILA BÉDARD, 41409-o AVILA BFDARD.41409-o Deputy Minister.Département du Travail AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le Comité conjoint de l'industrie «les chapeaux en toile et des casquettes pour homines, garçons et enfants, dans la province de Québec, établi en exécution du décret numéro 1089, du 7 mars 1940, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1207 du 15 décembre 1955, section \"D\", le tout, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 103, et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1950; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 1089 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% des salaires fixes et des pourcentages payés à leurs salariés.b) Les salariés régis par ledit décret numéro 1089 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leurs salaires fixes.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport indiquant les heures de travail, le montant perçu pendant la semaine et les sommes versées au Comité paritaire.Les employeurs professionnels doivent voir à ce que les rapports soient remplis et retournés au Comité paritaire tous les mois.Les employeurs professionnels doivent percevoir, à la fin de chaque semaine, à même les salaires de leurs salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire.Le rapport de l'employeur professionnel doit être signé avant d'être adressé au Comité paritaire.Ledit Comité paritaire a le droit d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le rapport accompagné des cotisations doit être adressé au Comité paritaire le ou avant le mercredi suivant la date d'expiration dudit rapport.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit transmettre un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre «lu Travail, Department of Labour NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette.Minister of Labour, hereby gives notice, that the Joint Committee of the Men's, Boy's and Children's Cloth Hat, Cap and Hcadwcnr Industry for the Province of Quebec, formed under decree number 1089.of March 7.1940, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 1207 of December 15.1955, part \"D\" pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 103 and amendments), to levy assessments upon the professional employers ami the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned : 1.Levy The period of levy shall extend from January 1.1956, to December 31, 1956; the said levy is to be exercised as hercinbelow mentioned; «) The professional employers within the scope of the said decree No.1089, and amendments, shall remit to the Rarity Committee a sum equivalent to one half of one percent (.'^of 1%) of the fixed salaries and percentage paid to their employees.b) The employees within the scope of the said decree No.10S9.and amendments, shall remit to the Parity Committee a sum equivalent to one half of one percent {Yi of 1%) of their fixed salaries.2.Mode of Collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee will place at the disposal of the professional employers return forms indicating the hours of work, the amount of money collected during the week, and the sums fowarded to the Parity Committee.The professional employers shall have these forms completed and forwarded to the Parity Committee every month.The professional employers shall collect, at the end of each week, from the wages of their employees, the sums to be remitted to the Parity Committee.The report of the professional employer must be signed before being adresscd to the Parity Committee.The said Parity Committee has the right to have said report sworn to each time it shall judge it necessary.The report accompanied by the assessments must be addressed to the Parity Committee on or before the Wednesday following the date of expiration of the said report.3.Financial Report To domply with the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall present a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour, on the following dates: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2/,th, 1955, Vol.87, No.51 3971 aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé.un état des recettes et des déboursés prévus du Comité Conjoint de l'Industrie des Chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, pour la période comprise entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1950.Le Comité Conjoint de (.'Industrie des Chapeaux en Toile et des Casquettes pour Hommes, Garçons et Enfants dans la Province de Québec Etat des recettes et des déboursés probables pour la prériode comprise entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1950.Recettes: Cotisations (Yi de 1%): Employeurs professionnels.82.000.00 Salariés.2.000.00 81.000.00 Déboursés: Dépenses de bureau, frais légaux, frais de banque, frais de déplacement.$1,600.00 Dépenses de l'administrateur, dépenses des inspecteurs, salaire du bureau et secrétaire-trésorier.2,400.00 84,000.00 Le Sous-Ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail.Québec, le 24 décembre 1955.41422-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 1(53 et amendements), que le Comité paritaire de l'Industrie de la Sacoche de la province de Québec, établi en exécution du décret numéro 1197 du 25 octobre 1951, a é*té autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil 1240 du 7 décembre 1955, section \"H\", à prélever des cotisations des employeurs professionnels et «les salariés régis par ledit décret suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période «le cotisation s'étend du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1956; cette cotisation s'exerce comme di-«lessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 1197 et amen«lements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalent à Yz de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret, qu'ils soient payés à l'heure, à la semaine, à la pièce ou selon tout autre mode permis par ledit décret.6) Les salariés régis par ledit décret numéro 1197 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yi de 1% de leur rémunération, qu'ils soient payés à la pièce, à l'heure, à la semaine, ou selon tout autre mode permis par ledit décret.2.Mode de perception En vue «le faciliter la perception «le ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition March 31.dune 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an account of the estimated receipts and dibursements of the Joint Committee of the Men's Boys' and Children's Cloth Hat, Cap ami Hcadurar Industry for the Province of Quebec for the period comprised between January 1, 1950 and December 31, 1956.The Joint Committee ok Men's, Boy's and Children's Cloth Hat, Cap and Headwear Industry in the Province of Quebec Estimate of the receipts and «Iisbrusements for the period comprised between January 1, 1956 and December 31, 1956.Receipts: Levy (Y2of 1%): Professional employers.$2,000.00 Employers.2,000.00 84,000.00 Expenses: Office expenditures, legal and travelling expenses, Bank charges.81.000.00 Administrator's retainer, inspectors' expenses, «)ffice salary, secretary-treasurer.2,400.00 84.000.00 G ÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, December 24, 1955.41422-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the Parity Committee of the Handbag Industry of the Province of Quebec, formetl under decree number 1197 of October 25th, 1951, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 1240 of December 7th, 1955 part \"H\", to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree according to the mode and rate hereafter mentioned: 1.Assessments The period of levy extends from January 1st, 1956 to December 31st, 1956; it shall be laid as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 1197 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Y2 of 1% of their payroll as regards the employees governed by the said decree, whether paid on an hourly weekly, piece-work or other basis permitted under the said decree.b) The employees governed by the said decree, number 1197 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ^ of 1% of their remuneration, whether paid on an hourly, weekly, piece-work or other basis permitted under the said decree.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee shall supply 3972 CIZETTE OFFICIELLE DE QUETŒC.Ombre, 2.', décembre 1955.Tome 87, N° 51 des employeurs professionnels dos formules «le rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au bureau du Comité paritaire, dont l'adresse est indiquée sur la formule, à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la lin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire «le ces derniers.L'employeur professionnels doit transmettre son rapport mensuel au Comité para ire le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration du mois précédent pour lequel il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité paritaire a le pouvoir «l'exiger Passermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel de payer ou «le donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'acconl avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état dos recettes et «les déboursés prévus «lu Comité paritaire do l'industrie de la Sacoche do la province «le Québec, pour la pério«le comprise entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1050.Le Comité paritaire de l'Industrie de la Sacoche dê la Province de Québec Siège social: Chambre 1005, 1435 rue St-Alcxandre, Montréal État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er janvier 1950 et le 31 «l«?cembre 1950 inclusivement.Recettes: Cotisations (Y2 de 1%): Employeurs professionnels.$8,000.00 Salariés.8,000.00 Recettes diverses.300.00 810,300.00 Déboursés: Salaires: Inspecteur en chef.$4.000.00 Inspecteur (temps plain, 1).2,500.00 Inspecteur (temps partiel.3).2,500.00 Dépenses de voyage.400.00 Vérificateurs.500.00 Loyer et électricité.1,475.00 Impression et papeterie.300.00 Jetons «le présence des membres au taux de 85.00 par assemblée.620.00 Poste, téléphone et télégrammes.340.00 Assurance.100.00 Frais légaux et secrétariat.3,250.00 the professional employers with report forms upon which they shall give all particulars required by the said Parity Committee.The professional employer shall complete his report, sign ami forward it to Che office of the Parity Committee, as indicated on the said report form, each month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of his employees by means of a deduction from the hitter's wages.The professional employer shall transmit his monthly report to the Parity Committee on or before the 15th of the month following that for which it is requirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to the Parity Committee by his employees.The Parity Committee is empowered to exact that reports be sworn to when deemed advisable.The levy imposed by the present by-law is payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Upon refusal of the professional employer or of an artisan t«> pay the levy or to give the necessary information, five days notice shall bo given to him l«> fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial Report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall transmit, to the Minister of Labour a quarterly report of, its financial operations on the following dates, to wit : March 31st, June 30th.September 30th and December 31st.Hereto annexed is a statement of the receipts and disbursements estimated by the Parity Committee of the Handbag Industry of the Province of Quebec for the pariod between January 1st, 1950, and December 31st, 1956.The Parity committee of the Handbag Industry of the Province of Quebec Room 1095, 1435, St.Alexander Street, Montreal, P.Q.Statement of estimated receipts and disbursements for the period comprised between January 1st, 1956, to December 31st, 1956.inclusive.Receipts: Levy PA of 1%): Professional employers.$8.000.00 Employees.8,000.00 Sundry Receipts.300.00 810,300.00 Disbursements: Salaries: Chief Inspector.$4,000.00 Full time Inspector (1).2,500.00 Part, time Inspectors (3).2,500.00 Travelling expenses.400.00 Auditors.'500.00 Rent.and light.1,475.00 Printing and Stationery.300.00 Members' Indemnify at rate of 85.00 per mooting.620.00 Mail, telephone and telegrams.340.00 Insurance, security, etc.100.00 Legal and secretarial.3,250.00 QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, Quebec, December 2J,th, 1955, Vol.87, No.51 397.3 I >épcnses générales.140.00 Ameublement et accessoires.150.00 $16,275.00 Surplus.25.00 $16,300.00 Ia' Sous-Ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 17 décembre 1955.41422-o AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire de l'Industrie des Gants fins, établi en exécution des décrets numéros 246 et 247 du 20 février 1948, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1207 du 15 décembre 1955, section \"E\", le tout d'accord avec les dispositions de la Loi «le la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 103 et amendements), à prélever «les cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit «lécret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: General expenses.140.00 Furniture and fixtures.150.00 $16,275.00 Surplus.25.00 $10,300.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, December 17th, 1955.41422-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Fine Glove Industry, formed under «lecree numbers 246 and 247 of February 26th, 19-18, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 1267 of December 15th, 1955, part \"E\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans, and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Cotisation La pério«le «le cotisation s'étend «lu 1er janvier 1956 au 31 décembre 1956; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par lesdits «lécrcts numéros 240 et 247 et amendements doivent verser au Comité paritaire de l'Industrie «les Gants fins une somme équivalente à \\'i «le \\c/c de leur liste «le paye pour les salariés assujettis auxdits décrets.b) Les artisans régis par lesdits décrets numéros 246 et 247 et amendements doivent verser au Comité paritaire de l'Industrie des Gants fins une somme équivalente à Yi ('c 1% du salaire établi dans les décrets pour le compagnon le moins rémunéré, soit 825.00 par semaine.«\u2022) Les salariés régis |>ar lesdits décrets numéros 240 et 247 et amendements doivent verser au Comité paritaire «le l'Industrie des Gants fins une somme é«piivalentc à Yi «le 1% de leur rémunération.1.Assessments The period of levy extends from January 1st, 1956, to December 31st, 1956; such levy is laid as follows: «/) The professional employers governe«l by the said decrees, numbers 246 an«l 247 and amendments, shall pay to the Joint Committee of the Fine Glove Industry an amount equivalent to Yi of 1% of their payroll as regar«ls the employees governetl by the said decrees.b) The artisans governed by the said dcerees, numbers 246 an«l 247 and amendments, shall pay to the Joint Committee of the Fine Glove Industry an amount equivalent to Yi of 1% of the lowest wages established in the said decrees for journeymen, namely: $25.00 per week.c) The employers governed by the said decrees, numbers 246 and 247 and amendments, shall pay to the Joint Committee of the Fine Glove Industry an amount equivalent to Yi of 1% of their remuneration.2.Mode de perception En vue «le faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire de l'Industrie des Gants Fins met à la disposition «les employeurs professionnels «les formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel «loit percevoir à la fin de chaepic semaine, au nom du Comité paritaire de l'Industrie des Gants Fins, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen «l'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire de l'Industrie des Gants Fins le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Ledit Comité pari- 2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Joint Committee of the Fine Glove Industry supplies the professional employers with report forms on which all particulars required by the said Parity Committee shall be given.The professional employer shall complete and sign his report, and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Joint Committee of the Fine Glove Industry the assessments imposed on his employees by means of a deduction from the latter's wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Joint Committee of the Fine Glove Industry on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the period for which it is requirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to the Joint Committee of the Fine Glove In. 3974 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 21, décembre 1955, Tome 87, N° 51 taire a le pouvoir d'exiger l'assormentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le 'salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la Convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du.Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé.un état des recettes et des déboursés prévus par le Comité paritaire de l'Industrie des Gants Kins pour la période comprise entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1956.Comité paritaire de l'Industrie des Gants Fins État des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 1er janvier 1050 et le 31 décembre 1950.Recettes: Cotisations ('{, de 1%): Employeurs professionnels.S 5.000.00 Salariés et artisans.5.000.00 Déficit prévu à combler par surplue au 31 décembre 1955.1,050.00 SI 1.050.00 Déboursés: Frais d'administration.S 050.00 Salaires des inspecteurs.3,900.00 Frais de déplacement: Membres du Comité.720.00 Inspecteurs.T 1.093.00 Loyer de bureau.900.00 Frais légaux et professionnels.500.00 Papeterie et impressions.1,200.00 Poste, téléphone, télégrammes.482.00 Assurance cautionnement.5.00 Jetons de présence.600.00 Bureau des examinateurs.50.00 Taxe d'eau.62.00 Assurance chômage.31.00 Publicité, dons et souscriptions.7.00 Relations industrielles.70.00 Divers.180.00 811.050.00 Le Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail.Québec, le 24 décembre 1955.41422-0^ AVIS DE PRÉLÈVEMENT , L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail donne avis par les présentes, «pie le Comité paritaire des Plombiers des Trois-Bivières et district, établi en exécution du décret numéro 338, du 11 mars 1948, a été autorisé par règlement approuve par l'arrêté en conseil numéro 1267 du 15 décembre 1955, section \"F\", le tout dustry by his employees.The committee has the power to exact sworn reports when deemed advisable.The assessments imposed by the present bylaw are payable every month by the professional employer, the artisans and the employee, without not ice.Should a professional employer or an artisan refuse to pay or to give the necessary information, five days notice shall be given to them to fulfill their obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly financial report to the Minister of Labour on the following dates: March 31st, June 30th.September 30th and December 31st.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of the Fine Glove Industry, for the period between January 1st.1956 and December 31st, 1950.The Joint Committee of the Fink Glove Industry Estimate of the receipts and disbursements for the period between January 1st, 1956 and December 31st, 1950.Receipts: Assessments OA of 1%): Professionals employers.$5,000.00 Employees and artisans.5,000.00 Probable Deficit to be covcre«I by the surplus on March 31st.1955.1,050.00 811.050.00 Disbursements: Administration.$ 650.00 Insped ors' salary.3,900.00 Travelling expenses: Committee-members.720.00 Inspectors.1,093.00 Office rent.900.00 Legal ami professional fees.500.00 Stationery and printing.1.200.00 Postage, telephone, telegrams.482.00 Fidelity bond.5.00 Meet ing expenses.600.00 Board of Examinators.50.00 Water tax.62.00 Unemployment insurance.31.00 Publicity, donations and subscriptions.7.00 Indust rial relations.70.00 Miscellaneous.180.00 $11,050.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour.Quebec, December 24th, 1955.41422-o NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notices that the Joint Committee of Plumbers of the district of Trois-Rivières.formed under decree No.338 of March 11, 1948, has been authorized by a by-law approved by Order in Council No.1267 of December 15, 1955, part \"F\" in conformity with the QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, December 24th, 1955, Vol.87, No.51 3975 d'accord avec les dispositions de la Loi de la COn- provisions of the Collective Agreement Act, to vention collective à prélever des cotisations des levy assessments from the professional employers, employeurs professionnels, des artisans des sala- the artisans ami the employees governed hy the ries assujettis audit décret, suivant la méthode et said decree, according to the method and rate le taux ci-après mentionnés.hereinafter mentioned./.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1956; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 338 et amendements doivent verser au Comité paritaire une si mine équivalente à 3-2 '1° '% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 338 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 1 ¦> de \\% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit 81.20 l'heure.c) Les salariés assujettis audit décret numéro 33S et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ccs cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit c< mplé-ter son rapport.le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la On dé chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 12 du mois suivant la date d'expiration «le la période pour laquelle il est exigible: ledit rapport doit être accompagné «le la cotisation de l'employeur professionnel et «les sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir «l'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus «l'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis «le einq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars.30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et «les déboursés prévus du Comité paritaire des Plombiers des Trois-Rivières et district, pour la période comprise entre le 1er janvier 1050 et le 31 décembre 1956.Le comité paritaire des Plommers des TltOIS-RlVlÈRES ET DISTRICT 1.Assessments The period of levy extends from January I, 1956, to December 31, 1956; it shall be laid in' the following manner: «/) The professional employers governed by the said decree, number 338 ami amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 1 \u2022_> of \\c/, «>f their pay-roll for their employees governed by the decree.b) The artisans governed by the said décret-, number 338 ami amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yi °f \\'f «)f the lowest wage rate set in the «lecree for journeymen, i.e.81.20 per hour.c) The employees governed by the said decree, number 338 and amendments, shall pay to the Parity Commit tee a sum equivalent to Yi of I',' of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which shall be given all particulars required by the said Parity Committee.The professional employer shall complete anil sign his report and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name «)f the Committee, the assessments of his employees by means of a deduction from the hitter's wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 12th day of the month following the date of «-xpiration of the period for which it is requirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to thé Parity Committee by his employees.The Committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The levy enacted by the present by-law is payable every month by.the professional employer, the artisan ami the employee, without notice.Upon refusal by a professional employer or an artisan to pay or to give the necessary information, a five days notice will be given to him to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant \u2022> the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a «piarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following fixed dates: March 31, June 30, September 30 ami De2 of 1%): Professional employers.S 4.900.00 Artisans.300.00 Employees.4,900.00 810,100.00 Disbursements: Meeting expenses, travelling expenses ami other expenses of Commit- tee members.8 2,980.00 Inspection : Salary.3,824.00 Expenses.2.000.00 Office rent and telephone.300.00 Legal fees.400.00 Audition.00.00 Stationery.100.00 Furniture and miscellaneous.430.00 810,100.00 GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, December 24.1955.41422-0 Ministère des Finances Assurances Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné, par les présentes que \"Alpina Insurance Company Ltd.\", enregistrée sous le numéro 5G5, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 2417 qui l'autorise, à compter du 8 novembre 1955, à effectuer dans la Province des contrats d'assurance relatifs aux genres suivants: Incendie et accessoirement \u2014 agitation civile, choc de véhicules, chute «l'aéronef, défectuosité d'extincteurs automatiques, explosion limitée ou inhérente, fuite «l'eau, grêle, ouragan, tremblement de terre; Accident; Automobile; Biens immobiliers; Biens mobiliers; Bris de glace; Transport intérieur.Le siège social de la compagnie est situé à Zurich, Suisse.La compagnie a nommé monsieur William Oswald Sharp, 507 Place d'Armes, Montréal 1, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des finances, le 14 décembre 1955.Pour le Ministre des finances de la Province, GEORGES LAFRANCE, 41390-50-2-o Surintendant des assurances.Department of Finance Insurances Notice of Issie of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"Alpina Insurance Company Ltd.\", registered under number 505, has obtained the license and certificate of registry number 2417 authorizing it, as from the 8th of November 1955, to undertake in the Province contracts of insurance of the following classes: Fire, and supplementary thereto \u2014 civil commotion, earthquake, falling aircraft, hail, impact by vehicles, limited or inherent explosion sprinkler leakage, water damage, windstorm; Accident; Automobile; Inland transportation; Personal property; Plate glass; Real property.The head office of the company is situate at Zurich, Switzerland.The company has appointed Mr.William Oswald Sharp, 507 Place «l'Armes, Montreal 1, its attorney in the Province.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14 th of December 1955.For the Minister of Finance of the Province, GEORGES LAFRANCE, 41390-50-2-o Superintendent of Insurance.Nomination PRÉSIDENT D'ÉLECTION Il a plû «à son Honneur, le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, par commission Sous le Grand Sceau, de faire, pour remplir la charge de président d'élection, la nomination suivante: Appointment RETURNING-OFFICER His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the executive Council to appoint by commission under the Great Seal, to fill the office of returning-officer, the person whose name follows: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2J,th, 1955, Vol.87, No.51 3977 District électoral\tNom, prénoms\tProfession ou occupation\tDocimile Electoral district\tName, christian names\tProfession or calling\tDomicile \tLaperrièrc Ludovic (1).\tAvocat \u2014 Advocate .\tTrois-Rivières \t\t\t (1) En remplacement de monsieur Arthur Bélivcnu démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Arthur Béliveau résigner.Quebec, le 19 décembre 1955.Quebec, December 19tli, 1955.Le President general des élections.FRANÇOIS DROUIN, Q.C., 41423-0 FRANÇOIS DROUIN, C.R.41423-o Chief Returning Officer.Proclamations Proclamations Canada.Province de Québec.[L.S.] CASPAR!) FAUTEUX Canada, Province of Quebec.[L.S.] GASPARD FAUTEUX ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of Commonwealth, Defender of the Faith.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou To all to whom these present letters shall qu'icelles pourront concerner, come or whom the same may concern, Salut: Greeting: PRC X'LAM ATION PROCLA !\\ IATION L'Assistant-procureur ( a T T E N I) U qu'une gênerai, ) demande Nous a C.E.Cantin.j été faite à l'effet de déta-'cher le territoire ci-après décrit de la municipalité du canton de Marchand, dans le comté municipal de Labellc.et de l'annexer à la municipalité du village de l'Annonciation, dans le même comté municipal; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à celle demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazelle officii Ile de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 15 décembre 1955, portant le numéro 1279.et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons par les présentes; que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de Marchand étant tout le lot 52/;.rang Sud-Ouest-Rivière-Rouge du cadastre officiel du canton de Marchand, borné au sud-est.par le lot 52n et au nord-ouest, par le lot 53 du même rang, au sud-ouest, par le rang III et au nord-est, par le lot 24S du cadastre officiel du village de L'Annonciation; lequel territoire, sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité du canton de Marchand, dans le comté municipal de Labelle, et sera annexé à la municipalité du village de L'Annonciation, dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.C.E.Cantin, (TWIIEREAS We have been Deputy Attorney) requested to detach the General \\ territory hereinafter described 'from the Municipality of the township of Marchand, in the Municipal County of Labelle, in order that it be annexed to the Municipality of the village of L'Annonciation, in the same Municipal county: whereas all formalities prescribed by law in this respect have been fulfilled; Whereas it is expedient that this request be granted: Whereas under section 42 of the Municipal Code, the present Proclamation shall enter into force on the first day of January following the dale of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 15, 1955, bearing number 1279, and in accordance with the provision of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by the presents; That the following territory, to wit: A territory situated in the township of Marchand being the whole of lot 526, range sud-ouest-Rivière-Rouge, of the official cadastre of the township of Marchand, bounded to the southeast by lot 52« and northwesterly, by lot 53, same range, southwesterly, by range III and northeasterly, by lot 248 of the official cadastre of the village of L'Annonciation; which territory shall be, as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the Municipality of the township of Marchand, in the Municipality county of Labelle.and annexed to the Municipality of the village municipality of L'Annonciation, in the same municipal county.That this proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette. 397S GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, S/, décembre 1955, Tome 87, N° 61 ])b tout ce Ql'e dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur ieelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Ti'.moix: Notre très fidèle et bien-ainié l'honorable GASPARD FAUTEUX, ('.P.LL.D., D.D.S.L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce dix-neuvième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-cinq de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatrième année.Par ordre.Le Sous-secrétaire de la Province, 41408-o JEAN BRUCHÉSI.Canada.Province .le GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( ATT E N I) U qu'une général, ) **¦ demande Nous a C.È.Cantin.\\ été faite d'ériger en mu-' nicipalité, sous le nom de \"municipalité de la paroisse de La-Rédemption\", le territoire ci-après décrit, situé dans le comté municipal de Matapédia; attendu que ce territoire n'est pas actuellement organisé en municipalité; Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 15 décembre 1955, portant le numéro 1279, et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons, par les présentes.Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire non organisé situé partie dans le canton de Massé et partie dans le canton d'Awant-jish comprenant, en référence au cadastre officiel desdits cantons, tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rivières, lacs, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne separative des cantons d'Awantjish et de Massé avec la ligne separative des rangs XI et XII du canton de Massé; de là, successivement, les lignes suivantes; ladite ligne separative des rangs XI et XII du canton de Massé; une ligne brisée séparant le canton de Massé de la seigneurie de Lac Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent, and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed ;> Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S.L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this nineteenth day of December, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-five and the fourth year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 41408 Under Secretary of the Province.( 'anada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.|L.S.J ELIZABETH THF SECOND, by the Grace or God of the United Kingdom.Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these present letters shall come or whom the same may concern.Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, (YW'HEREAS We have been Deputy Attorney) * * requested to erect into General.\\ a municipality under the name ' of \"Municipality of the parish of La-Rédemption\", the territory hereinafter described, situated in the Municipal county of Matapédia ; whereas the said territory is not as yet organized as a municipality; whereas all formalities prescribed by-law in this respect have been fulfilled; Whereas it is expedient that this request be granted; Whereas under section 42 of the Municipal Code, the present Proclamation shall enter into force on the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 15th, 1955.bearing number 1279, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by the presents; That the following territory, to wit: An unorganized territory situated partly in the township of Massé and partly in the township of Awantjish comprising, with reference to the official cadastre of said townships, all lots and their present and future subdivisions, as well as roads, rivers, lakes, streams or parts thereof, included within the following boundaries, to wit: commencing at the point of intersection of the dividing line of the townships of Awantjish and Massé with the dividing line of ranges XI and XII of the township of Massé; thence, successively, the following lines: the said dividing line of ranges XI and XII of the township of Massé; a broken line separating the township of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2J,th, 1955, Vol.87, No.51 3979 Métis; la ligne nord-est «lu lot 33 de chacun des rangs IX.VIII, VII et VI; la ligne separative dés rangs Y et VI du canton de Masse; la ligne separative des cantons d'Awantjisli et de Massé jusqu'à la ligne separative des cantons d'Awantjish et de Cahot; cette dernière ligne jusqu'à la ligne separative des lots 12 et 13 du rang I du canton d'Awantjish; dans le canton d'Awantjish, la ligne separative des lots 12 et 13 de chacun des rangs I et II; la ligne separative des rangs II et III en allant vers le nord-est; la ligne separative des lots 22 «-t 23 de chacun des rangs III.IV et Y; la ligne separative des rangs Y et VI jusqu'à la ligue separative des cantons d'Awantjish et de Massé et enfin ladite ligne separative «lesdits cantons en allant vers le sud-est jusqu'au point de départ ; lequel territoire ne provenant d'aucune municipalité locale sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, érigé «'u municipalité, sous le nom de \"municipalité de la paroisse de La-Rédemption\", dans le comté municipal de Matapédia; Que la présente proclamai ion entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De TOUT ce QUE DESSUS, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance «\u2022t de se conduire en conséquence.En foi de QUOI, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icellcs apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle «-t bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S.L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce dix-neuvième jour «le décembre en l'année mil neuf cent cinquante-cinq île l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatrième année.Par or«lre, Le Sous-secrétaire de la Province.41408-o JEftN BRUCHÉSI.Canada.Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, défendeur de la foi.A tous ceux «pli ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.^ Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur { A TTENDU qu'unede-gênêral, ) **¦ mande Nous a été C.E.Cantin.\\ faite à l'effet de détacher \\ le territoire ci-après «lé-crit de la municipalité «lu Lac du Cerf, dans le comté municipal de Labelle, et de l'annexer à la municipalité du canton de Kiamika.dans le même comté municipal; attendu que les formalités prescrites par la loi à cet é-gard ont été observées; ATTENDU Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Massé from the Seigniory of Lake Métis; the northeast line of lot 33 of each one of ranges IX.VIII, Y1I and VI; the dividing line of ranges Y and YI of the township of Masse; the dividing line of the townships of Awantjish and Massé as far as the dividing line of the townships of Awantjish and Cabot; this latter line as far as tin- dividing line of lots 12 and 13.range I of the township of Awantjish; in the township of Awantjish.the dividing line of lots 12 and 13 of each one of ranges I ami II; the dividing line of ranges II and III northeastwards; the dividing 22 and 23 of each one of ranges III, IY and Y; the dividing line of ranges Y and VI as far as the dividing line of the townships of Massé and Awantjish and finally the said dividing line of said townships in a southeasterly direction to the point of commençassent, which territory not taken from any local municipality whatsoever shall be.as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, erected into a municipality under the name of \"Municipality of La-Rédemption\", in the Municipal county of Matapédia.That this proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Cazitte.Of all which Our loving subjects, and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice ami to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent, and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX.P.C.LL.D., D.D.S.L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this nineteenth day of December, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred, and fifty-five and the fourth year of Our Reign.By Command.JEAN BRUCHÉSI, \u2022lllOS-o Under Secretary of the Province.( anada.Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.| ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom.Canada and Her other Realms ami Territories.Queen Head of Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these present letters shall come or whom the same may concern.Greeting: PROCLAMATION C.E.Cantin, ITWHEREAS We have been Deputy Attorney ) vv requested to detach the General.1 territory hereinafter described 'from the Municipality of Lac du Cerf, in the Municipal county of Labelle.in order that it be annexed to the Municipality of the township of Kiamika, in the same Municipal county; Whereas all formalities prescribed by law in this respect have been fulfilled; whereas it is expedient that this request be granted; 3980 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2/, décembre 1955, Tome 87, N° 51 Attendu qu'en vertu de l'artiele -12 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 15 décembre 1955.portant le numéro 1279.et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons par les présentes; Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire situé dans le canton de Dudley, comprenant, en référence au cadastre officiel pour ledit canton, les lots ou parties de lot et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi (pie les chemins, rivières, lacs, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du sommer de l'angle nord-est du canton de Dudley; de là, successivement, la ligne extérieure est du canton de Dudley; la ligne extérieure sud dudit canton sur la profondeur des rangs XIII, XII et XI; la ligne separative des rangs X et XI du même canton, prolongée jusqu'à l'axe de la rivière du Lièvre; ledit axe de la rivière du Lièvre en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la ligne separative des cantons de Dudley et de Kiamika et enfin ce dernier prolongement et cette dernière ligne jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité du Lac au Cerf, dans le comté municipal de Labelle, et sera annexé à la municipalité du canton de Kiamika, dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icellcs apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèles et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP.LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce dix-neuvième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-cinq de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatrième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la province, 41408-o JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Coulis monwealth, défenseur de la foi.\u2022 ' A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: Whereas under section 42 of the Municipal Code, the present Proclamation shall enter into force on the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.THEREFORE, with the consent and advice of Our Executive Council expressed in a decree dated December 15th, 1955, bearing number 1279, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by the presents; That the following territory, to wit: A territory situated in the township of Dudley, comprising, with reference to the official cadastre for the said township, lots or parts thereof and their subdivisions both present and future, as well as roads, rivers, lakes, streams or parts thereof, included within the following boundaries, to wit: commencing at thevertex of the northeast angle of the township of Dudley; thence, successively, the easterly outer line of the township of Dudley; the southerly outer line of said township along the depth of ranges XIII, XII and XI; the dividing line of ranges X and XI of the same township, extended as far as the axis of River du Lièvre; the said axis of River du Lièvre northeastwards as far as the prolongation of the dividing line of the township of Dudley and Kiamika and finally the latter prolongation and said line to the point of commencement; which territory shall be, as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the Municipality of Lac du Cerf in the Municipal County of Labelle, and annexed to the Municipality of the Township of Kiamika in the same municipal county.That this proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We baye caused these Out Letters to be made Patent, and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed: Witness: Our Right Trustv and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this nineteenth day of December, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-five and the fourth year of Our Reign.By Command, JEAN BRUCHÉSI, 41408-o Under Scerctaryof the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these presents shall come or whom the same may in anywise concern, Greeting: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2/>th, 1955, Vol.87, No.51 3981 PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une de-gênéral, ) mande Nous a été C.E.Cantin.j faite à l'effet de détacher (,1c territoire ci-après décrit de la municipalité de la paroisse de Saint-Cyprien-de-Léry, dans le comté municipal de Napierville, et de l'annexer à la municipalité du village de Napierville, dans le même comté municipal: Attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec, A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 15 décembre 1955, portant le numéro 1279.et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons par les présentes; Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire faisant actuellement partie de la municipalité de la paroisse de Saint-Cyprien-de-l.érv comprenant, en référence au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Cyprien, les parties des lots originaires 93 et 94 et leurs subdivisions présentes et fuiures, ainsi que les chemins, rues, ruelles, ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: parlant du point d'intersection du prolongement de la ligne sud du lot originaire 93 avec le côté nord-ouest d'un chemin public étant la continuation de la rue Saint-Luc; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: le dit côté nord-ouest dudit chemin publie en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots originaires 91 et 95; le dit prolongement et la dite ligne separative des lots originaires 94 et 95 en allant vers l'est jusqu'à la rive ouest d'un cours d'eau; la dite rive ouest du dit cours d'eau en allant vers le sud-est et le sud et limitant vers l'est les lots de subdivision 94-02, 94-63 (rue), 94-64, 94-85, 93-55, 93-44 (rue), 93-33 et 93-32; et enfin la ligne sud du lot originaire 93 en allant vers l'ouest et son prolongement à travers le chemin public jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité de la paroisse de Saint-Cyprien-de-Léry, dans le comté municipal de Napierville, et sera annexé à la municipalité du village de Napierville, dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Ex foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; TÉMOIN: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre PROCLAMATION C.E.Cantin-, / Vl/HEREAS a petition has Deputy Attorney) W heen submitted to Us General \\ requesting that the territory \\ hereinafter described be detached from the municipality of the parish of Saint-Cyprien-de-Léry, in the municipal county of Napierville and to annex it to the municipality of the village of Napierville, the same municipal county; Whereas all formalities prescribed by law in this respect have been fulfilled; Whereas it is expedient that this request be granted; Whereas under section 42 of the Municipal Code, the present Proclamation shall enter into force on the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 15, 1955, bearing number 1279, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by these presents, That the following territory, to wit: A territory presently forming part of the Municipality of the parish of Saint Cyprien-de-Léry comprising, with reference to the official cadastre of the parish of Saint Cyprien, parts of original lots 93 and 94 and their present and future subdivisions, as well as roads, streets, lanes, or parts thereof included within the following boundaries, to wit: commencing at a point of intersection of the prolongation of the south line of original lot 93 with the northwest side of the public highway being the continuation of Saint Luc street, thence, successively, the following lines and demarcations: the said northwesterly side of said public highway in a northeasterly direction as far as the prolongation of the dividing line of original lots 94 and 95; the said prolongation and the said dividing line of original lots 94 and 95 in an easterly direction as far as the west bank of a stream; the said westerly bank of said stream in a southeasterly and southerly direction bounding to the east, subdivision lots 94-62, 94-63 (street) 94-64, 94-85, 93-55, 93-44 (street), 93-33 and 93-32; and finally the south line of original lot 93 in a westerly direction and its prolongation across the public highway as far as the point of commencement; which territory shall be, as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the municipality of the parish of Saint Cyprien-dc-Léry, in the municipal county of Napierville, and annexed to the municipality of the village of Napierville, in the same municipal county.That this Proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made patent, and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of 3982 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC.Québec, 2J, décembre 1955, Tome 87, N° 51 cité de Québec\", de Notre province «le Quebec\", ce dix-neuvième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-cinq de l'ère chrétienne et de Noire Règne la quatrième année.Par on Ire, Le Sous-secrétaire de la province, 41408-o JEAN BRUCHÉSI.Canada.Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux (pu ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur é A T T K N 1) U qu'une général, ) demande Nous a C.U.Cantin.) été faite à l'effet de ' détacher le territoire ci-après décrit de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-des-Laurentides, dans le comté municipal de Terrebonne, «'t de l'ériger en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Saint-Antoine-des-Laiirenlides\", dans le même comté municipal; attendu que les formalités prescrites par la loi à cet égard ont été observées; attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 du Code municipal, la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret en date du 15 décembre 1055, portant le numéro 1279.et conformément aux dispositions du Code municipal de Notre province de Québec, Nous déclarons et décrétons par les présentes; Que le territoire suivant, à savoir: Un territoire faisant actuellement partie de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-dcs-Laiirentides.comprenant, en référence au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jérôme, tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi (pie les chemins, rues, ruelles, emprise de chemin de fer, rivières, cours d'eau ou partie d'iceux renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant du sommet de l'angle sud du lot 112; de.là, passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: la ligue sud-ouest du lot 112; la rive gauche ou rive est de la rivière du Nord jusqu'aux limites de la cité de Saint-Jérôme; puis suivant lesdites limites de la cité de Saint-Jérênne en passant par la ligne ouest des lots 113.194, 195, 196, 197, 199.209.201.202 et 203; la ligne nord du lot 203 prolongée jusqu'à l'axe du ruisseau des Prairies; ledit axe du ruisseau des Prairies jusqu'à la ligue sud-ouest du lot 1S2; ladite ligne sud-ouest du lot 182 en allant vers le nord-ouest; la ligne nord-ouest du même lot; la ligne sud-ouest du lot 181 en allant vers le nord-ouest; une ligne brisée limitant au nord et à l'ouest les lots 181 et 180; la ligne sud-ouest du lot 179 en allant vers le nord-ouest; la ligne nord-ouest et la ligne nord-est du lot 179 jusqu'au coin ouest Quebec, in Our Province of Quebec, this nineteenth day of December, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-five and the fourth year of Our Reign.\\>\\ command.JEAN BRUCHÉSI, 41408 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD PAUTEUX Quebec.|L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of (iod of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories.Queen, Head of Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these present letters shall come or whom the same may concern.Greeting : PROCLAMATION C.E.Cantin.< VWI1EREAS We have been Deputy Attorney) W requested to detach the General.\\ territory hereinafter described (from the Municipality of the parish of Saint-Antoine-des-Laurentides, in the Municipal county of Terrebonne, in order that it be erected into a separate municipality under, the name of \"Village Municipality of Saint-Antoine-des-Laurentides\", in the same Municipal county; Whereas all formalities prescribed by law in this respect have been fulfilled; Whereas it is expedient that this request be granted; Whereas under section 42 of the Municipal Code, the present Proclamation shall enter into force on the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree dated December 15, 1955, bearing number 1279, and in accordance with the provisions of the Municipal Code of Our Province of Quebec, We hereby declare and enact, by the presents: That the following territory, to wit: A territory presently forming part of the parish municipality of Saint Antoine-des-Laurèntides, comprising, with reference to the official cadastre of the parish of Saint Jérôme, all lots and their present and future subdivisions, as well as roads, streets, lanes, railroad rights-of-way, rivers, streams or parts thereof, included wihin the following boundaries: to wit: commencing at the vertex of the south angle of lot 112; thence, passing successively along the following lines and demarcations: the southwest line of lot 112; the left bank or cast bank of River du Nord as far as the limits of the city of Saint-Jérôme; then following the said city limits of Saint Jérôme passing along the westerly line of lots 113.194, 195.196.197.199.200, 201.202 and 203; the north line of lot 203 extended as far as the axis of the des Prairies Brook; the said axis of the des Prairies Brook as far as the southwest line of lot 182; the said southwest line of lot 1S2 in a northwesterly direction; northwest line of the same lot; the southwest line of lot 181 in a northwesterly direction; a broken line bounding to the north and west, lots lsi and 180; the southwest line of lot 179 in a northwesterly direction, the northwest and northeast lines of lot 179 as far as the westerly corner of lot 177; an irregular line QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 24th, 1955, Vol.87, No.51 3983 du lot 177; une ligne irrégulière limitant vers le nord-ouest le lot 177 jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 204; puis laissant les limites de la cité de Saint-Jérôme, une ligne irrégulière séparant le lot 177 du lot 204; la ligne nord-ouest du lot 172; la ligne nord-est des lots 172 et 173; la dernière prolongée jusqu'au côté sud-est du chemin du Cordon de Saint-Antoine; le dit côté sud-est dudit chemin en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne nord-est du lot 189; cette dernière ligne; la ligne nord du chemin de la Côte Saint-Antoine en allant vers l'ouest jusqu'à l'axe de la rivière Saint-Antoine; ledit axe de la rivière Saint-Antoine jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 135; ledit prolongement et ladite ligne nord-est du lot 135; la ligne sud-est des lots 135, 127, 120, 121, 120, 119, 118, 117 et 110; une ligne brisée séparant le lot 115 des lots 89 et 90 et enfin la ligne sud-est des lots 114, 113 et 112 jusqu'au point de départ; lequel territoire sera, à compter du premier janvier suivant la date de la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle de Québec, détaché de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoinc-des-Laurentidcs, dans le comté municipal de Terrebonne, et sera érigé en municipalité distincte, sous le nom de \"municipalité du village de Saint-Antoine-dcs-Laurcntides\", dans le même comté municipal.Que la présente proclamation entrera en vigueur le premier janvier suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icellcs apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, CP., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce dix-neuvième jour de décembre en l'année mil neuf cent cinquante-cinq de l'ère chrétienne et de Notre Règne la quatrième année.Par ordre, Le Sous-secrétaire de la Province, 41408-o JEAN BRUCHÉSI.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut: PROCLAMATION L'Assistant-procureur ( A TTENDU qu'une de-gènêral, ) -O- mantle Nous a été C.E.Cantin.) faite à l'effet de détacher v le territoire ci-après décrit de la municipalité de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, dans le comté municipal de Berthier, et de l'annexer à la municipalité du bounding to the northwest lot 177 as far as the southwest line of lot 204; thence leaving the city limits of Saint Jerome, an irregular line dividing lot 177 from lot 204; the northwest line of lot 172; the northeast line of lots 172 and 173; the latter extended as far as the southeast side of the Cordon Road of Saint Antoine; the said southeast side of said road southwesterly as far as the northeast line of lot 189; the latter line; the line north of the Côte Saint Antoine Road in a westerly direction as far as the axis of the Saint Antoine River; the said axis of the Saint Antoine River as far as the prolongation of the said northeast line of lot 135; the southeasterly line of lots 135, 127, 120, 121, 120.119, 118, 117, and 116; a broken line dividing lot 115 from lots 89 and 90 and finally the southeast line of lots 114, 113 ami 112, as far as the point of commencement; which territoty shall be, as from the first day of January following the date of publication of this Proclamation in the Quebec Official Gazette, detached from the Municipality of the parish of Saint Antoine-des-Laurentides, in the Municipal county of Terrebonne, and erected'into a separate municipality, under the name of \"Village Municipality of Saint-Antoine-des-Laurcntides\", in the same municipal county.That this proclamation shall come into force the first day of January following the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent, and the Great Seal of the Province of Quebec, to be hereunto affixed ; Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.Given at Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this nineteenth day of December, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and fifty-five and the fourth year of Our Reign.By command, JEAN BRUCHÉSI, 41408 Under Secretary of the Province.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these present letters shall come or whom the same may concern, Greeting : PROCLAMATION C.E.Cantin, / V\\7HEREAS We have been Deputy Attorney 1 requested to detach the General.J territory hereinafter described 'from the Municipality of the Parish of Saint-Gabriel-de-Brandon, in the Municipal County of Berthier, in order that it be annexed to the Village Municipality of Saint- 3984 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Quebec, 2Jt décembre 1955, Tome 87, N° 51 village % par année payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d'emprunt en date du 20septembre 1955.telle que modifiée \u2014 Agrandissement et restauration de l'école des garçons.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul d'intérêt sera fait à compter du 1er février 1950.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $135,GC0.00 \u2014 20 ans.Année Capital 1er décembre\t1950 .\t.x 831,000\t00 1er décembre\t1957 .\t.x 32.500\t00 1er décembre\t1958 .\t.x 34,000\t00 1er décembre\t\t\t00 1er décembre\t1900\t1.500\t00 1er décembre\t1961\t1,500\t00 1er décembre\t1902\t1,500\t00 1er décembre\t1963\t2.000\t00 1er décembre\t1964\t2.0(H)\t00 1er décembre\t1965\t2.000\t00 1er décembre\t1906\t2.000\t00 1er décembre\t1907\t2,000\t00 1er décembre\t1968\t2.500\t00 1er décembre\t1909\t2.500\t(II) 1er décembre\t1970 .\t2.500\t00 1er décembre\t1971\t2,500\t00 1er décembre\t1972\t2,500\t00 1er décembre\t1973\t3,000\t00 1er décembre\t1974\t3.000\t00 1er décembre\t1975 .\t3,000\t00 Les \"x\" indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de 8103.320.accordé par le Secrétaire de la province, et payable en trois versements de 834.440 chacun, de 1956 à 1958 inclusivement, seront recuis et appliqués au service de cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obliga- ry is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Monday January 9.1950.al S o'clock p.m., at 30 Pilion Street.St-Sauvcur-dcs-Monts, county of Terrebonne.The council is not bound to accept the highest or any of t he tenders.St-Sauvour-des-MontS (County of Terrebonne), this December 21, 1955.J.-O.-J.LAPOINTE, Secretary-Treasurer.B.O.Box 50, St-Sauveur-des-Monts, (County of Terrebonne), P.Q.41436 Province of Quebec The School Commissioners for the Municipality of the Village of Saint Coeur-de-M àrie (County of Lake St.John) Public notice is hereby given that sealed lenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will he received by the undersigned Jean-Paul Tremblay, Secretary-treasurer.St.Cœur-de-Marie, county of Lake St.John, until S o'clock p.m.Monday, January 9, 1956, for the purchase of an issue of 8135.000 of bonds of the School Commissioners for the Municipality of the Village of Saint Cœur-de-Marie county of Lake St.John, dated December 1.1955, and redeemable serially from December 1.1956 to December 1.1975.inclusively, with interest at a rate of not less than 3% or more than 4 >\u2022//(' Pt>r annum, payable semi-annually on June 1, and December 1, of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan Resolution dated September 20, 1955, as modified \u2014 Extension to and restoration of school for boys.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from February 1, 1956.The table of redemption is as follows: Table of dercmption \u2014 S135.000.00 \u2014 20 years.Year Capital December\t1.1956____\t.x 831.000\t00 December\t1.1957.\t.x 32.500\t00 December\t1, 195S.\t.x 34,000\t00 December\t\t\t00 December\t1.1960.\t1,500\t00 December\t1, 1961\t1,500\t00 December\t1.1902.\t1.500\t00 December\t1.1963____\t2.000\t00 December\t1, 1964____\t2,000\t00 December\t1.1905____\t2,000\t00 December\t1, 1900\t2.000\t00 December\t1.1907.\t2.000\t00 December 1.1968____\t\t.\u2022 2.500\t00 December 1, 1969____\t\t2,500\t00 December 1.1970____\t\t2,500\t00 December\t1.1971\t2.500\t00 December 1.1972\t\t2,500\t00 December\t1.1973.\t3.000\t00 December 1, 1974____\t\t3.000\t00 December\t1.1975.\t3.000\t00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of 8103.320 granted by the Provincial Secretary and payable in three instalments of 834,440 each, from 1950 to 195S inclusively, shall be received and applied to the service of the said loan.The successful tenderer agrees to pay for ft QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2J,th, 1955, Vol.87, No.61 3989 lions, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Aima, comté de bac St-Jean.be capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt à Montréal, à Québec ou à Aima, comté de Lac St-Jean.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 9 janvier 1950.à S heures p.m., dans la salle «lu couvent.St-Cœur-de-Marie, comté de Lac St-Jean.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Cœur-de-Marie, (Comté de Lac St-Jean).ce 21 décembre 1955.Le Secrétaire-t résorier, JEAN-PAUL TREMI3LAY.St-Cœur-de-Marie.(Comté de Lac St-Jean), P.Q.41435-o the bonds, principal and accrued interest if any, by certified cheque payable at par at Alma, county of Lake St.John.Capital and interest are payable at Montreal, Quebec or Alma, county of Lake St.John.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date, however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Monday, January 9.1956, at 8 o'clock p.m., in the Convent Hall, St.Cœur-de-Marie, county of Lake St.John.The School Commissioners are not bound to accept the hightcst or nay of the tenders.St.Cœur-de-Marie (County of Lake St.John), this December 21, 1955.JEAN-PAUL TREM BLAY, Secreta ry-Treasu rer.St.Cœur-de-Marie, (County of Lake St.John), P.Q.-11435 Vente \u2014 Loi de faillite Canada Province de Québec, district de Rouyn-Noranda, dans l'affaire de la faillite de: La Société Coopérative du Témiscamingue.AVIS Avis est.par le présent donné que la propriété immobilière sous-mentionnée appartenant à la faillie sera vendue par les Syndics conjoints à la faillite Rex N» Smith et Harold Inns aux enchères publiques, le NEUF JANVIER 1956, à DEUX heures de l'après-midi, à Ville-Marie, district de Témiscamingue, sur ladite propriété: \"Un certain lopin de terre, au village de Ville-Marie, ayant front sur la rue Stc-Annc, faisant partie du lot numéro cent cinquante-et-un des plan et livre de Renvoi officiels du village de Ville-Marie (Ptie N° 151 V.M.) mesurant du cê>té nord-est et du cê>té nord-ouest deux cent quatre-vingt-dix-huit pieds (298'), du côté est trois cent treize pieds (313').du côté sud-est et du côté sud-ouest trois cent seize pieds (316') et formant une superficie d'environ quatre-vingt-trois mille pieds (83,000'), mesure anglaise, plus ou moins.Cette partie de lot est bornée: au nord par le chemin de Ville-Marie-Lorrainvillc, au sud par une autre partie du même lot, propriété des Pères Oblats ou représentants, à l'est par le résidu de ce lot, propriété des Pères Oblats.\" Ainsi que le tout se trouve actuellement avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances et les servitudes qui peuvent l'affecter\" Ladite vente aura l'effet du décret, le tout suivant les dispositions des articles 55 et 59 Sale \u2014 Bakrupcy Act Canada.Province of Quebec district of Rouyn-Noranda.In the matter of the bankruptcy of: La Société Coopérative du Témiscamingue.NOTICE Notice is hereby given that the under-mentioned immoveable property, belonging to the bankrupt, will be sold by the joint trustees to the bankruptcy, Rex II.Smith and Harold Inns, by way of auction sale, on JANUARY NINTH, 1956, at TWO o'clock in the afternoon in Ville-Marie on the said property.\"A certain piece of land, in the village of Ville-Marie, having front on Ste-Anne street, forming part of lot number one hundred and fifty-one of the official plan an book of reference of the village of Ville-Marie, (Part No.151 V.M.) measuring on the North-East and North West side two hundred and ninety-eight feet (298') on the East side, three hundred and thirteen feet (313'), on the South East and South West sides three hundred ami sixteen (316').ami forming a surface of approximately eighty three thousand feet (83,000') English measure more or less.The said part of lot is bound: towards the North by the Ville-Maric-Lorrainville road, towards the South by another part of the same lot, property of the Oblates Fathers or their representatives, towards the East by the residue of the said lot and towards the West by part of the same lot, property of the Oblates Fathers.The whole as it is actually with buildings thereon erected, circumstances and dépendances, and the servitude that may affect it.\" The said sale will have the effect of a sheriff's sale, the whole according to Sections 55 to 59 .who (i.I /.ET '/'/\u2022: OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, r, décembre 1955, Time 87, N° 51 de la Loi «le faillite (1949) c't conformément au jugemenl rendu le 21 novembre 1955, dans un dossier portant le numéro F-52 de la Cour supérieure (en matière de faillite) division X° 10 Rouyn-Noranda.Rouyn ce 1er décembre 1955.Les Procureur-; des Syndics Hex II.Smith et Harold Inns.41335-49-2-0 CINQ-MARS & LACROIX.Vente par limitation Province de Québec, district de Montréal.(Our Supérieure, N° 377279, Honoré Dupras et (d, demandeurs, vs I )a nie Jeanne ( 'ourtemaiiehc et al, défendeurs.AVIS DE LICITATION Avis est donné par les présentes qu'en vertu d'un jugement de la-Cour Supérieure siégeant à Montréal, dans le district de Montréal, et rendu par l'honorable juge Harry Batshaw, le 17 novembre 1955.dans une cause dans laquelle Honoré Dupras, Napoléon Dupras, Joseph Dupras.1 )ocil lié I )upras, tous quat re gentilshommes, de Saint-Lin.district de Joliette, Dame Victoria Dupras.d'Ottawa.Ontario, épouse commune en biens de Joseph Desjardins, des cité et district de Montréal, et ledit Joseph Desjardins pour autoriser son épouse aux fins des présentes.Dame Rose-Anna Dupras, des cité et district de Montréal, épouse conlracluellcincnt séparée de biens de Louis Rouillard, des mêmes lieux, et ce dernier pour autoriser son épouse aux lins des présentes.Rosario Dupras, gentilhomme, des cité et district «le Montréal, Yvonne Dupras, tille majeure usant de ses droits, des cité et district «h1 Montréal, Cécile Dupras, fille majeure usant de ses droits, des cité et district de Montréal, Armand Courtenianclie.gentilhomme, «les cité et district de Montréal, Simone Courte-manche, fille majeure usant de ses droits, «les cité et district de Montreal, Leopold Courte-manclie.gentilhomme, des cité et district de Montréal, Yvonne Courtcmanche, des cité et district de Montréal, épouse contractuellement séparée de biens de Ernest Trudel, «les mêmes lieux, et ce dernier pour autoriser sou épouse aux fins des présentes, Albert Court «-manche, gentilhomme, des cité et «listrict de Montréal.Roger Courtcmanche, gentilhomme, des riser son épouse aux fins des présentes, Eva Coyer, de l'Ascension, district de Labelle, épouse contractuellement séparée de biens de Ferdinand Leclerc, des mêmes lieux, et ledit Ferdinand Leclerc pour autoriser sou épouse aux fins des présentes, sont demandeurs, «-t Dame Jeanne Courtemanche, des cité et district «le Montréal, épouse contrac- of the Bankruptcy Act (1919), ami in conformity with a Judgment rendered on the twenty-first of November, 1955, in a file bearing No.F-52 of the Superior Court (in Bankruptcy) Division No.16, Rouyn-Noranda.Roiivn this 1st of Dc«'einber, 1955.CINQ-MARS & LACROIX, At tome vs for the Trustees Rex H.41335-49-2-0 Smith & Harold Inns.Sale by Licitation Province of Quebec, District of Montreal Superior Court, No.377279, Honoré Dupras et (d.plaintiffs, vs Dame Jeanne Courtemanche et al.defendants.NOTICE OF LICITATION Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superi«>r Court sitting in Montreal, in the district of Montreal, and rendered by the Honourable Justice Harry Batshaw, on the 17th day of November 1955, in a case in which Honoré Dupras, Napoléon Dupras, Joseph Dupras.Docithé Dupras.all four gentlemen, of St.Lin, District of Joliette, Dame Victoria Dupras, of Ottawa, Ontario, wife common as to properly of Joseph Desjardins, of the city and «listrict of Montreal, and the sait! Joseph Desjardins t«> authorize his wife for the purposes of these presents, Dame Rose-Anna Dupras, of the city and district of Montreal, wife separated as to property by marriage contract of Louis Rouillard, of the same place, and the latter to authorize his wife for the purposes of these presents, Rosario Dupras, Gentleman, of the city and «listrict of Montreal, Yvonne Dupras, spinster, of the city and district of Montreal, Cécile Dupras, spinster, of the city and district of Montreal, Armand Courtemanche.gentleman, of the city ami district of Montreal.Simone Courtcmanche, spinster of the city and district of Montreal, Leopold Courtemanche.gentleman, of the city and «listrict of Montreal.Yvonne Courtemanche, of the city and district of Montreal, wife separated as to property by marriage contract of Ernest Trudel, of the same place, and the latter to authorize his wife for the purposes «>f these presents, Albert Courtemanche, gentleman, of the city and district of Montreal.Roger Courtemanche, gentleman, of the city and district of Montreal, René Courtemanche, gentleman, of the city and «listrict of Montreal, V.va Courtemanche, spinster, of the city and «listrict of Montréal, Joseph Léo Courtemanche, gentleman, of the city and district of Montreal, Thérèse Courtemanche.of ville St.Laurent, district of Montreal, wife separated as to property by marriage contract of Yvon Earl, of the same place, and the said Yvon Earl to authorise his wife for the purposes of these presents, André Courtemanche, gentleman, of the city and district of Montreal, Albert G«>yer, gentleman, of the city and district of Montreal, Bertha Goyer, of Joliette, district of Joliette, wife separated as to property by marriage contract of Maurice Assclin.of the same place, and the said Maurice Assclin to authorize his wife for the purposes of these presents, Eva Goyer, of L'Ascension, district of Labelle, wife separated as to property by marriage contract of Ferdinand Leclerc, of the same place, and the said Ferdinand Leclerc to authorize his wife for the purposes of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec.December 2'lih.1966, Vol.87, No.51 3991 tuellement séparée té.vers le sud-est, par une partie dudit lot 261 appartenant à Jean Marie Deniers, tel que le tout se trouve actuellement; avec bâtisse ci-dessus cri-gées.Pour être vendu, à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de Laprairie, le CINQ JANVIER 1956, à ONZE heures du matin.Le Shérif.Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 30 novembre 1955.41311-48-2-0 having its head ofliee at Quebec, petitioner; vs ROLAND LEMERY, Rural Route No.1, Cbcnéville, county of Papineau, respondent.\"A piece of land known and described on the official plan and book of reference of range five of the township of Suffolk under lots of land numbers ten and eleven (10-11) with all buildings creeled thereon, having an area of two hundred acres more or less.\" To be sold \"en bloc\" at the Parochial Church door of St.Félix-dc-Valois, at Chénéville, district of Hull, the THIRD day of FEBRUARY 1956, at THREE o'clock in the afternoon.R.ST.PIERRE.Sheriff's Office.Sheriff.Hull, this December 19, 1955.41427-51-2 District of Hull Superior Court.( CANADIAN WESTING-No.1114.< ^ HOUSE SUPPLY (COMPANY LIMITED, a body politic and corporate having its Head Office and principal place of business in the city and district of Montreal.Province of Quebec, plaintiff, vs JOSEPH POIRIER and HERVÉ POIRIER, both of the city and district of Hull, Electrical Contractors and there carrying on business under the name and style of Joseph Poirier & Fils, defendants.Subdivision number fifty-eight of lot number four of ward one (\\Y 1, 4-58) on the Official plan and in the book of reference for the city of Hull, together with all buildings thereon erected and improvements thereon made in-chiding the building bearing civic number 74 of Bisson Street, and all rights members and appurtenances thereunto belonging.To be sold at my office, in the Court House, in the city of Hull.TWENTY-SEVENTH day of JANUARY 1956, at THREE o'clock in the afternoon.R.ST.PIERRE, Sheriff's Office, Sheriff, this December 19th,.1955.41426-51-2 MONTREAL Fieri Facias de Tern's Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: I'D OMÉO LUSSIER, plain-No.379628.< *v tiff; vs THE HEIRS ( OF THE ESTATE OF AUGUSTE BABEU.defendants.An emplacement situated at Laprairie, county of Laprairie, St.Charles Street, forming part of the original lot 261 of the official cadastre of the village of Laprairie, containing forty-three (43) feet in width, by ninety (90) feet in depth, French measure, more or less, and bounded as follows: In front: on the southwest, by St.Charles Street; on the northeast by, lot 242, on one side, on the northwest, by a part of the said lot 261 belonging to Gérard Roy and on the other side, on the southeast, by a part of the said lot 261 belonging to Jean Marie Dcmers, as the whole now stands; with building thereon erected.To be sold, at the parochial church door of the parish of Laprairie, on JANUARY FIFTH, 1956, at ELEVEN o'clock in the forenoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, November 30th, 1955.41311-48-2 3996 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 2>t décembre 1955, Tome 87, N° 51 Fieri Facias de Bonis et de Terris C.S.district de Montréal Montréal, à savoir: / ^TUK T.EATON CO.N° 371552.< 1 LTD., of Montreal, de-\\ manderessc vs C.E.GI- ROUX, défendeur.Ce certain emplacement situé sur l'avenue Holyrood, en la cité d'Outremont, district de Montréal, composé du lot de resubdivision numéro deux du lot de subdivision numéro cinq du lot originaire numéro douze (12-5-2) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal, et du lot de resubdivision numéro un du lot de subdivision numéro six du lot originaire numéro douze (12-6-1) des dits plan et livre de renvoi officiels, avec ensemble les bâtisses dessus érigées, y compris celle portant le numéro civique M avenue Holyrood, cité d'Outremont.Pour être vendu à mon bureau en la cité, de Montréal, le CINQUIÈME jour de JANVIER 1956, â ONZE heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 30 novembre 1955.41313-48-2 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure\u2014 District de Montréal Montréal, â savoir: ( CLAUDE TRAHAN & N° 376265.< ^ GEORGES TRA-v HAX.faisant affaires sous les nom et raison sociale de \"G.& G Trahan\", demandeurs vs PAUL ROBERT défendeur.\"Un emplacement situé à Ville Jacques-Cartier, dans le comté de Chambly, mesurant 75 pieds de largeur par 80 pieds de profondeur mesure anglaise compose des lots numéros 1423.1424 et 1425 de la subdivision officielle du lot originaire numéro 86 des plan et livre de renvoi officiel de la paroisse St-Antoine de Longueuil, avec maison dessus construite, circonstances et dépendances.\" Pour être vendu, au bureau d'enregistrement du comté de Chambly, à Longueuil, le CINQ JANVIER 1956.à OXZE heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 30 novembre 1955.41314-48-2-0- Fieri Fadas de Louis et de Terris S.C.District of Montreal Montreal, to wit : ( TUK T.EATON CO.No.371552.< -1- LTD, of Montreal, I plaintiff, vs C.E.GI- ROUX, defendant.That certain emplacement located on Holy-rood Avenue, in the city of Outreniont.district of Montreal, and composed of resubdivision lot number two of subdivision lot number five of original lot number twelve (12-5-2) on the Official plan and in the book of reference of the parish of Montreal, and of resubdivision lot number one of subdivision lot number six or original lot number twelve (12-6-1) on the said official plan and in the said book of reference, together with the buildings thereon erected, including that bearing civic number 11, Holyrood Avenue, city of Outreniont.To be sold, at niv office in the cilv of Montreal, on JANUARY FIFTH, 1956, at ELEVEN o'clock in the forenoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office.Sheriff.Montreal, November 30th.1955.4I313-48-2-0 Fieri Facias de 'Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: / CLAUDE TRAHAN & No.376265.j ^ GEORGES TRAHAN, v carrying on business under the name and style of \"G.& C.Trahan\", plaintiffs vs PAIL ROBERT, defendant.\"An emplacement situated in the town of Jacques (\"artier, in the county of Chambly, measuring 75 feet in width by SO feet in depth, English measure, including lots number 1423, 1 121 and 1 125 of the official subdivision of original lot number 80 of the.official plan and book of reference of the parish of St.Antoine de Longueuil.with house erected thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold at the Registry Office of the county of Chambly, at Longueuil.the FIFTH dav of JANUARY 1950, at ELEVEN o'clock in'the morning.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal.November 30th.1955.41314-48-2 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: ( T-JARRY SOKOLOFF, N° 354907.< *¦ A des cité et district de ( Montréal, faisant affaires sous les nom et raison sociale de \"Acton Credit House\", demandeur, vs LA SUCCESSION DE FEU ERNEST ST-ARNAUD, défendeur.Un certain emplacement ayant front sur la rue Vauquelin, dans la cité de Montréal, connu et désigné sous le numéro cinq cent dix-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent soixante-dix-sept (477-519) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-Recollet, avec la maison dessus érigée et portant le numéro civique 2214 de ladite rue Vauquelin, à Montréal, circonstances et dépendances, servitudes actives et passives, apparentes ou occultes.Pour être vendu, à mon bureau, en la cité de Montréal, le CINQ JANVIER 1950 à DIX heures du malin.Le Shérif, Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 30 novembre.,1955.41312-48-2-0 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: ( T\u2014TA B R Y SOKOLOFF, No.354907.< A 1 of the city and district lof Montreal, therein trading under the firm name and style of \"Acton Credit House\", plaintifî, vs THE ESTATE OF THE LATE ERNEST ST.ARNAUD, defendant.An emplacement fronting Vauquelin Street, m the city of Montreal, known and designated under number five hundred and nineteen of the official subdivision of original lot number four hundred and seventy-seven (477-519) of the official plan and book of reference of the parish of Sault-au-RccolIet.with a house erected there-*on and having civic number 2214 of the said Vauquelin Street, at Montreal, circumstances and dependencies, active and passive servitudes, both apparent or unapparent.To be sold at my office, in the city of Montreal, the FIFTH .lay of JANUARY 1956, at TEN o'clock in the morning.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, November 30th, 1955.41312-48-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Quebec.December 2',th, 1955, Vol.87, So.51 3997 QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: ( T 'OFFICE DU CRÉDIT N° 77.839.< -L* AGRICOLE DU QUE-K BEC, contre Dame veuve LOUIS (îUAY, épouse (le feu Louis (iuay, en son vivant de La Croche, district judiciaire de Québec.1° Une terre située à La Croche, «le figure irrégulière, connue et désignée sous le numéro cinquante (N° 50) rang Ouest Canton Langelier compris dans les bornes suivantes: à l'Ouest par le lot X° 93, à l'Est par la Rivière La Croche, au Sud par le lot N° 19 et au Nord par le lot N° 51, mesurant treize chaînes de largeur sur la profondeur moyenne de cent trente-cinq chaînes.2.Une terre située à La Croche, connue et désignée sous le numéro cinquante-un (N° 51) rang Ouest Canton Langelier, comprise dans les bornes suivantes: à l'Ouest par le lot N° 93, à l'Est par la Rivière La Croche, au Sud par le lot N° 50 et au Xord par le lot X° 52 de la contenance de treize chaînes de largeur sur une profondeur moyenne de quatre-vingt-seize chaînes.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu en bloc au bureau d'enregistrement de la ville de La Tuque, comté «le Lavio-lette, le VINGT-SEPTIÈME jour de JANVIER prochain, à DIX heures de l'avant-nidi.Le Député-Shérif, ALBERT F.RACETTE.Québec, 20 décembre 1955.41428-51-2-0 |Première insertion: 24 décembre 1955] , [Deuxième insertion: 7 janvier I9ô(i.] SAINT-HYACINTHE Fieri Facias ill1 linn is- et de Terris Dis! rict «le Montréal Cour Supérieure.( T TNITED LOAN CORPO-X° 300-757 ,th, 1955, Vol.87, No.51 3999 Bishop's College.3965 L'Abord-à-Plouffe, ville.3964 Lachine, cité de.3966 Laperrièrc, Paul-Emile.3965 L'Association de Diétique du Québec\u2014 Quebec Dietetic Association.3962 Le Bureau Métropolitain des écoles protestantes de Montréal.3967 Mus/.ka, A.de S.3967 Richmond, ville de.3964 Rivièrc-des-Prairies, ville de.3966 St-Hubert, municipalité.3963 St-Léonard-de-Port-Mauride, paroissd.3966 Succession J.-L.Sabbath.3964 The International Society of Commerce Limited.3965 DÊPARTEMEXTS \u2014 AVIS DES: Instruction publique: Municipalité scolaire de: Onslow (protestante).Terres et Forets: Services du Cadastre: Arvida, cité._____ 3968 Ascot, canton.3968 Beauport, paroisse.3967 Bolton, canton.3969 Ile Allright.3968 Xcmtoyé, canton.3969 Ste-Foy, paroisse.3969 Ste-Foy, paroisse.3969 St-Vincent-de-Paul, paroisse.3969 Travail: Industrie ou métiers de : Chapeaux en toile et de Casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la Province (prélèvements).3970 Gants fins (prélèvement).3973 Plombiers de Trois-Rivières et «listrict (prélèvement).3974 Sacoche dans la Province (prélèvement) 3971 Lettres patentes: Abias Pépin Automobiles Ltée.3920 Acme Stone Cie Ltée \u2014 Acme Stone Co.Ltd.3921 A.& M.Weis Household Furniture Inc.3921 Artmar Construction Co.Ltd.3921 Beaurepaire Beauty Bar Inc.3922 Belle Fleur Construction Corp.3922 Bernard Bros, Outfitters Inc.3922 Brotherhood Centre Inc.3923 Carticrville Shopping Centre Inc.3923 Champion and Company Limited \u2014 Champion et Compagnie Limitée.3923 Coltex Trading Company Limited.3924 Comfort Regal & Wilco Fashions Inc.3924 Confection Saint-Agathe Limitée.3924 Crémazie Automobile Inc.3925 Crête et Champoux Equipements Ltée Crête and Champoux Equipments Ltd.3925 CyrAuto Body Ltd.3925 Danford Lake District Property Owners Association.3920 David Transport & Cie Ltée.3926 Doby Realties Inc.3927 Domaine L'Achigan Inc.3927 Dufresne Xettoyeurs Inc.3927 Eastdor Holdings Inc.3928 Entreprises Frigorifiques Ltée \u2014 Refri- Bishop's College.3965 L'Abord-à-Plouffe, town.3964 Lachine, city of.3966 Laperrière, Paul-Emile.3965 L'Association de Diététique du Québec \u2014Quebec Dietetic Association.3962 The Protestant School Board of Greater Montreal.3967 Mus/.ka, A.de S.3967 Richmond, town of.3964 Rivière-dcs-Prairies, town of.3966 St-Hubert, Municipality.3963 St-Léonard-de-Port-Maurice, Parish.3966 Estate J.L.Sabbath.3964 The International Societv of Commerce Limited.3965 DEPARTMENTAL NOTICES : Education: School Municipality of: 3967 Lands and Forest : Cadastral Branch: Arvida, city.3968 Ascot, township.3968 Beauport, parish.3967 Bolton township.3969 Allright Island.3968 Nemtoyé, township.3969 Ste-Foy, parish.3969 Ste-Foy.parish.3969 St-Vincent-de-Paul, parish.3969 Labour : Industry or Trades of: Men's, Boys' and Children's Cloth Hat, Cap and Hcadwear in the Province (lew).3970 Fine Gloves (levy).3973 Plumbers of Trois-Rivières and district (levy).3974 Handbag in the Province (levy).3971 Letters Patent: Abias Pépin Automobiles Ltée.3920 Acme Stone Cie Ltée \u2014 Acme Stone Co.Ltd.3921 A.& M.Weis Household Furniture Inc.3921 Artmar Construction Co.Ltd.3921 Beaurepaire Beauty Bar Inc.3922 Belle Fleur Construction Corp.3922 Bernard Bros, Outfitters Inc.3922 Brotherhood Centre Inc.3923 Carticrville Shopping Outre Inc.3923 Champion and Company Limited \u2014 Champion et Compagnie Limitée.3923 Coltex Trading Company Limited.3924 Comfort Regal & Wilco Fashions Inc.3924 Confection Saint-Agathe Limitée.3924 Crémazie Automobile Inc.3925 Crête et Champoux Equipements Ltée Crête and Champoux Equipments Ltd.3925 Cyr Avito Body Ltd.3925 Danford Lake District Property Owners Association.3926 David Transport & Cie Ltée.3926 Doby Realties Inc.3927 Domaine L'Achigan Inc.3927 Dufresne Nettoveurs Inc.3927 Eastdor Holdings Inc.3928 Entreprises Frigorifiques Ltée \u2014 Refri- 3967 Onslow (protestant) 4000 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Quebec, 2/, décembre 1955, Tame 87, N° 61 geration Enterprises Ltd.3928 Excel Nettoyeurs & Cleaners Inc.3928 Gale Lumber Ltd.3929 Gérard Lagaeé Ltée.3929 Gravel et Fils Investments Corporation 3929 Gorvenor Distributors Inc.3930 Hendec Holdings Inc.3930 Hôtel George (Rouyn) Limitée.3930 International Development lue.3931 Irman Realties Inc.3931 Jeffrose Ltd.3931 Jos.Brassard Limitée.3932 Jos.Houde.Limitée.3932 J.-T.Cloutier Inc.3932 Kates Millinery Ltd.3933 L'Achigan Holdings Ltd.3933 La Construction Populaire, Inc.3933 Lapointe Exploration Limited.3931 Le Restaurant Bastogne lue.3934 Les Carrières Sept-lles Incorporée \u2014 Seven Islands Quarries Incorporated 3931 Les Entreprises Lemire.Limitée.393\") Les Industries Farnham Ltée\u2014Farnham Industries Ltd.3935 L'Hôpital St-Joseph de Sept-lles Incorporée.3935 Limary Builders Supply Ltd \u2014 La Cie de Matériaux de Construction Limary Ltée.3930 Luxor Millinery Ltd.3936 Man-Lcn Building Corp.3937 Maxwell Upholstering Co.3937 Mercury Land & House Corp.3937 Mid-Town Service Station Ltd.3938 Miron Quarry Ltd.3938 Morein's Service Station Ltd.3938 Moricelli Co.Ltd.3939 M.S.McCuaig Ltd.:.3939 National Factors Corporation.3939 Perhou Ltée.3940 Preissae Molybdenite Mines Limited .3940 Produits Avicoles de Roberval Ltée.3910 Raymond Transport Inc.3911 Rcdhrook Estates Ltd.3911 Riviera Espresso Codec Bar Inc.3941 Rubyco Mills Ltd.3942 Rupert's Land Trading Company (Quebec) Ltd.3912 Speedy Tailors Inc.3912 Style Pads Inc.3943 Suburban Auto Service Ltd.3943 Super Realties Inc.3913 The Reuben Ross Corp.3943 The Ryldith Corp.3941 Tombur Machinery Corporation.3944 Traders Realties (Montreal) Inc.394 I Turnabout Shop.Inc.3945 Twin Mountain Holding Company.3945 U.M arcoux & Fils Ltée.3945 Vaudreuil Shopping Center Inc.3941 Viens & Vallée Automobiles Ltée .3941 Wentworth Home Owners' Association 3940 Lettres patentes supplémentaires: Bentom Beef Co.Ltd.3917 Les Entreprises de J.Emile Langlois Ltée.3947 McCord Street Sites Limited.3947 Rachel Realties Inc.3948 Rôtisserie C Si Bon Bar-B-Q, Inc.3948 Sillery Investment Corporation.394S Ministère des Finances: Assurances: geration Enterprises Ltd.3928 Excel Nettoyeurs & Cleaners Inc.3928 Gale Lumber Ltd.3929 Gérard Lagaeé Ltée.3929 Gravel et Fils Investments Corporation 3929 Gorvenor Distributors Inc.3930 Hendec Holdings Inc.3930 Hôtel George (Rouyn) Limitée.3930 International Development Inc.3931 Irman Realties lue.3931 .Jeffrose Ltd.3931 Jos.Brassard Limitée.3932 Jos.Houde, Limitée.3932 J.-T.Cloutier Inc.3932 Kates Millinery Ltd.3933 L'Achigan Holdings Ltd.3933 La Construction Populaire.Inc.3933 Lapointe Exploration Limited.3934 Le Restaurant Bastogne lue.3934 Les Carrières Sept-lles Incorporée \u2014 Seven Islands Quarries Incorporated 3934 Les Entreprises Lemire, Limitée.3935 Les Industries Farnham Ltée\u2014Farnham Industries Ltd.3935 L'Hôpital St-Joseph de Sept-lles Incorporée.3935 Limary Builders Supply Ltd \u2014 La Cie de Matériaux «le Construction Limary Ltée.3936 Luxor Millinery Ltd.3930 Man-Lcn Building Corp.3937 Maxwell Upholstering Co.3937 Mercury Laud & House Corp.3937 Mid-Town Service Station Ltd.3938 Mirdh Quarry Ltd.393S Morein's Service Station Ltd.3938 Moricelli Co.Ltd.3939 M.S.McCuaig Ltd.3939 National Factors Corporation.3939 Perhou Ltée.3940 Preissae Molybdenite Mines Limited.3910 Produits Avicoles de Roberval Ltée.3940 Raymond Transport Inc.3941 Redbrook Estates Ltd.3941 Riviera Espresso Coffee Bar Inc.3941 Rubyco Mills Ltd.3912 Rupert's Land Trading Company (Quebec) Ltd.3942 Spee.lv Tailors Inc.3942 Style Pads Inc.3943 Suburban Auto Service Ltd.3943 Super Realties Inc.3943 The Reuben Ross Corp.3943 The Ryldith Corp.3944 Tombur Machinery Corporation.3944 - Trailers Realties (Montreal) Inc.3944 Turnabout Shop, Inc.3945 Twin Mountain Holding Coinpanv.3945 U.Marcoux & Fils Ltée.\".3945 Vaudreuil Shopping Center Inc.3941 Viens & Vallée Automobiles Ltée.3941 Wentworth Home Owners' Association 3940 Supplementary Letters Patent: Bentom Beef Co.Ltd.3947 Les Entreprises de J.Emile Langlois Ltée.3947 McCord Street Sites Limited.3947 Rachel Realties Inc.3948 Rôtisserie C Si Bon Bar-B-Q, Inc.3948 Sillery Investment Corporation.3948 Department of Finance: Insurance: Alpina Insurance Company Ltd 3970 Alpina Insurance Company Ltd 3970 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 2.',th, 1955, Vol.87, No.51 4001 Nomination : Président d'élection.3970 Proclamations: Concernant l'annexion d'un certain territoire de la municipalité du Lac du Cerf à la municipalité du Canton de Kiamika.3979 Concernant l'érection de la municipalité de la paroisse de La Rédemption.3978 Concernant l'érection de la municipalité du village de Saint-Anloinc-dcs-Lau-rentides.3982 Concernant l'annexion d'un certain territoire de la municipalité du Canton de Marchand à la municipalité du village de L'Annonciation.3977 Concernant l'annexion d'un certain territoire de la paroisse de Saint-Cy-prien-de-Léry à la municipalité du village de Napierville., .3980 Concernant l'érection de la municipalité du village de Saint-Emile.3985 Concernant l'annexion d'un certain territoire de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon à la municipalité du village de Saint-Gabriel-de-Brandon.3983 Sièges soci aux : Perhou Ltée.3986 Mount Bruno Investment Ltd.3986 Soumissions: St-Cœur-de-Marie.Commission scolaire 39S8 St-Sauveur-des-Monts, village.3987 Vente, Loi de faillite: La Société Coopérative du Témiscamingue.3989 Vente par u citation: Dupras et al vs Courtemanche et al.3999 Vente pour taxis: Delisle.Munie.Canton.3992 VENTES PAR SHÉRIFS: Abitibi: Hudon vs Héritiers de Hervé Coulomhe 3993 Northern Plumbing Limited vs Tony Dry Cleaner Co.Ltd.3994 Arthabaska: Banque Provincial du Canada vs Cardin et al.3994 Gaspé: Russell vs Therrien.3994 Hull : Canadian Westinghouse Supply Company Limited vs Poirier et al'.3995 Office du Crédit Agricole de Québec vs Lemery.3994 Appointment: Returning-Officer.3967 Proclamations: Concerning the annexation of a certain territory of the municipality of Lac du Cerf to the municipality of the township of Kiamika.3979 Concerning the erection of the municipality of the parish of La Rédemption.3978 Concerning the erection of the municipality of the village of Saint-Antoine-des-Laurcntides.3982 Concerning the annexation of a certain territory of the municipality of the township of Marchand to the municipality of the village of L'Annonciation.*.3977 Concerning the annexation of a certain territory of the parish of Saint-Cy-prien-de-Léry to the municipality of the village of Napierville.3980 Concerning the erection of the municipality village of Saint-Émile.3985 Concerning the annexation of a certain territory of the parish of Saint-Gabriel-de-Brandon to the municipality of the village of Saint-Gabriel-de-Brandon.3983 Head Offices: Perhou Ltée.3986 Mount Bruno Investment Ltd.3986 Tenders: St-Cceur-dc-Marie, School Commission 3988 St-Sauveur-des-Monts, village.39S7 Sale, Bankruptcy Act: La Société Cooperative du Témiscamingue.3989 Sale by Licttation: Dupras et al vs Courtemanche et al.3990 Sale for Taxes: Delisle.Munie, township.3992 SHERIFFS' SALES : AniTim: Hudon vs Heirs of Hervé Coulomhe.3993 Northern Plumbing Limited vs Tony Dry Cleaner Co.Ltd.3994 Arthabaska: Provincial Bank of Canada vs Cardin et al.3994 GÀspé : Russell vs Therrien.3994 Hull: Canadian Westinghouse Supply Company Limited vs Poirier et al.3995 Quebec Farm Credit Bureau vs Lemery.3994 4002 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, U décembre 1955, Tome 87, N° 61 Montréal: Montreal: Lussier vs Héritiers de Auguste Babeu 3995 Lussier vs Heirs of Auguste Babeu.3995 Sokoloff vs Succession.3996 Sokololf vs Estate Ernest St-Amand.3996 The T.Eaton Co.Ltd of Montreal vs The T.Eaton Co., Ltd of Montreal Giroux.3996 vs Giroux.3996 Traban et al vs Robert.3996 Traban et al vs Robert.3996 Québec : Quebec : L'Office du Crédit Agricole vs Guay.3997 The Quebec Farm Credit Bureau vs ( Guay.3997 Saint-Hyacinthe : Saint-Hyacinthe : United Loan Corporation vs Leclerc United Loan Corporation vs Leclerc et *ir.3997 et vît.3997 Terrebonne : Terrebonne: Desjardins vs Bélair.3997 Desjardins vs Bélair.3997 41408-o 41408-o Québec: \u2014 Imprimé par rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Queen's Printer."]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.