Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 juillet 1955, samedi 16 (no 28)
[" Tome 87, N° 28 2115 Vol.87, No.28 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act re»pecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 16 juillet 1955 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1955.Québec, le 14 juin 1955.L'Imprimeur de la Reine, 40188-26-9-O RÊDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, July 16th, 1955 RECEIPT OP ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1955.Quebec, June 14th.1955.RÊDEMPTI PARADIS, 40188-26-9-O Queen's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 2116 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 ».insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi a condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: 87 par année.N.P>.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.38933 \u2014 1-52 Lettres patentes (P.G.11400-55) A liai iv Drilling Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mai, 1955, constituant en corporation: Théoval Allaire, Joseph Allaire, industriels, et Rita Lapointe Allaire, ménagère, épouse séparée de biens dudit Théoval Allaire, tous de Disraeli, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation : 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: SI.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once arc followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.38933 \u20141-52 Letters Patent (A.G.11400-55) Allaire Drilling Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of May, 1955, incorporating: Théoval Allaire, Joseph Allaire, industrialists, and Rita Lapointe Allaire, housewife, wife separate as to property of the said Théoval Allaire, all of Disraeli, judicial district of Saint-Francis, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2117 Faire le commerce dans Ic forage à diamants et la localisation de mines, sous le nom de \"Allaire Drilling Incorporated\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Disraeli, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mai 1955.L'Assistant-procurcur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.12931-54) Association Canadienne des Jardiniers d'Enfants Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Thérèse Léveillé, directrice d'école maternelle, de Montréal, Madeleine Pagnuelo, directrice d'école maternelle, de Westmount, et Jeannette Dalpé, directrice d'école maternelle d'Outrcmont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir l'éducation pré-scolaire, sous le nom de \"Association Canadienne des Jardinières d'Enfants\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 820,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district Judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mai 1955.L'Assistant-procurcur général, .40252-0 C.E.CANTIN.(P.G.11025-55) Associés du Vieux Quai Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Pierre Arcand, chef inspecteur, Leopold Bibeau, Lorenzo Rousseau, Wilfrid Auger, tous trois commis, Jean Victor Vallée, chef mécanicien, Roméo Longpré, boucher, Léonard Pou Hot, camionneur, et Gérard Rousseau, concierge, tous de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Distraire ses membres par la pratique des sports, sous le nom de \"Associés du Vieux Quai\".Le montant auquel sont limités les biens meubles et immeubles que la corporation peut posséder, est de SI 00,000.Le siège social de la corporation sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11193-55) Boudreau & Ross Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéoec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit mai 1955, constituant en corporation: Alfred-Henri Boudreau, industriel, H.- To carry on the business of and deal in diamond drilling and in the localization of mines, under the name of \"Allaire Drilling Incorporated\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Disraeli, judicial district of Saint-Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.12931-54) Association Canadienne des Jardiniers d'Enfants Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of May, 1955.to incorporate as a corporation without share capital: Thérèse Léveillé, directrice of the Maternal School, of Montreal, Madeleine Pagnuelo, directrice of the Maternal School, of Westmount, and Jeannette Dalpé, directrice of the Maternal School, of Outremount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote pre-school education under the name of \"Association Canadienne des Jardinières d'Enfants\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation mav hold is to be limited, is §20,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth clay of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11025-55) Associés du Vieux Quai Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Pierc Arcand, chief inspector, Leopold Bibcau, Lorenzo Rousseau, Wilfrid Auger, all three clerks, Jean Victor Vallée, chief mechanic, Roméo Longpré, butcher, Léonard Pouliot, trucker, and Gérard Rousseau, janitor, all of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To divert its members by means of sports, under the name of \"Associés du Vieux Quai\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8100,000.The head office of the corporation will be at Sherbrooke judicial district of Saint Francis Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11193-55) Boudreau & Ross Ltde Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of May 1955, incorporating: Alfred Henri Boudreau, industrial, H.Aubin Dussault, ad- 2118 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 Aubin Dussault, avocat, et Claudette Thibault, sténographe, célibataire, tous de Mont-Joli, district judiciaire de Rimouski, pour les objets suivants: Exercer le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Boudreau & Ross Ltée\", avec un capital total de S40,000, divisé en 100 actions ordinaires de SI00 chacune et en 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 39, Avenue du Sanatorium, Mont-Joli, district de Rimouski.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit mai 1955.1/Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11184-55) C.D.Racine Ltd., Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du .seizième jour de mai 1955, constituant en corporation: Philip Vineberg, Neil F.Phillips, avocats, de Westmount et David Goodman, avocat, de Hampstead, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bois dans toutes ses spécialités et ceux d'entrepreneurs, constructeurs et couvreurs, sous le nom de \"CD.Racine Ltd., Ltée\", avec un capital total de SI,000 divisé en 1,000 actions de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de mai 1955.L'Assistant-procurcur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11303-55) Champlain Slippers Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze mai 1955, constituant en corporation: L.-E.-Langis Galipeault, c.r., avocat, François Veilleux, «avocat, Antonio Leclerc, auditeur public accrédité, et Jeanne Déchêne, sténographe, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de pantoufles, souliers, bottes et chaussures, sous le nom de \"Champlain Slippers Inc.\", avec un capital total de 850,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $5 chacune et en 9,000 actions privilégiées de S5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Émile, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1955.L'Assistant-procurcur général suppléant, 40252-O P.FRENETTE.(P.G.11289-55) C.H.Désaultcls Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mai 1955, constituant en corporation: Charles-Henri Dcsautels, voyageur de commerce, Jacqueline Choquette, ménagère, épouse con-tractuellement séparée de biens dudit Charles- vocatc, and Claudette Thibault, stenographer, spinster, all of Mont-Joli, judicial district of Rimouski, for the following purposes: To deal in building materials, under the name of \"Boudreau & Ross Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 commonshares of S100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 39 Sanatorium Avenue, judicial district of Rimouski.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11184-55) C.D.Racine Ltd., Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1955, incorporating: Philip Vineberg, Neil F.Phillips, advocates, of Westmount, and David Goodman, advocate, of Hampstead, all of the judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of lumbering in all its branches; to carry on business as contractors, builders and roofers, under the name of \"C.D.Racine Ltd., Ltée\", with a total capital stock of 81,000 divided into 1,000 shares of SI each.The head office of the company will be at Montreal, judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11303-55) Champlain Slippers Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May 1955, incorporating: L.E.Langis Galipeault, Q.C., advocate, François Veilleux, advocate, Antonio Leclerc, accredited public auditor, and Jeanne Déchêne, stenographer, fille majeure, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in slippers, shoes, high boots and footwear, under the name of \"Champlain Slippers Inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 1,000 common shares of S5 each and 9,000 preferred shares of S5 each.The head office of the company will be at Saint Emile, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1955.P.FRENETTE, 40252 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11289-55) C.H.Désaultels Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of May 1955, incorporating: Charles Henri De-sautels, commercial traveller, Jacqueline Choquette, housewife, wife contractually separate as to property of the said Charles Henri Desautels, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2119 Henri Dcsautels, et Bernard St-Gerniain, marchand, tous des cité et district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Exercer le commerce de vêtements pour enfants et adolescents, sous le nom de \"C.H.Desautels Ltée\", avec un capital total de §40,000, divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI00 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mai 1955.L'Assistant-procurcur général suppléant, 40252-O P.FRENETTE.(P.G.11189-55) Clément & Frère Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1955, constituant en corporation: Jacques Charette, Pierre Beaudoin, comptables, et David Belhumeur, c.a., tous des cité et district judiciaire des Trois-Rivièrcs, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes, sous le nom de \"Clément & Frère Ltée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 200 actions ordinaires de S100 chacune et en 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Louise-ville, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1955.L'Assistant-procurcur général suppléant, 40252-O P.FRENETTE.(P.G.11407-55) Contre-Plaques Ste-Marie Inc.Ste-Marie Plywoods Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit mai 1955, constituant en corporation: Reina Sauriol Ste-Marie, veuve de J.Ulysse Ste-Marie, Guy Ste-Marie, Paul Ste-Marie, industriels, et Paulette Ste-Marie, fille majeure, tous de Beauport, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce du bois et des produits du bois, sous le nom de \"Contre-Plaques Ste-Marie Inc.\u2014 Ste-Marié Plywoods Inc.\", avec un capital divisé en 990 actions sans valeur nominale.Le siège social de la compagnie sera au Centre Industriel N° 5, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.10916-55) Coulombe & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéoec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation: Emmanuel Coulombe, marchand, Blanche Mon-geau, ménagère, épouse commune en biens dudit and Bernard St-Germain, merchant, all of the city and judicial district of Saint Hyacinthe, for the following purposes: To deal in wearing apparel for children and youths, under the name of \"C.H.Desautels Ltée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 300 common shares of a nominal value of $100 each and 100 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at Saint Hyacinthe, judicial district of Saint Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May 1955.P.FRENETTE, 40252 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11189-55) Clément & Frère Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May 1955, incorporating: Jacques Charette, Pierre Beaudoin, accountants, and David Belhumeur, C.A., both of the city and judicial district of Trois-Rivières.To carry on business as garage-keepers, under the name of \"Clement & Frère Ltée\", with a total capital stock of $100,000^ divided into 200 common shares of S100 each and 800 preferred shares of a par value of SI 00 each.The head office of the company will be at Louiseville, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of Mav 1955.P.FRENETTE, 40252 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11407-55) Contre-Plaques Stc-Marie Inc.Ste-Marie Plywoods Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of May 1955, incorporating: Reina Sauriol Ste-Marie, widow of J.Ulysse Ste-Marie, Guy Ste-Marie, Paid Ste-Marie, industrialists, and Paulette Ste-Marie,, fille majeure, all of Beau-port, judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the lumber business and the products thereof, under the name of \"Contre-Plaques Ste-Marie Inc.\u2014 Ste-Marie Plywoods Inc.\" with a capital stock divided into 990 shares without nominal value.The head office of the company will be at Industrial Centre No.5, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.10916-55) Coulombe & Fils Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May 1955, incorporating: Emmanuel Coulombe, merchant, Blanche Mongeau, housewife, wife common as to property of the said 2120 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 Emmanuel Coulombe et dûment autorisé par lui, aux fins des présentes, et Guy Coulombe, comptable, tous de Granby, district judiciaire de Bedford, pour les objets suivants: Exercer le commerce des huiles et combustibles, sous le nom de \"Coulombe & Fils Inc.\", avec un capital total de 8-10,000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Bedford.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O \u2022 C.E.CANTIN.(P.G.10943-55) Damar Products of Canada Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-septième jour de mai 1955, constituant en corporation: David Goodman, avocat, de la ville de Hampstead, Neil Phillips, avocat de Westmount et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tops du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'accessoires domestiques, articles de maison, ustensiles de cuisine et articles vestimentaires, sous le nom de \"Damar Products of Canada Ltd.\", avec un capital total de 810,000, divisé en 1,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11409-55) Drainage Ste-Marie Inc.\u2014 Ste-Marie Drainage Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit mai 1955, constituant en corporation: Reina Sauriol Ste-Marie, veuve de J.Ulysse Ste-Marie, André Ste-Marie, Jacques Ste-Marie, industriels, et Lconnc Ste-Marie-Leroux, épouse séparée de biens de Armand Leroux,\" tous de Beauport, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Drainage Ste-Marie Inc.\u2014 Ste-Marie Drainage Inc.\", avec un capital divisé en 990 actions sans valeur nominale.Lé siège social de la compagnie sera Centre Industriel N° 5, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-o C.E.CANTIN.(P.G.11438-55) Eastlin Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinquième jour de mai 1955, constituant en corporation: Paul De Sève, administrateur, Theresa Franks, secrétaire, tous deux de Mout- Emmanuel Coulombe and duly authorized by him for these presents, and Guy Coulombe, accountant, all of Granby, judicial district of Bedford, for the following purposes: To djeal in oils and fuels, under the name of \"Coulombe & Fils Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 shares of S100 each.The head office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of May, 1955.' C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.10943-55) Damar Products of Canada Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of May, 1955, incorporating: David Goodman, advocate, of the Town of Hampstead, Neil Phillips, advocate, of Westmount, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in household appliances, house wares, kitchen utensils and wearing apparel, under the name of \"Damar Products of Canada Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 1,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May, 1955.C.E.CANTIN.40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11409-55) Drainage Ste-Marie Inc.\u2014 Sic-Marie Drainage Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of May 1955, incorporating: Reina Sauriol Ste-Marie, widow of J.Ulysse Ste-Marie, André Ste-Marie, Jacques Ste-Marie, industrialist, and Léonne Ste-Marie Leroux, wife separate as to property of Armand Leroux, all of Beauport, judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Drainage Ste-Marie Inc.\u2014 Ste-Marie Drainage Inc.\", with a capital stock divided into 990 shares without nominal value.The head office of the company will be at Industrial Centre No.5, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.A.G.11438-55) Eastlin Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of May, 1955, incorporating: Paul De Seve, executive, Theresa Franks, secretary, both of Montreal, and Stuart H.Ayres, execu* QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.47, No.28 2121 real et Stuart H.Ayres, administrateur, de Pointe-Claire, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des terrains ou intérêts en iceux; ériger des édifices et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Eastlin Corporation\", avec un capital total de 325,000 divisé en 2,500 actions de §10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-cinquième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11374-55) Édifice Laflcur Liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et unième jour de mai 1955, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, Neil Franklin Phillips, avocats, de Westmount et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme bailleurs et administrateurs d'immeubles, sous le nom de \"Édifice Lafleur Ltée\", avec un capital total de 8100,000 divisé en 100 actions ordinaires de SI 00 chacune et 90,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt et unième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.1133(5-55) Fenêtre Kaufmann Window Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation: Jean-Paul Grenier, industriel, Evelyne Garncau, secrétaire, fille majeure et usant de ses droits, tous deux de Neuville, et Samuel Bard, avocat, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fenêtres, portes, châssis et en général de tout ce qui fait partie d'un immeuble, sous le nom de \"Fenêtre Kaufmann Window Inc.\", avec un capital total de 810,000, divise en 100 actions communes de $10 chacune et en 900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 885, rué St-Joseph.Est, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procureur général.40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11356-55) General Tile & Terrazzo Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de mai 1955, constituant en corporation: Louis Abraham DeZwirek, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Daniel Morris, tive, of Pointe Claire, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire lands or interests therein; to erect buildings and to deal in building materials, under the name of \"Eastlin Corporation\", with a total capital stock of S25,000, divided into 2,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth dav of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11374-55) Édifice Lafleur Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1955, incorporating: Philip Fischel Vineberg, Neil Franklin Phillips, advocates, of Westmount, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as real estate lessors and administrators, under the name of \"Édifice Lafleur Ltée\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 100 common shares of S100 each and into 90,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11336-55) Fenêtre Kaufmann Window Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1955, incorporating: Jean-Paul Grenier, industrialist, Evelyne Garneau, secretary, spinster in use of her rights, both of Neuville, and Samuel Bard, advocate of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on a business dealing in windows, doors, sashes and to deal generally in any ting pertaining to a building, under the name of \"Fenêtre Kaufmann window Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of S10 each and into 900 preferred shares of S10 each.The head office of the company will be at.885 St-Joseph St., East, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of Mav, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11356-55) General Tile & Terrazzo Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1955, incorporating: Louis Abraham DeZwirek, advocate and Queen's Counsel, Daniel Morris, advocate, both of Montreal, and 2122 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juiUct 1956, Tome 87, N° 28 avocat, tous deux de Montréal et Samuel Léon Mendelsohn, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer des affaires comme entrepreneurs et constructeurs, sous le nom de \"General Tile & Terrazzo Company\", avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11325-55) Hotel Dorchester Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et unième jour de mai 1955, constituant en corporation: Sol Sidnay Fels, Bernard Gardner et David L.Cabana, avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce d'hôtellerie, sous le nom de \"Hotel Dorchester Inc.\", avec un capital total de $40,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt et unième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11651-55) Hôtel National (Rouyn) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéoec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize juin 1955, constituant en corporation: Normand Grimard, Gérald Ryan, avocats, de Noranda, et Denise Corriveau, secrétaire, fille majeure, de Rouyn, tous du district judiciaire de Rouyn-Noranda, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôtelier, sous le nom de \"Hôtel National (Rouyn) Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 8,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rouyn, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Daté du bureau du Procureur général, le treize juin 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11264-55) Isolation de Québec Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation: Maurice Gagné, Jacques Flynn, avocats et conseils en loi de la Reine, de Québec, et Julien Chouinard, avocat, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Samuel Leon Mendelsohn, advocate and Queen's Counsel, of Westmount, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as contractors and builders, under the name of \"General Tile & Terrazzo Company\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11325-55) Hotel Dorchester Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1955, incorporating: Sol Sidney Fels, Bernard Gardner and David L.Cabana, advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hotel, under the name of \"Hotel Dorchester Inc.\", with a total stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11651-55) Hôtel National (Rouyn) Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the June thirteenth, 1955, incorporating: Normand Grimard, Gerald Ryan, advocates, of Noranda, and Denise Corriveau, secretary, spinster, of Rouyn, all of the judicial district of Rouyn-Noranda, for the following purposes: To carry on business as hotel-keeper, under the name of \"Hôtel National (Rouyn) Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 8,000 common shares of a par value of $5 each.The head office of the company will be at Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of June, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11264-55) Isolation de Québec Limitée Notice is hereby given that under Part I the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1955, incorporating: Maurice Gagné, Jacques Flynn, advocates and Queen's Counsel of Quebec, and Julien'Chouinard, advocate, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2123 Agir comme entrepreneurs généraux sous le nom de \"Isolation de Québec Limitée\", avec un capital total de $2,000, divisé en 20 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 604, rue St-Jean, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11276-55) J.A.Houle Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation: J.-Adélard Houle, Bruno Pellerin, marchands, de Shawinigan-Falls, Lionel Pellerin, marchand, Rolande Lacroix, sténographe, fille majeure, et Roger Deshaies, avocat, de Grand'Mère, tous du district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de meubles, articles de verre, porcelaine, plastique, accessoires de cuisine et autres articles d'utilité domestique, sous le nom de \"J.A.Houle Ltée\", avec un capital total de $150,000, divisé en 1,000 actions communes de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Shawinigan-Falls, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procureur général 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11319-55) Jean-Talon Automobile Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mai 1955, constituant en corporation: Lucien Biais, comptable, Joseph-Paul-Léon Ri-vard, courtier d'assurance, et Warry Ward, vendeur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter dans toutes ses spécialités le commerce de ventes et services d'automobiles, sous le nom de \"Jean-Talon Automobile Limitée\", avec un capital total de*$40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252-O P.FRENETTE.(P.G.10761-55) La Chambre de Commerce de Terrebonne Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Louis-Philippe De Serres, vendeur, Jean-Paul Legris, comptable, et Fer- To operate as general contractors under the name of \"Isolation de Québec Limitée\", with a total capital stock of $2,000, divided into 20 common shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company will be at 604 St-John Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11276-55) J.A.Houle Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May 1955, incorporating: J.Adélard Houle, Bruno Pellerin, merchants, of Shawinigan Falls, Lionel Pellerin, merchant, Rolande Lacroix, stenographer, fille majeure, and Roger Deshaies.advocate, of Grand'Mère, all of the judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture, glassware, china-ware, plastics, kitchen appliances and other objects of a domestic utility, under the name of \"J.A.Houle Ltée\", with a total capital stock of $150,000, divided into 1,000 common shares $100 each and 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Shawinigan Falls, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, tin's thirteenth day of May 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11319-55) Jean-Talon Automobile Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of May, 1955.incorporating: Lucien Brais, accountant, Joseph-Paul-Léon Rivard, insurance broker and Warry Ward, salesman, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on in all its specialties the business selling automobiles and dealing in services pertaining thereto under the name of \"Jean-Talon Automobiles Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.\u2022 Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May 1955.P.FRENETTE, 40252 Acting Deputy Attorney General.' (A.G.10761-55) La Chambre de Commerce de Terrebonne Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Louis-Phillipe De Serres, salesman, Jean-Paul Legris, accountant, 2124 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 nand Champagne, acheteur, tous de Terre-bonne, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Travailler au bien-être économique, civique et social de la ville de Terrebonne et au développement de ses ressources, sous le nom de \"La Chambre de Commerce de Terrebonne\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $10,000.Le siège social de la corporation sera au Centre Civique, rue St-Pierre, Terrebonne, district ju-juciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procurcur général, 40252-o C.E.CANTIN.(P.G.11519-55) La Chambre de Commerce du Cap de la Madeleine Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize juin, 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Paul Dupuis, journaliste, Orner Boivin, entrepreneur, et Louis-Charles Labissonnière, professeur, tous du Cap-de-la-Madeleine, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Maintenir, développer et promouvoir les relations commerciales, sociales et culturelles des membres de la corporation, ainsi que de la communauté des citoyens du Cap-de-la-Madcleine, sous le nom de \"La Chambre de Commerce du Cap de la Madeleine Inc.\".Le montant auquel soiit limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $20,000.Le siège social de la corporation sera au Cap-de-la-Madeleine, district judiciaire des Trois-Ptivières.Daté du bureau du Procureur général, le seize juin 1955.L'Assistant-procurcur général, 40252-o C.E.CANTIN.(P.G.11153-55) Lafrenière Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation: Adrienne Lafrenière, Claire Laurin et Gisèle Lauzon, sténographes, filles majeures, des cité etdistrict judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de brûleurs à l'huile et autre appareils du même genre, sous le nom de \"Lafrenière Inc.\", avec un capital total de $50,000, divisé en 2,500 actions communes de $10 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2722, Boulevard Rosemont, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur .général, le treize mai 1955.L'Assistant-procurcur général, 40252-o C, E.CANTIN.and Fcrnand Champagne, purchaser, all of Terrebonne, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To work for the economical, civic and social welfare cJ the town of Terrebonne and for the development of its resources, under the name of \"La Chambre de Commerce de Terrebonne\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at Civic Center, St-Peter Street, Terrebonne, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11549-55) La Chambre de Commerce du Cap de la Madeleine Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of June, 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Paul Dupuis, journalist, Omer Boivin, contractor and Louis Charles Labissonnière, professor, all of Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: Maintain, develop and promote a commercial, social and cultural relationship between the members of the corporation as well as good followship among the citizens of Cap-de-la-Madeleine, under the name of \"La Chambre de Commerce du Cap de la Madeleine Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will be at Cap-de-la-Madcleine, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of June, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11153-55) Lafrenière Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1955, incorporating: Adrienne Lafrenière, Claire Laurin and Gisèle Lauzon, stenographers, spinsters, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in oil burners and other apparatus of the same kind, under the name of \"Lafrenière Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 2,500 common shares of $10 each and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the.company will be at 2722 Rosemount Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, 4his thirteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2125 (P.G.11353-55) La Mode Hat Mfg.Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et unième jour de mai 1955, constituant en corporation: Moses Feigcnbaum, avocat, Louis Gerald Ptack et David Ptack manufacturiers, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire de commerce de chapeaux pour dames, granitures, boutons, dentelles, textile et produits d'icelui, sous le nom de \"La Mode Hat Mfg.Co.Ltd.\", avec un capital total de 820,000 divisé en 200 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt et unième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11377-55) Laphkas Bowling Academy Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huitième jour de mai 1955, constituant en corporation: Constantine Laphkas, étudiant Demetrius Laphkas et Georges Laphkas, commis, tous de ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une salle de jeu de quilles et de billards, sous le nom de \"Laphkas Bowling Academy Ltd.\", avec un capital total de 840,000 divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 57 ouest, rue St-Jacques, chambre 401, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-huitième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11307-55) LaSallc Heights Inc.Avis est donné qu'en vertu tie la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingtième jour de mai 1955, constituant en corporation: Moses Samuel Yelin, avocat, Anna Mikula et Esther Monson, secrétaire, filles majeures et usant de leurs droits, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: / Exercer le commerce d'une compagnie de logements à dividende limitée, sous le nom de \"La-Salle Heights Inc.\", avec un capital total de $500,000 divisé en 5,000 actions d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingtième jour de mai 1955.L'Assistant-procurcur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11713-55) Le Club Boréal Saguenay, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a (A.G.11353-55) La Mode Hat Mfg.Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1955, incorporating: Moses Feignebaum, advocate, Louis Gerald Ptack and David Ptack, manufacturers, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in ladies' hats, trimmings, buttons, laces, textiles and textile products, under the name of \"La Mode Hat Mfg.Co.Ltd.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 200 shares of 8100 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first dav of Mav, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11377-55) Laphkas Bowling Academy Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of May, 1955, incorporating: Constantine Laphkas, student, Demetrius Laphkas and Georges Laphkas, clerks, all of the town of Mount Royal, judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate a bowling academy and pool room business in all its branches, under the name of \"Laphkas Bowling Academy Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 57 St.James St.West, Room 401, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteeenth dav of Mav, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11307-55) LaSallc Heights Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1955.incorporating: Moses Samuel Yelin, advocate, Anna Mikula and Esther Monson, secretaries, filles majeures et usant de leurs droits, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a limited dividend housing company, under the name of \"LaSalle Heights Inc.\", with a total capital stock of $500.000, divided into 5,000 shares of the par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of Mav, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11713-55) Le Club Boréal Saguenay, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 2126 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt juin 1955, constituant en corporation: Claude Aubin, avocat, Robert Larouche, marchand, J.-Uldéric Bergeron, électricien, et Jean-Paul Clouticr, commis, tous d'Arvida, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce de présentation de spectacles sportifs, musicaux et théâtraux, sous le nom de \"Le Club Boréal Saguenay, Inc.\", avec un capital total de SI,000, divisé en 1,000 actions de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Arvida, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le vingt juin 1955.L' Assist ai î t-p rocu reu r général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11285-55) Les Entreprises du Parc Ste-Foy, Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingtième jour de mai 1955, constituant en corporation: Raymond DeRosa, courtier en immeubles, Jean-Charles Cantin, avocat, et Thérèse Ringuet, célibataire, fille majeure, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Acquérir des terrains ou intérêts en iceux*.ériger des bâtisses et faire le commerce de matériaux de construction, sous le nom de \"Les Entreprises du Parc Ste-Foy, Ltée\", avec un capital-actions divisé en 400 actions sans valeur nominale ou au pair.Lç siège social de la compagnie sera à Ste-Foy, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce vingtième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11331-55) Les Immeubles Bertri Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze mai 1955, constituant en corporation: Berthold Brisebois, publiciste, de Ville Saint-Laurent, Henri Rodrigue, notaire, et Tonico Calandrini, commis, ces deux derniers de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Les Immeubles Bertri Inc.\", avec un capital total de S50.000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 689, Blvd Gouin, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252-O P.FRENETTE.(P.G.11337-55) Madison Mining Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of June 1955, incorporating: Claude Aubin, advocate, Robert Larouche, merchand, J.Uldé-ric Bergeron, electrician, and Jean Paul Cloutier, clerk all of Arvida, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on the business of athletic, musical and theatrical entertainment, under the name of \"Le Club Boréal, Saguenay, Inc.\", with a total capital of $1,000, divided into 1,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Arvida, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of June 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11285-55) Les Entreprises du Parc Ste-Foy, Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have'been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1955, incorporating: Raymond DeRosa, real estate broker, Jean-Charles Cantin, advocate, and Thérèse Ringuet, single, of full age, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To acquire lands or interest therein; to erect buildings and to deal in building materials,* under the name of \"Les Entreprises du Parc Ste-Foy, Ltée\", with a capital stock divided into 400 shares having no nominal or par vlue.The head office of the company will be at Ste-Foy, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11331-55) Les Immeubles Bertri Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May 1955, incorporating: Berthold Brisebois.publiciste, of the Town of Saint Laurent.Henri Rodrigue, notary, and Tonino Calandrini, clerk, the two latter of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Les Immeubles Bertri Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 250 common shares of a par value of $100 each and 250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 689 Gouin Boulevard, East, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May 1955.P.FRENETTE, 40252 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11337-55) Madison Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2127 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treize mai 1955, constituant en corporation: John E.Gauld, administrateur de mine, Lily Ship, secrétaire, fille majeure et Samuel J.Smiley, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Madison Mining Corporation\" (No Personal Liability), avec un capital total de $4,000,000 divisé en 4,000,000 d'actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252 P.FRENETTE.(P.G.11203-55) Maison Fred Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treizième jour de mai 1955, constituant en corporation: Moses Samuel Yelin, avocat, Anna Mikula, Esther Monson et Micheline Bertrand, secrétaires, filles majeures usant de leurs droits, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'articles vestimentaires, bijouterie, accessoires de maison, fournitures, dispositifs, marchandises électriques et effets domestiques, sous le nom de \"Maison Fred Inc.\", avec un capital total de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hull, district judiciaire de Hull.Daté du bureau du Procureur général, ce treizième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252 P.FRENETTE.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1955, incorporating: John E.Gauld, mine executive, Lily Ship, secretary, spinster of the full age of majority, and Samuel J.Smiley, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Madison Mining Corporation\" (No Personal Liability), with a total capital stock of $4,000,-000, divided into 4,000,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of Mav, 1955.P.FRENETTE, 40252-O Acting Deputy Attorney General.(A.G.11203-55) Maison Fred Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1955, incorporating: Moses Samuel Yelin, advocate, Anna Mikula, Esther Monson, and Micheline Bertrand, secretaries, filles majeures usant de leurs droits, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in wearing apparel, jewellery, household equipment, furniture, appliances, electrical goods and household effects under the name of \"Maison Fred Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each and into 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Hull, judicial district of Hull.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1955.P.FRENETTE, 40252-O Acting Deputy Attorney General.(P.G.11313-55) Maison Irene Shops Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze mai 1955, constituant en corporation: Marcus Meyer Sperber, avocat et conseil en loi de la Reine, de Westmount, Murray Lapin, avocat, de Hampstead et Morris Weiner, avocat, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de vête-, monts et chaussures, sous le nom de \"Maison Irene Shops Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1309 est, rue Ste-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252 P.FRENETTE.(A.G.11313-55) Maison Irene Shops Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1955, incorporating: Marcus Meyer Sperber, advocate and Queen's Counsel, of West-mount, Murray Lapin, advocate, of Hampstead, and Morris Weiner, advocate, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and shoes, under the name of \"Maison Irene Shops Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each and into 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at 1309 St.Catherine Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of May, 1955.P.FRENETTE, 40252-O Assistant Deputy Attorney General. 2128 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 (P.G.11273-55) Maplewood Inn, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douzième jour de mai 1955, constituant en corporation: Charles William Leslie, Daniel Do-heny et David MacKenzie, avocat, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, sous le nom de \"Maplewood Inn, Ltd.\", avec un capital total de 8100,000 divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Arundel, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, -10252 C.E.CANTIN.(P.G.11335-55) Mi H work & Lumber Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1955, constituant en corporation : Jean Marinier, marchand de bois, Lucille Cardinal Marinier, ménagère, épouse dudit Jean Marinier et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, de Montréal, et Alfred St-Yves, vendeur, de Pont-Viaux, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce du bois, sous le nom de \"Millwork & Lumber Company Limited\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2a, rue St-Antoine, Saint-Martin, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11310-55) Morier Construction Ltée, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation: Jacques Morier, entrepreneur, Daniel Morier, industriel et Fabien, Lussier, ingénieur, tous de Saint-Jean-Baptiste, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Morier Construction Ltée, Ltd.\", avec un capital total de 875,000, divisé en 750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean-Baptiste, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11204-55) .Nova Agencies Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date (A.G.11273-55) Maplewood Inn, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of May, 1955, incorporating: Charles William Leslie, Daniel Doheny and David MacKenzie, advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate hotels, under the name of \"Maplewood Inn, Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Arundel, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O .Deputy Attorney General.(A.G.11335-55) Millwork & Lumber Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1955, incorporating: Jean Marinier, wood merchand, Lucille Cardinal Marinier, housewife, wife of the said Jean Marinier and duly authorized by him for these present purposes, of Montreal, and Alfred St-Yves, salesman, of Pont-Viau, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the lumber business under the name of \"Millwork & Lumber Company Limited\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 2a, St-Antoine St., Saint-Martin, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-first day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11310-55) Morier Construction Ltée, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1955, incorporating: Jacques Morier, contractor, Daniel Morier, industrialist, and Fabien Lussier, engineer, all of Saint-Jean-Baptiste, judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes : To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Morier Construction Ltée, Ltd.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 750 shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Jean-Baptiste, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11204-55) Nova Agencies Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the four- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2129 du quatorze mai 1955, constituant en corporation: Jacques Lefebvre, Gilbert Perras, tous deux vendeurs, des cité et district judiciaire de Montréal, et Rolande Cantin, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens de Henri Chapleau, de L'Epiphanie, district judiciaire de Joliette, pour les objets suivants: Exercer le commerce de tissus, sous le nom de \"Nova Agencies Limited\", avec un capital total de 810,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-o C.E.CANTIN.(P.G.11236-55) Novelty & Party Goods Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mai 1955, constituant en corporation: René Salette, Paul-Emile Lefebvre, industriels, Marcelle Leborgne, épouse dudit René Salette, Maria Laroche, épouse dudit Paul-Émile Lefebvre, ces deux dernières ménagères et contractuellement séparées de biens de leurs époux et dûment autorisées par eux aux fins des présentes, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce d'articles de nouveautés, sous le nom de \"Novelty & Party Goods Company Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1415, rue Bélanger, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-o C.E.CANTIN.(P.G.11183-55) Orner Laurin & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-huit mai 1955, constituant en corporation: Guy LaGarde, agent d'assurances, J.Albert Landry, comptable, et DesNeiges Lalle-ment, tous de Lachute, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Omer Laurin & Fils Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lachute, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252-O P.FRENETTE.(P.G.11091-55) Payette & Payette Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la teenth day of May 1955, incorporating: Jacques Lefebvre, Gilbert Perras, both salesmen, of the city and judicial district of Montreal, and Rolande Cantin, housewife, wife contractually separate as to property of Henri Chapleau, of L'Epiphanie, judicial district of Joliette, for the following purposes: To deal in fabrics, under the name of \"Nove Agencies Limited\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN.40252 Deputy Attorney General.(A.G.11236-55) Novelty & Party Goods Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May 1955, incorporating: René Salette, Paul Emile Lefebvre, industrialists, Marcelle Leborgne, wife of the said René^ Salette, Marie Laroche, wife of the said Paul Emile Lefebvre, the two latter, housewives, and contractually separate as to property from their husbands and duly authorized by them for the purposes herein, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in novelties, under the name of \"Novelty & Party Goods Company Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 1415 Bélanger Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN.40252 Deputy Attorney General.(A.G.11183-55) Omcr Laurin & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of May, 1955, incorporating: Guy Lagarde, insurance agent, J.Albert Landry, accountant, and DesNeiges Lallement, all of Lachute, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To carry on a business of general contractors under the name of \"Omer Laurin & Fils Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of par value of $100 each and into 200 preference shares of par value of $100 each.The head office of the company will be at Lachute, judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of May, 1955.P.FRENETTE, 40252 Acting Deputy Attorney General.(A.G.11091-55) ' Payette & Payette Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- 2130 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 province de Québec des lettres patentes, en date du dix-sept mai 1955, constituant en corporation: Georges H.Payette, Jacques Payette, imprimeurs et Hélène Payette, comptable, fille majeure usant de ses droits, tous de Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs et éditeurs, sous le nom de \"Payette & Payette Incorporée\", avec un capital total de $100,000, divisé en 500 actions ordinaires de $100 chacune et en 500 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11344-55) Piccolo & Malnis Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt et unième jour de mai 1955, constituant en corporation: Albert Malouf, Peter Shor-teno, avocats, de ville Mont-Royal et John Ciaccia, étudiant, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir des terrains ou intérêts en iceux; faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Piccolo & Malnis Construction Co.Ltd.\", avec un capital total de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 8990 rue St-Urbain, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt et unième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11410-55) Polytechnos Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt et un mai 1955, constituant en corporation: Jean Miquelon, avocat et conseil en Loi de la Reine, Charles Edward Gibson, agent, et Yvette Picard, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de meubles, sous le nom de \"Polytechnos Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 500 actions communes d'une valeur au pair de $1 chacune et en 195 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 370, rue Rachel, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11579-55) Quebec Wood Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ince of Quebec, bearing date seventeenth day of May, 1955, incorporating: Georges H.Payette, Jacques Payette, printers and Hélène Payette, accountant, spinster in use of her rights, all of Saint-John, judicial district of Iberville, for the following purposes: To operate and carry on business as printers and editors under the name of \"Payette & Payette Incorporée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 500 common shares of $100 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Saint-John, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11344-55) Piccolo & Malnis Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1955, incorporating: Albert Malouf, Peter Shorteno, advocates, of the town of Mount Royal, and John Ciaccia, student, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire lands or interests therein; to deal in real estate, under the name of \"Piccolo & Malnis Construction Co.Ltd.\", with a total capital stock, of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 8990 St.Urbain Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11410-55) Polytechnos Inc.Notice is hereby given that under Part I of hre Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-first day of May, 1955, incorporating: Jean, Miquelon, advocate and Queen's Counsel, Charles Edward Gibson, agent, and Yvette Picard secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture, under the name of \"Polytechnos Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 500 common shares of a par value of $1 each and into 195 preference shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 370 Rachel Street-East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11579-55) Quebec Wood Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2131 province tie Québec, «les lettres patentes en «late «lu huitième jour «le juin, 1955, constituant en corporation: Kenneth Albert Wilson, avocat et Conseil en Loi tie la Reine, Kenneth Hunter Wilson, avocat, et Helen Hague, gérant de bureau, fille majeure, tous des cité et tlistrict judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de bois et le négoce de bois dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Quebec Wood Industries Ltd.\", avec un capital total de $1,500,000 «livisé en 1.000,000 d'actions ordinaires tl'une valeur au pair «le $1 chacune et 100,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $5 chacune.Le siège social tie la compagnie sera à Montréal, district judiciaire tie Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour tie juin 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11405-55) Recollet Development Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie tie la Loi ties compagnies tie Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur tie la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinquième jour tie mai 1955, constituant en corporation: Donald Kujan, étudiant, Leona Green, teneuse tie livres, fille majeure et Michael Ettinger, commis, tous des cité et district judiciaire tie Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom «le \"Recollet Development Inc.\", avec un capital total tie $40,000 divisé en 100 actions ordinaires tl'une valeur au pair tie $100 chacune et 300 actions privilégiées tl'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-cinquième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252 C.E.CANTIN.(P.G.11262-55) Service Central des Achats Inc.Avis est donné qu'en vertu tie la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province tie Québec ties lettres patentes, en tlate du quatorze mai 1955, constituant en corporation: Paul-André Founder, L.Petl., professeur, de Sainte-Foy, Albert Guay, comptable, tie Québec, Lionel Lafrance, B.S.A., employé civil, de Château-d'Eeau, tous «lu tlistrict judiciaire «le Québec, André Breton, marchand général, de Saint-Jean-de-la-Lande, district judiciaire de Beauce, et Auguste Scott, M.S.A., professeur de Sainte-Annc-de-la-Pocatière, district jutli-ciaire tie Kamouraska, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de fournitures et accessoires d'écoles et de bureaux, sous le nom de \"Service Central ties Achats Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires tie $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, tlistrict judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252-o P.FRENETTE.ince of Quebec, bearing tlate the eighth day of June, 1955, incorporating: Kenneth Albert Wilson, advocate ami Queen's Counsel, Kenneth Hunter Wilson, advocate, and Helen Hague, office manager, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of lumbering and the lumber trade in all its branches, under the name of \"Quebec Wood Industries Ltd.\".with a total capital stock of $1,500,000, divided into 1,000,000 confmon shares of the par value of $1 each and into 100,000 preferred shares of the par value of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial tlistrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of June, 1955.C.E.CANTIN, 40252-o Deputy Attorney General.(A.G.11405-55) \u2022 Recollet Development Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing «late the twenty-fifth day of May, 1955, incorporating: Donald Kujan, student, Leona Green, bookkeeper, spinster, and Michael Ettinger, clerk, all of the city ami judicial tlistrict of Montreal, for the following purposes: To «leal in real estate, under the name of \"Recollet Development Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares having a par value of $100 each and into 300 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fifth dav of Mav, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(A.G.11262-55) Service Central des Achats Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of May.1955, incorporating: Paul-André Fournier, L.Ped., professor, of Sainte-Roy, Albert Guay, accountant, of Quebec, Lionel Lafrance, B.S.A., civil employee of Château «l'Eau, all of the jmlicial tlistrict of Quebec, André Breton, general merchant, of Saint-Jean-de-la-Lande, judicial tlistrict of Beauce, and Auguste Scott, M.S.A., professeur, of Sainte-Anne-dc-la-Pocatière, judicial district of Kamouraska.for the following purposes: To manufacture an«l «leal in supplies and accessories for schools and offices, under the name of \"Service Central des Achats Inc.\".with a total capital stock, of $40,000.divided into 300 common shares of $100 each and into 100 preferred shares of $100 each.The hea«l office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this Fourteenth dav of Mav, 1955.\" P.FRENETTE, 40252 Acting Deputy Attorney General. 2132 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 juillet 1955, Tome 87, N° 28 (P.G.11136-55) Service Social de Porliicuf Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies' de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-quatre mai 1955, constituant en corporation sans capital-actions: Désiré Chabot, prêtre curé, de Saint-Ubald, Jean-Baptiste Tremblay, prêtre, curé, de Donnacona, Paul Sylvain 'fessier, chirurgien-dentiste, de Saint-Casimir, et Andréa St-Pierre.agronome, de Des-chambault, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Offrir aux individus et aux familles aux prises avec des problèmes d'adaptation sociale, des services professionnels d'assistance et de traitement, sous le nom de \"Service Social de Portncuf.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 8100,000.Le siège social de la'Corporation sera à Donnacona, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre mai 1955.L'Assistant-procureur général, 40252-O C.E.CANTIN.(P.G.11305-55) Shacter Woollens Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des letttres patentes en date du dix-septième jour de mai 1955, constituant en corporation: David Goodman, avocat, de Hampstead, Neil Phillips, avocat, de Westmount, et Yvonne Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de tissus et produits de tissus, sous le nom de \"Schacter Woolens Inc.\", avec un capital total de 8200,000 divisé en 100 actions ordinaires de S100 chacune et 1,900 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252 P.FRENETTE.(P.G.11267-55) .Si m i Electrique Compagnie Limitée Simi Electric Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize mai 1955, constituant en corporation: Marcel-G.Robitaille, avocat, Andrée Bourdon, secrétaire, fille majeure, tous deux de Montréal, et Marin Dion, avocat, d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'appareils et d'accessoires électriques, sous le nom de \"Simi Électrique Companic Limitée \u2014 Simi Electric Company Limited\", avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252-O P.FRENETTE.(A.G.11136-55) Service Social de Portncuf Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fourth day of May, 1955, to incorporate as a corporation without share capital: Désiré Chabot, priest,.pastor, of Saint-Ubald, Jean-Baptiste Tremblay, priest, pastor of Donnacona, Paul-Sylvain Tessier, surgeon-dentist of Saint-Casimir, and Andrea St-Pierrè, agronomist, of Descham-bault, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To offer individuals and families who have social adaptation problems, the services of professional assistance and treatment under the name of \"Service Social de Portncuf\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8100.000.The head office of the corporation will be at Donnacona, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of Mav.1955.C.E.CANTIN, 40252 Deputy Attorney General.(A.G.11305-55) Shactcr Woollens Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventeenth day of May, 1955, incorporating: David Goodman, advocate, of Hampstead, Neil Phillips, advocate, of Westmount, and Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montreal, all.of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in fabrics and fabrics products, under the name of \"Schactor Woollens Inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 100 common shares of 8100 each and into 1,900 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May, 1955.P.FRENETTE, 40252-o Acting Deputy Attorney General.(A.G.11267-55) Simi Electrique Compagnie Limitée Simi Electric Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May 1955, incorporating: Marcel G.Robitaille, advocate, Andrée Bourdon, secretary, fille majeure, both of Montreal, and Maria Dion, advocate, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of electrical apparatus and appliances, under the name of \"Simi Electrique Compagnie Limitée \u2014 Simi Electric Company Limited\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of May, 1955.P.FRENETTE, 40252 Acting Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2133 (P.G.11408-55) Studios de Danse de Québec Ltée Quebec Dance Studios Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-huitième jour de mai 1955, constituant en corporation: Maurice Gagné, C.R., Cécile McGee, comptable, tous deux de Québec, Julien Chouinard, avocat, et Eliette Dionne, secrétaire, de Sillery, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Posséder et exploiter des écoles et studios de danse, sous le nom de \"Studios de Danse de Québec Ltée \u2014 Quebec Dance Studios Ltd.\", avec un capital-actions divisé en 400 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-huitième jour de mai 1955.L'Assistant-procurcur général, 40252 C.E.CANTIN.(A.G.11408-55) Studios de Danse de Québec Ltée Quebec Dance Studios Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of May, 1955, incorporating: Maurice Gagné, Q.C., Cécile McGee, accountant, both of Quebec, Julien Chouinard, advocate, and Êliette Dionne, secretary, of Sillery, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To own and operate dancing schools and studios, under the name of \"Studios de Danse de Québec Ltée \u2014 Quebec Dance Studios Ltd.\", with a capital stock divided into 400 shares without nominal or par value.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of May, 1955.C.E.CANTIN, 40252-O Deputy Attorney General.(P.G.11259-55) Trend Agencies Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingtième jour de mai 1955, constituant en corporation: Hilda Hooper, secrétaire, Guy Laferté, notaire, tous deux de Montréal, et Wm.Johnston, notaire, de Lachine, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités, le commerce de courtiers d'assurances, sous le nom de \"Trend Agencies Limited\", avec un capital total de 810,000 divisé en 1,000 actions d'une valeur nominale ou au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingtième jour de mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252 P.FRENETTE.(A.G.11259-55) Trend Agencies Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of May, 1955, incorporating: Hilda Hooper, secretary, spinster, Guy Laferté, notary, both of Montreal, and Wm.Johnston, notary, of Lachine, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on in all its branches the business of Insurance brokers, under the name of \"Trend Agencies Limited\", with a total capital stock of 810,000, divided into 1,000 shares with a nominal or par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1955.P.FRENETTE, 40252-O Assistant Deputy Attorney General.(P.G.11235-55) Vélodrome Métropolitain, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize mai 1955, constituant en corporation: Marc Lacost, c.r., avocat d'Outremont, Georges Brodeur, vendeur, et Florent Jodoin, menuisier, des deux derniers de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des pistes, enceintes, bâtisses, stades pour le sport en général, sous le nom de \"Vélodrome Métropolitain Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252-o P.FRENETTE.(A.G.11235-55) Vélodrome Métropolitain, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of May, 1955, incorporating: Marc Lacoste, Q.C., advocate, of Outremont, Georges Brodeur, salesman, and Florent Jodoin, carpenter, the two latter of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate race-tracks, rings, buildings, stadiums for sports generally, under the name of \"Vélodrome Métropolitain, Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and 350 preferred shares of $100 each.The bead office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of Montreal, 1955.P.FRENETTE, 40252 Acting Deputy Attorney General. 2134 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 (P.O.11339-55) Versailles Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treize mai 1955, constituant en corporation: Jean Jobin, gérant, Max Seigler, Berthold Siver-man, courtiers d'assurances, et Roger Bèaulieu, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Versailles Investments Inc.\", avec un capital-actions divisé en 1,000 actions sans valeur nominale ou au pair et 950 actions privilégiées de $100 chacune.% Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize'mai 1955.L'Assistant-procureur général suppléant, 40252 P.FRENETTE.Action en séparation de corps et de biens Canada.Province de Québec, district de Québec, (our Supérieure, N° 79-545.Dame Bernadette Champagne, épouse de Rodolphe Bureau, domiciliée à 20, rue Garneau, Québec, dûment autorisée à rester en justice, demanderesse, vs ledit Rodolphe Bureau, défendeur.Une action en séparation de biens et de corps a été instituée en cette cause le 29e jour de juin 1955.Québec, le 11 juillet 1955.Les Procureurs de la demanderesse, LAPOINTE, DESRIVIÈRES & BÊRUBÉ.40272-O Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 727 Québec, le iS juillet 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"D\" Concernant la prolongation du droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le droit de prélèvement du Comité conjoint des métiers de la construction de Montréal, autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro (527-G du 17 juin 1954, soit prolongé jusqu'au 1er septembre 1955.aux mêmes tnux et conditions.L.DÉSILETS, 40267-o Greffier du Conseil Exécutif.(A.G.11339-55) Versailles Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of May, 1955, incorporating: Jean Jobin manager.Max Seigler, Bcrthold Siverman, insurance brokers, and Roger Beaulieu, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Versailles Investments Inc.\", with a capital stock divided into 1,000 shares having no nominal or par value and 950 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of Mav, 1955.P.FRENETTE, 40252-O Acting Deputy Attorney General.Action for Separation as to Bed and Board and Property Canada, Province of Quebec, district of Quebec.Superior Court, No.79-545.Dame Bernadette Champagne, wife of Rodolphe Bureau, domiciled at 20, Garneau Street, Quebec, duly authorized to appear in court, plaintiff, vs the said Rodolphe Bureau, defendant.An action for separation of bed and board has been instituted in this case on June 29, 1955.Quebec, July 11.1955.LAPOINTE.DESRIVIÈRES & BÉRUBÊ, Attomevs for the Defendant.40272 Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 727 Quebec, July 0, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"/)\" Concerning an extension of the right to levy of the Building Trades and Joint Committee of Montreal.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour.That the right to levy of the Building Trades Joint Committee of Montreal, authorized by a by-law approved by Order in Council number G27-G of June 17th, 1954, be extended until September 1st 1955, with the same rate and conditions.L.DÉSILETS, 40207-o Clerk of the Executive Council. QUEBEC OFFICIAI, GAZETTE, Quebec, July Kith, 1965, Vol.87, No.28 2135 ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 727 Québec, le 6 juillet 1955.Présent: Ix?Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"/*\"' Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la boîte de carton dans la province de Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de fia convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Comité paritaire de l'Industrie de la Botte de carton de la province de Québec, a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil, des modifications au décret numéro 1884 du 12 novembre 1947, amendé par les arrêtés en conseil numéros 277-B, 422-A, 74S-D, 971-C, 1288-E, 1763-G et 1784-A des 4 et 30 mars.27 mai.30 juin, 29 septembre, 23 et 29 décembre 1948.883-C du 11 août 1949, 108-B du 25 janvier 1950, 120-A du 1er février 1951, 71-A, 412-F et 888-B des 31 janvier.17 avril et 28 août 1952, 80-B et 101-E des 21 et 29 janvier 1953, 101 -B du 10 février 1954.25-A et 101-A des 5 et 26 janvier 1955 relatif à l'industrie de la boîte de carton dans la province de Québec; Attendu que ladite requête a été pubiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 7 mai 1955; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 1884, soit modifié comme suit: 1° Les paragraphes \"6\" et \"c\" de l'article I, sont biffés et remplacés par le suivant: \"b) Juridiction -professionnelle: Le présent décret régit et gouverne tout travail de même nature ou de même genre que celui visé par ce décret.Le travail visé par ce décret comprend celui de toute personne exécutant quelqu'une ou plusieurs des opérations participantes, incidentes ou connexes à la fabrication des boîtes de carton, des boîtes faites d'imitation de bois, faites en parties ou finies avec papier, fivre, bois, ou carton et de toute autres boîtes à base de pulpe ou papier non gaufré, sans égard à la couverture extérieure, que lesdites opérations soient effectuées en totalité ou en partie par le même employeur ou par plusieurs employeurs, qu'elles soient effectuées en totalité ou en partie dans un ou plusieurs ateliers spécialisés, entreprises privées, industrielles ou commerciales ou dans tout autre établissement, qu'elles constituent le commerce principal de l'employeur ou noient secondaires ou complémentaires à tout autre commerce ou occupation, et que lesdites boîtes soient fabriquées pour fins de vente à d'autres consommateurs ou exclusivement pour la propre consommation de l'employeur.Sans limiter la généralité des termes du paragraphe précédent, le formage et l'assemblage des boîtes de carton sont des opérations comprises dans la juridiction professionnelle de ce décret.Toutefois, le présent décret ne régit pas la fabrication des boîtes de carton gaufré.\" 2° Les opérations suivantes sont ajoutées aux paragraphes \"a\" et \"d\" de l'article III: ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 727 Quebec, July 6, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"E\" Concerning amendments of the decree relating to the paper box industry in the province of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941.chapter 163 and amendments) the Joint Committee of the Paper Box Industry of the Province of Quebec has petitioned the Minister of Labour to submit to the approval and decision of the Lieutenant-Governor in Council some amendments to the decree No.1884 of November 12th.1947, as amended by Orders in Council Nos.277-B.422-A, 748-D, 971-C, 1288-E, 1763-G and 1784-A.of March 4th and 30th, Mav 27th, June 30th, September 29th, December 23rd and 29th.1948, 883-C of August 11th, 1949.108-B of January 25th, 1950, 120-A of February 1st 1951, 71-A.412-F and 888-B of January 31st.April 17th and August 28th, 1952, 80-B and 101-E of January 21st and 29th, 1953, 101-B of February \"10th, 1954, 25-A and 101-A of January 5th and 26th, 1955, relating to the paper box industry in the province of Quebec; Whereas the said petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of May 7, 1955; Whereas no objection has been made against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour.That the said decree.No.1884, be amended as follows: 1.Subsections \"b\" and \"c\" of section I arc deleted and replaced by the following: \"b) Professional jurisdiction: The present decree governs and rules any work of the same nature or kind as that contemplated by this decree.The work contemplated by this decree comprises the work of all persons performing any 'or many of the operations being part of, related to or connected with the manufacturing of paper boxes, of wood imitation boxes, partly made or completed with paper, fibre wood or cardboard and of all other pulp or paper boxes made of uncorrugated material, regardless of exterior covering, whether said operations are performed completely or in part by the same employer or by several employers, whether they are performed completely or in part in one or several trade plants, private, industrial, commercial or any other establishments, whether such operations constitute the principal business of the employer or are accessory or complementary to any other business or enterprise, and whether the said boxes \"are manufactured for the purpose of sale to other consumers or for the exclusive use of the employer.Without limiting the generality of the preceding paragraph, the forming and assembling of these boxes are operations comprised in the professional jurisdiction of this decree.However, the present decree does not apply to manufacturing of corrugated paper boxes.\" 2.The following operations are added to section III, subsections \"a\" and \"d\": 2136 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 \"a) Salariées, (Femmes) \u2014 (Female) employees: Zone Département des boîtes rigides \u2014 Set-up Box Department: I II Mécanicienne, machine à assembler ou former les boîtes \u2014 Box assembling or forming machine operator.$0.75 $0.71 Fileuse, machine auto, à assembler ou former les boîtes \u2014 Feeder, Auto Box assembling or forming machine.0.71 0.67 Département des boîtes pliantes \u2014 Folding Box Department: Mécanicienne, machine à assembler ou former les boîtes \u2014 Box assembling or forming machine operator.0.75 0.71 Fileuse, machine auto, à assembler ou former les boîtes \u2014 Feeder, auto box assembling or forming machine.0.71 0.67\" \"d) Salariés, (Hommes) \u2014 (Male) employees: Département des boîtes rigides \u2014 Set-up Box Department: Mécanicien» machine à assembler ou former les boîtes \u2014 Box assembling or forming machine operator.1.12 1.06 Préposé à la mise en train, machine auto, à assembler ou former les boîtes \u2014 Auto box assembling or forming machine make-ready man.1.30 1.23 Fileur, machine auto, à assembler ou former les boîtes \u2014 Feeder, auto box assembling or forming machine.1.00 0.95 Département des boîtes pliantes \u2014 Folding Box Department: Mécanicien, machine à assembler ou former les boîtes \u2014 Box assembling or forming machine operator.1.12 1.06 Préposé à la mise en train machine auto, à assembler ou former les boîtes \u2014 Auto box assembling or forming machine make ready-man.1.30 1.23 Fileur, machine à assembler ou former les boîtes \u2014 Feeder, auto box assembling ôr forming box machine.1.00 0.95 ' (Document \"E\" annexé à l'arrêté) (Document \"E\" annexed to tlfe order) L.DÉSILETS, L.DÉSILETS, 40267-o Greffier du Conseil Exécutif.40267-o Clerk of the Executive Council.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 727 Québec, le 6 juillet 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Section \"F\" Concernant la prolongation du décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le décret numéro 1021 du 10 septembre 1953 et amendements, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal, soit prolongé jusqu'au 1er septembre 1955.(Document \"F\" annexé à l'arrêté) L.DÉSILETS, 40267-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 728 Québec, le 6 juillet 1955.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant une convention collective de travail relative à la fabrication des boîtes de carton gaufré dans la province de Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 727 Quebec, July 6, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"F\" Concerning an extension of the decree relating to the construction industry and trades in the region of Montreal.It is ordered, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour.That the decree No.1021 of September 10th, 1953, and amendments, relating to the construction industry and trades in the region of Montreal, be extended until September 1st, 1955.(Document \"F\" annexed to the order) L.DÉSILETS, 40267-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 728 Quebec, July 6th, 1955.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning a collective labour agreement relating to the manufacturing of corrugated paper boxes in the Province of Quebec* Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties hereafter mentioned have submitted to the Minister of Labour a petition to render obligatory the collective labour agreement entered into between: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol 87, No.28 2137 D'une part: On the one part; \"Canadian Wirebound Boxes Limited; Cham- \"Canadian Wirebound Boxes Limited; Champlain Paper Box Limited, section papier gaufré plain Paper Box Limited, Corrugated Paper de Québec; Hinde & Dauch Paper Company Division of Quebec; Ilindc & Dauch Paper of Canada Limited; Shipping Containers Lim- Company of Canada Limited; Shipping Cohtai-ited; Standard Paper Box Mfg., Limited, sec- ners Limited; Standard Paper Box Mfg.Limited, tion papier gaufré;\" Corrugated Paper Division\".Et, d'autre part: And, on the other part: \"L'Association des Employés de Canadian \"The Canadian Wirebound Boxes Limited Wirebound Boxes Limited; Le Syndicat Catho- Employees' Association; Le Syndicat Catholique lique de la Boîte de carton de Québec Inc.; de la Boîte de Carton de Québec, Inc.; L'Union L'Union Fédérale des Travailleurs du Conte- Fédérale des Travailleurs du Contenant, local nant, local numéro 415, affiliée au Congrès des No.415, affiliated to the Trades and Labour Métiers et du Travail du Canada; L'Union des Congress of Canada; L'Union des Travailleurs Travailleurs du Carton et Papier Façonnés du Carton et Papier Façonnés (C.T.C.C.)\" (C.T.C.C.)\" for the employers and the employees of the indus- pour les employeurs et les salariés de l'industrie try and occupations concerned, according to the et des occupations visées, suivant les conditions conditions described in the Quebec Official Gazette, décrites dans la Gazette officielle de Québec, issue of May 7th, 1955; édition du 7 mai 1955; Attendu que les dispositions de ladite con- Whereas the provisions of the said petition vention orit acquis une signification et une im- have acquired a preponderant significance and portanec prépondérantes pour l'établissement importance for the establishing of working con- des conditions de travail dans l'industrie et les ditions in the industry and trades concerned and occupations visées et dans la juridiction terri- in the territorial jurisdiction indicated in the toriale indiquée dans ladite requête; said petition; Attendu que les prescriptions de la*Loi ont Whereas the provisions of the Act have been été dûment suivies en ce qui touche la publi- duly observed as regards the publication of no-cation des avis; tices; Attendu Qu'aucune objection n'a été for- Whereas no objection has been made against mulée contre l'approbation de ladite requête; the approval of the said petition; Il est ordonné, en conséquence, sur la pro- It is ordered, therefore, upon the rccommen- position de l'honorable Ministre du Travail: dation of the Honourable Prime Minister: Que ladite requête soit acceptée conformé- That the said petition be accepted in pursuance ment aux dispositions de la Loi de la conven- of the provisions of the Collective Agreement tion collective (Statuts refondus de Québec Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 1941, chapitre 163 et amendements) avec, toute- 163 and amendments) with, however, the follow-fois, les nouvelles dispositions suivantes tenant ing new provisions to be substituted for the con-lieu des conditions décrites dans la Gazette offi- ditions described in the Quebec Official Gazette, cielle de Québec, édition du 7 mai 1955.issue of May 7th, 1955.I.Juridiction: a) Juridiction territoriale: La I.Jurisdiction:, a) Territorial jurisdiction: The juridiction territoriale du décret comprend toute territorial jurisdiction of the decree comprises la province de Québec et se divise en deux zones the entire Province of Quebec and is divided into comme suit: ' two zones as follows: Zone I: Toute la province de Québec à l'ex- Zone I: The entire Provinces of Quebec with ceptiori de la cité de Quebec; the exception of the city of Quebec; Zone II: La cité de Quebec.Zone II: The city of Quebec.b) Juridiction industrielle: La juridiction in- b) Industrial jurisdiction: The industrial juris- dustrielle du présent décret comprend la fabri- diction of the present decree comprises the cation des boîtes de carton gaufré et de tous manufacturing of corrugated paper boxes and autres réceptacles entièrement ou partiellement all other containers entirely or partly made of faits de carton gaufré.corrugated paper board.IL Salaires minima: Le salaire minimum des IL Minimum wages: The minimum wages salariés travaillant à la fabrication des articles of all employees working at the manufacturing of inclus dans la juridiction industrielle du présent articles comprised in the industrial jurisdiction décret, de même que celui des mécaniciens de.of the present decree, as well as that of stationary machines fixes, des chauffeurs de bouilloires enginemen, boiler, firemen (stokers), shippers (stokers), des employés préposés à l'expédition, delivery men, maintenance and repair men on à la livraison, à l'entretien ou à la réparation des buildings, machinery and equipment, employees immeubles, des machines et de l'outillage, à doing printing and allied work, provided such l'impression et à des travaux analogues, pourvu printing and other work concern exclusively the que cesdits travaux se rapportent exclusivement printing of boxes and articles included in the à l'impression des boîtes et articles compris dans industrial jurisdiction of the decree, are the la juridiction industrielle du décret, est le sui- following for the respective categories of cm- vant pour chacune des catégories de salariés ployees hereinafter mentioned : mentionnées ci-après: Taux minima Minimum Bates faxes \u2014 Sexes Masculin Féminin \"a) Salariés \u2014 Employees: Male Female Sous-contremaître \u2014 Assistant-foreman.$1.17 $0.93 Machine à gaufrer \u2014 Corrugating Machine: Gaufreur \u2014 Operator.1-30 Gaufroir temporaire \u2014 Temporary Operator.1.20 Découpeur \u2014 Slitter and Knife.:.1.20 Mécanicien de machine à coller \u2014 Double Backer.1.15 Receveur et \"Shafter \"de rouleau \u2014 Tailer & Roll Shafter.1.00 2138 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1(> juillet 19,55, Tome 87, N° 28 Machine à imprimer et à rainer\u2014 Printer-slotter machine: Mécanicien \u2014 Operator.1 20 Assistant-mécanicien \u2014 Assistant operator.1.10 Receveur et fournisseur \u2014 Tailer & Feeder.1.05 Presse à imprimer (sur la longueur) \u2014 Printing Press Machine (long-way): Mécanicien \u2014 Operator.115 Receveur \u2014 Tailer.;.1 \u2022 05 0.78 Machine à rainer \u2014 Grosses boîtes \u2014 barge Box Slotting Machine: Haineur \u2014 Operator.115 Receveur-Tailer.1.00 0.78 Machine à rainer \u2014 Petites boîtes \u2014 Small Box Slotting Machines: Raineui\u2014 Operator*.1 \u2022 05 0.83 Receveur \u2014 Tailer.\\.1 -00 0 78 Machine à découper les boîtes et marqueuse-mitrailleuse (première opération) \u2014 Box Slitting and Scoring Machine (first way): Découpeur \u2014 Operator.112 Receveur \u2014 Tailer.;.1 \u2022 00 Machine à découper les feuilles, marqueuse-mitrailleuse (divers) \u2014 Sheet Slitting and Scoring Machine (Misccllenaous) : Mécanicien \u2014 Operator.1.12 Receveur \u2014 Tailer.1.00 0.78 Machine combinée à découper et à rainer les divisions \u2014 Combination partition Slilter-Slotter: Mécanicien \u2014 Operator.1.10 Receveur \u2014 Tailer.1.00 0.78 Machine simple à rainer les divisions \u2014 Plain Partition Slotter: Raineur \u2014 Operator.f.I -05 0.83 Receveur \u2014 Tailer.; 1.00 0.78 Machine à assembler les divisions \u2014 Partition assembly Machine: Mécanicien \u2014 Operator.1.10 Pournisseuse \u2014 Feeder.0.78 Receveuse \u2014 Tailer.0.78 Machine à découper les pans\u2014 Flap Cutting machine: Découpeur \u2014 Operator.1 \u2022 09 0.83 Receveur\u2014Tailer.1 00 0.78 Machine à plier et à appliquer la toile gommée \u2014 Folder-tapcr: Mécanicien \u2014 Operator.1.18 Receveur et inspecteur \u2014 Tailer & Inspector.0.83 Machine automatique à appliquer la toile gommée \u2014 Automatic Taping machine: Mécanicien \u2014 Operator.1 ¦ 10 Aide \u2014Helper.100 Receveur et inspecteur \u2014 Tailer & Inspector.1.00 0.83 Machine semi-automatique à appliquer la toile gommée \u2014 Semi-Automatic Taper: Mécanicien \u2014 Operator.0.83 Receveur et inspecteur \u2014 Tailer & Inspector.\".0.78 Machine à appliquer la toile gommée à la main \u2014 Hand Taper: Mécanicien \u2014 Operator.0.78 Machine automatique à plier et à piquer\u2014 Automatic Folder-stitcher: Piqueur \u2014 Operator.115 Fournisseur \u2014 Feeder.1.00 Machine semi-automatique à piquer \u2014 Semi-automatic stitching machine: Piqucu r \u2014 Operator.1.05 0.83 Machine à piquer à la main \u2014 Manual Stitching machine: Piqueur \u2014 Operator.> 1.05 0.83 Presse à découper \u2014 Die Press Machine: Découpeur \u2014 Operator.1.15 Aide et éplucheur \u2014 Helper & Stripper.1.00 0.78 Machines non classifiées \u2014 Non-classified machines: Mécanicien \u2014 Operator.1.05 0.83 Fournisseur \u2014 Feeder.0.78 Scie à ruban \u2014 Band Saw : Préposé à la scie à ruban \u2014 Operator.1.00 0.83 Machine à remonter et «à couper (S.F.) \u2014 S.F.Rewinder and cutter: Mécanicien \u2014 Operator.\"1.05 0.83 Receveur \u2014 Tailer.1.00 0.78 Matière adhésives \u2014 Adhesive unit: Préposé à la colle \u2014 Operator.1.10 Aide \u2014Helper.1.05 Presses à rebuts\u2014 Waste Baling press: Presseur \u2014 Operator.1.05 Aide \u2014Helper.100 Manutention de rouleaux \u2014 Roll handling: Premier préposé à la manutention \u2014 Chief roll handler.1.15 Préposé à la manutention motorisée \u2014 Power Roll Handling Operator.1.15 Manutenteur \u2014 Roll handler.1.00 Manutention générale \u2014 Handling general: Préposé au camion-empilleur motorisé \u2014 Powered Lift truck operator.1.15 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 767//.1955, Vol.87.No.28 2139 Pliages de boîtes \u2014 Box Folding: Plieuse \u2014 Folder.0.78 Assemblage et divisions \u2014 Partition assembly: Assembleuse \u2014 Assembler.0.78 Enveloppement et ficelage \u2014 Bundling and tying: Préposé au ficelage \u2014 Tier.1.00 0.78 Expédition \u2014 Shipping Department: Expéd iteu r \u2014 Shipper.1.20 Assistant-expéditeur \u2014 Assistant shipper.1.10 Aide et vérificateur \u2014 Helper & Checker.1.00 Chauffeur de camion \u2014 Truck driver.1.10 Aide pour chauffeur dc camion \u2014 Truck Driver Helper.1.00 Entetien \u2014 Maintenance: Homme de métier \u2014 Tradesman.1.20 Mécanicien \u2014 Mechanic.1.20 Huileur \u2014 Oiler.1.05 Concierge \u2014 Janitor.1.00 Chambre de bouilloires \u2014 Boiler Boom: Mécanicien de machine fixe \u2014 Stationary Engineman: 2èmc classe \u2014 2nd class.1.34 3ème classe \u2014 3rd class.1.24 4ème classe \u2014 4th class.1.14 Travail général \u2014 General Labour: L'échelle de base de salaire pour le travail général est la suivante \u2014 The basic wage scale for General Labour shall be as follows: Premier trimestre \u2014 First three months.0.85 0.70 Deuxième trimestre \u2014 Second tli rce months.0.90 0.73 Après six mois \u2014 After six months.0.95 0.76 b) Salariés (sexe masculin): Nonobstant la b) Male employees: Notwithstanding the prece-cédule de salaires apparaissant au présent arti- ding schedule of wages, the minimum average cle, le salaire minimum moyen fies salariés du wage for male employees shall not be less than sexe masculin ne doit pas être inférieur à 81.05 81.05 per hour.de l'heure.c) Salariés (sexe féminin): Nonobstant la c) Female employees: Notwithstanding thé cédule de salaires apparaissant au présent ar- preceding schedule of wages, the average mini-ticle, le salaire minimum moyen des salariés mum wage for female employees shall not be less du sexe féminin ne doit pas être inférieur «à 80.79 than 80.79 per hour.de l'heure.\" d) Zone II: \\ms taux de salaires minima et les d) Zone II: The minimum rates and minimum moyennes de salaires minima pour les salariés averages for employees of zone II shall be five de la zone II sont cinq sous (0.05) de moins que cents less than those mentioned in the foregoing ceux mentionnés dans les paragraphes \"a\", subsections \"a\", \"b\" and \"c\".\"//' et \"c\" du présent article.e) Responsabilités des employeurs et salariés: e) Besponsibilities of employees and employers: 1° Contremaître et sous-contremaître: Chaque 1.Foreman and Assistant Foreman: Each manu-employeur doit employer au moins un contre- facturer shall employ a minimum of one foreman maître et un sous-contremaître.Advenant Tab- and one assistant foreman.In the event of sence du contremaître, le sous-contremaître the foreman's absence, the assistant foreman doit le remplacer dans ses fonctions et agir shall take over his duties and shall continue to do comme tel durant une période de six (fi) jours so for a period of 6 consecutive days without consécutifs, sans rémunération supplémentaire, extra remuneration.After this period, he shall Après cette période, il ne doit pas recevoir, receive for this added duty, a rate not less than pour ses nouvelles fonctions, une rémunération the minimum prescribed for foremen, but shall inférieure au taux minimum prescrit pour le revert to his former position and wage scale when contremaître; toutefois, au retour du contre- the foreman returns.There may be any number maître, il doit reprendre ses anciennes fonctions of foreman or assistant foremen in addition to the et recevoir son ancien taux de salaire.Il peut above minimums, but only the assistant foreman y avoir plusieurs contremaîtres et sous-contre- effectively replacing the foreman in his absence maîtres, mais seul le sous-contremaître qui is entitled to the foreman's wage under the remplace un contremaître pendant son absence conditions prescribed above.a droit au salaire de contremaître, suivant les conditions ci-haut décrites.2° Machine à gaufrer: Le personnel requis pour chaque machine à gaufrer en opération et pour chaque équipe, s'il y en a plus qu'une, doit se composer d'un gaufreur, d'un mécanicien de machine à coller (Double-backer), d'un découpeur ou bobineur avec le nombre nécessaire de receveurs et (le \"shafter\" de rouleau.Advenant l'absence du gaufreur, le mécanicien de la machine à coller (Double-backer) pourra prendre charge du fonctionnement de la machine comme gaufreur temporaire et devra être rémunéré suivant le taux minimum de cette classification pour une période de six (6)jours 2.Corrugating machine: Corrugator and liner .crew must consist of the following crew members, on each machine and for each shift, if more than one shift is worked: operator, double backer man, knife or slitter man, with necessary tailers and roll shafters.In the event of the absence of the operator, the double backer man may operate the machine in the capacity of temporary operator at listed minimum for this occupation for, a period of six-consecutive days.After this time, he shall receive not less than the minimum scale of pay for 2140 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 consécutifs.Après cette période, il ne doit pas recevoir une rémunération inférieure au taux minimum de salaire du gaufreur jusqu'au retour de celui-ci, alors qu'il doit reprendre ses anciennes fonctions et recevoir son ancien taux de salaire.3° Machine à imprimer et à rainer: S'il y a plus d'une équipe, il doit y avoir pour chaque machine et sur chaque équipe au moins un mécanicien et un assitant-mécanicien et autant de receveurs et de fournisseurs que requis.Les dispositions décrites à l'alinéa précédent (machine à gaufrer) sont applicables advenant, l'absence du mécanicien.Quand la machine à imprimer fait également une opération de rainure, les taux minima de salaire pour l'opération de cette machine combinée sont les mêmes que ceux fixés pour le fonctionnement de la \"machine à imprimer et à rainer\".4° Machine à imprimer, machine à rainer les boîtes, machine à découper les boîtes et feuilles, machine à découper les pans, marqueuscs mitrailleuses de barres, machines à appliquer la toile gommée, machine à piquer, presse à découper, machine à [rainer les divisions, presse à rebuts, coupeur de coins, guillotine, emporte-pièce, machine à rainer (verticale).Un mécanicien doit être chargé du fonctionnement de chacune de ces machines à un taux de salaire non inférieur à celui prescrit.Il n'est pas nécessaire d'avoir un assistant-mécanicien sur ces machines, mais le nombre de receveurs et de fournisseurs nécessaires peut être employé.Advenant l'absence du mécanicien, un salarié travaillant à un taux inférieur à celui des mécaniciens ci-haut mentionnés doit voir au fonctionnement de la machine, sans rémunération supplémentaire pendant une période de six (6) jours consécutifs.Après cette période, il ne doit pas recevoir une rémunération inférieure au taux minimum de salaire du mécanicien jusqu'au retour de celui-ci, alors qu'il doit reprendre ses anciennes fonctions et recevoir son ancien taux de salaire.5° Déchargement et manutention de carton et de rouleaux de papier: Tout employeur doit employer au moins un premier manutenteur de rouleaux de papier.6° Expédition: Tout employeur doit employer au moins un expéditeur et peut, à sa discrétion, employer un assistant-expéditeur.En l'absence de l'expéditeur, l'assistant-expéditeur doit assumer ses fonctions aux mêmes conditions que celles prescrites au présent article (machine à gaufrer).7° Général: Quand un salarié autre qu'un aide, lequel est régi par les dispositions précédentes a plus de trois (3) mois d'emploi et remplace un salarié exécutant une opération classifiée, il doit recevoir le taux prescrit pour ledit travail, à partir du jour suivant le changement.8° Vacances annuelles d'une ou de deux semaines payées: Quand un sous-contremaître remplace un contremaître ou qu'un aide-mécanicien remplace un mécanicien durant leurs vacances annuelles payées, ils doivent le faire sans augmentation de gages, mais pour une période n'excédant pas deux semaines et une fois par année seulement.III.Toutes sommes requises pour parfaire les salaires minima moyens stipulés dans l'article précédent, perçues d'un employeur au moyen de procédures judiciaires par le Comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements, doivent être distribuées par an operator until this man returns, at which time he shall revert to his original position (of double backer man) with previous wage scale.3.Printer-slotter machine: There shall be at least one operator and one assistant operator on each printer-slotter for each shift worked, if more than one shift is worked and as many tai-lers and feeders as required.The same conditions as prescribed above (corrugating machine) shall prevail in the event of the operator's absence.Where a printing machine- incorporates the slotting feature, the minimum wage rate for a printer-slotter shall apply to its operation.4.Printing Machine, Box Slotting Machine, Box and Sheet Slitting Machine, Flap Cutting Machine, Bar Scorer Machine, Taping Machine, Stitching Machine, Die Press Machine, Partition Slotting Machine, Baling Machine, Corner Cutting Machine, Knife, Punch, Slotter-up and down : Each of the above machines must be operated by an operator at a rate not less than that prescribed.No assistant operators are necessary on these machines and as many tailcrs and feeders as are required may be employed.Any employee paid at a rate less than that required for the above operators shall, in the event of the operator's absence, operate the machine without extra remuneration for a period of six consecutive days.After this time, he shall receive not less than the minimum scale of pay for an operator until the operator returns, at which time he shall revert to his original position with previous wage scale.5.Roll and Board unloading and handling: Every manufacturer shall employ at least one (1 ) head roll handler.6.Shipping Department: Every manufacturer shall employ at least one shipper and may, at his discretion, employ one assistant shipper.The assistant shipper shall, in the absence of the shipper, take over his duties on the same basis as listed in this section, under \"Corrugating Machine\".7.General: When employees, other than helpers which are governed by the foregoing provisions, with more than three (3) months of service replace employees engaged in a classified operation, they shall receive the rate established for such work from the day following such change.8.Yearly holidays of one or two weeks with pay: When an assistant foreman replaces a foreman during his yearly paid holidays or when an assistant operator replaces an operator during his yearly paid holidays, they shall do so without any increase in remuneration but for a period of not over two weeks and only once per year.III.All payments required to make up the minimum average wages provided by the preceding section, collected from an employer by the Joint Committee formed to supervise and ensure the carrying out of the decree, its amendements and renewals, by recourse to judicial proceedings, must be distributed by the said QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2141 ledit Comité aux salariés dont le salaire a servi à établir le salaire moyen à compléter, proportionnellement au salaire gagné par chacun d'eux durant la période concernée.IV.Semaine de travail et surtemps: La durée du travail pour tous les salariés y compris les mécaniciens de machines fixes et les chauffeurs de bouilloires, les gardiens, les employés préposés à la réparation et à l'expédition, est de quarante-cinq (45) heures par semaine.Tout travail exécuté les jours de congés et les dimanches ou en plus de quarante-cinq heures par semaine par ces mêmes salariés doit être rémunéré à raison de salaire et demi, mais tout travail exécuté et payé au taux de salaire et demi lesdits dimanches et jours de congé n'est pas inclus dans les heures de travail hebdomadaire au moment de calculer le temps supplémentaire de la semaine.Nonobastnt les dispositions du paragraphe précédent, les mécaniciens de machines fixes et les chauffeurs de bouilloires (stokers) ont droit à une journée de repos pour chaque six (6) jours de travail.Tout travail exécuté le septième jour consécutif de travail doit être rémunéré au taux de salaire et demi.V.Vacances payées: a) Tout salarié qui a été à l'emploi du même employeur, sans interruption, pendant une période d'un an ou plus avant le 1er mai de chaque année, a droit chaque année à une semaine de vacances payées au taux de son salaire régulier.b) Tout salarié qui a été à, l'emploi du même employeur, sans interruption, pendant une période de cinq (5) ans ou plus avant le 1er mai de chaque année, a droit chaque année à deux semaines de vacances payées au taux de son salaire régulier.c) Tout salarié ayant plus de trois mois de service continu avec le même employeur avant le 1er mai de chaque année a droit à des vacances payées équivalentes à un douzième (1/12) des heures de la semaine normale de travail pour chaque mois de service, rémunérées au taux de son salaire régulier.d) Pour avoir droit aux vacances payées stipulées ci-haut, l'assiduité du salarié au travail doit avoir été satisfaisante.Le terme \"assiduité satisfaisante\" signifie qu'un salarié ne s'est pas absenté sans permission pour plus d'une journée à chaque mois de calendrier employé pour déterminer la période de vacances allouées, à moins que son absence ne soit due à-une des causes suivantes: 1° Maladie personnelle; 2° Mortalité dans la famille immédiate du salarié; 3° Obligation de paraître devant la Cour pour agir comme juré ou pour rendre témoignage, mais non si le salarié est requis de répondre à une accusation criminelle.4° Absence conforme à une permission accordée par écrit de la part de l'employeur afin de permettre au salarié de voir à des affaires personnelles ou commerciales, du moment que cette absence n'excède pas 10 jours «à la fois.VI.Jours de congé: a) Les jours suivants sont considérés comme jours de congé: Le Premier de l'An, le Vendredi-Saint, le 24 juin, le 1er juillet, la fête du Travail, l'Immaculée Conception et Noël.b) Au moins six (6) jours de congé choisis parmi ceux mentionnés plus haut doivent être payés en plus d'être chômés, pourvu que ces jours de congé tombent ou sont observés un jour régulier de travail.c) Pour avoir droit à la rémunération précitée, le salarié doit travailler ou être prêt à travailler la journée de travail qui précède et qui suit le Committee to the employees whose wages were used to compute the average wage to be completed, in proportion to the wage earned by each said employee during the period involved.IV.Work week and overtime: The duration of work for all employees, including stationary enginemen and firemen (stokers), maintenance, shipping men, watchmen, is forty-five (45) hours per week, and any hours of work exceeding forty-five (45) hours in any one week or performed on holidays and Sundays by such employees is to be paid at the rate of time and one half, but hours worked and paid at the rate of time and one half on such holidays and Sundays will not be included in the total weekly hours worked when computing the weekly overtime.Notwithstanding what is specified in the preceding paragraph, the stationary enginemen and firemen (stockers) shall be entitled to one day of rest for each six (G) days of work and any work performed on the seventh consecutive day of work shall be paid at the rate of time and one half.* V.Vacation with pay: a) Any employee who has been continuously employed by the same employer for one year or more prior to the first day of May in each, year will be entitled, each year, to one week of vacation at his basic hourly rate.6) Every employee who has been continuously employed by the same employer for five years or more prior to the first day of May in each year is entitled, each year, to two weeks of with pay at bis basic hourly rate.c) Any employee with more than three months continuous service with the same employer prior to the first day of May will be entitled to with pay equivalent to one twelfth (1/12) of the hours of the normal work week for each month worked, at his basic hourly rate.d) To qualify for the above schedule of holiday pay allowances, an employee's attendance at work must have been satisfactory.Satisfactory attendance means that an employee has not been absent without permission for more than one day of the calendar months used to determine the holidays allowance, unless his absence has been due to one of the following causes: 1.Personal illness; 2.Death in the immediate family of the employee; 3.Compulsory Court attendance for jury duty or as a witness, but not if required on a criminal charge; 4.Absence pursuant to leave granted in writing by the employer to enable the employee to attend to personal or business matters, provided such leave does not exceed 10 days at anyone time.VI.Holidays: a) The following days are to be considered as holidays: New Year's Day, Good Friday, June 24th, July 1st, Labour Day, Immaculate Conception Day and Christmas Day.b) At least six (6) of the above mentioned holidays shall be paid in addition to being observed, provided they fall or are observed on a regular working day.c) To qualify for such holiday pay as aforesaid, an employee must work or stand ready to work, the regular working day preceding and following 2142 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, Hi juillet 1955, Tome 87, N° 28 jour où le congé est observé, sauf dans le cas de maladie justifiée ou encore à la suite d'une autorisation écrite de l'employeur.d) Nonobstant les dispositions des paragraphes \"a'\\ \"b\" et \"c\" du présent article, tout employeur accordant six (6) jours de congé payés ou plus par année à ses salariés en vertu d'une convention collective de travail privée, n'est pas sujet aux dispositions des alinéas précédents.VII.Paiement du .salaire: Le salaire de l'employé doit lui être payé par chèque ou en deniers ayant cours légal, dans cette province.Ce salaire, si payé en deniers, doit lui être remis dans une enveloppe scellée sur laquelle doivent être inscrits ses nom et prénom, la date de la semaine ou de la période de travail; le nombre d'heures rémunérées, le taux de salaire à l'heure et le montant contenu dans l'enveloppe; celle-ci doit être initialée par la personne qui a fait la paie.VIII.Les salaires actuellement supérieurs aux taux minima spécifiés dans le décret ne doivent pas être déduits durant l'existence dudit décret.IX.Lors de la ratification de la présente convention, le Comité paritaire existant, formé pour surveiller l'application du décret antérieur dans la juridiction territoriale déterminée par le présent décret, demeure en fonction et surveille la mise à exécution du présent décret jusqu'à ce qu'un nouveau Comité soit formé.Ce nouveau comité succède à l'ancien et est investi de tous les actifs et droits dudit Comité paritaire; il assume également toutes les dettes de l'ancien comité en vertu dudit décret antérieur.X.Le présent décret abroge le décret numéro 561 du 11 mars 1942 et tous ses amendements.XI.Durée du décret: Le décret entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeure en vigueur jusqu'au Ici-janvier 19ÔG.II se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite à moins qu'un groupe prépondérant des parties contractantes patronales ou ouvrières ne donne aux autres parties un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant le 1er janvier de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail.L.DÉSILETS.40267-o Greffier du Conseil Exécutif.the day on which the holiday is observed, except in the case of bona fide illness or written authorization from the employer.d) Notwithstanding provisions of paragraphs \"a\", \"b\" and \"c\" of the present section, an employer who grants six (6) or more observed holidays with pay per year to his employees in virtue of a private collective labour agreement, shall not be subject to the above subsections.VII.Payment of wages: The wages of the employee must be paid to him by cheque or in currency which is legal in this Province.Such wages, if paid in currency, must be banded to the employee in a sealed envelope on which is written; his name and surname, the date of the week or period of work, the number of hours paid, the rate of wages per hour and the amount contained in the envelope; the envelope must be initialed by the pay clerk.VIII.Wages actually higher than the minima herein specified shall not be reduced during the existence of the decree.IX.On the ratification of the present agreement, the existing Joint Committee, organized to carry out the previous decree in the territorial jurisdiction contemplated by the new decree, shall remain, in office and supervise the carrying out of the present decree until a new Committee is formed which shall succeed to and be vested with all the assets and rights of the former Joint Committee; it shall assume all the liabilities of the former Joint Committee under the said previous decree.X.The present decree repeals decree No.561 of the 11th of March 1942, and all amendments thereto.XL Duration of the decree: The present decree comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and so remains until January 1st, 1956.It then renews itself automatically from year to year unless a preponderant group of the contracting parties of the first or second part notify the other parties in writing to the contrary, within the period extending from the sixtieth (60th) to the thirtieth (30th) day before January 1st of any subsequent year.Such a notice must also be forwarded to the Minister of Labour.L.DÉSILETS.40267-o Clerk of the Executive Council.Avis divers (A.G.6383-48) J.B.Laliberté Limitée Extrait des minutes d'une assemblée des actionnaires de \"J.B.Laliberté Limitée\", tenue au bureau de la compagnie, 595, rue St-Joseph, est, Québec, le 24 mai 1955: \"II est proposé par M.Émilien Rochette, secondé par M.Guy Fortier, C.A.que le règlement \"C\" soit amendé de la façon suivante: 10 Que le nombre de directeurs formant le Bureau de Direction de la compagnie soit et il est augmenté par les présentes de cinq à sept directeurs.2° Que les règlements de la compagnie soient et ils sont par les présentes amendés pour donner plein et entier effet à cette augmentation dans le nombre des directeurs.\" Vrai copie Le Secrétaire.40253-o GÉRARD PLANTE.Miscellaneous Notices (A.G.6383-48) J.B.Laliberté Limitée Excerpt from minutes of a meeting of shareholders of \"J.B.Laliberté Ltée\".held at the office of the company, 595 St.Joseph Street, East, Quebec, on May 24th, 1955: 1.It was moved by Mr.Émilien Rochette, seconded by Mr.Guy Fortier, C.A., that Bylaw \"C\" be amended as follows: 1.That the number of directors forming the Board of Directors of the company be and is hereby increased from five to seven directors.2.That the by-laws of the company be and are hereby amended in order to give full effect to this increase in the number of directors.True copy GÉRARD PLANTE, 40253 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2143 (P.G.14453-53) Méthot & Gagne, Ltée Règlement N° 27 II est statue par les présentes comme un règlement de \"Methot & Gagné, Ltée\", de la façon suivante: 1° Que le nombre des directeurs de lu compagnie soit, et il est par les présentes augmenté de trois à cinq, de sorte que le bureau de direction de la compagnie sera composé de cinq directeurs.2° Que trois directeurs constitueront le quorum de toute assemblée du bureau de direction.3° Que toute règlement, résolution et procédure antérieure de la compagnie incompatibles à ce règlement sont par les présentes amendés, modifiés et revisés afin de lui donner effet.Certifié vrai copie.% (Sceau) La Secretaire.40254-o JOSÉPHINE BASTIEN MÉTHOT.(A.G.14453-53) Mêthot & Gagiié, Ltée By-law No.27 It is hereby enacted as a by-law of \"Methot & Gagné, Ltée\", as follows: 1.That the number of directors of the company be and it is hereby increased from three to five, in order that the Board of Directors of the company be composed of five directors.2.That three directors shall form a quorum at any meeting of the Board of Directors.3.That all prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.Certified true copy.(Seal) JOSÉPHINE BASTIEN METHOT, 40254 Secretary.Avis est par les présentes donné par les soussignés que le Lieutenant-gouverneur en conseil a adopté, en date du 22 juin 1955, un arrêté en conseil à l'effet de changer le nom de la municipalité des Cantons-Unis de Sainte-Anne-de-Portneuf, comté de Saguenay, en celui de \"Municipalité de Sainte-Anne-de-Portneuf\".comté de Saguenay.Conformément aux dispositions de l'article 4.S du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la publication du présent avis dans la Gazette officielle Je Québec.Rivière Portncuf, Sag., P.Q.4 juillet.1955.Le Maire, ALCIDE TREMBLAY.Le Secrétaire-trésorier, 40255-o PIERRE PAUL PAQUET.Dominion Silk Dyeing & Finishing Company, Limited Sommaire du Règlement Spécial \"F\" La compagnie est autorisée à disposer de ses biens, distribuer son actif au prorata entre ses actionnaires et subséquemment procéder à sa dissolution par voie de procédures d'abandon de charte, et ce, en vertu de l'article 26 «le la Loi des compagnies de Québec.Certifié sommaire authentique.Daté à Montréal, Québec, ce 1 le jour de juillet 1955.(Sceau) Le Secrétaire, 40269 RALPH C.TEES.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de La Tête à la Baleine\", en date du 8 mai 1955, dont le siège social est situé à La Tête-à-la-Baleine, dans le comté de Saguenay, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le trente mai 1955.Le Sous-secrétaire de la Province, 40270-o JEAN BRUCHES! Notice is hereby given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council has adopted an Order in Council, dated June 22nd, in order to change the name of the municipality of the United Townships of Saint Anne-de-Port-neuf, county of Saguenay, to that of \"Municipality of Saint Anne-de-Portneuf\".county of Saguenay.In accordance with the provisions of article 48 of the Municipal Code, this change of name shall come into force as from the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Rivière Portncuf.Sag., P.Q.July 4th, 1955.ALCIDE TREMBLAY, Mayor.PIERRE PAUL PAQUET, 40255 Secreta ry-Treasurer.Dominion Silk Dyeing & Finishing Company, Limited Summary of Special By-law \"F\" The company is authorized to dispose of its property, to distribute its assets rateably among its shareholders and subsequently to proceed to dissolution by way of surrender of charter proceedings under Section 26 of the Quebec Companies' Act.Certified a true summary.Dated at Montreal, Quebec, this 11th dav of Julv, 1955.(Seal) RALPH C.TEES, 40269-o Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de La Tête à la Baleine\", under date May 8, 1955, whereof the head office is at Tête-à-la-Baleine, in the county of Saguenay and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this thirtieth dav of Mav, 1955.JEAN BRUCHÊSI, 40270 Under Secretary of the Province. 2144 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 (P.G.11409-55) Drainage Ste-Marie Incu Ste-Marie Drainage Inc.Extrait des règlements généraux de la compagnie ci-haut mentionnée concernant l'augmentation du nombre de ses directeurs de quatre à cinq: \"Règlement N° /,.Directeurs.a) Nombre \u2014 Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de cinq directeurs\".Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 40283-o F.TURGEON.Hays Securities Corporation Limited Règlement \"D\" Un règlement qui autorise la ventilation des affaires de la compagnie.\"Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété: Que les affaires de cette compagnie* soient ventillées à partie du 20 juin 1955, que toutes ses responsabilités soient satsifaites, son actif distribué entre ses actionnaires et que les démarches nécessaires soient prises de manière que la compagnie puisse demander au Procureur général, de la province of Quebec, la permission d'abandonner sa charte\".Décrété ce 17 juin 1955.Hays Securities Corporation Limited Le Secrétaire-trésorier, 402S4 P.J.CREWE.(A.G.11409-55) Drainage Ste-Marie Inc.Ste-Marie Drainage Inc.Excerpt from general by-laws of the above-mentioned company concerning the increasing of the number of its directors from four to five: i \"By-law No.4- Directors.a) Number \u2014 The affairs of the company shall be managed by a Board of five directors.\" Certified true copy.F.TURGEON, 40283 Secretary.Hays Securities Corporation Limited By-law \"D\" A By-law to authorize the winding up of the company.\"Be and it is hereby enacted: That the affairs of this company be wound up as of the 20th June, 1955, all its liabilities be satisfied, its assets distributed among its shareholders, and that the necessary steps be taken in order to enable the company to apply to the Attorney General of the Province of Quebec, for leave to surrender its Charter.\" Enacted 17th June, 1955.Hays Securities Corporation Limited, P.J.CREWE, 40284-o Secretary-Treasurer.(P.G.10869-54) Standard Motors (Quebec) Limited Règlement N° 12 Qu'il soit et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Standard Motors (Quebec) Limited.\" (ci-après appelée la \"compagnie\") ce qui suit: 1° Le siège social de la compagnie est, par les présentes, transporté de la cité de Montréal à la cité de Verdun.2° Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui, sont, par les présentes, amendés, modifiés et reA'isés de manière à donner effet à ce règlement.Décrété ce 3e jour de décembre 1954.Témoin: Le Sceau corporatif de la compagnie.Le Président, A.S.DICK.(C.S.) Le Secrétaire, 40285 I.G.WAHN.(A.G.10869-54) Standard Motors (Quebec) Limited By-law No.12 Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of \"Standard Motors (Quebec) Limited.\" (hereinafter called the \"Company\") as follows: 1.The head office of the company is hereby changed from the city of Montreal to the city of Verdun.2.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the Company inconsistent herewith, are hereby amended, modified* and revised in order to give effect to this by-law.Enacted this 3rd day of December, 1954.Witness the corporate seal of the company., A.S.DICK, President.(C.S.) I.G.WAHN, 40285-o Secretary.Bills, Assemblée législative Avis de l'assemblée législative Concernant les bills privés qui seront présentés pendant la prochaine session.Aux termes du règlement, les bills privés devront être déposés avant le 26 octobre 1955 et présentés avant le 7 décembre 1955, les pétitions introductives de bills privés devront être présentées avant le 26 novembre 1955 et reçues avant le 1er décembre 1955, et les rapports de comités Bills, Legislative Assembly Notice of Legislative Assembly Concerning private bills which shall be introduced during the coming Session.According to standing orders, private bills shall be deposited before October 26th, 1955 and introduced before December 7th, 1955; petitions for private bills shall be presented prior to November 26th, 1955 and received prior to December 1st., 1955, and reports from elected QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2145 élus chargés de l'examen des bills privés devront être reçus avant le 21 décembre 1955.Québec, le 12 juillet 1955.Le Greffier de l'Assemblée législative, 40279-28-18-o ANTOINE LEMIEUX.Chartes \u2014 Abandon de Avis est donné par les présentes que \"Green-hill Apts.Inc.\", demandera la permission d'abandonner sa charte à compter d'une date à être déterminée.Montréal, 7 juillet 1955.Greeniull Apts.Inc.Par le Procureurs, 40256-o GARBER & BLUMENSTEIN.Mill-Knit Ltd.En vertu des dispositions.de la Loi des com-pagniesde Québec, lacompagnie \"Mill-Knit Ltd.\", donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera au Procureur général, aux ministres des Affaires municipales, de l'Industrie ét du ' Commerce pour obtenir l'abandon de sa charte à compter d'un date qu'il leur plaira de fixer.Montréal, 6 juillet 1955.Mill-Knit Ltd., Par le Secrétaire, J.MILLER, a/s Mtre Emmanuel Cooke, Avocat, 40261 1117 ouest, rue Ste-Catherine.American Laundry Limited Avis est, par les présentes, donné que \"American Laundry Limited\" s'adressera au Lieutenant-gouverneur de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Le Secrétaire-trésorier, 40281 GEO.W.A.DAWE.Compagnie autorisée à faire des affaires (Sec.P.467-55) Avis est, par les présente, donné que la compagnie \"American-Marietta Company\" a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, S.R.Q.1941, chapitre 279.Le bureau principal de ladite compagnie dans la Province est à 2000 édifice Aldred, 507 Place d'Armes, en les cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les prodécures prises contre elle, est M.W.H.Laidley, de ladite cité de Montréal.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, ce 12e jour de juillet.Le Sous-secrétaire de la Province, 40252 JEAN BRUCHÊSI.committees charged with the examining of private bills must be received before December 21st, 1955.Quebec, July 12th, 1955.ANTOINE LEMIEUX, 40279-28-18 Clerk of the Legislative Assembly.Charters \u2014 Surrender of Notice is hereby given that \"Greenhill Apts.Inc.\" will apply for leave to surrender its Charter at a date to be fixed.Montreal, July 7th, 1955.Greehill Apts.Inc.GARBER & BLUMENSTEIN, 40256-o per Attorneys.Mill-Knit Ltd.Under the provisions of the Quebec Companies' Act, \"Mill-Knit Ltd.\", hereby gives notice that it will make application to the Attorney General and the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce, for acceptance of the surrender of its Charter on and from a date to be fixed by them.Montreal July 6, 1955.Mill-Knit Ltd., Per J.MILLER, Secretary, c/o Mtre.Emmanuel Cooke, Advocate, 40261-o 1117 St.Catherine St.W.'American Laundry Limited Notice is hereby given that \"American Laundry Limited\", will petition the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec for permissions to surrender its Charter.GEO.W.A.DAWE, 4028 l-o Secretary-Treasurer.Company Licensed to do Business 4P.Sec.467-55) Notice is hereby given that \"American-Marietta Company\", has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies' Act, R.S.Q.1941, chapter 279.The principal office of the said company in the Province is at 2000 Aldred Building, 507 Place d'Armes, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.W.H.Laidley, of the said city of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of July, 1955.JEAN BRUCHÊSI, 40252 Under Secretary of the Province. 2146 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 Curatelle publique Canada\u2014Province de Québec District de Témiscamingue Succession vancante de Robert Plamondon.En sou vivant camionneur, de Nédelec, district de Témiscamingue.Le soussigné donne avis que cette succession a été déclarée vacante en vertu d'un jugement rendu le 18 juin 1954 par un juge de la Cour supérieure siégeant à Ville-Marie, dans le district de Tétnicaminguc que, sous l'autorité delà Loi de la curatelle publique (9 Geo.VI, c.62), il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.LE CURATEUR PUBLIC, 187, rue Sainte-Catherine (ouest), 40257-o Montréal 18.Public Curatorship ( \"anada \u2014 Province of Quebec District of Témiscamingue Vacant estate of Robert Plamondon.In bis lifetime, trucker, of Nédelec, district of Témiscamingue.The undersigned gives notice that this estate has been declared vacant under judgment rendered June 18th, 1954 by a Judge of the Superior Court sitting at Ville-Marie in the district of Témiscamingue, that under authority of the Public Curatorship Act (9 Geo.VI, Chap.(52), he is Curator e.v officio for this estate, and that he will receive, at the address herebelow, payment of any debt due the estate and proof of any claim against it.PUBLIC CURATOR, 1S7 Sainte-Catherine Street (West).40257 Montreal IS.Département de l'Instruction Publique Department of Education Bureau des Examinateurs catholiques Board of Catholic Examiners for des Aspirants Inspecteurs d'Ecoles Candidates as School Inspectors Avis est donné par les présentes que le Bureau Notice is hereby given that the Board of des Examinateurs catholiques des Aspirants Catholic Examiners for candidates as School inspecteurs d'écoles siégera à l'École normale Inspectors will be held at the Laval Normal Laval.Québec, les 22-23-24-25-26 août prochain.School Quebec, on August 22-23-24-25-26 next, pour l'examen des candidats au brevet d'aptitu- for the examination of candidates desiring des à l'inspection ties écoles.certificates for positions as School inspectors.L'examen des candidats commencera le mer- The examination of candidates will begin on credi, 23 août 1955, à 9 heures du matin.Wednesday, August 23, 1955, at 9 o'clock in the morning.Québec, le 7 juillet 1955.Quebec, July 7, 1955.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.J.DÉSAULNIERS, 40262-o 0.J.DÉSAULNIERS.40262 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg ville de Charlesbourg division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 277-51 est annulé en vertu de l'article 2I74A du Code civil.Québec, le 6 juillet 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 40268-o AVI LA BÊDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Roch nord cité.de Québec division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 587-119 est annulée en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 28 juin 1955.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, .0268-0 A VILA BÉDARD.Department of Lands and Forests NOTICE Official cadastre of the parish of Charlesbourg town of Charlesbourg registration division of Quebec.Notice is hereby given that lot 277-51 has been cancelled in virtue of article 2174A of the civil Code.Quebec, July 6th, 1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.A VILA BÊDARD, 4020K-o Deputy Minister.NOTICE Official cadastre of the parish of St-Roch nord city of Quebec registration division of Quebec.Notice is hereby given that part of lot 5S7-119 has been cancelled in virtue of article 2174A of the civil Code.> Quebec, June 28th.1955.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch.AVILA BÉDARD, 40268-o Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2147 Département du Travail AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire du Commerce de Mégantic établi en exécution du décret numéro 548 du 2H mai 1954, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 727 du 6 juillet 1955, section \"C\", le tout d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitc 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après mentionnés: \" 1.Cotisation La période de cotisation s'étend de la date de publication du présent règlement dans la Gazette officielle de Québec au 5 juin 1956; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 548 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à % de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 548 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Y\\ de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit $0.15 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 548 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de leur rémunération.2.Mode de -perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur profcssioimel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration de la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi de lu convention collective, le Comité paritaire doit présenter un Department of Labour NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette.Minister of Labour, hereby gives notice that \"Le Comité paritaire du Commerce de Mégantic\".formed under decree number 548 of May 28th, 1954.has been authorized by a by-law approved by Order in council number 727 of July 6, 1955, part \"('\" in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 163 and amendments), to levy assessments from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree according to the method and rate hereinafter mentioned: 1.Assessments The period of levy shall extend from the date of the publication of the present by-law in the Quebec Official Gazette, until June 5th, 1956; it shall be laid in the following manner: a) The pr-fessional employers governed by the decree number 548 shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 34 of 1% of their pay-roll for their employees govemeeTby the decree.b) The artisans governed by the decree number 548 shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yv of 1% of the least remunerated journeyman, i.e.80.15 per week.c) The employees governed by the said decree, number 548, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to 14 of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which shall be given all particulars required by the said Parity Committee.The professional employer shall complete his report, sign and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each week, in the name of the Committee, the assessments of his employees by means of a deduction on the hitter's wages.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 15th of the month following the date of expiration of the period for which it is requir-able; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and the sums payable to the Parity Committee by his employees.The Committee has the right the exact sworn reports when deemed advisable.The levy enacted by the present by-law is payable every month by the professional employer, and the employee, without notice.Upon refusal by a professional employer or an artisan to pay or to give the necessary information, five days notice will be given to him to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly 2148 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 juillet 1955, Tome 78, N° '28 rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire du Commerce de Mégantic, pour la période se terminant le 5 juin 1956.Le Comité paritaire du.Comerce de Mégantic \u2022 Siège social Mégantic Etat des recettes el des déboursés probables pour la période see ternant le 5 juin 1956.Recettes: Cotisations {\\i de 1%) Employeurs professionnels.S 800.00 Artisans.100.00 Salariés.800.00 S 1,700.00 Déboursés: Salaires: Secrétaire.1,300.00 Papeterie, impressions, timbres, téléphone et télégrammes.100.00 Vérification des livres.50.00 Jetons de présence aux membres du Comité.250.00 81,700.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 16 juillet 1955.40267-o repor) of its financial operations to the Minister of Labour, on the following fixed dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of \"Le Comité paritaire du Commerce de Mégantic\" for the period ending June 5th, 1956.Le Comité paritaire du Commerce de Mégantic Corporate seat: Mégantic Estimate of the receipts and disbursements for the period ending June 5th, 1956.Receipts: Assessments (Ij of 1%): Professional employers.$ 800.00 Artisans.:.100.00 Employees.800.00 $1,700.00 Disbursements: Salary of the secretary.$1,300.00 Stationery, printing, postage, telephone, telegrams.100.00 Audition.50.00 Members'Attendance fees.250.00 $1,700.00 GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 16th, 1955.40267-o \u2022 AVIS DE PRÉLÈVEMENT L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité conjoint de l'Industrie de la confection pour dames, dans la province de Québec, établi en exécution du décret numéro 523 du 11 mai 1955, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 727 du 6 juillet 1955 (section \"B\"), le tout d'abord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs professionnels et des salariés assujettis audit décret, suivant la méthode et le taux ci-après: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er juillet, 1955, au 30 juin 1956, ladite cotisation s'exerce de la façon suivante: a) Tous les employeurs professionnels de l'industrie de la confection pour dames assujettis au décret numéro 523 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^2 (lc 1% des salaires, bonis et allocations payés à leurs salariés des deux sexes (à l'exception de gérants, surintendant, contremaîtres et employés de bureau) assujettis audit décret./;) Tous les salariés des deux-sexes de l'industrie de la confection pour dames, assujettis au décret numéro 523 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yl de 1% de leur salaire, bonis et allocations, à l'exception des gérants, surintendants, contremaîtres et employés de bureau.NOTICE OF LEVY The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), that the Joint Committee of the Ladies Cloak and Suit Industry for the Province of Quebec, established under decree number 523 of May 11th, 1955 has been authorized by a by-law approval by Order in Council number 727 of July 6th, 1955, part \"B\" to levy assessments upon the professional employers and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereafter mentioned: 1.Levy The period of levy shall extend from July 1st, 1955, to June 30th, 1956, and apply as hereinafter mentioned : a) All professional employers in the Ladies' Cloak and Suit Industry, subject to the said decree number 523 and its amendments must pay to the Parity Committee a sum equivalent to ]/2 of 1% of salaries, bonuses and allowances paid to their employees of both sexes, with the exception of managers, superintendents, foremen and office employees, subject to the said decree.b) All employees of both sexes of the Ladies' Cloak and Suit Industry, subject to decree number 523 and its amendments, are obliged to contribute to the said Parity Committee, a sum equivalent to 3^ of 1% of their salaries, bonuses and allowances, with the exception of managers, superintendents, foremen and office employees. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2149 2.Mode de perception L'employeur professionnel doit faire des rapports mensuels, en duplicata, sur des formules fournies par le comité paritaire.Ces rapports doivent indiquer les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, la qualification de tel salarié, les heures régulières et supplémentaires effectuées chaque jour, la nature de tel travail ainsi que les salaires payés, avec mention du mode et de la période de paye.Ces rapports mensuels doivent être signés par l'employeur ou un agent dûment autorisé dont l'original où apparaît la liste de paye doit être adressé aux bureaux du comité paritaire au plus tard le dix du mois suivant.Les employeurs professionnels doivent percevoir à la fin de chaque semaine, à même le salaire de chacun de leurs salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire et faire parvenir les montants ainsi perçus audit Comité paritaire en même temps que leur propre cotisation, dans les quatre jours qui suivent la date à laquelle les-dits salaires hebdomadaires sont payables aux salariés.3.Rapport financier Conformément aux dispositions de la Loi de le convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé un état des recettes et déboursés probables du Comité paritaire pour la période commençant le 1er juillet 1955, et se terminant le 30 juin 195G.Comité conjoint de l'Industrie de la Confection pour Dames dans la province de Québec État des recettes et déboursés pour une année, du 1er juillet 1955, au 30 juin 1956.Recettes: Cotisation {lA de 1%): Employeurs professionnels.830,000.00 Salariés.30,000.00 Intérêts sur obligations.1,100.00 Revenus légaux.200.00 861,300.00 Déboursés: Salaires (bureau.812,500.00 Salaires des inspecteurs et inspections supplémentaires.14,000.00 Administration.10,080.00 Téléphone et télégrammes.520.00 Frais de déplacement.3,400.00 Loyer.4,324.00 Taxes.350.00 Papeterie, timbres et dépenses de bureau.4,350.00 Frais légaux.5,500.00 Audition.600.00 Électricité.30.00 Billet de tramways et déplacement local.250.00 Accessoires de bureau.500.00 Assurance chômage.250.00 Frais de cautionnement, Dépenses divers, Enquêtes spéciales, 2.Mode of collection The professional employer must make monthly payroll reports, in duplicate, the form of which to be supplied by the Parity Committee.These reports are to indicate the surnames, christian names and residence of each employee in his employ, the competency of each employee, the regular and extra hours of daily labour, and its nature, as well as the wages paid for such labour, with mention of the method and time of payment.Said monthly payroll reports are to be signed by the employer or a duly authorized agent, the original of which, containing the payroll report, shall be sent to the offices of the Parity Committee not later than the tenth (10th) of the month following.The professional employer must collect at the end of each week from the wages of every one of his employees the sums owed to the Parity Committee and remit the amount so collected to the said Parity Committee together with his own assessment not later than four (4) days from the date when the said weekly wages were due to the employees.3.Financial report Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour, on the following dates: March 31st, June 30th, September 30th and December 31st.An estimated statement of the receipts and expenditures of the Parity Committee for the period beginning July 1st, 1955 and ending June 30th, 1956, is hereto annexed.The Joint Committee of the Ladies' Cloak and Suit Industry for the Province of Quebec Estimates of receipts and expenditures for the period comprised between July 1st, 1955 and June 30th, 1956.Receipts: Assessments (J/£ de 1%): Professional employers.830,000.00 Employees.30,000.00 Bond Interest.1,000.00 Miscellaneous Legal Income.200.00 861,300.00 Expenditures: Office salaries.12,500.00 Inspectors' salaries and extra inspection.14,000.00 Administration.10,080.00 Telephone & Telegraph.520.00 Travelling expenses.3,400.00 Rent.4,324.00 Taxes.350.00 Stationery, postage and office expenses.4,350.00 Legal fees.5,500.00 Audit fees.600.00 Lights.30.00 Carfare & Local transportation.250.00 Office equipment.500.00 Unemployment Insurance.250.00 Insurance Guarantee Bond, Miscellaneous, Expenses, Special investigations, 2150 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 Frais de banque, .Jetons de présence, Dépenses des inspecteurs, etc.Bank charges, Committee meeting expenses.4,200.00 Inspectors expenses, etc.$60,854.00 4,200.00 860,854.00 Surplus prévu.446.00 Estimates Surplus.446.00 Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 16 juillet 1955.40267-O Quebec, July 16th.1955.40207-o Avis d'approbation de règlements L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que la constitution et les règlements généraux du Comité conjoint de l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec, établi en exécution du décret numéro 523 du 11 mai 1955, et dont le siège social est situé dans la cité de Montréal ont été approuves par l'arrêté en conseil numéro 727-A du 6 juillet 1955.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 16 juillet 1955.40267-u Notice of Approval of By-Laws The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the constitution and general by-laws of the Joint Committee of the Ladies' Cloak and Suit Industry for the Province of Quebec, established under decree No.523 of May llth, 1955, with head office in the city of Montreal, have been approved by Orders in Council No.727-A of July 6th, 1955.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 16th, 1955.40207-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis, par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la boîte de carton dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 758 du 19 juillet 1951, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil les modifications suivantes audit décret, dans sa teneur modifiée: 1° Le nom de lu partie contractante de seconde part sera modifiée pour se lire comme suit: \"Le Syndicat catholique de la Boîte de Carton de Québec Inc.\" 2° Le paragraphe \"b\" de l'article I sera remplacé par le suivant : \"b) Juridiction professionnelle: Le présent décret régit et gouverne tout travail de même nature ou de même genre que celui visé par ce décret.Le travail visé par ce décret comprend celui de toute personne exécutant quelqu'une ou plusieurs des opérations participantes, incidentes ou connexes à la fabrication des boîte de carton, des boîtes faites d'imitation de bois, faites en parties ou finies avec papier, fibre, bois, ou carton et de toutes autres boîtes à base de pulpe ou papier non gaufré, sans égard à la couverture extérieure, que lesdites opérâtious soient effectuées en totalité ou en partie par le même employeur ou par plusieurs employeurs, qu'elles soient effectuées en totalité ou en partie dans un ou plusieurs ateliers spécialisés, entreprises privées, industrielles ou commerciales ou dans tout autre établissement, qu'elles constituent le commerce principal de l'employeur ou soient secondaire ou complémentaires à tout autre commerce ou occupation, et que lesdites boîtes soient NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the paper box industry in the region of Quebec, rendered obligatory by the decree number 758 of July 19th, 1951, have petitioned him to submit to the consideration and decisicn of the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the said decree, as amended: 1.The name of the contracting party of the second part will be changed to read as follows: \"Le Syndicat catholiques de la Boîte de Carton de Québec Inc.\" 2.Subsection \"b\" of section I will be replaced by the following: \"b) Professional jurisdiction: The present decree governs and rules any work of the same nature or kind as that contemplated by this decree.The work contemplated by this decree comprises the work of all persons performing any or many of the operatioiis being part of, related to or connected with the manufacturing of paper boxes, of word imitation boxes, partly made or completed with paper, fibre wood or cardboard and of all ether pulp or paper boxes made of uncorrugated material, regardless of exterior covering, whether said operations are performed completely or in part by the same employer or by several employers, whether they are performed completely or in part in one or several trade plants, private, industrial, commercial or any other establishments, whether such operations constitute the principal business of the employer or are accessory or complementary to any other business or enterprise and whether the said boxes are manufactured for the purposes of sale QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955.Vol.87, No.28 2151 fabriquées pour fins de vente à d'autres consommateurs ou exclusivement pour la propre consommation de l'employeur.Sans limiter la généralité des termes du paragraphe précédent, le formage et l'assemblage des bottes de carton sont des opérations comprises dans la juridiction professionnelle de ce décret.Toutefois, le présent décret ne régit pas la fabrication des boîtes de carton gaufré.Le Comité paritaire s'en reporte à la classification de la Commission des Accidents du Travail qui détermine, pour fins de cotisation, si une industrie est essentiellement engagée dans la fabrication de la boîte de bois ou dans celle de la boîte de carton.\" 3° Les mots \"et chauffeur\" apparaissant au paragraphe \"g\" de l'article II seront biffés.4° La classification suivante sera ajoutée au paragraphe \"a\" de l'article III: \"Salariés \u2014 Femmes: Département des boites rigides: Mécanicienne, machine à assembler ou former les boîtes.$0.71 Fileuse, machine auto, à assembler ou former les boîtes.0.67 Département des boîtes pliantes: Mécanicienne, machine à assembler ou former les boîtes.0.71 Pileuses, machine auto, à assembler ou former les boîtes.0.67\" 5° Les mots \"chauffeur de bouilloires\" apparaissant au paragraphe \"d\" de l'article III seront biffés.6° Les item concernant les chefs-mécaniciens et les mécaniciens de machines fixes, article \\\\\\-d, seront remplacés par les suivants: \"Chef mécanicien de machines fixes: par semaine 2èm'e classe catégorie A.$55.36 3ème classe catégorie A.48.05 Mécanicien de machines fixes: Par heure 3ème classe catégorie A.$ 1.05 4ème classe catégorie A.0.99\" 7° La classification suivante sera ajoutée au paragraphe \"d\" de l'article III: \"Salariés \u2014 Hommes Département des boîtes rigides: Mécanicien, machine à assembler ou former les boîtes.$1.06 Préposé à la mise en train machine auto, à assembler ou former les boîtes.1.23 Fileur, machine auto, à assembler ou former les boîtes.0.95\" Département des boîtes pliantes: Mécanicien, machine à assembler ou former les boîtes.$1.06 Préposé à la mise en train machine auto, à assembler ou former les boîtes.1.23 Fileur, machine à assembler ou former les boîtes.0.95\" 8° Les mots \"chauffeurs\" apparaissant au paragraphe \"a-2\" de l'article IV seront biffés.9° Le paragraphe \"b\" de l'article VIII sera remplacé par le suivant : \"6) Lorsque chômées et ouvrables, les fêtes suivantes sont payées au taux du salaire régulier: Le jour de Noël, le Premier de l'An, l'Epiphanie, la St-Jean Baptiste ou la Confédération, au choix de l'employeur, la fête du Travail et l'Immaculée Conception.Toutefois, pour bénéficier de ces fêtes payées, le salarié doit avoir travaillé ou avait été à la disposition de son employeur la veille et le lendemain desdites fêtes.Cependant, si une de ces fêtes tombe dans un semaine de vacances payées, ladite fête devra être payée à temps double ou compensée par une journée additionnelle de vacances.\" to other consumers or for the exclusive use of the employer.Without limiting the generality of the preceding paragraph, the forming and assembling of these boxes are operations comprised in the professional jurisdiction of this decree.However, the present decree does not apply to manufacturing of corrugated paper boxes.The Parity Committee shall refer to the classification of the Workmen's Compensation Commission which determines, for purposes of assessment, whether an industry is essentially engaged in the manufacturing of wooden or paper boxes.\" 3.The words \"and fireman\" mentioned in subsection \"g\" of section II will be deleted.4.The following classification will be added to subsection \"a\" of section III: \"(Female) employees: ¦ Set-up Deparmeni Box assembling or forming machine operator.$0.71 Feeder.Auto Box assembling or forming machine.0.67 Folding Box Department: Box assembling or forming machine opcr-\u2022 ator.0.71 Feeder, auto box assembling or forming machine.0.67\" 5.The words \"boiler fireman\" mentioned in subsection \"d\" of section III will be deleted.6.The items concerning Chief enginemen and stationary enginemen, section lll-d, will be replaced by the following: \"Chief stationary engincman: Per week 2nd class, category A.$55.36 3rd class, category A.48.05 Stationary engineman: Per hour 3rd class, category A.$1.05 4th class, category A.0.99\" 7.The following classification will be added to subsection \"d\" of section III: \"(Male) employees: Set-up Box Department: Box assembling or forming machine operator.$1.06 Auto, box assembling or forming machine make ready man.1.23 Feeder, auto box assembling or forming machine.0.95 Folding Box Department: Box assembling or forming machine operator.$1.06 Auto box assembling or forming machine make ready man.1.23 Feeder, auto box assembling or forming box machine.0.95\" 8.The word \"firemen\" mentioned in subsection \"a-2\" of section IV will be deleted.9.Subsection \"6\" of section VIII will be replaced by the following: \"b) When the following holidays on a work day and are not worked, they shall be paid at the regular rate of pay: Christmas Day, New Years' Day, Epiphany Day, St-Jean Baptiste or Confederation Day, at the option of the employer, Labour Day and Immaculate Conception Day.However, to be entitled to those holidays with pay, the employee shall work, or be at the disposal of his employer the day before and the day after such holidays.However', when one of the above holidays falls in a week of vacation with pay, the said holiday shall be paid double time or be replaced by an additional day of vacation.\" 2152 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 10° Le paragraphe \"a\" de l'article IX sera remplacé par le suivant: \"a) Jours chômés: Lorsque travaillés, les jours suivants sont payés à temps double: Les dimanches, le Premier de l'An, l'Epiphanie, le Vendredi-Saint jusqu'à midi, l'Ascension, la St-Jean Baptiste, la Confédération, la féte du Travail, la Toussaint.l'Immaculée Conception et le jour de Noël.Toutefois l'employeur qui aura chômé l'une des fêtes de la St-.Iean Baptiste ou de la Confédération pourra faire travailler à l'autre de ces fêtes à temps simple.\" 11° Le paragraphe \"b-iv\" de l'article IX sera remplacé par le suivant: \"iv.Ne sauraient notamment être considérés comme interrompant la durée des services continus, les jours de maladie, si le contrat n'a pas été résilié, les jours de fermeture, les périodes de congé annuel, de délai-congé, les absences autorisées si le salarié revient immédiatement reprendre sa position à la demande de l'employeur.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 16 juillet 1955.40267-o Nominations Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, de nommer par lettres patentes sous le grand sceau de la province, au nom de Sa Majesté, les personnes dont les noms suivent, savoir: Québec, le 8 juin 1955.MM.Paul Gérin et Roger Bouchard, tous deux avocats et membres du Bareau de la province, pratiquant comme tels à Coaticook, comté de Stanstead, conseils en loi de la Reine.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, et par commission, de faire la nomination suivante: Québec, le 8 juin 1955.Docteur Sarto Sirois, médecin régional à l'emploi du ministère de la Santé, à Rivièrc-du-Loup: commissaire \"per dedimus potestatem\".40252-o Proclamation Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Com-monwelath, défenseur de la foi.A nos très aimés et fidèles conseillers les membres du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de la province de Québec, Salut: 10.Subsection \"a\" of section IX will be replaced by the following: \"a) Days kept as holidays: The following days, when worked, shall be paid double time: Sunday, New Year's Day, Epiphany, Good Friday until noon, Ascension Day, St.John the Baptist Day, Confederation Day, Labour Day, All Saints Day, Immaculate Conception Day and Christmas Day.However, employers who have not worked neither St.John the Baptist or Confederation Day may work the other holiday at straight time.\" 11.Subsection \"b'iv\" of section IX will be replaced by the following: \"iv.The duration of continuous service should not be considered as being interrupted especially in cases of illness, when the contract has not been annulled, of days of closing of annual, vacation periods, of terms of notice, of authorized absences, when during these days, the employee comes back to work immediately if so requested by the employer.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, July 16th, 1955.40267-o Appointments His Honour the Lieutenant-Governor, with the advice and consent of the Executive Council, has been pleased to appoint by letters patent under the Great Seal of the Province, in the name of Her Majesty, the persons whose names follow, to wit: Quebec, June 8, 1955.Messrs Paul Gérin and.Roger Bouchard, both advocates and members of the Bar of the Province, practising as such in Coaticook, County of Stanstead: Queen's Counsel.His Honour the Lieutenant-Governor, with the advice and consent of the Executive Council, and by Commission, has been pleased to make the following appointment: Quebec, June 8, 1955.Doctor Sarto Sirois, district Health Office for the Department of Health, at Rivière-du-Loup; Commissioner \"per dedimus potestatem\".40252 Proclamation Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To our Beloved and Faithful Councilors, the members of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of the Province of Quebec.Greeting : QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2153 PROCLAMATION Attendu que pour diverses considérations, il est à propos de convoquer la Législature de la province de Québec pour l'expédition des affaires, Nous vous convoquons par les présentes pour le seize novembre prochain et, en conséquence, vous mandons et ordonnons de vous assembler à cette date, au palais législatif, en la cité de Québec, pour y expédier les affaires de la Province et y examiner, discuter et décider les questions qui vous seront soumises.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de la province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable monsieur GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S.L.D.S., lieutenant-gouverneur de ladite Province.Donné en Notre hôtel du Gouvernement, à Québec, le sixème jour de juillet, l'an de grâce mil neuf cent cinquante-cinq et de Notre Règne le quatrième.Par ordre, Le Secrétaire de la chancellerie à Québec, 40279-28-18-o ANTOINE LEMIEUX.Sièges sociaux Avis de la situation du bureau principal Avis Avis est donné que la compagnie \"Pierre Raby Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 28 mars 1955, et ayant son bureau principal dans la cité d'Outremont, a établi son bureau au numéro 237 de la rue Bloom-field.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné aux Trois-Rivières, ce 4e jour de juillet 1955.Le Président, 40273-o PIERRE RABY.(P.G.10869-54) Standard Motors (Quebec) Limited Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Standard Motors (Quebec) Limited constituée en corporation par iettres patentes en date du 25 mars 1954 et ayant son siège social en la cité de Montréal, où, jusqu'à ce jour, son bureau était situé à 360 ouest, rue St-Jacques, l'a transporté à 112 rue River en la cité de Verdun.A compter de la date de cet avis ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Verdun, ce 24e jour de février 1955.(Sceau) Le Secrétaire, 40285 I.G.WAHN.Soumissions Province de Québec Ville de Black Lake (Comté de Mégantic) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées \"Sou- PROCLAMATION Whereas for various considerations, it is expedient to convoke the Legislature of the Province of Quebec for the dispatch of business, We hereby convene you for the sixteenth day of November next and, accordingly, command and order you to meet on such date at the Parliament Buildings, in the City of Quebec, for the dispatch of the business of the Province and to examine, discuss and decide the questions to be submitted to you.In testimony whereof, We have caused these Our letters to be made patent and the Great Seal of Our Province of Quebec to be hereunto affixed.Witness: Our right Trustv and Well Beloved.The Honourable Mr.GASPARD FAUTEUX, .P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of the said Province.Given at Our Government House in Quebec, the sixth day of July, in the year of Our Lord, nineteen hundred and fifty-five and fourth year of Our Reign.By command, ANTOINE LEMIEUX, Secretary of the Crown in Chancery, at 40279-28-18 Quebec.Head Offices Notice of Location of Head Office Notice Notice is given that the company \"Pierre Raby Inc.\", constituted as a corporation by letters patent dated March 28th, 1955, and having its head office in the city of Outremont, has established its office at number 237 Bloomfield Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Given at Trois-Rivières, this 4th day of July 1955.PIERRE RABY, 40273 President.(A.G.10869-54) Standard Motors (Quebec) Limited Notice is hereby given that Standard Motors (Quebec) Limited incorporated by letters patent on March 25, 1954 and having its head office in the City of Montreal where its head office was situated up to today at 360 St.James Street West, has moved it to 112 River Street in the City of Verdun.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Verdun this 24th, day of February, 1955.(Seal) I.G.WAHN, 40285-o Secretary.Tenders Province of Québec Town of Black Lake (County of Megantic) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be 2154 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 juillet 1955, Tome 87, N° 28 missions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-O.Laplante, secrétaire-trésorier, C.P.41, Hôtel éonidas Gagné, régistraire des Faillites.Conditions de paiement: argent comptant.Québec, ce 13 juillet 1955.Les Svndics.JOSEPH M AU METTE & RENÉ LEFAIVRE.111.Côte de la Montagne, Québec, Que.40287-28-2-o Ventes pour taxes Company and partly by the \"trait-carré\" of these lots, on one side, on the West, partly by the route of Range \"St-Pierre\" and partly by the land of Mrs.Germaine Duval above named, and on the other side, on the East, by the land of Mr.Jospeh-Arthur and Guy Tremblay, the whole with buildings, circumstances and dependencies.The immoveable above described shall be offered to the highest and last bidder, with ground rents which may exist and distributions for the church which may exist.Titles and certificates may be examined at all times by applying to the undersigned trustees, 111 Mountain Hill, Quebec.This sale is carried out in accordance with articles 716, 717 and 7I9A of the Code of Civil Procedure and also with section 55 of the Bankruptcy Act 1949.This sale is equivalent to a sale by Sheriff, and in conformity with judgr ment rendered by Me Léonidas Gagné, Registrar for Bankruptcy.Conditions of payment : cash.Quebec, July 13, 1955.JOSEPH MARMETTE & RENÉ LEFAIVRE, Trustees.Ill, Mountain Hill, Quebec, Que.40287-28-2 Sales for Taxes Province de Québec Ville Montréal-nord (Comté Laval) Avis public est, par les présentes, donné que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère, à l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord, MERCREDI le (10) DIXIÈME jour du mois d'AOUT, mil neuf cent cinquante-cinq (1955) à DIX (10) heures de l'avant-midi, heure avancée, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.La Commission Municipale de Québec, par décision en date du 7 juillet 1955, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles, sous l'autorité de la Loi des Cités et Villes, art.550, tel qu'amendé par 24 Geo.V, chapitre 33, section 3.Province of Quebec Town of Montreal North (County of Laval) , Public notice is hereby given that the properties hereinafter described will be sold by auction at the office of the Council of the Town of Montreal North, on WEDNESDAY (10) the TENTH of AUGUST, nineteen hundred and fifty-five at TEN (10) o'clock in the forenoon, daylight saving time, to satisfy the payment of the municipal and school taxes, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.The Quebec Municipal Commission, by a decision, dated July 7th, 1955, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of the article 550, of Cities ami Town Act, as amended by 24 Geo.V, chap.33, section 3.Noms des propriétaires Names of proprietors Mine (Mrs.) J.F.Bragg.Victor Massicotte.(avec bâtisse dessus érigée) M.& Mme (Mr.& Mrs.) Frs.Thibault Chs.A.Bamlètt.Mme (Mrs.) Sylvestre Luisi.(avec bâtisses dessus érigées) Thomas Murpliy.(avec bâtisse dessus érigée).René Turcotte.(avec bâtisse dessus érigée) Maurice Pommier.61 W.Ramioa.77a.Philippe Muzoff.97.Les immeubles susdits sont tous du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet, et situés dans la Ville Montréal-Nord.Subdivisions 728, 729, 730.228, 229.(with building thereon erected).253.397, 398.1053, 1054, 1055.(with buildings thereon erected).105G.8-2.(with building thereon erected).27.(with building thereon erected).209, 210.55.187.The alx)ve immoveables are all in the plan and book of reference of the Parish of Sault-au-Recollet, and situated in the Town of Montreal North. 2160 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 16 juillet 1955, Tome 87, N° 28 Ladite vente sera en outre faito avec toutes les The said sale will be made with all active and servitudes actives et passisves ou occultes, attachées passive- servitudes apparent or occult, attached to auxdits immeubles.the said properties.Donné en la Ville Montréal-Nord, ce douzième (12) jour du mois de juillet, mil neuf cent cinquante-cinq (1955).Le Secrétaire-trésorier, 402S8-2S-2-O RENÉ BERGERON, C.A.Given at the Town of Montreal North, this 12th, day of July, nineteen hundred and fifty-five (1955).r RENÉ BERGERON, C.A., 40288-28-2-o Secretary-Treasurer.Province de Québec Ville de la Pointe-aux-Trembles (Comté de Laval) Avis public est par les présentes donné que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère en l'Hôtel de Ville de la ville de la Pointe-aux-Trembles, MARDI, le NEUVIÈME jour du mois d'AOÛT, mil neuf cent cinquante-cinq (1955) à, DIX heures de.l'avant-midi (heure solaire) pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêt, plus les frais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.La Commission Municipale de Québec par résolution adoptée à sa séance, du 29 juin 1955, a autorisé la ville à faire une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles, conformément aux disposition de l'article 550 de la Loi des Cités et Villes, tel que modifié par la Loi 24, George V, chapitre 33, section 3.Province of Quebec Town of Pointe-aux-Trembles County of Laval Public notice is hereby given that the properties hereinafter described will be sold by public auction at the Office of the Council, at the Town-Hall of the town of Pointe-aux-Trcmbles, on TUESDAY, the NINTH day of the month of AUGUST, nineteen hundred and fifty-five (1955), at TEN o'clock in the forenoon (Eastern Standard Time), to satisfy the payment of the Municipal and school taxes, plus the costs which shall subsequently be incurred .unless the said taxes, interest and cost be paid before the sale.The Quebec Municipal Commission, by a resolution adopted at its meeting on June 29th, 1955, authorized the town to make an abbreviated enumeration of the cadastral numbers of the immoveables, pursuant to the provisions of article 550 of the cities and town's Act, as amended by the Law 24th, George V, chap.33, section 3.Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Cadastral Subdivisions Bélanger, J.Doria.Cozzolino, Thomas Cardinal, Joseph.Folker Karl.Fortin, Amédée.199.10.45.335.184.79,80.182.229, 230.199.531.A distraire dudit lot la partie vendue à la ville do la To be detached from the said lot the part sold to the Pointe-aux-Trembles pour l'ouverture et l'établisse- Town of Pointo-aux-Trembles for the opening and the ment de la rue Sherbrooke suivant acte enregistré au establishment of Sherbrooke Street by deed registered Bureau d'Enregistrement de Montréal, le 21 décembre at the Registry Office in Montreal, on the 21st day of 1937, SOUS le numéro 425138.December 1937, under the number 425138.199.180.181.Fortin, Amédée.Leclcrc Philomène, épouse de - wife of J.-E.Desjardins.Masse, Lucille et-and Denise.Mignault Cécile, épouse de-wife of Antonio Lus-6icr.:.Millaire, L.J.P.Succ.Nolin, René.Tcllier, Lorenzo.Vallières, Georges.Les immeubles susdits sont tous aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de la Pointe-aux-Trcmblc3, et situés dans la ville do la Pointe-aux-Trembles.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes et occultes, attachées auxdits immeubles.199.180.206.210.206.532.72.827.388 à-to 393 incl.106 à-to 109 incl.420, 421.133 à-to 136 incl.321.The above immoveables are all on the plan and book of reference of the parish of Pointe-aux-Trcmbles, and situated in the town of Pointe-aux-Trembles.The said sale will be made, with all active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said properties.Donné en la ville de la Pointe-aux-Trembles, ce onzième jour du mois de juillet, mil neuf cent cinquante-cinq.(Vraie copie) Le Secrétaire-trésorier, 40274-28-2-o PAUL A.TRUDEAU.Province de Québec Cité de Saint-Michel Comté de Laval Avis public est par les présentes donné que les propriétés ci-dessous désignées seront ven- Given at the town of Pointe-aux-Trembles, this eleventh day of July, nineteen hundred and fifty-five.(True copy).PAUL A.TRUDEAU, 40274-28-2-o Secretary-Treasurer.Province of Quebec City of St.Michel County of Laval ' Public notice is hereby given that the properties hereinafter described will be sold by QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2161 dues à l'enchère, à l'Hôtcl-de-Villc de la cité de Saint-Michel, JEUDI, le (11) ONZIÈME jour du mois d'AOÛT, mil neuf cent cinquante-cinq (1955) à DIX heures de l'avant-midi, heure avancée, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens, ne soient payés avant la vente.La Commission Municipale de Québec par décision en date du 27 juin 1955 a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles, sous l'autorité de la Loi des Cités et Villes, article 550, tel qu'amendé par 24 Geo.V, chapitre 33, section 3.public auction at the office of the city of St.Michel, on THURSDAY, the (11th) ELEVENTH day of AUGUST, nineteen hundred and fifty-five (1955) at TEN o'clock in the forenoon daylight saving time, to satisfy the payment of the municipal and school taxes, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interests and costs, be pair! before the sale.The Quebec Municipal Commission, by a decision, dated June 27th, 1955, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of the article 550, of Cities and Towns Act, as amended by 24 Geo.V, Chap.33, section 3.Nom des propriétaires\tCadastre\t.\u2014\t\u2014\tSubdivisions Names of proprietors\tCadastral\t \t343.\t713.432.37, 38, 39, 40.\t443.\t \t474A.\t avec bâtisses dessus érigées.\u2014 with buildings thereon erected.Les immeubles susdits sont tous du cadastre do la The above immoveables are all in the plan and book paroisse du Sault-au-Récollct et situés dans la Cité de of reference of.the parish of Sault au|Recollet, and situa- Saint-Michel.ted in the city of St.Michel.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les The said sale will be made with all active and passive servitudes actives et passives ou occultes, attachés servitudes apparent or accult, attached to the said auxdits immeubles.properties.Donné en la cité de Saint-Michel, ce (12) douzième jour du mois de juillet, mil neuf cent cinquante-cinq (1955).(Sceau) ' Le Secrétaire-trésorier, Vraie copie.A.E.CHEVRIER.40280-28-2-o Given at city of St.Michel, this (12th) twelfth day of the month of July, nineteen hundred and fifty-five (1955).(Seal) A.E.CHEVRIER, True copy Secretary-Treasurer.40280-28-2-o VENTES PAR SHERIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEDFORD BEDFORD Canada \u2014 Province de Québec Canada \u2014 Province of Quebec District de Bedford District of Bedford Cour de Magistrat / \\*\\ /ALTER BEAURE- Magist rate' Court / \\\\/ALTER BEAURE- N° 3509 < vv GARD, demandeur.No.3509 < vv GARD, plaintiff, vs I vs, EUGENE JACQUES, (EUGÈNE JACQUES, de- defendeur.fendant.Comme appartenant au défendeur.As belonging to the defendant.\"Le lot numéro 136 du Cadastre du canton \"Lot number 136 of the cadastre of the town- de Bolton, et les bâtisses dessus érigées.\" ship of Bolton, and the buildings thereon erected.\" Pour être vendu à la porte de l'église catho- To be sold at the catholic church door of St- lique de St-Barnadin de Waterloo, MERCREDI Bernadin of Waterloo, WEDNESDAY, AU- le DIX-SEPT AOUT 1955 à DIX heures de GUST SEVENTEENTH, 1955, at TEN o'clock l'avant-midi.in the forenoon.Le Sheriff, A.ST.MARTIN, Bureau du Shérif, A.ST.MARTIN.Sheriff's Office, Sheriff.Palais de Justice, Court House, \"Sweetsburg, Québec.40282-28-2-o Sweetsburg, Quebec.40282-28-2 CHICOUTIMI CHICOUTIMI District de Chicoutimi District of Chicoutimi Cour Supérieure, ( t A CAISSE POPULAIRE Superior Court, (J A CAISSE POPULAIRE N° 19,399 < j-* DE BAGOTVILLE, so- No.19,399 ^ DE BAGOTVILLE, a \\ ciété coopérative régie par la I cooperative association gov- Loi coopérative de Québec, corps légalement erned by the Quebec Cooperative Act, a body 2162 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 juillet 1965, Tome 87, N° 28 constitué ayant son siège social, rue Albert Bagotville, district de Chicoutimi, demandeur; vs JEAN-YVES JEAN, papetier, domicilié au rang Saint-Anicet, Bagotville, district de Chicoutimi, défendeur.Contre le défendeur: \"Un terrain ou emplacement de forme irrégulière, mesurant quatre-vingt-six pieds de front, cent pieds de largeur, en arrière, quatre-vingt-six pieds de profondeur dans son côté est et soixante-sept pieds de profondeur dans son côté ouest, faisant partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro cinq cent vingt-neuf (partie N° 529).au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Alphonse, borné comme suit: En front à l'ancien chemin qui passait à cet endroit, en arrière ainsi que du côté ouest à la balance de ce lot restant à M; Riverin, et du côté est, au terrain de M.Louis-Joseph Jean, avec ensemble toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Tel que le tout est actuellement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées.Avec droit pour le propriétaire dudit terrain de passer sur le terrain de M.Henri Riverin pour communiquer dudit terrain au chemin public.\" Pour être vendu à lu porte de l'église paroissiale de Saint-Alphonse, de Bagotville, JEUDI, le VINGT-HUITIÈME jour du mois de JUILLET 1955, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, RENÉ DELISLE.Bureau du Shérif, Chicoutimi, le 18 juin 1955.40182-25-2-o District de Chicoutimi Cour Supérieure, / CAISSE POPULAIRE DE N° 19,398.< BAGOTVILLE, société v coopérative régie par la loi coopérative de Québec, corps légalement constitué ayant son siège social à rue Albert, Bagotville.tlistrict de Chicoutimi, demandeur; vs LOUIS JOSEPH JEAN, papetier, domicilié au rang St-Anicet Bagotville, district de Chicoutimi.défendeur.Contre le défendeur: \"Un terrain ou emplacement mesurant cinquante pieds de largeur par cent pieds de profondeur, faisant partie des lots de terre connus et désignés sous les numéros cinq cent vingt-neuf et cinq cent trente (Ptie Nos 529 & 530) au cadastre officiel de la paroisse de St-Alphonse, borné et compris dans les limites suivantes: En front vers le sud, au chemin public, en arrière, vers le nord, partie à la balance du lot cinq cent vingt-neuf et partie à la balance du lot cinq cent trente restant à Henrie Riverin, d'un côté vers l'est à la balance du lot numéro cinq cent trente, et de l'autre côté vers l'ouest à la balance du lot numéro cinq cent vingt-neuf, ledit terrain étant localisé vingt-cinq pieds de largeur sur chacun desdits lots, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Tel que le tout est actuellement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale «le St-AI»honse.de Bagotville.JEUDI, le VINGT-HUITIÈME jour du mois de JUILLET 1955, à DEUX heures TRENTE minutes de l'après-midi (2:30 hres p.m.).ï c Shérif Bureau du Shérif, RENÉ DELISLE.Chicoutimi.le 18 juin 1955.40181-25-2-O legally constituted having its head office on Albert Street, Bagotville.district of Chicoutimi, plaintiff; vs JEAN-YVES JEAN, paper maker, residing in range St.Anicet, Bagotville, district of Chicoutimi, defendant.Against the defendant: \"A piece of land or emplacement of irregular shape, measuring eighty-six feet in front, one hundred feet in width, in the rear, eighty-six feet in depth to the cast side and sixty-seven feet in depth to the west side, forming part of lot of land known and designated under number five hundred and twenty-nine (part No.529), on the official cadastre of the parish of St.Alphonse, bounded as follows: In front by the former road which passed at that place, in the rear as well as to the west side by the residue of said lot remaining with Mr.Riverin, and to the east side, by the land of Mr.Ixniis-Joseph Jean, together with all the buildings erected thereon, circumstances and dependencies.Such us the whole appears presently, with active and passive servitudes, apparent and iinappaicnI attaching thereto.The proprietor of said land having the right to pass on the land of Mr.Henri Riverin in order to commute between said land and the public road.\" To be sold at the parochial church door of St.Alphonse, of Bagotville, THURSDAY, the TWENTY-EIGHTH day of the month of JULY, 1955, at TWO o'clock in the afternoon.RENÉ DELISLE, Sheriff.Sheriff's Office, Chicoutimi, June 18th, 1955.40182-25-2 District of Chicoutimi Superior Court, l CAISSE POPULAIRE DE No.19,398.< v-| BAGOTVILLE, coope-v rative association governed by the Quebec Corporative Act, a body legally incorporated havingt its head office on Albert Street, Bagotville, district of Chicoutimi, plaintiff: vs LOUIS JOSEPH JEAN, papcrmakcr, domiciled in Range St-Anicet, Bagotvifle, district of Chicoutimi, defendant.Against the defendant: \"A lot of land or emplacement measuring fifty feet in width by one hundred feet in depth, forming part of lots of land known and designated under numbers five hundred and twenty-nine and five hundred and thirty (Pt.Nos.529 and 530) on the official cadastre of the parish of St-Alphonse, bounded and comprised within the following limits.\u2014 In front on the south, by the public highway, in rear, on the north, partly by the remainder of lot five hundred and twenty-nine and partly by the balance of lot five hundred and thirty remaining to Henrie Riverin, on one side towards the east, by the balance of lot five hundred and thirty, and on the other side, on the west, by the remainder of lot number five hundred and twenty-nine, the said lot of land being situate twenty-five feet in width upon each of the said lots, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.As the whole is to be found presently, with the servitudes, active and passive, apparent and unapparent thereto attached.\" To be sold at the parochial church door of St-Alphonse of Bagotville, THURSDAY, the TWENTY-EIGHTH day of the month of JULY, 1955, at TWO THIRTY o'clock in the afternoon (2:30 o'clock p.m.).RENE DELISLE, Sheriff's office, Sheriff.Chicoutimi, June IS, 1955.40181-25-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, July 16th, 1955, Vol.87, No.28 2163 HULL District de Hull Cour Supérieure, ( Ç*\\ E.ÉTHIER, garagiste, N° 3673.< >J» domicilié et résidant à (.Maniwaki, comté de Gati-neau, district de Hull, demandeur; vs ALPHONSE DÉNOMMÉ, cultivateur, domicilié et résidant à Blue Sea, district de Hull, défendeur.Le lot numéro huit (8) du septième rang, aux plan et livre de renvoi officiels pour le canton de Bouchette, evec les bâtisses y érigées, moins cependant et â déduire dudit lot: a) Partie appartenant à Daniel Courchaine ou représentants, telle que décrite dans une vente consentie audit Daniel Courchaine par J.Napoléon Fortin, enregistrée le 16 juin 1939, sous No.5605.b) Partie vendue par Alphonse Dénommé à Patrice Tremblay, en vertu d'une vente enregistrée le 10 juillet 1942, sous le N° 9346.c) Partie vendue par Alphonse Dénommé à Alain St.Jacques, en vertu d'une vente enregistrée le 26 novembre 1949, sous le No.23823.d) Partie cédée par Alphonse Dénommé à Jean-Marie Dénommé, en vertu d'une donation enregistrée le 5 décembre 1949, sous le N° 23855.e) Partie cédée par Alphonse Dénommé à Gilles Dénommé, en vertu d'une donation enregistrée le 5 décembre 1949, sous le N° 23856./) Partie cédée par Alphonse Dénommé à Guy Dénommé, en vertu d'une donation enregistrée le 15 décembre 1949, sous le N° 23927.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Félix de Blue Sea Lake, district de Hull, le VINGT-TROISIÈME jour du mois d'AOUT 1955, à TROIS heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.ST-PIERRE.Hull, ce 11 juillet 1955.40275-28-2-O District de Hull Cour Supérieure, ( T G.BISSON CONSTRUC-N°3517
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.