Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 décembre 1954, samedi 11 (no 50)
[" Tome 86, N° 50 3705 Vol.86,'.No.50 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant !e drapeau officiel de la province (14 Geo.VI ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC\tPROVINCE OF QUEBEC Québec, samedi 11 décembre 1954\tQuebec, Saturday, December 11th, 1954 AVIS AUX INTÉRESSÉS\tNOTICE TO INTERESTED PARTIES Règlements\tRules 1° Adresser toute correspondance à: lTmpri- 1.Address all communications to: The Queen's meur de la Reine, Québec.Printer, Quebec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues 2.Transmit advertising copy in the two official officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans languages.When saine is transmitted in one une seule langue, la traduction en est faite aux language only, the translation will be made at the frais des intéressés, d'après le tarif officiel.cost of the interested parties, according to official rates.3° Spécifier le nombre d'insertions.3.Specify the number of insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût 4.Cash payment is exacted for advertising des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cepen- copy before publication, according to the rates dant, exception est faite lorsque ces annonces hereinbelow set forth.Exception being made doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé when the said .advertising copy is to be published doit alors, acquitter la facture sur réception et several times.The interested party shall then avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière pay upon reception of his account and before insertion est suspendue, sans autre avis et sans the second insertion: otherwise this last insertion préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine will be suspended without further notice and qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute without prejudice as regards the rights of the somme versée en plus.Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., 5.Subscriptions, sale of documents, etc., are sont strictement payables d'avance.strictly payable in advance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de 6.Remittance must be made to the order of l'Imprimeur de la Reine, .par chèque visé, par the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank mandat de banque ou mandat-poste.or postal money order.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le 7.The Quebec Official Gazette is published every samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 3700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 60 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à mi li, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Heine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.S0 Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, dos frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 260 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mot?.Exemplaire séparé: 30 cents cKacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: 87 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec.27 juin 1940.31753 \u2014 1-52 Lettres patentes receiving notices documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provi led that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties arc requested to advise the\" Queen's Printer before the second insertion so as to avoi I, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 Ihes to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for c.ch version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: 81.per dozen.PuVcoptions: 87.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once arc followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Govemement House.Quebec, June 27th, 1910.31753 \u2014 1-52 Letters Patent (P.G.12747-54) (A.G.12747-54) < Abeta Mining Corporation Limited Ahcta Mining Corporation Limited (No Personal Liability) (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions delà Notice is hereby given that under the provi- Loi des compagnies minières de Québec, il a été sions of the Quebec Mining Companies' Act, accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- letters patent have been issued by the Lieute- vince de Québec, des lettres patentes en date du nant-Governor of the Province of Quebec, bearing cinquième jour de novembre 1954, constituant date the fifth day of November, 1954, incorpora- en corporation: Ernest La fontaine, avocat, J.ting: Ernest Lafontainc, advocate, J.Crawford Crawford Brown, bourgeois, tous deux des cité Brown, retired gentleman, both of the city and et district judiciaire de Montréal, et John W.judicial district of Montreal, and John W.MacKenzie, ingénieur minier, de Arntfield, MacKenzie, mining engineer, of Arntfield, judicial district judiciaire de Témiscaminguc, pour les district of Témiscamingue, for the following objets suivants: purposes: Faire des explorations et des recherches pour Prospect and explore for mines and minerais découvrir des mines et minerais et les négocier, and deal with same, under the name of \"Abeta sous le nom de \"Abeta Mining Corporation Minirg Corporation Limited\" (No Personal Limited\" (No Personal Liability), avec un capital Liability)* with a total capital stock of 85,000,000, total de S5,000,000, divisé en 5,000,000 d'actions divided into 5,000,000 shares of SI each, de 81 chacune.Les actionnaires de la compagnie n'encourront The shareholders of the company shall incur aucune responsabilité personnelle au delà du no personal responsibility in excess of the amount montant du prix payé ou convenu d'être payé à la of the price paid or agreed to be paid to the compagnie pour ses actions.company for its shares. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 195/,, Vol.86, No.50 3707 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal, Daté du bureau du Procureur général, ce cinquième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-0 Deputy Attorney General.(P.G.12725-54) American Buttons Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze\" novembre 1954, constituant en corporation: Louis Tabachnick, vendeur, Mendel Schre-kinger, marchand, tous deux de Montréal, Armand Bonneau, outilleur de Ville St-Michel, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de boutons, ornements et garnitures de toutes sortes, sous le nom de \"American Buttons Co.Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 400 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(A.G.12725-54) American Buttons Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1954, incorporating: Louis Tabachnick, salesman, Mendel Schrekinger, merchant, both of Montreal, Armand Bonneau, tool maker, of ville St.Michel, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as dealers in buttons, ornaments and trimmings of all kinds, under the name of \"American Buttons Co.Ltd.\", with a capital of 840,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-0 Deputy Attorney General.(P.G.J 2738-54) Arrow Pad Corporation (A.G.12738-54) Arrow Pad Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a éWthe Quebec Companies' Act, letters patent have accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the vince de Québec, des lettres patentes en date du Province of Quebec, bearing date the fifteenth day quinze novembre 1954, constituant en corpora- of November, 1954, incorporating: , Cyril .E.tion: Cyril E.Schwisberg, Irwin S.Brodie, Schwisberg, Irwin S.Brodie, advocates, of avocats, d'Outremont, et Sonya Schneyer, secré- Outremont, and Sonya Schneyer, secretary, taire, fille majeure, de Montréal, tous du district spinster, of Montreal, all of the judicial district of judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Montreal, for the following purposes: Manufacturer et faire le commerce de bourrures To manufacture and deal in shoulder pads of d'épaules de toutes sortes et genres, garnitures all manners and types, tailors' trimming and pour tailleurs et nouveautés, sous le nom de \"Ar- novelties, under the name of \"Arrow Pad Corpo- row Pad Corporation\", avec un capital total dc ration\", with a total capital stock of 840,000, 840,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 divided into 400 common shares of 8100 each.chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.* L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12312-54) Beau Marché Ltéc Avis est donné qu'en vertu dé la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatre novembre 1954, constituant en corporation: Michael Drazncr, Isidore Greenbaum, avocats, Wolfe Friedman, étudiant en droit, tous des cité et district judiciaire dc Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de manufacturiers et marchands de vêtements, marchandises sèches, garnitures de tailleurs, soieries, satins, lainages, tissus textiles de toutes sortes, étoffes, cotonnades, fourrures et garnitures de robes, galons, cordons, ornements, dentelles, boutons, accessoires électriques, nouveautés, articles en cuir, bijouterie, vêtements et habits de toute The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-o Deputy Attorney General.(A.G.12312-54) Beau Marché Ltéc Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of November, 1954, incorporating: Michael Drazncr, Isidore Greenbaum, advocates, Wolfe Friedman, law student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade and business of manufacturers, and dealers in clothing, dry goods, tailors' trimmings, silks, satins, woollens, textile fabrics of all kinds, cloth, cotton goods, fur and dress trimmings, braids, cords, ornaments, laces, buttons, electric appliances, novelties, leather goods, jewellery, garments and wearing apparel of every description, under the name of \"Beau 3708 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 60 description, sous le nom de \"Beau Marché Ltée\", avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune et en 200 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12636-54) Boulangerie Moderne Vald'Or Ltée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre 1954, constituant en corporation: Dominique Caouctte, boulanger, Léo Gauthier, comptable, et Vital Cliche, avocat, tous de Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: .Exercer le commerce de boulanger, confiseur et manufacturier de biscuits, sous le nom de \"Boulangerie Moderne Vald'Or Ltée\", avec un capital total dc S65.000, divisé en 650 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12743-54) Braided Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze novembre 1954, constituant en corporation: David Lack, avocat, Pearl Auerbach, secrétaire, célibataire, tous deux de Montréal et Rhoda Cohen, secrétaire, célibataire, d'Outre-mont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et négocier des fibres, fils, galons, cordons, rubans et produits connexes, sous le nom dé \"Braided Products Ltd.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de S50 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.' 12765-54) Buffet Raymond Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze novembre 1954 constituant en corporation: Eugène Charbonneau, imprimeur et éditeur, d'Outremont, Réal Marcoux, avocat, de Montréal, tous deux du district judiciaire de Montréal, et Ronald Halpin, avocat et conseil en Loi de la Reine, de Saint-Eustache, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Marché Ltée\", with a capital of $40,000, divided into 200 preferred shares of the par value of $100 each and into 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the fourth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-0 Deputy Attorney General.(A.G.12636-54) Boulangerie Moderne Vald'Or Ltéc Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, dated November sixteenth, 1954, incorporating: Dominique Caouette, baker, Léo Gauthier, accountant, and Vital Cliche, advocate, all of Val d'Or, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To carry on business as a baker, confectioner and manufacturer of biscuits, under the name of \"Boulangerie Moderne Vald'Or Ltée\", with a total capital stock of $65,000, divided into 650 shares of $100 each.The head office of the company will be at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12743-54) Braided Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1954, incorporating: David Lack, advocate, Pearl Auerbach, secretary, unmarried, both of Montreal, and Rhoda Cohen, secretary, unmarried, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the' following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in fibres, threads, braided lines, cords, ribbons, and allied products, under the name of \"Braided Products Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares Of the par value of $50 each and into 200 preferred shares of the par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-o Deputy Attorney General.(A.G.12765-54) Buffet Raymond Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November 1954, incorporating: Eugène Charbonneau, printer and editor, of Outremont, Real Marcoux, advocate, of Montreal, both of the judicial district of Montreal, and Ronald Halpin, advocate, and Queen's Counsel, of Saint-Eustache, judicial district of Terrebonne, for for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 195k, Vol.86, No.60 3709 Exercer les opérations de restaurateurs et hôtel iess, sons le nom de \"Buffet Raymond Inc.\", avec un capital total de 815,000, divisé en 150 actions de S100 chacune.Le siège t >eial de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12771-54) C.D'Alcantara Ltéc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze novembre 1954, constituant en corporation: Herman Plante, comptable, 'Jean-Marie Martel, étudiant comptable, tous deux de Montréal, et Jean-G.Peloquin, comptable agréé, de Longueuil, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations de fleuriste et d'horticulteur, sous le nom de \"C.D'Alcantara Ltée\", avec un capital total de 875,000, divisé en 500 actions ordinaires dc 8100 chacune et en 250 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie» sera «à 8976, rue Notre-Dame, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o C.E.CANTIN.(P.G.12803-54) Charles Gauthier Limitée \u2022 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze novembre 1954, constituant en corporation: Charles Gauthier, restaurateur, Robert Gauthier, instituteur, et Maurice Gauthier, opticien, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs et hôteliers, sous le nom de \"Charles Gauthier Limitée\", avec un capital total de 8100,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et en 7,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.11659-54) Clearside Explorations Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seize novembre 1954, constituant en corporation: Maxwell M.Ellison, Maurice Steinberg, avocats, Thomas Gavin, comptable, James Mc-William, expert industriel, et Helen Borenstein, secrétaire, fille majeure, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: To carry on the operations of restaurateurs and hotel-keepers, under the name of \"Buffet Raymond Inc.\", with a total capital stock of 815,000, divided into 150 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of November 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12771-54) C.D'Alcantara Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November 1954, incorporating: Herman Plante, accountant, Jean-Marie Martel, student accountant, both of Montreal, and Jcan-G.Peloquin, chartered accountant, of Longueuil.all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a florist and horticulturist, under the name of \"C.D'Alcantara Ltée\", with a total capital of 875,000, divided into 500 common shares of 8100 each and 250 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at 8976 Notre Dame Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of November 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12803-54) Charles Gauthier Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November 1954, incorporating: Charles Gauthier, restaurateur, Robert Gauthier, teacher, and MauVice Gauthier, optician, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs and hotel-keepers, under the name of \"Charles Gauthier Limitée\", with a total capital stock of S 100.000, divided into 2,500 common shares of a par value of S10 each and 7,500 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of November 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.11659-54) Clearside Explorations Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, incorporating: Maxwell M.Ellison, Maurice Steinberg, advocates, Thomas Gavin, accountant, James McWilliam, industrial consultant, and Helen Borenstein, secretary, spinster, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: 3710 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 50 Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Clearsidé Explorations Limited\" (No Personal Liability) avec un capital total de 83,000,000, divisé en 3,000,000 d'actions de $1 chacune.Les actionnaires de la compagnie n encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à 510 rue McGill, suite 3, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12703-54) Commercial Lit ho Plate Graining Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douzième jour de novembre 1954, constituant en corporation: David Schwartz, avocat, Joseph William Cox, fleuriste, tous deux de Valois et William Edward McCarthy, ingénieur, dc Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exécuter la préparation, le traitement et le grainage d'aucune et toute sorte de plaques utilisées dans le métier de la lithographie; fabriquer et vendre des produits chimiques utilisés dans le traitement dc plaques lithographiques presensibilitées et les accessoires dc lithographie en général, sous le nom dc \"Commercial Litho Plate Graining Ltd.\", avec un capital total do 8100,000, divisé en 600 actions prévilégiées catégorie \"A\" d'une valeur au pair de S100 chacune et 20,000 actions privilégiées catégorie \"B\" d'une valeur au pair de SI chacune et en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce douzième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12789-54) Do-Mar Steel & Alloy Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en.date du quinze novembre 1954, constituant en corporation: Cecil H.Macnaughtcn, avocat, de Saint-* Lambert, Jean Bruneau, avocat, de Longueuil, et Suzanne Savignac, sténographe, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire dc Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer Je commerce dc produits dans la fabrication desquels entrent du fer, de l'acier, de la fonte, de l'aluminium ou autres métaux, sous le nom dc \"Do-Mar Steel & Alloy Inc.\", avec un capital total de 840,000, divisé en 250 actions ordinaires de 8100 chacune et en 150 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Basile-le-Grand, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-e C.E.CANTIN.Prospect and explore for mines and minerais and deal with same, under the name of \"Olear-side Explorations Limited\" (No Personal Liability), with a total capital stocks of 83,000,000, divided into 3,000,000 shares of 81 each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at 510 McGill Street, Suite 3, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-u Deputy Attorney General.(A.G.12703-54) Commercial Lilho Plate Graining Ltd.Notice is hereby given that u'lder Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1954, incorporating: David Schwartz, advocate, Joseph William Cox, florist, both of Valois, and William Edward McCarthy, engineer, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: The preparation, processing and graining of any and all li ds of plites used in the lithographic trade; the manufacture and sale of chemicals use:! in the treatment of presensitized lithographic plates and the sales of general lithographic supplies, under the name of \"Commercial Litho Plate Graining Ltd.\", with a total capital stock of 8100,030, divided into 600 class \"A\" preferred shares of the par value of S100 each and 20,030 class \"B\" preferre 1 shares of the par v: 1 îe of 81 each and into 200 common shares of the par value of 8103 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-0 Deputy Attorney General.(A.G.12789-54) Do-Mar Steel & Alloy Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November 1954, incorporating: Cecil H.Macnaughtcn, advocate, of Saint-Lambert, Jean Bruneau, advocate, of Longueuil, and Zuzannc Savignac, stenographer, fille majeure, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in products into the fabrication of which enters iron, steel, cast iron, aluminium or other metals, under the name of \"Do-Mar Steel & Alloy Inc.\", with a total capital stock of S40,000, divided into 250 common shares of S100 each and 150 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Saint-Basile-lc-Grand, judicial district of Montreal.Dated at* the office of the Attorney General, this fifteenth day of November 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, Vol.86, No.50 3711 (P.G.12873-54) < Dominion Ready Mix Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt novembre 1954, constituant en corporation: Adrien Hébert, homme d'affaires, Gaston Flibotte, entrepreneur et marchand, tous deux de Québec, et Jacques Émond, gérant, de Lac St-Charlcs, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'entrepreneur pour l'exécution, l'érection, la confection, la réparation et la modification de tous ouvrages et bâtisses, publics, ou privés, sous le nom de \"Dominion Ready Mix Inc.\", avec un capital total de 850,000, eivisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec-Ouest, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o C.E.CANTIN.(P.G.13494-54) Dry Wall Applicators Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du neuf octobre 1954, constituant en corporation: Alexander Ciega, avocat, Lvo Cardinal, entrepreneur, et Fernand Beauregard, étudiant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'excavation, d'isolation, de l'application et la pose de tous genres de planches murales; faire affaires comme entrepreneurs et sous-entrepreneurs en .général, sous le nom de \"Dry Wall Applicators Inc.\", avec un capital total dc 850,000, divisé en 210 actions ordinaires de 8100 chacune et en 290 actions privilégiées de 8100 chacune.^ Le siège social de la compagnie sera à 57 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf octobre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12855-54) Eastern Townships Terrazzo Tile Marble Ltd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes, en date du dix-huit novembre 1954, constituant en corporation: Gérard Corbeil, avocat, de Longueuil, Janine Pilon et Yvette Marcoux, secrétaires, filles majeures, de* Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations de manufacturier et de poseur de tuiles, de terrazzo et de marbre, de propriétaire ou opérateur d'entreprise de construction, de carrières, ainsi que d'usines d'asphalte et de béton, sous le nom de \"Eastern Townships Terrazzo Tile Marble Ltd\", avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions communes d'une valeur au pair de 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair do S10 chacune.(A.G.12873-54) Dominion Ready Mix Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Litutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of November, 1954, incorporating: Adrien Hébert, business man, Gaston Flibotte, contractor and merchant, both of Quebec, and Jacques Émond, manager, of Lake St-Charlcs, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate as a contractor for the execution, erection, confection repairs and modification of all kinds of work and buildings, public or private, under the name of \"Dominion Ready Mix Inc.\", with a total* capital stock of S50,000, divided into 300 common shares of 8100 each and into 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Quebec-West, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 3S761 Deputy Attorney General.(A.G.12494-54) Dry Wall Applicators Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of October, 1954, incorporating: Alexander Bic-ga, advocate, Léo Cardinal, contractor, and Fernand Beauregard, student, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: \u2022 To carry on a business of excavation, insulation, application and erection of all types of wall board; to do business as contractors and sub-contractors in general, under the name of \"Dry Wall Applicators Inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 210 common shares of 8100 each and into 290 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at 57 St.James St.West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of October, 1954.C.E.CANTIN, 38701-o Deputy Attorney General.(A.G.12S55-54) Eastern Townships Terrazzo Tile Marble Ltd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighteenth day of November, 1954, incorporating: Gérard Corbeil, advocate, of Longueuil, Janine Pilon and Yvette Marcoux, secretaries, spinsters, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of manufacturers and layers of tile terrazzo and marble, owners or operators of building and quarrying enterprises, as well as those of asphalt and concrete plants, under the name of \"Eastern Townships Terrazzo Tile Marble* Ltd\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of a par value of 810 each and 2,000 preferred shares of a par value of 810 each. 3712 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 50 Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o C.E.CANTIN.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of Saint Francis.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(P.G.12710-54) (A.G.12710-54) Grand Hardware Inc.Grand Hardware Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été the Quebec Companies' Act, letters patent have accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- been issued by the Lieutenant-Governor of the vince de Québec, des lettres patentes en date du Province of Quebec, bearing date the twelfth day douzième jour de novembre 1954, constituant of November, 1954, incorporating: John Jacob en corporation: John Jacob Spcctor, avocat et Spector, advocate and Queen's Counsel, Ben Conseil en Loi de la Reine, Ben Schecter, avocat Schecter, advocate, and Magaret McMartin, et Margaret McMartin, commis, fille majeure, clerk, spinster, all of the city and judicial district tous des cité et district judiciaire de Montréal, of Montreal, for the following purposes: pour les objets suivants: Exercer dans toute ou aucune dc leurs spéciali- To carry on in all or any of their branches all tés tous ou aucun des commerces de ferronnerie, or any of the business of hardware, under the sous le nom de \"Grand Hardware Inc.\", avec un name of \"Grand Hardware Inc.\", with a total capital total de 850,000, divisé en 300 actions capital stock of 850,000, divided into 300 common ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et shares of the par value of 8100 each and into 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 200 preferred shares of the par value of 8100 8100 chacune.each.Le siège social de la compagnie sera à 6165 The head office of the company will be at avenue Monkland, Montréal, district judiciaire 6165 Monkland Ave., Montreal, judicial district de Montréal.of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, ce Dated at the office of the Attorney General, douzième jour de novembre 1954.this twelfth day of November, 1954.L'Assistant-procureur général, C.E.CANTIN, 38761 C.E.CANTIN.38761-o Deputy Attorney General.(P.G.12746-54) (A.G.12746-54) Quildcraft Artistic Jewellery Ltd.Quildcraft Artistic Jewellery Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the fifth day du cinq novembre 1954, constituant en corpo- of November, 1954, incorporating: Ernest La-ration: Ernest Lafontaine, avocat, Jacques La- fontaine, advocate, Jacques Laf ont aine, man-fontaine, gérant, Crawford Brown, bourgeois, ager, Crawford Brown, gentleman, all of the tous des cité et district judiciaire de Montréal, city and judicial district of Montreal, for the pour les objets suivants: following purposes: Exercer le commerce qui consiste à négocier To carry on business as merchants dealing toutes catégories de marchandises ordinaire- in ail classes of merchandise usually carried in ment gardées en magasin par les bijoutiers, or- stock by jewellers, silversmiths, watchmakers, fèvres, fabricants de montres et horlogers, sous clockmakers, under the name of \"Guildcraft Arti- le nom de \"Guildcraft Artistic Jewellery Ltd.\", stic Jewellery Ltd.\", with a capital of $20,000, avec un capital de $20,000, divisé en 200 actions divided into 200 shares of $100 each, de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Mont- The head office of the company will be at real, district judiciaire de Montréal.Montreal, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le cinq Dated at the office of the Attorney General, novembre 1954.this fifth day of November, 1954.L'Assistant-procureur général, \u2022 C.E.CANTIN, 38761 C.E.CANTIN.38761-o Deputy Attorney General.(P.G.12891-54) (A.G.12891-54) Jean Tellier & Fils Limitée Jean Tellier & Fils Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the twenty-du vingt-quatre novembre 1954, constituant en fourth day of November, 1954, incorporating: corporations: Jean Tellier, courtier en assu- Jean Tellier, insurance broker, Pierre Tellier, ranees, Pierre Tellier, agent d'assurances, et insurance agent, and Charles Robillard, chart-Charles Robillard, comptable agréé, tous des ered accountant, all of the city and judicial discité et district judiciaire de Joliette, pour les trict of Joliette, for the following purposes: objets suivants: Agir comme courtier en assurances, sous le To operate as an insurance broker, under nom de \"Jean Tellier & Fils Limitée\", avec un the name of \"Jean Tellier & Fils Limitée\", QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, Vol.86, No.60 3713 capital total de $75,000, divisé en 7,500 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 418, rue Manseau, Joliette, district judiciaire de Juliette.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-quatre novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o C.E.CAJSTIN.(P.G.12352-54) J.I.Claude Construction Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze novembre 1954, constituant en corporation: Wilfrid Eltlege Lauriault, arpenteur-géomètre, de Montréal, Donalda Trudeau Claude, journaliste, épouse contractuellement séparée de biens de Irénée Claude, agent d'immeubles, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Marcelle Tanguay, secrétaire, fille majeure, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'entrepreneurs en construction, sous le nom dc \"J.I.Claude Construction Incorporée\", avec un.capital total de '$100,000, divisé en 750 actions ordinaires de 8100 chacune et en 250 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social de là compagnie sera à Verdun, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12534-54) Jos.Lahoud Automobiles Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze octobre 1954, constituant en corporation: Joseph Lahoud, Michel Lahoud, commerçants, et Maurice Lahoud, étudiant en droit, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer un commerce d'automobiles et toutes les opérations accessoires qui s'y rattachent, sous le nom de \"Jos.Lahoud Automobiles Limitée\", avec un capital total de $3,000, divisé en 30 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 130, de la Couronne, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le douze octobre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12666-54) Katz Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze.novembre 1954, constituant en corporation: Max S.Kaufman, avocat, de West-mount, Joseph Roy Hoffman, avocat, de Mont-tréal et Léonore Gloven, fille majeure, secrétaire d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands et négociants, en général, de fruits et légumes, sous with a total capital stock of $75,000, divided into 7,500 shares of $10 each.The head office of the company will be at 418, Manseau Street, Joliette, \u2022 judicial district of Joliette.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fourth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12352-54) J.I.Claude Construction Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1954, incorporating: Wilfrid Eldege Lauriault, land-surveyor, of Montreal, Donalda Trudeau Claude, journalist, wife contractually separate as to property of Irénée Claude, real estate agent, and duly authorized by him for the purposes herein, and Marcelle Tanguay, secretary, spinster, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of building contractors, under the name of \"J.I.Claude Construction Incorporée\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 750 common shares of 8100 each and 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Verdun, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12534-54) Jos.Lahoud Automobiles Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twcl'th day of October, 1954, incorporating: Joseph Lahoud, Michel Lahoud, dealers, and Maurice Lahoud, law student, all of the city and ju licial district of Quebec, for the following purposes: To deal in automobiles and carry on all accessories operations pertaining thereto, under the name of \"Jos.Lahoud Automobiles Limitée\", with a total capital stock of 83,000, divided into 30 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 130, Crown Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of October, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12666-54) Katz Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of November, 1954, incorporating: Max S.Kaufman, advocate, of Wcstmount, Joseph Roy Hoffman, advocate, of Montreal, and Léonore Gloven, fille majeure, secretary, of Outremont, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of fruit and vegetable merchants and general traders, under the 3714 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 195.',, Tome 86, N° 50 le nom de \"Katz Co.\", avec un capital de 140,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chadune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune et 100 actions catégorie \"A\" de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12768-54) Les Immeubles Bizier Ltéc Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes, en date du neuf novembre 1954, constituant en corporation: Lavery Sirois, notaire, de Sillery, Pauline Davignon, secrétaire, de Lauzon, et Laurettc Hudon, copiste, de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les bojets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de portefeuille et de gestion, sous le nom dc \"Les Immeubles Bizier Ltée\", avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions de S100 chacune.» Le siège social de la compagnie sera à 43^, rue St-Joseph, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12148-54) Les Loisirs de Giffard Inc.Avis est donné qu'en vertu, de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre 1954, constituant en corporation: sans capital-actions: Barthélémy Renaud, Georges-Edgar Girard in, employés civils.Jean-Charles Lemay, Léo Pelletier, professeurs, Marcel Roy, gérant, Louis-Philippe Roy, journaliste, Paul-Êmile Veilleux, imprimeur, Edmond-Louis Maltais, postier ambulant, Dclphis Rousseau, mécanicien, et Paul-Émile Lapointc, agent, tous de Giffard, district judiciaire dc Québec, pour les objets suivants: Grouper les enfants, les jeunes gens et les adultes de la cité de Giffard, en vue d'organiser leurs loisirs extra scolaires et extra familiaux, sous le nom de \"Les Loisirs de Giffard Inc.\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 8100,000.Le siège social de la corporation sera à Giffard, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o C.E.CANTIN.(P.G.12766-54) Longucuil Development Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinze novembre 1954, constituant en corporation: Samuel Chait, Harry L.Aronovitcli, et name of \"Katz Co.\", with a capital of 840,000,.divided into 100 common shares of 8100 each, and into 200 preferred shares of S100 each, and 100 Class \"A\" shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of November, 1954.C.E.CANTIN.38761-0 Deputy Attorney General.(A.G.12768-54) Les Immeubles Bizier Ltée Notice is* hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of November, 1954, incorporating: Lavery Sirois, notary, of Sillery, Pauline Davignon, secretary of Lauzon, and Laurettc Hudon, copyist, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of a holding and administration company, under the name of \"Les Immeubles Bizier Ltée\", with a total capital stock, of S10,000, divided into 100 shares of 8100 each.The head office of the company will be at 43J/J2 St-Joseph Street, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of November, 1951.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12148-54) Les Loisirs dc Giffard Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issue;! by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, to incorporate as a corporation without share capital: Barthélémy Renaud, Georges Edgar Girar lin, civil servants, Jean-Charles Lemay, Léo Pelletier, professors, Marcel Roy, manager, Louis Philippe Roy, journalist, Paul-Émile Veilleux, printer, Edmond-Louis Maltais, postman, Dclphis Rousseau, mechanic, and Paul-Êmile Lapointc agent, all of Giffard, judicial district of Quebec, for the following purposes: Grouping together the children, youth and adults of the city of Giffard, in order to organize recreational activities for them, exclusive of their family and school life, under the name of \"Les Loisirs de Giffard Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is 8101,000.The head office of the corporation will be at Giffard, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12766-54) Longueuil Development Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1954, incorporating: Samuel Chait.Harry L.Aronovitch and Abraham QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1964, Vol.80, No.60 3715 Abraham Sinister, tous avocats, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants : Agir comme une corporation de portefeuille et de placements, sous le nom de \"Longueuil Development Corporation\", avec un capital total de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38701 C.E.CANTIN.(P.G.12405-54) Louis Corbeil Incorporé Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize novembre, 1954, constituant en corporation: Louis Corbeil, entrepreneur, Cécilia Dumoulin, ménagère, épouse contractucllement séparée dc biens dudit Louis Corbeil et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, et Roger Dumoulin, menuisier, tous des cité et district judiciaire dc Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de construction, d'entreposage \u2022 et de transport, sous le nom de \"Louis Corbeil Incorporé\", avec un capital total de S100.000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 500 actions privilégiées dc 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1710, rue Fleury est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12420-54) Monarch Asbestos Co.Ltd (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix-neuf octobre 1954, constituant en corporation: Henri Crépeau, C.R., avocat, Françoise Gagnon et Yvette Picard, secrétaire, filles majeures, tous des cité et district judiciaire dc Montréal, poulies objets suivants: Faire des recherches et des explorations pour découvrir des mines et minerais et les négocier, sous le nom de \"Monarch Asbestos Co.Ltd\" (No Personal Liability), avec un capital total de 84,000,000, divisé en 4,000,000 d'actions dc $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leur actions.Le siège social de la compagnie sera à 132, rue St-Jacques, ouest, chambre 326, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf octobre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.Sinister, all advocates, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a holding and investment corporation, under the name of \"Longueuil Development Corporation\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of the par value of 8100 each and into 300 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 3876l-o Deputy Attorney General.(A.G.12405-54) Louis Corbeil Incorporé Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, incorporating: Louis Corbeil.contractor, Cécilia Dumoulin, housewife, wife separate as to property of the said Louis Corbeil, and duly authorized by the latter for these present purposes, and Roger Dumoulin, joiner, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a building, warehousing and transportation company, under the name of \"Louis Corbeil Incorporé\", with a total capital stock of SI 00,000, divided into 500 common shares of a par value of 8100 each and into 500 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at 1710 Fleury Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney Général, this sixteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12420-54) Monarch Asbestos Co.Ltd (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of October 1954, incorporating: Henri Crépeau, Q.C., advocate, Françoise Gagnon and Yvette Picard, secretaries, filles majeures, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals and deal with same, under the name of \"Monarch Asbestos Co.Ltd\" (No Personal Liability), with a total capital stock of S4,000,000, divided into 4,000,000 shares of SI each.The shareholders of the company shall incur no personal responsibility in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at 132 St.James Street, west, Room 326, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of October, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General. 3716 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 50 (P.G.12734-54) Plomberie Morin Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze novembre 1954, constituant en corporation: Y von Morin, entrepreneur en plomberie et chauffage, Yvonne Roy Morin, ménagère, épouse commune en biens dudit Yvon Morin et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous deux de Sherbrooke, et Henri-Louis Morin, serre-freins, dc Mégantic, tous du district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'un entrepreneur en plomberie et chauffage, sous le nom de \"Plomberie Morin Limitée\", avec un capital total de 825,000, divisé en 250 actions d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 -o C.E.CANTIN.(P.G.12707-54) Pointe Claire Barbecue & Spaghetti \u2022 House Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huitième jour de novembre 1954, constituant en corporation: Marcelle Lussier, avocat, d'Outre-mont, Jeanne Scnay, sténographe, fille majeure, de Verdun et Jacqueline Matte, sténographe, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et exploiter des restaurants, sous le nom de \"Pointe Claire Barbecue & Spaghetti House Inc.\", avec un capital total de 850,000, divisé en 1,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la ville de Pointe Claire, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 .C.E.CANTIN.(P.G.12736-54) Powers of Paris Limited Avis est donné, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huitième jour de novembre 1954, constituant en corporations: Frank Bernard Chauvin, Robert Harold Walker, avocats et Conseils en Loi de la Reine, Peter Robert MacKell, avocat, Madeleine F.Brennan, secrétaire, fille majeure, tous de Montréal, William Tetley, Charles Alexander Phelan, avocats de ville Mont Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de bas, lingerie et autres articles vestimentaires, sous le nom de \"Powers of Paris Limited\", avec un capital total de 840,000 divisé, en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.(A.G.12734-54) Plomberie Morin Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1954, incorporating: Yvon Morin, plumbing and heating contractor, Yvonne Roy Morin, housewife, wife common as to property of the said Yvon Morin and duly authorized by the latter for these present purposes, both of Sherbrooke, and Henri-Louis Morin, brakeman, of Mégantic, all of the judicial district of Saint-Francis, for the following purposes: To operate as a heating and plumbing contractor, under the name of \"Plomberie Morin Limitée\", with a total capital stock of 825,000, divided into 250 shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G; 12707-54) Pointe Claire Barbecue & Spaghetti House Inc.Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November, 1954.incorporating: Marcelle Lussier, lawyer, of Outremont, Jeanne Senay, stenographer, spinster, of Verdun, and Jacqueline Matte, stenographer, spinster, of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and operate restaurants, under the name of \"Pointe Claire Barbecue & Spaghetti House Inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 1,500 common shares of a par value of 810 each and into 350 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be in the town of Pointe Claire, judicial district of Montreal.Dater! at the office of the Attorney General, this eighth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-0 Deputy Attorney General.(A.G.12736-54) Powers of Paris Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November 1954, incorporating: Frank Bernard Chauvin, Robert Harold Walker, advocates and Queen's Councels, Peter MacKell, advocate, Madeline F.Brennan, secretary, spinster of the full age of majority, all of Montreal, William Tetley, Charles Alexander Phelan, advocates, of the town of Mount Royal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and sell hosiery, lingerie and other articles of wearing apparel, under the name of \"Powers of Paris Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1951, Vol.86, No.50 3717 Daté du bureau du Procureur général, ce huitième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12548-54) Produits Deshydratés Roza Cie Ltée Roza Dehydrated Food Products Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres, patentes, en date du quinze novembre 1954, constituant en corporation: Roland Robillard, avocat, Rosaire Guay, vendeur, et Wilfrid Ward, négociant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de bases alimentaires, de produits deshydratés et de préparations culinaires, sous le nom de \"Produits Deshydratés Roza Cie Ltée \u2014 Roza Dehydrated Food Products Co.Ltd.\", avec un capital total de 817,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et en 70 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o C.E.CANTIN.(P.G.12521-54) Pyramid Building Products Ltd.Produits de Construction Pyramide Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatre novembre 1954, constituant en corporation: José Luis Antolinez.administrateur, de Laval-sur-le-Lac, Roger Varrin, représentant, d'Outremont, et Jacques Chadillon, comptable agréé, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: * Manufacturer et exercer le commerce de matériaux de construction eu autres produits connexes, sous le nom de \"Pyramid Building Products Ltd.\u2014 Produits de Construction Pyramide Ltée'-', avec un capital total de 85,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 85 chacune et en 45 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI 00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatre novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12772-54) Shawinigan Falls Hockey Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze novembre 1954, constituant en corporation: Arthur Lacoursière, architecte, Joseph-L.Tremblay, ajusteur, Fernand Lemay, hôtelier, Gilles Trudel, journaliste, et André Lefebvre, secrétaire, tous de Shawinigan-Falls, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Construire et exploiter un arena, auditorium ou amphithéâtre et tous édifices quelconques, sous Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-o Deputy Attorney General.(A.G.12548-54) Produits Deshydratés Roza Cie Ltée Roza Dehydrated Food Products Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1954, incorporating: Roland Robillard, advocate, Rosaire Guay, salesman, and Wilfrid Ward, merchant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business in basic foodstuffs, dehydrated, products and culinary preparations, under the name of \"Products Deshydratés Roza Cie Ltéc \u2014 Roza Dehydrated Food Products Co.Ltd.\", with a total capital stock of 817,000, divided into 1,000 common shares of a par value of S10 each and into 70 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12521-54) Pyramid Building Products Ltd.Produits de Construction Pyramide Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of November, 1954, incorporating: José Luis Antolinez, administrator, of Laval-sur-le-Lac, Roger Varrin, representative of Outremont, and Jacques Chadillon, chartered accountant, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in building materials or other connected products, under the name of \"Pyramid Building Products Ltd.\u2014 Produits de Construction Pyramide Ltée\", with a total capital stcck cf S5,000, divided into 1C0 common shares of a par value of 85 each and into 45 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12772-54) Shawinigan Falls Hockey Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of November, 1954, incorporating: Arthur Lacoursière, architect, Joseph-L.Tremblay, adjuster, Fernand Lemay, hotel-keeper, Gilles Trudel, journalist, and André Lefebvre, secretary, all of Shawinigan Falls, judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To build and operate an arena, autorium or amphitheatre and buildings of any kind, under 87IS GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre l'JôJ,, Tome 80, N° 60 le nom de \"Shawinigan Falls Hockey Club Inc.\", avec un capital total de 850,000, divisé eu 500 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Shawinigan-Falls, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le onze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12781-54) Sifto Sait Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de novembre 1954, constituant en corporation: William Patrick Creagh, commis en loi, Ernest William Mockridge, administrateur et Cecil Bruce Cookc, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, poulies objets suivants: Manufacturer et faire le commerce du sel, sous le nom dc \"Sifto Sait Limited\", avec un capital divisé en 100 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12723-54) Southwest Really Co.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quinzième jour dc novembre 1954, constituant en corporation: Harold S.Freeman, avocat, Dorothy Martel et Theresa Murray, secrétaires, filles majeures, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Southwest Realty Co.\", avec un capital total de 875,000, divisé en 1,500 actions ordin-naires de S10 chacune et 600 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12786-54) St-Georges Côté Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouver»eur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf novembre 1954, constituant en corporation: St-Georges Côté, artiste, Jacqueline Bienvenue Côté, artiste, épouse séparée de biens dud it St-Georges Côté, tous deux de Sillery, et Paul Gingras, comptable agréé, dc Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants : Exercer les opérations d'impressario, réalisateur, gérant d'artistes, d'annonceur, de maître de cérémonie et vendeurs de programmes de radio, de télévision, de vaudeville et de variétés, sous the name of \"Shawinigan Falls Hockey Club Inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 500 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Shawinigan-Falls, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12781-54) Sifto Salt Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, incorporating: William Patrick Creagh, law clerk, Ernest William Mock-ridge, manager, and Cecil Bruce Cooke, secretary, all of the city and judicial district of Mont-treal, for the following purposes: To manufacture and deal in salt, under the name of \"Sifto Salt Limited\", with a capital stock divided into 100 shares without nominal oikpar value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-0 Deputy Attorney General, (A.G.12723-54) Southwest Really Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of November, 1954, incorporating: Harold S.Freeman, advocate, Dorothy Martel and Theresa Murray, secretaries, spinsters of the full age of majority, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in immoveable property, under the name of \"Southwest Realty Co.\", with a total capital stock of 875,000, divided into 1,500 common shares of 810 each and into 600 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-0 Deputy Attorney General.(A.G.12786-54) St-Georges Côté Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of November, 1954, incorporating: St-Georges Côté, artist, Jacqueline Bienvenue Côté, artist, wife separate as to property of the said St-Georges Côté, both of Sillery, and Paul Gingras, chartered accountant, of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the operations of impresario, producer, manager for artists, announcer, master of ceremonies and salesman of radio, television, vaudeville and variety programmes, under the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, Vol.80, No.50 3719 le nom de \"St-Georges Côté Inc.\", avec un capital total de S100,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur de 8100 chacune et en 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1710, Parc Chesnaye, Sillery, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.name of \"St-Georges Côté Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 500 com-mrn shares of a par value of S100 each and 500 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company will be at 1710 Park Chesnaye, Sillery, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(P.G.12788-54) St-Pierre Auto Electric Liée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf novembre 1954, constituant en corporation: Gérard St-Pierre, garagiste, Madeleine Vézeau St-Pierre, ménagère, épouse séparée de biens dudit Gérard St-Pierre et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, et André St-Pierrc, garagiste, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'automobiles et de tout ce qui s'y rapporte, sous le nom de \"St-Pierre Auto Electric Ltée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 400 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.127S0-54).The Laprairie Brick & Tile Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, des lettres patentes en date du seizième jour de novembre 1954, constituant en corporation: William Patrick Creagh, commis en loi, Ernest William Mockridge, administrateur et Cecil Bruce Cooke, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toute et aucune sorte et description de briques, tuiles, tuyaux, poterie, articles en grès, porcelaine de chine, articles en or, argile, menus objets en terre cuite et céramique, sous le nom de \"The Laprairie Brick & Tile Incorporated\", avec un capital de 100 actions sans valeur nominale ou au pair.Le siège social dc la compagnies sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12728-54) Torco Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deuxième jour de novembre 1954, constituant en corporation: Koger Louis Beaulieu, Jérôme Choquette, avocats, de Montréal, George (A.G.12788-54) St-Pierre Auto Electric Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of November, 1954, incorporating: Gérard St-Pierre, garage-keeper, Madeleine Vézeau St-Pierre, housewife, wife separate as to property of the said Gérard St-Pierre and duly authorized by the latter for these present purposes, and André St-Pierre, garage-keeper, all of the city and judicial district of Montreal, for the folloytfug purposes: To carry on the business and deal in automobiles and in all things therewith connected, under the name of \"St-Pierre Auto Electric Ltée\" with a total capital stock of 840,000, divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12780-54) The Laprairie Brick & Tile Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of November, 1954, incorporating: William Patrick Creagh, law clerk, Ernest William Mockridge, manager, and Cecil Bruce Cooke, seretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in any and all kinds and descriptions of bricks, tiles, pipes, pottery, earthware, china, porcelain, bone ware, fireclay, terra cotta and ceramic ware, under the name of \"The Laprairie Brick & Tile Incorporated\", with a capital stock of 100 shares without nominal or par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 3876 l-o Deputy Attorney General.(A.G.12728-54) Torco Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of November, 1954, incorporating: Roger Louis Beaulie\"», Jérôme Choquette, advocates, of Montreal, George Anthony Allison, Charles 3720 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 60 Anthony Allison, Charles Alexander Phelan et William Tetley, avocats, de ville Mont Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme propriétaire et administrateur d'immeubles, sous le nom de \"Torco Limited\", avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce deuxième jour de novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12655-54) Vermont Construction Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accc rdé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze novembre 1954, constituant en corporation : Marcel Pilon, estimateur, Roger Prévost, vendeur, tous deux de Montréal., et Marcel Girard, clmptable, de Verdun, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme entrepreneurs en construction pour des travaux publics et prives; faire les affaires d'une compagnie d'immeubles et d'agents d'immeubles, sous le nom de \"Vermont Construction Incorporée\", avec un capital total de 840,000, divisé en 1,600 actions ordinaires d'une valeur au pair de 825 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o C.E.CANTIN.(P.G.10760-54) < W.Gariépy & Associés Ltée.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accortlé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix novembre 1954, constituant en corporation: Aimé Petit, Wilbrod Gariépy et Jean-Baptiste Loiseau, tous industriels, de Saint-Denis-sur-Richelieu, district judiciaire de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur général pour la construction, l'érection et la fabrication de tous genres de constructions, sous le nom de \"W.Gariépy & Associés Ltée.\", avec un capital total de 840,009, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur nominale ou au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Denis-sur-Richelieu, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le dix novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o *** C.E.CANTIN.(P.G.12607-54) Whiteco Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par la Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze novembre 1954, constituant en corporation: Cyril E.Schwisberg, Irwin S.Brodie, avocats, tous deux d'Outremont et Sonya Schne- Alexander Phelan and William Tetley, advocates, of the town of Mount Royal, all of the district of Montreal, for the following purposes: To act as an owner and operator of real estate, under the name of \"Torco Limited\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-0 Deputy Attorney General.(A.G.12655-54) Vermont Construction Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1954, incorporating: Marcel Pilon, appraiser, Roger Prévost, salesman, both of Montreal, and Marcel Girard, accountant, of Verdun, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on as building contractors for public and private works; to carry on the business of a real estate company and real estate agents, under the name of \"Vermont Construction Incorporée\", with a total capital stock of 840,030, divided into 1,600 common shares of a par value of 825 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.10760-54) W.Gariépy & Associés Ltée.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of November, 1954, incorporating: Aimé Petit, Wilbrod Gariépy and Jean-Baptiste Loiseau, all industrialists, of Saint-Denis-sur-Richelieu, judicial district of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To carry on the business of a general contractor for the building, erection and the fabrication of all kinds of buildings, under the name of \"W.Gariépy & Associés Ltée.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of a nominal or par value of $100 each.The head office of the company will be at Saint-Denis-sur-Richelieu, judicial district of Saint-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12607-54) Whiteco Enterprises Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of November, 1954, incorporating: Cyril E.Schwisberg, Irwin S.Brodie, advocates, both of Outremont, and Sonya Schneyer, secretary, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 195k, Vol.86, No.60 3721 yer, secretaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires de constructions, soit comme constructeurs, entrepreneurs, couvreurs, répareurs de toutes sortes et genres de travaux publics et privés, et faire le commerce et le négoce d'immeubles et matériaux de constructions, sous le nom de \"Whiteco Enterprises Inc.\", avec un capital total de $20,000, divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.(P.G.12721-54) 1540 Stanley Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lattres patentes en date du huit novembre 1954, constituant en corporation: Philip Fischel Vineberg, Neil Franklin Phillips, avocats, tous deux de Westmount, Yvonne -Bélanger, secrétaire, fille majeure, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Effectuer un placement, acheter, ou autrement acquérir, administrer, détenir, posséder, louer et exploiter la propriété immobilière, portant l'adresse civique 1540 rue Stanley, en la cité de Montréal, et toute propriété immobilière adjacente ou contigué' à icelle ou près d'icelle, sous le nom dc \"1540 Stanley Inc.\", avec un capital-actions divisé en 200 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et en 3,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761 C.E.CANTIN.fille majeure, of Montreal, all of the official district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of construction, whether as builders, contractors, roofers, repairers of all manners and types of public and private works and to deal in and with real estate and builders' supplies, under the name of \"Whiteco Enterprises Inc.\", with a capital of 820,000, divided into 2,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twelfth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761-0 Deputy Attorney General.(A.G.12721-54) 1540 Stanley Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of November, 1954, incorporating: Philip Fischel Vineberg, Neil Franklin Phillips, advocates, both of Westmount, Yvonne Bélanger, secretary, fille majeure, of Montréal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To invest in, purchase or otherwise acquire, administer, hold, own, lease and operate the immoveable property bearing the civic address 1540 Stanley Street, in the city of Montreal, and any immoveable property adjacent or contiguous thereof or in the vicinity thereof, under the name of \"1540 Stanley Inc.\", with a capital stock divided into 230 common shares without nominal or par value and 3,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 3876l-o Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires (P.G.12678-54) Alfred Beauniier & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-huit novembre 1954, à la compagnie \"Beaumier & Morin Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 3 septembre 1949, changeant son nom en celui de \"Alfred Beaumier & Fils Ltée\".Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.127S5-54) Beauharnois Curling Club Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémen- Supplementary Letters Patent (A.G.12678-54) Alfred Beaumier & Fils Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November eighteenth, 1954, to the company: \"Beaumier & Morin Limitée\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated September 3rd, 1949, changing its name into that of \"Alfred Beaumier & Fils Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12785-54) Beauharnois Curling Club Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated 3722 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 105k, Tome 86, N° 50 taires, en date du neuf novembre 1954, à la corporation \"Beauharnois Curling Club\", retranchant une disposition des lettres patentes originaires de ladite corporation.Daté du bureau du Procureur général, le neuf novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.10968-54) Bell Radio & Television Service Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du seize novembre 1954, à la compagnie \"Belltone Television Service Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 28 juin 1954, changeant son nom en celui de \"Bell Radio & Television Service Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12867-54) Bevcourt Gold Mines Limited (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-trois novembre 1954, à la compagnie \"Bevcourt Gold Mines Limited\" (No Personal Liability), augmentant son capital dc 86,000,000 à 87,000,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000,000 actions de 81 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38701-o C.E.CANTIN.(P.G.12679-54) Chibougamau Mining & Smelting Co.Inc, (No Personal Liability) * Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix novembre 1954, à la compagnie \"Chibougamau Smelter Inc.\" (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu de ladite Loi des compagnies minières de Québec, par lettres patentes en date du 27 novembre 1953, 1° augmentant son capital de 840,000 à 85,000,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 4,960,000 actions de SI chacune; 2° changeant son nom en celui de \"Chibougamau Mining & Smelting Co.Inc.\" (No Personal Liability).Daté du bureau du Procureur général le dix novembre, 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.10345-54) Ducharne, Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a plu au Lieutenant-gouverneur de la province the ninth day of November 1954, to the corporation \"Beauharnois Curling Club\", striking out a provision of the original letters patent of said corporation.Dated at the office of the Attorney General, this ninth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.10968-54) Bell Radio & Television Service Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November sixteenth, 1954, to the company \"Belltone Television Service Ltd.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' by letters patent dated June 28th, 1954, changing its name into that of \"Bell Radio & Television Service Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12867-54) Bevcourt Gold Mines Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-third day of November, to the company \"Bevcourt Gold Mines Limited\" (No Personal Liability), increasing its capital from the sum of $6,000,000 to $7,000,000: the additional share capital being divided into 1,000,-000, shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney- General, this twenty-third day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12679-54) Chibougamau Mining & Smelting Co.Inc.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November tenth, 1954, to the company \"Chibougamau Smelter Inc.\" (No Personal Liability), incorporated under the said Quebec Mining Companies' Act, by letters patent dated November 27th, 1953, 1.increasing its capital stock from 840,000 to S5,000,000: the additional capital stock being divided into 4,960,000 shares of SI each; 2.changing its name into that of \"Chibougamau Mining & Smelting Co.Inc.\" (No Personal Liability).Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.10345-54) Ducharne, Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieute- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1951, Vol.86, No.60 3723 de Québec, d'émettre de nouvelles lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-trois novembre 1954, pour remplacer les lettres patentes supplémentaires en date du vingt-cinq octobre 1954, de la compagnie \"Soieries F.Du-charne, Ltd.\".En vertu desdites nouvelles lettres patentes supplémentaires, le nom de ladite compagnie a été changé en celui de \"Du-charne, Incorporée\".Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois novembre, 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12809-54) Eastern Industries Limited Les Industries dc l'Est Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-cinq novembre 1954, à la compagnie \"Eastern Industries Limited \u2014 Les Industries de l'Est Limitée\", a) augmentant son capital de 820.0C0 à 8100,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 600 actions communes de $50 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $50 chacune; b) étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq novembre 1954.L'Ass istan t-procu reu r général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12802-54) H.Chenoy & Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux novembre 1954, à la compagnie \"Brooklyn Delicacies Inc.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie dc la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 8 juin 1950, changeant son nom en celui de \"H.Chenoy & Co.Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le vingt-deux novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o C.E.CANTIN.(P.G.12791-54) Hill Durham Forgings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du douze novembre 1954, à la compagnie \"Hayes-Durham Forgings Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 12 septembre 1950, sous le nom originaire de \"W.J.Keating & Sons Ltd.\", et par lettres patentes supplémentaires en date du 18 décembre 1951, et par de nouvelles lettres patentes supplémentaires en date du 28 mars 1952, changeant ledit nom originaire en celui de \"Hayes-Durham Forgings Ltd.\", et par de nouvelles lettres patentes supplémentaires en date du 22 février 1954, changeant de nouveau le nom de ladite compagnie en celui de \"Hill Durham Forgings Ltd.\".Daté du bureau du Procureur général, le douze novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.nant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-third day of November 1954, replacing the supplementary letters patent dated the twenty-fifth day of October 1954, of the company \"Soieries F, Ducharne, Ltd.\".In accordance with the new sais supplementary letters patent, the name of said company has been changed to that of \"Ducharne, Incorporée\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12809-54) Eastern Industries Limited Les Industries de l'Est Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November twenty-fifth day of November, 1954, to the company \"Eastern Industries Limited \u2014 Les Industries de l'Est Limitée\", a) increasing its capital stock from 820,000 to 8100,000: the additional capital stock being divided into 600 common stock of $50 each and into 1,000 preferred stock of 850 each ; b) extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-fifth day of November.1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12802-54) H.Chenoy & Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November twenty-second, 1954, to the company \"Brooklyn Delicacies Inc.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated June 8th, 1950, changing its name into that of \"H.Chenoy & Co.Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12791-54) Hill Durham Forgings Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twelfth day of November, 1954, to the company \"Hayes-Durham Forgings Ltd.\", constituted as a corporation under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated September 12th, 1950, under the original name of \"W.J.Keating & Sons Ltd.\", and by supplementary letters patent dated December ISth, 1951, and by additional supplementary letters patent dated March 28th, 1952, changing the said original name to that of \"Hayes Durham Forgings Ltd.\", and by further supplementary letters patent dated February 22nd, 1954, changing again the name of said company to that of \"Hill Durham Forgings Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General, this twelfth clay of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General. 3724 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1964, Tome 86, N° OU (P.G.12567-54) Joseph Shamic & Sons, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du dix-sept novembre 1954, à la compagnie \"Joseph Shamie & Sons Ltd.\", augmentant son capital de $100,000 à 8200,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 990 actions privilégiées classe \"A\" de $100 chacune et en 1000 actions privilégiées classe \"B\" de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept novembre, 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12702-54) Ka-Y Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deux novembre, 1954, à la compagnie \"Ka-Y Reallies Inc.\", a) augmentant le nombre de ses directeurs de trois (3) à quatre(4); b) augmentant son capital dc 810,000 à 850,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 150 actions ordinaires de S100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le vingt-deux novembre, 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12749-54) Pacific Atlantic Canadian Investment Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec dés lettres patentes supplémentaires, en date du seize novembre, 1954, à la compagnie \"Second Canadian International Investment Company, Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie dc la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 22 février 1937, et par lettres patentes supplémentaires en date du 29 janvier 1941, «) convertissant ses 350,000 actions privilégiées de 85 chacune en 350,000 actions ordinaires de 85 chacune; b) subdivisant ses 500,000 actions ordinaires dc 85 chacune en 2,500,000 actions ordinaires dc 81 chacune; c) changeant son nom en celui de \"Pacific Atlantic Canadian Investment Company Ltd.\"; d) retranchant certaines dispositions des lettres patentes originaires de ladite compagnie.Daté du bureau du Procureur général, le seize novembre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12576-54) Simpson Hill Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes sup-mentaires, en date du vingt-cinq novembre 1954, à la compagnie \"Simpson Hill Inc.\", a) réduisant son capital de 840,000 à S15.000: le capital-actions annulé étant divisé en 2,500 ac- (A.G.12567-54) Joseph Shamie & Sons, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November seventeenth, 1954, to the company \"Joseph Shamie & Sons, Ltd.\", increasing its capital stock from S100.000 to $200,000: the additional capital stock being divided into 990 preferred shares class \"A\" of $100 each and into 1000 preferred shares class \"B\" of SI each.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12702-54) Ka-Y Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-second day of November, 1954, to the company \"Ka-Y Realties Inc.\", a) increasing the number of the company's directors from three (3) to four (4); b) increasing its capital from the sum of 810,000 to $50,000: the additional share capital being divided into 150 common shares of S100 each and 250 preferred shares of SI00 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12749-54) Pacific Atlantic Canadian Investment Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated November sixteenth, 1954, to the company: \"Second Canadian International Investment Company, Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated February 22nd, 1937 and by supplementary letters patent dated January 29th, 1941, a) converting its 350,000 preferred shares of 85 each into 350,000 common shares of $5 each; b) subdividing its 500,000 common shares of 85 each into 2,500,000 common shares of SI each; c) changing its name into that of \"Pacific Atlantic Canadian Investment Company Ltd.\"; d) to strike out certain provisions from the original letters patent of the company.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of November, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12576-54) Simpson Hill Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-fifth day of November 1954, to the company \"Simpson Hill Inc.\", a) reducing the company's capital from the sum of 840,000 to $15,0C0: the cancelled share capital being divided QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, Vol.86, No.50 3725 tions ordinaires de 810 chacune; b) augmentant son dit capital de 815.000 à 8165,000: le capital-actions additionnel étant divisé en, 1,500 actions privilégiées de 8100 chacune.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq novembre, 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-0 C.E.CANTIN.(P.G.12669-54) Vilas Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-neuf octobre 1954, à la compagnie \"Vilas Company Limited\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf octobre 1954.L'Assistant-procureur général, 38761-o C.E.CANTIN.into 2,500 common shares of $10 each; /;) increasing its said capital from the sum of 815.000 to 8165.000: the a Idition.al share capital being divided into 1,500 preferred shares of S100 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of November.1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.(A.G.12669-54) Vilas Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.supplementary letters patent have been issue 1 by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the twenty-ninth day of October 1954, to the company \"Vilas Company Limited\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth dav of October, 1954.C.E.CANTIN, 38761 Deputy Attorney General.Demandes à la Legislature Canada \u2014 Province de Québec District de Terrebonne AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné qu'un bill privé sera présenté à la présente session dc l'Assemblée Législative de la Province dc Québec ou aussitôt que possible, par la commission scoliire catholique de la ville de Lachutc pour imposer une taxe, dite taxe d'éducation pour rencontrer les exigences de leurs écoles et s'assurer des revenus supplémentaires nécessaires, le tout en conformité à la loi de l'impôt sur la vente en détail.Statuts refondus 1941, chapitre 88 et ses amendements mutadi.t mutandvi.Les Avocats et procureurs, 38577-47-4-0 LEGAULT & LEGAULT.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la ville de Victoriaville s'adressera à la Législature de la province de Québec, au cours de la prochaine session pour faire, modifier sa charte et obtenir des pouvoirs additionnels, comme suit: 1° Pour amender les paragraphes 7° et S0 de l'article 26; 2° Pour établir une commission d'urbanisme, et lui octroyer des deniers; 3° Pour augmenter la qualification du maire et des échevins, et leur dépôt; 4° Pour changer la date de la confiction de la liste des électeurs; 5° Pour changer les heures de votation; 6° Pour établir zones de construction; 7° Pour modifier l'article 446a; 8° Pour faire disparaître certaines nuisances; 9° Pour aider aux estimateurs; 10° Pour évaluer et imposer les lignes de distribution d'énergie électrique et téléphoniques; 11° Pour modifier la base des taxes d'affaires;.12° Pour établir une taxe sur certains appareils mécaniques; 13° Pour établir un fonds de roulement.Victoriaville, le 8 novembre 1954.La Procureurs de la ville de Victoriaville, LACOURSIÈRE, LALIBERTÉ, 38579-47-4-0 & FERLAND.Applications to Legislature Canada \u2014 Province of Quebec District of Terrebonne public]notice Notice is hereby given that a private bill will be presented at the present session of the Legislative Assembly of the province of Quebec or as soon as possible by the Catholic School Commission of the town of Lachute in order to impose an educational tax of 1% to meet the requirements of their schools and to insure the necessary supplementary revenues; the whole according to the Retail Sales Tax Act, chapter 88 Revised Statutes 1941 and its wnnendments, mutadis mutandis.LEGAULT & LEGAULT, 38577-47-4-0 Attorneys.PUBLIC_NOTICE Public notice is hereby given that the town of Victoriaville will apply to the Legislature of the Province of Quebec (luring the course of the next session for the amendment of its Charter and to obtain additional powers.1.For the amendment of paragraphs 7 and 8 of Article 26; 2.To establish a Town-planning Commission and to issue money grants; 3.To increase qualifications for Mayor and Aldermen, and their deposits; 4.To change the date of the preparation of the electoral list; 5.To change polling hours; 6.To establish building zones; 7.To raidify Article 446a;_ 8.To eliminate certain nuisances; 9.To help appraisers; 10.To valuate and to impose the distribution of power and telephone lines; 11.To modify the basis of business taxes; 12.To establish a tax upon certain mechanical appliances; 13.To establish a working capital.Victoriaville, November 8th, 1954.LACOURCIÈRE, LA LI BERT É & FERLAND, Attornevs for the town of Victoriaville.38579-47-4 3726 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 50 AVIS La ville de Laval Ouest donne par les présentes avis qu'elle s'adressera à la Législature provinciale, à sa prochaine session, pour obtenir des amendements à sa charte sur les matières suivantes: Augmentation du fonds dc roulement; Service d'autobus; Changement de l'année fiscale de la commission scolaire; Changement du taux d'intérêt re: pouvoir d'emprunt.Emprunt pour la construction d'un chalet municipal.Montréal, 15 novembre 1954.1 L'Aviseur légal, 38583-47-4-0 \u201e FRS.FAUTEUX.Canada \u2014 Province de Québec District de Québec Avis public est par les présentes donné que \"la Ville de Beauport\", une corporation de ville régie par les dispositions de la Loi des Cités et Villes et celles de sa charte spéciale, s'adressera à la législature de la province de Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi amendant sa charte, la Loi 14-1-5 George VI, chapitre 91, sur les matières suivantes: dispenser de la publication en langue anglaise les avis municipaux, règlements et autres ordonnances municipales; valider tous les règlements municipaux adoptés sans avis préalable; autoriser le conseil à accorder une allocation pour frais de représentations à ses membres par résolution; permettre au conseil d'amender une fois d'ici un an le règlement de construction et de zonage sans autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales; étendre à trois ans, à compter de la prochaine élection générale, le terme d'office du maire et des échevins; autoriser le conseil à emprunter annuellement pendant trois ans une somme de cinquante mille dollars pour l'exécution de travaux permanents et urgents se rapportant aux dépenses d'une nature capitale et qu'il faut exécuter chaque année pour ne pas paralyser le développement du territoire soumis à la juridiction de la ville; et pour autres fins.Québec, le 18 novembre 1954.(Sceau) La Ville de Beauport.Par le Maire, J.-U.STE-MARIE, Le Secrétaire-trésorier, 38617-47-4-0 GEO.-E.BOUTET.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la \"Commission des Écoles Catholiques de Québec\" s'adressera à la Législature à sa présente session pour demander l'adoption d'une loi: o) Octroyant à ladite Commission un pouvoir d'emprunt n'excédant pas deux millions de dollars pour l'acquisition de terrains et de bâtisses, la construction et l'ameublement ou l'agrandissement d'écoles et de couvents dans les paroisses où il y a nécessité, la construction d'une résidence au couvent St-Cœur-de-Marie et au couvent Notre-Dame-du-Chemin, l'agrandissement de la résidence du couvent St-.ïoseph et de l'entrepôt de la Commission ainsi que la construction d'un \"high school\" en la paroisse de St-Patrice; b) Autorisant la modification de l'article 34 de la Loi 32 Victoria, chapitre 16, ou toute autre joi modificative concernant la rétribution men- NOTICE The town of Laval West gives by these presents notice that it will apply to-the Provincial legislature at its next session, to obtain certain amendments on its charter on the following matters: Increase the working capital; Autobus service; Change the fiscal year for the School Commission; Change rate of interest in the loan by-laws; Loan to erect a municipal bungalow.Montreal, November 15th, 1954.FRS.FAUTEUX, 38583-47-4-o Legal Advisor.Canada \u2014 Province of Quebec District of Quebec Public notice is by these presents given that \"The Town of Beauport\", a town corporation governed by the provisions of the Cities and Towns Act and those of its special charter, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, to request that a law be passed to amend its charter, Act 14-15 George VI, Chapter 91, in respect to the following matters: to dispense from publishing in the English language the municipal notices, by-laws and other special ordinances; to validate all the municipal by-laws passed without prior notice; to authorize the council to grant an allowance to cover costs of representation to its members by resolution; to allow the council to amend once within a year from now the building and zoning by-law without other approval than that of the Minister of Municipal Affairs; to extend to three years, commencing with the next general election, the term of office of the mayor and of the aldermen; to authorize the council to borrow annually during three years a sum of fifty thousand dollars for the execution of permanent and urgent works relating to expenditures of a capital nature and which must be executed each year so as not to paralyse the development of the territory subject to the jurisdiction of the town; and for other purposes.Quebec, November 18th, 1954.The town of Beauport.(Seal) J.-U.STE-MARIE, Mavor.GEO.-E.BOUTET, 38617-47-4-0 Secretary-Treasurer.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the \"Catholic School Commission of Quebec\" shall apply to the Legislature at its present session praying for the adoption of an Act: a) Granting to the said Commission a borrowing power not exceeding two million dollars for the acquisition' of lands and buildings, the construction and furnishing or enlarging of schools and convents in the parishes where necessary, the construction of a residence at St-Coeur-de-Marie and Notre-Dame-du-Chemin convents, the enlarging of the residence of St-Joseph convent and the warehouse of the Commission as well as the construction of a \"high school\" in the parish of St-Patrick.6) To authorize the amendment of section 34 of the Act 32 Victoria, chapter 16 or any amending Act respecting the mensualities payable by QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, Vol.86, No.50 3727 suelle à être payée par les enfants fréquentant les écoles de ladite Commission.Québec, le 17 novembre 1954.Le Procureur de la pétitionnaire, 38618-47-4-0 VICTOR TRÉPANIER, C.R.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la ville Saint-Laurent s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa prochaine session, pour l'adoption d'une loi aux fins d'amender sa charte, conserver les pouvoirs spéciaux et en obtenir des nouveaux sur les matières suivantes: changer le nom de ville en celui de cité; travaux d'améliorations locales par requêtes; réglementer l'approbation des règlements par les électeurs propriétaires; confection des rôles d'évaluation; annexion des lots nos 481, 482, 485 et 488 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent faisant présentement partie de la municipalité de Notre-Dame de Liesse et des lots nos 84, 85 et 86 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire faisant présentement partie de la municipalité de la paroisse de Saint-Joachim; et pour autres fins.Ville Saint-Laurent, 11 novembre 1954.Le Maire, MAURICE COUSINEAU, C.R.Le Gérant, 38624-47-4-o LUCIEN TOUPIN, C.A.La Commission des Écoles Catholiques de Verdun AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que la Commission des Ecoles Catholiques de Verdun s'adressera à la Législature de la Province de Québec, à sa prochaine session, pour l'adoption d'une loi lui accordant les pouvoirs suivants: 1° Promouvoir l'engagement d'un instituteur ou d'une institutrice par simple résolution.2° Lui permettre en tout temps durant l'année scolaire de permuter de fonction pédagogique, de classe ou d'école un instituteur ou une institutrice, pourvu que son traitement ne soit pas réduit.3° Dispenser le Commissaire nommé par l'archevêché de Montréal du cens d'éligibilité requis s'il apparrtient au clergé séculier ou régulier.4° Fixer la nomination du président à la première séance du mois de juillet de chaque année.5° Avec l'autorisation préalable du Surintendant de l'Instruction Publique, autoriser la Commission à adopter des règlements lui permettant de payer, à même ses revenus annuels, à un instituteur ou institutrice démissionnaire pour raison de santé uniquement et ayant été à son service comme tel pendant au moins vingt ans, des annuités pendant au plus dix «ans, d'une valeur ne devant pas excéder la moitié du traitement annuel que l'instituteur ou l'institutrice concerné touchait au moment de sa démission.6° Autoriser la Commission à souscrire auprès d'une compagnie d'assurance, un contrat d'assurance de groupe, à base contributoire sur la vie, contre les accidents et la maladie, pouf le bénéfice du personnel enseignant, administratif, et des ouvriers réguliers.7° Sous réserve de certaines restrictions, lui permettre de nommer le secrétaire-trésorier et le directeur des études par simple résolution et children attending the schools of the said Commission.Quebec, November 17th.1954.VICTOR TRÉPANIER, Q.C., 3S618-47-4-0 Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Saint Laurent will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its next session, for the adoption of an act to amend its charter, retain its special powers and acquire additional ones in the following matters: to change the name town to that of city; carry out petitioned local improvement works; regulate approval of bylaws by elector-proprietors; compiling of valuation rolls; annexation of lots number 4SI, 482, 485 and 488 of the official cadastre of the parish of Saint-Laurent presently forming part of the municipality of Notre-Dame de Liesse and lots number 84, 85 and 86 of the cadastre of the parish of Pointe-Claire presently forming part of the municipality of the parish of Saint-Joachim; and for other purposes.Town of Saint Laurent November 11.1954.MAURICE COUSINEAU, Q.C., Mayor.LUCIEN TOUPIN, C.À., 38624-47-4 Manager.The Catholic School Commission of Verdun PUBLIC NOTICE Public notice is, by these presents, given that the Catholic School Commission of Verdun will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its next session, for the adoption of an Act granting it the following powers: 1.To promote the engagement of a teacher (male or female) by a simple resolution.2.To allow the Commission, at any time during the school term, to change a teacher (male or female) from his or her pedagogic functions, grade or school, providing there be no reduction in salary.3.To dispense from eligible qualifications the Commissioner appointed by the Archbishopric of Montreal, should he bolong to the secular or regular clergy.4.To fix the nomination of the president at the first meeting in the month of July of each year.5.With authorization previously obtained from the Superintendent of Education, to authorize the Commission to adopt by-laws which will allow it to pay from its own annual revenues, annuities to a teacher (male or female) who resigns for reasons pertaining to health only, and who have been teachers in the service of the Commission during at least twenty years, said annuities to run during ten years at the most, to a value which must not exceed the amount of one-half the annual salary that the teacher concerned (male or female) earned at the time of his or her resignation.6.To authorize the Commission to subscribe to an insurance company for a group insurance contract, on a life contributory basis against accidents and sickness, for the benefit of the teaching personnel, administrative and regular workmen.7.Under reserve of certain restrictions, to allow the Commission to name the Secretary-Treasurer and the Director of Studies by a simple 3728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1964, Tome 86, N* 60 subordonner leur destitution et la réduction de leurs émoluments au vote unanime de tous lea membres de la Commission.Verdun, ce 17 novembre 1954.Le Secrétaire-Trésorier, 3500, rue Wellington, PAUL ROY.Verdun, Que.' 38626-47-4-0 AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que Alfred Leduc, fils, de Montréal, s'adressera à la Législature de Québec, à sa prochaine session, pour lui demander l'abrogation du chapitre 130 de 15-16 Geo.VI.Montréal, ce 13 novembre 1954.Le pétitionnaire, 38578-47-4-0 ALFRED LEDUC, fils.AVIS Avis est par les présentes donné, que les \"Commissaires d'École pour la municipalité du Cap de la Madeleine dans le comté de Cham-plain\", s'adresseront à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour faire confirmer et ratifier à toutes fins que de droit les ententes intervenues entre les commissaires d'École pour la municipalité du Cap de la Madeleine dans le comté de Champlain et certaines industries situées dans les limites du territoire sur lequel, ils ont juridiction; Cap de la Madeleine, 17 novembre 1954.Les commissaires d'Écoles pour la municipalité de la cité du Cap de la Madeleine dans le comté de Champlain.Par le procureur, 38652-48-4-0 LÉON MÉTHOT.AVIS Avis par la présente donné que la cité de Chi-coutimi, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à la présente Session pour obtenir la passation d'une loi amendant sa charte, fixant à $500,000.00 l'évaluation des propriétés de Eastern Smelting and Refining Company Limited dans la cité de Chicoutimi, et pour autres fins.Chicoutimi, ce 19 novembre 1954.Le Greffier de la cité de Chicoutimi, 38653-48-4-0 GASTON CARRIER.AVIS Avis est par la présente est donné que Le Club Shawinigan s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour obtenir la passation d'une loi amendant sa charte, définissant ses pouvoirs, abolissant son capital actions, le rendant sujet aux dispositions de la Loi des clubs de chasse et pêche de Québec, et pour autres fins.Montréal, ce 20 novembre 1954.Le Club Shawinigan, Le Secrétaire, 38654-48-4-0 JULES BOLDUC.AVIS PUBLIC La cité de Joliette donne, par les présentes, avis qu'elle s'adressera à la Législature provinciale, lors de la présente session, pour amender sa charte aux fins d'exempter l'imposition des machineries.Joliette, ce 19 novembre 1954.Le Procureur de la pétitionnaire, 38656-48-4-0 ARMAND LAVALLÉE, N.P.resolution and to subordinate their dismissal and the reduction of their remuneration to the unanimous vote of all members of the Commission.Verdun.November 17, 1954.PAUL ROY, 3500, Wellington Street, Secretary-Treasurer.Verdun, Que.38626-47-4 PUBLIC NOTICE Notice is hereby given by Alfred Leduc, jr., of Montreal, that he will make an application to the Legislature of Quebec, at its next session, to ask for the repeal of chapter 130 of 15-16 Goe.VI.Montreal, November 13th.1954.ALFRED LEDUC, jr., 38578-47-4-o Petitioner.NOTICE Notice is hereby given that the \"School commissioners for the municipality of Cap de la Madeleine in the county of Champlain\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec during its present session, to have confirmed and ratified for all legal purposes the agreements concluded between the School commissioners for the municipality of Cap de la Madeleine in the county of Champlain and certain industries situate within the limits of the territory upon which they have jurisdiction; Cap de la Madeleine, November 17th, 1954.School commissioners for the municipality of the city of Cap de la Madeleine in the county of Champlain.LÉON MÉTHOT, 38652-48-4 _ By the attorney.NOTICE Notice is hereby given that the city of Chicoutimi will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, fixing the sum of $500,000.00 as the valuation of the properties of Eastern Smelting and Refining Company Limited in the city of Chicoutimi, and for other purposes.Chicoutimi, this November 19th, 1954.GASTON CARRIER, 38653-4S-4 Clerk of the city of Chicojitimi.NOTICE Notice is hereby given that \"Le Club Shawinigan\" will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act to amend its charter, define its powers, abolish its share capital, and render it subject to the provisions of the Quebec Fish and Game Clubs Act, and other purposes.Montreal, this November 20th, 1954.Le Club Shawignigan, JULES BOLDUC, 38654-48-4 _ Secretary.\u2022 PUBLIC NOTICE The city of Joliette does hereby give notice that it will apply at the Provincial Legislature, at its present session, to amend its charter for the purposes of exempting assessment of machinery.Joliette, this 19th, November, 1954.ARMAND LAVALLÉE, N.P., 38656-48-4-0 Attorney for the petitioner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 195J,, Vol.86, No.60 3729 AVIS Avis est par les présentes donné que le Révérend Père Paul Gay, de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, supérieur, domicilié au Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, Lini-bourg via Hull, comté de Gatineau, province de Québec, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session pour demander la modification de la Loi constituant en corporation le Collège Apostolique Saint-Alexandre de la Gatineau, dans le but d'augmenter les pouvoirs de cette corporation, afin de mieux atteindre les fins pour lesquelles cette corporation a été constituée.Hull, le 18 novembre 1954.Le Procureur du pétitionnaire, 38655-48-4-0 Me PHILLIPE MALTAIS.AVIS~PÛBLIC Avis public est par les présentes donné que la Commission Métropolitaine de Montréal demandera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi pour autoriser l'émission, à un taux n'excédant pas 5%, de l'emprunt décrété par sa résolution numéro 25 du 4 décembre 1946, pour amender la charte de la Commission en vue des circonstances présentes, et particulièrement pour augmenter son fonds de roulement, et pour d'autres fins.Montréal, le 22 novembre, 1954.Le Procureur de la Commission Métropolitaine de Montréal, 38660-48-4-o GASTON POULIOT.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que la Ville de Sept-Iles s'adressera à la législature à sa pré sente session, aux fins de demander l'autorisation de diviser la Ville en trois (3) quartiers, \u2014 d'augmenter la taxe personnelle de 82.00 à 85.00,\u2014 d'imposer une taxe de vente de 2% et de déterminer que le lot 10 du rang I du canton Letellier n'a jamais fait partie du territoire de la Ville.Le Procureur dc la pétitionnaire, 38669-48-4-0 (Signé) HONORÉ DIONNE.AVIS PUBLIC Avis est donné de la ville d'Acton Vale et les commissaires d'écoles pour la ville d'Acton Vale feront à la Législature de la province de Québec, à sa présente sessien une demande conjointe pour avoir la permission d'imposer dans leurs territoires respectifs une taxe dc vente de 2% et une taxe d'éducation de 1%.Avis est aussi donné que la ville d'Acton Vale, dans la même demande, priera la Législature de la province de Québec: 1° De lui accorder la permission d'emprunter par règlement une somme n'excédant pas soixante mille dollars pour acquérir ou construire des immeubles devant servir à des fins municipales ou industrielles.2° De lui accorder la permission d'annexer un terrain faisant partie de la municipalité de Saint-André d'Acton, ledit terrain décrit comme suit: les lots N° 363, 364, 368, 369, 370 ainsi que partie des lots 367, 366, 371 et 372 du cadastre officiel de la paroisse de Saint André d'Acton.3° Et pour autres.Acton Vale, le 22 novembre 1954.Le Procureur de la ville d'Acton Vale et de la Commission scolaire de la ville d'Acton Vale, 38671-48-4-0 JACQUES BOUSQUET.NOTICE Notice is hereby given that Reverend Father Paul Gay, of the Congregation of the Fathers of the Holy Gost, superior, domiciled at Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, Limbourg via Hull, county of Gatineau, Province of Quebec, will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for an amendment to the Act incorporating the \"Collège Apostolique Saint-Alexandre de la Gatineau\", with a view in increasing the powers of the said corporation in order to enable the said corporation to reach the objectives for which it was incorporated.Hull, November 18th, 1954.Me PHILIPPE MALTAIS, 38655-48-4-0 Solicitor for the petitioner.PUBLIC_NOTICE .Public notice is hereby given that The Montreal Metropolitan Commission will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an act to authorize the issue of a loan decreed by its resolution number 25 dated December 4, 1946, at a rate not exceeding 5%, to amend its charter in view of the present circumstances, and in particular to increase its revolving fund, and for other purposes.Montreal November 22nd, 1954.GASTON POULIOT, Attorney for the Montreal 38660-48-4-o Metropolitan Commission.PUBLICjNOTICE Public notice is hereby given that the Town of Sept-Iles will apply to the Legislature at its present session for the purposes of requesting the authorization to divide the Town into three (3) wards,\u2014 to increase the personal tax from S2.00 to S5.00,\u2014 to impose a sales tax of 2% and to settle the fact that lot 10 of Range I of Letellier Township has never been a part of the territory of the Town.(Signed) HONORÉ DIONNE, 38669-48-4 Attorney for the petitioner.PUBLIC_NOTICE Notice is hereby given that the town of Acton Vale and the School Commissionners for the town, of Acton Vale will make a joint request to the Quebec Législature at its present session to obtain permission to impose in their respective territories à 2% sales tax and a 1% education tax.Notice is also given that in the same request the town of Acton Vale will ask the Quebec Legislature: 1.To be authorized to borrow by by-law an amount not exceeding sixty thousant dollars to acquire or build immoveables which shall serve for municipal or industrial puiposes; 2.To permit annexation of a piece of land, being part of the municipality of St.André d'Acton, the said piece of land described as follows: lots numbers 363, 364, 368, 369, 370 as well as part of lots 367, 366, 371 and 372 of the official book and cadastre of the parish of St-André d'Acton, 3.And for other purposes.Acton Vale, November 22nd, 1954.JACQUES BOUSQUET, Attorney for the town and the School Coinmi- sioners of Acton Vale.38671-48-4-0 3730 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 50 AVIS PUBLIC Avis public est, par les présentes, donné que la ville de Dorval, s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présent session, pour l'adoption d'une loi, amendant sa charte, la Loi 14 Georges VI, chapitre 120 et amendements, sur les matières suivantes: droit de percevoir une taxe d'affaires sur les commerces imposer une taxe de 2% pour fins municipales; réglementer l'emploi des excédents des différents règlements d'emprunt non utilisés; annexion de la moitié du Chemin des Sources, faisant front au territoire de la ville; et pour autres fins.Montréal, le 22 novembre 1954.Les Procureurs de la ville de Dorval, LACROIX, VIAU & POUPART.38672-48-4-0 AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que La Corporation de téléphone de Québec, La Compa-nie de téléphone du golfe St-Laurcnt Limitée, The Bonaventure & Gaspé Telephone Company Limited, s'adresseront «à la Législature de la Province de Québec à la session 1954-55 pour demander l'adoption d'un Bill aux fins suivantes: Obtenir les pouvoirs pour acquérir de gré à gré ou par expropriation, les terrains, droits de passage ou servitudes nécessaires à l'extension de leurs services dans la province de Québec.Rimouski, le 22 novembre 1954.Les Procureurs tics pétitionnaires, GAGNON & GAGNON.38673-48-4-0 AVIS Avis est, par les présentes, donné que la ville de Mistassini, district de Roberval, s'adressera à la Législature, à sa présente session, pour obtenir la passation d'une loi autorisant l'imposition dans le territoire des municipalités de la ville de Dolbeau, de la ville de Mistassini et de la paroisse de Mistassini, d'une taxe de vente de 2%, ana-loque à la Loi de l'impôt de la vente en détail (S.R.Q.1941 \u2014chapitre 88), qui devra être perçue par le contrôleur du Revenu de la province et distribuée par lui de la façon suivante: a) Entre la ville de Dolbeau, d'une part, et la ville et la paroisse de Mistassini, d'autre part, au prorata de la population; b) Entre la ville de Mistassini et la paroisse de Mistassini, au prorata de l'évaluation foncière; Ou de toute façon que la Législature voudra bien fixer.Québec, le 24 novembre 1954.Les Procureurs de la pétitionnaire, MAURICE MARQUIS, 38689-48-4-0 ARMAND MALTAIS.Avis est par les présentes que la ville de Tracy et la ville de St.Joseph-de-Sorel, s'adresseront à la Législature de Québec demandant l'adoption d'une Loi accordant le pouvoir de construire et opérer une usine de filtration à frais communs dans les limites de la ville de Tracy.Le Maire de Tracy, ELZÉAR COURNOYER.Le Maire de St.Joseph-de-Sorel, T.AUSSANT.Chs, Parent, C.R., Procureur des requérantes.38700-48-4-O PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the town of Dorval will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter, the Act 14 George VI, chapter 120 and amendments, for the following purposes: right to to collect a business tax on the trades; to impose a 2% tax for municipal purposes; to regulate the use of excess of différent loan by-laws non employed; annexation of the half of Chemin des Sources, in front of territory of the town; and for other purposes.Montreal, November 22nd, 1954.LACROIX, VIAU & POUPART, The Attorneys for the town of Dorval.38672-48-4-0 PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that La Corporation de Téléphone de Québec, La Compagnie de Téléphone du Golfe St-Laurent Limitée and The Bonaventure & Gaspé Telephone Company Limited, will apply to the Legislature of the Province of Q lebec, at its session 1954-55, for the adoption of a Bill for the following purposes: To obtain the power to acquire \"de gré à gré\" or by expropriation \"the properties, rights of way or servitudes necessary for the extension of their services in the province of Quebec.Rimouski, November 22nd, 1954.GAGNON & GANON, 38673-48-4-0 Attornies for the petitioners.NOTICE Notice is hereby given that the town of Mistassini, district of Roberval will apply to the Legislature, at its present session, for the adoption of an act authorizing the imposition of a 2% sales tax within the territory of the municipalities of the town of Dolbeau, that of Mistassini and the parish of Mistassini, similar to the Retail Sales Act (R.S.Q.1941\u2014chapter 88), which tax to be collected by the Comptroller of Provincial Revenue and distributed by him in the following manner: a) Between the town of Dolbeau, on one part, and the town and parish of Mistassini, on the other part, proportionately to the population; b) Between the town of Mistassini and the parish of Mistassini, proportionately to land valuation.Or in any other manner which the Legislature would be willing to determine.Quebec, November 24th, 1954.MAURICE MARQUIS, ARMAND MALTAIS, 38689-48-4 Attorneys for the petitioner.Notice is hereby given that the town of Tracy and the town of St.Joseph-de-Sorel will apply to the Legislature of Quebec for the adoption of an Act granting them the power to erect and operate a filtration plant, with costs in common, within the limits of the town of Tracy.ELZÉAR COURNOYER, Mayor of Tracy.T.AUSSANT, Mayor of St.Joseph-de-Sorel.Chs.Parent, Q.C., Attorney for the petitioners.38700-48-4 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, Vol.86, No.50 3731 AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE Avis public est par les présentes donné que la corporation du village de Plessisville s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, dans le but d'obtenir l'adoption d'une loi spéciale aux fins suivantes: 1° L'érection en municipalité de ville de son territoire actuel; 2° Fixation de la date des prochaines élections; 3° Autorisation à la dite corporation à emprunter une somme n'excédant pas 860,000.00 destinée à favoriser l'expansion industrielle dans les limites de la municipalité; 4° Octrois de pouvoirs spéciaux concernant les infractions aux règlements municipaux relatifs à la circulation et à la sécurité publique; Et pour autres fins administratives.Plessisville, le 22 novembre 1954.\\ Le Procureur de la Corporation, 38697-48-4-0 ROBERT MARCHAND.AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné que les commissaires d'écoles pour la municipalité de la Côte Notre-Dame de Liesse, dans le comté de Jacques-Cartier, s'adressera à la Législature à sa présente session, lui demandant l'adoption d'une loi pour décréter que les lots nos.505, 507 et 509 à 515 inclusivement de la paroisse St-Laurent, dans le comté de Jacques-Cartier, font et ont toujours fait partie de la municipalité scolaire de la Côte de Notre-Dame de Liesse et que les redevances scolaires perçues par ladite corporation scolaire, des propriétaires des dits lots ont été légalement perçues et ladite corporation scolaire est autorisée à les retenir.Montréal, le 18 novembre 1954.Le Procureur de la demanderesse, 38701-48-4-0 HENRI COURTEMANCHE.AVIS DE BILL PRIVÉ Avis est par les présentes donné que le Collège des Médecins et Chirurgiens de la province de Québec demandera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, l'adoption d'une loi l'autorisant à payer une pension viagère à son régistraire et à ses employés.Montréal, 24 novembre 1954.L'Avocat du requérant, 38725-49-4-0 JEAN TRUDEL.AVIS PUBLIC Demande à la législature Avis est par les présentes donné que les Révérends Pères Roger Pérusse, Lorenzo Picher, Henri Meek, Bernard Bisson et Roger Gendreau, membres de la congrégation des Religieux du Très Saint-Sacrement s'adresseront à la législature de Québec, au cours de la présente session, pour l'obtention d'un projet de loi à l'effet de les constituer en corporation sous le nom de \"Congrégation du Très Saint-Sacrement\", sous certaines conditions.Québec, ce 25 novembre 1954.Les Procureurs des requérants, DORION, DORION & DOYON.38726-49-4-0 Public notice is hereby given that the corporation of the village of Plessisville will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its next session, with the object of obtaining the adoption of a special Act, for the following purposes: 1.The rection of its present territory into a town municipality; 2.To fix the date of the next elections; 3.To give to the said Corporation the authorization to borrow an amount not exceeding 860,000.00 destined to favor the industrial expansion within the limits of the municipality; ¦ 4.Grants for special powers concerning infringements against municipal by-laws relative to traffic and public security; And for other administrative purposes.Plessisville, November 22nd, 1954.ROBERT MARCHAND, 38697-48-4 Attorney for the Corporation.PUBLIC NOTICE Public notice is hereby given that the school commissioners for the parish of Côte Notre-Dame de Liesse, -in the county of Jacques-Cartier, shall apply to the Legislature, at its present session, praying for the adoption of an Act to decree that lots No.505, 507 and 509 to 515 inclusive, of the official cadastre for the parish of St-Laurent, in the county of Jacques-Catier, form and have always formed part of the school municipality of La Côte de Notre-Dame de Liesse, in the county of Jacques-Cartier, and that the school taxes already collected by the school commissioners of the said school corporation have been legally collected and the said commissioners are authorized to retain the same.Montreal, November 18th, 1954.HENRI COURTEMANCHE, 38701-48-4-o Attorney for the plaintiff.NOTICE OF PRIVATE BILL Notice is hereby that the College of the Physicians and Surgeons of the Province of Quebec will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the adoption of an Act for the authorisation to pay a life annuity to its registrar and to its employees.Montreal, November 24th, 1954.JEAN TRUDEL, 38725-49-4 Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Application to the legislature Notice is hereby given that the Reverend Fathers Roger Pérusse, Lorenzo Picher, Henri Meek, Bernard Bisson and Roger Gendreau, members of the religious congregation of the Blessed Sacrement will apply to the legislature of Quebec, at its present session, to obtain the adoption of a draft bill in order to constitute them as a corporation under the name of \"Congrégation du Très Saint-Sacrement\", with certain conditions.Quebec, November 25th, 1954.DORION, DORION & DOYON, 38726-49-4 Attorneys for the petitioners. 3732 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 195A, Tome S6, N° 50 AVIS Avis est par les présentes donné que The Children's Memorial Hospital des cité et district de Montréal s'adressera à la Législature de la province de Québec, à sa présente session, pour demander l'adoption d'une loi pour changer son nom en celui de \"The Montreal Children's Hospital\", pour être investi des propriétés, droits, pouvoirs et privilèges de Montreal Children's Hospital et, pour d'autres fins.Montreal, le 25 novembre 1954.The Children's Memorial Hospital, Par le Président, 38727-49-4-0 JOHN H.MOLSON.AVIS Avis est par les présentes donné que la Corporation des Pères Bénédictins dc Saint-Bcnoit-du-Lac s'adressera à la Législature delà province de Québec à sa présente session pour demander l'adoption d'une loi modifiant son nom corporatif, étendant ses pouvoirs et ceux de ses membres, étendant le territoire de la Municipalité de Saint-Benoit-du-Lac et les pouvoirs de cette corporation.Saint-Benoit-du-Lac, le 3 novembre 1953.Le Procureur de la pétitionnaire, 38780-50-4-o IVAN SABOURIN.Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Avis est, par les présentes, donné que la Corporation de \"Les Frères de la Charité\", corporation ayant son bureau-chef dans les cité et district de Montréal, fera une demande à la Législation de la province de Québec à sa présente session aux fins de faire adopter une loi pour augmenter son pouvoir de posséder des immeubles et pour d'autres fins.Montréal, ce 1er décembre 1954.Le Procureur de la requérante, 38781-50-4-o PHILIPPE FERLAND, C.R., AVIS PUBLIC Avis est par les présentes donné que la corporation de la ville d'Arthabaska, les commissaires d'écoles pour la municipalité du village d'Arthabaskaville, la corporation du village de Princeville, les commissaires d'écoles pour la municipalité du village de Princeville, la corporation du village de Warwick et les commissaires d'écoles pour le village de Warwick, tous du comté d'Arthabaska, s'adresseront à la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi aux fins suivantes : 1° Autoriser l'imposition d'une taxe de vente de 2% et d'une taxe d'éducation de 1% dans leurs territoires respectifs; 2° Additionner le produit des susdites taxes perçues dans les territoires sus-mentionnés et des taxes identiques perçues dans la ville de Victoriaville et en partager le total dans une proportion à être établie entre les différentes parties en cause; 3° Autoriser la ville d'Arthabaska, la corporation du ville de Princeville et la corporation du village de Warwick à emprunter respectivement des sommes de $75,000.00, 875,000.00 et $150,000.00 pour expansion industrielle; 4° Autoriser la ville d'Arthabaska à effectuer pour fins de publicité, d'annonces, de représentation du maire et des échevins une somme NOTICE Notice is hereby given that The Children's Mémorial Hospital of the city and district of Montreal will apply to the legislature of the Province of Quebec at its present session for the passing of an Act to change its name to \"The Montreal Children's Hospital\", to vest in it the property, rights, powers and privileges of Montreal Children's Hospital and for other purposes.Montreal, November 25th, 1954.The Children's Memorial Hospital, By: JOHN II.MOLSON, 38727-49-4 President.NOTICE Public notice is hereby given that la Corporation des Pères Bénédictins dc Saint-Benoit-du-Lac will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its current session for the adoption of a law modifying its corporate name, increasing its powers and those of its members, increasing the territory of the Municipality of Saint-Benoit-du-Lac and the powers of this Corporation.Saint-Benoit-du-Lac, 3rd November 1954.IVAN SABOURIN, 38780-50-4-o Attorney for the petitioner.Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Notice is hereby given that the Corporation of \"Les Frères dc la Charité\", corporation having its head office in the city aud district of Montreal, will apply to the Legislature of the Province of Quebec at its present session for the purposes of adopting an act to increase its power to possess immoveables and for other purposes.Montreal, December 1st, 1954.PHILIPPE FERLAND, Q.C., 38781-50-4 Attorney for the petitioner.PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that the corporation of the town of Arthabaska and the School commissioners for the municipality of the village of Arthabaskaville, the corporation of the village of Princeville, the School commissioners for the municipality of the village of Princeville, the corporation of the village of Warwick, and the School commissioners for the municipality of the village of Warwick, all of the county of Arthabaska, will apply to the Legislature of the province of Quebec, at its present session, for the passing of an Act.for the following purposes: 1.To authorize the imposition of a* sales tax of 2% and of an Education tax of 1% in their respective territories; 2.To add the product of these collected taxes in the abovementioncd territories and of the same identical taxes collected in the town of Victoriaville, and to share the total thereof in the proportion to be made between the several parties in issue.3.To authorize the town of Arthabaska, the corporation of the village of Princeville and the corporation of the village of Warwick to borrow respectively the amounts of 875,000.00, $75,000.00 and $150,000.00 for industrial expansion; 4.To authorize the town of Arthabaska to grant annually a sum not exceeding $1,000.00 for publicity and advertisement purposes, and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, Vol.80, No.50 3733 n'excédant pas 31,000.00 annuellement; 5° Autoriser le conseil municipal d'Arthabaska à octroyer des deniers jusqu'à concurrence de 81,000.00 annuellement pour ai 1er, dans la ville, certaines sociétés, organisations et œuvres sans but lucratif, et pour autres fins.Arthabaska, P.Q., 18 novembre 1954.Les Procureurs des requérants, 38803-50-4-o WALSH & MOISAN.to pay entertainment expenses of mayor and councillors.5.To authorize the municipal council of Arthabaska to grant moneys to the amount of 81,000.00 annually to help certain non-profit associations, organizations and works, within the town; and for other purposes.Arthabaska, P.Q., november 18th, 1954.WALSH & MOISAN, 38803-50-4-o Attorneys for the petitioners.Action en separation de biens Action for separation as to property AVIS LEGAL Cour Supérieure, province de Québec, district dc Montréal, N° 3(53347, Dame Lucille Jolicceur épouse de Léo Victor Rousseau, commis de Montréal, a formé contre son mari une demande en séparation dc biens.Montréal, le 3 décembre 1954.Les avocats de l.a demanderesse, RENÉ DEGUIRE 38796-0 & ALBAN OUELLETTE.LEGAL NOTICE In the Superior Court, Province of Quebec, district of Montreal, No.363347, Dame Lucille Jolicceur, wife of Léo Victor Rousseau, clerk, domicilied at Montreal, has taken as action for separation as to property against her husband.Montreal, December 3rd, 1954.RENÉ DEGUIRE & ALBAN OUELLETTE, 38796-0 Attorneys for plaintiff.Arrêté en Conseil - ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1126 Québec, le 10 novembre 1954.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant la Réserve des Chic-Chocs.Attendu que le paragraphe 1 de la partie de l'arrêté en conseil numéro 1200, en date du 27 octobre 1949, concernant la Réserve de chasse et de pêche des Chic-Chocs, créait cette Réserve et que le paragraphe 2 se lisait comme suit: 2.Qu'il soit tout spécialement défendu de chasser, tuer ou prendre tout gibier, animal ou oiseau sauvage quelconque d'hui au 1er novembre 1954.Attendu que la Réserve de chasse et de pêche des Chic-Chocs est maintenant établie de façon permanente.Vu l'article 65 du chapitre 153 des S.R.Q., 1941, Il est ordonné en conséquence, sur la propotion de l'honorable Ministre de la chasse et des pêcheries : Que la défense d'y chasser, tuer ou prendre tout gibier, animal ou oiseau sauvage quelconque soit maintenant édictée de façon permanente et que le paragraphe 2 de la partie de l'arrêté en conseil numéro 1200, en date du 27 octobre 1949, concernant la Réserve de chasse et de pêche des Chic-Chocs, se lise comme suit: 2.Qu'il soit tout spécialement défendu d'y chasser, tuer ou prendre tout gibier, animal ou oiseau sauvage quelconque.Concernant la Réserve de chasse et de pêche d'Aiguebelle.Attendu que le paragraphe 1 de l'arrêté en conseil numéro 4442, en date du 18 octobre 1945, créait la Réserve de chasse et de pêche d'Aiguebelle et que le paragraphe 2 y prohibait la chasse de tout gibier jusqu'au 31 décembre 1949; Order in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 1126 Quebec, November 10th, 1954.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Chic-Chocs Reserve.Whereas paragraph 1 of that part of Order in Council number 1200, dated October 27th, 1949, concerning the Fish and Game -Reserve of Chic-Chocs, created said Reserve, and in which paragraph 2 read as follows: 2.That it be especially prohibited to hunt, take or kill any game, animal or wild bird whatsoever from this day to November 1st, 1954.Whereas the Fish and Game Reserve of Chic-Chocs is now permanently established.In view of section 65, chapter 153, R.S.Q., 1941, In consequence it is ordained, upon the proposition of the Honourable the Minister of Game and Fisheries: That the prohibition to hunt, kill or take any game, animal or wild bird whatsoever therein, be now enacted permanently and that paragraph 2 of that part of Order in Council number 1200, dated October 27th, 1949, concerning the Fish and Game Reserve of Chic-Chocs, should read as follows: 2.That it be especially prohibited to hunt, kill or take any game, animal or wild bird whatsoever therein.Concerning the Fish and Game Reserve of Aiguebelle.Whereas paragraph 1 of Order in Council number 4442, dated October 18th, 1945, created the Fish and Game Reserve of Aiguebelle and that paragraph 2 prohibited, therein, the hunting of any game up to December 31st, 1949; 3734 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 60 Attendu que la partie de l'arrêté en conseil numéro 1031, en date du 14 septembre 1949, concernant la Réserve de chasse et de pêche (l'Aiguebelle, prolongeait cette défense de chasser jusqu'au 31 décembre 1954; Attendu que ladite Réserve d'Aiguebelle est maintenant établie de façon permanente et qu'il y a lieu d'y prohiber toute chasse.Vu l'article 65 du chapitre 153 des S.R.Q., 1941, Il est ordonne en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre de la Chasse et des Pêcheries: Que le paragraphe 2 de l'arrêté en conseil numéro 4442, en date du 18 octobre 1945, concernant la Réserve de chasse et de pêche d'Aiguebelle, soit modifié et se lise comme suit: 2.Qu'il soit tout spécialement défendu d'y chasser, tuer ou prendre tout gibier, animal ou oiseau sauvage quelconque.Concernant la création d'une Réserve à castors dans le comté dc Saguenay et le Nouveau-Québec (Ungava).Attendu Qu'une étendue d'environ 200,000 milles carrés de territoire dans la province de Québec est maintenant organisée en réserve à castors; Attendu Qu'un aménagement rationnel de ces territoires a donné les meilleurs résultats en ce qui concerne la conservation du castor en particulier et des animaux à fourrure en général.Vu l'article 65 du chapitre 153 des S.R.Q., 1941, Il est ordonné en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre de la Chasse et des Pêcheries: Que tout le territoire du district électoral de Saguenay situé à l'est de la Réserve à castors de Bersimis et au Nord d'une ligne imaginaire établie à cinq milles au nord de la côte du fleuve et du golfe Saint-Laurent, ainsi que tout le territoire du Nouveau-Québec, non encore organisé en Réserve à castors, soit, le 1er mai 1955, déclaré Réserve à castors, sujet aux règlements stipulés dans la partie de l'arrêté en conseil numéro 1068, en date du 15 octobre 1952, concernant la chasse au castor dans les réserves spécialement affectées à sa conservation, tel qu'amendé par la partie de l'arrêté en conseil numéro 1159, en date du 23 octobre 1953, concernant le castor.Concernant la chasse au castor.Attendu que la presque totalité de la province est maintenant organisée en réserves «à castors ou en régions de terrains enregistrés pour les trappeurs: Attendu Qu'il y a lieu de mettre sur pied dans tout le reste de la province le système qui a fait ses preixves dans ces régions et territoires.Vu l'article 65 du chapitre 153 des S.R.Q., 1941, Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre de la chasse et des pêcheries: Qu'il soit permis de trapper le castor dans la province du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante, inclusivement, aux conditions suivantes: 1.Dans les régions de terrains enregistrés pour fins de chasse aux animaux à fourrure, sur les terrains où les privilèges de trappage des animaux à fourrure ont été loués par le gouvernement à des particuliers ou à des clubs, ainsi que dans d'autres parties de la province, en dehors des réserves à castors, où l'état de la po- Whereas that part of Order in Council number 1031, dated September 14th, 1919, concerning the Fish and Game Reserve of Aiguebelle, extended said prohibition to hunt up to December 31st, 1951.Whereas the said Reserve of Aiguebelle is now established permanently, and that it is expedient that hunting be prohibited therein.In view of section 65, chapter 153, R.S.Q., 1941, In consequence it is ordained, upon the proposition of the Honourable the Minister of Game Fisheries: That paragraph 2 of Order in Council number 4442, dated October 18th, 1945, concerning the Fish and Game Reserve of Aiguebelle, be modified in order to read as follows: 2.That it be especially prohibited to hunt, kill or take any game, animal or wild bird whatsoever therein.Concerning the creation of a Reserve for Beaver in the county of Saguenay and New Quebec (Ungava).Whereas an area of about 200,000 square miles in the Province of Quebec is now organized as a reserve for Beaver; Whereas the rationalization of these territories has been very effective as to the conservation of Beaver in particular, and fur-bearing animals in general.In view of section 65, chapter 153, R.S.Q., 1941, In consequence it is ordained, upon the proposition of the Honourable the Minister of Game and Fisheries: That the whole territory of the electoral district of Saguenay situated east of the Beaver Reserve of Bersimis and north of the imaginary line established five miles north of the shore of the River and Gulf of Saint Lawrence, as well as the whole territory of New Quebec, not as yet organized as a Beaver reserve, be declared, on May 1st, 1955, as a Beaver Reserve, subject to the regulations stipulated in that part of Order in Council number 1068, dated October 15th, 1952, concerning the hunting of Beaver in reserves especially organized for its conservation, such as amended by that part of Order in Council number 1159, dated October 23rd, 1953, concerning Beaver.Concerning the Hunting of Beaver.Whereas nearly the whole of the Province is now organized into reserves for Beaver or regions of land registered for trappers; Whereas it is expedient to establish in the rest of the Province the same system which has been so effective in the said regions and territories.In view of section 65, chapter 153, R.S.Q., 1941, In consequence it is ordained, upon the proposition of the Honourable the Minister of Game and Fisheries: That permission be granted to drap Beaver in the Province from November 1st, of any year to April 15th of the next year, inclusive, on the following conditions: 1.In the regions of land registered purposely for the hunting of fur-bearing animals, on land where the rights for trapping fur-bearing animals have been leased by the Government to individuals or clubs, as well as in other parts of the Province, outside Beaver reserves, where in the conditions of the Beaver population would QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, I ol.80, No.5U 3735 puliation du castor le justifiera, suivant la prescriptions de l'arrêté en conseil numéro 3551, en date du 5 septembre 1945, tel qu'amendé; 2.Dans les réserves à castors, suivant les prescriptions de la partie de l'arrêté en conseil numéro 1068, en date du 15 octobre 1952, concernant la chasse au castor dans les réserves spécialement afl'ectées à sa conservation, tel qu'amendé par la partie de l'arrêté en conseil numéro 1159, en date du 23 octobre 1953, concernant le castor; 3.Que tout commerçant dc fourrure, muni de son permis régulier, devra identifier les peaux de castor qu'il achètera, par le numéro du permis de trappeur à être inscrit dans son rapport; 4.Que la partie de l'arrêté en conseil numéro 777, en date du 30 juin 1953, concernant la chasse au castor, soit abrogée.Concernant un amendement à l'arrêté en conseil numéro 3551, en date du 5 septembre 1945, concernant la chasse au castor.Attendu Qu'il y a lieu, à la suite de certaines constatations d'ordre biologique, de modifier les règlements concernant le trappage du castor sur les terrains de chasse enregistrés pour les trappeurs.Vu l'article 65 du chapitre 153 des S.R.Q.1941, Il est ordonné en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre de la chasse et des pêcheries : Que le paragraphe 5 de l'arrêté en conseil numéro 3551, en date du 5 septembre 1945, soit remplacé par le suivant: 5.Les permis spéciaux pour trapper le castor seront accordés suivant l'inventaire annuel et le Ministre de la Chasse et des Pêcheries pourra indiquer la façon dont ces peaux pourront être mises sur le marché.Le Greffier du Conseil Exécutif, 38762-0 L.DÉSILETS.Avis divers Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original dc la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"ACTRA (Montréal) Credit Union\", en date du 24 novembre 1954, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le vingt-neuf novembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38763-0 JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Imperial Oil Refinery Employees (Montreal East) Credit Union\", en date du 24 novembre 1954, dont le siège social est situé à Montréal-Est, dans le district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le vingt-neuf novembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38764-o JEAN BRUCHÉSI.warrant it, in accordance with the prescriptions of Order in Council number 3551, dated September 5th, 1945, as amended.2.In Beaver Reserves, in accordance with the prescriptions of that part of Order in Council number 1068, dated October 15th, 1952, concerning the hunting of Beaver in reserves especially organized for its conservation, such as amended by that part of Order in Council number 1159, dated October 23rd, 1953, concerning Beaver; 3.That any fur dealer holding a regular permit, shall identify the Beaver pelts which lie intends buying by means of the number of the trapper's permit, to be written down in his report : 4.That, that part of Order in Council number 777, dated June 30th, 1953, concerning the hunting of Beaver, be repealed.Concerning an amendment to Order in Council number 3551, dated September 5th, 1945, concerning the hunting of Beaver.Whereas as a result of certain biological research work, it is expedient that the regulations concerning the trapping of Beaver on hunting grounds registered for trappers, be modified.In view of section 65, chapter 153, R.S.Q., 1941, In consequence it is ordained, upon the proposition of the Honourable Minister of Game and Fisheries: That paragraph 5 of Order in Council number 3551, dated September 5th, 1945, be replaced by the following: 5.Special permits for the trapping of Beaver shall be granted according to the annual inventory and the Minister of Game and Fisheries may determine the manner in which these pelts may be put on the market.L.DÉSILETS, 38762 Clerk of the Executive Council.Miscellaneous Notices Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"ACTRA (Montreal) Credit Union\", under date November 24th, 1954, whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-ninth day of November, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38763 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Imperial Oil Refinery Employees (Montreal East) Credit Union\", under date the twenty-fourth day of November 1954, whereof the head office is at Montreal-East, in the judicial district of Montreal and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-ninth day of November, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38764 Under Secretary of the Province. 3736 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 195A, Tome 86, N° 60 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Montreal Chapter NABET Credit Union\", en date du 24 novembre 1954, dont le siège social est situé à Montréal, dans le district de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le vingt-neuf novembre 1954.» Le Sous-secrétaire de la Province, 38765-0 JEAN BRUCHÉSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association des Employés de Paul Service Stores Ltd\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le premier décembre 1954.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Montréal, dans le district judiciaire de Montréal.Le Sous-secretaire de la Province, 38766-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.51312-53) Mrs.Whyte's Products Inc.Règlement N° 28 Un règlement diminuant le nombre des directeurs.\"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Mrs.Whyte's Products, Inc.\" (ici nommée la \"Compagnie\") ce qui suit: 1.Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, parles présentes, diminué dc quatre à trois de manière que le bureau de direction de la compagnie, soit dorénavant composé de trois directeurs.2.Trois directeurs formeront quorum à toute assemblée du bureau de direction.3.Tous règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie, incompatibles à icelui sont, par les présentes, amendés modifiés et revisés de manière à donner effet à ce règlement.\" Décrété ce 12e jour de novembre 1954.Certifié vraie copie, ce 15e jour de novembre 1954.(Sceau) Le Secrétaire, 38767 (Signé) II.WLTENOFF.AVIS Avis est, par les présentes, donné que, conformément aux dispositions de l'article 90 de la Loi des compagnies de Québec, \"Howick Realties Ltd.\", une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, a cessé d'exercer son commerce, sauf aux fins de ventilation de ses affaires, et n'ayant pas de dettes ou responsabilités, a décrété le règlement N° 24 de la compagnie l'autorisant à distribuer son actif au Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Montreal Chapter NABET Credit Union\", under date November 24th, 1954, whereof the head office is at Montreal, in the judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-ninth day of November, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38765 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association des Employés de Paul Service Stores Ltd.\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on December first, 1954.The principal place of business of the said professional syndicate is at Montreal, in the judicial district of Montreal.JEAN BRUCHÉSI, 38766 Under Secretary of the Province.(P.G.51312-53) Mrs.Whyte's Products Inc.By-law No.23 A.by-law to decrease the number of directors \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of \"Mrs.Whyte's Products, Inc.\" (herein called the \"company\") as follows: 1.The number of the directors of the company be and the same is hereby decreased from four to three so that the Board of directors of the company shall hereafter be composed of three directors.2.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.\" Enacted this 12th day of November, 1954.Certified true copy, this 15th day of November, 1954.(Seal) (Signed) H.WITENOFF, 38767-0 Secretary.NOTICE Notice is hereby given under the Provisions of section 90 of the Quebec Companies' Act, that \"Howick Realties Ltd.\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, having ceased to carry on business except for the purpose of winding up its affairs, and having no debts or obligations, has enacted by-law No.24 of the company authorizing the company to distribute its assets rateably among its shareholders, and QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, * ol.86, No.50 3737 pro rata entre ses actionnaires, et subséqucm-ment procéder à sa dissolution par voie dc pro-décures d'abandon de charte en vertu de l'article 26 de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 2e jour de décembre 1954.Le Procureur de la compagnie, 38768 ALBERT IL MALOUF.(P.G.9033-50) British Coal Corporation Règlement spécial 1-A Un règlement pour changer l'adresse du siège social de la compagnie et amender le règlement N° 1.\"1.Qu'il soit décrété que le siège social de la compagnie sera en la cité de Montréal, province (4 de Québec.2.Que la deuxième ligne du règlement N°l soit amendée en rayant les mots \"Québec, district de Québec\" et en y substituant les mots \"la cité de Montréal, province de Québec\".\" Certifié vraie copie.Le Secrétaire-trésorier, 38772 C.W.COULSOxX.(Sec.P.1565-50) Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 18 novembre 1954, les règlements de \"L'Association des Loisirs de Châteauguay\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le dix-neuf novembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38775-0 JEAN BRUCHÉSI.subsequently to proceed to dissolution by way of surrender of Charter proceedings under section 26 of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 2nd day of December, 1954.ALBERT H.MALOUF, 38768-o Attorney for the Company.(A.G.9033-50) British Coal Corporation Special by-law 1-A A by-law to change the address of the head office of the company and to amend by-law No.1 \"1.Be it enacted that the head office of the company be in the city of Montreal in the Province of Quebec.2.That the second line of by-law No.1 be amended by deleting the words \"Quebec, in the District of Quebec\" and by substituting therefor the words \"the city of Montreal in the Province of Quebec\".\" Certified true copy.C.W.COULSON, 38772-0 Secretary-Treasurer.(P.Sec.1565-50) Notice is hereby given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable the Provincial Secretary has approved, on November 18th, 1954, the by-laws of the \"L'Association des Loisirs de Châteauguay\", and such, pursuant to the provisions 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, \u2022 this nineteenth day of November, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38775 Under Secretary of the Province.Montréal \u2014 Province de Québec Montreal \u2014 Province of Quebec Avis vous est par les présentes donné que les per- Notice is hereby given that the following sonnes suivantes sont membres de L'Associa- persons are members of the Association of Pro- tion des Chimistes Professionnels de Québec.fessional Chemists of Quebec.C.Allard, Montréal; J.A.F.Bonnier, Mont- C.Allard, Montreal; J.A.F.Bonnier, Montréal; B.P.Buckley, Shawinigan Falls; B.L.real; B.P.Buckley, Shawinigan Falls; B.L.Carrier, Montréal; M.P.Charest, Montréal; Carrier, Montréal; M.P.Charest, Montreal; J.Délonne, Montréal; R.Desjardins, Montréal; J.Délorme, Montreal; R.Desjardins, Montreal; B.Dussault, Montréal; A.A.Gareau, Montréal; B.Dussault, Montreal; A.A.Gareau, Montreal; J.Gauthier, Montréal; J.S.Hole, Drummond- J.Gauthier, Montreal; J.S.Hole, Drummond-ville; P.Koch, Montréal; G.de Lamirande, ville; P.Koch, Montreal; G.de Lamirande, Montréal; P.Lapointe, Montréal; L.L'Heureux, Montreal; P.Lapointe, Montreal; L.L'Heureux, Belœil; R.Limoges, Montréal; F.J.Pearce, Beloeil; R.Limoges, Montreal; F.J.Pcarce, Montréal; V.Portelance,Montréal;!).F.Rhodes, Montreal; V.Portelance; Montreal;D.F.Rhodes, Montréal; E.Bakewell, Montréal; H.Barnett, Montreal; E.Bakewell, Montreal; H.Barnett, Montréal; R.N.Barrett, Baie D'Urfee; R.Ber- Montreal; R.N.Barrett, Baie D'Urfee, R.Bergeron, Trois-Rivières; G.A.Cimon, Montréal; geron, Trois-Rivières; G.A.Cimon, Montreal; L.V.Clegg, Montréal; R.H.Common, Mac- L.V.Clegg, Montreal; R.H.Common Mac-donald College; L.A.Cox, Montréal; O.F.donald College; L.A.Cox, Montreal; O.F.Denstedt, Montréal; J.A.Desnoyers, Montréal; Denstedt, Montreal; J.A.Desnoyers, Montreal; P.E.Duranceau, Montréal; W.H.Eastlake, P.E.Duranceau; Montreal; W.H.Eastlake, Lachine; B.Farrar, Montréal; H.E.Fisher, Lachine; B.Farrar, Montreal; H.E.Fisher, Shawinigan Falls; E.Giguère, Montréal; L.Shawinigan Falls; E.Giguère, Montreal; L.Girouard, Montréal, G.A.Grant, Montréal; Girouard, Montreal; G.A.Grant, Montreal; A.H.Heatley, St.Lambert; W.R.Heumann, A.H.Heatley, St.Lambert; W.R.Heumann, Montréal; Z.Jégier, Montréal; J.M.Keith, Montreal; Z.Jégier, Montreal; J.M.Keith, Montréal; M.Kriaucionis, Verdun; L.C.Lajoie, Montreal; M.Kriaucionis, Verdun; L.C.Lajoie, Montréal; H.Laniel, Saint-Jean; L.C.Laporte, Montreal; H.Laniel, Saint-Jean; L.C.Laporte, Montréal; R.Leduc, Saint-Jean; M.Lessard, Montreal; R.Leduc, Saint-Jean; M.Lessard, Québec; V.B.Lillie, Montréal; W.W.Lummis, Quebec; V.B.Lillie, Montreal; W.W.Lummis, Montréal, J.A.McCoubrey, Montréal; A.F.Montreal; J.A.McCoubrey, Montreal; A.F.McKay, Pointe-Claire.McKay, Pointe-Claire.Le Secrétaire-Régistraire, ARTHUR F.WATSON, 38776-0 ARTHUR F.WATSON.38776-0 Secretary-Registrat. 3738 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 60 AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE Avis est, par les présentes, donné que \"Hope Baptist Church\", de Ilopetown, Québec, présentera une requête au Lieutenant-gouverneur en Conseil de la province de Québec pour obtenir sa constitution en corporation en vertu de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 311 des Statuts refondus'de la province de Québec, 19-11, et amendements.Montréal, 4 décembre 1954.Les Procureurs de la requérante, CERINI & JAMIESON.231- ouest, rue St-Jacques, Montréal, Que.38778-50-5 (P.G.11543-54) Avis est donné que, sur la recommandation dc l'Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le deux décembre 1954, les règlements numéros 1 à 33 inclusivement de \"Le Camp dc Vacances Armand Dubrcuil Incorporé\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le deux décembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38777-0 JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that the \"Hope Baptist Church\", of Hopetown, Quebec, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quebec for incorporation under the Church Incorporation Act, chapter 311 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, 1941, and amendments.Montreal, December 4th, 1954.CERINI & JAMIESON, Solicitors for petitioner.231 St.James Street West, Montreal, Que.38778-50-5-O (A.G.11543-54) Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the Honourable Secretary of the province has approved, on December second, 1954, by-laws numbers 1 to 33 inclusively of \"Le Camp de Vacances Armand Dubreuil Incorporé\", and such, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this second dav of December, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38777 Under Secretary of the Province.Avis concernant l'aménagement de forces Notice concerning the development op hydrauliques sur la riviere 15 a zi x à 8 hydraulic power of the bazin rlver, milles du village de parent, comté de at 8 miles distance from the village of La violette.Parent, county of Laviolette.Conformément au régime des eaux courantes, la corporation du village de Parent comté de Laviolette, après avoir obtenu, par ordre en conseil du gouvernement de la province de Québec daté du 21 août 1954, lequel ordre autorise le ministre des Ressources Hydrauliques à louer à la corporation municipale dudit village, les forces hydrauliques dc la rivière Bazin cantons Landry et Bazin, entre le pont du 8 milles du chemin qui conduit de Parent à Clova, et la rivière Pitchpine, demande au Lieutenant-gouverneur en conseil la permission de construire, de maintenir et d'exploiter un barrage en béton et une usine génératrice d'électricité à environ 200 pieds en amont du site dudit pont.Les originaux des plans et devis ont été déposés au Département des Ressources Hydrauliques dc la province de Québec, et copies des djts plans et devis ont été déposées au bureau de la division d'enregistrement du comté d'Abitibi à Amos.La demande contenue dans cette requête sera prise en considération le ou après les jours suivants la date de la dernière publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Québec, le 18 novembre 1954.Les Ingénieurs-Conseil, ZACHÉE & PIERRE LANGLAIS.38779-50-4-O In accordance with the Water Course Act, the Village Corporation of Parent, county of Laviolette, after having obtained by Order in Council of the Government of the Province of Quebec, dated August 21st, 1954, which Order authorizes the Minister of Hydraulic Resources to lease to the Municipal Corporation of the said village, the hydraulic power resources of the Bazin River, Townships of Landry and Bazin, between the bridge situate at 8 miles from the road leading from Parent to Clova, and the Pitchpine River, prays the Lieutenant-Governor in- Council for permission to build, maintain and develop a concrete dam and electric generating station at some 200 feet above the site of said bridge.The original plans and specifications have been deposited with the Department of Hydraulic Resources of the Province of Quebec, and copy of said plans and specifications has been deposited at the Registry Office of the Registration Division of the county of Abitibi at Amos.The application contained in this petition will be taken into consideration on or about the days following the date of the last publication of this notice in the Quebec Official Gazette.Quebec, November 18th, 1954.ZACHÉE & PIERRE LANGLAIS, Consulting Engineers.38779-50-4 (P.G.12329-54) Barnabe Motors Ltd.Règlement N° 26 changeant le nombre des directeurs.Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de \"Barnabe Motors Ltd.\", ce qui suit: 1° Que le nombre des membres du bureau de direction dc la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de trois (3) à quatre (4).(A.G.12329-54) Barnabe Motors Ltd.By-law No.26 changing number of directors.Be it enacted and it is hereby enacted as a By-law of \"Barnabe Motors Ltd.\", as follows: 1.The number of the board of directors of .the Company be, and it is hereby increased from three (3) to four(4). QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1964, Vol.80, No.60 3739 2° Que les règlements de la compagnie soient et ils sont, par les présentes, amendés pour se conformer au précédent.Décrété ce 28e jour d'octobre 1954.(Sceau) Le Secrétaire, 38806 ALFRED K.LAWEE.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Syndicat Coopératif des Loisirs de l'Anse St-.Iean\", en date du 16 novembre 1954, dont le siège social est situé à l'Anse St-Jean, dans le comté de Chicoutimi, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire dc la Province, le vingt-neuf novembre 1954.Le Sous-secrétairc de la Province, 38807-o JEAN BRUCHÉSI.(P.G.12785-54) Beauharnois Curling Club Extrait de la constitution et règlements de la corporation nommée ci-dessus concernant une augmentation du nombre de ses directeurs dc quatre (4) à quatorze (14): Bureau de direction \u2014 6.Les affaires du club seront administrées par un bureau de direction composé de 14 membres élus à l'assemblée générale annuelle.Le Secrétaire, 38809 REAL L.DEMERS.(P.G.46261-53) Chantecler Curling & Country Club Règlement Quatre-A 1.Le nombre des directeurs du club est, par les présentes, augmenté de sept (7) à quinze (15).2.L'article 1 du règlement quatre est amendé en rayant les mot et chiffre \"Sept (7)\" et insérant les mot et chiffre \"Quinze (15)\".Certifié vraie copie.22 novembre 1954.\u2022 Le Secrétaire, 38812 JOHN G.PORÏEOUS.(P.G.2737-48) hurtubisk et St-CyR limitee Règlement augmentant le nombre des directeurs dc trois (3) à cinq (5) : \" \"H est unanimement résolu que: Le règlement N° 1-A est adopté comme suit: Le paragraphe 1 du règlement N° III de la compagnie est remplacé par le suivant : \"1.Nombre: Les affaires de la compagnie seront administrées par un Conseil d'Administration composé de cinq membres.\" Certifie vraie copie, Montréal, le 22 septembre 1954.\"Le Secrétaire, 38813-0 ALFRED ST-CYR.(P.G.6455-44) La Compagnie de Ferronnerie Letang Limitée The Letang Hardware Company Limited Règlement N° VII \"Qu'il soit décrété que: t 1° Le nombre des Directeurs de la compagnie \u2022 'La Compagnie de Ferronnerie Letang Limitée 2.The by-aws of the Company be, and they are hereby amended to accord with the foregoing.Enacted this 28th day of October, 1954.(Seal) ALFRED K.LAWEE, 38806-o Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Syndicat Coopératif des Loisirs de FAnsc St-Jean\", under date November 16th, 1954, whereof the head office is at L'Anse St-Jean, in the county of Chicoutimi and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-ninth day of November, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38S07 Under Secretary of the Province.(A.G.12785-54) Beauharnois Curling Club Extract from the Constitution and by-laws of the above-named Corporation concerning an increase in the directorate thereof from four (4) to fourteen (14): Board of Directors \u2014 6.The affairs of the Club shall be administered by a Board composed of fourteen members elected at the Annual General Meeting.REAL L.DEMERS, 38809-o Secretary.(A.G.46261-53) Chanteclkr Curling & Country Club By-law Four-A 1.The number of directors of the Club is hereby increased from Seven (7) to Fifteen (15).2.Article 1 of by-law four is amended by deleting the words and figures \"Seven (7)\" and inserting the words and figures \"Fifteen (15)\".Certified true copy : November 22nd, 1954.JOHN G.PORTEOUS, 38812-o Secretary.(A.G.2737-48) hurtubise et St-CyR limitée By-law increasing the number of directors from three (3) to five (5): \"It is unanimously resolved that: by-law No.1-A is adopted as follows: Paragraph 1 of Company's by-law No.Ill is replaced by the following: \"1.Number: The affairs of the company shall be managed by a Board of Directors composed of five members.\" Certified true copy, Montreal, September 22nd, 1954.ALFRED ST-CYR, 38813 Secretary.(A.G.6455-44) La Compagnie de Ferronnerie Letang Limitée The Letang Hardware Company Limited By-law No.VII \"Be it enacted that: 1° The number of Directors of the Company \"La Compagnie de Ferronnerie Letang Limitée 3740 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 50 \u2014 The Letang Hardware Company Limited\" soit et est par les présentes réduit dc sept (7) à cinq (5) de façon à ce que le Bureau de Direction de la compagnie se compose désormais de cinq (5) Directeurs.\" Certifié vraie copie, le 28 octobre 1954.Le Secrétaire, 38814-0 JEAN ST-JACQUES.Chartes \u2014 Abandon de AVIS Avis est, par les présentes donné que la compagnie \"Howick Realties Ltd.\" s'adressera au Lieutenant-gouverneur en Conseil pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, de l'annuler; aussi fixer une date à Compter de laquelle elle sera dissoute.Daté à Montréal, ce 2e jour dc décembre 1954.Le Procureur de la compagnie, 38768 ALBERT H.MALOUF.A.C.Baker Company Ltd.Avis est, par les présentes, donné que \"A.C.Baker Company Ltd.\", une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au Procureur général de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 1er jour de décembre 1954.Le Secrétaire, 38769 K.ATKINSON.Avis de requête d'abandon de charte Avis est par les présentes donné que \"Acme Holding Corporation\" ayant son bureau chef dans les cité et district de Montréal, s'adressera au Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner ses lettres patentes, à partir de et après la date qu'il lui plaira de déterminer.Daté à Montréal, ce 29e jour de novembre 1954.Les Procureurs de la requérante, STEIN & STEIN.Ch.1075 \u2014 1435 St.Alexandre, Montreal, Que.38770-o Seven Ten Victoria Square Ltd.Avis est par les présentes donné que \"Seven Ten Victoria Square Ltd.\", a l'intention de demander au Procureur Général de la Province de Québec la permission d'abandonner sa charte.7 décembre 1954.Le Secrétaire, 38808-o JOSEPH HOPMEYER.Département de l'Instruction Publique N° 552-54.Québec, le 3 décembre 1954.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Lacolle, dans le comté de St-Jean, le lot 1 du cadastre officiel de la paroisse \u2014 The Letang Hardware Company Limited\" be and is hereby decreased from seven (7) to five (5) in order that the Company's Board of Directors be composed hereafter of five (5) Directors.\" Certified true copy, October 28th, 1954.JEAN ST-JACQUES, 38814 Secretary.Charters \u2014 Surrender of NOTICE Notice is hereby given that \"Howick Realties Ltd\", will apply to the Lieutenant-Governor in Council for leave to surrender its Charter, have it cancelled, and have a date fixed on and from which the Company shall be dissolved.Dated at Montreal, this 2nd day of December, 1954.ALBERT II.MALOUF, 3S708-o Attorney for the Company.A.C.Baker Company Ltd.Notice is hereby given that the \"A.C.Baker Company Ltd.\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Attorney-General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 1st day of December, 1954.K.ATKINSON, 38769-0 Secretary.Notice of application for leave to surrender charter Notice is hereby given that \"Acme Holding Corporation\" having its head office in the city and district of Montreal, will apply to the Honourable Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, for leave to surrender its letters patent, from and after the date which he will be plâesed to determine.Dated at Montreal, this 29th day of November, 1954.STEIN & STEIN, Attorneys for petitioner.Suite 1075 \u2014 1435 St.Alexander St., Montreal, Que.38770-O Seven Ten Victoria Square Ltd.Notice is hereby given under the Quebec Companies' Act and Amendments that \"Seven Ten Victoria Square Ltd.\", intends to make application to the Attorney General of the Prov ince of Quebec for leave to surrender its charter.December 7th, 1954.JOSEPH HOPMEYER, 38808-O Secretary.Department of Education No.552-54.Quebec, December 3rd, 1954.Application is made to detach from the school municipality of Lacolle, in the county of St-John, lot 1 of the official cadastre of the parish QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1951, Vol.86, No.50 3741 de St-Valentin, et la partie du lot 426 du même cadastre, bornés au sud par la rivière Lacolle, à l'ouest par la ligne de division entre les lots 426 et 427, au nord par la ligne qui passe dans la Montée Bowman et à l'est par le chemin dc fer Canadien National, pour les annexer à la municipalité scolaire dc St-Paul-dc-L'Ile-aux-Noix, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38795-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 728-53.Québec, le 7 décembre 1954.Demande est faite d'annexer pour les contribuables protestants seulement, le territoire dc la municipalité scolaire du canton East Farn-ham, dans le comté de Brome, a la municipalité scolaire protestante de Cowansville, comté de Missisquoi.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38793-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 503-54.Québec, le 3 décembre 1954.Demande est faite de détacher dc la municipalité scolaire dc St-Francois-Xavicr-dc-Bromp-ton, dans le comté de Richmond, les lots 1 à 7 inclusivement du rang 1 et 1 à 17 inclusivement du rang 11 du cadastre officiel de St-François-Xavier-dc-Brompton, pour les annexer, pour les contribuables catholiques seulement, à la municipalité scolaire catholique de St-Grégoire-de Greenlay, dans le même co:nté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38794-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 751-51.Québec, le 2 décembre 1954.Demande est faite d'annexer, pour les contribuables protestants seulement, le territoire de la municipalité scolaire du village de Dunham, dans le comté dc Missisquoi, à celui dc la municipalité scolaire protestante de Cowansvillc, même comté.Le village de Dunham comprend la demie ouest des lots originaires 10, 11 et 12 du rang VI et la demie est des lots originaires 10, 11 et 12 du rang VII du canton Dunham.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38798-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS.No.1225-54.Québec, le 3 décembre 1954.Avis est par la présente donné que je me propose d'annexer au territoire actuel dc la municipalité scolaire de Rapide Danseur, comté d'Abitibi-Ouest, tous les lots du rang VI du canton Hébécourt, territoire qui n'est pas pas encore organisé au point de vue scolaire.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38799-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 763-54.Québec, le 2 décembre 1954.Demande est faire d'annexer, pour les contribuables protestants seulement, le territoire de la municipalité scolaire de Port Daniel-Est, comté de Bonaventure, à la municipalité scolaire protestante dc Shigawake de Port Daniel, dans le même comté.Le Surintendant dc l'Instruction publique, 38800-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS.N° 731-54.Québec, le 3 décembre 1954.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Saint-Adolphe-de-Dudswell, dans of St-Valentin, and part of lot 426 of the same cadastre, bounded on the south by the Lacolle River, on the west by the dividing line between lots 426 and 427, on the North by the line which passes in the Bowman slope and on the cast by the Canadian National Railway, to annex them to the school municipality of St-Paul-de-l'Ile-aux-Noix, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38795-50-2 Superintendent of Education.No.728-53.Quebec, December 7th, 1954.Application is made to annex for the Protestant ratepayers only, the territory of the school municipality of the Township of East Farnham, in the county of Brume, to the Protestant School Municipality of Cowansville, county of Missisquoi.O.J.DÉSAULNIERS, 38793-50-2 Superintendent of Education.No.503-54.Quebec, December 3rd, 1954.Application is made to detach from the school municipality of St-FrancoisTXavicr-dc-Bromp-ton, in the county of Richmond, lots 1 to 7 inclusively of range 1 and I to 17 inclusively of Range II, of the official cadastre of St-François-Xavier de-Brompton, to annex them, for the Catholic ratepayers only, to the Catholic School Municipality of St-Grégoire de Greenlay, in the same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38794-50-2 Superintendent of Education.No.751-54.Quebec, December 2nd, 1951.Application is made to annex, for Protestant ratepayers only, the territory of the school municipality of the village of Dunham, in the County of Missisquoi, to that of the Protestant school municipality of Cowansville, same county.The village of Dunham includes the westerly half of original lots 10, 11, and 12, range VI, and the easterly half of original lots 10, 11 and 12, range VII, of the township of Dunham.O.J.DÉSAULNIERS, 38798-50-O Superintendent of Education.No.1225-54.Quebec, December 3rd, 1954.Notice is hereby given that I propose to annex to the present territory of the school municipality of Rapide Danseur, County of Abitibi-West all lots of range VI of the township of Hébécourt, territory which is not as yet organized from an educational point of view.O.J.DÉSAULNIERS, 38799-50-2 Superintendent of Education.No.763-54.Quebec, December 2nd, 1954.Application is made to annex for the ProJest-ant ratepayers only the territory of the school municipality of Port Daniel-East, county of Bonaventure, to the Protestant school municipality of Shigawake of Port Daniel, in the same county.O.1.DÉSAULNIERS, 38S00-50-2 Superintendent of Education.No.731-54.Quebec, December 3rd, 1954.Application is made to detach from the school municipality of St.Adolphe-de-Dudswcll, in.the 3742 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 80, N° 50 le comté de Wolfe, les lots 13 à 15 inclusivement du rang VII du canton Dudswell, pour les annexer à la municipalité scolaire de Saint-Adol-phe-de-Marbleton, même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique, 38801-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS.No.707-54.Québec, le 3 décembre 1954.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Cranbourne, dans le comté de Dorchester, les lots 20, 24 et 25 du rang I du cadastre officiel de Saint-Odilon-dc-Cranbourne, pour les annexer à la municipalité scolaire dc Saint-Édouard-dc-Frampton-Ouest, dans le même comté.Le Surintendant de l'Inslruction publique, 38802-50-2-O O.J.DÉSAULNIERS.Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 103 et amenden ents), que le Con ité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appiéciation et à la décision du Lieutenant-gouverneur en Conseil les modifications suivantes au décret N° 1197 du 25 octobre 1951, et amendements, relatif a l'industrie de la sacoche dans la province de Québec: 1° Le paragraphe \"a\" suivant sera ajouté à l'article VI: \"a) Travail supplémentaire: Tout travail supplémentaire exécuté en plus et en dehors des heures régulières n'est périr is que jusqu'à 7.00 p.m.les lundi, mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine, et entre 8.00 a.m.et midi le samedi de chaque serra inc.Dans les cas d'urgence, dans la période d'échantillonnage ou en d'autres occasions spéciales jugées par le Comité, on peut permettre du travail le samedi après-midi entre 1.00 p.m.et 5.00 p.m.sur autorisation spéciale accordée à l'avance.\" 2° Le paragraphe \"c\" suivant sera ajouté à l'article XVI: \"c) Tout employeur doit garder dans son établissement l'original des cartes poinçonnées (punch cards), des registres d'heures dc travail ou des listes dc paye, et être en mesure de le soumettre, pour examen et étude, aux inspecteurs du Comité paritaire pendant une période minimum de deux ans suivant la date de tels registres, cartes ou listes.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication dc cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.JjC Sous-ministre du Travail.GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 11 décembre 1954.38797-o ERRATUM Dans l'édition de la Gazette officielle de Québec, du 4 décembre 1954, à la page 3673, aux cinquième et sixième lignes de l'avis de modification qui y apparaît, veuillez lire \"Le Syndicat catho- county of Wilfc, lots 13 to 15 inclusive, range VII of the township of Dudswell, in order to annex them to the school municipality of St.Adolphc-de-Marblcton, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38801-50-2 Superintendent of Education.No.767-54.Quebec, December 3rd, 1954.Application is made to detach from the school municipality of Cranbourne, in the county of Dorchester, lots 20, 24 and 25, range I of the official cadastre of St.Odilon-de-Cranbourne, in order to annex them to the school municipality of St.Édouard-dc-Frampton-West, same county.O.J.DÉSAULNIERS, 38802-50-2 Superintendent of Education.Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the Parity Committee of the Handbag Industry of the Province of Quebec has petitioned him to submit to the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the decree No.1197 of October 25th, 1951, and amendments, relating to the handbag industry in the province of Quebec: 1.The following subsection \"a\" will be added to section VI: \"a) Overtime: Overtime work in addition to and after regular hours will be permitted only up to and not later than 7.00 p.m.on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday of each week, and between the hours of 8.00 a.m.and 12.00 noon on Saturday of each week.In cases of emergency, sample period or other special occasions deemed sufficient by the Committee, work on Saturday afternoon between the hours of 1.00 p.m.and 5.00 p.m.may be permitted by special permit granted in advance.\" 2.The following subsection \"c\" will be added to section XVI: \"c) It shall be obligatory for every employer to keep the original punch cards, time records, or payroll reports in his establishment and to make same available for examination and peril-sal by the inspectors of the Parity Committee for a period of at least two years from the date of such records.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parlies may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, December 11st, 1953.38797-o ERRATUM In the Quebec Official Gazette of December 4th, 1954, page 3673, please read in the fifth and sixth lines of the Notice of Amendment mentioned therein, please read \"Le Syndicat catholique QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 195A,.Vol.86, No.50 3743 lique de la Boîte de Carton de Québec Inc.,\" de la Boîte de Carton dc Québec Inc.,\" instead au lieu de \"Le Syndicat catholique de la Boîte of \"Le Syndicat catholique de la Boîte de Carton de Carton Gaufré Inc.\".Gaufré Inc.\".Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY, GÉRARD TREMBLAY.Deputy Minister of Labour.Ministère du Travail, Department of Labour, Québec, le 11 décembre 1954.38797-o Quebec, December 11th, 1954.38797-o Examens du Barreau \u2014 Bar Examinations BARREAU DE MONTRÉAL \u2014BAR OF MONTREAL Candidats pouh l'admission' à l'étude du duoit Candidates to the admission to the study ok law (Décembre 1054 \u2014 December 1951) Noms\tPrénoms\t\tRésidence\tCollège \u2014\t\u2014\tAge\t\u2014\t_ Names\tSurnames\t\tResidence\tCollege 1.Cyr.\t\t31 41\tMontreal.\tUniversité McGill.Bill privé.\tNicolas.\t\t\t \t\t\t\t Montréal, le 7 décembre 1954.\u2014 Montreal, December 7th, 1954.Le Secrétaire, ANDRÉ TESSIER, 38816-0 Secretary.BARREAU DE QUÉBEC \u2014BAR OF QUEBEC Candidats à l'examen pratique final Candidates to final practical examination Noms Names\tPrénoms Surnames\tAgo\tAd rosso Address \tGilles.\t20 25 20 27 25 34 34 24 20 27 28 26\tQuébec.Québec.Québec.Montmorency.Québec.Québec.Québec.Ste-Claire (Dorchester).Québec.Québec.St-Joscph (Boauce).St-Léon de Standon (Dorchester) .\tAndré.\t\t Vallée.\t\t\t Boily.\tCharles E.\t\t \t\t\t Gobeil.\t\t\t Thibault.\tLucile.\t\t \t\t\t \tJean-Paul.\t\t \tRené.\t\t \t\t\t \tJean-Marie.\t\t \t\t\t Candidats à l'examen théorique préliminaire Candidates to l'rcliminaru Theorilical Examination\t\t\t Gobeil.\t\t34 34' 27\tQuébec.Québec.Québec.Thibault.:.\t\t\t \tRené.\t\t \t\t\t Candidats à l'examen final (régime de trois ans) Candidates to Final Examination (S years System)\t\t\t Bédard.\tPierre .\t31\tQuébec.\t\t\t Candidats pour l'admission à l'Étude du Droit Candidates for the Admission to the Study of Law\t\t\t \tGérard.\t30\tEast Brought on.Collège de St.Laurent.\t\t\t Québec, le 3 décembre 1954.\u2014 Quebec, December 3rd, 1954.Le Secrétaire du Barreau de Québec, ANDRÉ GAGNON, 38810-o Secretary of Quebec Bar. 3744 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1951, Tome 86, N° 50 BARREAU DE MONTRÉAL \u2014 BAR OF MONTREAL Candidats à l'examen de décembre 1954 Candidates to the examination of December 1954 Noms\tPrénoms\t\tRésidence _\t_\tAge\t_ ' Names\tSurnames\t\tResidence Examen final (4c année) Final Examination (4th year) 1.Cadette.2.Caumartin 3.Cutler.4.Dumaine.5.Fiske.0.Grafftey.7.LeBcl____ 8.Marcotte.9.Martial.10.Spector.Clémentaine Jean.Philip.Michel.Clarence., Wm Howard Gabriclle Léo-C.Jean-A.Seymour.33\tMontréal.24\tMontréal.35\tMontréal.23\tMontréal.32\tMontréal.26\tMontréal.25\tMontréal.24\tMontréal.30\tMontréal.25\tMontréal.Examens théorique et pratique (Se et Ac année) Theoretical and Practical Examinations (3rd and Alh years) 1.Bertrand.2.Founder.3.Lahaise.4.Mateosco Jacques Bernard Georges Nicolas.Montréal.Montréal.Gamelin, Co.Laval.Montréal.Examen de reprise partielle (Ae année) Supplementary Examinations (4th year) 1.Adessky.2.Archambault 3.Bélanger.4.Bcllemare.5.Brunct.6.Cossette.7.Dorais.8.Favreau.9.Gamache.10.Gates.11.Gougeon.12.Lattimer.13.Mierzwinski.14.Miller.15.Pollack.10.Rosenhek.17.Salmon.18.Savoie.19.Surprenant.Irving L.J.-Louis.André.Jacques.Rhéal.Luc.Bernard.Denis.i., Gaston.Kenneth A.-F.Michel.E.-J.Alexander.William.Baruch B.Marvin.H.-C.Reginald André.20\tMontréal.25\tMontréal.27\tVille St-Laurent.26\tMontréal.30\tMontréal.26\tMontréal.25\tMontréal.25\tMontréal.31\tMontréal.25\tMontréal.28\tMontréal.26\tMontréal.29\tMontréal.27\tMontréal.25\tMontréal.25\tMontréal.25\tMontréal.25\tMontréal.26\tMontréal.Examen de reprise partielle théorique (3e an?iée) Theoretical Supplementary Examinations (3rd year)\t\t\t \t\t29 26 24\tMontréal.Montréal.Montréal.2.Hope.\tR.-A.\t\t \tLéo-C.\t\t \t\t\t Examen dc l'aiicien régime de trois ans Former Three-Year Examination\t\t\t \tJohn J.\t34 28\tMontréal.Montréal.\tAlan C.\t\t \t\t\t Examen dc reprise partielle (ancien régime de trois ans) Supplementary Examinations (Former three-years)\t\t\t 1.St-Pierre.\tLéo-A.\t32\tMontréal.\t\t\t Montréal, le 7 décembre 1954.\u2014 Montreal, December 7th, 1954.38810-o Le Secrétaire, ANDRÉ TESSIER, Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, Vol.86, No.60 3743 Liquidation, avis de: Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des membres du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire Desjardins de Lau-nay\", tenue à Launay, le 24 octobre 1954, une résolution a été adoptée, à l'effet que les affaires de ladite société soient liquidées volontairement, et que celle-ci soit dissoute, conformément aux dispositions de la Loi des syndicats coopératifs de Québec et de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, et que MM.Joseph Brochu, Georges Boucher et Gérald Rheault ont été nommés liquidateurs.Donné au'bureau du Secrétaire dc la Province, le vingt-neuf novembre 1954.Le Sous-secrétaire de la Province, 38771-0 JEAN BRUCHÉSI.(P.G.6996-47) Avis est donné que, lors d'une assemblée des actionnaires de la compagnie \"L'Aréna de Sorcl Ltée\", tenue à Sorel, le 15 mars 1954, une résolution a été adoptée, à l'effet que les affaires de ladite compagnie soient liquidées volontairement et que celle-ci soit dissoute, conformément aux dispositions de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, S.R.Q., 1941, chapitre 278, et que MM.Hector Guèvremont, Roger Pontbriand et Paul Charbonneau ont nommés liquidateurs.Donné au bureau du Secrétaire dc la Province, le neuf décembre 1954.Le Sous-secrétaire dc la Province, 38815-o JEAN BRUCHÉSI.Nominations Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur, \"de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, et par commissions, de faire les nominations suivantes: Québec, le 3 novembre 1954.MM.Hervé Roux, marchand, et Léo Proulx, médecin, tous deux de Danville: commissaires pour tenir, avec MM.Bert J.Barlow, garagiste, Georges Letendre, médecin, et Gérard Gagnon, secrétaire-trésorier de la compagnie d'aqueduc de Danville, nommés antérieurement, et tous de Danville, la Cour des commissaires du canton de Shipton, dans le district électoral de Richmond.Québec, le 10 novembre 1954.MM.J.-Antonio Pelletier, C.R., de Québec, officier en loi au Ministère du Bicn-Etrc Social et de la Jeunesse, et Raoul Bourret, de Montréal, secrétaire des Écoles d'arts et métiers: commissaires \"per dedimus potestatem\".38761-o Sièges sociaux (P.G.50271-53) Périni Québec Inc.Règlement N° 7 \"Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme règlement N° 7 de la compagnie que: Winding up Notices: Notice is hereby given that, at a special general meeting of the members of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire Desjardins de Launay\", held at Launay on October 24th, 1954, a resolution was adopted to the effect that the affairs of the said association be voluntarily wound-up and that the latter be dissolved, pursuant to the provisions of the Quebec Cooperative Syndicates' Act and of the Winding-up Act and that Messrs.Joseph Brochu, Georges Boucher and Gerald Rheault have been appointed liquidators.Given at the office of the Provincial Secretary, the twenty-ninth day of November, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38771 Under Secretary of the Province.(A.G.6996-47) Notice is given that at a meeting of the shareholders of the Company \"L'Aréna de Sorel Ltée\", held at Sorel, on March 15th, 1954, a resolution was adopted to the effect that the affairs of the said company be voluntarily liquidated, and that the latter be dissolved, pursuant to the provisions of the Winding-up Act, R.S.Q., 1941, chapter 278, and that Messrs.Hector Guèvremont, Roger Pontbriand and Paul Charbonneau were appointed liquidators.Given at the office of the Provincial Secretary on December ninth, 1954.JEAN BRUCHÉSI, 38815 Under Secretary of the Province.Appointements His Honour, the Lieutenant-Governor, with the advice and consent of the Executive Council, «and by Commission, has been pleased to make the following appointments: Quebec, November 3rd, 1954.Messrs.Hervé Roux, merchant, and Léo Proulx, physician, both of Danville: Commissioners to hold, with Messrs.Bert.J.Barlow, garage-keeper, Georges Lctendre, physician, and Gérard Chagnon, Secretary-Treasurer of the waterworks company of Danville, previously appointed, and all of Danville, the Commissioners Court of the Township of Shipton, in the electoral district of Richmond.\u2022 Quebec, November 10th, 1954.Messrs.J.-Antonio Pelletier, Q.C., of Quebec, legal officer for Youth and Social Welfare Department, and Raoul Bourret, of Montreal, Secretary of Arts and Trades Schools: Commissioners \"per dedimus potestatem\".38761 Head Offices (A.G.50271-53) Périni Quebec Inc.By-law No.7 \"Be it enacted and it is hereby enacted as by-law No.7 of the company that: 3746 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 80, N° 60 La situation du siège social tie la compagnie soit et il est, par les présentes, transporté de 65 rue Ste-Annc en la cité de Québec, à 1510 rue Drummond, en la cité de Montréal, province dc Québec.\" Décrété, ce lie jour dc septembre 1954.Certifie vraie copie.Le Secrétaire, 38706-x CAMIL NOEL.(P.O.9033-50) british Coal Corporation Avis dc changement d'adresse du siège social Avis est donné que la compagnie \"British Coal Corporation\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 8 avril 1929 dont le siège social était situé jusqu'à ce jour à 83 rue Dalhousie, Québec.P.Q., l'a transporté à 5250 avenue Western, Montréal, P.Q.A compter de la date de cet avis, le dernier bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, P.Q., le 10 novembre 1954.Le Secret a i rc-t résor ier, 38772 C.W.COULSON.Derby Development Corporation Avis est, par les présentes, donné que la compagnie \"Derby Development Corporation\", constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la lioi des compagnies de Québec, le 14 mai 1954, et ayant son siège social en la cité de Montréal, province dc Québec, a établi son siège social à 6268 chemin Côte des Neiges, en ladite cité.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant le siège social de la compagnie.Daté à Montréal, P.Q., ce 4e jour de juin 1954.Le Président, 38773 EZRA SHAH MOON.AVIS D'ADRESSE Avis est donné que la compagnie \"Eastern Townships Terrazzo Tile Marble Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 18 novembre 1954 et ayant son bureau principal dans la ville de Sherbrooke, district de St-François, a établi son bureau au numéro 111 ouest, rue King.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré connue étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce lOièmc jour de novembre 1954.Le Président.38774-o THÉODORE-A.PIZZAGALLI.(P.G.10283-54) Inox Ltée \u2014 Inox Ltd Avis est par la présente donné que \"Inox Ltée \u2014 Inox Ltd\", corporation légalement constituée par lettres patentes en vertu de la Loi des compagnies dc Québec le 8ièine jour de février 1954, ayant son siège social à Montréal, district de Montréal, où ses bureaux étaient situés, jusqu'à ce jour, au numéro 5268 de l'avenue Clanranald, a maintenant son siège social au The location of the head office of the company be and the same is hereby changed from 65 Stc-Anne street in the city of Quebec, to 1510, Drummond street, in the city of Montreal, in the Province of Quebec.\" Enacted this, 11th day of September 1954.Certified true copy.CAMIL NOËL, 38706-x-o Secretary.(A.G.9033-50) British Coal Corporation Notice of change in address of Head Office Notice is hereby given that the \"British Coal Corporation\", incorporated by letters patent on the 8th day of April, 1929, whose Head Office was situated up to to-day at 83 Dalhousie Street.Quebec, P.Q., has moved it to 5250 Western Avenue.Montreal.P.Q.From and after the date of this notice, the latter office shall be considered by the company as being the Head Office of the company.Dated at Montreal, P.Q., this 10th day of November, 1954.C.W.COULSON, 38772-0 Secretary -Trcasu rcr.Derby Development Corporation Notice is hereby given that \"Derby Development Corporation,\" incorporated by letters patent issued under the provisions of Part I of the Quebec Companies' Act, op May 14th, 1954, and having its head office in the city of Montreal in the Province of Quebec, has established its Head Office at 6268 Côte des Neiges Road, in the said city.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the Head Office of the company.Dated at Montreal, P.Q., this 4th day of June, 1954.EZRA SHAHMOON.38773-0 President.NOTICE OF ADDRESS Notice is hereby given that \"Eastern Townships Terrazzo Tile Marble Ltd.\", company constituted in corporation by letters patent on November 18th, 1954 and having its head office in the town of Sherbrooke, district of St.François, has established its office at 111 King Street West.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 19th day of November, 1954.TH ÉODORE-A.PIZZAGALLI, 38774-o President.(A.G.10283-54) Inox Ltée \u2014 Inox Ltd Notice is hereby given that \"Inox Ltée \u2014 Inox Ltd\", company incorporated by letters patent under the Quebec Companies' Act, on February the 8th, 1954, and having its head office in Montreal, district of Montreal, where its office was situated, up to today, at 5268 Clanranald Avenue, has moved it to 60 St.James Street West, Room 902, city of Montreal, district of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 195Jh I ol.80, No.50 3747 numéro 60 ouest, rue Saint-Jacques, Chambre 902, cité de Montréal, district «le Montréal.Montréal, ce 2 décembre 1954.(Sceau) \"Inox Ltkk \u2014 Inox Ltd\", Par le Secrétaire-trésorier.38810-o RAYMOND LETTE.(P.G.14470-53) Sadam Co.Ltd Avis est par la présente donné que \"Sadam Co.Ltd\", corporation légalement constituée par lettres patentes en vertu de la I/oi des compagnies de Québec le Oième jour dc juillet 1953, ayant son siège social à Montréal, district de Montréal, où ses bureaux étaient situés, jusqu'à ce jour, au numéro 5268 de l'avenue Clanranald, a maintenant son siège social au numéro 60 ouest, rue Saint-Jacques, chambre 902, cité de Montréal, district de Montréal.Montréal, ce 2 décembre 1954.(Sceau) Sadam Co.Ltd, Par le Secrétaire-trésorier.3881 l-o RAYMOND LETTE.Montreal.Montreal, this 2nd dav of December, 1954.(Seal) \"Inox Ltkk \u2014 Inox Ltd\", per: RAYMOND LETTE, 38810-o Secretary-Treasurer.(A.G.14470-53) Sadam Co.Ltd Notice is hereby given that \"Sadam Co.Ltd\", company incorporated by letters patent under the Quebec Companies' Act on July the 6th 1953, and having its head office in Montreal, district of Montreal, where its office was situated up to today at 5268 Clanranald Avenue, has moved it to 60 St.James Street West, Room 902, city of Montreal, district of Montreal.Montreal, this 2nd dav of December, 1954.(Seal) Sadam Co.Ltd.per: RAYMOND LETTE, 38S11 -o Secretary-Treasurer.Ventes \u2014 Loi de faillite Canada \u2014 province de Québec, district dc Québec.Cour Supérieure.En matière dc Faillite.Dans l'affaire de la faillite de: Emile Tremblay lequel fait affaires seul sous la raison sociale de \"Equitable Shoe Iteg'd Les Saules, Québec, débiteur.AVIS DE VENTE A L'ENCAN Avis est par les présentes donné que M ERC H E-DI.le VINGT-NEUVIÈME jour de DÉCEMBRE.1954.à ONZE heures a.m.sera vendu par encan public à la porte de l'Église paroissiale, à Sainte-Monique Les Saules, Québec, l'immeuble ci-après décrit, savoir: Item A: Un terrain ou emplacement connu et désigné comme étant les lots numéros dix et onze, subdivisions du lot originaire un (1-10 & 11) du cadastre officiel de la paroisse de L'Ancienne-Lorettc, comté de Québec, avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Cet item sera vendu au plus haut et donner enchérisseur, à charge des rentes et autres servitudes qui peuvent exister.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux syndics soussignés.Cette vente est faite conformément aux articles 716, 717 et 719A du C.P.C.et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite 1949; cette vente équivaut à la vente par le Shérif.Le tout suivant jugement rendu par l'Honorable Tribunal des Faillites, pour le district de Québec.Conditions dc paiement: argent comptant.' Québec, le 20 novembre, 1954.Les Syndics, R.ERNEST LEFAIVRE, JOSEPH MARMETTE & RENÉ LEFAIVRE.111 Côte de la Montagne, Québec, Que.38682-48-2-0 Canada, province de Québec, district de Chicoutimi, N° 466-B, Cour Supérieure.En matière de faillite.Dans l'affaire de la faillite de Raoul Plourde, contracteur, 91 Sir Wilfrid Laurier, Jonquière.Québec, débiteur; Sales \u2014 Hankrupcy Act Canada, Province of Quebec, district of Quebec, Superior Court (Sitting in Bankruptcy).In the matter of Emile Tremblay, c.-'.rrying on business alone under the style of \"Equitable Shoe Rcg'd \u2014 Les Saules, Que.debtor.NOTICE OF AUCTION SALE Notice is hercbv given that WEDNESDAY, on the TWENTY-NINTH day of DECEMBER, 1951, at ELEVEN o'clock in the morning, there will be sold, by public auction, at the door of the parochial church of Sainte-Monique Les Saules, Que., the immoveable hereinafter described, to wit: Item A: A lot of hind or emplacement known and designated as being lots numbers ten and eleven, subdivisions or original lot one (1-10 & 11) of the official cadastre of the parish of An-cienne-Lorette, county of Quebec, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.This item shall be put up for sale and adjudged to the last and highest bidder, subject to any rents which may be a charge thereon.Titles and certificates may be examined at all times at the offices of the undersigned.This sale is made pursuant to articles 716, 717 and 719A of the ('.CP.and also of section 55 of the Bankruptcy Act 1949; this sale is to have the effect of a Sheriff's sale.All of which in accordance with a judgment rendered by the Honourable Bankruptcy Court.Conditions of payment: cash.Quebec.November 20th, 1954.R.ERNEST LEFAIVRE.JOSEPH MARMETTE.& RENÉ LEFAIVRE, Trustees.lllMountain Hill, Quebec, Que.38682-48-2 Canada.Province of Quebec, district of Chicoutimi Superior Court, No.466-B.(Sitting in Bankruptcy).In the matter of Raoul Plourde, contractor 91.Sir Wilfrid Laurier, Jonquière, Quebec, debtor; 3748 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1954, Tome 86, N° 50 AVIS DE VENTE À L'ENCAN Avis est par les présentes donné que MERCREDI, le DOUZE JANVIER 1955, à DEUX heures p.m., sera vendu par encan public, à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Gerogcs, en la ville de Jonquière, l'immeuble comme suit: Iten A: Un certain morceau de terrain, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Jonquière, comme formant partie du lot N° douze (P.N° 12) dans le rang quatre (rg.IV) dudit canton, lequel terrain mesure cent cinquante pieds dc profondeur du sud au nord sur une largeur de cent quatre-vingts pieds de l'est à l'ouest et est compris dans les bornes et limites suivantes: au nord par la ligne limitative sud de l'ancienne route régionale Jonquièrc-Larouchc, ver l'est par laligne latérale ouest du lot cadastral numéro treize des dits rang et canton et des deux autres côtés sud et ouest par le résidu dudit lot dont il forme partie, propriété du vendeur, le tout avec la maison à logements dessus construite avec appartenances et dépendances et tel que se trouve présentement.» Cet item sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes qui peuvent exister.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux des syndics soussignés.Cette vente est faite conformément aux articles 716, 717 et 719A du Code de procédure civil et aussi à l'article 55 de la Loi de faillite 1949.Cette vente équivaut à la vente faite par le shérif et faite conformément au jugement rendu par Me Léonidas Gagné, Régistraire des des faillites.Conditions de paiement: comptant.Québec, ce 4 décembre 1954.Les Syndics, JOSEPH MARMETTE & RENÉ LEFAIVRE.111, Côté de la Montagne, Québec 38785-50-2-cr NOTICE OF AUCTION SALE Notice is hereby given that: WEDNESDAY, JANUARY TWELFTH, 1955, at TWO o'clock p.m., shall be sold at public auction, at the church door of the parish of St-Georges, in the town of Jonquière, the following immoveable, as follows: Item A: A certain parcel of land, known and designed on the official plan and in the book of reference of the township of Jonquière, as forming part of lot No.twelve (P.No.12), in range four (rg.IV) of the said township, which land measures one hundred and fifty feet in depth from south to north upon a width of one hundred and eighty feet from east to west and is comprised within the following boundaries and limits: on the north, by the southern limit line of the old regional Jonquière-Larouche highway, on the east by the lateral line west of cadastral lot number thirteen of the said range and township and of the two other sides south and west by the residue of the said lot of which they form part, property of the seller, the whole with tenement house thereon erected, with appurtenances and dependencies and as it now stands.This item shall be put up for sale and adjudged to the last and highest bidder, subject to any rents which may be a charge thereon.Titles and certificates may be examined at all times at the offices of the undersigned trustees.This sale is made pursuant to articles 716, 717 and 719A of the Code of civil procedure and also of section 55 of the Bankruptcy Act 1949.This sale will have the effect of a Sheriff's sale, and shall be made in conformity with a judgment rendered by Me Léonidas Gagné, Registrar for bankruptcies.Conditions of payment: cash.Quebec, December 4th, 1954.JOSEPH MARMETTE & RENÉ LEFAIVRE, Trustees.Ill Mountain Hill, Quebec.38785-50-2 Canada, province de Québec, district de Chicoutimi, Cour Supérieure.En matière de faillite.Dans l'affaire de faillite de: Raoul Plourde, contracteur, 91, rue Sir Wilfrid Laurier, Jonquière, Québec, débiteur.AVIS DE VENTE À L'ENCAN Avis est par les présentes donné que: MERCREDI, le DOUZE JANVIER, 1955, à ONZE heures a.m., sera vendu par encan public, à la porte de l'église paroissiale de St-Dominique dc Jonquière, l'immeuble suivant, savoir: Iten A: Un lopin de terre ou emplacement connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Jonquière, comme formant partie des lots numéros vingt-trois-A-cent vingt-cinq et vingt-trois-A-cent-vingt-quatre (Pt.Nos 23-A-125 & 23-A-124), dans le rang quatre (Rg.IV) du dit canton, lequel terrain mesure cinquante pieds (50') dc largeur du sud au nord sur une profondeur de quatre-vingt pieds (80') de l'est à l'ouest et peut être plus particulièrement décrit comme suit: a) Toute cette partie dudit lot numéro vingt-trois-A-cent vingt-cinq (Pt.N° 23-A-125) mesurant cinquante pieds (50') de largeur du sud au nord sur une profondeur de quarante pieds (40') de l'est à l'ouest et est borné au non! par Canada, Province of Quebec, district of Chicoutimi, Superior Court.(Sitting in bankruptcy).In the mater of Raoul Plourde, contractor, 91 Sir Laurier Street, Jonquière, Quebec, debtor.NOTICE OF AUCTION SALE Notice is hereby given that: WEDNESDAY, on JANUARY TWELFTH, 1955, et ELEVEN o'clock a.m., shall be sold by public auction, at the parochial church door of St-Dominique de Jonquière, the following immovable, to wit: Item A: A strip of land or emplacement known and designated on the official plan and in the book of reference of the official cadastre of the township of Jonquière, as forming part of lots numbers twenty-three-A-one hundred and twenty-five and twent.y-thrce-A-one hundred and twenty-four (P.Nos 23-A-123 &23-A-124) in range four (rg.IV) of the said township, which land measures fifty feet (50') in width from the south to the north upon a depth of eighty feet (80') from East and west and may be more particularly described as follows: a) All that part of said lot number twenty-three-A-one hundred and twenty-five (P.No.23-A-125) measuring fifty feet (50') in width from south to north upon a depth of forty feet (40') from east to west and is bounded on the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 195A, I ol.86, No.50 3749 le lot cadastral numéro vingt-trois-A-ccnt vingt (23-A-120) desdits rang et canton, propriété de M.Joseph Levesque, au sud par le résidu dudit lot dont elle forme partie, propriété de M.J.Wellie Gagnon ou représentants, à l'est par le terrain ci-après décrit au paragraphe, b) ci-après et à l'ouest par l'avenue Laurier; et b) Toute Cette partie dudit lot numéro vingt-trois-A-cent vingt-quatre (Pt.N° 23-A-124) mesurant cinquante pieds (50') de largeur du sud au nord sur une profondeur de quarante fpieds (40') de l'est à l'ouest, et est borné au nord par le lot cadastral numéro vingt-trois-A-cent vingt (23-A-120) desdits rang et canton, propriété de M.Joseph Levesque au sud par le résidu dudit lot dont elle forme partie propriété de M.J.Wellie Gagnon ou représentants, à l'est par le lot cadastral numéro vingt-trois-A-cent vingt-trois (23-A-123) desdits rang et canton, et à l'ouest par le terrain ci-dessus décrit au paragraphe a) ci-dessus: Le tout avec bâtisses, circonstances et dépendances.\u2022 Cet item sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur à charge des rentes et servitudes qui peuvent exister.Les titres et certificats peuvent être examinés en tout temps en s'adressant aux bureaux des syndics soussignés.Cette vente est faite conformément aux articles 716, 717 et 719A du Code de procédure civil et aussi à l'article 55 de la Loi de faillite 1949.Cette vente équivaut à la vente faite par le shérif et faite conformément au jugement rendu par Me.Léonidas Gagné, régis-traire des faillites.Conditions de paiement: comptant.Québec, ce 4 décembre 1954.Les Syndics, JOSEPH MARMETTE, & RENÉ LEFAIVRE.111 Côte de la Montagne, Québec.38785-50-2-o north by cadastral lot number twenty-three-A-one hundred and twenty (23-A-120) of the said range and township, property of Mr.Joseph Levesque, on the south by the residue of the said lot of which it forms part, property of Mr.J.Wellie Gagnon or representatives, on the east, by the land hereinafter described at paragraph b) hereinafter and on the west by Laurier avenue; and b) All that part of said lot number twenty-three-A-one hundred and twenty-four (P.No.23-A-124) measuring fifty feet (50') in width from south to north upon a depth of forty feet (40') from east to west, and is bounded on the north by cadastral lot number twenty-three-A-one hundred and twenty (23-A-120) of the said range and township, property of Mr.Joseph Levesque on the south by the residue of the said lot of which it forms part of the property of Mr.J.Wellie Gagnon or representatives, on the east, by cadastral lot number twenty-three-A-one hundred and twenty-three (23-A-123) of the said range and township, and on the west, by the land hereinabove described at para-graphd a) hereinabove: The whole with buildings, circumstances and dependencies.This item shall be put up for sale and adjudged to the last and highest bidder, subject to any rents which may have a charge thereon.Titles and certificates may be examined at all times at the offices of the undersigned trustees.This sale is made pursuant to articles 716, 717 and 719A of the Code of civil procedure and also of section 55 of the Bankruptcy Act 1949.This sale will have the effect of a Sheriff's sale and shall be made in conformity with a judgment rendered by Me Léonidas Gagné, Registrar for bankruptcies.Condition of payment: cash.Quebec, December 4th, 1954.JOSEPH MARMETTE & RENÉ LEFAIVRE, Trustees.Ill Mountain Hill, Quebec.38785-50-2 Ventes pour taxes Sales for Taxes Province de Québec Province of Quebec Corporation de la ville d'Acton-Vale Municipality op the town of Acton-vale (comté de Gagot) (county of Bagot) Avis public est par le présent donné par le Public notice is hereby given by the under- soussigné secrétaire-trésorier de la Corporation signed, Secretary-Treasurer of the municipal Municipale de la ville d'Acton-Vale, que la pro- corporation of the town of Acton-Vale, that priété ci-dessous désignée, sera vendue à l'en- the property hereinunder described, shall be chère, au bureau du soussigné à l'hôtel de ville sold by public auction, at the office of the under- d'Acton-Vale, le LUNDI DIX JANVIER, 1955, signed, at thé City Hall of Acton-Vale, MON- à DIX heures de l'avant midi, pour satisfaire au DAY, the TENTH day of JANUARY 1955, at paiement des taxes municipales et scolaires, TEN o'clock in the forenoon, in payment ¦ of avec intérêts, plus les frais encourus subséquem- municipal and school taxes due, with interest, ment, à moins que ces taxes, intérêts, et dépenses plus costs subsequently incurred, unless said ne soient payé avant la vente.taxes, interest, and expenditures are paid prior to the sale.1° Comme appartenant à la succession Char- 1.As belonging to the Charbonneau estate: bonneau: le lot deux cent vingt et un (221) et la the whole of lot number two hundred and twenty - partie du lot deux cent vingt-deux (P.222) du one (221) and a part of lot two hundred and plan et livre de renvoi officiel du village d'Acton- twenty-two (P.222) of the official plan and book Vale, avec maison et autre bâtisses dessus éri- of reference for the village of Acton-Vale, with gées.buildings erected thereon.a) Lot numéro deux cent vingt et un (221) a) Lot number two hundred and twenty- du plan et livre de renvoi officiel du village one (221) of the official plan and book of reference d'Acton-Vale, plus particulièrement décrite et of the village of Acton-Vale, more particularly 3750 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 1964, Tome 86, N° 60 bornée comme suit: borné au sud par la rue Lemay, au nord par la \"Moose River\", à l'est par le N° 220 et à l'ouest par le N° 222; ayant environ cinquante huit pieds sur cinquante-trois pieds, formant trois mille soixante-quatorze pieds anglais en superficie (3074).b) Partie du lot deux cent vingt-deux (P.222) du plan et livre dc renvoi officiel du village d'Acton-Vale, plus particulièrement décrite et bornée comme suit: une lisière de (terrain de cinquante pieds de largeur, borné au sud par la rue Lemay, au nord par la \"Moose River\", à l'est par le N° 221 et à l'ouest par le résidu du lot N° 222.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble, et sujette a»: droit de retrait.Cet avis remplace les autres avis annulés et publiés dans les journaux français et anglais et dans la Gazt tte Officielle de Québec.Donné à Acton-Vale, P.Q., ce trentième jour du mois de novembre dc l'an mil neuf cent cinquante-quatre.Le Secrétaire-trésorier, 38732-49-2-0 FERNAND MÉNARD.Province de Québec Ville de Lennoxville described and bounded as follows: to the south by Lemay Street, northerly by Moose River, easterly by No.220 and westerly by No.222; containing son e fifty-eight feet by fifty-three covering an area of three tousand and seventy-four feet, English measure (3074).b) Part of lot number two hundred and twenty-two (P.222) of the official plan and book of reference for- the village of Acton-Vale, more particularly described and bounded as follows: a piece of land of fifty (50) feet width, bounded to the south by Lemay Street, northerly bu Moose River, easterly by No.221 and westerly by the residue of lot No.222.Moreover the said sale shall be made with all active and passive servitudes, both apparent and unapparcnt, attaching thereto, and subject to right of redemption.This notice replaces the others cancelled and published in French and English newspapers and also in the Quebec Official Gazette.Given at Acton-Vale, P.Q., this thirtieth day of November, one thousand one hundred and fifty-four.FERNAND MÉNARD, 38732-49-2-o Secretary-Treasurer.Province of Quebec Town of Lennoxville Avis public est par les présentes donné que les immeubles ci-dessous désignés, seront vendus à l'enchère publique, a DIX heures de Pavant-midi (heures normale), le MARDI, VINGT-HUIT DÉCEMBRE, mil neuf cent cinquante-quatre, (28 décembre, 1954) à l'hôtel de ville, Lennoxville, Que.pour satisfaire au paiement des taxes municipales, générales et spéciales, taxes scolaires, des intérêts et des frais encourus à moins que ces taxes, frais et intérêts ne soient réglés avant la vente.Public notice is hereby given that the immoveable properties hereinafter describee, will be sold by Public Auction at the Town Hall, town of Lennoxville, on TUESDAY, DECEMBER TWENTY-EIGHT, nineteen hundred and fifty-four.(December 28th, 1954) at TEN o'clock in the morning (Standard Time) for the payment of general and special municipal taxes, school taxes and interest, as given below, and the costs which may be subsequently incurred, unless before that date, the said taxes, interest and costs have been paid before the sale.Noms de propriétaires Names of proprietors Nos.de cadastre Cadastral numbers Taxes & Intérêts Taxée and Interesta Bennett, Mmc-Mrs.Gertrude .Bessette, David, Succ.-Estate.Bradley, J.A.Bradley, J.J.Chambcrland, Normand.Desruisseaux, Henri.Doyon, Aimé.Dufour, J.Elisée.Gagnon, Gérard.Harmer, Mmc-Mrs.Aleta.Mercier, Lillis.McLean, M.H.Nadeau, Robert.Faquin, Garage-Limitée-Limited Parkin, Mme-Mrs.Feme.Povey, James & Goergo T.Smith, E.C.St-Cyr, Gilles.St-Jean, Paul.Pt.187.\t$149\t01 Pt.383-3S4.\t24\t78 347 Pt.7.\t16\t52 273/22, 273/23 .\t45\t79 5/16.17.\t\t72 3G8/62.\t40\t57 5/107.114.\t2\t90 Pt.377 .\t22\t90 5/56/58, 60/65, 95/98.\t4\t33 Pt.183.\t109\t30 2, 21/24 4, 21/32 5, 56/58 61/65\t\t 68/76 83/98 101/104 - 14, 1/6 15/18 15, 1/5 5 non subdivisé-unsubdivided.Pt.331.5/67.\u2022.Pt.382 .P.221, 222, 223, 224 .299/95.96 P.299 .356/75.76.14/8.418.43.40 139.10 1.45 94.19 379.00 144.73 135.79 2.90 105.41 Les immeubles ci-haut mentionnés sont au plan et livre de renvoie du village (maintenant ville) de Lennoxville et situés dans la ville de Lennoxville.Termes; Argent comptant ou chèque visé.Donné à la ville de Lennoxville le vingt-neuf novembre 1954.Le Secrétaire-trésorier, 38754-49-2-0 W.R.BAKER.The above immoveables are all on the plan and book of reference of the village (now town) of Lennoxville and are situated in the town of Lennoxville.Terms; Cash or accepted cheque.Given at Lennoxville this twenty-ninth day of November, 1954.W.R.BAKER, 38754-49-2-0 Secretary-Treasurer. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1964, Vol.80, No.60 3751 Province de Québec Ville de Pointe-Claire Avis public est pur les présentes donné, que les immeubles ci-dessous désignés, seront vendus à l'enchère publique, à DIX heures dc Pavant-midi, (heure normale), le LUNDI VINGT-SEPT DÉCEMBRE, mil neuf cent cinquante-quatre (27 décembre, 105*1) en la Salle de l'Hôtel de Ville, Peinte-Claire, P.Q., pour satisfaire' au paiement des taxes municipales, générales et spéciales, taxes scolaires, des intérêts et des frais encourus, à moins que ces taxes, frais et intérêts ne soient réglés avant la* vente au Bureau du Secrétaire-Trésorier de la Ville, 293 Bord du Lac, Pointe-Claire, P.Q.Province of Quebec Town of Pointe-Claire Public notice is hereby given that the immoveable properties hereinafter described, will be sold by Public Auction at the Town Hall, Town of Pointe Cl.dre, on MONDAY, DECEMBER TWENTY-SEVENTH, Nineteen Hundred and fifty-four (December 27th, 1954) at TEN o'clock in the morning (Standard Time), for the payment of general and special municipal taxes, school taxes and interest, as given below, and the costs which may be subsequently incurred, unless before that date, the said taxes, interest and costs have been paid for at the Office of the Sec.-Treas.of the Town, 293 Lakeshorc Road, Pointc-Cluire, P.Q.Cadastre de la paroisse de Pointe-Claire \u2014 Cadastre of the parish of Pointe-Claire Noms des propriétaires\tNos.de cadastre\tTaxes & intérêts Names of proprietors\tCadastral numbers\tTaxes and Interests Ewing, S.W.& G.B.\tP.50-30 .\t$164.46 Un lot irrégulier contenant une superficie de cinq Of irregular figure containing an area of five thou- mille soixante-treize pieds carrés et cinq dixième sand and seventy-three square feet and five tenths (5,073.5), mesure anglaise, et étant la plus grande of a square foot (5.073.5) english measure and being partie du lot originaire qui est situé du côté ouest de the greater part of the original lot which is situated on l'Avenue Hillside, immédiatement au sud du Boulevard the western side of Hillside Avenue immediately south Métropolitain.of the Metropolitan Boulevard.Ewing, S.W.& G.B.I P.50-37 .| 36.22 Un lot triangulaire contenant une superficie de deux Of triangular figure containing an area of two hundred cent quatre-vingt-onze pieds carrés et neuf dixième and ninety-one square feet and nine tenths of a square (291.9), mesure anglaise, et étant le coin sud-est du lot foot (291.9) english measure, and being the south originaire qui est situé a l'ouest de l'Avenue Hillside, eastern corner of the original lot which is situated an immédiatement au sud du boulcvnrd Métropolitain, the western side of Hillside Avenue, immediately south of the Metropolitan Boulevard.Ewing, S.W.& G.B.I ' P.50-53 .| 24.11 Un lot triangulaire contenant une superficie de quatre Of triangular figure containing an area of four hun« cent soixante-dix-sept pieds carrés et deux dixième dred and sevcntycseven square feet and two tenths of a (477.2), mesure anglaise, étant le lot do coin su-est du square foot (477.2) English measure and being the lot originaire qui est situé sur la partie est dc l'Avenue south eastern corner of the original lot which is sitated Hillside, immédiatement au sud du boulevard Métropo- on the eastern side of Hillside Avenue immediately litain.south of the Metropolitan Boulevard.Ewing, 8.W.4G.B.I P.50-54 .\u201e.| 88.71 Un lot irrégulier contenant une superficie de quatre Of irregular figure containing an area of four thousand mille six cent trente-sept pieds carrés et deux dixième, six hundred and thirty seven square feet and two tenths (4.637.2), mesure anglaise, étant la plus grande partie of a square foot (4.037.2) english measure and being the du lot originaire qui est situé sur le côté est de l'avenue greater part of the original lot which is sittuated on the Hillside, immédiatement au sud du boulevard Métro- eastern side of Hillside Avenue, immediately south of politain.the Metropolitan Boulevard.Ewing.S.W.& G.B.I P.50-106 .1 13.20 Un lot do forme trapèze contenant une superficie do Of trapezoidal figure containing an area of two thou-deux mille sept cent neuf pieds carrés et six dixième, sand seven hundred and nine square feet and six tenths (2.709.6), mesure anglaise, et étant la partie sud du lot of a square foot (2.709.6) english measure and being the originaire situé sur le côté ouest do l'avenue Hillcrest et southern section of the original lot which is situated on immédiatement au sud du boulevard Métropolitain.the western side of Hillcrest Avenue and immediately south of the Metropolitan Boulevard.Ewing, S.W.4G.B.I P.50-119.| 7.34 Un lot de forme trapèze contenant une supreficie de Of trapezoidal figure containing an area of two thou- deux mille huit cent quarante-quatre pieds carrés et sand eight hundred and forty-four square feet and three trois dixième (2.844.3), mesure anglaise, et étant la tenths of a square foot (2.844.3) english measure and partie nord du lot originaire qui est situé sur le côté being the northern section of the original lot which is est de l'avenue Hillcrest et immédiatement au nord du situated on the eastern side of Hillcrest Avenue and im- boulcvard Métropolitain.mediately north of the Metropolitan Boulevard.Ewing, S.W.& G.B.I P.50-122 .1 8.07 Un lot de forme trapèze contenant une superficie Of trapezoidal figure containing an area of one thou-de mille sept cent vingt-neuf pieds carrés et quatre sand, seven hundred and twenty nine square feet and dixièmo (1.729.4), mesure anglaise, et étant la partie four tenths of a square foot (1.729.4), english measure sud du lot originaire qui est situé sur le côté est do l'ave- and being the southern section of the original lot which nuo Hillcrest, et immédiatement au sud du boulevard is on the eastern side of Hillcrest Avenue and immédiat-Métropolitain, ely south of the Metropolitan Boulevard.Autorisation pour l'énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles ci-dessus mentionnés, a dûment été obtenue.Donné en la ville de Pointe-Claire, ce 1er jour de décembre 1954.Le Secrétaire-trésorier, 38755-49-2-0 (Signé) R.LABROSSE.Authorization for abridged enumeration of the Cadastral numbers of the above mentioned immoveables has been duly obtained.Given at the Town of Pointe-Claire, this 1st day of December, 1954.(Signed) R.LABROSSE, 38755-49-2-0 Secretary-Treasurer. 3752 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 195A, Tome 86, N° 50 VENTES PAR SHERIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnes plus bas.ABITIBI Canada \u2014 Province de Québec District de Rouyn-Noranda Cour Supérieure, (pARAGE THIBAULT N° 3222 < vJ LTÉE, corporation lé-v gaiement constitué, ayant son siège social et place d'affaire à Rouyn, district de Rouyn-Noranda; demander, vs PIERRE ST-GELAIS, domicilié à Launay, district d'Abitibi, défendeur.AVIS DE VENTE Un emplacement portant le numéro trente et un C (31-C) du rang cinq (5) et les droits acquis sur le lot numéro dix-huit (18) du rang six (6) tous deux du cadastre officiel du canton Launay, avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Launay.le MERCREDI VINGT-DEUX (22) DÉCEMBRE 1954 a ONZE (11) heures de l'avant-midi.Le Shérif Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos, le 15 novembre 1954.38604-47-2-o ABITIBI Province dc Québec \u2014 District d'Abitibi Cour Supérieure, ( T\"*\\AME MARTINE AYOT-N° V-2634.< *J TE D U M O N TI* R, (.ménagère de la ville de Malaisie, épouse séparée de biens de Armand Dumontier, et ce dernier, du même endroit pour assister son épouse; saisissant vs DAME BRO-NIS LISS TOMKYVICH, fille majeure usant de ses droits, autrefois de la ville de Malartic, district d'Abitibi, et maintenant de lieux inconnus; saisi.AVIS DE VENTE Un emplacement situé dans la ville de Malartic, connu et désigné comme étant le lot numéro seize (16) de la subdivision du bloc deux (2) \u2014 (2-16) canton Fournière avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte dc l'église de Malartic le SAMEDI QUINZE JANVIER 1955 à DEUX (2) heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos, le 4 décembre 1954.38789-50-2-o ARTHABASKA Fieri Fadas de Terris District D'Arthabaska Cour Supérieure, ( A LPHONSE GOUPIL, N° 9739 < bourgeois de Daveluy- ( ville, demandeur; vs J.RAYMOND DEMERS, agent d'immeubles de Victoriaville, défendeur.Un emplacement situé à Victoriaville à l'angle des rues St-Philippe et Notre-Dame-ouest, SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Canada \u2014 Province of Quebec District of Rouyn-Noranda Superior Court, (/PARAGE THIBAULT No.3232 < VJ LTÉE, legally incor-\\ porated corporation, having its head office and place of business at Rouyn, district of Rouyn-Noranda, plaintiff, vs PIERRE ST-GELAIS, domiciled at Launay, district of Abitibi; defendant.NOTICE OF SALE An emplacement bearing number thirty-one C (31-C) of range five (5) and the rights acquired upon lot number eighteen (18) of range six (6) both of the official cadastre of the township of Launay, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Launay on WEDNESDAY, DECEMBER TWENTY-SECOND (22nd) 1954, at ELEVEN (11) o'clock in the forenoon.FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, November 15th, 1954.38694-47-2 ABITIBI Province of Quebec \u2014 District of Abitibi Superior Court, ( TNAME MARTINE AYOT-No.V-2634.< -L/ TE, DUMONTIER, \\ housewife, of the town of Malartic, wife separate as to property of Armand Dumontier, and the latter of the same locality to assist his wife; Distrainer vs DAME LISS TOMKYVICH, fille majeure making use of her rights, formerly of the town of Malartic, district of Abitibi.and now of unknown whereabouts: distraine.NOTICE OF SALE An emplacement situate in the town of Malartic, known and designated as being lot number sixteen (16) of subdivision of block two (2) \u2014 (2-16) Fournière township with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold at the church door of Malartic, SATURDAY, the FIFTEENTH day of JANUARY 1955 at TWO (2) o'clock in the afternoon.FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, December 4th, 1954.38789-59-2 ARTHABASKA Fieri Facias de Terris District of Arthabaska Superior Court, /-ALPHONSE GOUPIL, No.9739 < gentlemen of Daveluy- ( ville, plaintiff, vs J.RAYMOND DEMERS, Real estate agent of Victo-riaville, defendant.An emplacement situate at Victoriaville at the street angle of St-Philippe and Notre-Dame- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, Ï95L Vol.8C>, No.50 3753 connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre revisé pour cette partie du canton d'Arthabaska, paroisse de Ste-Victoire, comme étant la subdivision cent un du lot originaire numéro quatre cent cinquante-quatre (454-101) avec toutes bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Ste-Victoire d'Arthabaska, le TREIZE JANVIER 1955, à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bueau du Shérif, FÉLIX HOULE.Athabaska, ce 4 décembre 1954.38782-50-2-O O BEAUHARNOIS Fieri Facias de Bonis et dc Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure, / ADRIEN LEBOEUF, N° 1566 < vendeur, de la ville de \\ Huntingdon, dit district, demander, vs D.A.LANG, autrefois de ladite ville dc Huntingdon, et maintenant de lieux inconnus, défendeur.Saisùcomme appartenant au défendeur: \"Un emplacement situé en la ville de Huntingdon, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de ladite ville, comme faisant partie du lot numéro deux cent quatre-vingt-treize (Pt.293) borné comme suit: au nord par partie du lot N° 293 appartenant à W.T.Haraill, à l'est par partie du lot N° 293 appartenant à à W.T.Hamill, et à la succession R.L.Kelly, au sud par le lot N° 291 subdivision N° 15 et à l'ouest par la rue Henderson, avec bâtisses dessus construites.\" Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de la paroisse dc St-Joseph de Huntingdon, en la ville de Huntingdon, dit district de Beauharnois, MERCREDI, le VINGT-DEUXIÈME jour de DÉCEMBRE 1954, à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, (Signé) ERNEST POIRIER.Salaberry de Valleyfield, ce 15 novembre 1954.38605-47-2-O Province de Québec \u2014 District de Beauharnois Cour de Magistrat, ( T\\ A.BARRINGTON, N° 4334.< marchand, du village l de Ormstown dit district, demandeur; vs Les Héritiers de HENRY VAIL-LANCOURT, en son vivant, du même lieu, défendeurs.Saisi comme appartenant auxdits défendeurs: Un emplacement situé dans la paroisse St-Malachic de Ormstown, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de ladite paroisse, comme étant les lots numéros treize et quatorze de la subdivision officielle du lot originaire numéro soixante-huit (N° 68-13 et 14), avec les bâtisses dessus construites.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de St-Malachie d'Ormstown, comté de Châteauguay, district de Beauharnois, SAMEDI, le QUINZIÈME jour de JANVIER 1955 à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, ERNEST PODIIER.Salaberry de Valleyfield, ce 6 décembre 1954.38787-50-2-O west, known and designated on the official plan and in the book of reference of the revised cadastre for this part of the township of Arthabaska, parish of Ste-Victoire, as being the subdivision one hundred and one of the original lot number four hundred and fifty-four (454-101) with all buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold at the parochial church door of Ste-Victoire of Arthabaska, the THIRTEENTH day of JANUARY, 1955, at TWO o'clock in the afternoon.FÉLIX HOULE, Sheriff's Office, Sheriff.Arthabaska, this 4th December, 1954.38782-50-2 BEAUHARNOIS Fieri Facias dc Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec Superior Court, /-ADRIEN LEBOEUF, No.1566 < salesman, of the town I of Huntingdon, said district, plaintiff, vs D.A.LANG, formerly of said town of Huntingdon and now of unknown whereabouts, defendant.Seized as belonging to the defendant: \"An emplacement situate in the town of Huntingdon, known and designated on the official plan and book of reference of said town, as being part of lot number two hundred and ninety-three (P.293) bounded as follows: northerly by part of lot No.293 belonging to W.T.Ham-ill, easterly by part of lot No.293 belong to W.T.Hamill and the R.L.Kelly estate, southerly by lot No.291, subdivision No.15, and westerly by Henderson Street; with building erected thereon.\" To be sold at the parochial church door of the parish of St.Joseph de Huntingdon, in the town of Huntingdon, said district of Beauharnois, WEDNESDAY, the TWENTY-SECOND day of DECEMBER 1954, at ELEVENTH o'clock in the forenoon.(Signed) ERNEST POIRIER, Sheriff's Office, Sheriff.Salaberry de Valleyfield, this November 15th, 1954.38605-47-2 Province of Quebec \u2014 District of Beauharnois Magistrate's Court, ( T\"\\ A.BARRINGTON, No.4334.< -LA merchant, of the vil-\\ lage of Ormstown, said district, plaintiff; vs The Heirs of HENRY VAILLANCOURT, in his lifetime, of the same place, defendants.Seized as belonging to the defendants: An emplacement situate in the parish of St.Malachie of Ormstown, known and designated on the official plan and in the book of reference of the said parish, as being lots numbers thirteen and fourteen of the official subdivision of the original lot number sixty-eight (No.68-13 and 14), with the buildings thereon erected.\" To be sold at the parochial church door of the parish of St.Malachie of Ormstown, county of Châteauguay, district of Beauharnois, SATURDAY, the FIFrEENTH day of JANUARY, 1955, at TEN o'clock in the forenoon.ERNEST POIRD3R, Sheriff's Office, , Sheriff.Salaberry de Valleyfield, December 6th, 1954.38787-50-2 \u2022 3754 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 195A, Tome 86, N° 50 BEDFORD Canada \u2014 Province de Québec District de Bedford Cour Supérieure, t T 'OFFICE DU CRÉDIT N° 5798.< -L* AGRICOLE DU QUÉ-IBEC, demandeur; vs HENRI ST-GERMAIN, défendeur; et PHILIPPE A.JOLIN, mis en cause.Comme appartenant au défendeur.Une terre sise et situé dans le canton dc Brome, connue et désignée comme étant les lots numéros six cent vingt-deux (622), six cent vingt-trois, (623) et six cent vingt-quatre (624) du cadastre, officiel du canton de Brome, avec maison et toutes autres bâtisses y édifiées.La juste moitié nord de la partie sud du lot numéro huit cent cinquante-huit (858) du cadastre, du canton de Brome, de la contenance (ladite partie dc lot) de dix-huit acres en superficie plus ou moins bornée (ladite partie de lot) comme suit: A l'ouest par le chemin public, au nord par la moitié nord dudit lot N° 858; à l'est par le numéro 857 dudit cadastre et au sud par la partie, du lot numéro 858; sans bâtisses.Pour être vendu en bloc à la porte de l'église catholique de St-Françe-is-Xavier de Shefford, MERCREDI le DOUZE JANVIER 1955, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, 'Bureau du Shérif, A.ST.MARTIN.Palais dc Justice, Sweetsburg, Que., ce 4 décembre 1954.38788-50-2-0 BEDFORD Canada \u2014 Province of Quebec District of Bedford Superior Court, ( OuebeC FARM CREDIT No.5798.< v< BUREAU, plaintiff; vs (HENRI ST-GERMAIN, defendant and PHILIPPE A.JOLIN, mis en cause.As belonging to the defendant: A farm located and situated in the township of Brome, Tmown and designated as being lots numbers six hundred and twenty-two (622), six hundred and twenty-three (623) and six hundred and twenty-four (624) of the official cadastre of the township of Brome, with house and all other buildings thereon erected.The exact norther.i half ot the southern part of 1-1 number eight hundred and fifty-eight (858) cf the cadastre of the towns!lip of Brome, contai: .ing (the said part of lot) eighteen r'.cres in superficial area more or less bounded (the said f).irt of lot) as fellows: On the west by the public lighway, on the north, by the northtr.i half of the said lot No.858; on the east, by number 857 of the sai I cadastre and on the south by part of lot number 858; without buildings.To be s- 11 in block at the Cath- lie church door of St-Françcis-Xavier of Shefford, WEDNESDAY, JANUARY, TWELFTH, 1955, at TEN o'clock in the forenoon.A.ST.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Court House, Sweetsburg, Que., December 4th, 1954.38788-50-2 IBERVILLE Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec District d'Iberville Cour de Magistrat, ( O.GERVAIS & FRÈ-N° 8887 < RE LIMITÉE, corps v politique incorporé, ayant sa principale place d'affaires à St-Jean, district d'Iberville, demandeur vs; RENÉ ROY, de St-Jean, district d'Iberville, défendeur, Comme appartenant au défendeur: Une terre située en la paroisse de Lacadie, bornée et désignée comme étant composée des lots numéros cent soixante-seize, cent soixante-dix-sept, cent soicante-dix-huit, et cent soixante-dix-neuf, (Nos 176, 177, 178, 179,) du cadastre officiel de la paroisse de Stc-Margucrite dc Blairfindie; avec maison et autres bâtisses y érigées.Pour être vendue à la porte de l'église de Lacadie, MERCREDI he DOUZIÈME jour de JANVIER 1955, à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RICHARD MERCIER.Saint-Jean, le 1er décembre 1954.38783-50-2-o Fieri Facias Canada \u2014 Province de Québec District d'Iberville Cour Supérieure, / T 'OFFICE DU CRÉDIT N° 8143 < *-* AGRICOLE DU QUÉ-v BEC, corps politique et bureau d'affaires à Québec, requérant ; vs ALBERT OLIGNY, de St-Rémi, comté de Napierreville, district d'R)erville, intimé.Comme appartenant à l'intimé; Savoir: \"Une terre située en la Côte St-An-toine dans la paroisse de St-Rémi, connue et désignée sous le N° 79 aux plan et livre de renvoi IBERVILLE Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Iberville Magistrate's Court./ O.GERVAIS & FRÈ-No.8887 < RE LIMITÉE, a ( body politic and corporate, having its princ pal place of business at St-John, district of Iberville, plaintiff; vs RENÉ ROY, of St-John, district of Iberville, defendant, As belonging to the defendant; A farm situate in the parish of Lacadie, bounded and described as being composed of lots numbers one hundred and seventy-six, one hundred and seventy-seven, one hundred and seventy-eight, and one hundred and seventy-nine, (176, 177, 178, 179,) of the official cadastre of the parish of Ste-Marguerite of Blairfindie; with house and other buildings thereon erected.To be sold at the church door of Lacadie, WEDNESDAY, the TWELFTH dav of JANUARY, 1955, at ELEVEN o'clock in the forenoon.RICHARD MERCIER, Sheriff's Office.Sheriff.Saint-John, December 1st, 1954.38783-50-2 Fieri Facias Canada \u2014 Province of Quebec District of Iberville Superior Court, / QUEBEC FARM CREDIT No.8143 < VC BUREAU, a body politic \\ and corporate, having its head office at Quebec, petitioner, vs ARLBERT OLIGNY, of St-Rémi, county of Napierville, district of Iberville, respondent.As belonging to the respondent; To wit : \"A farm situate at \"Côte St-Antoine,\" in the parish of St-Rémi, known and designated under No.79 on the official plan and in the book QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 1954, Vol.86, No.50 3755 officiels de la paroisse de St-Rémi, borné en front vers le sud-est par le chemin public, en profondeur vers le nord-ouest par la ligne limitative de la paroisse de St-Rémi, d'un côté au sud-ouest par le N° 78 et de l'autre côté vers le nord-est par les numéros 80-81, contenant trois arpents de largeur sur trente arpents de profondeur formant 90 arpents en superficie.\"Avec une maison et autres bâtisses dessus construites a distraire une partie du lot 79 dans un acte de vente passé devant Me.Jean Bros-sard, notaire, le 24 mai 1949, enregistré au bureau d'enregistrement du comté dc Napiervillc, sous le N° 37,977\".Pour être vendue à lu porte de l'église de St-Rémi, VENDREDI le QUATORZIEME jour de JANVIER 1955, à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, RICHARD MERCIER.Saint-Jean, le 2 décembre 1954.38784-50-2-o of reference of the parish of St-Rémi, bounded in front on the southeast by the public highway, in depth on the northwest by the limit line of the parish of St-Rémi, on one side on the southwest by No.78 and on the other side on the northeast by numbers 80-81, containing three arpents in width by thirty arpents in depth forming 90 arpents in superficial area.\"With a house and other buildings thereon erected.To withdraw a part ot lot 79 in a deed of sale passed before Me.Jean Brossard, notary, on May 24th, 1949, registered at the Registry Office of the county of Napicrville, under No.37,977\".To be sold at the church door of St-Rémi, FRIDAY, the FOURTEENTH day of JANUARY, 1955, ELEVEN o'clock in the forenoon.RICHARD MERCIER, Sheriff's Office, Sheriff.Saint-John, December 2nd, 1954.38784-50-2 MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: / E.CHAMPAGNE II-N° 290799.{ MITÉE, demande-Iresse; vs VICTOR VILLENEUVE, défendeur.Un emplacement ayant front sur la rue Notre-Dame-de-Graces en la ville de Jacques-Cartier, composé des lots trois cent dix et trois cent onze du lot originaire numéro cent trente-huit (138-310 & 311) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Longueuil avec bâtisses dessus érigées et formant qu'une seule et même exploitation.Pour être vendu, au bureau d'enregistrement du comté de Chambly, à Longueuil, le TREIZE JANVIER 1955, à ONZE heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 0 décembre 1954.38790-50-2-o MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit : ( (~i E.CHAMPAGNE LI-No.290799.MITÉE, plaintiff; I vs VICTOR VILLENEUVE, defendant.An emplacement fronting- Notrc-Dame-de-Graces Street in the town of Jacques-Cartier, consisting of lots three hundred and ten and three hundred and eleven of original lot one hundred and thirty-eight (138-310 & 311) on the official plan and book of reference of the parish of Longueuil with buildings erected thereon ane consisting of a one and only concern.To be sold at the Registry office of the county of Chambly, at Longueuil, the THIRTEENTH day of JANUARY 1955, at ELEVEN o'clock in the morning.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, December 6th, 1954.38790-50-2 Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir : / R ÊDIT FONCIER N° 256,985 < V> FRANCO - CANA-v DIEN, demandeur; vs be: ST, REALTIES CORPORATION, défenderesse.1° Un emplacement formé de la partie nord-ouest du lot numéro deux mille six cent vingt-six (2626) du cadastre officiel de la paroisse dc Montréal mesurant en largeur en front 51.6 pieds, en arrière dans sa limite sud-est 50.5 pieds, en profondeur dans sa limite nord-est 78.3° et dans sa limite sud-ouest 78.8 pieds, le tout en mesure anglaise, borné en front vers le nord ouest par la rue Châteauguay de la cité de Montréal, en arrière vers le sud-est par le résidu dudit lot N° 2626, d'un côté vers le nord-est par partie du lot N° 2627, dudit cadastre et de l'autre côté vers le sud-ouest, partie par une partie du lot N° 2625 dudit cadastre qui fait le coin des rues Châteauguay et D'Argenson de ladite cité et partie par une autre partie du lot N° 2625, avec la maison portant les numéros civiques 2776 à 2786 de ladite rue Châteauguay et les dépendances dessus construites; 2° Un emplacement formé d'une partie du lot numéro deux mille six cent vingt-cinq pieds (2625) du cadastre officiel de la paroisc dc Mont- Fieiri Facias de Bonis et de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit : / REDIT FONCIER No.256,985 < V>» FRANCO - CANA-( DIEN, plaintiff, vs be: ST.REALTIES CORPORATION, défendant.1.An emplacement consisting of the northwestern part of lot number two thousand six hundred and twenty-six (2626) of the official cadastre of the parish of Montreal, the front width of which measuring 51.6 feet, the rear within its southeastern limit 50.5 feet, the depth within its northeastern limit 78.3 feet and within its southwestern limit 78.8 feet, all of which in English measure, and bounded in front, northwesterly, by Châteauguay street of the city of Montreal, in the rear, southeasterly, by the res-isue of said lot 2626 on one side, northeasterly, by part of lot No.2627 of sais cadastre and on the other side, southwesterly, partly by a portion of lot No.2625 of said cadastre forming the corner of Châteauguay and D'Argenson streets, of the said city, and partly by another portion of lot 2625, plus the house bearing civic numbers 2776 to 2786 of said Châteauguay street and dependencies erected thereon; 2.An amplacement forming part of lot number two thousand six hundred and twenty-five (2625) of the official cadastre of the parish of 3756 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 décembre 195A, Tome 86, N° 50 réal, mesurant en largeur 38.6 pieds en avant sur la rue D|Argenspn, de la cité de Montréal, en arrière dans sa limite nord-est 38.8 pieds, en profondeur dans sa limite sud-est 50.7 pieds et dans sa limite nord-ouest 52.5 pieds, le tout en mesure anglaise, borné en front vers le sud-ouest par ladite rue D'Argenson en arrière vers le nord-est par partie du lot N° 2626 dudit cadastre, d'un côté vers le sud-est par une autre partie dudit lot N° 2625 et de l'autre côté vers le nord-ouest par une autre partie dudit lot N° 2625, faisant le coin des rues Châteauguay et D'Argenson dont le fron sur ladite rue D'Argenson est de 41.1 pieds, avec la maison portant les numéros civiques 1121-1123-1125 et 1125-A de ladite rue D'Argenson et les dépendances dessus construites.Pour être vendus, à mon bureau, en la cité de Montréal, le TREIZE JANVIER 1955, à ONZE heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, 6 décembre 1954.38791-50-2-o Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District dc Montréal Montréal, à savoir: ( T-JARRY SOKOLOFF, N° 354907 < a 1 des cité et district de l Montréal, faisant affaires sous les nom et raison sociale de \"Acton Credit House\", demandeur, vs LA SUCCESSION DE FEU ERNEST ST-ARNAUD, défendeur.Un certain emplacement ayant front sur la rue Vauquelin, dans la cité de Montréal, connu et désigné sous le numéro cinq cent dix-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent soixante-dix-sept (477-519) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Saut-aù-Recollct, avec la maison dessus érigée et portant le numéro civique 2214 de ladite rue Vauquelin, à Montréal, circonstances et dépendances, servitudes actives et passives, apparentes ou occultes.Pour être vendu à mon bureau en la cité de Montréal, le TREIZIÈME jour de JANVIER 1955, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, CAISSE & HURTEAU.Montréal, le décembre 1954.38792-50-2 QUÉBEC Fieri Facias Cour de Magistrat Québec, à savoir:¦/ pHARLESH.CROTEAU, N° 166770.< ^ garagiste de St-Apol-\\ linaire, comté de Lotbinière; contre EUGENE FORTIER, de St-Apollinaire, comté de Lotbinière, à savoir: Le lot N° 317 (trois cent dix-sept) du cadastre officiel pour la paroisse de St-Apollinaire, comté de Lotbinière, étant un lopin de terre contenant deux arpents de front sur trente arpents de profondeur, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.' Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de St-Apollinaire, comté de Lotbinière, le TRENTE ET UNIÈME jour de DÉCEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, DR.J.-R.GOBEIL.Québec, 22 novembre 1954.[Première insertion: 27 novembre 1954.] [Deuxième insertion: 11 décembre 1954.] 38685-48-2-o Montreal, measuring 38.6 feet in width in front on D'Argenson street, of the city of Montreal, 38.8 feet in the rear within its northeasterly limit in depth, 50.7 feet within its southeasterly limit, and 52.5 feet within its northwesterly, all of which in English measure, bounded in front southwesterly by the said D'Argenson street, in the rear, northeasterly, partly by lot No.2626 of the said cadastre, on one side southeasterly partly by said lot No.2625 and on the other side northwesterly, partly by another part of said lot No.2625, forming the corner of Châteauguay and D'Argenson streets, the frontage of which on said D'Argenson street measures 41.1 feet with house bearing civic numbers 1121-1123-1125 and 1125A of said D'Argenson street and dependencies erected thereon.To be sold at my office, in the city of Montreal, the THIRTEENTH day of JANUARY 1955, at ELEVEN o'clock in the morning.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, December 6th, 1954.38791-50-2 Fieri Facias de Terris Superior Court ¦»\u2014 District of Montreal Montreal, to wit : / T-JARRY SOKOLOFF, No.354097 Gf the city and district (.of Montreal, therein trading under the firm name and style of \"Acton Credit House\", plaintiff, vs THE ESTATE OF THE LATE ERNEST ST.ARNAUD, defendant.An emplacement fronting Vauquelin Street, in the city of Montreal, known and designated under number five hundred and nineteen of the official subdivision of original lot number four hundred and seventy-seven (477-519) of the official plan and book of reference of the parish of Sault-au-Recollet, with a house erected thereon and bearing civic number 2214'of the said Vauquelin Street,' at Montreal, circumstances and dependencies, active and passive servitudes, both apparent or unapparent.To be sold, at my office, in the city of Montreal, on the THIRTEENTH of JANUARY 1955, at TEN o'clock in the forenoon.CAISSE & HURTEAU, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, December 6th, 1954.38792-50-2-o QUEBEC Fieri Facias Magistrate's Court Quebec, to wit: ( CHARLES H.GROTEAU, No.166770.< garage-keeper of St.Apol-\\ linaire, county of Lotbinière; vs EUGÈNE FORTIER, of St.Apollinaire, county of Lotbinière, to wit: Lot No.317 (three hundred and seventeen) of the official cadastre for the parish of St.Apollinaire, county of Lotbinière, being a plot of land containing two arpents in frontage and thirty arpents in depth, with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.To be sold at the door of the parochial church door of St.Apollinaire, county of Lotbinière, the THIRTY-FIRST day of DECEMBER next, at TEN o'clock in the morning.DR.J.-R.GOBEJX, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, November 22nd, 1954.[First insertion: November 17th, 1954.] [Second insertion: December 11th, 1954.) 38685-48-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, December 11th, 195A, Vol.86, No.50 3757 Fieri Facias Cour de Magistrat Québec, à savoir: C t A COMMUNAUTÉ DES N° 171-821 \\ RELIGIEUSES DE (L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC, corps politique et incorporé, ayant sa place d'affaires à Québec; contre Daine veuve NAPOLÉON LAPERRIÈRE, veuve de feu Napoléon Laperrière, domiciliée à 274 rue St-Olivier, Québec, à savoir: Un immeuble situé à Québec, 274 rue St-Olivier, maintenant connu et désigné sous le lot numéro 3552 (trois mille cinq cent cinquante-deux ) du cadastre officiel pour le quartier St-Jean de la cité dc Québec, borné vers le nord par les lots numéros 3558 et 3559 (trois mille cinq cent cinquante-huit et trois mille cinq cent cinquante-neuf), vers le sud par la rue St-OIivier, vers l'est'par le lot numéro 3551 (trois mille cinq cent cinquante et un) et vers l'ouest par le lot numéro 3553 (trois mille cinq cent cinquante-trois); mesurant 31 pieds sur la ligne qui le divise des numéros 3558 et 3559, 32 pieds sur la rue St-Olivier, 65 pieds et 6 pouces sur la ligne qui le divise du numéro 3551, 65 pieds et 9 pouces sur la ligne qui le divise du numéro 3553, contenant en superficie 2,062 pieds, mesure anglaise, avec les bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Sujet à une rente foncière, annuelle et perpétuelle de 86.00 payable le 1er mai de chaque année à la Communauté des Religieuses de l'H'ô-tcl-Dieu de Québec.Pour être vendu à mon bureau, au Palais de Justice, à Québec, le TRENTE-UNIÈME jour de DÉCEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, Dr.J.-R.GOBEIL.Québec, 23 novembre 1954.38686-48-2-0 [Première insertion: 27 novembre 1954.] [Deuxième insertion: 11 décembre 1954.] Fieri Facias Québec, à savoir: / JOSEPH OLIVIER, de St-N° 73,836
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.