Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 30 mai 1953, samedi 30 (no 22)
[" Tome 85, N° 22 1775 Vol.85, No.22 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de l« province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 30 mai 1953 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, May 30th, 1953 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party snail then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 1776 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome 85, N° 22 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes dçmandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.v Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.33898 \u2014 1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to .their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per ear N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, Queen's Printer.Governement House.Quebec, June 27th, 1940.33898\u20141-52 Lettres patentes Abattoirs Desrochers Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.La-Richelièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941.des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1953, constituant en corporation: J.-Eugène Desrochers, commerçant, Eva Laramée Dcsrochers, ménagère, épouse de Eugène Desrochers, Vincent Desrochers, commerçant, tous trois de la paroisse de Saint-Esprit district judiciaire de Joliette, pour les objets suivants: Faire l'abattage et la classification, et faire le commerce de tous les animaux en général, ainsi que des volailles et des œufs, sous le nom de \"Abattoirs Desrochers Ltée\", avec un capital de 8100,000, divisé en 300 actions ordinaires de S100 chacune et en 700 actions privilégiées de $100 chacune.Letters Patent Abattoirs Desrochers Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of April, 1953, incorporating: J.Eugène Desrochers, dealer, Eva Laramée Desrochers, housewife, wife of Eugène Desrochers, Vicent Desrochers, dealer, all three of the Parish of \"Saint-Esprit\", judicial district of Joliette, for the following purposes: To slaughter and classify, and deal in livestock generally, as well as fowl and eggs, under the name of \"Abattoirs Desrochers Ltée\", with a capital stock of 8100,000, divided into 300 common shares of S100 each and into 700 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 30th, 1953, Vol.85, No.22 1777 Le siège social de la compagnie sera à Saint-Esprit, district judiciaire de Jolictte.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Arga Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt avril 1953, constituant en corporation: Arsène Ménard, Gaston Lachapelle, industriels, Marcel Lamoureux, voyageur, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeubles et de placements; agir comme compagnie de contrôle, sous le nom de \"Arga Corporation;\" avec un capital de 5100,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et en 900 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt avril 1953.L'Assistant-procurcur général, 34903-o L.DÉSILETS.Association de Ski Nautique de Montréal Montreal Water Ski Association Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt-trois ' avril 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Rosaire Dufrcsne, marchand, Pierre Bcaudin vendeur, Gilles Boissonneault, étudiant e.e.d., tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir l'avancement du ski nautique, sous le nom de \"Association de Ski Nautique de Montréal\"\u2014\"Montreal Water Ski Association\", Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $20,000.Le siège social de la corporation sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois avril 1953.L'Assistant-procu reu r général, 34903-o L.DÉSILETS.Automotive General Supplies Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.C.La-ichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-septième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Robert Harold Earle Walker, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Roger-Louis Beaulieu, avocat, tous deux de la cité de Montréal, Charles Alexander Phelan, avocat de West-mount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: The head office of the company will be at Saint-Esprit, judicial district of Jolictte.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April, 1953.L.DÉSILETS.34903 Deputy Attorney General.Arga Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date April twentieth, 1953, incorporating: Arsène Menard, Gaston Lachapelle industrialists, Marcel Lamoureux, traveller, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a Real Estate and Investment Company, to operate as a holding company, under the name of \"Arga Coiporation\", with a capital stock of 8100,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 900 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tentieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Association de Ski Nautique de Montréal Montreal Water Ski Association Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor, of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with Section 2, Chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-third day of April 1953, to incorporate as a corporation without capital stock: Rosaire Dufresne, merchant, Pierre Bcaudin, salesman, Gilles Boissonneault, law student, all of the city and judicial district of Montreal,' for the following purposes: To further the advancement of water skiing, under the name of the \"Association de Ski Nautique de Montréal\"\u2014\"Montreal Water Ski Association\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, si $20,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-third day of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Automotive General Supplies Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventeenth day of April, 1953, incorporating: Robert Harold Earle Walker, advocate and Queen's Counsel, Roger-Louis Beaulieu, advocate, both of the city of Montreal, Charles Alexander Phelan, advocate, of Westmount, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: 1778 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome 85, N° 22 Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes d'automobiles, moteurs, machines et tous appareils ou machineries électriques et autres à l'usage du gaz ou de la réfrigération, sous le nom de \"Automotive General Supplies Co, Limited\", avec un capital de 840,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du Bureau du Procureur général, ce dix-septième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 * L.DÉSILETS.Baie Comcau Transport Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.('.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 27G, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt et unième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Gilles Rouleau., avocat, Maurice Carpentier, commis, Bérangèrc Vignolas, secrétaire, tous de Baie Comeau, district judiciaire du Sagucnay, pour les objets suivants: Exercer le commerce général de camionnage et transport des marchandises, articles et effets sous le nom tie \"Baie Comeau Transport Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de 8100 chacune et 200 action privilégiées de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Baie Comeau, district judiciaire du Sagucnay.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt et unième jour d'avril 1953.L'Assist ant-procu reu r général, 34903 L.DÉSILETS.Bisson et Bisson Compagnie Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt et un avril 1953, constituant en corporation: Charles-Christophe Taschcreau, avocat, c.r., de Val d'Or, Philippe Bisson, et Arthur Bisson, commerçants de bois, tous deux de Pascal is, tous du district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Faire le commerce de bois, sous le nom de \"Bison et Bisson Compagnie Limitée\", avec un capital de 860,000, divisé en 600 actions de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Pascalis, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.C.& A.Anbcr & Sons Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatorzième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Charles-H.Desjardins, Edward G.Tannage, avocats, Jeannette Desjardins, sté- To manufacture and deal in all kinds of automobiles, motors, machines, and all electrical, gas or refrigerating apparatus or machinery, under the name of \"Automotive General Supplies Co.Limited\", with a capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.*Baie Comcau Transport Inc.Notice is hereby given that 'under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière.in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-first day of April, 1953, incorporating: Gilles Rouleau, lawyer, Maurice Carpentier, clerk, Bérangèrc Vignolas, secretary, all of Baie Comeau, in the judicial district of Sagucnay, for the following purposes: To carry on generally the business of trucking and transporting goods, wares and merchandise, under the name- of \"Baie Comeau Transport Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each, and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company will be at Baie Comeau, in the judicial district of Saguenay.Dated at the office of the Attorney General this twenty-first day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Bisson et Bisson Compagnie Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-first day of April 1953, incoq>orating: Charles-Christophe Taschcreau, advocate, Q.C., of Val d'Or, Philippe Bisson, and Arthur Bisson, lumber merchants, both of Pascalis, all of the judicial district of Abitibi, for the following purposes: Tq carry on a lumber business, under the name of \"Bisson et Bisson Compagnie Limitée\", with a capital stock of $60,000, divided into 600 shares of $100 each.The head office of the company will be at Pascalis, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-first day of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.C.& A.Anber & Sons Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of April, 1953, incorporating: Charles-H.Desjar-dins, Edward G.Tannage, advocates, Jeannette Desjardins, stenographer, unmarried, Allan G. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May SOth, 1953, Vol.85, No.22 1779 nographe, célibataire, Allan G.Anber, marehan, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme marchands de marchandises sèches, vêtements, menus articles et nouveautés, sous le nom de \"C.& A.Anber & Sons Limited\", avec un capital de §175,000, divisé en 1,750 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Caprice Hosiery Mills Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, »1 a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatorzième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Nathan Lcvitsky, Boris Gar-maise, avocats, Rose Markis, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises entièrement ou partiellement fabriques de cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textile, verre et leurs sous-produits, sous le nom de \"Caprice Hosiery Mills Ltd.\", avec un capital de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera A Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Castle & Son Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du seizième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant, Clifford George Meek, teneur de livres, Cecil Bruce Cooke, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de travailleurs de bois, ébénistes, travailleurs de métaux, peintres, rembourreurs, polisseurs et décorateurs d'intérieurs et d'extérieurs, sous le nom de \"Castle & Son Ltd.\", Le capital-actions autorisé de la compagnie consistera en 2,000 actions sans valeur nominale ou au pair; Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce seizième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, .34903 L.DÉSILETS.Club de Baseball de Valleyficld Incorporé Valleyfield Baseball Club Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Anber merchant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as dealers in dry goods, clothing, small-wares and novelties, under the name of \"C.& A.Anber & Sons Limited\", with a capital stock of $175,000, divided into 1,750 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fourteenth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, ¦¦.34903-o Deputy Attorney General.Caprice Hosiery Mills Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of April, 1953, incorporating: Nathan Levitsky, Boris Garmaise, attorneys, Rose Markis, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise made, in whole or in part of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products, under the name of \"Caprice Hosiery Mills Ltd.\", with a capital stock of $100,000, divided into 500 common shares of a par value of $100 each and 500 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office cf the Attorney General this fourteenth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Castle & Son Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Qnebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Proviuce of Quebec, represented by Mr.C.La-Richolière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixteenth day of April 1953, incorporating : Ernest William Mockridge, manager, Clifford George Meek, bookkeeper, Cicil Bruce Cooke, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To .carry on the business of woodworkers, cabinet makers, metal workers, painters, upholsterers, polishers and interior and exterior decorators, under the name of \"Castle & Son Ltd.\".The authorized capital stock of the company shall consist of 2,000 shares without nominal or par value; The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixteenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Club de Baseball de Valleyfield Incorporé Valleyfield Baseball Club Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have 1780 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1963, Tome 86, N° 22 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1953, constituant en corporation: Leahy Lcfebvre, garagiste, Lucien Leduc, marchand, Jean Malouin, gérant d'Hôtel, tous de Valleyfiled, district judiciaire de Beauhar-nois, pour les objets suivants: Promouvoir des événements sportifs en la cité « de Valleyfield, et spécialement des joutes de baseball, sous le nom de \"Club de Baseball de Valleyfield Incorporé\" \u2014 \"Valleyfield Baseball Club Incorporated\", avec un capital de 810,000, divisé en 400 actions de 825 chacune.Lé siège social de la compagnie sera à Val ley-field, district judiciaire de Bcauharnois.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Corporate Holdings Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-huitième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Moses Moscovitch, Ben Schecter, tous deux avocats, Margaret McMartin, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce \"d'une compagnie de portefeuille et de placements sous le nom de \"Corporate Holdings Limited\", avec un capital de 8300,000, divisé en 4500 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune, 500 actions privilégiées, série \"A\", d'une valeur au pair de 810 chacune, 1750 actions privilégiées, série \"B\", d'une valeur au pair de 8100 chacune, 1500 actions privilégiées, série \"C\", d'une valeur au pair de 850 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-huitième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSDLETS.Desgagné & Boileau Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1953, constituant en corporation: Paul Boileau, Paul-Marie Côté, Léonce Desgagné, tous trois architectes, Jean-Julien Fortin, ingénieur civil, Ernest Dauphinais, ingénieur, Jacques Tessier, ingénieur forestier, tous de Chicoutimi, district judiciaire de Chi-coutimi, pour les objets suivants: Faire commerce d'ameublements de maison, de bureau, sous le nom de \"Desgagné & Boileau Ltée\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Richefière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of April 1953, incorporating: Leahy Lefeb-vrc, garage-keeper, Lucien Leduc, merchant, Jean Malouin, Hotel Manager, all of Valleyfield, judicial district of Beauharnois, for the following purposes: To promote sports in the city of Valleyfield, and especially baseball games, under' the name of \"Club dc Baseball dc Valleyfield Incorporé\"\u2014 \"Valleyfield Baseball Club Incorporated\", with a capital stock of 810,000, divided into 400 shares of $25.each.The head office of the company will be at Valleyfield, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth dav of April, 1953.L' DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Corporate Holdings Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighteenth day of April, 1953, incorporating: Moses Moscovitch, Ben Schecter, both advocates, Margaret McMartin, clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business of a holding and investment company, under the name of \"Corporate Holdings Limited\", with a capital stock of 8300,000, divided into 4500 shares of the par value of 810 each, 500 class \"A\" preferred shares of the par value of 810 each, 1750 Class \"B\" preferred shares of the par value of $100 each, 1500 Class \"C\" preferred shares of the par value of 850 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Desgagné & Boileau Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRiche-lière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of April, 1953, incorporating: Paul Boileau, Paul-Marie Côté, Léonce Desgagné, all three architects, Jean-Julien Fortin, civil engineer, Ernest Dauphinais, engineer, Jacques Tessier, forestry engineer, all of Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in household and office furniture, under the name of \"Desgagné & Boileau Ltée\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company will .be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April, 1953.\\ L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 80th, 1953, Vol 85, No.22 1781 Développement Immobilier Montréal-Nord Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du dix-huit avril 1953, constituant en corporation: Almanzor Laberge, comptable, Louise Normandeau, sténographe, tous deux de la cité de Montréal, et Contran Daoust, comptable, dc St-Vincent-dc-Paul, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'agents d'immeubles, sous le nom de \"Développement Immobilier Montréal-Nord Ltée\", avec un capital de 8100,-000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et en 800 actions privilégiés d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureiir général le dix-huit avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Eastern Townships Vending Co., Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-huitième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Guy Blanchette, Jean-L.Pélo-quin, avocats, Lucienne Gosselin, secrétaire, de la cité dc Sherbrooke, district judiciaire de St-François, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à vendre ou disposer de machines, machinerie, pièces s'y rapportant, accessoires, instruments, dispositifs, fournitures, attaches et outillage, sous le nom de \"Eastern Townships Vending Co., Inc.\", avec un capital dc S20,000, divisé en 200 actions de S100 chacune.- Le siège social de la compagnie sera à 1412 ouest, rue King, Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-huitième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Gaina Motion Picture Productions Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-trois avril 1953, constituant en corporation: Jean-Paul Massicotte, André Daviault, avocats, Simone Dansereau, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et l'industrie de la réalisation, de la distribution et de la représentation des œuvres du théâtre, de la cinematographic, de la radiodiffusion, de la télévision et de la publicité, sous le nom de \"Gama Motion Picture Productions Corporation\", avec un capital de S 150,000, divisé en 1,500 actions de 8100 chacune.Développement Immobilier Montréal-Nord Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighteenth day of April 1953, incorporating: Almanzor Laberge, accountant, Louis Normandeau, stenographer, both of the city of Montreal, and Gon-tran Daoust, accountant, of St-Vincent-de-Paul, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate as Real Estate Agents, under the name of \"Développement Immobilier Montréal-Nord Ltée\", with a capital stock of 8100,000, divided into 200 common shares of a par value of 8100 each and into 800 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be at Montreal-North, judicial disti ict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Eastern Townships Vending Co., Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighteenth day of April, 1953, incorporating: Guy Blanchette Jean-L.Pcloquin, attorneys.Lucienne Gosselin, secretary, of the city of Shcibrooke, judicial district of St.Francis, for the following purposes: To carry on the business of selling or otherwise disposing of machines, machinery, parts thereof, accessories, instruments, devices, supplies, attachments and equipment, under the name of \"Eastern Townships Vending Co., Inc.\", with a capital stock of 820,000, divided into 200 shaies of 8100 each.The head office of the company will be at M12, King Street West, Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Gama Motion Picture Productions Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the April twenty-three, 1953 incorporating: Jean-Paul Massicotte, André Daviault, advocates, Simone Dansereau, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To operate and carry on the business of production, distribution and the presenting of theatrical plays, cinematography, broadcasting, television and publicity, under the name of \"Gama Motion Picture Productions Corporation\", with a capital stock of 8150,000, divided into 1,500 shares of 8100 each. 1782 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 mai 1953, Tome 85, N° 22 Le siège social de la compagnie sera à 10 est, rue Saint-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-trois avril 1953.L'Assistant-procureur général.34903-o L.DÉSILETS.G.A.Manzato Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingtième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Louis Fitch, avocat, c.r., de la cité de Westmount, Nathan A.I^evitsky, Gertrude Wasserman, avocats, dc la cité de Mpntréal.tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce comme agents vendeurs de textiles, soies, laine, cotons et toutes sortes de tissus, sous le nom dc \"G.A.Manzato Ltd.\", avec un capital de S20.000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera «à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingtième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.The head office of the company will be at 10 St.James Street, East, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.G.A.Manzato Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day ¦of April, 1953, incorporating: Louis Fitch, barrister, Q.C., of the city of Wcstmount, Nathan A.Levitsky, Gertrude Wasserman, advocates, of the city of Montreal, all in the judicial district cf Montreal, for the following purposes: To engage in the business of selling agents for textiles, silks, wool, cottons and all types of fabrics, under the name of \"G.A.Manzato Ltd.\", with à capital stock of 820,000, divided into 200 common shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Graphic Litho Plate Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-huitième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Marcus Meyer Sperber, avocat et Conseil en Loi de la Reine, de la cité de West-mount, Alan Bernard Gold, avocat, de la cité de Montréal, Murray Lapin, avocat, de la ville de Hampstead, tous du district judiciaire dc Montréal, pour les objets suivants: .Exercer le commerce général de lithographes, manufacturiers et marchands de nouveautés accessoires de bureau, sous le nom de \"Graphie Litho Plate Corp.\", avec un capital dc S40.000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $50 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au patr de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-huitième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Hervé Ouellette Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du seize avril 1953, constituant en corporation: Jacques Décary, avocat, de Dorval, Georges Bi-lodeau, avocat, de Montréal-Nord, et Neil L.King, avocat, de Verdun, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Graphie Litho Plate Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière* in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eighteenth day of April, 1953, incorporating: Marcus Meyer Sperber, advocate and Queen's Counsel, of the city of Westmount, Alan Bernard Gold, advocate, of the city of Montreal, Murray La-,pin, advocate, of the town of Hampstead, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business generally as .ithographers, manufacturers, and dealers in novelties, office supplies, under the name of \"Graphic Litho Plate Corp.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of the par value of $50 each, and 200 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this eighteenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Hervé Ouellette Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the sixteenth day of April, 1953, incorporating: Jacques Décary, advocate, of Dorval, Georges Bilodeau, advocate of Montreal-North, aDd Neil L.King, advocate of Verdun, judicial district of Montreal, for the following purposes: \u2022 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 80th, 1968, Vol 85, No.22 1783 Faire le commerce de vente, fabrication et réparation de meubles meublants; manufacturer et faire le commerce de confection et vêtements de toutes sortes, articles dc maison, quincaillerie, produits alimentaires, articles dc toilette, sous le nom de \"Hervé Ouellette Limitée\", avec un capital de 840,000, divisé en 250 actions ordinaires de 8100 chacune et en 150 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à rue Ontario Est, cité de Montréal, district jueiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le seize avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.To sell, manufacture and repair household furniture, to manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, household articles, hardware, foodstuffs, toilet articles, under the name of \"Hervé Ouellette Limitée\", with a capital stock of 840.000, divided into 250 common shares of 8100 each and into 150 preferred shares of S100 each.The head office of the company will be on Ontario Street, East, city of Montreal^ judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Iberville Realty Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québc, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt-tro'.sième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Myer Gamcroff, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Seymour Fenster, Stanley Kandestin.avocats, Anne Goldenblatt, secrétaire, de Montréal, Irene Strecko, secrétaire, de St-Hubert, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et d'agents d'assurance, aussi ceux dc constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de \"Iberville Realty Limited\".Le capital-actions de la compagnie sera de 1000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et 10,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair.Le siège social de la compagnie sera à Iberville, district judiciaire d'Ibervillc.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-troisième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Industrial Steel & Supply Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi tics compagnies tie Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur tie la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt et un avril 1953, constituant en corporation : Claude Ducharme, avocat, Marthe Mongeau, Jacqueline Gariépy, secrétaires, tous des cité et district judiciaire tie Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous objet ou marchandises de quincaillerie, ferronnerie et plomberie, sous le nom de \"Industrial Steel & Supply Co.Ltd.\", avec un capital dc 865,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 6,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à 1418 ouest, rue Notre-Dame, dans les cité et district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt et un avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Iberville Realty Limited Notice is hereby given that untler Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformitv with section 2, chapter 270, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-third day of April, 1953, incorporating: Myer Gameroff, advocate and Queen's Counsel, Seymour Fenster, Stanley Kandestin, advocates, Anne Goldenblatt, secretary, of Montreal, Irene Strecko, secretary, of St.Hubert, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of real estate and insurance agents, builders and contractors, under the name of \"Iberville Realty Limited\".The amount of the capital stock of the company shall be 1000 preference shares of a par value 8100 each, and 10,000 common .shares without nominal or par value.The head office of the company will be at Iberville, judicial district, of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of April, 1953.L.DÉSILETS.34903-o Deputy Attorney General.Industrial Steel & Supply Co.Ltd.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-first day of April 1953, incorporating: Claude Ducharme, advocate, Marthe Mongeau, Jacqueline Gariépy, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all hardware, ironmongery and plumbing objects or merchandise, under the name of \"Industrial Steel & Supply Co.Ltd.\", with a capital stock of $65,000, divided into 500 common shares of a par value of $10 each and 6,000 preferretl shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 1418 Notre-Dame Street, West, in the city and judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, the twenty-first day of April 1953.L.DÉSILETS.34903 Deputy Attorney General. 1784 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 mai 1968, Tome 86, N° 22 Inter-Cité Construction Ltée Ïnter-City Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du onze avril 1953, constituant en corporation: Jacques Tcssier, ingénieur-forestier, Dame Jacqueline Claveau, ménagère, Dame Solange Tremblay, ménagère, tous de Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer généralement le commerce et l'indus-tire d'entrepreneurs et de constructeurs, sous le nom de \"Inter-Cité Construction Ltée\" \u2014 \"In-ter-City Construction Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 2,000 actions communes de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire dc Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le onze avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Jane Apartments Ltd.Avis est \"donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière.conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettrés patentes en date du vingt-troisième jour d'avril 1953, constituant en corporation: June Kirlin, sténographe, Blan-ka Ovulai, veuve, tencusc de livres, et Raymon-dc Doyle, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acquérir et négocier des immeubles et propriétés immobilières de toutes sortes, sous le nom de \"Jane Apartments Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune et 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-troisième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Inter-Cité Construction Ltée Inter-City Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eleventh day of April, 1953, incorporating: Jacques Tcssier, Forestry Engineer, Dame Jacqueline Claveau, housewife, Dame Solange Tremblay, housewife, all of Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To generally carry on the business and operate as contractors and builders, under the name of \"Inter-Cité ( 'oust ruction Ltée\" \u2014 \"Inter-City Construction Ltd.\", with a capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of S10 each and into 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General,, this eleventh dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Jane Apartments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière.in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941.bearing date the twenty-third day of April, 1953, incorporating: June Kirlin, stenographer, Blanka Gyulai, widow, bookkeeper, and Raymonde Doyle, stenographer, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To acquire and deal with real estate and immoveable property of all kinds, under the name of \"Jane Apartments Ltd.'', with a capital stock of 840,000, divided into 300 preferred shares having a par value of 8100 each and 100 common shares having a par value of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.\u2022 Dated at the office of the Attorney\" General this twenty-third day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.J.P.A.Normand Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec, représenté pur M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du seize avril 1953, constituant en corporation: Raymond Normand, entrepreneur, François Beaulieu, comptable, de l'Islet, district judiciaire de Montmagny, Paide Dussault, secrétaire, de Québec, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Agir généralement comme constructeurs ou entrepreneurs-constructeurs, sous le nom de \"J .P.A.Normand Inc.\", avec un capital de $75,000 divisé en 250 actions privilégiées de $100 chacune et en 500 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à LTslet, district judiciaire de Montmagny.J.P.A.Normand Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the sixteenth day of April, 1953, incorporating: Raymond Normand, contractor, François Beaulieu, accountant, of L'Islet, judicial district of Montmagny, Paulc Dussault, secretary, of Quebec, judicial district of Quebec, for the following purposes: To act generally as builders or building contractors under the name of \"J.-P.-A.Normand Inc.\", with a capital stock of S75.000, divided into 250 preferred shares of 8100 each and into 500 common shares of SI00 each.The head office of the company will be at ITslet, judicial district of Montmagny. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 30th, 1953, Vol.85, No.22 1785 Daté du bureau du Procureur général le seize avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-c- L.DÉSILETS.La Compagnie d'ExpansionTlndustrielle de Warwick Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représente par M.C.LaRichc-lièrc, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du dix-huit avril 1953, constituant en corporation: Roland Boulanger, industriel, Dr Liguori Breton, médecin, Raoul L'Heureux, Cyrille Rondeau, tous deux agents d'assurances, Clément Letarte, comptable, tous de Warwick, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: L'expansion et le développement industriel du village dc Warwick et dc ses banlieues, sous le nom dc \"La Compagnie d'Expansion industrielle de Warwick Limitée\", avec un capital de 8100,000 divisé en 2,000 actions de S50 chacune.Le siège social de la compagnie sera au village de Warwick, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le dix-huit avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.La Ligue des Propriétaires de .la Cité de SorcI Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, représenté par M.C.LaRichclière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt avril 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Alpha Chicoine, commerçant.Michel Lemoine, industriel, Ernest Pronovost, soudeur, Louis-Philippe Chap-delaine, contracteur, Gaston .loyal, marchand, Antoine Rajotte, menuisier, Luc Chabot, Gaston Roux, comptables, Orner Fagnan, mécanicien, Chrs-Ed.Houle, laitier, tous de Sorel, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Pour mieux discuter des affaires de la cité au point dc vue améliorations et embellissements, sous le nom de \"La Ligue des Propriétaires dc la Cité dc Sorel Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $4,000.Le siège social deda corporation sera à la Salle des Loisirs de Stc-Maximc, à Sorel, district judiciaire de Richelieu.Daté du bureau du Procureur général le vingt avril 1953.' ¦ L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.La Société des Canaux d'Egouts des rues St-Pierre, St-Paul, Gcrvais et partie de la rue St-Joscph, dc Stc-Martine Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelièse, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes, Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.La Compagnie d'Expansion Industrielle de Warwick Limitée Notice is hereby given that under Part I 'of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighteenth day of April 1953, incorporating: Roland Boulanger, industrialist.Dr.Liguori Breton, physician, Raoul l'Heureux, Cyrille Rondeau, both insurance agents, Clément Letarte, accountant, all of Warwick, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: For the industrial expansion and development of the village of Warwick and its outskirts, under the name of \"La Compagnie d'Expansion Industrielle de Warwick Limitée\", with a capital stock of $100,000, divided into 2.0C0 shares of 850 each.The head office of the company shall be in the village of Warwick, judicial district of Arthabaska Dated at the office of the Attorney General, the eighteenth dav of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.La Ligue des Propriétaires dc la Cité de Sorel Inc.Notice is hereby given that under Part DU of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the ¦Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twentieth day of April 1953, to iucorporate as a corporation without capital stock: Alpha Chicoine, merchant, Michel Lemoine, industrialist, Ernest Pronovost, welder, Louis-Philippe Chapdelainc, contractor, Gaston Joyal, merchant, Antoine Rajotte, carpenter, Luc Chabot, Gaston Roux, accountants, Omer Fagnan, mechanic, Chrs-Ed.Houle, dairyman, a'll of Sorel, judicial district of Richelieu, for the following purposes: To discuss, at greater lengt, the affairs, of the city in order to bring about improvements and embellishments, under the name of \"La Ligue des Propriétaires de la Cité de Sorel Inc.\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $4,000.The head office of the corporation will be at the Recreation Hall of Stc-Maxime, at Sorel, judicial district of Richelieu.' Dated at the office of the Attorney General, the twentieth dav of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.La Société des Canaux d'Egouts des rues St-Pierre, St-Paul, Gervais et partie de la rue St-Joscph, dc Ste-.Martine Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with'section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing datejhe seventeenth 1786 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 mai 1963, Tome 86, N° 22 en date du dix-sept \"avril 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Wellie Mélodie, camionneur, Valérien Laberge, Emery Labergc, Aloysius Cusson, journaliers, Wilfrid Lacoste, rentier, tous de Stc-Martinc, district judiciaire de Beauharnois, pour les objets suivants: Exploiter une entreprise publique d'égoûts, sous le nom dc \"La Société des Canaux d'Egouts des rues St-Pierre, St-Paul, Gervais et partie de la rue St-Joseph, de Ste-Martine\".Le montant auquel sont limites les biens immobiliers que la Corporation peut posséder, est fixé à la somme de $50,000.Le siège social de la corporation sera situé à Ste-Martine, district judiciaire dc Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général le dîx-sept avril 1953.L Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.La Société d'Habitation Jacques Butcux Ltée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province dc Québec, représenté par M.C.LaRichc-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du quatorze avril 1953, constituant en corporation: Frank Spcnard, courtier, Maurice Fortin, marchand, tous deux de la cité des Trois-Rivières, André Piché, industriel, dc la municipalité de la paroisse des Trois-Rivières, tous du district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Agir et faire affaires comme société de logement à dividende limité, soiis le nom dc \"La Société d'Habitation Jacques Buteux Ltée\", avec un capital de $125,000, divisé en 1250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité des Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le quatorze avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.L'Association de l'Union Nationale de Maisonneuvc Incorporée Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du vingt-trois avril 1953, constituant en corporation sans capital-actions: Alphonse Samuel Bisson, bijoutier, Raymond Godin, avocat, Léon Vigeant, fonctionnaire provincial, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objet suivants : Promouvoir l'étude et l'action politique, sous le nom de \"L'Association de l'Union Nationale de Maisonneuve Incorporée\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $20,000.Le siège social de la corporation sera à Mont-tréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-trois avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.day of April 1953, to incorporate as a corporation without capital stock: Wellie Meloche, carrier, Valérien Laberge, Emery Laberge, Aloysius Cusson, labourers, Wilfrid Lacoste, annuitant, all of Ste-Martine.judicial district of Beauharnois, for the following purposes: To operate a public sewage system, under the name of \"La Société des Canaux d'Egouts des mes St-Pierre, St-Paul, Gervais et partie de la rue St-Joseph,' de Ste-Martine\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be located at Ste-Martine, judicial district of Beauharnois.Dated at the office of the Attorney General, the seventeenth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.La Société d'Habitation Jacques Buteux Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRir chelière, in conformity with section 2, chapte-276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of April, 1953, incorporating: Frank Spenard, broker, Maurice Fortin, merchant, both of the city of Trois-Rivières, André Piché, industrialist, of the municipality of the parish of Trois-Rivières, all of the judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on and operate as a housing society with limited dividends, under the name of \"La -Société d'Habitation Jacques Buteux Ltée\", with a capital stock of $125,000, divided into 1250 shares of $100 each.The head office of the company will be in the city of Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.L'Association de l'Union Nationale de Maisonneuvc Incorporée Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-third day of April, 1953, to incorporate as a corporation without share capital : Alphonse Samuel Bisson, jeweller, Raymond Godin, advocate, Léon Vigeant, civil employee, all of the city and judicial district of Montreal.for the following purposes: To promote the study of politics and political action, under the name of \"L'Association de l'Union Nationale de Maisonneuve Incorporée\".The amount to which the annual revenue from the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 30th, 1953, Vol.85, No.22 1787 Les Produits, Alimentaires Every Day Inc.Every Day Food Products Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la i>rovincc de Québec, représenté par M.G.La-lichelière, conformément a l'article 2, chapitre 27G, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du treize avril 1953, constituant en corporation: Jacques Drucllc, industriel, Guy Girard, notaire, d'Outremout, Robert Borremans, industriel, de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer généralement l'industrie de la confection, de la distribution, et «le la vente de tous genres de produits alimentaires, sous le nom de \"Les Produits Alimentaires Every Day Inc.\" \u2014 \"Every Day Food Products Inc.\", avec un capital de 840,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 5215, Avenue du Parc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le treize avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Lowenthal Bros, Mfg.Co.Avis est donné qu'en Vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovincc de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres, patentes en date du dix-septième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat, de la cité d'Outremont, Bernard Diamond, avocat, Gilbert Howard, marchand, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer, faire le commerce et le négoce de cuirs, peaux de chamois, suède, textiles et autres substances de même sorte et description sous le nom de \"Lowenthal Bros.Mfg.Co.\", avec un capital de $40,000, divisé en 200 actions privilégiées ide $100 chacune et 200 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce dix-septième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Maple Silks & Woollens Co.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingtième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Issie Kaplovitch, Ben Steinberg, tous deux marchands, Abe Green, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce et exercer les affaires de marchands de coton, laine, filés et autres substances fibreuses; et manufacturer des vêtements de toutes descriptions, sous le nom de \"Maple Silks & Woollens Co.\", avec un capital de $40,000, divisé en^OO actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de $10 chacune.Les Produits Alimentaires Every Day Inc.Every Day Food Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276; R.S.Q., 1941, bearing date the thirteenth day of April, 1953, incorporating: Jacques Druel-le, industrialist, Guy Girard, notary, of Outre-mont, Robert Borremans, industrialist of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business generally in the clothing industry, to distribute and to deal in the sale of all kinds of food products, under the name of \"Les Produits Alimentaires Every Day Inc.\" \u2014 \"Every Day Food Products Inc.\", with a capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 5215, Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Lowenthal Bros, Mfg.Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventeenth day of April, 1953, incorporating: Louis Orenstein, advocate, of the city of Outremont, Bernard Diamond, advocate, Gilbert Howard, merchant, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture, trade and deal in leathers, chamois, suede, and other textiles and substances of the same kind and description, under the name of \"Lowenthal Bros.Mfg.Co.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 preferred shares of $100 each, and 200 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Maple Silks & Woollens Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day of April, 1953, incorporating Issie Kaplovitch, Ben Steinberg, both merchants, Abe Green, accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes : To deal in and carry on the business of dealers in cotton, wool, worsted and other fibre substances; and to manufacture clothing of every description, under the name of \"Maple Silks & Woollens Co.\", with a capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each, and 3,500 preferred shares of $10 each. 1788 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome S5, A'0 22 Le iiège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingtième jour d'avril 1953.L'Assistant-procurcur général, 34903 L.DÉSILETS.Metal Sales Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiehe-lière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt et unième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Arthur Daniel Ruby, Lewis Jack Manolson tous deux comptables agréés, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme vendeurs de rebuts, ferrailles, camelote, articles de seconde-main et usagés, sous le nom de \"Metal Sales Limited\", avec un capital de 840.000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt et unième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Michael Palangio Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de.la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingtième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Michael Palangio, entrepreneur, Lillian Lyons, secrétaire, tous deux de la cité de Montréal, Jcremie Palangio, entrepreneur, de Ville Mont-Royal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie générale de construction, sous le nom dc \"Michael Palangio Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 7279 avenue McEachran, Ville Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingtième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSLLETS.Montreal Bowling Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1953, constituant en corporation: Ulysse Tremblay, vendeur, Henri-Paul Tremblay, gérant, Georges Tremblay, menuisier, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'allées de quilles, de tables de billard et depool et d'articles d'amusement, sous The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Metal Sales Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-first day of April 1953, incorporating: Milton Lowen Klein, advocate, Arthur Daniel Ruby, Lewis Jack Manolson, both chartered accountants, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as dealers in scrap metal, junk, secondhand articles and used articles, under the name of \"Metal Sales Limited\", with a capital stock of S40.000, divided into 250 common shares of $100 each, and 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Michael Palangio Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twentieth day of April, 1953, incorporating: Michael Palangio, contractor, Lillian Lyons, secretary, both of the city of Montreal, Jcremie Palangio, contractor, of the town of Mount Royal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a general construction company, under the name of \"Michael Palangio Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 200 common shares wich a par value of $100 each aud 200 preferred shares with a par value of $100 each.The head office of the company will be at 7279 McEachran Avenue, in the town of Mount Royal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Montreal Bowling Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of April, 1953, incorporating: Ulysse Tremblay, salesman, Henri-Paul Tremblay manager, Georges Tremblay, joiner, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in bowling allies, billiard and pool tables and amusement articles, under the name QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec ,May SOth, 1953, Vol 85, No.22 1789 le nom dc \"Montreal Bowling Construction Ltd.\", avec un capital de 840,000, divisé en 4,000 actions d'une valeur au pair dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréxl.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Motel Mont-Valin, Ltée Mount-Valin Motel Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec, représenté par M.C.LaRichc-lière, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du dix-huit avril 1953, constituant en corporation: Marcel Clavet, gérant, Henri Tremblay, imprimeur, Robert Tremblay, courtier d'assurances, tous de Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôtellerie, sous le nom de \"Motel Mont-Valin, Ltée\" \u2014 \"Mount-Valin Motel Ltd.\", avec -un capital de S100,000, divisé en 1,000 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire dc Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général, le dix-huit avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.of \"Montreal Bowling Construction Ltd.\", with a capital stock of 840,000, divided into 4,000 shares of a par value of 810 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April, 1953.L.DÉSILETS.34903 Deputy Attorney General.Motel Mont-Valin, Ltée Mount-Valin Motel Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chclière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighteenth day of April 1953, incorporating: Marcel Clavet, manager, Henri Tremblay, printer, Robert Tremblay, insurance broker, all of Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To carry on the business of hotel-keeper, under the name of \"Motel Mont-Valin, Ltée\" \u2014 \"Mount-Valin Motel Ltd.\", with a capital stock of S100,000, divided into 1,000 shares of S10 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, the eighteenth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Parkway Amusements Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-septième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Harry Blank, avocat, June Kirlin, sténographe, Blanka Gyulai, teneuse de livres, veuve, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à procurer des amusements et dispositifs pour divertir le Eublic, sous le nom de \"Parkway Amusements ,imited\", avec un capital de S15.000, divisé en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 810 chacune et 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal, Daté du bureau, du Procureur général, ce dix-septième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 \u2022 L.DÉSILETS.Parkway Amusements Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of April, 1953, incorporating: Harry Blank, advocate, June Kirlin, stenographer, Blanka Gyulai, bookkeeper, widow, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of furnishing amusements and amusement devices to the public, under the name of \"Parkway Amusements Limited\", with a capital stock of 815,000, divided into 1,000 preferred shares having a par value of S10 each, and 500 common shares having a par value of S10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Pine Land Lumber Sales Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q.1941, des lettres patentes, en date du onze avril 1953, constituant en corporation: Paul-Yvan Marquis, notaire, Louis Dugal, avocat, Gérard Lapointe, comptable agréé, tous trois de Rivière-du-Loup, district judiciaire de Ka: mouraska, pour les objet suivants: Pine Land Lumber Sales Ltd.\u2022\u2022 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the eleventh day of April 1953, incorporating: Paul-Yvan Marquis, notary, Louis Dugal, advocate, Gérard Lapointe, chartered accountant, all three of Rivière-du-Loup, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: 1790 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome 86, N° 22 Exercer le commerce et négoce de bois, sous le nom de 'Tine Land Lumber Sales Ltd.\", avec un capital dc $40,000, divisé en 1600 actions de §25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Rivière-du-Loup, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur .général le onze avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Polar Electric Refrigeration Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a plu au Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec, de corriger les lettres patentes datées du 21e jour d'août 1950, de la compagnie \"Polar Electric Refrigeration Co.Ltd.\", de la manière suivante: la description du capital-actions de la compagnie a été modifiée pour se lire comme suit: \"Le montant du capital-actions dc la compagnie divisé en mille actions ordinaires dc dix dollars chacune doit être fixé à la somme dc dix mille dollars, monnaie légale du Canada.Daté du bureau du Procureur général, le 9e jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Prêt d'Honneur Limoilou Incorporé Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il'a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du dix-huit avril 1953, constituant en corporation sans capital-actions; E.-Alexandre Martel, employé civil et chef de personnel, Conrad Tanguay, instituteur, J.-Paul Pouliot, chef de personnel, Guy Marchand, directeur de compagnie, Gérard Lebel, employé civique, Frère Martial (Marius Ruel), Frère Gonzalve (Gaston Dion) Frère Sévéricn (René Domon), Frère Adrias (Noël Trottier), Maxime Morin, avocat, et conseil en Loi de la Reine, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Effectuer des prêts sans intérêt à des étudiants, sous le nom de \"Prêt d'Honneur Limoilou Incorporé\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à 334, 12ème rue, Limoilou, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le dix-huit avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Progress Development Limited Avis est donné qu'en vertu-de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRiche-lière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quinzième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Adolphe Velan, ingénieur, Olga Velan, ménagère, épouse séparée de biens dudit Adolphe Velan, et dûment autorisée par lui et Henry Lonn, comptable agréé, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: To carry on the business of and deal in lumber, under the name of \"Pine Land Lumber Sales Ltd\", with a capital stock of $40,000, divided into 1600 shares of $25 each.The head office of the company will be at Rivière-du-Loup, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, the eleventh day of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Polar Electric Refrigeration Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Qucgcc Companies' Act, the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec has been pleased to correct the letters patent bearing date the 21st day of August, 1950, of the company \"Polar Electric Refrigeration Co.Ltd.\", in the following manner: the description of the capital stock has been rewriteen up so as to read as follows: \"The amount of the capital stock of the company, divided into one thousand common shares of ten dollars each, to be fixed at the sum of ten thousand dollars, current money of Canada.\" Dated at the office of the Attorney General the 9th dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Prêt d'Honneur Limoilou Incorporé Notice is hereby given that urifler Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighteenth day of April 1953, to incorporate as a corporation without capital stock; E.-Alexandre Martel, civil servant, and personnel manager, Conrad Tanguay, teacher, J.-Paul Pouliot, personnel, manager, Guy Marchand, company's director, Gérard Lebel, civic employee, Brother Martial (Marius Ruel), Brother Gonzalve (Gaston Dion) Brother Sévérien (René Domon) Brother Adrias (Noël Trottier), Maxime Morin, advocate, and Queen's Counsel, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To make loans to students, without charging interest, under the name of \"Prêt d'Honneur Limoilou Incorporé\".The amount to which the value of immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation shall be at 334, 12th Street, Limoilou, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, the eighteenth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Progress Development Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRi-chelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of April, 1953, incorporating: Adolphe Velan, engineer, Olga Velan, housewife, wife separate as to property of the said Adolphe Velan, and duly authorized by him, and Henry Lonn, chartered accountant, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 80th, 1958, Vol.85, No.22 1791 Exploiter et diriger un commerce de construction en général, sous le nom de \"Progress Development Limited\", avec un capital de $100,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 750 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce quinzième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Quebec Beryllium Limited (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour d'avril 1953, constituant en corporation: William George Spence, manufacturier, Hugh David Heron, ingénieur mécanicien, Charles Miller, annonceur de radio, de la cité de Montréal, Maurice Sauvé, avocat de Ville St-Laurent, tous quatre du district judiciaire de Montréal, et François Coron, avocat dc Sorel, district judiciaire de Richelieu, pour les objets suivants: Faire des explorations et des recherches pour découvrir des mines et des minerais et les négocier, sous le nom de \"Quebec Beryllium Limited\" (Libre de responsabilité personnelle), avec unn capital de $3,500,000, divisé en 3,500,000 actions de $1 chacune.Les actionnaires dc la compagnie n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu d'être payé à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera a Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.Radio Allcghanys Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276.S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-sept avril 1953.constituant en corporation: Henri Deschênes, impresario, des cité et district judiciaire de Montréal, Roger Boulanger, publiciste, André Mercier, employé de bureau, tous deux des cité et district judiciciare de Montmagny, pour les objets suivants: Acquérir, maintenir et opérer une organisation radiophonique, sous le nom de \"Radio Alleghanys Inc.\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune et en 100 actions ordinaires ou communes sans valeur au pair: Le siège social de la compagnie sera à Montmagny, district judiciciare de Montmagny.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSDLETS' To operate and conduct a general contracting business, under the name of \"Progress Development Limited\", with a capital stock of $100,000, divided into 250 common shares of $100 each, and 750 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of April, 1953.L.DESILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Quebec Beryllium Limited (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of April, 1953, incorporating: William George Spence, manufacturer, Hugh David Heron, mechanical engineer, Charles Miller, Radio Announcer, of the city of Montreal, Maurice Sauvé, advocate, of Ville St.Laurent, all four in the judicial district of Montreal, and François Coron, advocate, of Sorel, in the judicial district of Richelieu, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals and deal with the same, under the name of \"Quebec Beryllium Limited\" (No Personal Liability), with a capital stock of $3,500,000, divided into 3,500,000 shares of $1 each.The shareholders shall incur no personal liability in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deouty Attorney General.Radio Alleghanys Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chpater 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of April, 1953, incorpoarting: Henri Deschênes, im-pressario, of the city and judicial district of Montreal, Roger Boulanger, publicist, André Mercier, office employee, both of the city and judicial district of Montmagny, for the following purposes: Acquire, maintain and operate a radiophonie organization under the name of Radio Alleghanys Inc.\", The capital stock of the company is divided into 400 preferred shares of a par value of $100 each and into 100 common shares of no par value; The head office of the company will be at Montmagny, judicial district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General. 1792 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 mai 1958, Tome 85, N° 22 Richmond Motor Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quatorzième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Raymond-L.Kiernan, garagiste, Laurette Brunette, secréaire, épouse commune en biens dudit Raymond-L.Kiernan, et Pauline Daigle, secrétaire, tous trois de la ville de Richmond, district judiciaire de St-François, pour les objets suivants: Acquérir, faire le commerce d'automobiles, moteurs, machineries agricoles, ferronnerie, provisions, accessoires électriques et aussi exploiter des garages, sous le nom de \"Richmond Motor Sales Inc.\", avec un capital de §50,000, divisé en 250 actions ordinaires de §100 chacune et 250 actions privilégiées de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Richmond, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, ce quatorzième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 24903 L.DÉSILETS.Roger Laurin Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Roger Laurin, entrepreneur-peintre, Mario Cousineau, technicien, tous deux de la cité de Montréal, Joseph-Arthur Laurin, peintre, de Longueuil, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Roger Laurin Ltd.\", avec un capital de §40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingtième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 24903 L.DÉSILETS.Roméo Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu ' de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du seize avril 1953, constituant en corporation: Gérard Corbeil, avocat, de Longueuil, Léo Da-vignon, comptable, Yvette Marcoux, secrétaire, tous deux de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire et exercer toutes ou aucune des opérations d'entrepreneurs généraux, sous le nom de \"Roméo Construction Ltée\", avec un capital de $100,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et de 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le seize avril 1953.L'Assistant-procureur général, 24903-o L.DÉSILETS.Richmond Motor Sales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of April, 1953, incorporating: Raymond-L.Kieman, Garage owner, Laurette Brunette, secretary, wife common as to property of the said Raymond-L.Kiernan, and Pauline Daigle, secretary, all three of the town of Richmond, judicial district of St.Francis, for the following purposes: To acquire, deal in automobiles, motors, farm machinery, hardware, provisions, electrical appliances and to operate garages, under the name of \"Richmond Motor Sales Inc.\", with a capital stock of $50,000 divided into 250 common shares of S100 each, and 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Richmond, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General this fourteenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Roger Laurin Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twentieth day of April, 1953, incorporatin : Roger Laurin, painting contractor, Mario Cousineau, technician, both of the city of Montreal, Joseph-Arthur Laurin, painter, of Longueuil, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors, under the name of \"Roger Laurin Ltd.\" with a capital stock of 840,000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Roméo Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the sixteenth day of April, 1953, incorporating: Gérard Corbeil, advocate of Longueuil, Léo Davignon, accountant, Yvette Marcoux, secretary, both of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To work on and carry out all and any operations as General Contractors, under the name of \"Roméo Construction Ltée\", with a capital stock of $100,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and of 800 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 80th, 1968, Vol.86, No.22 1793 Singer Plumbing & Heating Co.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt-deuxième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Oscar Singer, maître plombier, James Topping, John DiMassino, surintendants, Hyman Eric Feigelson, avocat, et Toshiko Nakatsuka, dactylo, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs en plomberie et chauffage, et aussi celui d'entrepreneurs en général, sous le nom de \"Singer Plumbing & Heating Co.\" avec un capital de $150,000, divisé en 2,500 actions ordinaires et 12,500 actions privilégiées, toutes d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, ce vingt-deuxième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 24903 L.DÉSILETS.Two-Island Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingtième jour d'avril 1953, constituant en corporation: Wendell Howard Laidley, avocat et Conseil en Loi de la Reine, Daiiel Doheny, James Arthur Soden, David Barlow Sinclair Mackenzie, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme agents d'immeubles et de location et transiger les affaires de placements, sous le nom de \"Two-Island Company\", avec un capital de $40,000, divisé en 4,000 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera en la cité de Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général ce vingtième jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 24903 .L.DÉSILETS.Singer Plumbing & Heating Co.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the twenty-second day of April, 1953, incorporating: Oscar Singer, master plumber, James Topping, John DiMassino, superintendents, Hyman Éric Feigelson, advocate, and Toshiko, Nakatsuka, typist, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of plumbing and heating contractors, and of general contractors, under the name of \"Singer Plumbing & Heating Co.\", with a capital stock of $150,000, divided into 2,500 common shares and 12,500 preferred shares, all of a par value of $10 each.The head office of the company will .be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-second day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Two-Island Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.La-Riche'ière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing' date the twentieth day of April, 1953, incorporating: Wendell Howard Laidley, advocate and Queen's counsel, Daniel Doheny, James Arthur Soden, David Barlow Sinclair Mackenzie, avocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as real estate, house and rental agents; to carry on the business of investment, under the name of \"Two-Island Company\", with a capital stock of$40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at the city of Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Vox Pop Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quatorze avril 1953, constituant, en corporation: Jean-J.Mercier, journaliste et éditeur, de Valois, Alphonse Allard, comptable, et Raymond Mondor, journaliste, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de propriétaires de journaux, de publicistes, d'agents de publicité, sous le nom de \"Vox Pop Inc.\", avec un capital de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune, et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Vox Pop Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fourteenth day of April 1953, incorporating: Jean-J.Mercier journalist and editor, of Valois, Alphonse Allard, accountant, and Raymond Mondor, journalist, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as newspaper owners, publicists, publicity agents, under the name of \"Vox Pop Inc.\", with a capital stock of $40,000, dividend into 2,000 common shares of $10 each, and 200 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. 1794 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome 85, N° 22 Daté du bureau du Procureur général le quatorze avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o * L.DÉSILETS.Comité dc vie paroissiale \"St-Rodrigue\" Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2, chapitre 27G, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du vingt mai 1953, constituant en corporation sans capital-actions: «Robert Béland, comptable, Roger Gagnon, mesureur de bois, Edouard Laurent, employé civil, Roland Mor-ncau, Robert Thériault, industriels, Paul-R.Thivierge, C.A., tous six de Charlesbourg, et Paul-R.LaRochelle, M.D., de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Travailler au progrès religieux, économique et social dc la paroisse de Saint-Rodrigue et des environs, sous le nom de \"Comité dc vie paroissiale \"St-Rodrigue\".Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $30,000.Le siège social de\" la corporation sera en la Paroisse Saint-Rodrigue, dans la ville de Charlesbourg, dans le district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le vingt mai 1953.L'Assistant-procureur général suppléant, 34903-o C.-E.CANTIN.Lettres patentes supplémentaires Alice Adrian Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 24e jour d'avril 1953, à la compagnie \"Alice Adrian Inc.\", augmentant son capital de $-19,000 à 889,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 400 actions privilégiées dc 8100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 24e jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.American Paper Box Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 25e jour d'avril 1953, à la compagnie \"American Paper Box Co.Limited\", augmentant son capital de 8298,900 à 8398,900: le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000 actions privilégiées de S108 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 25e jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Dated at the office of the Attorney General, the fourteenth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.Comité de vie paroissiale \"St-Rodrigue\" Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twentieth day of May, 1953, to incorporate as a corporation without share capital: Robert Béland, accountant, Roger Gagnon, culler, Edouard Laurent, civil employee, Roland Morneau, Robert Thériault, industrialists, Paul R.Thivierge, C.A., all six of Charlesbourg, and Paul R.LaRochelle, M.D., of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To work for the religious, economic and social progress of the parish of Saint-Rodrigue and environments, under the name of \"Comité de vie paroissiale \"St-Rodrigue\".The amount to which the annual revenue of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited, is 830,000.The head office of the corporation will be in the Parish of Saint-Rodrigue, in the town of Charlesbourg, in the judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of May, 1953.C.E.CANTIN, 34903 Acting Deputy Attorney General.Supplementary Letters Patent Alice Adrian Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of April, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.Larichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Alice Adrian Inc.\", increasing its capital from 849,000 to 889,000: the additional capital stock being divided into 400 preferred shares of 8100 each.Dated at the office of the Attorney General the 24th day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.American Paper Box Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of April, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière> in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"American Paper Box Co.Limited\", increasing its capital from $298,900 to $398,900: the additional capital stock being divided into 1,000 preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General the 25th day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 30th, 1953, Vol.85, No.22 1795 Arnora Sulphur Mining Corporation (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières dc Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1911, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 9 mai 1953, à la compagnie \"Arnora Sulphur Mining Corporation\" (Libre de responsabilité personnelle), augmentant son capital-actions dc §3,500,000 à S5,000.000: le nouveau capital étant divisé en 1,500,000 actions ordinaires de 81 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 9 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Atoniik Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 2 mai 1953, changeant le nom de la compagnie \"J Berger Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 31 décembre 1952, en vertu des dispositions de ladite première paitie dc la Loi des compagnies de Québec, en celui dc \"Atomik Sales Inc.\" Daté du bureau du Procureur général, le 2 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Concrete Placing & Exclavation Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 30 avril 1953, à la compagnie \"Concrete Placing Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec en date du 9 décembre 1949, sous le nom originaire de \"Contract Sales, Limited\", et par lettres patentes supplémentaires datées du 14 mars 1950 changeant ledit nom originaire en celui de \"Concrete Placing Limited\", changeant de nouveau le nom de la compagnie en celui de \"Concrete Placing & Excavation Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 30 avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Construction Rive-Sud Incorporée South Shore Construction Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 17 avril Arnora Sulphur Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act and of Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the latter Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Arnora Sulphur Mining Corporation\" (No Personal Liability), increasing its capital stock from 83,500.000 to 85,000,000: the new capital being divided into 81,500,000 common shares of SI each.Dated at the office of the Attorney-General this 9th dav of May, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Atomik Sales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformitv with section 2 of the said Act, R.S.Q., 19*41, chapter 276, changing the name of the company \"J.Berger Inc.\", incorporated by letters patent dated December 31, 1952, under the provisions of the said Part I of the Quebec Companies' Act, to that of \"Atomik Sales Inc.\" Dated at the office of the Attorney General the 2nd day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Concrete Placing & Exclavation Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of Apil, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941.chapter 276, to the company \"Concrete Placing Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated December 9, 1949, under the original name of \"Contract Sales, Limited\", and by supplementary letters patent dated March 14, 1950, changing said original name to \"Concrete Placing Limited\", again changing the name of the company to that of \"Concrete Placing & Excavation Limited\".Dated at the office of the Attorney General the 30th day of Apiil, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Construction Rive-Sud Incorporée South Shore Construction Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., chapter 276, bearing date the seventeenth day of Apri 1796 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 mai 1953, Tome 85, N° 22 1953, à la compagnie \"Construction Rive-Sud Incorporée \u2014 South Shore Construction Incorporated\", a) réduisant son capital de $49,-000 à $25,000, par l'annulation de 240 actions de $100 chacune; 6) subdivisant les 250 actions ordinaires restantes en 2500 actions de $10 chacune; c) portant le capital-actions de la compagnie de $25,000 à $175,000.le nouveau capital étant divisé en 15,000 actions privilégiées de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 17 avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.D.& D.Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 1er mai 1953, à la compagnie \"D.& D.Holdings Inc.\", augmentant son capital de $830,000 à $1,130,000; le capital-actions additionnel étant divisé en 3,000 actions privilégiées catégorie C de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 1er mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSIXETS.1953, to \"Construction Rive-Sud Incorporée \u2014 South Shore Construction Incorporated\", a) reducing its capital stock from $49,000 to $25,000, by the cancelling of 240 shares of $100 each; b) subdividing the remaining 250 common shares into 2500 shares of $10 each; c) increasing the capital stock of the company from $25,000 to $175,000, the new capital being divided into 15,000 preferred shares of $10 each.Dated at the office of the Attorney General the seventeenth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.D.& D.Holdings Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 1st day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by M.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276 to the company \"D.& D.Holdings Inc.\", increasing its capital from $830,000 to $1,130,000; the additional capital stock being divided into 3,000 Class C.preferred shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General the 1st day of May, 1953., L.DÉSIXETS, 34903-o Deputy Attorney General.Denault Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnie de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 23 avril 1953, à la compagnie \"Denault Limitée\", portant son capital-action de $20,000 à $50,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 23 avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Diamond Taxicab Association Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 20 avril 1953, à la compagnie \"Diamond Taxicab Association Limited\", augmentant son capital par la création de 2,500 actions privilégiées de $100 chacune, fixant à la somme de $38,200 le montant avec lequel la compagnie continuera ses opérations à l'avenir, et modifiant les conditions relatives au transfert des actions.Daté du bureau du Procureur général le 20 avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.DriscoU Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Denault Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date, April 23rd, 1953, to \"Denault Limitée\", increasing its capital stock from 20,000 to $50,-000: the additional capital stock being divided into 300 common shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, April 23rd, 1953.L.DÉSDLETS, 34903 Deputy Attorney General.Diamond Taxicab Association Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity .with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, bearing date April 20, 1953, to \"Diamond Taxicab Association Limited\", increasing its capital by means of an issue of 2,500 preferred shares of $100 each, and establishing at $38,200 the amount with which the company shall continue to operate in future, and modifying the conditions concerning the transfer of shares, Dated at the office of the Attorney General, April 20th 1953.L.DÉSILETS, 34003 Deputy Attorney General.Driscoll Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 80th, 1968, Vol.86, No.22 1797 été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 7 mai 1953, à la compagnie \"Driscoll Limited\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général le 7 mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o L.DÉSILETS.Dufrcsne & Laferrifcre Limitée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies dc Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 18 avril 1953, changeant le nom de la compagnie \"Laferrière & Dufrcsne Limitée\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 20 février 1953, en celui de \"Dufresne & Laferrière Limitée\".Daté du bureau du Procureur général le 18 avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903-o \u2022 L.DÉSILETS.letters patent, bearing date the seventh day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, bearing date May 7th, 1953, to the company \"Driscoll Limited\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, the 7th day of May, 1953.L.DÉSILETS, ' 34903 Deputy Attorney General.Dufresne & Laferrière Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, bearing date the eighteenth day of April 1953, changing the name of \"Laferrière & Dufresne Limitée\", a company incorporated under said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent bearing date the twentieth day of February 1953, into that of \"Dufresne & Laferrière Limitée\".Dated at the office of the Attorney General, the eighteenth day of April 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.E.H.Palmer & Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 1er mai 1953, changeant le nom de la compagnie \"Delta Industries Ltd.\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie dc la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes datées du 29 janvier 1951, en celui de \"E.H.Palmer & Co.Ltd.\" Daté du bureau du Procureur général, le 1er jour de mai 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.E.H.Palmer & Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 1st day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, changing the name of the company \"Delta Industries Ltd.\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent dated January 29, 1951, to that of \"E.H.Palmer & Co.Ltd.\".Dated at the office of the Attorney General the 1st day of May, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Fcnton Needlecraft Machines Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur dc la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, chapitre 276, «.S.R.Q.1941 des lettres patentes supplémentaires en date du 25 avril 1953, à la compagnie \"Fenton Steam Specialty Manufacturing Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes datées du 6 novembre 1945, en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnie de Québec, 1° changeant son nom en celui de \"Fenton Needlecraft Machines Ltd.\"; 2° augmentant son capital de $20,000 à $40,000 par la création de 4,000 actions privilégiées de $5 chacune; 3° subdivisant les 200 actions ordinaires de $100 en 4,000 actions ordinaires de $5 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 25 avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Fenton Needlecraft Machines Ltd., Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of April, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"Fenton Steam Specialty Manufacturing Company Limited\", incorporated by letters patent dated November 6, 1945, under the said Part I of the Quebec Companies' Act, 1.changing its name to that of \"Fenton Needlecraft Machines Ltd.\"; 2.increasing its capital from $20,000 to $40,000 by the creation of 4,000 preferred shares of $5 each; 3.subdividing the 200 common shares of $100 into 4,000 common shares of $5 each.Dated at the office of the Attorney General the 25th day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General. 1798 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 mai 195S, Tome 85, N° 22 La Chambre de Commerce des Jeunes de Nicolct Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément -à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 7 mai 1953, changeant le nom de la corporation \"Le Club Commercial dc Nicolet, Inc.\", constituée en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite loi par lettres patentes en date du 28 octobre 1942, en celui de \"La Chambre de Commerce des Jeunes de Nicolct Inc.\".Daté du bureau du Procureur général le 7 mai 1953.L'Assistant-procureur général.34903-o L.DÉSILETS.McFarlane Realty Co., Limited Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Srovince de Québec, représenté par M.C.La-lichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 23 avril 1953, à la compagnie \"McFarlane Realty Co., Limited\" diminuant son capital de 8135,000 à 8126,000 par l'annulation de 9,000 actions privilégiées de $1 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 23 avril 1953.\u2022 L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Montreal Packing Co.Ltd.Salaison Montréal Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du lie jour d'avril 1953 à la compagnie \"Thai's Limited\", constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes datées du 4 novembre 1949.1° augmentant son capital dc $40,-000 à $100,000: le capital-actions additionnel étant divisé en 6,000 actions privilégiées dc $10 chacune; 2° changeant le nom de la compagnie en celui de \"Montreal Packing Co.Ltd.\u2014 Salaison Montréal Ltée\".Daté du bureau du Procureur général, le lie jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Palmers Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la Ërovince de Québec, représenté par M.C.La-ichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276 dés lettres patentes supplémentaires en date du 18 avril 1953, à la compagnie \"Palmers Limited\", diminuant son capital par l'annulation de 1,000 actions privilégiées de $100 chacune.La Chambre de Commerce des Jeunes de Nicolet Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the seventh day of May, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the corporation \"Le Club Commercial de Nicolet, Inc.\", incorporated under the provisions of Part III of the said Act, by letters patent dated October twenty-eighth, 1952, changing its name into that of \"La Chambre de Commerce des Jeunes de Nicolet Inc.\".Dated at the office of the Attorney General, the seventh dav of Mav, 1953.L.DÉSILETS, 34903 Deputy Attorney General.McFarlane Realty Co., Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of April, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, repicsented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"McFarlane Realty Co., Limited\", reducing its capital from $135,000 to $126,000 by the cancellation of 9,000 preferred shares of $1 each.Dated at the office of the Attorney General the 23rd day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Montreal Packing Co.Ltd.Salaison Montréal Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th day of April.1953, were issued by the Lieutenant Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Thai's Limited\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act by letters patent dated November 4, 1949.1° increasing its capital from $40,000 to $100,000: the additional capital stock being divided into 6,000 preferred shares of $10 each; 2° changing the name of the company to that of \"Montreal Packing Co.Ltd.\u2014 Salaison Montréal Ltée\".Dated at the office of the Attorney General the 11th day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Palmers Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 18th day of April, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Palmers Limited\", reducing its capital by the cancellation of 1,000 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May SOth, 1963, Vol.86, No.M 1799 Daté du bureau du Procureur général, le 18 avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Ross Bros.Inc.Avis est donné qu'en vertu de 'a première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 24e jour d'avril 1953, à la compagnie\" Ross-Garrison Incorporated\", constitutée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 15 mars 1946, changeant son nom en celui de \"Ross Bros.Inc.\".Daté du bureau du Procureur général, le 24c jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Sanitizor Distributors (Quebec) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province dc Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q., 1941, chapitre 276.des lettres patentes supplémentaires en date du 8e jour d'avril 1953 à la compagnie \"Sanitizor Distributors (Quebec) Ltd.\", 1° diminuant son capital de 85,000 à 52,000: le capital-actions annulé étant divisé en 30.action de 8100; 2° augmentant ledit capital de $2,000 à $62,000:1e capital-actions additionnel étant divisé en 600 actions privilégiées de 8100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 8e jour d'avril 1953.L'Assistant-procureur général, 34903 L.DÉSILETS.Sherbrooke News Company Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière.conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 29 avril 1953, à la compagnie \"Sherbrooke News Company Incorporated\", augmentant son capital dc $20,000 à $80,000, le nouveau capital-actions étant divisé en 0,000 actions privilégiées de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 29 avril 1953.L'Assista nt-procu reu r général, 34903 L.DÉSDLETS.Dated at the office of the Attorney General the 18th day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Ross Bros.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary leteers patent, bearing date the 24th day of April, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act.R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Ross-Garrison Incorporated\", incorporated under the said Part I of the Quebec Companies' Act, by letters patent dated March 15, 1946, changing its name to that of \"Ross Bros.Inc.\".Dated at the office of the Attorney General the 24th day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Sanitizor Distributors (Quebec) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of April, Û953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Sanitizor Distributors (Quebec) Ltd.\", 1.reducing its capital from 85,000 to $2,000: the capital stock cancelled being divided into 30 shares of $100: 2.increasing such capital from $2,000 to $62,000: the additional -capital stock being divided into 600 preferred shares of $100.Dated at the office of the Attorney General the 8th dav of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.Sherbrooke News Company Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of April, 1953, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Sherbrooke News Company Incorporated\", increasing its capital from 820,000 to $80,000, the new capital stock being divided into, 6000 preferred shares of $10 each.Dated at the office of the Attorney General the 29th day of April, 1953.L.DÉSILETS, 34903-o Deputy Attorney General.St.Lawrence Ceramics Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.C.LaRichelière, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 14 avril 1953, à la compagnie \"St.Lawrence Ceramics Ltd.\", portant son capital de 8600,000 à $900,- St.Lawrence Ceramics Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.C.LaRichelière, in conformity with section 2, of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, bearing date the fourteenth day of April 1953, to the company- \"St.Lawrence Ceramics Ltd.\", increasing its capital from $600,- 1800 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 mai 1953, Tome 85, N° 22 000: le capital-actions additionnel étant divisé 000 to 8900,000: the additional capital stock en 3,000 actions ordinaires de $100 chacune.being divided into 3,000 common shares of $100 each.Daté du bureau du Procureur général le 14 Given at the office of the Attorney General, avril 1953.the 14th of April 1953.L'Assistant-procu reu r général, L.DÉSIXETS, 34903-o L.DÉSDLETS.34903 Deputy Attorney General.Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 024 Québec, le 20 mai 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXEUCUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 624 Quebec, May 20, 1953.Present: The Lieutenant-Govemor-in-Coun^il.Concernant la soustraction au jalonnement de Concerning the withdrawal of staking of cer-certains terrains miniers le long du chemin de tain mining lands bordering the railroad line fer Quebec North Shore and Labrador Railway.of the Quebec North Shore and Labrador Railway.Attendu que Quebec North Shore and La- Whereas the Quebec North Shore and Labra-brador Railway Company Limited construit un dor Railway Company Limited is building a chemin de fer à partir du rivage du fleuve St- railroad starting from the banks of the St.Law-Laurent, d'un point situé sur le lot 45 du rang I rence River, a point situate on Lot 45, Range I, du village des Sept-IIes et se dirigeant vers le of the village of Seven-Islands, running north-nord jusqu'au territoire du, Nouveau-Queoec, wards as far as the New Quebec area, in the district électoral de Saguenay; la compagnie electoral district of Saguenay; the Company is soumet que le jalonnage en claims miniers, la of the opinion that the staking of mining claims, prospection et toute activité minière sur les prospecting^ and all mining activities on lands terrains traversés par son chemin de fer seraient traversed by the railroad, would be detrimental préjudiciables à l'exploitation paisible et à la to the peaceful working and security of opera-sécurité des opérations, plus particulièrement tions, more especially within the limits of the dans les limites de la municipalité de la ville des municipality of the town of Seven-Islands, where Sept-IIes, où se trouve son terminus et port its terminal point and shipping port are located, d'expédition.La Compagnie soumet en plus Moreover, the Company proposes that quarries qu'il faut ouvrir des carrières de place en place should be opened up from place to place, in pour assurer l'approvisionnement de pierre order to ensure the necessary 'supply of stone nécessaire à la construction de la sous-structure for the construction or under-structure of the du chemin de fer; railroad; Attendu Qu'elle désire éviter de transiger Whereas it is desirous to avoid dealing with avec des détenteurs de claims miniers jalonnés holders of mining claims staked for the sole pour les seules fins de vendre leurs droits à la purpose of selling their rights to the Company; compagnie; Attendu Qu'à ces fins, la requérante demande Whereas for said purposes, the petionner de réserver à la Couronne et de soustraire au requests that the Crown reserve and withdraw jalonnement en claims miniers certains terrains from the staking out of mining claims, certain faisant partie de la municipalité des Sept-IIes, lands forming part of the municipality of Seven-ainsi qu'une lisière excédant en largeur l'emprise Islands, as well as a strip of land exceeding in de la voie ferrée en dehors de la municipalité; width that of the railroad line, outside the limits of the municipality; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette Whereas it is expedient to accede to this requête, afin d'éviter toute entrave à l'exécution request, in order to avoid hindering the carrying d'une entreprise considérable et nécessaire au out of a large undertaking, necessary for the développement de l'industrie minière dans le development of the mining- industry in New Nouveau-Québec.Quebec.Vu l'article 227, paragraphe 7, de la Loi des In view of Section 227, paragraph 7 of the Mines de Québec, permettant au lieutenant- Quebec Mining Act, authorizing the Lieutenant-gouverneur en conseil de réserver et soustraire Governor in Council to reserve or withdraw the au jalonnement en claims miniers les terrains staking out of any land, which in his opinion, qui, dans son opinion, peuvent être requis ou may be required or found necessary for the nécessaires pour les fins y spécifiées et autres fins, purposes herein specified, or for any other purposes, Il est ordonné en conséquence, sur la pro- It is therefore ordained, upon the recomposition de l'honorable Ministre des Mines: mendation of the Honourable Minister of Mines: a) Que les lots 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 et a) That Lots 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, and 47, rang I; les lots de subdivision cadastrale 47, Range I; lots.of cadastral subdivision 234 to 234 à 251 inclusivement, 392 à 427 inclusivement 251 inclusive, 392 to 427 inclusive; lots 10 to les lots 10 à 16 inclusivement, rang III, village 16 inclusive, Range III, village of Seven-Islands; des Sept-Res; les lots 16 à 20 inclusivement, lots 16 to 20 inclusive, Range I; lots 19 to 26 in-rang I; les lots 19 à 26 inclusivement, rang II, elusive, Range II, township of Letellier; canton de Letellier; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 80th, 1953, Vol.85, No.22 1801 6) Que l'étendue de grève sur une largeur d'un demi-mille en front des lots 39 à 47 inclusivement du rang I, y compris les lots de grève 2 et 3, du lot 16, rang III, village des Sept-Iles, des lots 16 à 20 inclusivement, rang I, canton de Letellier; c) Qu'une étendue d'une largeur de quinze cents pieds de chaque côte du centre de l'emprise du chemin de fer à partir de l'extrémité Est du lot 21, rang II, canton de Letellier, et en suivant cette emprise vers le Nord jusqu'à la ligne de séparation des eaux du versant laurentien, soient soustraits à la prospection et au jalonnement de claims miniers pour une période de trois ans à compter de la date de la publication du présent arrêté ministériel dans la Gazette officielle de Québec, à l'exception des claims présentement reconnus jusqu'à leur expiration ou leur renouvellement.(signé) C.LARICHELIÈRE, 34926-0 Greffier Suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF^ Numéro 620 Québec, le 20 mai 1953.Présent: Le Lieutenant Gouverneur en Conseil Section \"B\" Concernant des modifications au décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuses dans la région des Trois-Rivières.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Status refondus de Québec, 1941, chapitre 163 «et amendements), le Comité paritaire des barbiers, coiffeurs et coiffeuses des Trois-Rivières et district à présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'amender la section \"A\" du décret numéro 1040 du 4 août 1948 amendé par les arrêtés numéros 471-E, 829-C et 1000-C des 26 avril, 12 juillet et 6 septembre 1950, 172-B, 425-A et 735-D des 15 février, 19 avril et 12 juillet 1951, 788-E du 23 juillet 1952 et 253-E du 5 mars 1953, relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuses dans la région des Trois-Rivières; Attendu que ladite requête à été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 21 mars 1953; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulé contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 1040, soit modifié comme suit: 1° L'alinéa intitulé \"Zone III\" apparaissant au paragraphe \"6\" de l'article II, est remplacé par le suivant: \"Zone III: La ville de Louiseville et le village de Maskinongé et un rayon de deux (2) milles de leurs limites.\" 2° Dans le zone III, les prix minima des services se rapportant à la coupe des cheveux et de la barbe sont remplacé par les suivants: Barbe (tous les jours).$0.30 Coupe de cheveux pour adultes: Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.0.55 Samedi et veilles des fêtes chômées et les trois jours précédant Noël, le Premier de l'An et Pâques.0.60 b) That the beach area, one half mile wide in frontage of lots 39 to 47 inclusive, of Range I, including beach lots 2 and 3, of lot 16, Range III, village of Seven-Islands, lots 16 to 20 inclusive, Range I, township of Letellier; c) That an area fifteen hundred feet wide on each side of the centre of the right-of-way of the railroad, starting from the extreme eastern part of lot 21, Range II, township of Letellier, and following this right-of-way northwards, as far as the height-of-Land of the waters Slowing into the Laurentian Basin, be withdrawn from prospecting and staking out of mining claims for a period of three years, as from the date of publication of this Order in Council in the Quebec Official Gazette, with the exception of claims now recognized, up to the time of expiry or renewal.(Signed) C.LARICHELIÈRE, 34926 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTD7E COUNCEL CHAMBER Number 620 Quebec, May 20, 1953.Present: The Lieutenant Governor in Council .Part \"B\" Concerning amendments of the decree relating to the barber and hairdressing trades in the district of Trois-Rivières; Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Parity Committee of Barbers, Male and Female Hairdressers of the District of Trois-Rivières has submitted to the Minister of Labour a petition to amend part \"A\" of the decree No.1040 of August 4, 1948, as amended by Orders 471-E, 829-C and 1000-C of April 26, July 12 and September 6, 1950, 172-B, 425-A and 735-D of February 15, April 19 and July 12, 1951, 788-E of July 23, 1952,and 253-E of March, 5, 1953,relating to the barber and hair-dressing trades in the district of Trois-Rivières; Whereas the said petition has been publish in the Quebec Official Gazette, issue of March, 21, 1953; Whereas no objection has been raised against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the said decree, number 1040 be amended as follows: 1.The paragraph headed \"Zone HI\", contained in subsection \"b\" of section n, is replaced by the following: \"Zone III: The town of Louiseville and the village of Maskinongé and a radius of two (2) miles from their limits.\" 2.In zone HI, the minimum prices of haircut and shave services are replaced by the following: Shave (every day).80.30 Haircut for adults : Monday, Tuesday, Wednesday, Thrus- day and Friday.0.55 Saturday and holiday eves and the three days preceding [Christmas, New-Years' Day and Easter Sunday.0.60 1802 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quégec, 80 mai 1953, Tome 85, N° 22 Coupe de cheveux en brosse, pour adultes: Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.0.75 Samedi et veilles des fêtes chômées.0.80 Coupe de cheveux pour enfants de moins de 15 ans: Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi .0.30 Samedi et veilles des fêtes chômées.0.35 Coupe de cheveux en brosse, pour enfants 0.50\" 3° Les heures de travail pour la zone III apparaissant au paragraphe \"a\" de l'article V, sont remplacées par les suivants: \"Zone III: Barbiers et coiffeurs: Le lundi: de 8.00 a.m.à midi Les mardi, mercredi et jeudi: de 8.00 a.m.à 7.00 p.m.Le vendredi: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.Les samedi: de 8.00 a.m.à 0.00 p.m.Les veilles de fêtes chômées: de 8.00 a.m.à 9.00 p.m.I^es trois jours précédant le jour de Noël, le Premier de l'An et le jour de Pâques: de S.00 a.m.à 9.00 p.m.\" 4° L'alinéa suivant est ajouté à la suite de l'énumération des heures de travail pour la zone III : \"Pour le samedi seulement: Seul.le travail commencé sur un client avant la fin des périodes de travail ci-haut stipulées peut être terminé.\" (Document \"B\" annexé à l'arrêté) Le Greffier suppléant du Conseil Exécutif, 34912-0 C.LARICHELIÈRE.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 620 Québec, le 20 mai 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"C\" Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans les comtés de Jolicttc, Berthier, Montcalm et l'Assomption.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie et aux métiers de la construction dans les comtés de Joliette, Berthier, Montcalm et l'Assomption, rendue obligatoire par le décret numéro 1407 du 3 avril 1940, amande par les arrêtés numéros 146 du 24 janvier 1941, 1248 et 1904 des 27 mai et 30 juillet 1942, 147 et 154 du 22 janvier 1943, 2255 du 23 juin 1944, 1541 du 27 avril 1945, 2853 et 4320 des 17 juillet et 24 octobre 1946, 1116-D du 9 juillet 1947, 421-D du 30 mars 1948, 362-A et 623-E des 31 mars et 15 juin 1949, 471-A et 973-A des 26 avril et 30 août 1950, 350-A du 4 avril 1951, 556-A du 14 mai 1952 et 81-D du 21 janvier 1953, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'amender ledit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 21 mars 1953; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur Ja proposition de l'honorable Ministre du Travail: Brushcut for adults: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.0.75 Saturday and holiday eves.0.80 Haircut for children under 15 years of age: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.0.30 Saturday and holiday eves.0.35 Brushcut for children.0.50\" 3.The hours of work for zone III, as mentioned in subsection \"a\" of section V, are replaced by the following: \"Zone III: Barbers and hairdressers: Monday: 8.00 a.m.to 12.00 (noon).Tuesday, Wednesday and Thursday: 8.00 a.m.to 7.00 P.M.Friday: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.Saturday: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.Holidays eves: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.The three days preceding Christmas, New Year's Day and Easter Sunday: 8.00 a.m.to 9.00 p.m.\" 4.The following paragraph is added after the enumeration of working hours for zone III: \"For Saturday only: Only the work in progress on a customer before the end of the working periods above mentioned can be completed.\" (Document \"B\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34912-0 Acting clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 620 ?*\u2014- Quebec, May 20, 1953.Present: The Lieutenant-Governor-in-Council.Part \"C\" Concerning amendments of the decree relating to the construction industry and trades in the counties of Joliette, Berthier, Montcalm and L'Assomption.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 103 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the construction industry and trades in the counties of Joliette, Berthier, Montcalm and L'Assomption rendered obligatory by the decree number 1407 of April 3, 1940 and amended by Orders 146 of January 24, 1941, 1248 and 1904 of May 27 and July 30, 1942, 147 and 154 of January 22, 1943, 2255 of June 23, 1944, 1541 of April 27, 1945, 2853 and 4320 of July 17 and October 24, 1946, 1116-D of July 9, 1947, 421-D of March 30, 1948, 362-A and 623-E of March 31 and June 15, 1949, 471-A and 973-A of April 26 and Agust 30, 1950, 350-A of April 4, 1951 556-A of May 14, 1952 and 81-D of January 21, 1953, have submitted to the Minister of Labour a petition to amend the said decree; Whereas the said petition was published in the Quebec Official Gazette, issue of March 21, 1952; Whereas no objection was raised against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 30th, 1953, Vol.86, No.22 1803 Que ledit décret, numéro 1407, soit modifié That the said decree, number 1407, be amen\" comme suit: , ded as follows: 1° L'article III est remplacé par le suivant: 1.Section III is replaced by the following: III.Taux de salaire: Les taux de salaires \"ELL Rates of wages: The following shall be minima suivants doivent être payés pour chacun the minimum wage rates for the trades hereafter des métiers ci-après mentionnés: mentionned: Salaire horaires Métiers \u2014 Trades: Hourly rates ZONES I II Ajusteur de gicleur \u2014 Sprinkler Fitter.81.50 81.50 Briqueteur (compagnon) \u2014 Bricklayer (journeyman).1.50 1.50 Poseur de blocs et terra-cotta et tireur de joints \u2014 Block and terra-cotta layer and joint pointer.'.1.50 1.50 Apprenti \u2014 Apprentice: 1 ère année \u2014 1st year.\u2022.0.95 0.95 2ème année \u2014 2nd year.1.05 1.05 3ème année \u2014 3rd year.1.15 1.15 Brasseur dc mortier \u2014 Mortar mixer.1.20 1.15 Brasseur dc célanite \u2014 Celanite mixer.1.20 1.15 Charpentier et menuisier (compagnon) \u2014 Carpenter and joiner (journeyman) .1.50 1.40 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année \u2014 1st year.0.85 0.80 2ème année \u2014 2nd year.0.90 0.85 3ème année \u2014 3rd year.1.00 0.95 4èmc année \u2014 4th year.~.1.10 1.05 Calfat \u2014 Caulker.1.20 1.15 Couvreur d'amiante autre que les mécaniciens en isolement en tuyauterie \u2014 Asbestos coverer other than pipe insulation mechanic.1.50 1.40 Couvreur - ardoise, tuile \u2014 Roofer - slate, tile.1.50 1.40 Couvreur - composition, gravier, sable, asphalte \u2014 Roofer - composition, gravel sand, asphalt.1.50 1.40 Chauffeur de camion \u2014 Truck driver.1.20 1.10 Charretier \u2014Carter.1.15 1.10 Chauffeur (construction) \u2014 Fireman (construction).1.30 1.25 Conducteur de monte-charge \u2014 Freight elevator operator.1.15 1.15 Conducteur de tracteur \u2014 Tractor operator.1.35 1.35 Conducteur de rouleau compresseur (vapeur ou essence) \u2014 Roller operator (steam or gasoline).1.30 1.30 Conducteur de \"Bulldozer\" \u2014 Bulldozer operator.1.30 1.30 Conducteur de nivelleuse \u2014 Grader operator.1.30 1.30 Electricien (compagnon) \u2014 Electrician (journeyman).1.55 1.50 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année\u20141st year.0.85 0.80 2ème année \u2014 2nd year.0.90 0.85 3ème année \u2014 3rd year.1.00 0.90 4ème année \u2014 4th year.1.10 1.05 Ferblantier, couvreur (compagnon) ouvrier-tôlier, boutique ou chantier \u2014 Tinsmith, roofer (journeyman) sheet-metal worker, shop of job.1.50 1.45 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année\u20141st year.0.80 0.75 2ème année \u2014 2nd year.0.90 0.80 3ème année \u2014 3rd year.1.00 0.95 Finisseur de ciment \u2014 Cement finisher.1.45 1.40 Finisseur de plancher en mastic \u2014 Mastic floor finisher.1.45 1.40 Foreur et poudrier \u2014 Drill operator and blaster.1.45 1.40 Forgeron sur chantier \u2014 Blacksmith on job.1 -45 1.40 Journalier (ouvrier non qualifié) \u2014 Labourer (common worker).1 -10 1.05 Homme de chaudière (boilennan) \u2014 Boilerman.1.10 1.05 Gratteur, polisseur et sableur de plancher \u2014 Floor scraping, polishing and sanding employees.'.1-50 1.40 Gréeur (à la main ou machine)\u2014Rigger (hand or machine).1.50 1.40 Limeur de scie \u2014 Saw filer.1-50 1.45 Lettreur pour fins commerciales \u2014 Commercial letterer.1.60 1.60 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année\u20141st year.0.90 0.90 2ème année \u2014 2nd year.9.95 0.95 3ème année \u2014 3rd year.110 1.10 4ème année \u2014 4th year.1.20 1.20 Manœuvre, porteur de brique, bloc, mortier, terra-cotta que ce soit à l'oiseau ou à la brouette, ou à la chaudière \u2014 Labourer, brick, block, mortar and terra-cotta carrier with hod, wdieelbarrow or pail.1-20 1.15 Machiniste (millwright) \u2014 Millwright.' \u2022 50 1.40 Mécanicien en isolation de tuyauterie \u2014 Pipe insulation mechanic.1-50 1.40 Mécanicien de machine fixe ou mobile \u2014 Stationary or portable engineman.1.20 1.15 Peintre-doreur \u2014 Painter-gilder.1-50 1.40 1804 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 mai 1953, Tome 86, N° 22 Peintre, aspergeur, décorateur, vitrier, poseur de papier-tenture et vernisseur de plancher (compagnon) \u2014 Painter, sprayman, decorator, glazier, paper hanger, floor varnisher (journeyman).1.35 1.25 Apprentice \u2014 Apprentice : 1ère année\u20141st year.0.85 0.80 2ème année \u2014 2nd year.0.90 0.85 3ème année \u2014 3rd year.0.95 0.90 4ème année \u2014 4th year.1.05 1.00 Plâtrier (compagnon) \u2014 Plasterer (journeyman).1.50 1.50 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année \u2014 1st year.0.90 0.90 2ème année \u2014 2nd year.1.00 1.00 3ème année \u2014 3rd year.1.10 1.10 Préposé aux sonnettes (bois ou béton) \u2014 Pile driver operator (wood or concrete).1.25 1.15 Plombier, poseur d'appareil de chauffage, mécanicien en tuyauterie, poseur de brûleur à l'huile (compagnon) \u2014 Plumber, steamfitter, pipe mechanic, oil burner mechanic (journeyman).1.50 1.45 Apprenti \u2014 Apprentice: 1ère année\u20141st year.0.80 0.75 2ème année \u2014 2nd year.,.0.90 0.80 3ème année \u2014 3rd year.1.00 0.90 4ème année \u2014 4th year.1.10 1.00 Compagnon junior.1.25 1.15 Préposé aux compresseurs \u2014 Compressor operator.1.30 1.25 Poseur de lattes en métal ou de composition \u2014 Lather, metal or composition.1.35 1.35 Poseur de lattes en bois \u2014 Lather, wood.1.25 1.20 Préposé aux malaxeurs à vapeur ou gasoline \u2014 Steam or gasoline mixer operator .1.30 1.20 Préposé aux malaxeurs à l'électricité ou au petit malaxeur à gazoline \u2014 Electric or small gasoline mixer operator.1.20 1.10 Préposé aux bouilloires (travail de plancher seulement) \u2014 Boiler man (flooring only) 1.20 1.10 Préposé aux machines à polir le terrazzo (machine à sec) \u2014 Terrazzo polishing machine operator (dry).1.30 1.20 Préposé aux machines à polir le terrazzo (machine à l'eau) \u2014 Terrazzo polishing machine operator (wet).1.30 1.20 Préposé aux grues \u2014 Crane operator.1.30 1.20 Préposé aux pelles mécaniques \u2014 Power shovel operator:.1.55 1.45 Poseur d'acier d'armature \u2014 Reinforcing Steel erector.1.35 1.35 Poseur de liège (isolation) \u2014 Cork setter (insulation).1.50 1.40 Poseur de planchers en mastic \u2014 Mastic floor layer.1.50 1.40 Poseur de tuile, asphalte et terrazzo \u2014 Tile, asphalt and terrazzo layer.1.50 1.40 Poseur de marbre \u2014 Marbre layer.1.50 1.40 Soudeur en tuyauterie (acétylène ou électricité) \u2014 Pipe welder (acetylene or electricity).1.50 1.40 Surveillant employé également comme chauffeur et devant posséder un certificat de la 4ième classe (sans limite de la durée journalière de travail) maximum de 72 heures \u2014 Watchman employed also as fireman and required to hold a 4th class certificate (without daily limitation of duration of work) weekly maximum, 72 hours 1.18 1.08 Gardien sur le chantier, nuit et jour, sans limite de la durée quotidienne de travail, maximum hebdomadaire, 72 heures \u2014 Watchman on the job, night and dày (without daily limitation of duration of work) weekly maximum, 72 hours.0.75 0.75 Chauffeur de bouilloire devant posséder un certificat de 4ième classe \u2014 Boiler fireman required to hold a 4th class certificate.1.18 1.08 Porteur d'eau \u2014 Water carrier.1.00 0.90 Ratisseur d'asphalte \u2014 Asphalt raker.1.10 1.00 Pilonneur, lisseur et épandeur d'asphalte \u2014 Men committed to the ramming smoothing and spreading of asphalt._.1.10 1.00 Préposé à la canalisation, mateur et soudeur \u2014 Men commitcd to the piping, caulking and welding.1.10 1.00 Les contremaître préposés à la surveillance Foremen in charge of a group of three or d'une équipe d'hommes doivent être rémunérés more men shall be paid 80.10 more per hour au taux de $0.10 l'heure de plus que le salaire than the rate established for the trade concerned.\" établi pour le métier quand il y a trois hommes ou, plus.\" 2° L'article XIII est remplacé par le suivant: 2.Section XIU is replaced by the following: \"XIII.Durée du décret: Le présent décre \"XIII.Duration of the decree: The present demeure en vigueur jusqu'au 28 février 1955.decree remains in force until February 28, 1955.Il se renouvelle automatiquement d'année en It then renews itself automatically from year année par la suite, à moins que l'une des parties to year unless one of the contracting parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis notifies the other party, in writing, to the con- écrit à ce contraire dans un délai qui ne doit pas trary within the period extending, from the être de plus de soixante (60) ni de moins de sixtieth to the thirtieth day before February 28, trente (30) jours avant le 28 février 1955 ou de of the year 1955 or of any subsequent year, toute année subséquente.Un tel avis doit Such a notice shall also be forwarded to the également être adressé au Ministre du Travail.\" Minister of Labour.\" (Document \"C\" annexé à l'arrêté) (Document \"C\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, C.LARICHELIÈRE, 34912-0 Greffier suppléant du Conseil Exécutif.34912-0 Acting Clerk of the Executive Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May SOth, 1953, Vol.85, No.22 1805 ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 614 Québec, le 20 mai 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Section \"C\" Concernant l'abrogation du décret relatif aux employés d'épiceries, de boucheries et de restaurants-épiceries dans la cité de Sherbrooke .et un rayon de dix (10) milles de ses limites.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que le décret numéro 2331 du 17 juin 1940, relatif aux employés d'épiceries, de boucheries et de restaurants-épiceries dans la cité, de Sherbrooke et un rayon de dix (10) milles de ses limites, dans sa teneur modifiée, soit annulé et abrogé à toutes fins que de droit à compter du 15 mai 1953.(Document \"C\" annexé à l'arrêté).C.LARICHELIÈRE, 34912-o Greffier suppléant du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 614 Québec, le 20 mai 1953.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil Section \"A\" Concernant des modifications au décret relatif aux débardeurs, navigation océanique, dans le Port de Québec.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux débardeurs, navigation océanique, dans le Port de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 728 du 7 juillet 1949, amendé par l'arrêté en conseil numéro 1047-A du 19 septembre 1951, ont présenté au Ministre du Travail, une requête à l'effet d'amender ledit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 4 avril 1953; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Premier Ministre, Que ledit décret numéro 728, soit modifié comme suit: 1° Les paragraphes \"a\", \"6\", \"c\" et \"i\" de l'article II, sont remplacés par les suivantes: \"a) Les heures de travail sont répartie entre 8.00 a.m.et midi et entre 1.00 p.m.et 5.00 p.m.durant lesquelles le taux de salaire régulier est de 81.61 l'heure.Lorsque les hommes sont requis de commencer à 7.00 a.m., ils reçoivent salaire double entre 7.00 a.m.et 8.00 a.m.Tout travail exécuté entre 5.00 p.m.et 7.00 a.m.est rémunéré à raison de salaire et demi, et celui exécuté le dimanche, à raison de salaire double.b) Lorsque les débardeurs sont requis de travailler pendant les heures des repas, ils doivent ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 614 Quebec, May 20, 1953.Present: The Lieutenant Governor in Council.Part \"C\" Concerning the abrogation of the decree relating to grocery, butcher shop and restaurant-grocery employees in the City of Sherbrooke and a radius of ten (10) miles from its limits.It is ordered, on the recommendation of the Honourable the Minister of Labour, That the decree No.2331 of June 17, 1940, relating to grocery, butcher-shop and restaurant-grocery employees in the city of Sherbrooke and a radius of ten (10) miles from its limits, as amended, be annulled and repealed for all purposes of the law, from May 15, 1953.(Document \"C\" annexed to the Order) C.LARICHELIÈRE, 34912-0 Acting Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 614 Quebec, May 20, 1953.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Part \"A\" Concerning amendments of the decree relating to longshoremen, ocean navigation, in the Harbour of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to longshoremen, ocean navigation, in the Harbour of Quebec, rendered obligatory by the decree number 728 of July 7, 1949, and amended by Order in Council N° 1047-A of September 19, 1951, have submitted to the Minister of Labour a petition to amend the said decree: Whereas the said petition was published in the Quebec Official Gazette, issue of April 4, 1953; Whereas no objection was made against its approval; It is orperer, therefore on the recommendation of the Honourable Prime Minister That the said decree, number 728, be amended as follows: 1.Subsections \"a\" \"6\" \"c\" and \"i\" of section II, are replaced by the following: \"a) Working hours shall be from 8.00 a.m.until 12.00 noon, and from 1.00 p.m.until 5.00 p.m., during which time the regular rate of pay shall be 81.61 per hour.If men are required to start work at 7.00 a.m., they shall be paid at double rate between 7.00 a.m.and 8.00 a.m.For work performed during the hours of 5.00 p.m.and 7.00 a.m.the rate of pay shall be time and a half and for work performed on Sundays the rate of pay shall be double time.b) When longshoremen are required to work any meal hour, they shall receive double time 1806 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Rome S5, N° 22 recevoir salaire double, et ce, pour chaque heure subséquente jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés.Les dimanches et jours de fête mentionnés au paragraphe \"c\" du présent article, cependant, le taux «le rémunération pour les heures des repas doit être dc salaire et demi basé sur le taux de salaire fixé pour ces jours.Les heures des repas sont les suivantes; de 7.00 a.m.à 8.00 a.m., de midi à 1.00 p.m., de 6.00 p.m.à 7.00 p.m., de minuit à 1.00 a.m.Cependant, lorsque l'arrivée ou le départ d'un paquebot nécessite la manipulation des bagages, dc la malle, des messageries et des passerelles, de midi à 1.00 p.m., de 6.00 p.m.à 7.00 p.m.et de minuit à 1.00 a.m., le taux double doit être payé pour ces heures mais le taux simple s'applique par la suite.Lorsque le travail se fait sur un vaisseau le jour et la nuit, par équipe, le taux simple est payé pour toutes les heures du jour et de la nuit, y compris les dimanches et jours de fêtes, mais non cependant pour les heures des repas suivantes: de 7.00 a.m.à 8.00 a.m.et de 6.00 p.m.à 7.00 p.m.c) Tout travail exécuté les dimanches, le jour de la Saint-Jean-Baptistc, le jour de la Confédération et la Toussaint doit être rémunéré à raison de salaire double.Les hommes ne sont pas requis de travailler le jour de la Fête du Travail excepté pour la manutention de la malle, des bagages et des messageries et pour le service des vaisseaux à passagers, où le taux de salaire est boublé.ï) Subordonnémcnt au paragraphe \"a\" ci-haut, les heures de commencement du travail sont à 8.00 a.m., 10.00 a.m., 1.00 p.m., 3.00 p.m., 7.00 p.m.et 1.00 a.m.; les appels pour 8.00 a.m.et 1.00 p.m.doivent être signifiés deux (2) heures à l'avance tandis que les appels pour 10.00 a.m., 3.00 p.m., 7.00 p.m.et 1.00 a.m.doivent être signifiés trois (3) heures à l'avance.Cependant, lorsqu'il y a pénurie de groupes organisés de travailleurs et lorsqu'il y a des hommes disponibles à l'heure du commencement du travail, l'employeur a le droit de former un groupe et dc le mettfe au travail sans donner l'avis ci-haut mentionné.\" 2° Les mots suivants sont ajoutés au paragraphe 11° de l'article V: \"Les employeurs ont le droit de se servir de manipulateurs de grain automatiques.\" .3°^ Le paragraphe 19° de l'article V est remplacé par le suivant: \"19° Un minimum de quatre (4) hommes à chaque baille doit être employé lors du changement ou du déchargement de lest.\" 4° Le paragraphe 24°.de l'article V est remplacé par le suivant: \"24° Pour le déchargement de farine ou autre marchandise en sacs, la hauteur de l'empilage est la suivante: hauteur Sacs de moins de cent ( 100)livres.7 sacs Sacs de cent (110) à cent quarante (140) livres.5 sacs Sacs de plus de cent quarante (140) livres.4 sacs Sacs de plus de deux cents (200) livres.3 sacs 5° Les alinéas \"d\" et \"e\" du paragraphe 26° de l'article V, sont remplacés par les suivants: \"d) Pour le chargement de bois de soutènement, la chaîne de serrage ne doit pas excéder quinze (15) pieds de longueur.Pour le chargement de bois de pulpe, la chaîne ne doit pas excéder vingt-trois (23) pieds de longueur.\" \"e) La charge de l'élingue pour le chargement de bois de bouleau à papier en ballots ne at the prevailing rate of wages and for each succeeding hour until discharged, except that on Sundays and holidays mentioned in subsection \"c\" hereof, the rate for working meal hours shall be time-and-half the rate paid for such days.Meal hours shall be from 7.00 a.m.to 8.00 a.m., 12.00 noon to 1.00 p.m., 6.00 p.m.to 7.00 p.m., 12.00 midnight to 1.00 a.m.However, when the arrival or departure of passager vessels makes it necessary to start handling baggage, mail, express and gangways between 12.00 noon and 1.00 p.m., 6.00 p.m.and 7.00 p.m.ami midnight and 1.00 a.m.during which time, double the prevailing rate shall be paid and regular prevailing rate thereafter.When any vessel is worked day and night on shifts, straight time shall be payable during any day and night hours, including Sundays and holidays, except for the meal hours between 7.00 a.m.and 8.00 a.m.and between 0.00 p.m.and 7.00 p.m.c) For work performed on Sundays, St.Jean Baptiste Day, Dominion Day and all Saints Day, the rate of pay shall be double time.Men shall not be obliged to work on Labour Day except for mail, baggage, express and attending to passenger vessels, and in which case the rate of pay shall be double time.i) Subject to subsection \"a\" above, starting times shall be 8.00 a.m., 10.00 a.m., 1.00 p.m., 3.00 p.m., 7.00 p.m., and 1.00 a.m.and two hours notice to be given for 8.00 a.m.and 1.00 p.m.calls and three hours' notice for 10.00 a.m., 3.00 p.m., 7.00 p.m.and 1.00 a.m.calls.Except when there is a shortage of organized gangs and additional labour is available at the starting time, the employer shall have the right to form a gang and put it to work without giving the notice mentioned heretofore.\" 2.The following words are added to subsection 11 of section V: \"Employers shall have the right to use automatic grain trimming machines.\" 3.Subsection 19 of section V are replaced by the following: \"19.When unloading or loading ballast, not less then 4 men to be employed on each tub.'' 4.Subsection 24 of section V is replaced by the following: \"24.When unloading flour and other bagged commodities, the height of piling shall be as follows: high Bags under 100 lbs.7 bags Bags 100 to 140 lbs.5 bags Bags over 140 lbs.4 bags Bags over 200 lbs.3 bags\" 5.^ Paragraphs \"% per annum, payable semiannually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of redemption is as follows : Tableau d'amortissement\u2014$105,000\u201415 ans.Année Capital 1er juin 1954 .xSl 1,500.00 1er juin 1955 .-.x 12,500.00 1er juin 1950 .x 13.000.00 1er juin 1957 .x 13,500.00 1er juin 1958 .x 14.000.00 1er juin 1959 .3,000.00 1er juin 1960 .3,500.00 1er juin 1901 .3,500.00 1er juin 1962 .3,500.00 1er juin 1963 .4.000.00 1er juin 1964 .4,000.00 1er juin 1965 .4,500.00 1er juin 1966'.4,500.00 1er juin 1907.5,000.00 1er juin 1968 .5,000.00 Les x indiquent les années durant lesquelles les versements d'un octroi total de $58,481.25, accordé par le Secrétaire dc la province et payable en cinq versements dc SI 1,696.25 chacun, dc 1954 à 1958 inclusivement, seront reçus et appliqués au service dc cet emprunt.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Saint-Jacques, Cté Montcalm.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procé- Table of redemption \u2014 $105,000 \u2014 15 years Year Capital June 1st, 1954.xSl 1,500.00 June 1st, 1955.x 12,500.00 June 1st, 1956.x 13,000.00 June 1st, 1957.x 13,500.00 June 1st, 195S.x 14,000.00 June 1st, 1959.\u2022 3,000.00 June 1st, 1960.3,500.00 June 1st, 1961.3,500.00 June 1st, 1902.3,500.00 June 1st, 1963.4,000.00 June 1st, 1964.4,000.00 June 1st, 1965.4,500.00 June 1st, 1966.4,500.00 June 1st, 1907.5,000.00 June 1st, 1908.'.5,000.00 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount, of S58.481.25, granted by the Provincial Secretary and payable in five instalments of SI 1.696.25 each, from 1954 to 1958 inclusively, shall be received and applied to the services of said loan.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Saint-Jacques, Cty.Montcalm.Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure, at Montreal, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 30th, 1953, Vol 85, No.22 1863 dure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Saint-Jacques, comté de Montcalm.Lesditcs obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne compred pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue jeudi, le 18 juin 1953, à 8 heures, p.m., au bureau de la Commissions colairc, 97 rue St-Jacques, Saint-Jacques, comté de Montcalm.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Jacques, (Comté de Montcalm), ce 27 mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, A.-S.-R.LESAGE.Bureau de la Commission scolaire, 97, rue St-Jacques, Saint-Jacques,(Cté Montcalm), P.Q.34945-0 Province de Québec Ville de Courville (Comté dc Québec) Avis public est par les présentes donné (pic des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, L.-P.Laplante, secret a ire -trésorier.Hôtel de Ville, 26.rue Vachon, Courville, comté dc Québec, jusqu'à 8 heures p.m., mercredi,\"le 17 juin 1953.pour l'achat de' 8130,000 d'obligations de la ville de Courville, comté de Québec, datées du 1er mai 1953 et remboursables par séries du 1er mai 1954 au 1er mai 1973 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 43^2% par année payable semi-annucllement les 1er mai et 1er novembre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement\u2014$130,000\u201420 ans Année Capital 1er mai 1954 .S4.000.00 1er mai 1955 .4,500.00 1er mai 1956 .4,500.00 1er mai 1957 .4,500.00 1er mai 1958 .5,000.00 1er mai 1959 .5,500.00 1er mai 1960.5,500.00 1er mai 1961 .5,500.00 1er mai 1962.0,000.00 1er mai 1903 .0,000.00 1er mai 1964.6,000.00 1er mai 1965.7,000,00 1er mai 1966.7,000.00 1er mai 1967 .7,500.00 1er mai 1968 .7,500.00 1er mai 1969 .8,500.00 1er mai 1970.8,500.00 1er mai 1971.9,000.00 1er mai 1972 .9,000.00 1er mai 1973 .9,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Québec.Quebec or at Saint-Jacques, county of Montcalm.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Sgtatutes of Quebec, 1941 subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be rcceemed.will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Thursday June 18,1953, at 8 o'clock p.m., at the Office of the School Commission 97, St-James Street, Saint-Jacques, county of Montcalm.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Saint-Jacques, (County of Montcalm,) Mav 27, 1953.A.-S.-R.LESAGE, Secretary-Treasurer.Office of the School Commission, 97, St-James Street, Saint-Jacques, (Cty.Montcalm), P.Q.34945 Province of Quebec Towx of cou ii ville (County of Quebec) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned L.-P.Laplante, Secretary-Treasurer, Town Hall, 26 Vachon Street, Couvil-le, County of Quebec, until 8 o'clock p.m., Wednesday, June 17th, 1953.for the purchase of an issue of 8130,000 of bonds of the Town of Courville, County of Quebec, dated May first 1953 and redeemable serially from May first 1954 to May first 1973 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4j/>% per annum, payable semi-annually on May first and November first of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may-vary according to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $130,000 \u2014 20 years Year Capital May 1st, 1954.84,000.00 Mav 1st, 1955.4,500.00 Mav 1st, 1956.4,500.00 May 1st, 1957.4,500.00 May 1st, 1958.5,000.00 May 1st, 1959.5.500.00 May 1st, 1960.5,500.00 May 1st, 1961.5,500.00 May 1st, 1962.6,000.00 May 1st, 1963.6,000.00 Mav 1st, 1964.6.000.00 Mav 1st, 1965.7,000.00 Mav 1st, 1966.7,000.00 Mav 1st, 1967.7,500.00 May 1st, 1968.7,500.00 May 1st.1969.8,500.00 May 1st, 1970.8.500.00 Mav 1st, 1971.9,000.00 Mav 1st, 1972.9,000.00 May 1st, 1973.9,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Québec. 1864 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 80 mai 1953, Tome 85, N° 22 Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal ou à Québec.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 17 juin 1953, à 8 heures p.m., à l'Hôtel de Ville, 26, rue Vachon, Courville, comté de Québec.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Courville, (Comté dc Québec), ce 26 mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, L.-P.LAPLANTE.Hôtel de Ville, 26, rue Vachon, CourvUle, (Cté Québec), P.Q.34931-0 Capital and interest are payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal or Quebec.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest matirity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday, the 17th day of the month of June 1953, at 8 o'clock p.m.,at the Town Hall, 26 Vachon Street, Courville, County of Quebec.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Courville (County of Quebec), this 26th day of May 1953.L.-P.LAPLANTE, Secretary-Treasurer.Town Hall, 26 Vachon Street, Courville, (Cty.Quebec), P.Q.54931 Province de Québec Province of Quebec Village de Pit in ce ville (Comté d'Arthabaska) Avis.public est par les présentes donné (pie des soumissions cachetées et endossées \"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, André Cloutier, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, CP.70, PrinceviUe, comté d'Arthabaska, jusqu'à 8 heures p.m., mercredi, le 17 juin 1953.pour l'achat de $65,000 d'obligations du village de PrinceviUe, comté d'Arthabaska, datées du 1er juillet 1953 et remboursables par séries du 1er juillet 1954 au 1er juillet 1968 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 4j^% par année payable semi-annuellcment les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 865,000 \u2014 15 ans Année Capital 1er juillet 1954 .S 1,000 1er juillet 1955 .1,000 1er juillet 1956 .1,000 1er juillet 1957 .1,000 1er juillet 1958 .1,000 1er juillet 1959 .1,000 1er juillet 1900 .1,500 1er juillet 1961 .1,500 1er juillet 1962 .1,500 1er juillet 1963 .1,500 1er juillet 1904 .1,500 1er juillet 1965 .1,500 1er juillet 1966 .1,500 1er juillet 1967 .2,000 1er juillet 1968 .46,500 Village of Princeville (County of Arthabaska) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned André Cloutier, secretary-treasurer, City Hall, P.O.B.70, Prince-ville, County of Arthabaska, until 8 o'clock p.m., Wednesday, June 17, 1953, for the purchase of an issue of $65,000 of bonds of the Village of Princeville, County of Arthabaska dated July 1st, 1953 and redeemable serially from July 1st, 1954 to July 1st, 1968 inclusively, with interest at a rate not less than 3% nor more than 4%% per annum, payable semi-annually on the 1st of January and the 1st of July of each year.The rate ofvinterest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.The table of recemption is as follows: Table of redemption \u2014 866,000 \u201416 years Year Capital July 1st, 1954 .$ 1,000 July 1st, 1955 .1,000 July 1st, 1956 .1,000 July 1st, 1957 .1,000 July 1st, 1958 .1,000 July 1st, 1959 .1,000 July 1st, 1960 .1,500 July 1st, 1961 .1,500 July 1st, 1962 .1,500 July 1st, 1963 .1,500 July 1st, 1964 .1,500 July 1st, 1965 .1,500 July 1st, 1966 .1,500 July 1st, 1967.2,000 July 1st, 1968 .46,500 L'adjudicataire s'engage à payer les obliga- The successful tenderer agrees to pay the tions, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par bonds, capital and accrued interest, by certified chèque visé, payable au pair à Princeville, Cté cheque, at par, at Princeville, County of Artha- Arthabaska.baska.Le capital et les intérêts sont payables à la Capital and interest are payable at the bank banque dont le nom est mentionné dans la pro- mentioned in the loan procedure, at Montreal, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 30th, 1963, Vol.85, No.22 1865 cédure d'emprunt, à Montréal, à Québec ou à Princeville, comté d'Arthabaska.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 17 juin 1953, à 8 heures p.m.à l'Hôtel de Ville de Princeville, comté d'Arthabaska.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.¦ Princeville, (Comté d'Arthabaska), ce 27 mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, ANDRÉ CLOUTIER.Hôtel de Ville, CP.70, Princeville, (Cté Arthabaska), P.Q.34944-0 Province de Québec Ville de Saint-Félicien (Comté de Lac Saint-Jean-Ouest) Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées .\"Soumissions pour obligations\" seront reçues par le soussigné, J.-C Guy, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, St-Félicien, Comté de Lac St-Jean-Ouest, jusqu'à 8 heures p.m., mercredi, le 17 juin 1953, pour l'achat de $350,000.00 d'obligations de la ville de Saint-Félicien, comté de Lac Saint-Jean-Ouest, datées du 1er juillet 1953 et remboursables par séries du 1er janvier 1954 au 1er janvier 1974 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 3% ni supérieur à 5% par année payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Le tableau d'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $350,000 \u2014 20Y2 ans.Année Capital 1er janvier 1954.$ 3,000.00 1er janvier 1955.10,500.00 1er janvier 1956.11,000.00 1er janvier 1957.11,500.00 1er janvier 1958.12,000.00 1er janvier 1959.13,000.00 1er janvier 1960.13,500.00 1er janvier 1961.14,000.00 1er janvier 1962.15,000.00 1er janvier 1963.15,500.00 1er janvier 1964.16,500.00 1er janvier 1965.17,000.00 1er janvier 1966.18,000.00 1er janvier 1967.19,000.00 1er janvier 1968.20,000.00 1er janvier 1969.21,000.00 1er janvier 1970.t.22,000.00 1er janvier 1971.22,500.00 1er janvier 1972.24,000.00 1er janvier 1973.25,000.00 1er janvier 1974.26,000.00 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par Quebec or at Princeville, county of Arthabaska.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec, 1941, subject to te reemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date: however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number._ Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday, June 17, 1953, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall of Princeville, County of Arthabaska.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Princeville, (County of Arthabaska) May 27, 1953.ANDRÉ CLOUTIER, Secretary-Trcasu rér.Town Hall, P.O.B.70, Princeville, (Cty.Arthabaska), P.Q.34944 Province of Quebec Town of St-Félicien (County of Lake St.John-West) Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds will be received by the undersigned, J.-C.Guy, Secretary-treasurer, Town Hall, St-Félicien, county Lake St.John West until, 8 o'clock P.M., Wednesday, June 17, 1953, for the purchase of an issue of $350,000 of bonds of the Town of St.Félicien, county Lake St.John-West, dated July 1st, 1953, and redeemable serially from January 1st.1954 to January 1st, 1974, inclusively, with interest at a rate of not less than 3% nor more than 5% per annum, payable semi-annually on January 1st.and July 1st.of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary acording to maturities.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 $850,000 \u2014 20]/2 years Year Capital January 1st, 1954.$ 3,000.00 January 1st, 1955.10,500.00 January 1 st, 1956.11,000.00 January 1st, 1957.11,500.00 January 1st, 1958.12,000.00 January 1st, 1959.13,000.00 January 1st, 1960.13,500.00 January 1st, 1961.14,000.00 January 1st, 1962.15,000.00 January 1st, 1963.15,500.00 January 1st, 1964.16,500.00 January 1st, 1965.17,000.00 January 1 st, 1966.18,000.00 January 1st, 1967.19,000.00 January 1st, 1968 .20,000.00 January 1st, 1969.21,000.00 January 1st, 1970.22,000.00 January 1st, 1971.22,500.00 January 1st, 1972.24,000.00 January 1st, 1973.25,000.00 January 1st, 1974.26,000.00 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if anv, 1866 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome S5, N° 22 chèque visé, payable au pair à St-Félicien, Comté Lac St-Jean-Ouest.Le capital et les intérêts sont payables à la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, à Montréal, à Québec OU à St-Félicien, comté do Lac St-Jean-Ouest.Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 «les Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute échéance d'intérêts, cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui scia tenue mercredi, le 17 juin 1953, à 8 heures p.m., à l'Hôtel de Ville de St-Félicien.comté de Lac St-Jean-Ouest.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Félicien, (Comté de Lac St-Jean-Ouest), ce 27 mai 1953.Le Secret a i rc-t résor ier, J.-C.GUY.Hôtel de Ville, Saint-Félicien, (Comté de Lac St-Jcan-Oucst), P.Q.34946-0 Vente \u2014 Loi de faillite Canada, Province dc Québec, district d'Iber-ville, N° 16, Cour Supérieure, district dc Montréal, (en matière de faillite).Dans l'affaire de Odéna Méthé et Joseph P.Méthé, faisant affaires ensemble, sous les nom et raison sociale, non enregistré, dc \"Ferme Avicole Sabrevois\", Sabrevois, P.Q., cédants autorisés.Avis public est* par les présentes, dqnné que les immeubles désignés comme suit: 1° Un terrain étant une partie du lot numéro cent trente-neuf du cadastre dc la Paroisse de St-Athanase, situé en la paroisse de Ste-Anne dc Sabrevois, mesurant cent trente-trois pieds anglais le long du Rang du Uord dc l'Eau par deux cent trente-quatre pieds anglais, dc profondeur dans la ligne Est, la ligne Nord étant en angle droit avec cette dernière ligne; avec la maison et autres constructions y érigées.Ce terrain est borné au Sud par le dit rang; en profondeur et de chaque côté par le reste du dit lot N° 139 décrit ci-après.2° Un lopin de terre situé en la Paroisse île Stc-Annc-dc-Sabrevois.connu sous le lot numéro cent dix (110) du cadastre de la paroisse de St-Georges-de-Henryville; 3° Un terrain situé au même lieu connu sous partie du lot numéro cent trente-neuf (P.139) des plan et livre dc renvoi dc la paroisse de St-Athanase, avec la maison y érigée et contenant environ deux arpents en superficie, borné: au Sud par le chemin public; à l'Est et à l'Ouest par le reste du dit N° 139 (ci-après décrit: et au nord par la partie du N° 139 de la Fabrique de Sabrevois; moins cependant la partie décrite en premier lieu ci-dessus: by certified cheque payable at par at St-Félicien, County of Lake St.John-West.Capital and interest arc payable at the bank mentioned in the loan procedure at Montreal, Quebec or at St-Félicien, county of Lake St.John-West.The said bonds are, under the authority of Chapter 212, Revised Statutes of Quebec 1941, subject to be redeemed by anticipation, in whole or in part, at par, at any interest maturity date; however, in case of partial redemption, the bonds to be redeemed will be called for payment in reverse order of maturity and serial number.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting-of the Council to be held on Wednesday the seventeenth day of the month of June, 1953, at 8 o'clock p.m., at the Town Hall of St-Félicien, county of Lake St-John-West.The Council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St-Félicien, (County of Lake St.John-West), this Mav 27, 1953.J.C.GUY, Sccretary-Trcrtsurcr.Town Hall, St.Félicien.(Cty.Lake St.John-West), P.Q.34946 Sale \u2014 Bankrupcy Act Canada, Province of Québec, District of Iberville, No.16, Superior Court.District of Montreal, (Sitting in Bankruptcy).In the affair of Odéna Méthé and Joseph P.Méthé, doing business together, under the name and style, unregistered, of \"Ferme Avicole Sabrevois\", Sabrevois, P.Q., authorized assignees.Publie notice is hereby given that the immoveables described as follows: 1.A lot of land being a part of lot number one hundred and thirty-nine on the official cadastre of the Parish of St.Athanasc, situate in the parish of Ste-Anne de Sabrevois, measuring one hundred and thirty-three English feet along de Mord de l'Eau range, by two hundred and thirty-four English feet, in depth on the eastern line, the northern line being at right angle with this latter line; with the house and other buildings thereon erected.This lot of land is bounded on the South by the said range: in depth and on each side by the rest of the said lot No.139 hereinafter described.2.A parcel of land situate in the parish of Stc-Annc-de-Sabrevois, known under lot number one hundred and ten (110) on the cadastre of the parish of St-Georges-de-Henry ville: 3.A lot of land situate at the same place known under part of lot number one hundred thirty-nine (Pt.139) on the official plan and in the book of reference of the parish of St-Athanase, with the house thereon erected and containing about two arpents in superficial area, bounded: on the south by the public highway; on the East and West, by the balance of the said No.139 (hereinafter described); and on the North, by the part of No.139 of the church property of Sabrevois; less however, the first part described hereinabove; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 30th, 1953, Vol.85, No.22 1867 4° Une terre située «au même lieu, mesurant environ quatre arpents de largeur et contenant environ ceux deux arpents en superficie (y compris le terrain décrit en troisième lieu ci-dessus), connue sous la plus grande partie du dit lot numéro cent trente-neuf (P.139) et bornée: vers le Nord par les parties du dit N° 139 de la Fabrique dc Sabrevois, de M.J.Brault et autres; vers le Sud, au chemin public et aux lots Nos 110 et 111 du cadastre de St-Gcorges de Henryville; à l'Ouest par la Rivière Richelieu.A distraire une partie du dit lot!appartenant à M.S.11.Joncs, mesurant quatre-vingt-quatorze pieds anglais le long du chemin public sur une profon-deux de deux cents pieds anglais le long du terrain de la Fabrique; A distraire aussi du dit lot numéro cent trente-neuf les parties suivantes qui appartiennent à M.Stephen II.Jones: a) Un terrain situé sur le rang du Bord de l'Eau, ayant en front quatre-vingts pieds sur ce rang et cent soixante-quinze pieds dc profondeur environ/cent vingt pieds au côté du lot N° 111 d'Henryville et une longueur de cent vingt-cinq pieds à l'Ouest et quatre-vingts pieds du côté Nord-Ouest, mesure anglaise; b) Un terrain mesurant deux cent dix-huit pieds dc largeur, borné: à l'Est par la propriété de J.Brault, d'une largeur de cent vingt-quatre pieds et quatre-vingt-quatorze pieds le long de la propriété de .M.Stephen II.Jones, enregistrée à Iberville, N° 60.006, avec borne: au Nord par les trois cent quarante pieds «le la Fabrique, à l'Ouest par cent vingt pieds et longueur en allant vers le Sud, cent vingt-cinq pieds vers l'Est et cent deux pieds vers le Sud.La borne Sud sera à environ deux cents pieds au coin Sud-Ouest dc la propriété de M.J.Brault: c) Un lopin de terre dc vingt pieds «le largeur sur le rang du Bord «le l'Eau et environ cent quarante-cinq pieds de longueur au côté de la propriété dc M.F.Bonneau se trouvant à l'Est dc ce lopin, et borné: au Nord, par le terrain décrit au paragraphe b) ci-dessus.Le tout tel que spécifié sur un plan annexé au numéro quatre mille six cent trente-deux des minutes du notaire Rodolphe Founder, et mesure anglaise.Seront vendus en bloc et comme une seule et même exploitation, en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure pour le District de Montréal, en matière de faillite, rendu le treizième jour dc mai, mil neuf cent cinquante-trois, portant le N° 16 des dossiers dc la dite Cour, aux Enchères Publiques, de manière à donner à cette vente l'effet du décret, conformément aux prescriptions de l'article 45 dc la Loi de Faillite, à la porte dc l'église Catholique paroissiale de Stc-Annc-de-Sabrevois, à Sabrevois.comté d'Iber-ville, VENDREDI, le TROISIÈME jour du mois dc JUILLET, mil neuf cent cinquante-trois, à TROIS heures dc l'après-midi (heure avancée de l'Est).Conditions dc vente dix pour cent (10%) comptant, la balance sous trois jours.Pour informations et cahier des charges, s'adresser au soussigné.\u202230 mai 1953.Le Syndic, Du bureau de: ALBERT LAMARRE.Lamaire & Inns, 10 est, rue St-Jacqucs, Montréal.34923-22-2-o 4.A farm situate at the same place measuring about four arpents in width ami containing about one hundred and two arpents in superficial area (comprised therein the lot of land as described in the third place above), known as the*largest part of the said lot number one hundred and thirty-nine (P.139) and bounded: on the North, by the parts of the said No.139 of the church property of Sabrevois, of Mr.J.Brault and others; on the South, by the Public Highway and to lots Nos.110 and 111 of the cadastre of St-Georges de Henryville; on the West, by the Richelieu River.To subtract a part of the said lot belonging to Mr.S.II.Jones, measuring ninety-four English feet along the public highway on a depth of two hun-drcd English feet along the church property; To subtract also from the said lot number one hundred and thirty-nine the following parts which belong to Mr.Stephen II.Jones: a) A lot of land situate on the Bord «le l'Eau range, having eighty feet in front on this range, and about one hundred ami seventy-five feet in depth, one hundred and twenty feet on the side of lot No.Ill of Henryville and a length of one hundred and twenty-five feet to the West and eighty feet on the northwest side, English measure; b) A lot of land measuring two hundred and eighteen feet in width hounded: on the East by the property of J.Brault, one hundred twenty-four feet in width and ninety-four feet along the property of Mr.Stephen II.Jones, registered at Iberville, No.00,006, with boundary; on the North, by the three hundred and forty feet of Church property, on the West, by a length of one hundred and twenty feet going towards the South, one hundred and twenty-five feet towards the East and one hundred and two feet towards the South.The southern boundary is about two hundred feet to the southwest corner of the property of Mr.J.Brault; c) A parcel of land twenty feet in width on the Bord de l'Eau range and about one hundred and forty-five feet in length alongside the property of Mr.P.Bonneau which is to be found on the East of this parcel of land, and bounded: on the North, by the lot of land described in paragraph b) hereinabove.The whole as specified on a plan annexed to number four thousand six hundred and thirty-two from the Minutes of Notary Rodolphe Four-nier, and English measure.Shall be sold in block and as a one and only concern, by virtue of a judgment of the Superior Court for the District of Montreal, in the matter of bankruptcy, rendered the thirteenth day of May, one thousand and nine hundred and fifty-three, bearing No.16 in the files of the said Court, at public auction, so as to give to this sale the effect of a Sheriffs sale, in conformity with article 45 of the Bankruptcy Act, at the door of the Catholic Parish Church, of Ste-Annc-dc-Sabrevois, at Sabrevois, County of Iberville, FRIDAY, the THIRD day of the month of JULY, nine hundred and fifty-three, at THREE o'clock in the afternoon (Eastern Daylight Saving-Time).Conditions of sale ten per cent (10%) cash, balance in three days.For information and List of Charges, apply to the undersigned.May 30, 1953.ALBERT LAMARRE, From the office of: Trustee.Lamarre & Inns, 10 St.James Street, East, Montreal 34923-22-2 1868 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome 85, N° 22 Ventes par licitation Sales by Licitation Province de Québec, district de St-Hyacinthe, Province of Quebec, district of St-Hyacinthe, Cour supérieure, N° 7746.Charles Edouard Superior Court, No.7746.Charles Edouard Forand et al, garagiste, de St-Césaire demandeurs Forand et al, garage keeper, of St-Césaire, plain- vs Philippe Meril Lussier et al, défendeurs.tiffs vs Philippe Meril Lussier et al, defandants.AVIS DE LICITATION NOTICE OF LICITATION Avis est donné qu'en vertu d'un jugement Notice is hereby given that in virtue of a judg-de la Cour Supérieure siégeant à St-Hyacinthe, ment of the Superior Court, sitting at St.Hya-dans le district de St-Hyacinthe, le 15ème jour cinthe, the 15th day of May, 1953, in the case de mai 1953, dans la cause ci-dessus, aura lieu la hereinabove, will take place the licitation of licitation de certains immeuble désigné comme certain immoveable described as follows, to wit: suit, savoir: \"Un emplacement à distraire et formant partie \"An emplacement to be substracted and for-du lot numéro quatre cent quatre vingt-douze ming part of lot number four hundred and ninety-(N° 492) des plan et livre de renvoi officiels du two (492) on the official plan and in the book of cadastre de la paroisse de St-Pie, renfermé dans Reference of the cadastre of the Parish of St-Pie, les limites suivantes: borné au sud-est par une enclosed within the following limits: bounded on rue étant la continuation de la rue entre les Nos the southeast by a street, being the continuation 494 et 493 du cadastre de St-Pie, au nord-est à of the street between Nos.494 and 493 of the \u2022André Tarte, ou représentants, étant le terrain cadastre of St-Pie, on the northeast to André vendu à Valerie Chicoine et al, par acte devant le Tarte, or representiatives, being the land sold notaire Bathalon, du 11 juin 1904, et enregistré à to Valerie Chicoine et al, by deed before notary Bagot, à B-N° 36041, au nord-ouest une rue Bathalon, on June 11, 1904, and registered at étant la continuation de celle entre les Nos 495 Bagot, at B-No.36041, on the northwest, a et 490, et au sud-ouest les Nos 494-495 du cadas- street being the continuation of that one between tre de-St-Pie, formant environ un demi-arpent en Nos.495 and 496, and on the southwest, Nos.superficie, plus ou moins, sans garantie de mesure, 494-495 of the cadastre of St.Pie, forming about dont le plus ou le moins tournera au profit a half arpent in superficial area, more (or less, ou à la perte de l'acquéreur et sans indemnité, without guaranty of measurement, the more or avec une maison et autres bâtisses dessus érigées; less of which would turn to the profit or loss of the aquirer and without indemnity, with a house and other buildings thereon erected; L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'en- The immoveable hereinabove described shall chère et adjugé au plus offrant et dernier enché- be sold by auction and adjudged to the highest risseur, le TRENTE JUIN 1953, à DIX heures bidder on JUNE THI-RTEETH, 1953, at TEN a.m., cour tenante, dans la salle d'audience, du a.m.sitting the Court, in the court room of the Palais de Justice, de St-Hyacinthe, sujet aux Court House of St.Hyacinthe, subject to the charges, clauses et conditions indiquées dans le charges, clauses and conditions indicated in the cahier des charges déposé au Greffe de la dite list of charges filed in the office of the said Court; Cour; et que toute opposition à fin d'annuller, à and that any opposition to annul, to secure char-fin de distraire, ou à fin de distraire à la dite lici- ges or to withdraw to be made to the said licita-t at ion devra être déposée au Greffe de la dite Cour, tion, must be filed with the office of the said Court, au moins 12 jours avant le jour fixé comme susdit at least twelve days before the day fixed as pour la vente et adjudication et que toute oppo- aforesaid for the sale and adjudication; and that sition à fin de conserver devra être déposée dans any opposition must be filedd within six days folles 6 jours après l'adjudication; et à défaut par lowing the adjudication; in default of the parties les parties de déposer les dites oppositions dans le to file the said oppositions within the delay délai prescrit par le présent elles seront forcloses prescribed by these presents, they shall be fore-du droit de le faire.closed from the right to do so.St-Hyacinthe, ce 21 mai 1953.Le Procureur des demandeurs, St.Hyacinthe, this 21 st day of May, 1953.34929-22-2-0 EUGENE TOUSIGNANT.EUGENE TOUSIGNANT, - 34929-22-2 Attorney for the plaintiffs.Canada, Province de Québec, District de Canada, Province of Quebec, District of Mont-Montréal, Cour Supérieure, N° 323,455.real, Superior Court.No.323,455.AVIS DE LICITATION - NOTICE OF LICITATION Avis public est donné qu'en vertu d'un jugement de la cour supérieure siégeant à Montréal, le 20e jour de mai 1953, dans une cause dans laquelle Germaine Labadie, veuve non remariée de feu Henri Régis Beaudoin en son vivant notaire, et Antoinette Labadie, fille majeure et usant de ses droits, toutes deux des cité et district de Montréal, sont demanderesses, et Germaine Sylvain-Bélanger, épouse séparée de biens de J.Edouard Bélanger, et ce dernier pour autoriser sa dite épouse aux fins des présentes, tous deux domiciliés au numéro 45, rue Principale, Hull; district de Hu'l, et autres sont Public notice is hereby given that, by virtue of a judgment of the Superior Court sitting in Montreal, on the 20th day of May 1953, in a case wherein Germaine Labadie, widow unmarried of the late Henri Regis Beaudoin in his lifetime notary, and Antoinette Labadie, spinster of the full age of majority, both of the city and district of Montreal are plaintiffs, and Germaine Sylvain-Bélanger, wife separate as to property of J.-Edouard Bélanger and the latter to authorize his said wife to the presents, both domiciled at No.45 Principal Street, Hull, said district, and others, are defendants, the licitation of the im- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May SOth, 1953, Vol.86, No.22 1869 défendeurs, la licitation des immeubles désignés ci-après a été ordonnée, savoir: \"Un immeuble situé au coin sud-est du Blvd St-Laurent et de la rue St-Jacqucs en la cité de Montréal, connu et désigné sous le numéro 129 des plan et livre de renvoi officiels du Quartier Centre en la dite cité de Montréal, portant les numéros civiques 515, 517 et 521 du Blvd St-Laurent et 6 de la rue St-Jacques est, de figure irrégulière, contenant une superficie de deux mille quarante-deux (2042) pieds, le tout mesure anglaise, et plus ou moins, avec bAtisses dessus construites.Ainsi que le tout se poursuit, comporte et étend de toutes parts, circonstances et dépendances, sujet aux servitudes actives et passives, apparentes et occultes.L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, VENDREDI, le TROISIÈME jour de JUILLET 1953 à DIX heures et DEMIE dc l'avant-midi, heure avancée, Cour tenante, dans la salle d'audience de l'ancien palais de justice de Montréal, chambre 31, ou à toute chambre indiquée par cette cour suivant les circonstances, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges on liste des charges déposée au greffe du Protonotaire de la cour supérieure du district de Montréal, et toute opposition à fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à ladite licitation devra être déposée au greffe du Protonotaire de ladite cour au moins douze (12) jours avant le jour fixé comme sudit pour la vente et adjudication et toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six (6) jours après l'adjudication; et à défaut par es parties dc déposer les dites oppositions dans les délais prescrits par le présent avis, elles seront forcloses du droit de le faire; Tout enchérisseur devra accompagner son offre ou enchère d'une somme de einq mille ($5,000.00 dollars.Montréal, le 26e jour de mai 1953 Les Procureurs des demanderesses, TRUDEAU BEAULIEU & ÉTHIER.34930-22-2-o movable properties hereinafter described has been ordered as follows: \"An immovable property situate on the South East corner of St.Lawrence Boulevard and St.James Street in the city of Montreal known ami designed under number 129 of the official plan and book of reference of the Center District in the said city of Montreal, bearing civic numbers 515, 517 and 521 of the St.Lawrence Boulevard and 0 of St.James Street East, of irregular form, having a surface of Two thousand forty-five feet (2045), the whole english measure more or less, with buildings thereon erected.As the whole follows, comprises and extends throughout circumstances and dependencies subject to all servitudes, active and passive, apparent and unapparent.The above described immovable will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder on the FRIDAY, the THIRD of JULY 1953, at HALF PAST TEN o'clock in the forenoon, daylight saving time, Sitting the Court, in the Court Room of the Court House of Montreal, room 31, or any other room indicated by the said Court as circumstances permit, subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges filed in the office of the Prothonotary of the Superior Court for the District of Montreal, and any opposition to annul, to secure charges or to withdraw, to be made to the said licitation, must be filed in the office of the Prothonotary of the said Court at least twelve (12) days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and any opposition for payment must be filed within the six (6) days following the adjudication; and, failing the parties to file the said oppositions within the delays hereby limited, they will be foreclosed from so doing.The offer or bid of every bidder must be accompanied by an amount of five thousand ($5,000.00) dollars.Montreal, the 26th day of May 1953.TRUDEAU BEAULIEU & ÉTHIER, 34930-22-2-o Attorneys for plaintiffs.Ventes pour taxes Province de Québec, district de Chicoutimi Commission Scolaire de Canton Taché Sales for Taxes Province of Quebec, District of Chicoutimi School Commission of the Township of Taché Avis public est, par les présentes donné que la Public notice is hereby given that the Quebec Commission municipale de Québec, par un arrêté Municipal Commission by an Order dated may en date du neuf mai 1953, a ordonné au soussigné, ninth 1953, has ordered the under signed, pursu- conformément aux dispositions de l'article 54 ant to the provisions of section 54 of the Quebec de la Loi de la Commission municipale de Québec Municipal Commission Act, (R.S.Q.1941, chanter (S.R.Q.1941, chapitre 207) de vendre l'immeuble 207) to sell the immoveable hcreinunder desi- ci-dessous désigné, pour satisfaire au paiement gnatcd, in payment for arrears of taxes due to des arrérages de taxes dues aux commissaires the School Commissioners for the municipality d'écoles pour la municipalité de canton Taché of the Township of Taché and to the municipal et à la corporation municipale de canton Taché corporation of Taché Township (St-Nazaire) (St-Nazaire) avec intérêts et frais, et qu'en con- with interests and costs, and that consequently, séquence, ledit immeuble sera vendu par encan the said immoveable shall be sold at public public, dans la salle publique de canton Taché auction in the public hall of Taché Township (St-Nazaire), le DIX-SEPT JUIN 1953, à (St-Nazaire), JUNE SEVENTEENTH 1953, ONZE heures de l'avant-midi, heure avancée, at ELEVEN o'clock in the forenoon, daylight saving time.Toutefois, ledit immeuble sera exclus de la However, the said immoveable shall be exclu-vente si les taxes scolaires échues le ou avant le ded from the sale if the school taxes overdue on 30 juin 1953 sont payées, avec les frais, avant le or after June 30th, 1953, are paid plus costs, moment de la vente.before the time of the sale. 1870 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome 85, N\" 22 1.Joseph-Henri Martel.Le lot 21, rang 8, au cadastre officiel du canton Taché, sous billet dc location, avec réserve des droits de la compagnie Electrique du Saguenay pour un passage de ligne de transmission d'énergie électrique, suivant acte dûment enregistré.Le dit lot sera vendu avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes pouvant l'affecter.Les versements non échus «les taxes municipales ou scolaires consolidées, s'il en est, seront à la charge de l'acquéreur.Le prix d'adjudication de cet immeuble sera payable immédiatement.La vente sera en outre sujette au droit de retrait et aux autres dispositions de la Loi dc la Commission municipale de Québec.Donné à Saint-Nazaire, ce llième jour du mois de mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, 34868-21-2-0 J.A.TREMBLAY.1.Joseph Henri Martel \u2014 Lot 21, range 8, of the official cadastre of Township Taché under location ticket, with reserve of rights of \"La Compagnie Electrique du Sagucnay\" to pass an electric power transmission line, in accordance with a duly registered deed.The said'lot shall be sold with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and with all active and passive servitudes, apparent or unapparent by which it may be affected.The unmatured instalments of consolidated municipal or school taxes, if any, shall be charged to the purchaser.The adjudication price of said immoveable shall be paj'able immediately.Moreover, the sale shall be subject to right of redemption and to other provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at St-Nazairc, this 11th day of the month of May 1953.J.A.TREMBLAY, 34S68-21 -2 Secretary Treasu rer.Province de Québec Cité de Nor an da Avis public est par les présentes donné que conformément à une résolution du conseil en date du 24 avril 1953, le secrétaire-trésorier de la cité de Noranda vendra à l'enchère le QUINZIÈME jour de JUIN 1953, à DIX heures de l'avant-midi, au bureau du conseil, Bâtisse Municipale, 321 avenue Murdoch, Noranda, P.Q., de la manière prescrite par la loi, les immeubles suivants sur lesquels les taxes municipales et scolaires n'ont pas été payées: Province of Quebec City of Noranda Public notice is hereby given that pursuant to a resolution of the Council made on April 24th 1953, the secretary-treasurer of the city of Noranda will on the FIFTEENTH day of JUNE, 1953, at TEN o'clock in the forenoon at the office of the Council Municipal Building, 321 Murdoch Ave Noranda, P.Q., sell at public auction in the manner prescribed by law the following immoveables on which the municipal and school taxes assessed have not been paid: Description des Propriétés Description of property\tNoms des propriétaires Name of owners\tTaxes non-payées Unpaid taxes Lc lot N° 370 (trois cent soixante-dix) du cadastre officiel de la cité de Noranda.\u2014 Lot No.370 (three hundred and seventy) of the official cadastre of the City of Noranda.Bâtisses seulement, construites sur partie de terrain non subdivisé do Noranda Mines Ltd., et situées dans le Bloc 1 (un) de la cité do Noranda.Buildings only, erected on part of unsubdivided ground of Noranda Mines Ltd.and located in Block 1 (one) of the City of Noranda.\tDaniel Angcloff, Evan AiikcIoIT.Mme D.LazarofT Angeloff.\t$189.52 194.81 Donné à Noranda, ce 15e jour de mai, 1953.Given at Noranda, this 15th day of May, 1953.Le Secrétaire-trésorier, C.-E.COMEAU, 34870-21-2-o C.-E.COMEAU.34870-21-2-o Secretary-treasurer.Province de Québec \u2014 District de Saguenay Municipalité de Les Escoumains Avis public est, par les présentes donné que la Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du vingt-deux mai 1953, a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 207) de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la corporation municipale de Les Escoumains et aux commissaires d'écoles pour la municipalité de Les Escoumains, avec intérêt et frais, et Province of Quebec \u2014 District of Saguenay Municipality of Les Escoumains Public notice is hereby given that the Quebec Municipal Commission, by an order dated the twenty-second of May, 1953, has ordered the undersigned, pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act, (R.S.Q.1941, chapter 207) to sell the immovables hereinbelow described for the payment of arrears of taxes due to the municipal corporation of Les Escoumains and to the School Commissioners for the municipality of Les Escoumains, with interest and costs, and that conse- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 80th, 1968, Vol 86, No.88 1871 qu'en conséquence, les dits immeubles seront vendus par encan public, dans la salle de réunions du conseil, aux Escoumains, le VINGT-SIX JUIN 1953, à DEUX heures de l'après-midi.Toutefois, seront exclus de la vente, les immeubles sur lesquels les taxes municipales dues avant le 31 décembre 1952 et les taxes scolaires dues avant le 30 juin 1952, auront été payées avec les frais, au moment de la vente.1.\u2014 Raoul Boaulieu \u2014 a) Les lots 14-J-9 et le-J-10, rang 1.6) Le lot 15-A-3, rang 1.c) Le lot 15-A-9, rang 1.2.\u2014 Raymond Tremblay \u2014 Le lot 11-7, rang A.3.\u2014Gilbert ou Albert St-Gelais \u2014\u2022 Le lot A-2-11, rang A.4.\u2014 Joseph-Alfred Boulianno \u2014 a) Lo lot A-2-20, rang A.6) Le lot 9, rang A.5.\u2014 Ovila April \u2014 Le lot A-2-32, rang A.0.\u2014 Georges Dufour \u2014 Le lot 10-A-l, rang 1.7.\u2014 Mme Vve Ludger Bouchard \u2014 Lo lot ll-A-4, rang 1.8.\u2014 Adélard Boulianne \u2014 Le lot ll-A-13, rang 1.9.\u2014 Antoine Caron \u2014 Le lot ll-A-18, rang 1.10.\u2014 Mme Esdros Brisson \u2014 a) Les lots 45-2 et 45-3, rang 1, sous billot de location, b) Los lots 48 et 49, rung 4, sous billot de location.11.\u2014 Mme Jean-Baptiste Morin \u2014 Lolot45-4,rang 1.12.\u2014 Roger Deschône\u2014 Lo lot 43-1, rang 1, sous billot de location.13.\u2014 Lorenzo Deschéno \u2014 a) Le lot 30, rang 3, à titro très précaire, b) Le lot 47,.rang 4, sous billet de location, c) Les lots 32 et 33, rang 4.d) Le lot 34, rang 4, à titre très précaire, e) Le lot 43-2, rang 1, sous billet de location.14.\u2014 Raphael Brisson \u2014 Le lot 35, rang 1, sous billet de location.15.\u2014 Edouard Létournoau \u2014 Lo lot 13-F-2, rang 1.10.\u2014 Camille Boulianne\u2014Lo lot ll-A-7, rang 1.17.\u2014 Antonio Tremblay \"Père\" \u2014 Les lots 11-9 et 11-10, rang A.Les lots ou parties de lots ci-dessus sont du cadastre officiel du canton Les Escoumains.\u2022 Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y en a, et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes pouvant les affecter.La vente sera en outre sujette au droit de retrait et aux autres dispositions de la Loi de la Commission municipale de Québec.Donné aux Escoumains, ce 23ième jour du mois de mai 1953.Le Secrétaire-trésorier, 34917-22-2-0 LÉON TREMBLAY.VENTES PAR SHÉRIFS quently, the said immoveables shall be sold by public auction, in the Meeting Hall of the Council, at Escoumains, the TWENTY-SIXTH day of JUNE, 1953, at TWO o'clock in the afternoon.However, there shall be excluded from the sale, the immoveables upon which the municipal taxes due before December 31, 1952 and the school taxes due before June 30, 1952, have been paid, with costs, at time of sale.1.\u2014 Raoul Boaulieu \u2014 a) Lots 14-J-9 and J-10.rango 1.6) Lot 15-A-3, range 1.e) Lot 15-A-9, range 1.- 2.\u2014 Raymond Tremblay \u2014 Lot 11-7, range A.3.\u2014Gilbert ou Albert St-Gelais \u2014 Lot A-2-11, range A.4.\u2014 Joseph-Alfred Boulianno \u2014 a) Lot A-2-20, range A.b) Lot 9, range A.5 \u2014 Ovila April \u2014 Lot A-2-32, range A.6.\u2014 Georges Dufour \u2014 Lot 10-A-l, range 1.7.\u2014 Mrs.widow Ludgor Bouchard \u2014 Lot ll-A-4, range 1.8.\u2014 Adélard Boulianne\u2014Lot ll-A-13, rango 1.9.\u2014 Antoine Caron \u2014 Lot ll-A-18, range 1.10.\u2014 Mrs.Esdras Brisson \u2014 a) Lots 45-2 and 45-3, range 1, under location ticket.6) Lots 48 and 49, range 4, undor location ticket.11.\u2014 Mrs.Jean-Baptiste Morin, lot 45-4.range 1.12.\u2014 Roger Deschene\u2014 Lot 43-1, range 1, under location ticket.13.\u2014 Lorenzo Deschéno \u2014 a) Lot 30, range 3, title to deed, very doubtful, b) Lot 47, range 4, under ticket of location, c) Lots 32 and 33, range 4.d) Lot 34, range 4, title to deed, very doubtful, e) Lot 43-2, range 1, under ticket of location.14.\u2014 Raphael Brisson \u2014 Lot 35, rango 1, undor ticket of location.15.\u2014 Edouard Létournoau \u2014 Lot 13-F-2, range 1.18.\u2014 Camille Boulianne\u2014Lot ll-A-7, range 1.17.\u2014 Antonio Tremblay \"father\" \u2014 Lots 11-9 and 11-10, range A.The lots or parts of lots hereinabove are from \u2022 the Official Cadastre of the Township of Les Escoumains.The purchase price of each of these immoveables will be payable immediately.They shall be sold with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, should therebe any, and with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes affecting the same.The sale, shall, moreover, be subject to right of redemption and to the other provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at Escoumains, this 23rd day of the month of May, 1953.LÉON TREMBLAY, 34917-22-2 Secretary-Treasurer.SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEAUCE PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEAUCE Fieri Facias de Bonis et de Terris Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure District of Beauce District de Beauce Superior Court St-Joseph de Beauce, / JEAN TRACHY, culti- St-Joseph de Beauce, ( JEAN TRACHY, far- à Savoir: )J vateur de Ste-Mar- to-wit: )J mer of Ste.Margue- N° 22,398.) guérite, Dorchester No.22,398.) rite, Dorchester, f contre J.ÉMILLEN ( against J.ÉMTLDSN MARCOUX.St-Anseime et JEAN-BAPTISTE MARCOUX, St.Anselme and JEAN-BAPTIS- MARCOUX, Scott-Jonction, à savoir: TE MARCOUX, Scott-Junction, to wit: Un emplacement situé en la paroisse de St- An emplacement situate in the parish of St.Maxime de Scott, comté de Dorchester, mesurant Maxime de Scott, county of Dorchester, measu- soixante et trois pieds (63'!) de front sur quatre ring sixty-three (63') in front by four hundred cents pieds (400') de profondeur, le tout plus feet (400') in depth, the whole more of less, bound 1872 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome 86, N° 22 ou moins, borné en front par le chemin public, en arrière au bout de la profondeur, d'un côté au sud-est par le terrain de Georges Hébert ou représentants, et de l'autre côté au nord-ouest par un chemin privé appartenant à la Brown Corporation ou ses représentants et connu comme faisant partie du lot numéro sept cent-quarante et un (Ptie 741) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Marie, comté de Beauce, dans cette partie faisant aujourd'hui partie de la paroisse de St-Maxime de Scott, comté de Dorchester, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et avec en outre le droit de passer et repasser tant en voiture qu'à pieds et en tout temps de l'année dans le chemin privé bornant le terrain ci-dessus hypothéqué du côté nord-ouest pour communiquer au chemin public, à distraire toutefois du terrain sus-décrit cette partie appartenant au Ministère de la Voirie de la Province de Québec, suivant ses titres pour l'élargissement du chemin public, et cette partie appartenant à Ernest H.Lefèvre suivant ses titres, les circonstances et dépendances, tel que le tout se trouve actuellement.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale, en la paroisse de St-Maxime de Scott, le SIXIÈME jour de JUILLET prochain, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, J.-S.POULIOT.St-Joseph de Beauce, 28 mai 1953.34949-22-2-o [Première insertion: 30 mai 1953].[Seconde insertion: 13 juin 1953].BONAVENTURE Canada, Province de Québec, District de Bonaventure New Carlisle.Cour Supérieure, / TJTECTOR LAFERTÉ, de la N° 5684.< *¦A cité de Québec, district ( de Québec, demandeur, vs RENÉ C.CULLEN, de Carleton-sur-Mer, comté et district de Bovaventure, défendeur, 1.Une certaine partie de terrain formant partie du lot numéro quarante et un C (41-C) du premier rang du canton de Carleton, situé à et touchant le côté nord-est de la propriété appartenant à Dame Louise Marcil, épouse de l'Honorable Charles Marcil, et commençant au coin nord-est de la propriété de la dite Dame Marcil et allant vers le nord dans la ligne de division entre les lots 41-C et 41-D pour une distance de vingt-huit pieds, de là, en allant vers l'ouest, une distance de cent vingt et un pieds jusqu'à un autre coin de la propriété de la dite Dame Charles Marcil et de là vers le sud une distance de vingt pieds jusqu'à ce que cette ligne rejoigne encore la propriété de la dite Dame Charles Marcil.2.Un lot de terre ou emplacement sis et situé et étant du côté nord du chemin public dans le village de Carleton, dans le comté de Bonaventure, connu et désigné comme partie du lot numéro quarante et un C (41-C) aux Plan et Livres de Renvoi du Bureau d'enregistrement de la deuxième division d'enregistrement du comté de Bonaventure, le dit lot de terrain ou emplacement mesurant cent quatre-vingr-seize pieds de front: sur la ligne allant du sud au nord du côté ouest cent quinze pieds; sur la ligne allant du sud au nord du côté est, cent pieds; en arrière, deux cents-douze pieds (212) mesure anglaise et plus ou moins et sans garantie quant aux mesures exactes; borné en front par la Baie des Chaleurs et le Chemin Public, 'd'un côté, à l'est, par la propriété occupée auparavant par M.Paul in front by the public road, in rear, at end of depth, on the southeast at one side by the land of Georges Hébert or representatives, and on the other side on the northwest by a private road belonging to the Brown Corporation or its representatives and known as forming part of lot number seven hundred and forty-one (Pt.741) on the official cadastre for the parish of Ste-Marie, county of Beauce, in this part forming today part of the parish of St-Maxime de Scott, county of Dorchester, with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and with, moreover, the right to come and go by carriage as well as on foot and at any time of the year in the private road bounding the land hereinabove mortgaged on the northwest side to communicate with the public road, to subtract, however, from the land hereinabove described that part belonging to the Roads Department of the Province of Quebec according to its title deeds for the widening of the public road, and this part belonging to Ernest H.Lefèvre according to his titles deeds, the circumstances and dependencies, as the whole presently stands.To be sold at the parochial church door, in the parish of St.Maxime de Scott, the SIXTH day of JULY next at TEN o'clock in the morning.J.-S.POULIOT, Sheriff's Office, Sheriff.St-Joseph de Beauce, May 28, 1953.34949-22-2 [First insertion: May 30, 1953].[Second insertion: June 13, 19531- BONAVENTURE Canada, Province of Quebec, District of Bonaventure New Carlisle.Superior Court, / \"EJECTOR LAFERTÉ, of the No.5684.< * a city of Quebec, District (.of Quebec, Plaintiff, vs RENÉ C.CULLEN, of Carleton-sur-Mer, County and District of Bonaventure, Defendant.1.A certain piece or parcel of land forming part of lot number Forty-one C (41-C) of the First Range of the Township of Carleton, situated at and adjoining the north-eastern side of the property owned by Dame Louise Marcil, wife of the Honourable Charles Marcil, and starting from the north-eastern corner of the said Mrs Marcil's property and going towards the north in the division line between lots 41-C and 41-D a distance of twenty-eight feet, thence towards the west a distance of one hundred and twenty-one feet until it strikes another corner of the said Mrs.Marcil's property and thence towards the south a distance of twenty feet until it again strikes the said Mrs Marcil's property.2.A lot of land or emplacement situate, lying and being to the north side of the Public Road in the Village of Carleton, in the County of Bonaventure, known and designated as part of lot number Forty-one C (41-C) upon the Plan and in the Book of Reference deposited of record in the Registry Office of the Second Registration Division of the County of Bonaventure, containing the said lot of land or emplacement one hundred and ninety-six feet in front; on the line running from south to north on the west side one hundred and fifteen feet; on the line running from south to north on the east side one hundred feet: in rear 212 feet, English Measure and more or less without any guarantee as to exact measurements; bounded in front by the Baie de Chaleur and the Public Road, on one side to the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 30th, 1953, Vol.85, No.22 1873 P.Cullen; en arrière et à l'est par la balance du dit lot numéro quarante et un C, appartenant à M.William LeBIanc.Avec la maison, garage et glacière dessus érigées.Tel que la dite propriété existe actuellement, avec tous ses droits et accessoires mais sans exception et réserve quelconque de la part du défendeur.Pour être vendus à la porte de l'église de Carleton, comté et district de Bonaventure, le TRENTIÈME jour du mois de JUIN, mil neuf cent cinquante-trois (1953) à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, F.J.LEGRESLEY.New-Carlisle, le 16 mai 1953.34871-21-2-0 KAMOURASKA Fieri Fadas pie Bonis et de Terris Canada Province de Québec Cour Supérieure, ( A LBERT BÉRUBÉ, gara-N° 18485 < \u2022**giste de St-Philippe de ' Néri, demandeur vs ISIDORE LEVESQUE, cultivateur, Chemin de Fraser-ville, Rivière-du-Loup, défendeur.Une terre située en la municipalité de Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup, connue et désignée sous les numéros cent huit (108), onze cent treize (1113), et onze cent quatorze (1114) au cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup, comté de Témiscouata, avec ensemble les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et les autres bâtisses qui y seraient érigées à l'avenir, mais sous réserve de la Servitude de passage affectant le lot cent huit (108) ci-dessus en faveur de la Cité de Rivière-du-Loup, suivant acte enregistré dans Témiscouata sous le N° 104, 181.2° La moitié sud-ouest d'un circuit de terre situé en la dite municipalité de Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup, le dit circuit en entier contenant trois arpents et trois quarts de front sur le troisième rang de la même paroisse, par environ vingt-cinq arpents de profondeur, plus ou moins, lequel circuit est une partie du lot de terre numéro mille soixante dix-huit (1078) du même cadastre officiel de Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup; laquelle moitié est bornée au nord-ouest à la rivière dite Rivière-du-Loup; au sud-ouest au terrain des représentants de Magloire Deschênes; au nord-est, à l'autre moitié du même circuit de terre, avec bâtisses dessus construites, mais sous réserve des droits que peut avoir sieur Louis Lévesque sur la moitié d'une grange construite sur le dit circuit de terre aux conditions exprimées et convenues aux titres antérieurement enregistrés.Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de St-François Xavier de Rivière-du-Loup, LUNDI, le HUITIÈME (8) jour du mois de JUIN 1953 à DEUX heures de l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, P.E.MARTIN.Rivière-du-Loup, le 6 mai, 1953.34820-19-2-o [ Première insertion, samedi le 9 mai 1953.) QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir: ( T\\OMINIQUE GAUDRY, N° 66768.\\ *-S M.D., domicilié au N° ' 253 rue Price Ouest, Chicoutimi, et pratiquant comme médecin à ce dernier endroit; contre MICHAEL G.BIRMINGHAM, east by the property formerly occupied by Mr.Paul P.Cullen; in the rear and to the east by the balance of said lot number Forty-One C belonging to Mr.William LeBIanc.With the house, garage and ice-house thereon erected.As the said property now subsits, with all its rights, members and appurtenances without exception and reserve of any king on the part of the defendant.To be sold at the parochial church door, at Carleton, county and district of Bonaventure, on the THIRTIETH day of the month of JUNE, nineteen hundred and fifty-three, (1953) at TEN o'clock in the forenoon.F.J.LEGRESLEY, Sheriff's Office, Sheriff.New Carlisle, May 16th, 1953.34871-21-2-o KAMOURASKA Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada Province of Quebec Superior Court, ( A LBERT BÉRUBÊ, gara- No.18485 < -L*- ge-keeperof St.Philippe \\ de Néri, palintiff, vs ISIDORE LEVESQUE, farmer, Fraserville Road, Rivière-du-Loup, defendant.A farm situate in the municipality of Saint-Patrice of Rivière-du-Loup, known and designated under numbers one hundred and eight (108), eleven hundred and thirteen (1113), and eleven hundred and fourteen (1114) on.the official cadastre for the parish of Saint-Patrice of Rivière-du-Loup, county of Témiscouata, together with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, and other buildings which, in future, may ge built thereon, but under reserve of the right-of-way affecting lot one hundred and eight (108) hereinabove in favor of the City of Rivière-du-Loup, according to registered deed in Témiscouata under No.104, 181.2.\"The south-west half of a circuit of land situate in the said municipality of Saint-Patrice of Rivière-du-Loup, the entire said circuit, containing three arpents and three-quarters in front on the third range of the same parish, by about twenty-five arpents in depth, more or less, which circuit is a part of the lot of land number one thousand seventy-eight (1078) of the same official cadastre of Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup; which half is bounded on the northwest to the river called Rivière-du-Loup; on the southwest, to the land of the representatives of Magloire Deschênes; on the northeast, to the other half of the same circuit of land, with buildings thereon erected, but under reserve of the rights which Mr.Louis Lévesque may have on half of a barn built on the said circuit of land on the conditions expressed and agreed upon in the titles previously registered.\" To be sold at the door of the parish church of St.François Xavier de Rivière-du-Loup, MONDAY, the EIGHTH (8) day of the month of JUNE, 1953, at TWO o'clock in the afternoon.P.-E.MARTIN, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, May 6, 1953.34820-19-2 iFirst insertion, Saturday, May 9, 1953, QUEBEC Fieri Facias .Quebec, to wit : ( T\\OMINIQUE GAUDRY, No.66768.\\ *J M.D., residing at No.\\253 Price Street West, Chicoutimi, a physician, practising in the latter place; vs MICHAEL G.BIRMINGHAM, of 1874 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 30 mai 1953, Tome 85, N° 22 de la cité de Québec, résidant actuellement au N° 455, 1ère Avenue, Québec, à savoir: Un immeuble connu et désigné sous le numéro onze (11) du troisième (3e) rang, au plan et livre de renvoi pour la paroisse de Stoneham, comté de Québec, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église paroissiale de Stoneham, comté de Quélwc, le TROISIÈME jour de JUILLET prochain, à DIX heures du matin (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, AIMÉ DION.Québec, le 27 mai 1953.34948-22-2-0 (Première insertion: 30 mai 1953] [Deuxième insertion: 13 juin 1953] F icri Facias ' Québec, à savoir: f p< ASTON BOIL Y, notaire, N° 68,188.< VJ \u2022 domicilié à St-Flavien, A comté de Lotbinièrc, district de Québec: contre NEOLLA VIR, domiciliée à Plainsville, Conn.U.S.A., BELLA VIR, domicilié à Hartford, Conn.U.S.A.et PAULINE VIR, domiciliée a Hartford, Conn.U.S.A.à savoir: Une terre située en la paroisse de St-Janvier de Joly, connue et désignée comme étant les parties sud-est et au Nord-ouest du chemin de fer du lot primitif numéro trente-quatre (34), du rang trois (3), contenant respectivement quarante-sept arpents et trente sept arpents, de superficie, plus ou moins, mesure anglaise, correspondant aux lots numéros deux cent trente-deux et deux cent trente-trois de la subdivision du lot numéro trois cent quatre-vingt-huit (388-232 et 288-233) du cadastre officiel de la paroisse de St-Edouard, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendue â la porte de l'église paroissiale de St-Êdouard de Lotbinière, comté de Lot-binière, le TROISIÈME jour de JUILLET prochain, à DIX heures du matin (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, _ AIMÉ DION.Québec, 27 mai 1953.34947-22-2-o [Première insertion: 30 mai 1953 ] [Deuxième insertion: 20 juin 1953.] the city of Quebec, presently residing at No.455, 1st Avenue, Quebec, to wit: An immoveable known and designated under number eleven (11), range third (3rd), on the plan and book of reference of the parish of Stoneham, Quebec County, with buildings erected thereon, and appurtenances.To be sold at the door of the parochial church of Stoneham, Quebec County, the THIRD day of JULY next, at TEN o'clock in the morning (Daylight saving time).AIMÉ DION, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec.May 27th, 1953.34948-22-2 [First insertion: May 30, 1953] 'Second insertion: June 13, 195.] Fieri Facias Quebec, to wit: f pASTON BOILY, notary, No.68,188.\\ residing at St.Flavien, ' County of Lotbinière, district of Quebec: vs NOELLA VIR, residing at Plainsville, Conn.U.S.A., BELLA VIR, residirg in Hartford, Conn.U.S.A.and PAULINE VIR.residing in Hartford, Conn.U.S.A., to wit: A farm situate In the parish of St-Janvier de Joly known and designated as the south-east and North-west parts of the railroad of the original lot number theirty-four (34), of Range three (3), including respectively forty-seven arpents and thirty-seven arpents in area, more or less, English measure, corresponding to lots numbered two hundred and thirty-two and two hundred and thirty-three of the subdivision of lot number three hundred and eighty-eight (388-232 and 288-233) of the official cadastre of the parish of St-Edouard, with building erected thereon, and appartenances.To be sold at the door of the parochial church of St-Edouard de Lotbinière, county of Lotbinière, the THIRD day of JULY next, at TEN o'clock in the morning (Daylight saving time).AIMÉ DION, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, May 27, 1953.34947-22-2 [First Insertion: May 30th, 1953.1 [Second Insertion: June 20th, 1953.1 ROBERVAL Fieri Facias de Terris District de Roberval Cour de Magistrat d'Alma / JUSTIN DALLAI-N°9287
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.