Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 9 février 1952, samedi 9 (no 6)
[" Tome 84, N° 6 403 Vol.84, No.6 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCLAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 9 février 1952 AVIS AUX INTÉRESSSÉS Rbglements .1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en.est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le,tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, February 9th, 1952 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3* Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième - Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter.3366 \u2022104 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome SA, N° 6 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi j'i condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi, Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.!)° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 20G lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volontés: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.X.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne, sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, REDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.31753-1-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous cost?of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.REDEMPTI PARADIS, ' King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.31753-1-52 Lettres patentes A.Garber Fur Company .Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-sept décembre 1951, constituant en corporation: Abie Garber.fourreur, Jack Clément, marchand et Fera Xachshen Garber, épouse séparée de biens dudit Abie Garber et dûment autorisée par lui, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce et le négoce de fourrures de toutes sortes, pelleteries, peaux d'animaux, cuirs et peaux vertes; ainsi qu'articles vestimentaires, sous le nom de \"A.Garber Fur Company\", avec un capital de $50,000 divisé en 250 actions Letters Patent A.Garber Fur Company Xotice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented, by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of December, 1951, incorporating: Abie Garber, furier.Jack Clement, merchant, and Fera Nachshen Garber, wife separate as to property of the said Abie Garber, and by him duly authorized, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and deal in all kinds of furs, fur peJts, animal skins and leather and hides; and in wearing apparel, under the name of \"A.Garber Fur Company\", with a capital stock of $50.000.divided into 250 common QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.6 405 ordinaires de S100 chacune et 250 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1485, rue Bleury, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Atlas Enterprises Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1951, des lettres patentes en date du sept décembre 1951, constituant en corporation: Isidore M.Bobrove, avocat, Jack Bobrove, étudiant en loi, tous deux de la cité de Montréal et Ruth D.Budyk, secrétaire, de la cité d'Outre-mont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles, sous le nom de \"Atlas Enterprises Corporation\", avec un capital de §100,000 divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et 750 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Carmen Fleuriste (Liée) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-neuf décembre 1951, constituant en corporation: Joseph-Napoleon Bessette, commis, Carmen Mathieu, fleuriste, célibataire, et Maurice Bisail-lon investigateur, tous des cités et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer la culture et le commerce des fleurs et plantes, sous le nom de \"Carmen Fleuriste (Ltée),\" avec un capital de $39,000 divisé en 390 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-neuf décembre 1951.\\ L'Assistant-procuruer général, 31998-o L.DÉSILETS.Ceebee Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du dix-sept décembre 1951, constituant en corporation : Max Isidore Sigler, Moses Hyman Myerson, avocats et Ida Stein, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de placements, sous le nom de \"Ceebee Investments Ltd.\", avec un capital de $150,000 divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 1,400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.shares of $100 each, and 250 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at 1485, Bleury Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth dav of December, 1951.' L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.Atlas Enterprises Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 176, R.S.Q., 1951, bearing date the seventh day of December, 1951, incorporating: Isidore M.Bobrove, advocate, Jack Bobovre, law student, both of the City of Montreal, and Ruth D.Budyk, secretary, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate company, under the name of \"Atlas Enterprises Corporation\", with a capital stock of $100,000 divided into 250 common shares of $100 each and 750 preferred shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventh day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.Carmen Fleuriste (Ltée) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of December, 1951, incorporating: Joseph-Napoléon Bessette: clerk, Carmen Mathieu, Florist, spinster, and Maurice Bisaillon, investigator, alll of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To cultivate and deal in flowers and plants, under the name of \"Carmen Fleuriste (Ltée),\" with a capital stock of $39.000 divided into 390 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney-General, the nineteenth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Ceebee Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of December, 1951, incorporating: Max Isidore Sigler, Moses Hyman Myerson, lawyers, and Ida Stein, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Ceebee Investments Ltd.\", with a capital stock .of $150,000.divided into 100 common shares of $100 each and 1,400 preferred shares of a par value of $100 each. 406 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1962, Tome 84, N° 6 Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Cie Ideal Import Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du dix décembre 1951, constituant en corporation: Roland Geoffroy, Aimé Diotte, importateurs, et Lionel Laprade, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de manufacturier et commerçant d'objets et marchandises en nylon, plastique, acier, verre, bois, porcelaine, métal, sous le nom de \"Cie Ideal Import Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 2200, rue Desjardins, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté dii bureau du Procureur général le dix décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.Corporation des Chemins d'Hiver d'Ahitibi-Ouest Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compangies de Québec, il a été cacordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des letres patentes, en date du six dédembre 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Arsène Gagnon, contracteur, de Duparquet, Honoré Carrier, marchand de Macamic, et Emilien Bégin, gérant, de Palmarolle, tous du district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Le maintien «te chemins à la circulation automobile durant l'hiver dans le comté d'Ahitibi-Ouest, sou le nom de \"Corporation des Chemins d'Hiver d'Abitibi-Ouest\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $10,000.Le siège social de la corporation sera à La Sarre, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général le six décembre 1951.L'Assistant-procureur général.31998-0 L.DÉSILETS.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this seventeenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.Cie Ideal Import Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of December, 1951, incorporating: Roland Geoffroy, Aimé Diotte, importers, and Lionel Laprade, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as manufacturer of an dealer in articles and merchandises of nylon, plastic, steel, glass, wood, china, metal, under the name of \"Cie Ideal Import Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shaves of $100 each.The head office of the company will be at 2200 Desjardins Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Corporation des Chemins d'Hiver d'Abitibi-Ouest Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of December, 1951, to incorporate as a corpora-ration without share capital: Arsène Gagnon, contractor, of Duparquet, Honoré Carrier, merchant, of Macamic, and Emilien Begin, manager, of Palmorolle, all of the judicial district of Abitibi, for the following puiposes: The upkeep of roads for motor traffic during the the winter, in the county of Abitibi-West, under the name of \"Corporation des Chemins d'Hiver d'Abitibi-Ouest\".The amount to which the immoveable, property which the corporation may hold is to be limited is 810,000.The head office of the corporation will be at Sarre, judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Davie Brothers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onze décembre 1951, constituant en corporation: William Morin, C.R., avocat, André Verge, avocat et Fleurette Dussault, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exploiter et organiser des chantiers maritimes, sous le nom de \"Davie Brothers Ltd.\", avec un capital de $200,000 divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1400 actions privilégiées classe \"A\" d'une valeur de $100 l'action et 500 actions privilégiées classe \"B\" d'une valeur de $100 l'action.Davie Brothers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'.Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1951, incorporating: William Morin, K.C., advocate, André Verge, advocate, and Fleurette Dussault, stenographer, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To operate and organize shipyards, under the name of \"Davie Brothers Ltd.\", with a capital stock of $200,000 divided into 100 common shares of a par value of $100 each and 1400 Class \"A\" preferred shares of a value of $100 each and 500 Class \"B\" preferred shares of a value of $100 per share. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.6 407 Le siège social de la compagnie sera à Lévis, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le onze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-p L.DÉSILETS.Eastern Canada Vcnecr Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a é£é accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du cinq décembre 1951, constituant en corporation: L.E.Langis Galipeault, avocat et conseil en loi du Roi, J.Edouard Caron, avocat, et Antonio Leclcrc, comptable public accrédité, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'un manufacturier et marchand de bois de construction, bois de charpente, planches, bois contre-plaqué, bois plaqué et matériaux de construction, sous le nom de \"Eastern Canada Venecr Corporation\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Henry-ville, district judiciaire d'Iberville.Daté du bureau du Procureur général, le cinq décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSLLETS.The head office of the company will be at Levis, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Eastern Canada Veneer Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of December, 1951, incorporating: L.E.Langis Galipeault, advocate and King's Counsel, J.-Edouard Caron, advocate and Antonio Lcclerc, accredited public accountant, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To carry on the business of a manufacturer of and dealer in lumber, timber, boards, plywood, veneer and building materials, under the name of \"Eastern Canada Veneer Corporation\", with a capital stock of $100,000 diyided into 1,000 shares of $100 each.The head office of the company will be at Hen-ryville, judicial district of Iberville.Dated at the office of the Attorney General, this fifth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.Eskimo Fur Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du douze décembre 1951, constituant en corporation: Harry Berger, Terry Berger Dubin, épouse séparée de biens de Milton Dubin, et dûment autorisée par lui et Milton Dubin, tous marchands, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers et marchands de fourrures, peaux de fourrures, manteaux de fourrure, garnitures de fourrure et articles vestimentaires, sous le nom de \"Eskimo Fur Co.Limited.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 aetions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Fédération des Amicales Maristes Canadiennes Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1951, constituant en corporation sans-capital-actions: Yvon Jasmin, Réal Marcoux, avocats, Lucienne Mérineau, Rita Dufresne, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, et J.-Roger Marceau, commis, de Ste-Thérèse de Blainville, district judiciaire de Terrebonne, pour les objets suivants: Grouper toutes personnes ayant étudié dans un collège ou dans une école possédés ou dirigés Eskimo Fur Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearng date the twelfth day of December, 1951, incorporating: Harry Berger, Terry Berger Dubin, wife separate as to property of Milton Dubin, and duly authorized by him, and Milton Dubin, all merchants, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business as manufacturers and dealers in furs, fur skins, fur coasts, fur trimmings and wearing apparel, under the name of \"Eskimo Fur Co.Limited\", with a capital stock of $20,000.divided into 200 shares of $100 each.The head office of the Company will ,be at Montreal, Judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Fédération des Amicales Maristes Canadiennes Notive is hereby given that under Part UI of the Quebec Companies Act, lettrs patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Yvon Jasmin, Real Marcoux, advocates, Lucienne Mérineau, Rita Dufresne, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, and J,-Roger Marceau, clerk, of Ste-Thérèse de Blainville, judicial district of Terrebonne, for the following purposes: To form a group of all those who have studied in a college or school owned or directed by the 408 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome S/\u201e N° 6 par les Frères Maristes.sous le nom de \"Fédération des Amicales Maristes Canadiennes\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers et les revenus en provenant que la corporation peut posséder est de S200.000.Le siège social de la corporation sera au Collège Laval, Saint-Vincent de Paul, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau «lu Procureur général le quinze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.Goodcraft Clothing Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du onze décembre 1951.constituant en corporation: Peter (iotfrit, marchand.Bella Segal, commis et Clémence Warnickcr, commis, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de textiles et vêtements, sous le nom de \"Goodcraft Clothing Company Limited\", avec un capital de S30.000 divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le onze décembre 1951.L'Assistant-procureur général.31998 L.DÉSILETS.Hochelaga Auto Electric Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compapnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2.chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1951.constituant en corporation: Almanzor Laberge, comptable, Aline Nor-mandeau, sténographe, tous deux de la cité de Montréal, et Contran Daoust, comptable, domicilié à St-Vinccnt-de-Paul, tous du district de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce de véhicules moteurs, d'accessoires de garagiste, sous le nom de \"Hoche* laga Auto Electric Ltée\", avec un capital de §50,000 divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI 00 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI 00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-huit décembre 1951.L'Assistant-procureur général.31998 L.DÉSILETS.Ijay Investment Corporation Avis est donné qu'en vertu dé la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze décembre 1951, constituant en corporation: John J.Wasscrman, Sydney Phillips, avocats, et Tessy Frankel, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de portefeuille, d'immeubles et de placements, sous le Marist Brothers (Frères Maristes), under the name of \"Fédération des Amicales Maristes Canadiennes\".The amount to which the immoveable property, ot the revenue derived therefrom, which the corporation may hold is to be limited, is $200.000.The head oflice of the corporation will be at the \"Collège Laval\", Saint-Vicnent de Paid, 'judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of December.1951.L.DÉSILETS.3190S Deputy Attorney General.Coodcraft Clothing Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of December, 1951, incorporating: Peter Gotfrit, merchant, Bella Segal, clerk, and Clémence Warnickcr, clerk, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in textiles und clothing, under the name of \"Goodcraft Clothing Company Limited\", with a capital stock of 830,000 divided into 30!) shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Hochelaga Auto Electric Liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset.in conformity with section 2, chapter 276.R.S.Q.1941, bearing date the eighteenth day of December, 1951.incorporating: Almanzor Laberge, accountant, Aline Nonnandcau, stenographer, both of the city of Montreal, and Gontran Daoust, accountant, domiciled at Saint-Vincent-de-Paul, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in motor véhicules and accessories, and to act as garage-keeper, under the name of \"Hochelaga Auto Electric Ltée\", with, a capital stock of $50.000 divided into 300 common shares of value at par of $100 each and into 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 3199S Deputy Attorney General.Ijay Investment Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1951, incorporating: John J.Wasserman, Sydney Phillips, advocates, and Tessy Frankel, stenographer, all of the city and judiciul district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding, real estate and investment company, under the name of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol 84, No.6 409 nom de \"Ijay Investment Corporation\", avec un capital de S70.000 divisé en 100 actions ordinaires d'une Valeur au pair de S100 chacune et 600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compapnic sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1951.L'Assistant-procureur général.31998 L.DÉSILETS.Investment Services Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze décembre 1951, constituant en corporation: Alec Phelps Grigg, de Westmount, Charles Ambrose Lane Hibbard, de la cité de Montréal, tous deux avocats et conseils en loi du Roi et Robert Haggerty Short, comptable, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger des affaires comme conseillers en finance et en placement, sous le nom de \"Investment Services Inc.\", avec un capital de §40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 3199S L.DÉSILETS.ê _ J.E.Paré Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mo-risset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes en date du quinze décembre 1951, constituant en corporation Joseph-Edgar Paré, marchand, Dame Marie-Anne Paquet, épouse contractuellemcnt séparée de biens de J.-E.Paré, et Fernand Paré, commis, tous de Lauzon, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de nouveautés, merceries, quincaillerie, épicerie, matériaux de construction, sous le nom de \"J.-E.Paré Limitée\", avec un capital de 840,000 divisé en 400 actions de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Lauzon, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le quinze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.J.Novack Fur Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1941, des lettres patentes en date du vingt décembre 1951, constituant en corporation: Joel Novack, fourreur, Max Novack, marchand et Helen School Novack, épouse séparée de biens de Joel Novack, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: \u2022 Exercer le commerce et le négoce de pelleteries, peaux d'animaux cuir .et peaux vertes; et articles \"Ijay Investment Corporation\", with a capital stock of S70.000 divided into 100 common shares of the par value of S100 each, and 600 preferred shares of the par value of S100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of December, 1951.L.DÉSILETS.31098-o Deputy Attorney General.Investment Services Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1951, incorporating: Alec Phelps Grigg, of Westmount, Charles Ambrose Lane Hibbard.of the city of-Montreal, both advocates and King's Counsel, and Robert Haggerty Short, accountant, of the city of Montreal, all in the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as financial and investment advisers, under the name of \"Investment Services Inc.\", with a capital stock of 840,000 divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1951.L.DÉSILETS.31998-0 Deputy Attorney General.J.E.Paré Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of December, 1951, incorporating: Joseph-Edgar Paré, merchant.Dame .Marie-Anne Paquet, wife separate as to property by marriage contract of J.-E.Paré, and Fcrnand Pare, clerk, all of Lauzon.judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in novelties, dry-goods, hardware, groceries, building materials, under the name of \"J.-E.Paré Limitée\", with a capital stock of 840,000 divided into 400 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Lauzon, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General; the fifteenth day of December.1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.J.Novack Fur Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Alfred Morisset, in conformity with sccton 2, chapter 276, R.S.Q., bearing date the twentieth day of December, 1951, incorporating: Joel Navack, furrier, Max Novack merchant, and Helen Schoel Novack, wife separate as to property of Joel Novack, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an deal in fur pelts, animal skins and leather and hides; and wearing 410 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 8A, N° 6 vestimentaires, sous le nom de \"J.Novack Fur Company\", avec un capital de S40.000 divisé en 200 actions ordinaires de SI 00 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1485, rue Bleury, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Jones Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quinze décembre 1941, constituant en corporation: James Jones, industriel, David Lack, avocat et Pearl Aucrbach, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à manufacturer et faire le commerce d'ameublements de bureau et de maison, machinerie, outils, bois de charpente et bois de plaquage, sous le nom de \"Jones Industries Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 \u2022 L.DÉSILETS.apparel, under the name of \"J.Novack Fur Company\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the Company will be at 1485, Bleury Street, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.Jones Industries Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of December, 1951, incorporating: James Jones, industrialist, David Lack, advocate, and Pearl Aucrbach, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of manufacturing and dealing in office and household furniture, machinery, tools, timber, plywood, under the name of \"Jones Industries Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 2000 common shares at par value of $10 each and 200 preferred shares having a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.Jos.Latulippe Ltd Jos.Latulippe Avis est donné qu'en vertu de la première par- Notice is hereby given that under Part I of the tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été Quebec Companies' Act, letters patent have been accordé par le Lieutenant-gouverneur de la pro- issued by the Lieutenant-Governor of the Provin- vince de Québec des lettres patentes, en date du ce of Quebec, bearing date the twelfth day of De- douze décembre 1951, constituant en corporation: cember, 1951, incorporating: Paul Latulippe, Paul Latulippe, Roméo Latulippe, Joseph-Ed- Roméo Latulippe, Joseph Edmond Latulippe, mond Latulippe, Gérard Latulippe et Eugène Gérard Latulippe, et Eugène Latulippe, traders.Latulippe, commerçants, des cité et district ju- of the city and judicial district of Montreal, for diciaire de Montréal, pour les objets suivants: the following purposes: Exercer le commerce de quincaillerie, de maté- To deal in hardware, building materials, fur- riaux de construction, meubles et accessoires, sous niture and accessories, under the name of \"Jos le nom de \"Jos Latulippe j^»' avec un capital Latulippe ' with a capital stock of $175,000 de $175,000 divisé en 750 actions privilégiées divided into 750 preferred shares of a par value of d'une valeur au pair de $100 chacune et en 1,000 $100 each, and 1,000 common shares of a par actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 value of $100 each, chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the company will be at Mont-district judiciaire de Montréal.real, judicial district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le douze Dated at the office of the Attorney General, décembre, 1951.this twefth day of December, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 31998-o L.DÉSILETS.31998 Deputy Attorney General.Kill-Odor Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il à été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix- Kill-Odor Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the seventeenth day of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.6 sept décembre 1951, constituant en corporation: Nicholas Proctor, industriel, Neil Harold Mills, comptable et Claude Ducharme, avocat, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de germicides, désinfectants, antiseptiques, insecticides, vermicides et fongicides, sous le nom de \"Kill-Odor Products Inc.\", avec un capital de 810,000 divisé en 10,000 actions de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix-sept décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.La Compagnie Immobilière Stc-Cécilc*Ltéc Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze décembre 1951, constituant en corporation: Orner Carbonneau, contremaître, William Farrier, gérant, Roméo Baril, faiseur de papier, Aimé Dion, Adrien de Montigny, entrepreneurs, Liguori Villeneuve, entrepreneur-plombier, et Gérard Bourget, marchand, tous des cité et district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le métier d'agent d'immeubles, sous le nom de \"La Compagnie Immobilière Ste-Cécile Ltée\", avec un capital de §28,000 divisé en 280 actions de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le quinze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.La Compagnie Judc Tétreault*Limitée| Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du treize décembre 1951, constituant en corporation: Jude Téreault, marchand, Jean L%croix, télégraphiste, et Elphège Beauchênes, journalier, tous de Drummondvillc, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Faire le commerce des liqueurs douces de toutes sortes, sous le nom de \"La Compagnie Jude Té-trcault Limitée\", avec, un capital de $65,000 divisé en 650 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Drummondvillc, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le treize décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.L'Association des Propriétaires de Courville Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douze décembre 1951, constituant en corporation sans capital-actions: Georges-Henri Giroux, cultivateur, Jos.Thomassin, importateur, Albany Larouche, employé civil, Joseph Théberge, assistant-contremaître, Robert December, 1951, incorporating: Nicholas Proctor, industrial, Neil Harold Mills, accountant, and Claude Ducharme, advocate, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in germicides, désinfectants, antiseptics, insecticides, vermicides and fugicides.under the name of \"Kill-Odor Products Inc.\", with a capital stock of $10.000 divided into 10,000 shares of $1.each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, \u2022 31998-0 Deputy Attorney General.La Compagnie Immobilière Ste-Cécile Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of December, 1951, incorporating: Omer Carbonneau, foreman, William Farrier, manager, Roméo Baril, paper-maker, Aimé Dion, Adrien de Montigny, contractors, Liguori Villemure, plumbing-contractor, and Gérard Bourget, merchant, all of the judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on the business of real estate agent, under the name of \"La Compagnie Immobilière Ste-Cécile Ltée\", with a capital stock of $28,000 divided into 280 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, the fifteenth dav of December, 1951.L.DÉSDLETS, 31998 Deputy Attorney General.La'Compagnie Jude Tétreault Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1951, incorporating: Jude Tétreault, merchant, Jean Lacroix, telegraphist, and Elphège Beauchênes, laborer, all of Drummondville.judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To deal in soft drinks of all kinds, under the name of \"La Compagnie Jude Tétreault Limitée\", with a capital stock of $65.000 divided into 650 shares of $100 each.The head office of the company will be at Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.L'Association des Propriétaires de Courville Inc.Notice is hereby given that under Part LTI of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1951, to incorporate as a corporation without share-capital: Georges-Henri Giroux, farmer, Jos.Thomassin, importer, Albany Larouche, civil employee, Joseph Théberge, assistant-foreman.Robert Couillard, foreman. 412 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 8J\u201e N° 5 Couillard, contremaître, Armand Grenier, comptable, et Ulric Huot, gérant, tous de Courville, district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Protection et surveillance des intérêts communs des propriétaires de St-Louis de Courville, sous le nom de \"L'Association des Propriétaires de Courville Inc.\" Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $5,000.Le siège social de la corporation sera à Saint-Louis de Courville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le douze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.Le Marché Jules Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze décembre 1951, constituant en corporation: Jacques René de Cotret, comptable agréé, Henri Sylvestre, notaire, Bernard Pinard, avocat, tous de Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska, pour les objets suivants: Exercer le commerce de boucherie et d'épicerie, sous le nom de \"Le Marché Jules Limitée\", avec un capital de $40,000 divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 140, 12ème avenue, dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, Drummondvillc, district judiciaire d'Arthabaska.Daté du bureau du Procureur général le quatorze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.Les Magasins Yollande Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix décembre 1951, constituant en corporation: Jean-Charles Paradis, commerçant, Dame Eli-sianne \"Martel, commerçante, épouse séparée de biens de Jean-Charles Paradis, et Yolande Paradis, commerçante, tous des cité et district judiciaire de Chicoutimi.pour les objets suivants: Fabriquer et faire commerce des marchandises sèches, nouveautés, soie, toile, lainage, cotonnade, sous le nom de \"Les Magasins Yollande Limitée\", avec un capital de $40,000 divisé en 2,000 actions communes de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 239 est, rue Racine, Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le dix décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.Les Placements Baillar Ltée Baillai- Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2.chapitre 276, Armand Grenier, accountant, and Ulric Huot, manager, all of Courville, judicial district of Que-bec, for the following purposes: The protection and supervision of the common interests of the proprietors of St-Louis de Courville, under the name of \"L'Association des Propriétaires de Courville Inc.\" The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $5,000.The head office of the corporation will be at St-Louis de Courville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Le Marché Jules Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of December, 1951, incorporating: Jacques René de Cotret, chartered accountant, Henri Sylvestre, notary, Bernard Pinard, advocate, all of Drummondville, judicial district of Arthabaska, for the following purposes: To carry on business as butcher and grocer, under the name of \"Le Marché Jules Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 140, 12th avenue, in the municipality of Saint-Jean-Baptistc, Drummondville, judicial district of Arthabaska.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Les Magasins Yollande Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of December, 1951, ^incorporating: Jean-Charles Paradis, trader, Dame Elisianne Martel, trader, wife separate as to property of Jean-Charles Paradis, and Yolande Paradis, trader, all of the city and judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, novelties, silk, linen, woolens, cottons, under the name of \"Les Magasins Yollande Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 2,000 common shares of 810 each, and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 239 Racine street East, Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Les Placements Baillar Ltée Baillar Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.G 413 S.R.Q., 1951 des lettres patentes en date du vingt-huit décembre 195L constituant en corporation: P.-Lucien Lefcbvre, comptable, Gaston Péloquin, comptable, de la cité de Montréal, et Paul Hogue, commis, de Laval-des-Rapides, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placements, sous le nom de \"Les Placements Baillar Ltée\" \u2014 \"Baillar Investments Ltd.\", avec un capital de §75,000 divisé en 750 actions de S100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.Markirk Holdings, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi de la compagnie de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze décembre 1951.constituant en corporation: John Henry Ernest Colby, avocat, Galcn Lee Prime, gérant et Margot Mary Quinn.sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de portefeuille et de placements, sous le nom de ^Markirk Holdings Ltd.\", avec un capital de 810,000 divisé en 100 actions de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Mayfed Jewellers Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du dix décembre 1951, constituant en corporation: Eli Michœl Berger, avocat.Pearl Aucrbach et Rhoda Cohen, secrétaires, tous de-i cites et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce connue bijoutiers, orfèvres et faire le commerce d'outils, ameublement, appliqués, sous le nom de \"Mayfed Jewellers Ltd.\".avec un capital de 820.000 divisé en 400 actions de 850 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Mercerie Sherbrooke Ltée * Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du quinze décembre 1951.constituant en corporation: Lucien Bédard, ingénieur forestier, Henri Brunelle, Paul Gervais, agronomes, J.-Adélard Doyon, Bruno Michel, comptables, et Albert 276, R.S.Q., 1941, bearing date the twenty-eight day of December, 1951, incorporating: P.Lucien Lefebvre, accountant, Gaston Pelo-quin, accountant, of the city of Montreal, and Paul Hogue, clerk of Laval-des-Rapides, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Les Placements Baillar Ltée\" \u2014 \"Baillar Investments Ltd.\", with a capital stock of 875,000 divided into 750 shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, Judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-eight dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Markirk Holdings, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1951, incorporating: John Henry Ernest Colby, advocate, Galen Lee Prime, manager, and Margot Mary Quinn, stenographer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment company, under the name of ' Markirk Holdings, Ltd.\", with a capital stock of 810,000 divided into 100 shares of 8100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twelfth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Mayfed Jewellers Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the tenth day of December, 1951, incorporating: Eli Michad Berger, advocate, Pearl Aucrbach and Rhoda Cohen, secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on business as jewellers, silversmiths, and deal in tools, furniture, fixtures, under the name of \"Mayfed Jewellers Ltd.\", with a capital stock of 820,000 divided into 400 shares pf 850 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 3199S-0 Deputy Attorney General.Mercerie Sherbrooke Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the fifteenth day of December, 1951, incorporating: Lucien Bédard, forestry engineer, Henri Brunelle, Paul Gervais, \" agronomists, J.Adélard Doyon, Marcel Doyon, Bruno Michel, accountants, and Albert Dionne, 414 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 8/h N° G Dionne, barbier, tous de la cité de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de vêtements et articles de toilette, de chaussures, fourrures, sous le nom de \"Mercerie Sherbrooke Ltée\", avec un capital de §50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général le quinze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.Monde Sportif Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, des lettres patentes, en date du vingt-huit décembre 1951, constituant en corporation: Paul Desortniers, Ben Weider.éditeurs, et Jean Bradley, journaliste, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Éditer, imprimer et vendre des publications et faire le commerce de l'imprimerie, sous le nom de \"Monde Sportif Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 500 actions de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-huit décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.Morin & Frères Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, R.S.Q., 1951, des lettres patentes, en date du dix-huit décembre 1951, constituant en corporation: Clément Morin, entrepreneur général, Alfred Morin, enrtepreneur général, Jean-Noël Morin, commis, et dame veuve Philias Morin, ménagère, tous du Cap-de-la-Madeleine, district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants:.Faire le commerce de quincaillerie, ferronnerie, matériaux.de construction, sous le nom de \"Morin & Frères Incorporée\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 3,000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 2,000 actions privilégiées de $20.chacune; et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $20,000.Le siège social de la compagnie sera 65, Boulevard Ste-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le dix-huit décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.Parkway Electric, Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, barber, all of the city of Sherbrooke, judicial district of Saint Francis, for the following purposes: To engage in the business of and deal in clothing and toilet requisites, footwear and furs, under the name of \"Mercerie Sherbrooke Ltée\", with a capital stock of $50,000 divided into 500 shares of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Monde Sportif Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, hearing date the twenty-eight day of December, 1951, incorporating: Paul Desormicrs, Ben Weider, editors, and Jean Bradley, journalist, all of the city and judicial district of Montreal, fot the following purposes: To edit print and sell publications and carry on the printing business, under the name of \"Monde Sportif Inc.\", with a capital stock of $10,000 divided into 500 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $25.00 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twentv-eight dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Morin & Frères Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the eighteenth day of December, 1951, incorporating: Clément Morin, general contractor, Alfred Morin, general contractor, Jean Noël Morin, clerk, and Dame Widow Philias Morin, housewife, all of Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières.for the following purposes: To deal in hardware, ironware, building materials, under the name of \"Morin & Frères Incorporée\".The capital stock of the company will be divided into 3,000 shares without par or nominal value, and 2,000 preferred shares of $20 each; and the amount with which the company will begin its operations will be $20,000.The head office of the company will be at 65.Boulevard Ste-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Parkway Electric, Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2.chapter 276. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.6 415 S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du six décembre 1951, constituant en corporation: Harry Olishansky, marchand, Emmanuel Cooke, avocat et Lucy V.Clarke, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce d'accessoires électriques et appareils de maison, sous le nom de \"Parkway Electric Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 701 ouest Jean Talon.Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Raoul Chènevert Limitée - Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize décembre 1951, constituant en corporation: Raoul Chènevert, courtier en douane, Dame Marie-Ange Gagnon, épouse séparée de biens dudit Raoul Chènevert, et Pierre Chènevert, technicien en chimie, tous des cité et district des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Servir d'intermédiaire ou d'agent pour fin de dédouanement, importation et exportation, sous le nom de \"Raoul Chènevert Limitée\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le treize décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.Ridgewood Court Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze décembre 1951, constituant en corporation: Albert Laurent Bissonnette, avocat, Margot Mary Quinn et Marjorie Warkins, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une corporation de placements, sous le nom de \"Ridgewood Court Inc.\", avec un apital de $100,0000 divisé en 2,000 actions de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1311, Boulevard Mont-Royal, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatroze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DESILETS.Service d'Assurances Belec Insurance Service Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du douze décembre 1951, constituant en corporation: Médéric Belec, courtier d'assurances, Harold Joseph Evans, vendeur et Margaret Jean Kinhead, sténographe, tous de la cité de Sherbrooke, district judiciaire de St-François, pour les objets suivants: R.S.Q.1941, bearing date the sixth day of December, 1951, incorporating: Harry Olishansky, merchant, Emmanuel Cooke, advocate, and Lucy V.Clarke, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in electrical and household appliances, under the name of \"Parkway Electric, Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 701 Jean Talon West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.Raoul Chènevert Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies'.Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1951, incorporating: Raoul Chêne-vert, customs broker, Dame Marie-Ange Gagnon, wife separate as to property of said Raoul Chêne-vert, and Pierre Chènevert, technician in chemistry, all of the city and judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To act as intermediary or agent for the purpose of customs clearance, importing and exporting, under the name of \"Raoul Chènevert Limitée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Ridgewood Court Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the* Lieutenant-Governor of the Province of Quebec bearing date the fourteenth day of December, 1951, incorporating: Albert-Laurent Bissonnette, advocate, Margot Mary Quiiln and Majorie Watkins, secretaries, all of the city and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment corporation under the name of \"Ridgewood Court Inc.\", with' a capital stock of $100,000.divided into 2,000 shares of $50.each.The head office of the Company will be at 1311 Mount Royal Boulevard, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this fourteenth day of December, 1951.L.DESLLETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Service d'Assurances Belec Insurance Service Inc.\u2022 Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of December, 1951, incorprating: Médéric Belec, insurance broker, Harold Joseph Evans, salesman, and Margaret Jean Kinhead, stenographer, all of the City of Sherbrooke, judicial district of St.Francis, for the following purposes: 416 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome SA, N° 6 Exercer le commerce de courtiers d'assurance et agir comme agents d'assurance, sous le nom de \"Service d'Assurances Belec Insurance Service Inc.\", avec un capital de SI,000 divise en 100 actions de S10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sheer-hrooke, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, le douze décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DESILETS.Service Social de l'Abord-à-Plouflc Inc.L'Abord-h-Plouflc Social Service Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du cinq décembre 1951, consituant en corporation sans capital-actions: Yvon Jasmin, Réal Marcoux, Jean Drapeau, avocats, Rita Du-fresne et Lucienne Mérineau, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir toutes sortes d'organisations dont le but principal sera la charité, sous le nom de \"Service Social de l'Abord-à-Plouffe Inc.\"\u2014 \"L'Abord-à Plouffe Social Service Inc:\" Le montant auquel sont limités les biens immo biliers que la corporation peut posséder est de $200,000: Le siège social de la corporation sera dans la ville de l'Abord-à-PIouffe, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le cinq décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DESILETS.Spectator Sportswear Co.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date treize décembre 1951, constituant en corporation: Saul Tarnofsky, manufacturier, Dame Evelyn Enid Gross, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens de Saul Tarnofsky, Dame Rebecca Kushlin, ménagère, veuve de feu Sam Tarnofsky et Dame Celia Tarnofsky, ménagère épouse contractuellement séparée de biens de Issie Edgar et dûment autorisée par lui, tous des cité et district judiciaire de Montréal pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises sèches, vêtements et habits, sous le nom de \"Spectator Sportswear Co.Inc.\", avec un capital de S10.000 divisé en 500 actions ordinaires de S10 chacune et 500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize décembre 195L L'Assistant-procureur général, 31998 L.DESILETS.Spécialités Royal Specialties Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix décembre 1951, constituant en corporation: Charles-Edouard Dubois, commerçant, Alphonse Dubois, assistant-gérant, et Albert Deguire, To carry on the business of insurance brokers, and to act as insurance agents, under the name of \"Service d'Assurance Belec Insurance Service Inc.\", with a capital stock of $1,000.divided into 100 shares of 810 each.The head office of the Company will be at Sherbrooke, Judicial District of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General this twelfth dav of December, 1951 L.DESILETS.31998-0 Deputy Attorney General.Service Social de l'Abord-à-PloufTc Inc.L'Abord-a-Ploufte Social Service Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifth day of December, 1951, to incorporate as a corporation without share capital: Yvon Jasmin, Real Marcoux, Jean Drapeau, advocates, Rita Dufresnc ami Lucienne Mérineau.secretaries, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To promote all kinds of organizations whose main object will be charity, under the name of \"Service Social de l'Abord-à-Plouffe Inc.\" \u2014 \"L'Abord-à-Plouffe Social Service Inc.\" The amount to which the immova'de property which the corporation may hold is to be limited, is $200,000.The head office of the corporation will be in the Town of l'Abord-à-Plouffe, judicial distict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of December, 1951.L.DESILETS, 31998 Deputy Attorney General.Spectator Sportswear Co.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of- Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1951, incorporating: Saul Tarnosfsky, manufacturer, -Dame Evelyn Enid Gross, housewife, wife contractually separate as to property of Said -Tarnofsky, -Dame Rebecca Kushlin, housewife, widow of the late Sam-Tarnofsky, and Dame Celia Tarnofsky, housewife, wife contractually separate as to property of Issie Edgar, and^luly authorized by him, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in dry goods, clothing and garments under the name of \"Spectator Sportswear Co.Inc.\", with' a capital stock of $10,000.divide into 55 common shares of $10 each and 500 preferred shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirteenth dav of December, 1951.L.DESILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Spécialités Royal Specialties Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of December, 1951, incorporating: Charles Edouard Dubois, trader, Alphonse Dubois, assistant manager, and Albert Deguire, manager, all QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.SJ,, No.6 417 gérant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits alimentaires, vestimentaires, de toilette et de parfumerie, d'ameublements, de librairie, quincaillerie, bijouterie, sous le nom de ''Spécialités Royal Specialties Inc.\", avec un capital de $39,900 divisé en 399 actions de $100 chacune.Le siège social de la conipapnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le dix décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in food products, clothing, toilet articles, perfumes, furniture, stationery, hardware, jewellery, under the name of \"Spécialités Royal Specialties Inc.\", with a capital stock of $39,900, divided into 399 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Star Electric Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du treize décembre 1951, constituant en corporation: Armand Morissette, marchand, de Ville-montel, Mariette Morissette, commis, Charles-Eugène Hudon, commis, et Dame Aline Morissette Hudon, ménagère, épouse séparée de biens de Charles-Eugène Hudon, tous trois d'Amos, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Manufacturer, vendre et faire le commerce de toutes sortes d'appareils et matériaux électriques, magnétiques, galvaniques, ferronnerie, articles de sport et meubles, sous le nom de \"Star Electric Inc.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Amos, district judiciaire d'Abitibi.Daté du bureau du Procureur général, le treize décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.Star Electric Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of December, 1951, incorporating: Armand Morissette, merchant, of Villemontel, Mariette Morissette, clerk, Charles-Eugène Hudon, clerk, and Dame Aline Morissette Hudon,' housewife separate as to property of Charles-Eugène Hudon, all three of Amos, judicial district of Abitibi, for the following purposes: To manufacture, sell and deal in all kinds of apparatus and materials, whether electrical, magnetic, electro-plated and in ironware, sporting-goods and furniture, under the name of \"Star Electric Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the Company will be at An:os.judicial district of Abitibi.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Trinity Bay Products Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix décembre 1951, constituant en corporation: Sarto Goulet, industriel, Paul-André Gagné, clerc, et Dame Hélène Pedneault-Goulet, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens de Sarto Goulet, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire l'exploitation et le commerce des coquillages pour fins avicoles et tout produit marin, sou le nom de \"Trinity Bay Products Limited\", avec un capital de $100,000 divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le dix décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Two Mountains Equipment Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes, en date du dix-sept décembre 1951, constituant en corporation: Charles Forest, entrepreneur, de Ville Mont-Royal, Maurice Riel, avocat, de Laprairie, Trinity Bay Products Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of December, 1951, incorporating: Sarto Goulet, industrialist, Paul André Gagné, clerk, and Dame Hélène Pednault-Goulet, housewife, wife separate as to property by marriage contract of Sarto Goulet, all of the city and Judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in and with shells, for avicultural purposes and, in any other marine product, under the name of \"Trinity Bay Products Limited\", with a capital stock of $100,000 divided into shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec Dated at the office of £he Attorney General, this tenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Two Mountains Equipment Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the seventeenth day of December, 1951, incorporating: Charles Forest, contractor of the Town-of Mount Royal, Maurice Riel, advocate, .pf Laprairie, and Roland A.Diamond 418 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 84, N° 6 et Roland A.Diamond, notaire, de la cité de Montréal tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: De faire la vente de machinerie, équipement, quincaillerie, et de ferblanterie, sous le nom de \"Two Mountains Equipment Co.Ltd.\", avec un capital de 8100,000, divisé en 500 actions ordinaires de S100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix-sept décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.United Agency Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du six décembre 1951, constituant en corporation: Malcolm Stuart, agent d'assurances, Jean Mc-farlane, secrétaire, tous deux de la cité tic Montréal et Benjamin Robinson, avocat et conseil en loi du Roi, de la cité de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme courtiers d'assurances et agir comme agents d'assurances, sous le nom de \"United Agency Inc.\".Le capital-actions de la compagnie est divisé en 100 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et 950 actions privilégiées de 8100 chacune; et le montant avec lequel la compapnic commencera ses opérations sera, de $14,500.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.notary, of the City of Montreal, all of the Judicial district of Montreal, for the following purposes: To sell machinery, equipment, hardware and tin-ware, under the name of \"Two Mountains Equipment Co.Ltd\"., with a capital stock of $100,000 divided into 500 common shares of $100 each and in 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.United Agency Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the sixth day of December, 1951, incorporating: Malcolm Stuart, insurance agent, Jean Mcfarlane, secretary, both of the City of Montreal, and Benjamin Robinson, advocate and king's Counsel, of the City of Westmount, all in the judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers, and to act as insurance agents, under the name of \"United Agency Inc.\".The capital stock of the company is divided intc* 1000 common shares having no nominal or par value, and into 950 preferred shares of $100.each; and the amount with which the company will commence its operations will be $14,500.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-q Deputy Attorney General.West wood Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du quinze décembre 1951, constituant en corporation: John Richard Hyde, Roland-Gérard Lefran-çois, avocats et Robert John Forster, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général d'immeubles, de développement et d'assurances, sous le nom de \"Westwood Realties Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 35,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 363 Boulevard Décarie, Ville St-Laurent, district judiciaire de Montréal.' Daté du bureau du Procureur général, le quinze décembre 1951.Westwood Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q.1941, bearing date the fifteenth day of December, 1951, incorporating: John R:chard Hyde, Roland-Gérard Lefrançois, advocates, and Robert John Forster, accountant, all of the City and Judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on a general real estate, development and insurance business, under the name of \"West-wood Realties Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 500 common shares of $10.each, and 35,000 preferred shares of the par value of $1.each.The head office of the Company will be at 363 Decarie Boulevard, Town of St.Laurent, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of December, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSDLETS, 31998 L.DÉSILETS.31998-0 v Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.8A, No.6 419 Lettres patentes supplémentaires Cadillac Restaurant Limited Avis est donné qu'en vertu de la premiere partie de la Loi de la province de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 10 décembre 1951, à la compagnie \"Cadillac Restaurant Limited\", ratifiant son règlement No 21, augmentant son capital-actions de S15.000 à SI 15,000 par la création de 1,000 actions privilégiées de S100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 10 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 3199S L.DÉSILETS.Canadian Corporations, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 22 décembre 1951, à la compagnie \"Canadien Corporations, Limited\", ratifiant son règlement spécial \"C\", augmentant son capital autorisé par la création de 4,000 actions privilégiées de $10 chacune, sujettes aux droits et restrictions énoncés dans le règlement et déclarant que le montant du capital avec lequel la compagnie exercera dorénavant son commerce ne sera pas moins que $24,000.Daté du bureau du Procureur général, le 22 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Chibougamau Explorers Ltd.(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec et de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 270, des lettres patentes supplémentaires en date du 19 décembre 1951, à la compagnie \"Chibougamau Explorers Ltd.\" (Libre de responsabilité personnelle\u2014, ratifiant: 1° son règlement soixante et un, augmentant son capital de S3,000,000 à .$4,000,000 par la création de 1.000,000 d'actions ordinaires additionnelles de SI chacune; 2° son règlement soixante-deux, augmentant le nombre des directeurs de la compagnie de cinq à sept.Daté du bureau du Procureur général, le 19 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Citadel Brick Ltd.Brique Citadelle Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 18 décembre 1951, à la compagnie \"Citadel Brick Ltd.\u2014 Brique Citadelle Ltée\", ratifiant son règlement \"C\" 1°) subdivisant et convertissant les 14,000 actions Supplementary Letters Patent Cadillac Restaurant Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Cadillac Restaurant Limited\", ratifying its By-Law No.21 increasing its capital stock from S15.000 to SI 15,000, by the creation of 1,000 preferred shares of S100 each, comprising the rights, restrictions and privileges set forth in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 10th day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.Canadian Corporations, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 22nd day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Canadian Corporations, Limited\", ratifying its Special By-Law \"C\" increasing its authorized capital stock by the creation of 4,000 preferred shares of $10 each, subject to the rights and restrictijns set forth in the by-law, and declaring that the amount of capital with which the company shdl henceforth carry on business shall be not less than $24,000.Dated at the office of the Attorney General, this 22nd day of December, 1951.L.DESILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.T~ Chibougamau Explorers Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies Act and of Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the latter Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Chibougamau Explorers Ltd.\" (No Personal Liability), ratifying: 1° its By-Law Sixty-One increasing its capital stock from S3,000.000 to $4,000,000, by the creation of 1,000,000 additional common shares of $1 each; 2.By-Law Sixty-Two increasing the number of directors of the company from five to seven.Dated at the office of the Attorney General, this 19th day of December, 1951.' # L.DÉSILETS, 31998-o * Deputy Attorney General.Citadel Brick Ltd.Brique Citadelle Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the eighteenth day of December, 1951, were issued by the Lieutenant Governor of the Province of Quebec, to the company \"Citadel Brick Ltd.\u2014 Brique Citadelle Ltée\", ratifying its By-law \"C\" 1.) subdividing and converting the 14,000 common shares without 420 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 84, N° 6 ordinaires sans valeur au pair composant son capital-actions autorisé en 14,000 actions ordinaires sans valeur au pair et en 190,000 actions privilégiées de 85 chacune; 2°) augmentant tel capital-actions autorisé par la création de 00,000 actions privilégiées additionnelles de S5 chacune; 3°) énumérant les droits, restrictions et privilèges attachés aux actions privilégiées et fixant à $198,000 le montant avec lequel la compagnie continuera ses opérations à l'avenir.Daté du bureau du Procureur général, le 18 18 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.par value and into 190,000 preferred shares of $5 each; 2.) increasing said authorized capital stock by the creation of 60,000 additional preFer-re.l shares of 85 each; 3.) enumerating the rights, restrictions and privileges attaching to the preferred shares and fixing at S198.000 the amount with which the company will continue its future operations.Dated at the office of the Attorney General, this eighteenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.City Sponging Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutcnant-gouverncur'dc la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 10 décembre 1951, à la compagnie \"City Sponging Incorporated\", ratifiant son règlement N° 23: 1°) diminuant son capital-actions de 820,000 à S5,000 par l'annulation de 150 actions ordinaires de 8100 chacune 2e) augmentant ledit capital de $5,000 à $60.000 par la création de 150 actions ordinaires additionnelles de $100 chacune et 400 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux droits et restrictions mentionnés au règlement susdit.Daté du bureau du Procureur général, le 10 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.City Sponging Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"City Sponging Incorporated\", ratifying its By-Law No.23 1.) reducing its capital stock from S20.000 to 85,000, by the cancellation of 150 common shares of 8100 each; 2.) increasing said capital stock from $5,000 to $60,000, by the creation of 150 additional, common shares of S100 each and 400 preferred shares of $100 each, subject to the rights ami restrictions mentioned in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General the 10th day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Club Lac Bouchette de Roberval, Inc.Club Lac Bouchette de Roberval, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, supplementary let-été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ters patent, bearing date the fifteenth day of pjayince de Québec, représenté par M.Alfred December, 1951, were issued by the Lieutenant-Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Governor of the Province of Quebec, represented loi, S.R.Q.1941, chap.270, des lettres patentes by Mr.Alfred Morisset, in conformity with sec-supplémentaires, en date du 15 décembre 1951, tion 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, à la compagnie \"Club du Lac Bouchette Club, to the company \"Club du Lac Bouchette Club, Inc.\", constituée en corporation par lettres paten- Inc.\", incorporated by letters patent bearing tes du 5 juillet 1950, changeant son nom en celui date July fifth, 1950, changing its name to that de \"Club Lac Bouchette de Roberval, Inc.\" of \"Club Lac Bouchette de Roberval, Inc.\" Daté du bureau du Procureur général le 15 Dated the office of the Attorney General, this décembre 1951.fifteenth day of December, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 31998-q L.DÉSILETS.31998-o Deputy Attorney General.Georges Painchaud Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 13 décembre 1951, à la compagnie \"Georges Painchaud Limitée\", ratifiant son règlement mlméro 13-a: J° modifiant les dispositions des lettres patentes concernant les actions privilégiées en changeant les droits et restrictions attachés à telles actions privilégiées; 2° portant le capital-actions de la compagnie de $49,000 à $130.000 par la création de S.100 actions privilégiées additionnelles de $100 chacune, sujettes aux droits et restrictions indiqués audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 13 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS.Georges Painchaud Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the thirteenth day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Georges Painchaud Limitée\", ratifying its Bylaw No.13-a: 1.modifying the provisions of the letters patent concerning the preferred shares by changing the rights and restrictions attaching to such preferred shares; 2.increasing the capital stock of the company from $49,000 to $130,000 by the creation of 8,100 additional preferred shares of S100 each, subject to the rights and restrictions set forth ill the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1951: L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol 8A, No.6 421 Hcndcraon, Barwick Co., Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de latlite Loi, R.S.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 15 décembre 1951, à la compagnie \"Henderson, Barwick Co., Limited\", ratifiant son règlement \"M\" augmentant son capital de 899,000 à S799.000 par la création de 700,000 actions privilégiées deuxième catégorie de SI chacune, sujettes aux droits et restrictions énoncés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 15 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 - L.DÉSILETS.Indépendant Refrigeration Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 20 décembre 1951, à la compagnie \"Indépendant Electrical Refrigeration Service Limited\", constituée en corporation par lettres patentes du 23 novembre 1932, changeant son nom en celui de \"Indépendant Refrigeration Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 20 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.John Millcn Quebec Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite loi, S.R.Q.1941, chap.276, des lettres patentes supplémentaires, en date du 20 décembre 1951, à la compagnie \"John Millcn Quebec Limitée\", ratifiant son règlement spécial \"D\" portant de 4,000 à 8,000 les actions ordinaires sans valeur au pair de ladite compagnie et fixant à la somme de S 10,000 le montant avec lequel celle-ci continuera ses opérations à l'avenir.Daté du bureau du Procureur général, le 20 décembre 1951.L'Assistant-procureur général.31998-0 L.DÉSILETS.Henderson, Barwick Co., Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Henderson, Barwick Co., Limited\", ratifying its By-Law \"M\" increasing its capital stock from 899,000 to 8799,000, by the creation of 700,000 second preferred shares of 81 each, subject to the rights and restrictions set forth in sush by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 15th day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Indépendant Refrigeration Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twentieth day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Indépendant Electrical Refrigeration Service Limited\", incorporated by letters patent dated the 23rd of November, 1932, changing its name to that of \"Indépendant Refrigeration Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this twentieth dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.John Millen Quebec Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twentieth day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q., 1941, chapter 276, to the company \"John Millen Quebec Limitée\", ratifying its special by-law \"D\" increasing from 4,000 to 8,000 the common shares of no par value of the said company and fixing to the sum of S4O.O00 the amount with which the said company shall continue its operations in future.Dated at the office of the Attorney General, this twentieth day of December, 1951.L.DESILETS, 31998 Deputy Attorney General.La Cie Gagnon, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 6 décembre 1951, à \"La Cie Gagnon, Limitée\", ratifiant un règlement augmentant son capital-actions autorisé de $19,000 à $149,000, par la création de 10,000 actions privilégiées de $10 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 6 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.La Cie Gagnon, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent bearing date the sixth day of Decern-* ber, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the \"La Cie Gagnon, Limitée\", ratifying a By-law increasing its authorised capital stock from S49.000 to $149,000, by the creation of 10,000 preferred shares of $10 each, comprising the rights, restrictions and privileges as set forth in the said By-law.Dated at the office of the Deputy Attorney General, December 6, 1951.L: DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General. 422 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 84, 'N° 6 Lebœuf & Grenier, Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 7 décembre 1951, à la compagnie \"Lebœuf & Grenier, Limitée\", ratifiant son règlement numéro 4 augmentant son capital autorisé de $46,100 à §246,100, par la création de 200,000 actions privilégiées (2e catégorie) d'une valeur au pair de SI chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 7 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 3199S-0 L.DÉSILETS.Leduc Electrical Limited Avis est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 13 décembre 1951, à la compagnie \"Leduc Electrical Limited\", ratifiant son règlement No XIX, augmentant son capital-actions de $20,000 à S70,0()0 par la création de 50,-000 actions privilégiées de SI chacune, sujettres aux droits et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 13 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 3199S L.DESILETS, Maçonnerie du Saint-Laurent Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 5 décembre 1951, à la compagnie \"Jules Taillon Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 30 décembre 1949, ratifiant: 1° son règlement numéro 7 changeant son nom en celui de \"Maçonnerie du St-Laurent Ltée\"; 2° son règlement numéro 8 créant et émettant 200 actions communes de $100 chacune de son capital autorisé sous forme de 200 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans ledit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 5 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-o L.DÉSILETS, Modem Appliances Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 13 décembre 1951, à la compagnie \"The Modem Household Appliances Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 juin 1933 et par lettres patentes supplémentaires en date du 17 février 1941, ratifiant 1° son règlement N° 12, changeant son nom en celui de \"Modern Appliances Limited\"; 2° son règlement N° 13, augmentant son capital-actions de $20,000 à S195.000, par la création de 175,000 actions privilégiées, catégorie A, d'une valeur au pair de SI chacune, sujettes aux dits droits et restrictions tels que mentionnés au susdit règlement.Lebœuf & Grenier, Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplcmantary letters patent, bearing date the seventh day of December 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Lebœuf & Grenier, Limitée\", ratifying its By-law number 4, increasing its authorized capital from $46,100 to $246,100, by the creation of 200,000 preferred shares (class 2) of a par value of $1 each, comprising the rights, restrictions and privileges as set forth in the said by-law.Dated at the office of the Deputy Attorney General, December 7th, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Leduc Electrical Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 13th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Leduc Electrical Limited\", ratifying its By-Law No.XIX increasing its capital stock from $20,000 to $70,000, by the creation of 50,000 preferred shares of $1 each, subject to the rights and restrictions mentioned in such by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 13tli dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 3199S-o Deputy Attorney General.Maçonnerie du Saint-Laurent Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the fifth day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Jules Taillon Inc.\", incorporated by letters patent bearing date the 30th day of December, 1949, ratifying: 1.its By-law No.7 changing its name into that of \"Maçonnerie du St-Laurent Ltée\"; 2.its By-law No.8 creating and issuing 200 common shares of SI00 each of its authorized capital as 200 preferred shares of S100 each,subject to the rights, restrictions and privileges enumerated in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this fifth dav of December.1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Modern Appliances Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 13th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"The Modern Household Appliances Limited\", incorporated by letters patent dated June 10, 1933 and supplementary letters patent dated February 17, 1941, ratifying: 1.its By-law No.12 changing its name to that of \"Modern Appliances Limited\"; 2.By-Law No.13 increasing its capital stock from S20.000 to 8195,000, by the creation of S17\",000 preferred shares, Class A, of a par value of SI each, subject to such rights and restrictions as mentioned in the aforesaid by-law. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.6 423 Daté du bureau du Procureur général, le 13 décembre 1951.L'Assiitant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Nu-Way Food Products Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 5 décembre 1951, à la compagnie \"Nu-Way Food Products Incorporated\", ratifiant son règlement N° A, augmentant son capital de $40,000 à $140,000 par la création de 1,000 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux droits et restrictions mentionnés au susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 5 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Peter Pan Dress Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 270, des lettres patentes supplémentaires en date du 13 décembre 1951, à la compapnie \"Peter Pan Dress Inc.\", ratifiant son règlement N° 31, augmentant son capital autorisé de $49,000 à $129,000 par la création de 4,000 actions privilégiées de $20 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 13 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.PharmacicSj^VIodcrncs Inc.Avis est donné qu'en vertu de la premirèe partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, desWettrcs patentes supplémentaires, en date du 13 décembre 1951, à la compagnie \"Pharmacies Modernes Inc.\", ratifiant son règlement numéro 14-a augmentant son capital-actions de $168,000.à $300,000 par la création de 5,280 actions ordinaires additionnelles de $25 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 13 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 -o L.DÉSILETS.Ross-Smith Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 11 décembre 1951, à la compagnie \"Ross-Smith Company Limited\", ratifiant son règlement No 23, augmentant son capital-actions de $20,600 à S220.000 par la création de 20,000 actions privilégiées de $10 chacune, sujettes aux droits et restrictions mentionnés au susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 11 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS, Dated at the office of the Attorney General the 13th day of December, 1951.L.DESILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Nu-Way Food Products Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the, Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 5th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Nu-Way Food Products Incorporated\", ratifying its By-law No.A, increasing its capital stock from S40,000 to $140,000 by the creation of 1,000 preferred shares of $100 each subject to the rights and restrictions mentioned in the aforesaid bylaw.Dated at the office of the Attorney General, the 5th dav of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Peter Pan Dress Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent , bearing date the 13th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformitv with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Peter Pan Dress Inc.\", ratifying its By-law No.31 increasing its authorized capital stock from $49,000 to $129,000 by the creation of 4,000 preferred shares of $20 each, comprising the rights, restrictions and privileges mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 13th day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-0 Deputy Attorney General.Pharmacies Modernes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the thirteenth day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Pharmacies Modernes Inc.\", ratifying its Bylaw number 14-a, increasing its capital stock from $168,000 to $300,000 by the creation of 5,280 additional shares of $25 each.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney \u2022General.Ross-Smith Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Ross-Smith Company Limited'', ratifiying its Bv-Law No.23 increasing its capital stock from $20,000 to $220,000, by the creation of 20,-030 preferred shares of $10^ each, subject to the rights and restrictions mentioned in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 11th day of December, 1C51., L.DÉSILETS, 31998-0 Deputy Attorney General. 424 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome SA, N° 6 Rudolf Van Dcr Walde (Canada) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 12 décembre 1951, à la compagnie \"Rudolf Van Der Walde (Canada) Limited\", ratifiant son règlement N° 11 :a)réduisant son capital autorisé de 8100,000 à 820,000 par l'annulation de 800 actions privilégiées de S100 chacune formant partie dudit capital autorisé; b) augmentant ledit capital autorisé de $20,000 à $500,000, par la création de 4800 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilègea mentionnés au susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 12 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Ruwaca Pulp & Paper Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi S.R.Q.1941, chapitre 270, des lettres patentes supplémentaires en date du 21 décembre 1951 à la compagnie \"Ruwaca Pulp & Paper Limited\", ratifiant son règlement No \"A\", augmentant son capital autorisé de $20,000 à $200,000 par la creation de 1,800 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés au susdit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 21 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Rudolf Van Der Waldo (Canada) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Rudolf Van Dcr Walde (Canada) Limited\", ratifying its By-law No.11 : a) decreasing its authorized capital from 8100,000 to $20,000, by the cancellation of 800 preferred shares of $100 each forming part of the said authorized capital; b) increasing such authorized capital from $20,000 to $500,000, by the creation of 4800 preferred shares of $100 each, comprising the rights, restrictions and privileges mentioned in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 12th day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.Ruwaca Pulp & Paper Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"Ruwaca Pulp & Paper Limited\", ratifying its By-Law No.\"A\" increasing its authorized capital from $20,000 to $200,000, by the creation of 1,830 preferred shares of $100 each, comprising the rigths, restrictions and privileges set forth in the aforesaid by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 21st day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31988-0 Deputy Attorney General.Service Oucllet Ltée Service Ouellet Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première par tie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, ties lettres patentes supplémentaires, en date du 17 décembre 1951, à la compagnie \"Ouellet Automobiles Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes du 26 mai 1948, et par lettres patentes supplémentaires du 28 avril 1951, changeant son nom en celui de \"Service Ouellet Ltée\".Daté du bureau du Procureur général, le 17 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.Silbro Textile Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 10 décembre 1951, changeant le nom de \"Silbro's Limited\", une compagnie constituée en corporation par lettres patentes en date du 27 juin 1942, en celui de ''Silbro Textile Co.Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 10 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Notice is hereby giverf^hat under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the seventeenth day of December 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Ouellet Automobiles Inc.\" incorporated by letters patent dated May 26th, 1948, and by supplementary letters patent dated April 28th 1951, changing its name to that of \"Service Ouellet Ltée\".Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Silbro Textile Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, changing the name of \"Silbro's Limited\", a company incorporated by letters patent dated June 27, 1942, to that of \"Silbro Textile Co.Limited\".Dated at the office of the Attorney General, the 10th day of December, 1951.L.DÉSLLETS, 31998-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.81, No.6 425 Silbro Textile Co.Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes suppléracn-tairesNen date du 13 décembre 1951, à la compagnie \"Silbro Textile Co.Limited\", ratifiant son règlement N° 51 augmentant son capital de $20,000 à $120,000 par la création de 1,000 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 13 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Silbro Textile Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the 13th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Silbro Textile Co.Limited\", ratifying its By-law N°.51 increasing its capital stock from $20,000 to $120,000 by the creation of 1,000 preferred shares of $100 each, comprising the rights, restrictions and privileges set forth in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 13th day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-q Deputy Attorney General.Spino Construction Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par, le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 12 décembre 1951, à la compagnie \"Spino Construction Limited\", ratifiant son règlement numéro A-2 portant son capital-actions de $100,000 à $300,000.par la création de 15,000 actions ordinaires additionnelles de $10 chacune et de 500 actions privilégiées de $100 chacune, sujettes aux droits et restrictions indiqués audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 12 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998-0 L.DÉSILETS.Sutherland Construction Company Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 20 décembre 1951, à la compagnie \"Sutherland Construction Company\" ratifiant son règlement \"D\", augmentant son capital par la création de 500 actions privilégiées de $100 chacune, comportant les droits, restrictions et privilèges énoncés dans ce règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 20 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.The Mackay Realty Incorp'd Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset.conformément à l'article 2 de ladite Loi, S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes supplémentaires en date du 15 décembre 1951, à la compagnie \"The Mackay Realty Incorp-'d\",ra-tifiant son règlement N° 27; à) diminuant son capital-actions de $99,000 à $30,000 par l'annulation de 690 actions ordinaires de $100 chacune; b) augmentant ce capital-actions de $30,000 à $99,000 par la création de 190 actions ordinaires additionnelles de 8100 chacune et 500 actions privilégiées de 8100 chacun», sujettes aux droits et restrictions mentionnés audit règlement.Daté du bureau du Procureur général, le 15 décembre 1951.L'Assistant-procureur général, 31998 L.DÉSILETS.Spino Construction Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent bearing date the twelfth day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Spino Construction Limited\" ratifying its By-law number A-2 increasing its capital stock from 8100,000 to $300,000, by the creation of 15,000 additional common shares of $10 each.and 500 preferred shares of $100 each, subject to the rights and restrictions set forth in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998 Deputy Attorney General.Sutherland Construction Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Sutherland Construction Company\", ratifying its By-Law \"D\" increasing its capital stock by the creation of 500 preferred shares of $100 each, comprising the rights, restrictions and privileges set forth in such by-law.Dated at the office of the Attorney General, the 20th day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-o Deputy Attorney General.The Mackay Realty Incorp'd Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of December, 1951, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to the company \"The Mackay Realty Incorp'd\", ratifying its By-law No.27: a) reducing its capital stock from $99,000 to $30,000, by the cancellation of 690 common shares of $100 each: b) increasing such capital stock from 830,000 to $99,000, by the craetion of 190 additional common shares of S100 each and 500 preferred shares of $100 each, subject to the rights and restrictions mentioned in the said by-law.Dated at the office of the Attorney General, this 15th day of December, 1951.L.DÉSILETS, 31998-0 Deputy Attorney General. 426 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 81, N° 6 The Morris Finance & Mortgage Corporation The Morris Finance & Mortgage Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des comapgnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, supplementary let-été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ters patent, bearing date the 15th day of Decem-province de Québec, représenté par M.Alfred bcr, 1951, were issued by the Lieutenant-Gover-Morisset, conformcant à l'article 2 de ladite Loi nor of the Province of Quebec, represented by S.R.Q.1941, chapitre 27.6, des lettres patentes Mr.Alfred Morisset, in conformity with section supplémentaires en date du 15 décembre 1951 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to 1951 à la compagnie \"The Morris Finance & the company \"The Morris Finance & Mortgage Mortgage Corporation\", ratifiant son règlement Corporation\", ratifying its By-Law Number numéro quatre (4), modifiant certaines disposi- Four(4) modifying certain provision of the supputions des lettres patentes supplémentaires cou- mentary letters patent relating to the preferen-cernant les actions privilégiées de cette compagnie ce shares of this company.Daté du bureau du Procureur général, le 15 Dated at the office of the Attorney General, décembre 1951.this 15th day of December, 1951.L'Assistant-procureur général, L.DESILETS, 31998 L.DÉSILETS.31998-o Deputy Attorney General.W.J.Keating & Sons Ltd.W.J.Keating & Sons Ltd.Avis est donné'qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, supplementary let- été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la ters patent, bearing date the ISth day of Decem- province de Québec, représenté par M.Alfred ber, 1951, were issued by the Lieutenant-Gover- Morisset, conformément à l'article 2 de ladite Loi nor of the Province of Quebec, represented by S.R.Q.1941, chapitre 276, des lettres patentes sup- Mr.Alfred Morisset, in conformity with section plémentaires en date du 18 décembre 1951, à la 2 of the said Act, R.S.Q.1941, chapter 276, to compagnie \"W.J.Keating & Sons Ltd.\", ratifiant the company \"W.J.Keating & Sons Ltd.\", 1°) son règlement N° 27, étendant ses pouvoirs ratifying: 1.) its By-Law No.27 extending its 2 ) son règlement NJ 28, augmentant le capital powers; 2.) its By-Law No.28 increasing the autorisé de la compagnie de $20,000 à SI \"0,000 authorized capital of the company from $20,000 par la création de 1300 actions privilégiées de to $150,000, by the creation of 1300 preferred $100 chacune, comportant les droits, restrictions shares of $100 each, comprising the rights, énoncés audit règlement.restrictions and privileges set forth in the said by-law.Daté du bureau du Procureur général, le 18 Dated at the office of the Attorney General, décembre 1951.this ISth day of December, L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS.31998 L.DÉSILETS.31998-0 Deputy Attorney General.Actions en séparation de biens Canada, Province de Québec, District de Beaucc, dans la ('our Supérieure, N° 22,080.Dame Marie-Anne Giguère, épouse commune en biens de Euclide Roy, camionneur de St-Joseph, Cité de Beaucc, dûment autorisée aux fins des présentes, demsnderesse, vs Ledit Euclide Roy, camionneur de St-Joseph Comté de Bcauce, défendeur.La demanderesse a institué une action en séparation de biens en cette cause le 21 janvier 1952.St-Joseph de Beaucc, ce 25 janvier 1952.Les Procureurs de la demanderesse, 32007-u Drouin, Drouin & Lebel.Action en séparation de biens Canada, Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure, N° 311170.Dame Anita Turgel, épouse commune en biens de Moses David Selbst, résidante et domiciliée en les cité et district de Montréal, demanderesse, vs Moses David Selbst, marchand, des cité et district de Montréal, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée dans cette cause le 31e jour de janvier 1952: Montreal, 31 janvier 1952.Le Procureur de la demanderesse, 32025 LAWRENCE MARKS.Actions for separation as to property Canada Province of Quebec, District of Bcauce, in the Superior Court, No.22,080.Dame Marie-Anne Giguère, wife common as to property of Euclide Roy, trucker of St.Joseph de Beauce, duly authorized to institute proceedings, plaintiff, vs Euclide Roy, trucker of St.Joseph de Beaucc, defendant.An action in separation as to property has been instituted in this cause on January 21st, 1952.St.Joseph dc Beauce, January 25th 1952.Drouin, Drouin & Lebel, 32007-o Attorneys for the plaintiff.Action for separation as to tpopertv Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.311170.Dame Anita Turgel, wife common as to property of Moses David Selbst, residing and' domiciled in the City and District of Montreal, plaintiff, vs Moses David Selbst, merchant, of the city and District of Montreal, defendant.An action in separation as to property has been institued in this cause on the 31st, day of January, 1952.Montreal, January 31, 1952.LAWRENCE MARKS, 32025-o Attorney for the plaintiff. QUEBEC- OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.8A, No.6 427 Canada, Province de Québec, District dô Terrebonne, Cour Supérieur, N° 21299.Dame Marie Louise Pauline Proubt, épouse de Henri Lefebvre, entrepreneur domicilié à Ste-Thérèse, comté de Terrebonne, district de Terrebonne, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Saint-Jérôme, ce 31 janvier 1952.Les Procureurs de la demanderesse, 32009-o Signé: de Martiony & Marchessault AVIS Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure.Dame Mary (nommée Masha) Musicant, épouse commune en biens de Louis Ginsberg, boucher, de la cité de Montréal, demanderesse, vs Louis Gingbcrg, bouclier, du même lieu, défendeur.Une action en séparation de biens sera intentée dans cette cause après les délais légaux.Montréal, 2 février 1952.Le Procureur de la demanderesse, 32024 LOUIS DINER, C.R.Canada, Province de Québec, District de Québec, Cour Supérieure, N° 64-474.Dame Janet MacDonald Balscllie, demanderesse; vs Bernard Lahaisc, défendeur.Une action en séparation de biens a été intentée en cette cause.Québec, ce 7 février 1952.Le Procureur de la demanderesse, 32041-o WON CHAMBERLAND.Canada, Province of Quebec, District of Terrebonne, Superiror Court, No.21299.Dame Marie Louise Pauline Proulx, wife of Henri Lefebvre, contractor, domiciled at Ste-Thérèse, county of Terrebonne, district of Terrebonne, has entered an action against her husband for separation as to property.Saint-Jérôme, January 31, 1952.(Signed) de Martiony & Marchessault, 32009 Attorneys for the plaintiff.NOTICE Province of Quebec District of Montreal, Superior Court.Dame Mary (Called Masha) Musicant, wife common as to property of Louis Ginsberg, butcher of the City of Montreal, plaintiff vs Louis Ginsberg, butcher, of the same place, defendant.An action in separation as to property will be instituted in this case after legal delays.Montreal, February 2nd, 1952.LOUIS DINER, K.C., 32024-o Attorney for the plaintiff.Canada, Province of Quebec, District of Quebec Superior Court, No.64-474.Janet MacDonald Balscllie, plaintiff; vs Bernard Lahaise, defendant, An action in separation as to property has been instituted in this case.Quebec, February 7th, 1952.YVON CHAMBERLAND, 3204l-o Attorney for Plaintiff.Avis divers J.B.Deschamps, Incorporée Règlement No 22 Augmentant le nombre des directeurs de trois à cinq \"Les affaires- de la compagnie seront administrées par un bureau de direction de cinq directeurs dont trois formeront quorum.\" Beauport, le 21 janvier 1952 Certifié vraie copie.Le Secrétaire, 32003-o LOUIS DESCHAMPS, J.B.Harper (Limitée) J.B.Harper (Limited) Règlement numéro 6-A (Amendement au règlement numéro 6) Qu'il soit décrété comme règlement numéro 6-A de la compagnie \"J.-B.Harper (Limitée) \u2014 J.-B.Harper (Limited)\", comme suit: \"Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est par la présente augmenté de trois (3) à sept (7), et que le quorum aux assemblées des directeurs soit d'au moins quatre (4), conformément à l'article 84 de la Loi des Compangies de Québec.\" Le Président, ALBERT ROY.Le Secrétaire, 32004 DONAT VIEN.Miscellaneous Notices J.B.Deschamps, Incorporée By-law No.22 Increasing the number of directors from three to five \"The affairs of the company will be managed by a board of directors composed of five members, three of whom will form a quorum.\" Beauport, January 21, 1952.Certified true copy LOUIS DESCHAMPS, 32003 - Secretary.J.B.Harper (Limitée) -J.B.Harper (Limited) By-law Number C-A (Amending By-law Number 6) Be it enacted as By-law Number 6-A of the company \"J.-B.Harper (Limitée) \u2014 J.B.Harper (Limited) as follows: \"That the number of the directors of the company be and the same is hereby increased from three (3) to seven (7), and that the quorum at the directors' meetings be at least four (4), in conformity with section 84 of the Quebec Companies Act.\" ALBERT ROY, President.DONAT VIEN, 32004 Secretary, 428 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 8/,, N° 6 The Megantic People's Telephone Company Sommaire des règlements spéciaux Les règlements spéciaux passés par les administrateurs de \"The Megantic People's Telephone Company\", pourvoie à la distribution des biens de la Compagnie au pro rata entre ses actionnaires et, après telle distribution, à la dissolution de la Compagnie et à l'abandon de sa charte.Vraie copie certifiée le 30ième jour de janvier 1952.(Sceau) Le Secrétaire-trésorier, 32005-o A.J.SMYTH.The Megantic People's Telephone Company Summary of Special By-laws Special by-law enacted by the Directors of \"The Megantic People's Telephone Company\", provided for the distribution of all assets of this Company pro rata amongst its shareholders and, upon such distribution being made, for the dissolution of the Company and the surrender of its charter.A certified true summary, this 30th day of Januarv, 1952.(Seal) A.J.SMYTH.32005-o Secretary-Treasurer.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Club Automobile St-Pierre & Ste-Annc\", en date du 20 novembre 1951, dont le siège social est situé à Saint-Grorges, comté de Beauce, et que, ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétariat de la Province, le 31 janvier 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32010-o JEAN BRUCHÉSI, Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the dccleration of foundation of the cooperative syndicate \"Club Automobile St-Pierre & Stc-Anne\", under the 20th day of November, 1951 whereof the head office is at Saint-Georges, county of Bcauce, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 31st day of January, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32010 Under Secretary of the Province.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société sous le nom de \"L'Association des Employés de Sorel Clothing et Master Craft Uniform Co.Ltd\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 31 janvier 1952.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Sorel, comté de Richelieu.Le Sous-secrétaire de la Province, 3201 l-o JEAN BRUCHÉSI.NOTICE (Professional Syndicate's Act) The formation of an association under the name of \"L'Association des Employés de Sorel Clothing et Master Craft Uniform Co.Ltd\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on January 31, 1952.The principal place of business of the said professional syncicatc is at Sorel, county of Richelieu.^ JEAN BRUCHÉSI, 32011 Under Secretary of the Province.Avis est donné que, sur la recommandation de 1*Assistant-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 22 janvier 1952, les trois amendements apportes aux règlements de \"La Société des Hommes d'Affaires de l'Est de Montréal\", tels qu'adoptés à l'assemblée annuelle tenue les 7 et 17 mai 1951, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province le 23 janvier 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32012-o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the three amendments made to the By-laws of \"La Société des Homines d'Affaires de l'Est de Montréal\", as adopted at the annual meeting held on the 7th and 17th of May, 1951 were approved by the Honourable the Provincial Secretary, on January 22nd, 1952, pursuant to the provision of section 225a of the Quebec Companies Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of January.1952.JEAN BRUCHÉSI, 32012 Under Secretary of the Province.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistànt-procureur général, l'honorable Secrétaire de la province a approuvé, le 4 février 1942, les règlements comprenant les articles 1 à 47 inclusivement de \"Le Centre Médico-Social pour Enfants Inc.\", tels qu'adoptés à l'assemblée général spéciale tenue le 14 janvier 1952, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 4 février 1952.Le Sous-secrétaire de la province, 32023-o JEAN BRUCHÉSI.Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the By-laws comprising articles 1 to 47 inclusively of \"Le Centre Medico-Social pour Enfants Inc.\", as adopted as the special general meeting held on January 14, 1952, was approuved by the Honourable the Provincial Secretary on February 4, 1952, pursuant to the provisions of section 226 of the Quebec Companies Act.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of February, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32023 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol 84, No.6 429 Compagnie Vanier Limitée Règlement N° 28 Soit un règlement concernant la distribution des biens de \"Compagnie Vanicr Limitée\" 1° Considérant que \"Compagnie Vanier Limitée\" a cessé de faire affaires, excepté pour les fins de liquider ses affaires; 2° Considérant que \"Compagnie Vanier Limitée\" n'a aucune dette ni aucune obligation qui ne sont pas complètement protégées.Qu'il soit statué comme le règlement de \"Compagnie Vanier Limitée\" portant le N° 28: 1° Que \"Compagnie Vanier Limitée\" est autorisée à disposer de ses biens, de distribuer tout son actif au \"pro rata\" parmi ses actionnaires et subséquemment, de procéder à la dissolution de \"Compagnie Vanier Limitée\", en suivant les formalités de l'abandon de la charte requises sous la Section 20 de la Loi des Compagnies de la Province de Québec.2° Que les directeurs et officiers sont autorisés et requis de signer tous actes et documents et de faire et exécuter toutes choses nécessaires ou désirables 'pour le plein accomplissement des prémisses.Unanimement adopté.Statué ce 1er février, 1952.La Présidente.(Signé) MARIE EVA TRUDEAU.Le Secrétaire (Signé) G.BRAULT.Je, soussigné, Georges Brault, secrétaire, déclare que les présentes sont une vraie copie de l'original.Montréal, 1er février, 1952.(Sceau) Le Secrétaire, 32015-0 G.BRAULT.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"La Caisse Populaire de Sault-au-Mouton\", en date du 8 avril 1951, dont le siège social est situé à Sault-au-Mouton, comté de Saguenay, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 2 février 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32016-o JEAN BRUCHÉSI.AVIS DE CHANGEMENT DE NOM (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la province a autorisé, le 21 janvier 1952, le changement de nom du \"Centre des Industriels Chrétiens\", dont le siège social est situé en la ville de Québec, district judiciaire de Québec, en celui de \"Centre des Patrons Chrétiens\", et ce, conformément aux dispositions des articles 7 et suivants de la Loi des syndicats professionnels (S.R.Q.1941, chapitre 162).Donné au bureau du Secrétaire de la province, ce 22 janvier 1952.Compagnie Vanier Limitée By-law No.28 Being a By-Law for distributing the assets of \"Compagnie Vanier Limitée\".1st.Considering that \"Compagnie Vanier Limitée\", has ceased to carry on business except for the purposes of winding-up its affairs; 2nd.Considering that \"Compagnie Vanier Limitée\", has no debts or obligations that have not been fully protected.That it be enacted as a By-Law of \"Compagnie Vanier Limitée\", bearing N° 28: 1st.That \"Compagnie Vanier Limitée\" is authorized to dispose of its property, distribute its assets rateably among its shareholders and subsequently, to proceed to the dissolution of \"Compagnie Vanier Limitée\" in following the formalities required by way of surrender of the Charter under Section 26 of Quebec Companies Act.2nd.That the Directors and Officiers are hereby authorized and directed to do, sign and cxecutcyall things necessary or desirable for the due carrying out of the foregoing.Unanimously adopted.Enacted this 1st February, 1952.(Signed) MARIE EVA TRUDEAU, President.(Signed) G.BRAULT, Secretary.I, the undersigned, Georges Brault, Secretary, declare the above to be a true copy of the original.Montreal, February 1st, 1952.(Seal) G.BRAULT, 32015-o Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the decleration of foundation of the cooperative syndicate \"La Caisse Populaire de Sault-au-Mouton\", under date the 8th day of April, 1951, whereof the head office is at Sault-au-Mouton, county of Saguenay, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of February, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32016 Under Secretary of the Province.NOTICE OF CHANGE OF NAME (Professional Syndicates.Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has authorized, as of the 21st of January, 1952, the change of name of the \"Centre des Industriels Chrétiens\", whereof the principal place of business is in the City of Quebec, judicial district of Quebec, into that of \"Centre des Patrons Chrétiens\", and such, pursuant to the provisions of section 7 and following of the Professional Syndicates' Act (R.S.Q., 1941, chapter 1621.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of January, 1952.Le Sous-secrétaire de la province, JEAN BRUCHÉSI, 32022-o JEAN BRUCHÉSI.32022 Under Secretary of the Province. 430 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1962, Tome 84, N° 6 Avis est par les présentes donné que l'honora- Notice is hereby given that the Honourable ble Secrétaire de la Province a dûment reçu le the Provincial Secretary has duly received the troisième original de la déclaration de fondation third copy of the original of the declaration of du syndicat coopératif \"Gaspé Arena Coopéra- foundation of the cooperative syndicate \"Gaspé tive \u2014 La Coopérative de 1'Arena de Gaspé\", Arena Coopérative \u2014 \"La Coopérative de L'Aré- en date du 28 décembre 1951, dont le siège social na de Gaspé\".under date the twenty-eight day est situé à Gaspé, comté de Gaspé-Sud, et que of December, 1951, whereof the head office is ce document a été déposé dans les archives du at Gaspé, county of Gaspé-South, and that the Secrétariat de la Province.said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, Given at the office of the Provincial Secretary, le 19 Janvier 1952.this nineteenth day of January, 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, JEAN BRUCHÉSI, 32026-o JEAN BRUCHÉSI.32020 Under Secretary of the Province.Perma-Knit Limited Un règlement pour décroissance le nombre de directeur de la compagnie ci-dessus de quatre à trois.Règlements N° 12 \"12.Les affaires de la compagnie seront administrées par un bureau de direction de trois directeurs.\" (Sceau) Le Secrétaire, 32033-o J.KASHE.Perma-Knit Limited By-law decreasing the number of Directors of the above company from four to three.By-law No 12 \"12.The affairs of the company shall be managed by a Board of Three Directors.\" (Seal) J.KASHE, 32033-o Secretary.Laurentian Investment Company Sommaire des règlements spéciaux Les règlements spéciaux passés par les administrateurs de \"Laurentian Investment Company\" pourvoient à la distribution des biens de la Compagnie au pro rata entre ses actionnaires et, après telle distribution, à la dissolution de la Compagnie et à l'abandon de sa charte.Vraie copie certifiée le sixième jour de février 1952.Le Secrétaire, 32034-O C.TAYLOR.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Les Services Médicaux et Hospitaliers de Montréal\", en date du 30 janvier 1952, dont le siège social est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 4 février 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32037-o JEAN BRUCHÉSI.Avis est par les1 présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Les Services Médicaux et Hospitaliers des Comtés de St-Maurice et de Laviolette\", en date du 23 janvier 1952, dont le siège social est situé à Shawinigan-Falls, comté de St-Maurice, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 6 février 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32038-o JEAN BRUCHÉSI.Laurentian Investment Company Summary of Special By-laws Special by-laws enacted by the Directors of \"Laurentian Investment Company\" provide for the distribution of all assets of this Company pro rata amongst its shareholders and, upon such distribution being made, for the dissolution of the Company and the surrender of its charter.A certified true summary, this sixth day of February, 1952.C.TAYLOR, 32034-o Secretary.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Les Services médicaux et Hospitaliers de Montréal\", dated January 30, 1952, whereof the head office is at Montreal, judicial district of Montreal, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary February 4, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32037 Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Les Services Médicaux et Hospitaliers dès comtés de St-Maurice et de Laviolette\", dated January 23, 1952, whereof the head office is at Shawinigan-Falls, county of St-Maurice, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, February 6, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 32038 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.6 431 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Les Services Médicaux et Hospitaliers des Trois-Rivières\", en date du 22 janvier 1952, dont le siège social est situé aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 4 février 1952.Le Sous-secrétaire de la Province, 32039-o JEAN BRUCHÉSI.Atlas Hoist & Body Inc.Extrait des minutes d'une assemblée du bureau de direction de la compagnie \"Atlas Hoist & Body Inc.\" tenue au breau de Mtres Green-blatt & Godinsky, avocats, Montréal, le 23e jour de novembre 1951.Il a été proposé, secondé et résolu à l'unanimité que le suivant soit adopté comme le règlement N° 24 de la compagnie: \"Règlement N° 24\" Qu'il soit décrété et il est, par les présentes, décrété comme un règlement de la compagnie \"Atlas Hoist & Body Inc.\" ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est, par les présentes, augmenté de cinq à six de manière à ce que le bureau de direction soit composé dorénavant de six directeurs.Le Président, B.RICHLER.Le Secrétaire, 32045-o F.RICHLER.Atlas Press Limited Règlement spécial \"II\" Un règlement pour diminuer le nombre des directeurs et amender le règlement II en conséquence.Le nombre des directeurs de cette compagnie est, par les présentes, diminué de cinq à trois et le premier paragraphe du règlement II de la compagnie, tel qu'amendé, est, par les présentes, amendé de nouveau en y rayant le mot \"cinq\" et en y substituant le mot \"trois\".Je, le soussigné, secrétaire de la compagnie Atlas Press Limited, certifie, par les présentes, que le précédent est une copie conforme et exacte du règlement spécial \"H\" de ladite compagnie.Montréal, P.Q., 5 février 1952.(Sceau) Le Secrétaire, 32050 GEO.NICOL.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Les Services Médicaux et Hospitaliers des Trois-Rivières\" dated January 22, 1952, whereof the head office is at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, February 4, 1952.JEAN BRUCHÉSI, 31039 Under Secretary .of the Province.Atlas Hoist & Body Inc.Extract of minutes of meeting of the Board of directors of \"Atlas Hoist & Body Inc.\" held at the office of Mtres Greenblatt & Godinsky, advocates, Montreal, on the 23rd day of November, 1951.It was moved, second and unanimously resolved that the following be adopted as By-law No.24 of the Company: \"By-Laxo No.24\" Be it enacted and it is hereby enacted as a By-law of \"Atlas Hoist & Body Inc.\" as follows: 1.The number of Directors of the Company be and the same is hereby increased from five to six so that the Board of Directors of the Company shall hereafter be composed of six Directors.B.RICHLER, President.F.RICHLER, 32045-o Secretary.Atlas Press Limited Special By-Law \"II\" A By-law to reduce the number of Directors and to amend By-Law II accordingly.The number of Directors of this Company is hereby reduced from five to three and the first paragraph of By-Law II of the Company, as amended, is hereby further amended by deleting therefrom the word \"five\" and by substituting therefor the word \"three\".I, the undersigned, Secretary of Atlas Press Limited, do hereby certifiy that the foregoing is a true and correct copy of Special By-law \"H\" of the said Company.Montreal, P.Q., 5th February, 1952.(Seal) GEO.NICOL, 32050-o Secretary.Chartes \u2014 Abandon de Christie Mining Syndicate Inc.Avis est par les présentes donné qu'en vertu de la Loi des compagnies de Québec, la compagnie \"Christie Mining Syndicate Inc.\", a l'intention de demander au Procureur général de la province de-Québec, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 6 février 1952.Le Secrétaire, 32040 JOHN KERVIN.Charters \u2014 Surrender of Christie Mining Syndicate Inc.Notice is hereby given under the Quebec Companies Act, that \"Christie Mining Syndicate Inc.\", to apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter.Montreal, February 6th, 1952.JOHN KERVIN, 32040-o Secretary. 432 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 84, N° 6 The Meqantic People's Telephone Company Avis est par les présentes donné que \"The Megantic People's Telephone Company\", dont le bureau-chef est a Inverness, Province de Québec, s'adressera au Procureur Général de la Province de Québec pour demander la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 30 janvier 1952.Les Procureurs de The Megantic People's Telephone Company, 32006-o MUNNOCH & VENNE.Avis de demande d'abandon de charte Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec, la- compagnie U.S.Canadian & Cuba Co.Ltd.donne, par les pré, sentes, avis public qu'elle demandera au Procureur général et au Ministre des affaires municipales, de l'industrie et du commerce la permission d'abandonner sa charte et être déclarée dissoute.Daté à Montréal, ce 22c jour de janvier 1952.Par ordre du bureau de direction.Le Procureur de la compagnie, 32017 HAROLD S.FREEMAN.South American Agencies Limited Avis est par les présentes donné que la compagnie \"South American Agencies Limited\" a l'intention de demander au Procureur général de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de l'article 29 de la Loi des compagnies de Québec.Daté en la cité de Montréal, P.Q.le 31 janvier 1952.Le Secrétaire, 32021 LAURETTE SANGUINET.Laurentian Investment Company Avis est par les présentes donné que \"Laurentian Investment Company\", dont le siège social est à Montréal, Province de Québec, s'adressera au Procureur Général de la Province de Québec pour demander la permission d'abanconner sa charte.Montréal, le 6 janvier 1952.Les Procureurs de Laurentian Investment Company, 32035-o MUNNOCH & VENNE.Compagnies dissoutes Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Immeubles Vendôme Limitée \u2014 Vendôme Realties Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 novembre 1943.Avis est de plus donné qu'à compter du premier février 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 février 1952.L'Assistant-procureur général, 32018-o L.DÉSILETS.The Megantic People's Telephone Company Notice is hereby given that \"The Megantic People's Telephone Company\", with head office at Inverness, Province of Quebec, will apply to the Attorney General for the Province of Quebec for leave to surrender its Charter.Montreal, January 30,1952.MUNNOCH & VENNE, Attorneys for The Megantic People's 32006-0 Telephone Company.Notice of application for surrendeh of charter Under the provisions of the Quebec Companies Act, U.S., Canadian & Cuba Co.Ltd., hereby gives public notice that it will make application to the Attorney General and to the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce, for leave to surrender its charter and to be declared dissolved.Dated at Montreal, this 22nd day of January, 1952.By order of the Board of Directors.HAROLD S.FREEMAN, 32017-o Attorney for the Company.South American Agencies Limited Notice is hereby given that South American Agencies Limited intends to make application to The Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its Charter pursuant to the provisions of Section 29 of The Companies Act.Dated at the City of Montreal, P.Q., this 31st day of January, 1952.LAURETTE SANGUINET, 32021-o Secretary.Laurentian Investment Company Notice is hereby given that \"Laurentian Investment Company\", with head office at Montreal, Province of Quebec, will apply to the Attorney General for the Province of Quebec for leave to surrender its Charter.« Montreal, January 6, 1952.MUNNOCH & VENNE, Attorneys for 32035-o Laurentian Investment Company.Companies Dissolved Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Immeubles Vendôme Limitée \u2014 Vendôme Realties Limited\", incorporated by letters patent dated November 12, 1943.Notice is also given that from and after the first day of February, 1952, the said company has been dissolved.Dated.at the office of the Attorney General, this 2nd day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32018 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.6 433 Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de \"La Mané-canterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois de Québec, Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 20 avril 1950.Avis est de plus donné qu'à compter du premier février 1952, ladite corporation a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 février 1952.L'Assistant-procureur général, 32018-o L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Lanthier & Sons Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 19 octobre 1948.Avis est de plus donné qu'à compter du premier février 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 2 février 1952.L'Assistant-procureur général, 32018 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la respunsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Leduc & Prieur, Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 16 juin 1931.Avis est de plus donné qu'à compter du premier février 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général le 2 fé-virer 1952.L'Assistant-procureur général, 32018-o L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donsé qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d-'ac-cepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Teen-O-Miss Inc.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 avril 1947.Avis est de plus donné qu'à compter du premier février 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 2 février 1952.L'Assistant-procureur général, 3201S \u2022 L.DÉSILETS.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 20, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compapnie \"Whalcn Cartage Co.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 18 février 1937.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of \"La Ma-nécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois de Québec, Inc.\", incorporated by letters patent dated April 20, 1950.Notice is also given that from and after the first day of February, 1952, the said corporation has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this 2nd day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32018 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Lanthier & Sons Limited\", incorporated by letters patent dated the 19th day of October, 1948, Notice is also given that from and after the first day of February, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the 2nd day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32018-o Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, section 26, chapter 276, R.S.Q., 1941 and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Leduc & Prieur, Limitée\", incorporated by letters patent dated the 16th day of June, 1931.Notice is also hereby given that from and after the 1st day of February, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, February 2, 1952.L.DÉSILETS, 32018 Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Teen-O-Miss Inc.\", incorporated by letters patent dated the 24th day of April, 1947.Notice is also given that from and after the first day of February, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the 2nd day of February, 1952.L.DÉSILETS, 32018-o Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 270, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Whalen Cartage Co.\", incorporated by letters patent dated the 18th day of February, 1937. 434 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1962, Tome 84, N° 6 Avis est de plus donné qu'à compter du premier février 1952, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 2 février 1952.L'Assistant-procureur général, 32018 L.DÉSILETS.Notice is also given that from and after the first day of February, 1952, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, the 2nd day of Februarv, 1952.L.DÉSILETS, 32018-o Deputy Attorney General.Département des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Annexion à la cité de Thetford-Mines A qui les présentes peuvent concerner: Avis est par les présentes donné que, par l'arrêté en conseil N° 61, du 31 janvier 1952, il a plu au Lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver le règlement N° 403 du conseil de la cité de Thet-ford-Mines, et de décréter que le territoire mentionné audit règlement et décrit ci-dessous est détaché de la municipalité de Rivière-Blanche et annexé à la cité de Thetford-Mines.Ce territoire est le suivant: Un territoire situé dans le canton d'Ireland, comprenant en référence au cadastre officiel pour ledit canton, tous les lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que tous les chemins, rues, ruelles cours d'eau, ou partie d'iceux, renfermés dans les limites suivantes, à savoir: partant au point d'intersection de la ligne separative des cantons d'Ireand et de Thetford avec la ligne sud-est du lot 560; de là, passant par les lignes suivantes en continuité les unes des autres: ladite ligne sud-est du lot 560; la ligne nord-est des lots de subdivisions 560-1, 560-2 et 560-3; la ligne nord-ouest du lot de subdivision 560-3; une ligne droite joignant le coin ouest du lot de subdivision 560-3 au coin nord du lot de subdivision 557-62; la ligne nord-ouest des lots de subdivision 557-62, 557-60, 557-59 et 557-58; la ligne sud-ouest des lots de subdivision 557-58, 557-57 et 557-56; la ligne sud-est des lots de subdivisions 557-53, 557-87 et 557-86; la ligne sud-est du lot 557, la ligne separative des rangs VIII et IX sur la largeur des lots 557 et 556; la ligne nord-ouest des lots 556 et 561 et enfin la ligne separative des cantons d'Ireland et de Thetford jusqu'au point de départ.Québec, le 31 janvier 1952.Le Ministre des Affaires Municipales, 32019-o BONA DUSSAULT.Annexation to the city of Tetford-Mines To whom it may concern: Notice is hereby given that, by Order in Council No.61 of the 31st of January, 1952, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to approve By-law No.403 of the Council of the City of Thetford-Mines, and to enact that the territory mentioned in the said bylaw and described below, is detach from the municipality of Rivière-Blanche and annexed to the city of Thetford-Mines.The said territory being the following; A territory situate in the Township of Ireland, comprising, with reference to the official cadastre for the said township, all the lots and their present and future subdivisions, and also all the roads, street, lanes, watercourses or parts of same, enclosed within the following boundaries, to wit: Starting from the point of intersection of the division line of the townships Ireland and Thetford with the southeast line of lot 560; thence passing by the following lines successively: the said southeast line of lot 560; the northeast line of subdivision lots 560-1, 560-2 and 560-3; the northwest line of subdivision lot 560-3; a straight line joining the west corner of subdivision lot 560-3 to the north corner of subdivision lot 557-62; the northwest line of subdivision lots 557-62, 557-60, 557-59 and 557-58; the southest line of subdivision lots 557-58 557-57 and 557-56; the southeast line of subdivision lots 557-53, 557-87 and 557-86; the southeast line of lot 557, the division line of ranges VIII and IX on the width of lots 557 and 556; the northwest line of lots 556 and 561 and finally the division line of the townships Ireland and Thetford up to the starting point.Quebec, January 31, 1952.BONA DUSSAULT, 32019 Minister of Municipal Affairs.' Département de l'Agriculture Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la paroisse St-Didace, comté de Mas-kinongé, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture le déclare dissous, conformément aux dispositions de l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 4 février 1952.Le Sous-ministre de L'Agriculture, 32032-o R.TRÉPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la municipalité de la partie ouest du canton Farnham, comté de Missisquoi, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture le Department of Agriculture Notice is hereby given that the Farmers' Club of the parish of St-Didace, county of Maskinongé, having neglected for two years to comply with the requirements of the Farmers' Clubs Act (R.S.Q.1941, chapter 118) the Minister of Agriculture declares it dissolved, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.Quebec, February 4, 1952.R.TRÉPANIER, 32032 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the Farmers' Club of the Municipality of the west part of the township of Farnham, county of Missisquoi, having neglected for two years to comply with the requirements of the Farmers' Clubs Act R.S-Q.1941, chapter 118) the Minister of Agriculture declares QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.8J\u201e No.6 435 declare \"Hissous, conformément aux dispositions de l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 4 février 1942.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 32032-o R.TRÉPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la municipalité du village d'Asbestos et le cercle agricole de la paroisse St-Praxède de Brompton, tous deux dans le comté de Richmond, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les déclare dissous, conformément aux dispositions de l'Article 44 de ladite Loi.Québec, ce 4 février 1952.Le Sous-ministre de l'Agriculture.32()32-o R: TRÉPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur, le cercle agricole de la mission de St-Isidorc du I,ac des Aigles, le cercle agricole de la paroisse Ste-Lucc de Lessard et le cercle agricole de la paroisse St-Valérien, tous quatre dans le comté de Rimouski, ayant négligé, pendant deux ans.de se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les déclare dissous, conformément aux dispositions de l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 4 février 1952.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 32032-o R.TRÉPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la paroisse de Normandin, le cercle agricole de la paroisse St-Félicien, le cercle agricole de hi paroisse de Stc-Hcdwidge et le cercle agricob de la paroisse de St-Stanislas, tous quatre dans le comté de Roberval, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les déclare dissous, conformément aux dispositions de l'article 44 de ladite Loi.Québec, ce 4 février 1952.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 32032-2 R.TRÉPANIER.Avis est, par les présentes, donné que le cercle agricole de la municipalité St-François-Xavier de ShefFord et le cercle agricole de la paroisse de St-Théophile d'Ely, tous deux dans le comté de ShefTord, ayant négligé, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la Loi des cercles agricoles (S.R.Q.1941, chap.118), le ministre de l'Agriculture les déclare dissous, conformément aux dispositions de l'Article 44 de ladite Loi.Québec, ce 4 février 1952.Le Sous-ministre de l'Agriculture, 32032-o R.TRÉPANIER.it dissolve;!, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.R.TRÉPANIER, 32032 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the Farmers' Club of the municipality of the village of Asbestos and the Farmers' Club of the Parish of St-Praxèdc of Brompton, both in the county of Richmond, having neglected for two years to complv with the requirements of the Farmers' Clubs Act (R.S.Q.1941, chapter 118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.Quebec.February 4, 1952.R.TRÉPANIER.32032 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the Farmers' Club of the parish of Notre-Dame du Sacré-Cœur, the Farmers' Club of the mission of St-Isidore du Lac des Aigles, the Farmers' Club of the parish of Stc-Luce de Lessard and the Fanners' Club of the parish of St-Valérien, all four in the county of Rimouski, having neglected for two years to comply with the requirements of the Farmers' Clubs Act.(R.S.Q.1941, chap.118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.Quebec, February 4, 1952.R.TRKPANIER, 32032 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the Farmers' Club of the parish of Normandin, the Farmers' Club of the parish of St-Félicien, the Farmers' Club of the parish of Ste-Hedwidge and the Farmers' Club of the parish of St-Stanislas, all four in the county of Roberval, having neglected for two vears to comply with the requirements of the Farmers' Clubs Act (R.S.Q.1941, chapter 118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.Quebec, February 4, 1952.Ç.TRÉPANIER, 32032 Deputy Minister of Agriculture.Notice is hereby given that the Farmers' Club of the municipality of St-François-Xavier de Shelford and the Farmers' Club of the parish of St-Théophile d'Ely, both in the county of Shcf-ford, having neglected for two years to comply with the requirements of the Farmers' Clubs Act, (R.S.Q.1941, chap.118), the Minister of Agriculture declares them dissolved, pursuant to the provisions of section 44 of the said Act.Quebec, February 4.1952.R.TRÉPANIER, 32032 Deputy Minister of Agriculture.Département de l'Instruction publique Department of Education N° 71-52.No 71-52.Québec, le 29 janvier 1952.Quebec, January 29, 1952.Demande est faite de changer le nom de la municipalité scolaire de Petite-Rivière, dans le comté de Gaspé-Sud, en celui de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.32027-6-2-o O.J.DËSAULNIERS.Application is made to change the name of the school municipality of Petite-Rivière, in the County of Gaspé-South into that of Sainte-Thérèse-de-Gaspé, in the same county.O.J.DESAULNIERS, 32027-6-2 Superintendent of Education. 436 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome SA, N° 6 N° 1319-51.f Québec, le 29 janvier 1952.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de Sainte-Elisabeth, dans le comté de Stanstead, le lot N° 870, soit le lot 13 du rang V (5) du canton de Hatlcy et de l'annexer à la municipalité scolaire de Sainte-Catherine-de-Hatley, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction publique.32028-6-2-o O.J.DESAULNIERS.N° 1359-51.Québec, le 5 février 1952.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 31 janvier 1952, de changer le nom de la municipalité scolaire de St-Romuald, dans le comté de Lévis, en celui de \"New Liverpool\".Ce dit changement prendra effet huit mois après la publication dans la Gazette officielle de Québec.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32029-o O.J.DESAULNIERS.N° 471-51.Québec, le 5 février 1952.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 31 janvier 1952, de former en une municipalité scolaire distincte, sous le nom de \"Hauterive\", dans le comté de Saguenay, le territoire ci-dessous décrit, qui n'est pas encore organisé au point de vue scolaire: Ce territoire serait borné à l'est par une ligne partant de l'estuaire de la rivière Manicouagan et passant par le centre de la rivière Amédée jusqu'à la route nationale et de là par une ligne passant par le centre de la route nationale, laquelle a une orientation générale nord-sud pour une partie, et ensuite est-ouest pour une autre partie, et se rendant ainsi jusqu'à la limite ouest du bloc \"X\" et de là par la limite ouest du bloc \"X\" et la limite est du bloc \"6\"', jusqu'au coin nord-ouest du bloc \"K\" et de là par une ligne se rendant jusqu'à la limite nord du canton'Lafièche, avec orientation nord astronomique; Ce territoire serait borné au nord par la limite du canton de Lafièche; à l'ouest et au sud par une ligne passant par le centre de la rivière Manicouagan.Ce territoire comprendra aussi le bloc \"B\" du canton Eudes, les blocs \"D\" et \"M\" du canton Manicouagan ainsi que les lots 33-B à 38-B inclusivement du rang VI (6) du même canton.Cet arrêté ministériel prendra effet 15 jours après la publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec.Le Surintendant «le l'Instruction publique, 32029-o O.J.DESAULNIERS.N° 1249-50.Québec, 5 février 1952.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, par arrêté ministériel en date du 31 janvier 1952 de détacher de la municipalité scolaire du village d'Inverness, dans le comté de Megantic, le lot 457 du cadastre officiel d'Inverness et de l'annexer à la municipalité scolaire d'Inverness, dans le même comté.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1952.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32029-o O.J.DESAULNIERS.No.1319-51.Quebec, January 29, 1952.Application is made to detach from the school municipality of Sainte-Elisabeth, in the county of Stanstead, lot No.870, namely lot 13 of range V (5) of the township of Hatley and to annex it to the school municipality of Sainte-Catherine-de-Hatlev, in the same county.O.J.DESAULNIERS, 32028-6-2 Superintendent of Education.No.1359-51.Quebec, February 5, 1952.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by order in Council dated January 31, 1952, to change the name of the school municipality of St-Romuald, in the county of Levis, into that of \"New Liverpool\".The said change of name to become effective eight days after publication in the Quebec Official Gazette.^ O.J.DESAULNIERS, 32029 Superintendent of Education.No.471-51.Quebec, February 5, 1952.His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by Order in Council dated January 31, 1952 to erect into a separate school municipality, under the name of \"Hauterive\", in the county of Saguenay, the territory describetl below, which has not yet been organized as regards schools.This territory shall be bound on the east by a line starting from the estuary of the Manicouagan River and passing through thé center of the Amédée River as far as the national highway and thence, by a line passing through the center of the national highway, the general direction of which is north-south for one part, and then east-west for another part, and thus reaching the western limit of bloc \"X\" and thence, by the west limit of bloc \"X\" and the east limit of bloc \"6\", as far as the north-west corner of bloc \"K\" and thence by a line which reaches the north limit of the township of Lafièche, with a northern astronomic bearing.This territory shall be bounded on the north by the limits of the township of LaHèche, toward the west and on the south by a line passing through the center of the Manicouagan River.This territory will also comprise bloc \"B\" of the township of Eudes, blocs \"D\" and \"M\" of the township of Manicouagan, as well as lots 33B to 38B inclusively of range VI (6) of the same township.The said order in council to become effective 15 days after the publication of the present notice in the Quebec Official Gazette.O.J.DESAULNIERS, 32029 Superintendent of Education.No.1249-50.Quebec, February 5, 1952.His Honour, the Lieutenant-Governor, has been pleased, by Order in Council dated January 31, 1952, to detach from the school municipality of the Village of Inverness, in the county of Megantic, lot 457 of the official cadastre for Inverness, in the same county.The said Order in Council to become effective on the First of July, 1952.O.J.DESAULNIERS, 32029 Superintendent of Education. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.81, No.0 437- N° 1146-51.Québec, le 5 février 1952.Il a plu à Son Honneur le Lieutenant-gouverneur en conseil, par arrêté ministériel en date du 31 janvier 1952, de détacher de la municipalité scolaire de St-Narcisse-de-Beaurivage, dans le comté de Lotbinière, la partie du lot N° 131 du cadastre officiel de St-Narcisse-de-Beaurivage, appartenant à monsieur J.-Alexandre Goidet et de l'annexer à la municipalité scolaire de St-Ber-nard, dans le comté de Dorchester.Cet arrêté ministériel prendra effet le premier juillet 1952.Le Surintendant de l'Instruction publique, 32029-o O.J.DESAULNIERS.No.1146-51.Quebec, February 5, 1952.His Honour, the Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council dated January 31, 1952, to detach from the school municipality of St-Narcisse-de-Beaurivage, in the County of Lotbinière, part of lot No.131 of the official cadastre of St-Narcisse-de-Beaurivage, belonging to Mr.J.Alexandre Goulet and to annex it to the school municipality of St-Bernard, in the county, of Dorchester.The said order in council to become effective on the First July, 1952.0.J.DESAULNIERS, 32029 Superintendent of Education.Département des Terres et Forêts AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine-de-Longueuil (maintenant partie de la Ville de Jacques-Cartier) division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné que les 29-309 à 29-1205 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 25 janvier 1952.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 32030-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel du Village de Napierville division d'enregistrement de Napierville.Avis est par la présente donné que les lots 1, 2, une partie du lot 3 sont annulés et le lot 411 est ajouté, en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 1er février 1952.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 32030-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Agathe-des Monts rang, IV, canton de Beresford division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 17-27 (rue), 17-30 et 17-31 est annulée en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 21 janvier 1952.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 32030-o AVILA BÉDARD.-s*- Department of Lands and Forests NOTICE Official Cadastre of the Parish of St.Antoine-de-Longueuil (now part of the town of Jacques Cartier) Registration Divisions of Chambly.Notice is hereby given that lots 29-309 to 29-1205 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, January the 25th, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 32030-o Deputy Minister.NOTICE Official Cadastre of the Village of Napierville Registration division of Napierville.Notice is hereby given that lots 1, 2, part of lot 3 are cancelled and lot 411 is added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, February the 1st, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 32030-o Deputy Minister.NOTICE Official Cadastre of the Parish of Ste.Agathe des Monts range IV, Township of Beresford, Registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that part of lots 17-27 (street), 17-30 and 17-31 is cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, February the 21st, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BEDARD, 32030-o Deputy Minister.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine-de-Longueuil (maintenant partie de la ville de Jacques-Cartier) division d'enregistrement de Chambly.Avis est par les présente donné que les lots Nos 95-2 à 95-29, 95-31 à 95-56, 95-58 à 93-83, 95-85 N0T1.CE Officiai Cadastre of the Parish of St.Antoine-de-Longueuil (now part of the town of Jacques-Cartier) registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots Nos.95-2 to> 95-29, 95-31 to 95-56, 95-58 to 95-83, 95-85 to 438 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 84, N° 6 af95-U2, 95-110 à 95-130, 95-132 à 95-157, 95-159 à 95-184.95-186 à 95-225, 96-2 à 96-30, 96-32 à 9G-92, 96-95 à 96-120, 96-122 à 96 173, 96-176 à 96-201, 96-203 à 96-254, 96-257 à 96-285, 96-287 à 96-345 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 21 janvier 1952.I^e Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, AVILA BÉDARD, 32030-o Sous-Ministre.95-112, 95-110 to 95-130, 95-132 to 95-157, 95-159 to 95-184, 95-186 to 95-225, 96-2 to 96-30, 96-32 to 96-92, 96-95 to 96-120, 96-122 to 96-173, 90-176 to 96-201, 96-203 to 96-254, 96-257 to 96-285, 96-287 to 96-345 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, January the 21st, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 32030-o Deputy-Minister.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine-de-Longueuil (maintenant partie de la ville de Jacques-Cartier) division d'enregistrement de Chambly.* Avis est par lu présente donné que les lots Nos 29-318-1 à 29-318-5.29-349-1 à 29-34 '-5, 29-384.-1 à 29-381-5, 29-409-1 à 29-409-5, 29-436-1 à 29-436-5, 29-464-1 à 29-464-5, 29-492-1, 29-492-2, 29-501-1 à 29-501-3, 29-524-1 à 29-524-3, 29-535-1, 29-535-2,29-552-1 à 29-552-5, 29-5S1-1 à 29-581-5, 29-615-1 à 29-615-5, 29-643-1 ù 29-643-6, 29-673-1 à 29-673-6, 29-700-1 à 29-700-0, 29-734-1 à 29-734-6,29-764-1 à 29-764-4, 29-792-1 ù 29-792-4, 29-822-1 à 29-822-4, 29-848-1 à 29-848-4, 29-882-1 à 29-882-4, 29-1013-1 à 29-1013-3, 29-1033-1 à 29-1033-3, 29-1054-1 à 29-1054-3, 29-1072-1 à 29-1072-3, 29-1092-1 à 29-1092-3, 29-1112-1 à 29-1112-3, 29-1132-1 à 29-1132-3, 29-1152-1 à 29-1152-3, 29-1175-1 à 29-1175-4 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 25 janvier 1952.1/e Département des Terres et Forets, Service du Cadastre, AVILA BÉDARD.32030-o Sous-Ministre.NOTICE Officiai Cadastre of the Parish of St.Antoine de Longueuil (Now part of the town of Jacques-Cartier) registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots Nos 29-318-1 to 29-318-5.29-349-1 to 29-349-5, 29-381-1 to 29-381-5.29-409-1 to 29-409-5, 29-436-1 to 29-436-5, 29-464-1 to 29-464-5, 29-492-1, 29-192-2, 29-501-1 to 29-501-3, 29-524-1 to 29-524-3, 29-535-1, 29-535-2, 29-552-1 to 29-552-5, 29-581-1 to 29-581-5, 29-615-1 to 29-615-5, 29-643-1 to 29-643-6, 29-673-1 to 29-673-6, 39-700-1 to 29-700-0, 29-734-1 to 29-734-0, 29-764-1 to 29-764-4, 29-792-1 to 29-792-4, 29-822-1 to 29-822-4, 29-848-1 to 29-848-4, 29-8S2-1 to 29-882-4, 29-1013-1 to 29-1013-3, 29-1033-1 to 29-1033-3, 29-1054-1 to 29-1054-3, 29-1072-1 to 29-1072-3, 20, 1092-1 to 20-1092-3, 29-1112-1 to 29 1112-3, 29-1132-1 to 29-1132-3, 29-1152-1 to 29-1152-3, 29-1175-1 to 29-1175-4 arc annulcd in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, January the 25th, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 32030-o Deputy-Minister.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine-de-Longucuil (Maintenant partie de la cité de Longueuil), Division (l'enregistrement de Chambly.Avis est par les présentes donné que les lots Nos 69-1 à 69-28, 69-30, 69-32, à 69-66, 69-68 à 69-105.69-107 à G9-206, 69-211 à 69-237, 69-241, a 69-267, 69-269 à 69-328, 69-330 à 69-359, 69-361 à 69-420, 69-422 à 69-481, 69-483 à 69-512, 69-514 à 69-573, 69-575 à 69-634, 69-636 à 69-665, 69-667 à 69-726, 69-728 à 69-766, 69-768 à 69-775, 69-780 à 69-788,-69-790 à 69-817, 69-819 à 69-858, 69-860 à 69-901, 69-904, 69-912 à 69-928, 69-938 à 69-946, 69-946A, 69-947 à 69-960, 69-966, 69-968 à 69-980, 69-982 à 69-990, 69-997 à 69-1020, 70-1 à 70-13, 70-16 à 70-70, 70-72 à 70-79, 70-81 à 70-139, 70-141 à 70-197, 70-199 à 70-261, 70 - 263 à 70-322, 70-324 à 70-383, 70-385 à 70-444, 70-440 à 70-505, 70-507 à 70-566, 70-538A à 70-546A, 70-548A à 70-E66A, 70-567 à 70-616, 70-614A, 70-615A, 70-619 à 70-656,70-658 à 70-690 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 14 janvier 1952.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 32030-o AVILA BEDARD, NOTICE Officiel cadastre of the parish of St.Antoine-de-Longueuil (Now Part of the city of Longueil), Registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots 69-1 to 69-28, 69-30, 69-32 to 69-66, 69-68 to 69-105, 69-107 to 69-206, 69-211 to 69-237, 69-241 to 69-267, 69-269 to 69-328, 69-330 to 69-359, 69-361 to 69-420, 69-422 to 69-481, 69-483 to 69-512, 69-514 to 69-573, 69-575 to 69-634, 69-636 to 69-665, 69-667 to 69-726, 69-728 to 69-766, 69-768 to 69-775, 69-780 to 69-788, 69-790 to 69-817, 69-819 to 69-858, 69-860 to 69-901, 69-904, 69-912 to 69-928, 69-938 to 69-946, 69-946A, 69-947 to 69-960, 09-966, 69-968 to 69-980, 69-9S2 to 69-990, 69-997 to 69-1020, 70-1 to 70-13, 70-16 to 70-70, 70-72 to 70-79, 70-81 to 70-139, 70-141 to 70-197, 70-199 to 70-261, 70-263 to 70-322, 70-324 to 70-383, 70-385 to 70-444, 70-446 to 70-505, 70-507 to 70-566, 70-538 A to 70 - 546 A, 70-548 A to 70-566 A, 70-567 to 70-616, 70-614A, 70-615A, 70-619 to 70-056, 70-658 to 70-690 are annulet! in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, January the 14th, 1952.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BEDARD, 32030-o Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.6 439 ( \"a 428 Charters \u2014 Surrender of: 431 Christie Mining Syndicate Inc.431 432 Laurentian Investment Company.432 432 South American Agencies Limited.432 The Megantic People's Telephone Com- 432 pany.432 432 U.S., Canadian & Cuba Co.Ltd.432 Companies Dissolved: Immeubles Vendôme Limitée \u2014 Vendô- 432 me Realties Limited.432 La Manécanterie des Petits Chanteurs 433 à la Croix de Bois de Québec, Inc.433 433 Lanthier & Sons Limited.433 433 Leduc & Prieur, Limitée.433 433 Tecn-O-Miss Inc.433 433 Whalen Cartage Co.433 DEPARTMENTAL NOTICES: Municipal Affairs: 434 Thetford-Mines, annexion to the city of 434 Agriculture: Dissolution of farmers' clubs in the counties of Maskinongé, Missisquoi, Richmond, Rimouski, Roberval et 434 Shefford.434 Department of Finance: Insurance: Société St-Jean-Baptiste Permanente de 453 Waterloo.453 Education: School Municipality of: 436 Hauterive.436 436 Inverness.436 436 New-Liverpool.436 435 Petite-Rivière.435 437 St-Narcisse-de-Beaurivage.437 436 Sainte-Elisabeth.436 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.SA, No.6 477 Terrfs et Forêts: Service du Cadastre: Napierville, village.437 St-Antoine-de-Longueuil, paroisse.437 Ste-Agathe-dcs-Monts, paroisse.437 Trwail: Industrie ou métiers de: Barbiers-coiffeurs de Montréal (Prélèvement) .451 Camionnage de Québec (Prélèvement) 444 Chapeau en toile et casquettes pour hommes et garçons (Prélèvement).442 Chaussure (Prélèvement).447 Confection pour hommes et garçons (Modification).453 Construction du district de Hull (Modification) .451 Gants de travail (Prélèvement).441 Gants fins (Prélèvement).445 Sacoche de la province de Québec, (Approbation).450 Sacoche de la province de Québec, (Prélèvement).448 Verre, district de Québec, (Prélèvement) 439 Lettres patentes: A Garber Fur Company.404 Atlas Enterprises Corporation.405 Carmen Fleuriste (Ltée).405 Ceebee Investments Ltd.405 Cie Ideal Import Co.Ltd.400 Commission Diocésaine d'Aide ux Paroisses d'Amos.454 Corporation des Chemins d'Hiver d'Abitibi-Ouest.406 Davie Brothers Ltd.406 Eastern Canada Veneer Corporation .407 Eskimo Fur Co.Limited.407 Fédération des Amicales Maristes Canadiennes.407 Goodcraft Clothing Company Limited.408 Hochelaga Auto Electric Ltée.408 Ijay Investment Corporation.408 Investment Services Inc.409 J.E.Paré Limitée.409 J.Novack Fur Company.409 Joncs Industries Ltd.410 Jos.Latulippe Ltée-Ltd.410 Kill-Odor Products Inc.410 La Compagnie Immobilière Ste-Cécile Ltée.411 La Compagnie Jude Tétreault Limitée.411 L'Association des Propriétaires de Courville Inc.411 Le Marché Jules Limitée.412 Les Magasins Yolbnde Limitée.412 Les Placements Baillar Ltée \u2014 Baillar Investments Ltd.412 Markirk Holdings, Ltd.413 Mayfed Jewellers Ltd.413 Mercerie Sherbrooke Ltée-.413 Monde Sportif Inc.414 Morin & Frères Incorporée.414 Parkway Electric, Ltd.414 Raoul Chènevert Limitée.415 Ridgewood Court Inc.415 Service d'Assurances Belec Insurance Service Inc.415 Service Social de l'Abord-à-Plouffe Inc.\u2014 L'Abord-à-Plouffe Social Service Inc.416 Spécialités Royal Specialties Inc.416 Spectator Sportswear Co.Inc.416 Lands and Forest: Cadastral Branch: Napierville, village.437 St-Antoinc-de-Longueuil, parish.437 Ste-Agathe-dcs-Monts, parish.437 Labour: Industry or trades of: Barbers of Montreal (Levy).451 Camionnage de Québec (Levy).444 Men's and Boys' Hat and Cap (Levy).442 Shoe (Levy).447 Men's and Boys' Clothing (Amendment) .453 Building of the district of Hull (Amendment).451 Working Gloves (Levy).441 Fine Gloves (Levy).445 Handbag of the Province of Quebec (Approval).450 Handbag of the Province of Quebec, , (Levy) .448 Glass, district of Quebec (Levy).439 Letters Patent: A Garber Fur Company.404 Atlas Enterprises Corporation.405 Carmen Fleuriste (Ltée) .405* Ceebee Investments Ltd.405 Cie Ideal Import Co.Ltd.-.406 Commission Diocésaine d'Aide aux Paroisses d'Amos.454 Corporation des Chemins d'Hiver d'Abitibi-Ouest.406 Davie Brothers Ltd.406 Eastern Canada Veneer Corporation .407 Eskimo Fur Co.Limited.:.407 Fédération des Amicales Maristes Canadiennes.407 Goodcraft Clothing Company Limited.408 Hochelaga Auto Electric Ltée.408 Ijay Investment Corporatiun.408 Investment Services Inc.409 J- E.Paré Limitée.409 J.Novack Fur Company.409 Jones Industries Ltd.410 Jos.Latulippe Ltée-Ltd.410 Kill-Odor Products Inc.410 La Compapnie Immobilière Ste-Cécile Ltée.411 La Compapnie Jude Tétrc-i.ult Limitée.411 L'Association des Propriétaires de Courville Inc.411 Le Marché Jules Limitée.412 Les Magasins Yollande Limitée.412 Les Placements Baillar Ltée \u2014 Baillar Investments Ltd.412 Markirk Holdings, Ltd.413 Mayfed Jewellers Ltd.413 Mercerie Sherbrooke Ltée.413 Monde Sportif Inc.414 Morin & Frères In9orporée.414 Parkway Electric, Ltd.414 Raoul Chènevert Limitée.415 Ridgewood Court Inc.415 Servici d'Assurances Belec Insurance Service Inc.415 Service Social de l'Abord-à-Plouffe Inc.\u2014 L'Abord-à-Plouffe Social Servie* Inc.416 Spécialités Royal Specialties Inc.416 Spectator Sportswear Co.Inc.416 478 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 9 février 1952, Tome 84, N° 6 Star Electric Inc.Trinity Bay Products Limited.Two Mountains Equipment Co.Ltd.United Agency lue.Westwood Realties Ltd.Lettres patentes annulées: St-Eustache Boating Club, Limited.Lettres patentes supplémentaires: Cadillac Restaurant Limited.Canadian Corporations, Limited.Cbibaugamau Explorers Ltd.Citadel Brick Ltd.\u2014Brique Citadelle Ltée.City Spunging Incorporated.Club Lac Bouchette de Roberval, Inc.Georges Painchaud Limitée .Henderson, Barwick Co., Limited.Indépendant Refrigeration Limited John Millen Quebec Limitée.La Cie Gagnon, Limitée.Lebœuf & Grenier, Limitée.Leduc Electrical Limited-.Maçonnerie du St-Laurent Ltée.Modem Appliances Limited.Nu-Way Food Products Incorporated .Peter Pan Dress Inc.Pharmacies Modernes Inc.Ross-Smith Compnny Limited.! Rudolf Van Der Walde (Canada) Limited .\u2022 \u2022 ;.Ruwaca Pulp & Paper Limited.Service Ouellet Ltée.Silbro Textile Co.Limited.Silbro Textile Co.Limited.Spino Construction Limited.Sutherland Construction Compnny.The Mackay Realty Incorp'd.The Morris Finance & Mortgage Corporation .\u2022 ¦ W.J.Keating & Sons Ltd.Liquidation, avis de: La Caisse Populaire Desjardins de Deslandes.La Pourvoyeuse de Victoriaville.Société St-Jean-Baptiste Permanent de Waterloo.Sièges sociaux: Investment Services Inc.1.L.Guay & Frère Limitée.Paul-Emile Laciiance Ltée.Matane Construction Limited.Soumissions: Cap-de-la-Madeleine, cité.Granby, Corn.scol.cath.Hull, Com.scol.LaSalle, Ville.St-Jovite, village.Vente d'effets non-Rêclamés: Canadian Pacific Railway Company.Ventes pour taxes: Pontiac, mun.comté (Correction).Témiscamingue, mun.comté (Correction).417 Star Electric Inc.417 417 Trinity Bay Products Limited.417 417 Two Mountains Equipment Co.Ltd.417 418 United Agency Inc-.418 418 Westwood Realties Ltd.418 Letters Patent Annulled: 454 St-Eustache Boating Club, Limited.454 Supplementary Letters Patent: 419 Cadillac Restaurant Limited.419 419 Canadian Corporations, Limited.419 419 Cbibaugamnu Explorers Ltd.419 Citadel Brick Ltd.\u2014Brique Citadelle 419 Ltée.419 420 City Spunging Incorporated.420 420 Club Lac Bouchette dc Roberval, Inc.420 420 Georges Painchaud Limitée.420 421 Henderson, Barwick Co., Limited.421 421 Indépendant Refrigeration Limited.421 421 John Millen Quebec Limitée.421 421 La Cie Gagnon, Limitée.421 422 Lcbocuf & Grenier, Limitée.422 422 Leduc Electrical Limited.422 422.Maçonnerie du St-Laurent Ltée.422 422 Modern Appliances Limited.422 423 Nu-Way Food Products Incorporated .423 123 Peter Pan Dress Inc.423 423 Pharmacies Modernes Inc.423 423 Ross-Smith Company Limited.423 Rudolf Van Dcr Walde (Canada) Li- 424 mitcd.424 424 Ruwaca Pulp & Paper Limited.424 424 Service Ouellet Ltée.424 424 Silbro Textile Co.Limited.424 425 Silbro Textile Co.Limited.425 425 Spino Construction Limited.425 425 Sutherland Construction Company.425 425 The Mackay Realty Incorp'd.425 The Morris Finance & Mortgage Cor- 426 poration.426 426 W.J.Keating & Sons Ltd.426 Winding up Notices: La Caisse Populaire Desjardins de Des- 454 landes.454 455 La Pourvoyeuse de Victoriaville.455 \u2022 Société St-Jean-Baptiste Permanent de 455 Waterloo.455 Head Offices: 455 Investment Services Inc.455 455 J.L.Guay & Frère Limitée.455 456 Paul-Emile Laciiance Ltée.456 456 ' Matane Construction Limited.456 Tenders: 459 Cap-dc-la-Madeleine, city.459 456 Granby, Cath.School Comm.456 460 Hull, School Comm.460 457 LaSalle, Town.N.457 458 St-Jovite, village.'.458 Sale of Unclaimed Baggage: 461 Canadian Pacific Railway Company.461 Sales for Taxes: 461 Pontiac, Mun.County (Correction) .461 Témiscamingue, Mun.County (Correc-462 tion).462 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 9th, 1952, Vol.84, No.6 479 VENTES PAR SHÉRIFS: Montmagny: La Compagnie d'Habitation de Montmagny, Limitée vs Le Club de Courses de Montmagny, Inc.Montreal: Santfleben vs Lawlor.Quebec: Corp.municipale village de Saint-Jean de Boischatel vs Vézina.Roberval: Lavoie vs Desbiens.Terrebonne: Ville de Lachute vs Héritiers John Alexander Blow.31998-0 462 SHERIFFS' SALES: Montmagny: La Compagnie d'Habitation de Montmagny, Limitée vs Le Club de Courses de Montmagny, Inc.462 Montreal: 463 Santfleben vs Lawlor.Quebec: Corp.municipale village de Saint-Jean 463 463 463 de Boischatel vs Vézina.Roberval: 464 Lavoie vs Desbiens.464 Terrebonne: 464 Alexander Blow.131998-0 464 Quebec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis- Quebec:\u2014 Printed by Rbdhmpti Parade imprimeur de la Reine.Queen s Pnnter. f Gazette officielle de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUEBEC f\tI PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Lundi 11 février 1952.\tQuebec, Monday, February 11th, 1962.PROCLAMATIONS\tPROCLAMATIONS Canada, Province de Québec.[L.S.]\tCanada, Province of j Quebec.[L.S.] PROCLAMATION par Son Honneur l'honorable Gaspard Fauteux, Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec.A tous ceux à qui ces présentes parviendront \u2022 ou qu'icelles pourront concerner \u2014 Salut, i\tPROCLAMATION of His Honour the Honourable GASPARD FAUTEUX, Lieutenant-Governor of the Province of Quebec.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern \u2014 Greeting.Le Premier Ministre ( A TTENDU qu'il a plu et Procureur-Général, ) à Dieu dans sa mi-M.L.Duplessis.j séricorde de rappeler à Lui ' Notre bien-aimé Souverain le Roi George VI, de glorieuse mémoire, et que, par suite de ce décès, la Couronne de Grande-\tM.L.Duplessis, /\\\\7\"HEREAS it hath Prime Minister and) W pleased God in His Attorney-General.j Mercy to call to Himself \\ Our beloved Sovereign King George VI, of glorious memory, by whose decease the Crown of Great Britain, Ireland and Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 482 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 février 1952, Tome 8A, N° 6 a Bretagne, d'Irlande et toutes les possessions de feu Sa Majesté est dévolue légalement à la Haute et Puissante Princesse Elizabeth Alexandra Mary, je, Gaspard Fauteux, Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec, dans le Canada, de l'avis et avec le loyal concours du Conseil Exécutif de cette Province, proclame, par les présentes, que par le décès de Notre bien-aimé Roi, Son Altesse Royale Elizabeth Alexandra Mary est maintenant, par la Grâce de Dieu, sous le nom de Elizabeth Deux, Notre seule et légitime Souveraine, Reine de Grande-Bretagne, d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, défenseur de la foi, Dame lige suprême du Canada, et que Nous lui devons foi et obéissance, ainsi que Notre humble et sincère affection, et je requiers et ordonne en conséquence à toute personne dans cette Province de reconnaître son autorité et de s'y soumettre.Je prie Dieu, qui régit les rois et les peuples, de bénir Sa Majesté Elizabeth Deux, Notre souveraine, et de lui accorder de longues et heureuses années de règne.Donne sous mon seing et le Sceau de mes armes à Québec, ce HUITIÈME jour de FÉVRIER, en l'année mil neuf cent cinquante-deux, et du règne de Sa Majesté la première.(signé) GASPARD FAUTEUX, Lieutenant-Gouverneur.Canada, Province de Québec.GASPARD FAUTEUX IL.S.) ELIZABETH H, par la grâce de Dieu Reine de Grande-Bretagne, d'Irlande et des possessions britanniques'au delà des mers, défenseur de la foi, Dame lige suprême du Canada.A tous ceux qui ces présentes verront ou qu'elles peuvent concerner, Salut.Le Premier ministre et f ATENDU QU'en Procureur général, ) vertu de l'article 7 M.-L.Duplessib, ) de la Loi des employés ! publics (Statuts refondus, 1941, chapitre 10), il est décrété qu'il n'est pas nécessaire de renouveler, au décès du Souverain, les commissions ou nominations en vertu desquelles les fonctionnaires ou les employés publics de la province remplissaient leurs charges ou exerçaient leurs professions respectives sous le règne précédent; Attendu qu'en vertu du même article, il est aussi décrété qu'une proclamation est émise par le Lieutenant-Gouverneur, autorisant tous ces fonctionnaires ou employés à continuer l'exercice de leurs fonctions ou professions.A ces causes et de l'avis du Conseil Exécutif de Notre province, Nous autorisons par la présente proclamation tous les fonctionnaires et all the other of His Late Majesty's Dominions is lawfully come to the High and Mighty Princess Elizabeth Alexandra Mary, I, Gaspard Fauteux, Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, in Canada, by the advice and with the loyal con-urrence of the Executive Council of this Province, do hereby proclaim that by the death of Our well beloved King, Her Royal Highness Elizabeth Alexandra Mary is now, by the grace of God, under the name of Elizabeth the Second, Our sole and lawful Sovereign, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Queen, Defender of the Faith, Supreme Liege Lady in and over Canada, to whom wë owe faith and obedience with hearty and humble affection.And I do hereby require and command all persons whomsoever in the Province to acknowledge her authority and submit thereto.I beseech God who governs Kings and peoples to bless Her Majesty Elizabeth the Second, Our Sovereign, with long and happy years to reign over us.Given under my hand and seal at arms at Quebec, this EIGHTH day of FEBRUARY, in the year one thousand nine hundred and fifty-two and in the first year of Her Majesty's reign.(Signed) GASPARD FAUTEUX, Lieutenant-Governor.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.1 ELIZABETH H, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Queen, Defender of the Faith, Supreme Liege Lady in and over Canada.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern, Greeting.M.L.Duplessis, ( V\\7HEREAS by section Prime Minister and) VV 7 Qf ine Public Offi- Attorney-Gcneral.\\ cers Act (Revised Sta-\\ tutes, 1941, chapter 10), it is enacted that upon the demise of the Sovereign it is not necessary to renew any commission or appointment by virtue whereof any public officer or employee of the Province held his office or exercised his profession during the preceding reign; Whereas in virtue of the same section, it is also enacted that a proclamation is issued by the Lieutenant-Governor, authorizing every such officer or employee to continue in the exercise of his functions or profession.Now therefore, by and with the advice of the Executive Council of Our Province, We do by the present proclamation authorize all public QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, February 11th, 1952, Vol.84, No.6a 483 employés publics qui, au moment du décès de Notre Souverain, George VI, de glorieuse mémoire, remplissaient ou exerçaient, dûment et légalement, des charges, fonctions ou professions dans Notre dite province de Québec, à continuer l'exercice de telles charges, fonctions ou professions, la présente proclamation devant être pour eux un titre suffisant à cette fin.Nous demandons et commandons à tous nos fidèles sujets d'aider et favoriser tous tels fonctionnaires ou employés de la province dans l'accomplissement et dans l'exécution de leurs devoirs respectifs.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes pourront concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre Province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LLD., D.D.L., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de la province de Québec.Donné en Notre hôtel du Gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce huitième jour de février en l'année mil neuf cent cinquante-deux de l'ère chrétienne et de Notre Règne la première année.Canada, Province de GASPARD FAUTEUX Québec.[L.S.] ELIZABETH H, par la grâce de Dieu, Reine de Grande-Bretagne, d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, défenseur de la foi, Dame lige suprême du Canada.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.Le Premier ministre et [ A TTENDU QUE le Procureur général, ) ¦** vendredi, quinzième M.L.Duplessis.j jour du mois de février, ( 1952, a été fixé pour les funérailles de Sa Très Excellente Majesté le Roi George VI, de glorieuse mémoire.Et sachant que notre deuil profond est partagé par tous nos fidèles sujets, Nous désirons leur offrir l'occasion de le manifester et de témoigner publiquement leur sympathie dans la grande affliction qui Nous frappe, et avec Nous, le peuple entier de cette province.A ces causes, Nous avons jugé à propos, de l'avis du Conseil Exécutif de Notre province de Québec, de fixer et réserver, et par les présentes, Nous fixons et réservons le vendredi, quinzième jour du mois de février, 1952, comme un jour de deuil général qui sera observé par toutes les personnes de Notre province de Québec.officers or employees who duly and lawfully held offices or exercised professions in Our said Province of Quebec, at the moment of the death of Our Sovereign, George VI of glorious memory, to severally continue in the due exercise of their respective functions for which the present proclamation shall be sufficient warrant.We do hereby require and command all Our loving subjects to be aiding, helping and assisting all such officers or employees of the Province in the performance and execution of their respective duties.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are, hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this eighth day of February, in the year of Our Lord nineteen hundred and fifty-two and the first year of Our Reign.Canada, Province of GASPARD FAUTEUX Quebec.[L.S.] ELIZABETH n, by the grace of God of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Queen, defender of the Faith, Supreme Liege Lady in and over Canada.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern.Greeting.M.L.Duplessis, ( TWHEREAS Friday, the Prime Minister and ) W fifteenth day of the Attorney-General.\\ month of February, 1952, ( has been fixed for the obsequies of His Most Excellent Majesty King George VI, of glorious memory.And knowing that Our deep grief is shared by all Our loving subjects, We are desirous to afford them the opportunity of testifying their sorrow and publicly manifesting their sympathy in the grievous affliction which has befallen Us, and with Us, the entire population of this Province; Therefore, We have thought fit, by and with the advice of the Executive Council of.Our Province of Quebec, to appoint and set apart, and We do hereby appoint and set apart Friday, the fifteenth day of the month of February, 1952, as a day of General Mourning to be observed by all persons throughout Our Province of Quebec. 484 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 11 février 1952, Tome 8i, N° 6a De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable GASPARD FAUTEUX, C.P., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-gouverneur de la province de Québec.Donné en Notre hôtel du Gouvernement, en Notre cité de Québec, de Notre province de Québec, ce huitième jour de février en l'année mil neuf cent cinquante-deux de l'ère chrétienne et de Notre Règne la première année.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are, hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our Province of Quebec, to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well Beloved the Honourable GASPARD FAUTEUX, P.C., LL.D., D.D.S., L.D.S., Lieutenant-Governor Of Our Province of Quebec.At Our Governement House, in Our City of Quebec, in Our Province of Quebec, this eighth day of February, in the year of Our Lord nineteen hundred and fifty-two and the first year of Our Reign.Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, imprimeur de la Reine.Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, Queen's Printer."]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.