Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 5 (no 31)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1950-08-05, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tomb 82, N* 31 1965 Vol.82, No.31 4*\t\tf \t\t1 \t\t *\t\t* Drapeau delà province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC , Québec, samedi 5 août 1960 RÉCEPTION DES ANNONCES Avis est par les présentes donné que l'ultime délai pour la réception de toute annonce, pour publication dans la Gazette officielle de Québec, est fixé à midi, le mercredi de chaque semaine, durant les mois de juillet et août 1950.Québec, le 19 juin 1950.L'Imprimeur du Roi, 27765-25-10-o RÊDEMPTI PARADIS.AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter là facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, August 5th, 1950 RECEIPT OF ADVERTISING COPIES Notice is hereby given that the ultimate delay for receiving any advertising copy, for publication in the Quebec Official Gazette, is fixed to noon on Wednesday of each week, during the months of July and August, 1950.Quebec, this 19th of June 1950.RÊDEMPTI PARADIS, 27765-25-10-o King's Printer.NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbe!ow_ set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized, by the Canada Post Office, Otta-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter.4270 1966 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août 1960, Tome 88, N\" 81 insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement : S7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante : Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.26439 \u20141-52 Lettres patentes Atlantic Marine Salvage Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-six, mai 1950, constituant en corporation: George Couture, industriel, Mme Simone Couture, épouse séparée de biens dudit George Couture et Cécile McGee, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rate, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom df notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first inseition; the third the number of insertions, and.the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÊDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.26439 \u20141-52 Letters Patent Atlantic Marine Salvage Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of May, 1950, incorporating: George Couture, industrialist, Mrs Simone Couture, wife separate as to property of the said George Couture, and Cécile McGee, secretary, all of the City and Judicial District of Quebec, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 6th, 1950, Vol 82, No.31 1967 Exercer le commerce de sauvetage et de renflouage de bateaux et vaisseaux d'aucune sorte, sous le nom de \"Atlantic Marine Salvage Corporation\", avec un capital de $240,000 divisé en 2,400 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 21;600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera au Bassin Louise, en les cité et district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-six mai 1950.L'Assistant-procureur général, 2S007 L.DÉSILETS.To carry on the business of salvors and wreckers of ships and craft of any kind, under the name of \"Atlantic Marine Salvage Corporation\", with a capital stock of $240,000.divided into 2,400 common shares at a par value of $10.each, and 21,600 preferred shares at a par value of $10.each.The head office of the Company will be at the Louise Embankment, in the City and Judicial District of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of May, 1950.L.DÉSDLETS, 28007-o Deputy Attorney General.Bars Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six juin 1950, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, c.r., Manuel Shacter, avocats et Jessie Davine^ secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Bars Limited\", avec un capital de $3,000 divisé en 30 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Bars Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1950, incorporating: Louis H.Rohrlick, k.c, Manuel Shacter, advocates, and Jessie Davi-ne, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Bars Limited\", with a capital stock of $3,000.divided into 30 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Birch Lake Enterprises Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1950, constituant en corporation: Paul Gonthier, comptable, Joseph-Moise Loi-selle, agent et J.-Ernest Létourneau, bourgeois, et Paul Lanoue, agent, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'immeubles, sous le nom de \"Birch Lake Enterprises Limited\".Le capital de la compagnie sera divisé en 750 actions sans valeur au pair; et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $45,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le dix juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.Birch Lake Enterprises Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June, 1950, incorporating: Paul Gonthier, accountant, Joseph Moïse Loiselle, agent, and J.Ernest Létourneau, gentleman, and Paul Lanoue, agent, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in real estate, under the name of \"Birch Lake Enterprises Limited\".The capital stock of the company will be divided into 750 shares having no par value; and the amount with which the company will commence its operations will be $45,000.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Canac Marquis Limitée Avis est donné qu'en vertu de là première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt juin 1950, constituant en corporation: Clément Wragge, industriel, des cité et district judiciaire de Montréal, Paul Miquélon, avocat, de Beauportville, et Robert Perron, avocat, de la cité de Québec, tous deux du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants : Exercer en général le commerce de manufacturiers, acheteurs, vendeurs de la colle, gélatine, huile, graisse, viande, engrais, sous le nom de \"Canac Marquis Limitée\", avec un capital Canac Marquis Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twentieth day of June, 1950, incorporating: Clément Wragge, industrialist, of the City and Judicial District of Montreal Paul Miquelon, advocate, of Beauportville, and Robert Perron, advocate, of the City of Quebec, both of the Judicial District of Quebec, for the following purposes: To generally carry on business as manufacturers, buyers, vendors of glue, gelatine, oil, fat, meat, fertilizers, under the name of \"Canac Marquis Limitée,\" with a capital stock of $250,- 1968 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 août 1950, Tome 82, N° 81 de $250,000 divisé en 200,000 actions privilégiées de SI chacune et en 50,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le vingt juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Curlier Estate Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du neuf juin 1950, constituant en corporation: Geoffroy Birtz, Madeleine Béiquc, avocats, et Gabriellc Lahaie, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles et de biens fonds, sous le nom de \"Cartier Estate Corporation\", avec un capital de 875,000 divisé en 500 actions privilégiées de $100 chacune et en 250 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 4510 rue Cartier, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le neuf juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Celebrity Sponsors Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en (Jate du seize juin 1950, constituant en corporation: Albert Weber, directeur de productions théâtrales, Ben Steinberg et Moses Steinberg, marchands, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme commanditaires et organisateurs de pièces théâtrales et musicales, de représentations de cinéma et de chorégraphie et de danse, sous le nom de \"Celebrity Sponsors Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le seize juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.000.divided into 200,000 preferred shares of $1-each and 50,000 common shares of $1.each.The head office of the Company will be at Quebec, Judicial District of Quebec.Dated at the office of the Attorney General this twentieth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Cartier Estate Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the ninth day of June, 1950, incorporating: Geoffroy Birtz, Madeleine Béique, lawyers, and Gabrielle Lahaie, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the businesses of a land and real estate company, under the name of \"Cartier Estate Corporation\", with a capital stock of $75,000.divided into 500 preferred shares of $100.each, and 250 common shares of $100.each.The head office of the company will be at 4510 Cartier Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this ninth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Celebrity Sponsors Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of June, 1950, incorporating: Albert Weber, theatrical producer, Ben Steinberg, and Moses Steinberg, merchants, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on business as sponsors and producers of musical, theatrical, cinematographic, chorégraphie, dancing productions, exhibitions and concerts, under the name of \"Celebrity Sponsors Inc.\" with a capital stock of $40,000.divided into 4,000 shares of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Comité de Développement de Cabano Avis est donné qu'en vertu (les dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-¦ gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept juin 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Edmé Therriault, inspecteur de colonisation, J.-Camille Leclcrc, gérant de caisse populaire, et Lionel Poulin, professeur, tous de Cabano, district judiciaire de Kamouraska, pour les objets suivants: Secourir et aider toutes les personnes qui ont été directement ou indirectement éprouvées par la conflagration de Cabano, sous le nom de \"Comité de Développement de Cabano\".Comité de Développement de Cabano Notice is hereby given that under Part III ce the Quebec Companies' Act, letters patent havf been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of June, .1950, to incorporate as a corporation without share capital: Edmé Therriault, inspector of Colonization, J.Camille Leclerc, manager of the Caisse Populaire, and Lionel Poulin, professor, all of Cabano, judicial district of Kamouraska, for the following purposes: To give relief to and assist all persons who have suffered, directly or indirectly, by the fire at Cabano, under the name of \"Comité de Développement de Cabano\". QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 5th, 1950, Vol.82, No.31 1969 Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $10,000.Le siège social de la corporation sera à Cabano, district judiciaire de Kamouraska.Daté du bureau du Procureur général le vingt-sept juin-1950.L'Assistant-procureur général, 2S007-o L.DÉSILETS.The amount to which the annual revenue from the immovable property which the corporation may hold is |o be limited, is $10,000.The head office of the company will be at Cabano, judicial district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of June, 1950.L.DÉSILETS, 2S007 Deputy Attorney General.Congregation Reshith Chochma, First Mesifta of Canada Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux juin 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Rabbi Alexander Unsdorfer, Rabbi Herman Sigal et Nelson Lehman, négociant, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Établir une synagogue où les offices seront dirigés suivant l'interprétation strictement orthodoxe de la loi juive, sous le nom de \"Congregation Reshith Chochma, First Mesifta of Canada\".Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut posséder est de $20,000.Le siège social de la corporation sera à 5400 rue Jeanne Mance, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux juin 1950.L'Assistant-procureur général, 2S007 L.DÉSILETS.Congregation Reshith Chochma, First Mesifta of Canada Notice is hereby given that under the provisions of Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of June, 1950, incorporating without share capital: Rabbi Alexander Unsdbrfer, Rabbi Herman Sigal, and Nelson Lehman, jobber, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To establish a synagogue where services will be conducted in accordance with the strickly orthodox interpretation of the Jewish law, under the name of \"Congregation Reshith Chochma, First Mesifta of Canada\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may possess, is to l>c limited is $20,000.The head office of the Corporation will be at 5400 Jeanne Mance Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this second day of June, 1950, L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Escoe Realties Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du treize juin 1950, constituant en corporation: Marcel Marcus, avocat et conseil en loi du Roi, Allan Marcus, avocat, et Edmée Layigne, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie et d'un agent d'immeubles, sous le nom de \"Escoe Realties Limited\", avec un capital de $50,000 divisé en 500 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le treize juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Frank Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-cinq mai 1950, constituant en corporation: John Jacob Spector, avocat et conseil en loi du Roi, Ben Schecter, avocat, Moses Moscovitch, avocat et Margaret McMartin, sténographe, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme entrepreneurs généraux et faire le négoce et manufacturer des matériaux de construction, sous le nom de Escoe Realties Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of June, 1950, incorporating: Marcel Marcus, advocate and King's Counsel, Allan Marcus advocate, and Edmée Lavigne, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate agent and company, under the name of \"Escoe Realties Limited\", with a capital stock of $50,000.divided into 500 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this thirteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Frank Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of May, 1950, incorporating: John Jacob Spector, advocate and King's Counsel, Ben Schecter, advocate, Moses Moscovitch, advocate and Margaret McMartin, stenographer, all of the City and Judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of geneial contractors and deal in and manufacture building materials, under the name of \"Frank Construction Ltd.\", 1970 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août I960, Tome 82, N° 81 \"Frank Construction Ltd.\", avec un capital de $100,000 divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-cinq mai 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DESILETS.Georges Lachance Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du dix juin 1950, constituant en corporation: J.-Êmilio Lachance, comptable agréé, et Paul-Émile Lachance, agent d'assurances, tous des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Faire le commerce de liqueurs douces et eaux gazeuses, sous le nom de \"Georges.Lachance Ltée\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 1177, Chemin de la Canardièrc, Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général, le dix juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.with a capital stock of $100,000.divided into 5,000 common shares of the par value of $10.each and 500 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-fifth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Georges Lachance Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the tenth day of June, 1950, incorporating: J.Emilio Lachance, merchant, Georges Lachance, chartered accountant, and Paul Emile Lachance, insurance agent, all of the city and judicial district of Quebec, for the following purposes: To deal in soft drinks and aerated water, under the name of \"Georges Lachance Ltéc\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100 each.The head office of the company will be at 1177 de la Canardière Road, Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Gidko Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du quatorze juin 1950, constituant en corporation: Moses Samuel Yelin, avocat, Esther Mon-son, secrétaire, de la cité de Montréal et Rodolphe Koch, gérant, de la cité de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires et agir comme une compagnie de terrains et d'immeubles, sous le nom de \"Gidko Corporation\".Le capital de la compagnie sera composé de 1,000 actions sans aucune valeur nominale ou au pair; et le montant du capital avec lequel la compagnie commencera ses opérations ne sera pas moins que $5,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Hodge Bros.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du huit juin 1950, constituant en corporation: Yvon Jasmin, avocat, Lucienne Mérineau et Rita Dufresne, secrétaires, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer ou faire le négoce de moyens de transport, véhicules et accessoires ou leurs pièces, sous le nom de \"Hodge Bros.Ltd.\", avec un ca- Gidko Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of June, 1950, incorporating: Moses Samuel Yelin, advocate, Esther Monson, secretary, of the City of Montreal, and Rodolphe Koch, manager, of the City of Westmount, all in the Judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business and activities of a land and real estate company, under the name of \"Gidko Corporation\".The capital stock of the Company shall consist of 1,000 shares without any nominal or par value; an the amount of capital with which the company will commence operations shall be not less than $5,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS.28007-o Deputy Attorney General.Hodge Bros.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of June, 1950, incorporating: Yvon Jasmin, advocate, Lucienne Mérineau and Rita Dufresne, secretaries, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To manufacture or deal in or with conveyances and vehicles, and accessories, or parts thereof, under the name of \"Hodge Bros.Ltd.\", with QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 5th, 1950, Vol 82, No.31 1971 ,000 divisé en 990 actions de $100 a capital stock of $99,000.divided into 990 shares of $100.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.pital de chacune.Le siège social de- la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit juin 1950.' L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Imprimerie G.Désilets Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettre patentes, en date du premier juin 1950, constituant en corporation: Gérard Corbeil, avocat, Léo Davignon, comptable, et Jeanne Drouin, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeur, libraire et agent de publicité, sous le nom de \"Imprimerie G.Désilets Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 40,000 actions de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Acton Vale, district judiciaire de St-Hyacinthe.Daté du bureau du Procureur général, le premier juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.Isidore Vallée Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes en date du huit juin 1950, constituant en corporation: Paul Duval, notaire, de Sillery, J.-Léon Des-patis, comptable, et Gisèle Martel, secrétaire, tous deux de la cité de Québec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exécuter tous travaux de plâtrage, briquetage, maçonnerie et tous autres ouvrages touchant le bistiment, sous le nom de \"Isidore Vallée Inc.\", avec un capital de $200,000, divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le huit juin 1950.1/Assistant-procureur général, 2S007-o L.DÉSILETS.Imprimerie G.Désilets Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of June, 1950, incorporating: Gérard Corbeil, advocate, Léo Davignon, accountant, and Jeanne Drouin, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of printer, stationer and advertising agent, under the name of \"Imprimerie G.Désilets Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 40,000 shares of $1 each.The head office of the company will be at Acton Vale, judicial district of St-Hyacinthe.Dated at the office of the Attorney General, this first day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Isidore Vallée Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of June, 1950, incorporating: Paul Duval, notary, of Sillery, J.Léon Despatis, accountant, and Gisèle Martel, secretary, both of the city of Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To perforin all kinds of works in plastering, brick-laying, masonry and all other \u2022 works connected with the building trade, under the name of \"Isidore Vallée Inc.\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.La Cie d'Amiante Lafayette Ltée (Libre de responsabilité personnelle) Lafayette Asbestos Co.Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 276, S.R.Q., 1941, des lettres patentes, en date du dix juin 1950, constituant en corporation: Henri Crépeau, avocat et conseil en loi du Roi, Françoise Gagnon, secrétaire, des cité et district judiciaire de Montréal, et Roger Veillet, photographe, de Malartic, district judiciaire d'Abitibi, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines'et minerais; Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, La Cie d'Amiante Lafayette Ltée (Libre de responsabilité personnelle) Lafayette Asbestos Co.Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the provisions of the Quebec Mining Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1941, bearing date the tenth day of June, 1950, incorporating: Henri Crépeau, advocate and King's Counsel, Françoise Gagnon, secretary, of the city and judicial district of Montreal, and Roger Veillet, photographer, of Malartic, judicial district of Abitibi, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals; Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and stones may, for the purposes of extrac- 1972 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août I960, Tome 82, N° 81 épurer, broyer ou traiter de quelque autre manière que ce soit le sol ou les terres, les roches ou les pierres, dans le but d'en extraire des minerais quelconques; donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; les vendre ou autrement en disposer, sous le nom de \"La Cie d'Amiante Lafayette Ltée (Libre de responsabilité personnelle)\u2014\"Lafayette Asbestos Co.Ltd.(No Personal Liability)\", avec un capital de $3,500,000 divisé en 3,500,000 actions de $1 chacune.Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle au delà du montant du prix payé ou convenu de payer à la compagnie pour ses actions.Le siège social de la compagnie sera à Saint-Odilon, district judiciaire de Beauce.Daté du bureau du Procureur général le dix juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.La Cie de Literie et d'Ameublement Inter-Canada Ltée Inter-Canada Bedding and Furniture Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze juin 1950, constituant en corporation: Alphonse Begin, comptable public, Jean-Jacques Chagnon, vendeur, de Longueuil, et Henri Brassard, vendeur, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer des lits et généralement faire le commerce d'ameublements, sous le nom de \"La Cie de Literie et d'Ameublement Inter-Canada Ltée\"\u2014\"Inter-Canada Bedding and Furniture Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatorze juin 1950.L'Assistant-Procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.ting any minerals whatx soever, bien med, dug, raised, washed, cradled, smelted, refined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any means whatsoever; and sell or otherwise dispose thereof, under the name of \"La Cie d'Amiante Lafayette Ltée, (Libre de responsabilité personnelle)\"\u2014\"Lafayette Asbestos Co.Ltd.(No Personal Liability)\" with a capital stock of $3,500,000 divided into 3,500,000 shares of $1 each.The shareholders shall incur no personal liability in excess of the amount of the price paid or agreed to be paid to the company for its shares.The head office of the company will be at Saint-Odilon, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this tenth day of June, 1950.L.DÉSDLETS, 28007 Deputy Attorney General.La Cie de Literie et d'Ameublement Inter-Canada Ltée Inter-Canada Bedding and Furniture Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of June, 1950, incorporating: Alphonse Begin, public accountant, Jean Jacques Chagnon, salesman, of Longueuil, and Henri Brassard, salesman, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To manufacture beds and deal generally in furniture, under the name of \"La Cie de Literie et d'Ameublement Inter-Canada Ltée\"\u2014\"Inter Canada Bedding and Furniture Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000 divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Lake St.John and Chibougamau Transport Limited Lac Saint-Jean et Chibougamau Transport Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du treize juin 1950, constituant en corporation: J.-Albert Néron, négociant, Jean-Marie Marcotte, garagiste, de Roberval, et J.-Eugène Perron, camionneur, de Saint-Prime, tous du district judiciaire de Roberval, pour les objets suivants: Exercer généralement le commerce du transport, sous le nom de \"Lake St.John and Chibougamau Transport Limited\"\u2014\"Lac Saint-Jean et Chibougamau Transport Limitée\", avec un capital de $40,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 150 actions privilégiées d'une valeur de $100 chacune.lie siège social de la compagnie sera à Roberval, district judiciaire de Roberval.Lake St.John and Chibougamau Transport Limited Lac Saint-Jean et Chibougamau Transport Limitée Notice is hereby given that under Part J of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirteenth day of June, 1950, incorporating: J.Albert Neron jobber, Jean-Marie Marcotte, garage keeper, of Roberval, and J.Eugène Perron, carter, of Saint-Prime, all of the judicial district of Roberval, for the following purposes: To carry on the transportation business in general, under the name of \"Lake St.John and Chibougamau Transport Limited\"\u2014\"Lac Saint-Jean et Chibougamau Transport Limitée\", with a capital stock of $40,000 divided into 250 common shares of a par value of $100 each and 150 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Roberval, judicial district of Roberval. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 5th, 1950, Vol.82, No.31 1973 \u2014-:-i Daté du bureau du Procureur général le treize Dated at the office of the Attorney General, juin 1950.this thirteenth day of June, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28007-o L.DÉSILETS.28007 Deputy Attorney General.L'Association Sportive de Bcllevue Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze juin 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Monsieur l'abbé Médard Montpetit, curé de la desserte de Saint-Rémi de Bellevue, ville de Léry, Rodolphe Hainault, comptable, Louis Trudeau, marchand, Roger Boudreault, marchand, tous de Ville de Léry, Paul Trudeau, Orner Langlois, Réal Drapeau, marchands, Alexandre Chevalier, manufacturier, Horace-Hormisdas Dansercau, rentier, de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Travailler au bien-être en général de tous les paroissiens de la desserte de St-Rémi de Bcllevue, en la ville de Léry, dans le comté de Chateau-guay, sous le nom de \"L'Association Sportive de Bellevue\".lies pouvoirs de la corporation ne permettent pas les jeux de hasard, les jeux à l'argent, ni les jeux mixtes de hasard et d'habileté, et n'autorisent pas non plus la corporation à demander, détenir ou exploiter une licence octroyée par la Commission des Liqueurs de Québec.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $100,000.Le siège social de la corporation sera au N° 38, rue Notre-Dame ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le quatorze juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.Laval Securities Limited L'Association Sportive de Bellevue Notice is hereby given that under Part DTI of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of June, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: the Rev.abbé Médard Montpetit, parish priest of \"la desserte de Saint-Remi de Bellevue, Town of de Léry, Rodolphe Hainault, accountant, Louis Trudeau, merchant, Roger Boudreault, merchant, all of the Town of de Léry, Paul Trudeau, Orner Langlois, Réal Drapeau, merchants, Alexandre Chevalier manufacturer, Horace Hormisdas Danse-reau annuitant, of the city of Montreal, all of the judicial district of Montréal, for the following purposes: To work for the general welfare of all the parishioners of the \"desserte\" of St-Rémi de Bellevue, in the town of de Léry, in the county of Chateau-guay, under the name of \"L'Association Sportive de Bcllevue\".The powers of the corporation do not permit games of chance, gambling, nor games of chance and skill mixed, nor do they authorize the corporation to apply for, hold or operate a license granted by the Quebec Liquor Commission.The amount to which|the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation will be at No.38 Notre-Dame street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Laval Securities Limited Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of the partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the twenty-du vingt-sept mai 1950, constituant en corpora- seventh day of May, 1950, incorporating: Robert tion: Robert H.Waddell, comptable, Lottie Pa- H.Waddell, accountant, Lottie Pachal, typist, chai, dactylographe et Gerald McTeigue, pro- and Gerald McTeigue, barrister, all of the City curcur, tous des cité et district judiciaire de and Judicial District of Montreal, for the follow-Montréal, pour les objets suivants: ing purposes: Exercer le commerce comme marchands d'obli- To carry on the business of bond dealers, inv-gations, courtiers de placements et courtiers estment brokers and share brokers, under the (î'actions, sous le nom de \"Laval Securities Limi- name of \"Laval Securities Limited\", with a capital ted\", avec un capital de $40,000 divisé en 4,000 stock of $40,000.divided into 4,000 shares of actions de $10 chacune.$10.each.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, The head office of the Company will be at district judiciaire de Montréal.Montreal, Judicial District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le Dated at the office of the Attorney General, vingt-sept mai 1950.this twenty-seventh day of May, 1950.L'Assistant-procureur général, L.DÉSILETS, 28007 L.DÉSDLETS .28007-o Deputy Attorney General.Le Pétrole de Mt-Laurier Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du six juin 1950, constituant en corporation: Charlemagne Landry, avocat, Marcel Landry, étudiant en droit, et Marcel Armand, comptable Le Pétrole de Mt-Laurier Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1950, incorporating: Charlemagne Landry, advocate, Marcel Landry, law student, and Marcel Armand, chartered accountant, of the 1974 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août 1950, Tome 82, N° 81 agréé, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce des huiles à moteur, huiles à chauffage, des lubrifiants et de la gasoline, sous le nom de \"Le Pétrole de Mt-Laurier Ltée\", avec un capital de 820,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 132 ouest, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le six juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-O L.DÉSILETS.city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To deal in motor oils, fuel oils, lubricants and gasoline, under the name of \"Le Pétrole de Mt-Laurier Ltée\", with a capital stock of $20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at 132 St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Le Service Hypothécaire du Sagiicnay Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize juin 1950, constituant en corporation: Louis-René Lagacé, avocat, Lucienne Morin, Françoise Harvey, sténographes, tous de Chi-coutimi, district judiciaire de Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce des valeurs mobilières et immobilières, sous le nom de \"Le Service Hypothécaire du Sagucnay\", avec un capital de $10,000 divisé en 100 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Daté du bureau du Procureur général le seize juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.Le Service Hypothécaire du Sagucnay Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixteenth day of June, 1950, incorporating: Louis René Lagacé, advocate, Lucienne Morin, Françoise Harvey, stenographers, all of Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi, for the following purposes: To deal in movable and immovable securities, under the name of \"Le Service Hypothécaire du Sagucnay\", with a capital stock of $10,000 divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Les Placements Duvernay Inc.Duvernay Investments Inc.Avis est donné qu'en.vertu de la première partie de la IiOi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec des lettres patentes, en date du sept juin 1950, constituant en corporation: Paul Tanguay, Maurice Tanguay, courtiers d'assurances, Gérald Charette, surintendant, Guy Desjardins et Claude Ducharme, avocats, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Faire les opérations d'une compagnie de placements, sous le nom de \"Les Placements Duvernay Inc.\" \u2014 \"Duvernay Investments Inc.\", avec un capital de $18,000 divisé en 1,800 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le sept juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.Loisirs Notre Dame de Grâces de Ville Jacques-Cartier Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quinze juin 1950, constituant en corporation sans capital-actions: Victor Filteault, typographe, J.-Êdouard Valiquette, vendeur, Henri Lapierre, comptable, W.Gervais, journalier, Gérard Gagnon et Fabien Santoire, opérateurs, tous de Ville Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Les Placements Duvernay Inc.Duvernay Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the seventli day of June, 1950, incorporating: Paul Tanguay, Maurice Tanguay, insurance brokers, Gerald Charette, superintendent, Guy Dcsjardins and Claude Ducharme, advocates, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Les Placements Duvernay Inc.\" \u2014 \"Duvernay Investments Inc.\" with a capital stock of $18,000 divided into 1,800 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this seventh day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Loisirs Notre Dame de Grâces de Ville Jacques-Cartier Notice is% hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fifteenth day of June, 1950, to incorporate as a corporation without share capital: Victor Filteault, typographer, J.Edouard Valiquette, salesman, Henri Lapierre, accountant, W.Gervais, laborer, Gérard Gagnon and Fabien Santoire, operators, all of Ville Jacques-Cartier, judicial «district of Montreal, or the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 6th, 1950, Vol 82, No.81 1975 Travailler au bien-être moral et physique des residents de la paroisse Notre-Dame de Grâce, sous le nom de 'Loisirs Notre Dame de Grâces de Ville Jacques Cartier\", lœs pouvoirs accordés ne permettent pas les jeux à l'argent, les jeux mixtes de hasard et d'habileté, les paris illégaux, et n'autorisent pas non plus la corporation à demander, détenir ou exploiter une licence octroyée par la Commission des Liqueurs de Québec.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à 700 Chemin Côteau-Rouge, ville Jacques Cartier, district judiciaire de Montréal.\u2022 Daté du bureau du Procureur général, le quinze juin 1950.L'Assistant-procureur général, 2S007-O L.DÉSILETS.Metropolitan Realties Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quelle, des lettres patentes en date du trois juin 1950, constituant en corporation: Lucille Dunn, Frances McOuat et Olive Adams, secrétaires,.filles majeures, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Transiger les affaires d'une compagnie d'amélioration d'immeubles, de développement et de placement, sous le nom de \"Metropolitan Realties Ltd.\", avec un capital de $40,000 divisé en 400 actions de $100 chacune.l/c siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.To work for the moral and physical welfare of the residents of the parish of Notre-Dame de Grâces, under the name of \"Loisirs Notre Dame de Grâces de Ville Jacques Cartier\".The powers conferred do not permit gambling, games of chance and skill mixed, illegal betting, or do they authorize the corporation to apply for, hold or operate a license granted by the Quebec Liquor Commission.The amount to which the immovable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at 700 Côteau-Rouge Road, Ville Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fifteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Metropolitan Realties Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of June, 1950, incorporating: Lucille Dunn, Frances McOuat and Olive Adams, secretaries, spinsters, of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate improvement, development and investment company, under the name of \"Metropolitan Realties Ltd.\", with a capital stock of $40,000.divided into 400 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this third day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.New York Garment Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux juin 1950, constituant en corporation: Alan B.Gold, Murray Lapin, avocats, Anne Lash, secrétaire, de la cité de Montréal, et Marcus Meyer Sperber, avocat et conseil en loi du Roi, de la cité de Westmount, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de marchandises sèches, hardes et vêtements, sous le nom de \"New York Garment Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 3,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.lie siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le deux juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L- DÉSDLETS.New York Garment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec^ bearing date the second day of June, 1950, incorporating: Alan B.Gold, Murray Meyer Sperber, advocate and King's Counsel, of the City of Westmount, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes; To manufacturer and deal in dry goods, clothing and wearing apparel, under the name of \"New York Garment Inc.\", with a capital stock of $40,000.divided into 3,000 common shares of the par value of $100 each, and 1,000 preferred shares of the par value of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this second day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Nora Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six juin 1950, constituant en corporation: Saul Aron, Josep Axon et Mendie Aron, mar- Nora Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1950, incorporating: Saul Aron, Joseph Aron and Mendie Aron, merchants, of the City 1976 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août 1950, Tome 82, N° 31 chaiids, des cité et district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer ou autrement faire le négoce ou le commerce de laine, coton, tissus, lainages, soieries, toiles et vêtements de toutes sortes, sous le nom de \"Nora Ltée\", avec un capital de $40,-000 divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de §10 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 137 rue St-Joscph, Québec, district judiciaire de Quél>ec.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.P.A.Gouin Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du seize juin 1950, constituant en corporation: Jacques Raymond, comptable agréé, de la cité, de Montréal, Guy Chabot, comptable agréé d'Outrcmont, et Guy Martin, comptable agréé, de Lachine, district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants:- Faire la préparation et le commerce de quincaillerie, ferronnerie, matériaux de construction; explorer mines, droits miniers, carrières; les exploiter et en disposer, sous le nom de \"P.A.Gouin Limitée\", Le capital-actions de la compagnie est divisé en 5,000 actions sans valeur au pair ou nominale et en 2,000 actions privilégiées de $25 chacune; et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $35,000.Le siège social de la compagnie sera aux Trois-Rivières, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général, le seize juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.Peco Dyeing Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du huit juin 1950, constituant en corporation: Charles-Edouard Bertrand, Jean-Paul Danse-reau, avocats, et Marthe Toupin, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les fonctions de teinturiers, blanchisseurs et finisseurs, sous le nom de \"Peco Dyeing Inc.\", avec un capital de $25,000 divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le huit juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.P.H.Parent, Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatorze juin 1950, constituant en corporation: Ernest Godbout, Paul-Henri Parent, industriels, de Loretteville, et Rita Bouchard, sté- and Judicial District of Quebec, for the following purposes: To manufacture or otherwise deal in or with wool, cotton, fabrics, woollens, silks, linens and clothing of every sort, under the name of \"Nora Ltée\", with a capital stock of $40,000.divided into 2,000 common shares at a par value of $10.each, and 2,000 preferred shares at a par value of $10.each.The head office of the Company will be at 137 St.Joseph Street, Quebec, Judicial District of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.P.A.Gouin Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the province of Quebec, bearing date the sixteenth day of June, 1950, incorporating: Jacques Raymond, chartered accountant, of the city of Montreal, Guy Chabot, chartered accountant, of Outremont, and Guy Martin, chartered accountant, of Lachine, judicial district of Montreal, for the following purposes: To prepare and deal in hardware, ironware, building requisites; to explore mines,' mining rights, quarries; to operate and dispose of the same, under the name of \"P.A.Gouin Limitée\".The capital stock of the company is divided into 5,000 shares having no par or nominal value and into 2,000 preferred shares of $25 each; and the amount with which the company will commence its operations is $35,000.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General, this sixteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS.28007 Deputy Attorney General.Peco Dyeing Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day of June, 1950, incorporating: Charles Edouard Bertrand, Jean Paul Dansercau, advocates, and Marthe Toupin, secretary, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of dyers, bleachers and finishers, under the name of \"Peco Dyeing Inc.\", with a capital stock of $25,000 divided into 250 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.P.H.Parent, Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of June, 1950, incorporating: Ernest God-bout, Paul Henri Parent, industrialists, of Loretteville, and Rita Bouchard, stenographer, of QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 5th, I960, Vol.82, No.31 1977 nographe, de Quebec, tous du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Exécuter des travaux de plomberie, de chauffage, d'électricité et de béton et faire le commerce de matériaux de plomberie, de chauffage et d'électricité, sous le nom de \"P.H.Parent, Limitée\", avec un capital de §20,000 divisé en 200 actions de S100 chacune.Ix; siège social de la compagnie sera à Loretteville, district judiciaire de Québec.Daté du bureau du Procureur général le quatorze juin 1950.L'Assistant-procureur général, 2S007-o L.DÉSILETS.Quebec, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To perform works of plumbing, heating, electricity and concrete and to deal in plumbing, heating and electrical supplies, under the name of \"P.H.Parent, Limitée\", with a capital stock of 20,000 divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Loretteville, judicial district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.Pink & Grey Granite Co.Ltd.Avis est donné, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du dix-neuf juin 1950, constituant en corporation: Gordon S.Westgate, financier, de Ste-Agathe-des-Monts, district judiciaire de Terrebonne, Sully Meunier, courtier d'assurances, des cité et district judiciaire de Montréal et Jack Grow, financier, de Boston, U.S.A., pour les objets suivants: Négocier, manufacturer et préparer pour le marché, et pour toutes fins de construction et autres, du granit, du marbre, de la pierre et matériaux de construction de toute nature et nom, sous le nom de \"Pink & Grey Granite Co.Ltd.\", avec un capital de $100,000 divisé en 100,000 actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ste-Agathe-des-Monts, district judiciaire de Terrebonne.Daté du bureau du Procureur général, le dix-neuf juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Richmond Pulp & Paper Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, conformément à l'article 2, chapitre 270, S.R.Q.1941, des lettres patentes en date du vingt et un juin 1950, constituant en corporation: James Gibb Stewart, avocat, George Wanklyn Hali, avocat, Howard Spear Simpson, avocat, de la cité de Montréal, John Anthony Nolan, Pierre de Grandpré, avocats, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer dans toutes ses spécialités le commerce qui consiste à manufacturer et négocier aucun et toutes sortes de papier, cartonnage, bois de pulpe et pulpe de bois, carton et bois de construction, sous le nom de \"Richmond Pulp & Paper Co.Ltd.\".Le capital de la compagnie est divisé en 5,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et en 2,500 actions privilégiées de $100 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations sera de $50,000.Le siège social de la compagnie sera à Bromp-tonville, district judiciaire de St-François.Daté du bureau du Procureur général, le vingt et un juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Pink & Grey Granite Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the nineteenth day of June, 1950, incorporating: Gordon S.Westgate, financier, of Ste-Agathe-des-Monts, Judicial District of Terrebonne, Sully Meunier, insurance broker, of the City and Judicial District of Montreal, and Jack Grow, financier, of Boston, U.S.A., for the following purposes: To carry on, manufacture and prepare for market, and for all building and other purposes, granite, marble, stone and building material of every name and nature, under the name of \"Pink & GVcy Granite Co.Ltd.\", with a capital stock of $100,000.divided into 100,000 shares of a par value of $1.each.The head office of the Company will be at Ste-Agathe-des-Monts, Judicial district of Terrebonne.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Richmond Pulp & Paper Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with section 2, chapter 276, R.S.Q., 1951, bearing date the twenty-first day of June, 1950, incorporating: James Gibb Stewart, advocate, George Wanklyn Hall, advocate, Howard Spear Simpson, advocate, of the City of Montreal, John Anthony Nolan, Pierre de Grandpré, advocates, of the City of Outrcmont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on in all its branches the business of manufacturing and dealing in any and all kinds of paper, paper board, pulp wood, and wood pulp, cardboard and lumber, under the name of \"Richmond Pulp & Paper Co.Ltd.\", The capital stock of the company is divided into 5,000 common shares bearing no nominal or par'value and into 2,500 preferred shares of $100.each and the amount with which the company will commence its operations will be $50,000.The head office of the Company will be at Bromptonville, Judicial district of St.Francis.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-first day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General. 1978 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 août 1950, Tome 82, Nù 31 Rishon Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Quelle, des lettres patentes en date du douze juin 1950, constituant en corporation: Milton Lowen Klein, avocat, Arthur Daniel Ruby, comptable agréé et Irwin Bernard Blond, notaire public, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme hôteliers, propriétaires de restaurants et cafés, pourvoyeurs et fournisseurs, comme agents d'immeubles, agents d'assurances, sujet aux dispositions de la Loi des assurances de Québec, évaluateurs experts, courtiers d'immeubles et faire le commerce général d'une agence d'immeubles, sous le nom de \"Rishon Co.Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 200 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le douze juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Rishon Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of June, 1950, incorporating: Milton, Lowen Klein, advocate, Arthur Daniel Ruby chartered accountant, and Irwin Bernard Blond, notary public, all of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of hotel, restaurant, café, purveyors and caterers, real estate, insurance agents, subject to the provisions of the Quebec Insurance Act, expert valuators, realty brokers and to do a general real estate agency business, under the name of \"Rishon Co.Ltd.\", with a capital stock of $20,000.divided into 200 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial Dstrict of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Silver Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentas en date du quatorze juin 1950, constituant en corporation: Geoffroy Birtz, Madeleine Béique, avocats et Gabrielle Lahaie, secrétaire, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Entreprendre et exercer tous ou aucun des commerces d'entrepreneurs généraux et constructeurs, sous le nom de \"Silver Construction Co.Ltd.\", avec un capital de $20,000 divisé en 2,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 360 ouest, rue Craig, chambre 306, Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le quatorze juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 .L.DÉSILETS.Silver Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourteenth day of June, 1950, incorporating: Geoffroy Birtz, Madeleine Béique, lawyers, and Gabrielle Lahaie, secretary, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes : To engage in and carry on all or any of the business of general contractors and builders, under the name of \"Silver Construction Co.Ltd.\", with a capital stock of $20,000.divided into 2,000 shares of $10.each.The head office of the Company will be at 360 Craig St.West, Room 306, Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourteenth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Ste Marguerite Salmon Club Avis est donné qu'en vertu de la deuxième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du 11 juillet 1950, confirmant le règlement spécial \"A\" (1950) de \"Ste-Marguerite Salmon Club\", subdivisant les actions du capital de ladite corporation, originairement divisé en trente (30) actions de mille dollars ($1,000) chacune, ce capital étant maintenant subdivisé en trois mille (3,000) actions de dix dollars ($10) chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 11 juillet 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Stylecraft Leather Products Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trente et un mai 1950, constituant en cor- Ste Marguerite Salmon Club Notice is hereby given that under Part II of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the 11th day of July, 1950, confirming the Special By-law \"A\" (1950) of the \"Ste Marguerite Salmon Club\", subdividing the shares of the stock of the said corporation, originally divided into thirty (30) shares of one thousand dollars ($1,000) each, such shares now being subdivided into three thousand (3,000) shares of ten dollars ($10.) each.Dated at the office of the Attorney General, this 11th day of July, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General.Stylecraft Leather Products Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the thirty-first day of May, 1950, incorporating: Louis M. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 5th, 1950, Vol 82, No.21 1979 poration: Louis M.Benjamin, Irwin A.Fran-kel, avocats, Sadie Gersovitz, sténographe, de la cité de Montréal, et Jacob M.Rosenfeld, avocat, de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce général de cuir dans toutes ses spécialités, sous le nom de \"Style-craft Leather Products Inc.\", avec un capital de $40,000 divisé en 300 actions ordinaires de SI00 chacune et en 100 actions privilégiées de SI00 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trente et un mai 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.The Airport Garage Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du trois juin 1950, constituant en corporation: George Wanklyn Hall, avocat, de la cité de Montréal, Pierre de Grandpré, avocat et John Anthony Nolan, avocat de la cité d'Outremont, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un garage et faire le commerce d'automobiles et motocyclettes, sous le nom de \"The Airport Garage Co.Ltd.\".Le capital de ladite compagnie sera composé de 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de SI,000.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le trois juin 1950.L'Assistant-procureur général, 2S007 L.DÉSILETS.Togmastcr Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du deux juin 1950, constituant en corporation: Max Liverman, Leonard Liverman, Julius Bris-kin, avocats, Jack Klineberg, notaire et Charles Hyman, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme manufacturiers de hardes et vêtements, sous le nom de \"Togmas-ter Inc.\", avec un capital de $10,000 divisé en 500 actions privilégiées de $10 chacune et en 500 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général,-le deux juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Benjamin, Irwin A.Frankel, advocates, Sadie Gersovitz, stenographer, of the City of Montreal, and Jacob M.Rosenfeld, advocate, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on a general leather business in all 'its branches, under the name of \"Style'craft Leather Products Inc.\", with a capital stock of S40.000.divided into 300 common shares of $100 each, and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this thirty-first day of May, 1950.L.DÉSILETS, 2S007-o Deputy Attorney General.The Airport Garage Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act letters patent have been issued by the Lieutenant-governor of the Province of Quebec, bearing date the third day of June, 1950, incorporating: George Wanklyn Hall, advocate, of the City of Montreal, Pierre de Grandpré, advocate, and John Anthony Nolan, advocate, of the City of Outremont, all in the Judicial District of Montreal, for the following purposes: To oj>crate a garage and deal in automobiles and motorcycles, under the name of \"The Airport Garage Co.Ltd.\".The capital stock of the said company shall consist of 1,000 common shares of a par value of $10 each, and the amount of capital with which the company will commence operations is $1,000.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this third day of June.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General, Togmaster Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of June, 1950, incorporating: Max Liverman, Leonard Liverman, Julius Briskin, advocates, Jack Klineberg, notary, and Charles Hyman accountant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the businesses of manufacturers of clothing and wearing apparel, under the name of \".Togmaster Inc.\",' with a capital stock of $10,000.divided into 500 preferred shares of $10.each, and 500 common shares of a par value of $10.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this second day of June, 1950.L.DÉSJXETS, 280Ô7-o Deputy Attorney General.Victoria Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date Victoria Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eighth day 1980 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Quebec, 5 août i960, Tome 82, N° 31 du huit juin 1950, constituant en corporation: Marc Leroux, notaire, de ville Mont-Royal, Gisèle Mercier, secrétaire, et Jean Racicot, notaire, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce de la construction de bâtiments, maisons pour fins résidentielles, commerciales, industrielles ou autres, sous le nom de \"Victoria Corporation\", avec un capital de $25,000 divisé en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune et en 200 actions communes d'une valeur au pair de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le huit juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007-o L.DÉSILETS.of June, 1950, incorporating: Marc Leroux, notary, of the Town of Mount Royal, Gisèle Mercier, secretary, and Jean Racicot, notary, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To carry on the trade and business of constructing buildings and houses for residential, commercial, industrial or other purposes, under the name of \"Victoria Corporation\", with a capital stock of $25,000 divided into 300 preferred shares of a par value of $50 each and 200 common shares of a par value of $50 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eighth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007 Deputy Attorney General.William Wright Laboratories Inc.William Wright Laboratories Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la been issued by the Lieutenant-Governor of the province de Québec, des lettres patentes en date Province of Quebec, bearing date the seventh du sept juin 1950, constituant en corporation: day of June, 1950, incorporating: Gordon Mur-Gordon Murphy Webster, procureur, de la ville phy Webster, barrister, of the Town of Hudson de Hudson Heights, Robert Learmont Jamieson, Heights, Robert Learmont Jamieson, barrister procureur, de Pointe Claire et Lorna Thelma of Pointe Claire, and Lorna Watt, secretary, Watt, secrétaire, de la cité de Westmount, tous of the City of Westmount, all in the Judicial Dis-du district judiciaire de Montréal, pour les trict of Montreal, for the following purposes: objets suivants: ' Manufacturer ou autrement faire le négoce To manufacture or otherwise deal in and with et le commerce en gros de produits chimiques, all kinds and sorts of wholesale chemicals, drugs, drogues et remèdes de tous genres et sortes, and medicines, under the name of \"William sous le nom de \"William Wright Laboratories Wright Laboratories Inc.\" Inc.\" .Le capital de la compagnie est divisé en 5,000 The capital stock of the company is divided actions sans valeur nominale ou au pair et en into 5,000 shares having no nominal or par 1,000 actions privilégiées de $20 chacune, et value and into 1,000 preferred shares of $20 le montant avec lequel la compagnie commen- each, and the amount with which the company cera ses opérations sera de $27,000.will commence its operations will be $27,000.Le siège social de la compagnie sera à 1176 The head office of the Company will be at ouest, rue Sherbrooke, Montréal, district judi- 1176 Sherbrooke St., West, Montreal, Judicial ciaire de Montréal.District of Montreal.Daté du bureau du Procureur général, le sept Dated at the office of the Attorney General juin 1950.this seventh day of June, 1950 L'Assistant-procureur général, L.DÊSDLETS, 28007 L.DÉSILETS.28007-o Deputy Attorney General.Wrapping Advertising Limited Wrapping Advertising Limited Avis est donné qu'en vertu de la première \u2022 partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du six juin 1950, constituant en corporation: Max Bernfeld, avocat et conseil en loi du Roi, Milton Lewin Klein, avocat et Arthur Ruby, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce comme imprimeurs et publicistes et celui de toutes choses s'y rapportant, sous le nom de \"Wrapping Advertising Limited\", avec un capital de $25,000 divisé en 250 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le six juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28007 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of June, 1950, incorporating: Max Bernfeld, advocate and King's Counsel, Milton Lewin Klein, advocate, and Arthur Daniel Ruby accountant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of printers and advertising and all things incidental thereto, under the name of \"Wrapping Advertising Limited\", with' a capital stock of $25,000.divided into 250 shares of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this sixth day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28007-o Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 6th, 1950, Vol.82, No.81 1981 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Jarry & Frère Co.Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagines de Québec, il a été accordé.par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 23 mai 1950, à la compagnie \"Jarry &, Frère Co.Ltée\", ratifiant son Règlement N° XVI modifiant les conditions attachées aux actions privilégiées de ladite compagnie.Daté du bureau du Procureur général, le 23 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 28039-o L.DÉSILETS.Joseph Lorenzo Guay Incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 mai 1950, à la compagnie \"Joseph Lorenzo Guay Incorporée\", étendant ses pouvoirs.Daté du bureau du Procureur général, le 19 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 2S039-o L.DÉSILETS.Jarry & Frbre Co.Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-third day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Jafry & Frère Co.Ltée\", ratifying its By-law No.XVI amending the conditions attaching to the preferred shares of the said company.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1950.L.DÉSILETS.28039 Deputy Attorney General.Joseph Lorenzo Guay Incorporée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the nineteenth day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Joseph Lorenzo Guay Incorporée\", extending its powers.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 28039 Deputy Attorney General.Les Scies Mercier Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 23 mai 1950, à là compagnie \"Les Scies Mercier Limitée\", ratifiant son Règlement N° 4 augmentant son capital-actions de 840,000 à $100,000 par la création de 600 actions ordinaires additionnelles d'une valeur au pair de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 23 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 2S039-o L.DÉSILETS.Northern Furs Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 17 juin 1950, à la compagnie \"Fur Fashions Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 2 mars 1950, changeant son nom en celui de \"Northern Furs Limited\".Daté du bureau du Procureur général, le 17 juin 1950.L'Assistant-procureur général, 28039 L.DÉSDLETS.Les Scies Mercier Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-third day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Les Scies Mercier Limitée\", ratifying its By-law No.4 increasing its capital stock from $40,000 to $100,000 by the creation of 600 additional common shares of a par value of $100 each.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-third day of May, 1950.L.DÉSILETS, 28039 Deputy Attorney General.Northern Furs Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th day of June, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the com- {»any \"Fur Fashions Limited\", incorporated by etters patent dated March 2nd, 1950, changing its name to that of \"Northern Furs Limited\".Dated at the office of the Attorney General, this 17th day of June, 1950.L.DÉSILETS, 28039-o Deputy Attorney General.Pinker ton Flowers Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires en date du 16 mai 1950, à la compagnie \"Pinkerton Flowers Limited\", ratifiant: o) son règlement \"C\", changeant la situation du siège social de la dite compagnie de Rosemere à 5127 Pinkerton Flowers Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Pinkerton Flowers Limited\", ratifying: a) its By-Law \"C\" changing the head office of the said company from Rosemere to 5127 1982 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, é août I960, Tome 82, N° 81 ouest, rue Sherbrooke, en les cité et district judiciaire de Montréal; b) son règlement \"D\", augmentant le capital de ladite compagnie de $20,-400 à $60,400 par la création de 400 actions additionnelles de $100 chacune.Daté du bureau du Procureur général, le 16 mai 1950.L'Assistant-procureur général, 28039 L.DÉSILETS.Victoriaville Specialties Company Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été* accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes supplémentaires, en date du 17 mai 1950, à la compagnie \"Victoriaville Specialties Company Limited\", ratifiant son Règlement No 55 subdivisant ses 990 actions ordinaires de $100 chacune en 9,900 actions ordinaires de $10 chacune.Daté du bureau du Procureur général le 17 mai 1959.L'Assistant-procureur général, 28039-o L.DÉSILETS.Actions en séparation de biens Province de Québec, District d'Arthabaska, Cour Supérieure, N° 6466.Dame Madeleine Clôutier, demanderesse; vs .1.Roméo Fecteau, défendeur; Dame Madeleine Cloutier, épouse de J.Roméo Fecteau, hôtelier, de Warwick, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Victoriaville le 28 juillet, 1950.Les Procureurs de la demanderesse, 28008-o LACOURCIERE & LALIBERTÊ.Province de Québec, district de Montréal, Cour Supérieure, N° 288,443.Lydia Laudadio, des cité et district de Montréal, épouse commune en biens de Francesco Cacchione, demanderesse, vs Francesco Cacchione, des mêmes lieux, défendeur.La demanderesse a assigné le défendeur .en séparation de biens.Montréal, ce 31 juillet 1950.Les Procureurs de la demanderesse, 28034-o LAJEUNESSE & LAVERDURE.Arrêté en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 851 Québec, le 19 juillet 1950.Présent: Le Lieutepant-Gouverneur-en-Conseil.Concernant une convention collective de travail relative aux établissements commerciaux dans la ville de Magog et un rayon de 2 milles de ses limites.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes ci-après Sherbrooke Street West, in the City and Judicial District of Montreal; b) its By-Law \"D\" increasing the capital stock of the said companv from $20,400 to $60,400 by the creation of 400 additional shares of $100 each.Dated at the office of the Attorney General the 16th day of May, 1950.L.DÉSILETS, 28039-o Deputy Attorney General.Victoriaville Specialties Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the seventeenth day of May, 1950, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to the company \"Victoriaville Specialties Company Limited\", ratifying its By-law No.55 subdividing its 990 common shares of $100 each into 9,900 common shares of $10 each.Dated at the office of the Attorney General, this seventeenth day of May, 1950.L.DÉSILETS, 28039 Deputy Attorney General.Actions for separation as to property Province of Quebec, District of Arthabaska, Superior Court, No.6466.Dame Madeleine Cloutier, plaintiff; vs J.Roméo Fecteau, defendant.An action in separation of property has been brought by Mrs Madeleine Cloutier, wife of J.Roméo Fecteau, hôtel keeper from Warwick, against her husband, the said Roméo Fecteau.Victoriaville, July the 28th, 1950.LACOURCD3RE & LALIBERTÊ, 28008-o Attorneys for the plaintiff.Province of Quebec, district of Montreal, Superior Court, No.288,443.Lydia Laudadio, of the City and District of Montreal, wife common as to property of Francesco Cacchione, plaintiff, vs Francesco Cacchione, the same place, defendant, The plaintiff has assigned the defendant in separation of property.Montreal, July 31st, 1950.LAJEUNESSE & LAVERDURE.28034-o Attorneys for the Plaintiff.Order in Concil ORDER IN COUNCn, EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 851 Quebec, July 19, 1950.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning a collective labour agreement relating to the commercial establishments of the town of Magog and a radius of 2 miles from its limits.Whereas, pursuant to the provisions of th& Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties hereafter mentioned QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 6th, 1950, Vol.82, No.31 1983 mentionnées ont présenté au Ministre du Travail have submitted to the Minister of Labour a une requête à l'effet de rendre obligatoire la request to render obligatory the collective labour convention collective de travail intervenue entre: agreement entered into between: D'une part: On the one part: Le Syndicat Catholique et National des Com- \"Le Syndicat catholique et national des rais de Magog, Commis de Magog\", Et, d'autre part: And, on the other part: L'Association des Marchands de Magog, \"L'Association des Marchands de Magog\", pour les employeurs et les salariés des commerces for the employers and the employees of the et occupations visés, suivant les conditions trades and occupations concerned, according to décrites dans la Gazette officielle de Québec, the conditions described in the Quebec Official édition du 17 décembre 1949; Gazette, issue of December 17, 1949; Attendu que les dispositions de ladite con- Whereas the provisions of the said agree-vention ont acquis une signification et une ment have acquired a preponderant significance importance prépondérantes pour l'établissement and importance for the establishing of working des conditions de travail dans les commerces de conditions in the retail trades and occupations détail et occupations visées et dans la juridiction concerned and in the territorial jurisdiction territoriale indiquée dans ladite requête; indicated in the said request; Attendu que les prescriptions de la Loi ont Whereas the provisions of the Act have been été dûment suivies en ce qui touche la publication duly observed as regards the publication of des avis; notices; Attendu que les objections formulées ont été Whereas the objections raised have been appréciées conformément à la Loi; considered in pursuance of the Act; Il est ordonné, en conséquence, sur la pro- It is ordained, therefore, upon the recomposition de l'honorable Ministre du Travail; mendation of the Honourable the Minister of Labour, Que ladite requête soit acceptée, conformé- That the said request be accepted in conforment aux dispositions de la Loi de la convention mity with the provisions of the Collective Agree-collective (Statuts refondus de Québec 1941, ment Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapitre 163 et amendements), avec, toutefois, chapter 163 and amendments) with, however, les nouvelles dispositions suivantes, tenant lieu the following new provisions to be substituted des conditions décrites dans la Gazette officielle for the conditions described in the Quebec Official de Québec, édition du 17 décembre 1949.Gazette, issue cf December 17, 1949.I.Définitions: Pour les fins du décret, les mots I.Definitions: For the purposes of the decree, et termes suivants ont la signification qui leur the following words have the meaning hereafter est ci-après donnée : given to them : 1 a) Le terme \"établissements commerciaux\" a) The words \"commercial establishments\" désigne tous les commerces de détail comprenant mean all retail trades, including butcher shops, les boucheries, les épiceries, les merceries, les groceries, haberdasheries, shoe stores, drugstores, magasins de chaussures, les pharmacies, les hotels and restaurants; hardware, furniture and hôtels, les restaurants; les ferronneries, les quin- wall-paper stores; billiard rooms; musical instru-cailleries, les magasins de meubles, de tapisserie, ments, hat, paint, books, stationery and départies salles de billards, les magasins d'instruments ment stores and all kinds of retail trades now de musique, de chapeaux, de peinture, les maga- existing, or which may come into existence sins à rayons, les librairies, les papeteries, ainsi during the life of the decree, que tous les genres de commerce de détail qui existent ou qui pourraient exister pendant la durée du décret.Ce terme comprend également les boulangeries, These words also apply to bakeries, pastry-les pâtisseries, les minoteries et les fabriques shops, flour-mills and soft-drink works, d'eaux gazeuses.6) Un \"restaurant\" est un établissement 6) A \"restaurant\" is an establishment provided pourvu d'un local et d'aménagement spéciaux with special premises and equipment and in où, en considération d'un paiement, les clients which, in consideration of payment, customers trouvent habituellement à manger sans toutefois can usually eat without, however, putting up y loger.therein.c) Le terme \"marchand de rafraîchissements\" c) The words \"soda fountain keeper\" mean désigne tout magasin ou établissement commer- any retail store _ or commercial establishment cial de détail faisant la vente des bonbons, crèmes selling bonbons, ice cream, soft drinks, tobacco glacées, liqueurs douces, tabacs et accessoires and smokers' articles, trinkets, souvenirs and de fumeurs, bibelots et souvenirs, et possédant holding a municipal licence to that effect.la licence municipale à cet effet.d) Les mots \"boulangerie-pâtisserie\" dési- d) The words \"bakery-pastry shop\" mean any gnant tout établissement où se préparent et se establishment where bread and all pastries are cuisent le pain et n'importe quelle sorte de prepared and baked.pâtisseries.e) Le mot \"gérant\" désigne une personne qui e) The word \"manager\" means any person in a la pleine responsabilité de l'administration full charge of the administration of an establish-générale d'un établissement, avec pleins pou- ment, and authorized to hire and suspend em-voirs d'embaucher et de congédier le personnel, ployees./) Le mot \"apprenti\" désigne toute personne, /) The word \"apprentice\" means any male or du sexe masculin ou féminin, qui a moins de female employee with less than six (6) months six (6) mois de service dans le travail qu'elle est of service in the kind of work he or she is doing chargée de faire par son employeur.L'em- for the employer.The employer shall consider ployeur doit reconnaître la période d'appren- the period of apprenticeship previously served 1984 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août 1950, Tome 82, N° 81 tissage faite précédemment dans un autre établissement, pourvu que le salarié fournisse une déclaration assermentée établissant sa durée de service chez tel ou tel employeur.g) 1.Le terme \"employé régulier\" désigne tout salarié qui fait la semaine régulière de travail prévue par le décret.2.Tout salarié travaillant plus de quarante (40) heures par semaine est considéré comme un employé régulier et doit être rémunéré comme tel suivant les dispositions du décret.h) Le terme \"employé supplémentaire\" désigne tout salarié qui, embauché de façon intermittente, ne travaille pas plus de quarante (40) heures par semaine.i) Le terme \"employé surnuméraire\" désigne tout salarié qui est embauché spécialement et en plus du personnel régulier ou supplémentaire à l'occasion de certaines circonstances.j) Le mot \"surtemps\" comprend les heures de travail qu'un employé régulier fait en plus de la semaine régulière déterminée dans le décret pour l'établissement dans lequel il travaille.II.Juridiction territoriale: Le décret s'applique à la ville de Magog et au territoire compris dans un rayon de deux (2) milles de ses limites actuelles.III.Juridiction commerciale: Sont assujettis1 au présent décret, tous les établissements commerciaux définis au paragraphe \"a\" de l'article I du présent décret et tous les autres établissements commerciaux ou entreprises privées qui existent ou pourraient exister pendant la durée du décret et qui font le commerce de détail, c'est-à-dire, vendent directement au public consommateur ou à celui qui n'achète pas pour revendre.Est également régie, toute personne ayant un ou des agents ou un bureau dans la juridiction territoriale décrite dans l'article II du présent décret.Toutefois le présent décret ne s'applique pas à tout commerce déjà régi par un autre décret.IV.Durée du travail: La semaine régulière de travail doit être comme suit: a) Dans les épiceries et boucheries: soixante (60) heures réparties de la façon suivante: de 7.30 a.m.à 6.00 p.m., les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi; de 7.30 a.m.à 10.00 p.m., le vendredi.b) Dans tous les autres établissements commerciaux: cinquante-cinq (55) heures réparties de la façon suivante: de 8.00 a.m.à 6.00 p.m., les lundi, mardi et jeudi; de 8.00 a.m.à raidi, le mercredi; de 8.00 a.m.à 10.00 p.m., les vendredi et samedi.c) Dans les fabriques d'eaux gazeuses: quarante-huit (48) heures réparties selon les besoins de l'entreprise.d) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans les pharmacies, les librairies, papeteries, les salles de billards, les hôtels, les restaurants, les cafés, les salles de rafraîchissements et autres entreprises de même nature, la durée hebdomadaire de travail est de soixante (60) heures, réparties selon les besoins de l'entreprise.e) Les employés de bureau, tels que comptables, caissiers, etc., et les livreurs à bicyclette, sont soumis à la durée de travail prévue pour le genre d'établissement dans lequel ils travaillent./) Une heure doit être accordée pour le repas du midi; si les salariés travaillent le soir, une heure doit aussi être accordée pour le souper.Cependant, dans les boulangeries, une demi-heure seulement est accordée pour les repas.in another establishment providing the employee produce a sworn statement giving the duration of service with any other employer.g) 1.The words \"regular employee\" means any employee working the regular work week determined by the decree.2.Every employee working more than forty (40) hours per week shall be considered as a regular employee and remunerated accordingly, pursuant to the provisions of the decree.h) The words \"extra employee\" mean any employee who is employed intermittently and docs not work more than forty (40) hours per week.0 The words \"supernumerary employee\" mean any employee specially hired, in excess of the egular or extra personnel, in the event of certain circumstances.j) The word \"overtime\" means the hours worked by a regular employee in excess of the regular week, as determined in the decree for the establishment in which he works.It.Territorial jurisdiction: The decree applies to the town of Magog and to the territory comprised in a radius of two (2) miles from its present limits.III.Commercial jurisdiction: All the commercial establishments defined in subsection \"a\" of section I of the present decree are governed by it, as well as all other commercial establishments or private concerns now existing or which may come to exist during the fife of the decree and which are engaged in the retail trade, that is, who sell directly to the public or to those not buying for the purpose of selling.Any person having one or more agents or keeping an office in the territorial jurisdiction described in section II of the present decree is also governed by its provisions.However, the present decree does not apply to a trade already regulated by another decree.IV.Duration of work: The standard work week shall be as follows: o) In groceries and butcher shops: sixty (60) hours distributed as follows: 7.30 a.m.to 6.00 p.m.on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday; 7.30 a.m.to 10.00 p.m.on Friday.b) In all other commercial establishments: fifty-five (55) hours distributed as follows: 8.00 a.m.to 6.00 p.m.on Monday, Tuesday and Thursday; 8.00 a.m.to 12.00 (non) on Wednesday; 8.00 a.m.to 10.00 p.m.on Friday and Saturday.c) In soft-drink works: forty-eight (48) hours distributed as required by the concern.d) Notwithstanding the provisions of the foregoing subsections, in drugstores, bookshops, billard rooms, hotels, restaurants, cafes, soda-fountains and other concerns of the same nature, the weekly duration of work is sixty (60) hours distributed as required by the said concerns.e) Office employees, such as accountants, cashiers, etc., and delivery boys on bicycles, shall work the number of hours determined for the establishment in which they are employed./) One hour shall be granted for the noon meal.WTien the employees work in the evening, one hour shall also be given for the evening meal.However, in bakeries, one half-hour only is allowed for meals. \u2022 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 6th, 1960, Vol.82, No.81 1985 g) En dehors des heures mentionnées aux g) Outside the hours mentioned in subsections paragraphes \"a\" et \"b\" du présent article un \"a\" and \"b\" of the present section, an employee salarié ne peut travailler à la vente d'aucune shall not work at the sale of goods governed by marchandise assujettie au décret et un em- the decree, and an employer or professional ployeur ou employeur professionnel ne peut employer shall not make his employees work at faire travailler un salarié à la vente d'aucune the sale of goods governed by the decree, marchandise assujettie au décret.h) Durant la période des fêtes, le travail cesse h) During the holidays period work shall cease aux heures suivantes: du 20 au 23 décembre at the following hours: from December 20 to the inclusivement, à dix heures du soir (10.00) p.m.; 23rd inclusive, at 10.00 p.m.; on Christmas and les veilles de Noël et du Premier de l'An, à six New Year's eves, at 6.00 p.m.heures du soir (6.00) p.m.Réserve: Nonobstant les dispositions dù décret, Proviso: Notwithstanding the provisions of the la durée des heures de travail dans les établisse- decree, the duration of working hours in comments commerciaux ne doit en aucun cas consti- mercial establishments shall never constitute a tuer une dérogation aux dispositions de la Loi derogation of the provisions of the Industrial des Établissements Industriels et Commerciaux and Commercial Establishments Act (Revised (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 175), Statutes of Quebec 1941, chapter 175), of the aux décrets faits sous son autorité et aux règle- decrees rendered under its authorty or of the ments établis par les municipalités compétentes, by-laws passed by competent municipalities.V.Jours chômés: a) Il n'y a pas de travail, V.Holidays: a) No work is to be performed les dimanches, ainsi que les jours de fêtes sui- on Sundays and the following holidays: New vants: le Premier de l'An, l'Epiphanie, le Ven- Year's Day, Epiphany Day, Good Friday, As-dredi-Saint, l'Ascension, la Saint-Jean-Baptiste, cension Day, St.Jean Baptiste Day, Dominion la Confédération, la fête du Travail, l'Action de Day, Labour Day, Thanksgiving Day, All Saints Grâces, la Toussaint, lTmmaculée-Conception Day, Immaculate Conception Day and Christ-et la Noël.Le 26 décembre et le 2 janvier sont mas Day.December 26 and January 2 shall also également chômés, excepté si ces jours sont un be kept as holidays, except when falling on a Tues-mardi, un vendredi ou un samedi.Ces jours day, a Friday or a Saturday.These holidays chômés doivent être payés aux salariés qui tra- shall be paid to the employees who work and are vaillent et sont rémunérés sur une base heb- paid on a weekly basis.b) Cependant, les boulangers doivent répondre b) However, bakers shall work on the above-à l'appel de leur employeur quand leurs services mentioned days when required by their employer, sont requis durant lesdits jours chômés.c) Les dispositions du présent article ne s'ap- c) The provisions of the present section do pliquent pas aux établissements mentionnés au not apply to the establishemnts mentioned in paragraphe \"d\" de l'article IV.subsection \"d\" of section IV.VI.Salaires minima: Les salaires minima VI.Minimum wages: The following minimum suivants doivent être payés à toutes les caté- wages shall be paid to all the categories of gories de salariés assujettis au présent décret, employees governed by the present decree, ac- selon les tableaux ci-après et selon l'article VII.cording to the following tables and to sectionVH.Tableau N° 1 \u2014 Salaires hebdomadaires des salariés, excepté ceux indiqués aux tableaux numéro 2 et 8 et à l'article VII Table No.1 \u2014 Weekly wages of employees excepting those mentioned in tables 2 and 3 and in section VII.a) Apprentis: Durée hebdomadaire de travail de l'établissement Apprentices: Weekly duration of work of the establishment ier semestre d'emploi \u2014 1st six months of employment.$10.50 $12.00 $13.50 Le nombre des apprentis qu'un employeur The number of apprentices which an employer peut avoir à son service est indiqué dans le may have in his employ is indicated in the fol- tableau de classification ci-après mentionné.lowing classification table.Lorsque l'apprenti a terminé sa période d'ap- When an apprentice has completed his period prentissage de six mois, il doit immédiatement of apprenticeship of six months, he shall imme- être reconnu comme un employé régulier et être diately be considered as a regular employee and elassifié en conséquence.shall be classified accordingly.6) Employés réguliers: Durée hebdomadaire de travail de l'établissement Regular employees: Weekly duration of work of the establishement domadaire.48 heures-hours 66 heures-hours 60 heures-hours 48 heures-hours 56 heures-hours 60 heures-hours Classe-Class \"A\" (75%) Classe-Class \"B\" (25%) $14.00 12.00 $16.00 14.00 $18.00 16.00 1986 GAZETTE OFFÎCIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 août 1960, Tome 82, N° 81 Classification en pourcentages \u2014 Percentage classification Total des salariés Nombre des apprentis Total of employees Classe-Class \"A\" Classe-Class \"B\" Number of apprentices 1\t1 2\t1 3\t2 4\t3 5\t4 6\t4 7\t5 8\t6 9\t7 10\t7 11\t8 12\t9 13\t10 14\t10 15\t11 16\t12 17\t13 18\t13 19\t14 20\t15 21\t16 22\t16 23\t17 24\t18 25\t19 26\t19 27\t20 28\t21 29\t22 30\t22 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 2 5 2 5 2 5 3 6 3 6 3 6 3 6 3 7 3 7 3 8 c) Les employés de bureau et les livreurs à c) Office employees and delivery boys on bicyclette ne doivent pas être compris dans le bicycles shall not be included in the computing calcul des employés assujettis aux classes \"A\" of employees of classes \"A\" and \"B\".et \"B\".Tableau N° 2 \u2014 Salaires hebdomadaires des employés de bureau Table No.2 \u2014 Weekly wages of office employees Durée hebdomadaire de travail de l'établissement Weekly duration of work of the establishment Expérience \u2014 Experience: 48 heures-hours 56 heures-hours 60 heures-hours Moins de 6 mois \u2014 Less than 6 months.$ 8.00 $ 9.00 $10.00 6 mois et plus, mais moins de 12 mois \u2014 From 6 to 12 months exclusive.9.00 10.50 12.00 12 mois et plus, mais moins de 2 ans \u2014 From 12 months to 2 years exclusive.12.00 14.00 16.00 2 ans et plus \u2014 2 years or more.14.00 16.00 18.00 Tableau N° 8 \u2014 Salaire hebdomadaire des livreurs à bicyclette Table No.3 \u2014 Weekly wages of delivery boys on bicycles Durée hebdomadaire de travail de l'établissement Weekly duration of work of the establishment 48 heures-hours 66 heures-hours 60 heures-hours Selon que la bicyclette est fourni par: \u2014 Bicycle supplied by: L'employeur \u2014 The employer.$ 7.50 $ 8.75 $10.00 Le salarié \u2014The employee.10.00 11.50 13.00 La limite de pesanteur à être transportée sur The maximum load to be carried on a bicycle, bicyclette, tricycle ou voiturette est de trente tricycle or hand wagon shall be of 30 pounds.(30) livres.VII.Les salaires hebdomadaires minima des VII.The weekly minimum wages of servants employés à un service domestique dans les in hotels, restaurants, soda-fountains, clubs, inns, hôtels, les restaurants, les salles de rafraîchisse- cafes, or other similar concerns or trades,whether QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 6th, 1950, Vol 82, No.31 1987 merits, \"terrasses\", cercles, auberges, cafés, clubs ou autres entreprises ou commerces de cet ordre, qu'ils soient situés ou non dans un établissement commercial ou industriel, sont les suivants: a) Garçons ou filles de table, valets ou filles (le chambre, serviteurs de buvette ou cabaret, et conducteurs d'ascenseur (liftiers).$15.00 b) Maîtres d'hôtel, hôtesses, aides ou assistants aux cuisines.$17.00 c) Cuisiniers.$20.00 VIII.Surtemps: Tout travail exécuté en sus des heures régulières hebdomadaires déterminées à l'article IV, ou en sus de douze (12) heures par jour, doit être rémunéré à raison de taux et demi.Pour simplifier ce calcul, les taux horaires minima suivants doivent être payés pour les fins du présent article.a) Pour les salariés visés par le tableau Numéro 1 : 1.Classe A.$0.45 * 2.Classe B.0.42 3.Classe des apprentis.0.36 b) Pour les salariés visés par le tableau Numéro 2: 1.Deux ans et plus d'expérience.$0.45 2.Douze mois, mais moins de 2 ans d'expérience.0.42 3.Six mois, mais moins de 12 mois d'expérience.0.30 4.Moins de six mois d'expérience.0.27 c) Pour les salariés visés par le tableau Numéro 3 : 1.Pour les livreurs à qui l'employeur fournit et entretient la bicyclette.0.27 2.Pour les livreurs qui fournissent et entretiennent leur bicyclette.0.33 d) Toutefois, pour les salariés visés par l'article VII: 1.Garçons ou' filles de table, valets ou filles de chambre, serviteurs de buvette ou cabaret et conduc- teurs d'ascenseur (liftiers).$0.39 2.Maîtres d'hôtel, hôtesses, aides ou assistants aux cuisines.0.45 3.Cuisiniers.0.54 IX.Congé annuel payé: Après un an de service, tout salarié a droit à un congé annuel payé d'une semaine.S'il n'a pas un an de service, tout salarié a droit à un congé payé d'une durée d'autant de demi-jours qu'il a de mois de service.Le salarié a droit pour son congé, à une rémunération équivalente à 2% du salaire qu'il a gagné durant la période de service lui donnant droit à tel congé.Aux fins d'application du présent article, on doit rçférer aux dispositions de l'ordonnance numéro 3 revisée de la Commission du Salaire Minimum.Toutefois, le congé doit être accordé entre le premier février et le trente novembre, après entente entre l'employeur et le salarié.X.Tout travail doit être rémunéré en espèces.Les employés supplémentaires et surnuméraires doivent recevoir une rémunération minimum de vingt-cinq (25) cents l'heure.XL L'employeur qui exige de ses salariés le port d'un uniforme doit en assumer les frais d'achat, d'entretien et de blanchissage.Pour les fins du présent article, le mot \"uniforme\" ne comprend pas les tabliers des épiciers ou bouchers, non plus que les sarraus utilisés dans ce genre d'établissement.XII.Dans tous les genres de commerce ci-haut mentionnés, lorsque le logement, les repas ou located in a commercial or industrial establishments or not, shall be as follows: a) Waiters,- waitresses, room-maids or valets, bartenders and elevator operators.$15.00 b) Head waiter, hostesses, kitchen helpers or assistants.17.00 c) Cooks.! 20.00 VIII.Overtime: All work done in excess of the regular weekly hours determined in section IV, or in excess of twelve (12) hours per day shall be remunerated at the rate of time and a half.To simplify the computing thereof, the following minimum hourly rates shall be paid for overtime.a) Employees falling under table 1: 1.Class A.$0.45 2.Class B.0.42 3.Apprentices'class.0.36 b) Employees falling under table 2: 1.Two years' experience or more.$0.45 2.From one to two years' experience 0.42 3.From six to twelve months' experience .0.30 4.Less than six months' experience 0.27 c) Employees falling under table 3: 1.Delivery boys \u2014 bicycle owned and kept in repair by employer.0.27 2.Delivery boys supplying and repairing bicycle.0.33 d) However, employees governed by section VII shall be paid as follows: Waiter, waitresses, room-maids, valets, bartenders and elevator ope- rators.0.39 2.Head waiters, hostesses, kitchen helpers or assistants.0.45 3.Cooks.0.54 IX.Annual vacation with pay: After one year of service, every employee is entitled to an annual vacation with pay of one week.If he has less than one year of service, the employee is entitled to a vacation with pay of as many half-days as he has months of service.The employee shall receive for his vacation a remuneration equivalent to 2%\" of the wages earned by him during the period of service which entitles him to a vacation.For the purposes of enforcement of this section, the parties concerned shall refer to Ordinance number 3, revised, of the Minimum Wage Commission.However, the vacation shall be granted between February 1 and November 30, following an agreement between employer and employee.X.All work shall be paid for in cash.Extra or occasional employees shall receive a minimum of $0.25 per hour.XI.An employer who requires his employees to wear à uniform shall pay for the purchase, upkeep and cleaning thereof.For the purposes of this section, the word \"uniform\" neither includes grocers' or butchers' aprons nor the smocks or overalls used in such establishments.XH.In all trades mentioned above, when room and/or board is furnished by the employer, the 1988 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août I960, Tome 82, N° 81 la pension complète sont fournis par l'employeur, latter shall not deduct more than the following ce dernier ne peut déduire du salaire gagné plus amounts from the employees' wages: que les prix suivants: par semaine Per week Pension complète.$4.00 Room and board.$4.00 Pour repas.3.00 Board.3.00 Pour logement.1.25 Room(s).1.25 XIII.Dans un cas éventuel de maladie, de XIII.In the event of illness, decease or of décès ou de la visite d'un assez grand nombre de many unexpected callers, the employer of an personnes à la dernière minute, l'employeur d'un establishment governed by the decree may serve établissement régi par le décret peut servir un a customer but he shall notify the Parity Corn-client, mais il doit chaque fois en avertir le mittee each time.Comité paritaire.XrV.Les salaires actuellement payés, et qui XFV.The wages actually paid which are higher sont supérieurs aux minima fixés par le décret than the minimum ones determined by the dc-demeurent en vigueur pendant toute sa durée.crée remain in force for its entire duration.XV.Le présent décret abroge le décret numéro XV.The present decree repeals the decree 3585 du 4 octobre 1940 et tous ses amendements, number 3585 of /October 4, 1940, and all its amendments.XVI.Lors de la ratification de la présente XVI.At the time of promulgation of the convention, le Comité paritaire existant, formé present agreement, the existing Parity Commit -pour surveiller l'application du décret antérieur tee, formed to a .'minister the former decree in dans la juridiction territoriale déterminée par ce the territorial jurisdiction determined by that décret, demeure en fonction et surveille la mise decree, shall remain in office and administer the à exécution du décret jusqu'à ce qu'un nouveau present decree until the formation of a new comité soit formé.Ce nouveau comité succède committee.This new committee succeeds the à l'ancien et est investi de tous lès actifs et «former committee and is vested with all the as-droits dudit comité; il assume également toutes sets and rights of the said committee; is also les dettes de l'ancien comité en vertu dudit assumes all the liabilities of the former committee décret antérieur.incurred under the said previous decree.XVII.Durée du décret: Le présent décret est XVH.Duration of the decree: The present valable à compter du jour de sa publication dans decree comes into force on the day of its publi-la Gazette officielle de Québec et.demeure en cation in the Quebec Official Gazette and remains vigueur jusqu'au 12 octobre 1950.in full effect until October 12, 1950.Il se renouvelle automatiquement d'armée en It then renews itself automatically from year année par la suite, à moins que l'une des parties to year unless one of the contracting parties no-contractantes ne donne à l'autre partie un avis tified thé other party, in writing, to the con-écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit trary, within the period extending from the pas être de plus de soixante (60) ni de moins sixtieth to the thirtieth day prior to the expi-de trente (30) jours avant l'expiration du terme ration of the original term or prior to October original ou avant le 12 octobre de toute année 12 of any subsequent year.Such a notice shall subséquente.Un tel avis doit également être also be forwarded to the Minister of Labour, adressé au Ministre du Travail.A.MORISSET, A.MORISSET, 28041-o Greffier du Conseil Exécutif.28041-o Clerk of the Executive Council.Avis divers Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, le règlement \"A\" de \"Automotive Luncheon Club Inc.\" a été approuvé par l'Honorable Secrétaire de la Province le 19 juillet 1950, conformément aux dispositions de l'article 225 de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 26 juillet 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28009 JEAN BRUCHÊSI.'Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"L'Entraide Syndicat Coopératif Forestier de Mont-Louis Est\", en date du 9 juillet 1950, dont le siège social est situé à Mont-Louis, comté de Gaspé-Nord, et 3ue ce document a été déposé dans les archives u Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 24 juillet 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28010-o - JEAN BRUCHÊSI.Miscellaneous Notices Notice is hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, By-law \"A\" of \"Automotive Luncheon Club Inc.\" was approved by the Honourable the Provincial Secretary on July 19th, 1950, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies' Act (R.S.Q.1941, chapter 276).Given at the office of the Provincial Secretarv, this 26th day of July, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 28009-o Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"L'Entraide Syndicat Coopératif Forestier de Mont-Louis Est\", under date the ninth day of July, 1950, whereof the head office is at Mont-Louis, county of Gaspé-North, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-fourth day of Julv, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 28010 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 5th, 1950, Vol.82, No.31 1989 AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-Flavien\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 27 juillet 1950.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Saint-Flavien, comté de Lott binière.Le .Sous-secrétaire de la Province, 2801 l-o JEAN BRUCHÊSI.Montreal Polo & Country Club Limited Sommaire du Règlement N° Aï Qu'il soit décrété et il est, par les présentes décrété comme règlement N° A de \"Montreal Polo & Country Club Limited\" que l'actif de la compagnie soit distribué entre ses actionnaires.Montréal, le 1er août, 1950.Le Secrétaire, 28012-o C.HOWARD GORDON.Superior Brush Mfg.Co.Règlement 24 Que le nombre des directeurs de la compagnie soit, par les présentes, augmenté de trois à quatre.Montréal, 18 juillet 1950.(Sceau) Le Secrétaire, 28013 ALEC LEWIS.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 20 juillet 1950, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Syndicat National Catholique des Travailleurs aux Carrières de Frontenac\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la Loi 11 George VI, chapitre 52, article .5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 26 juillet 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28014-o JEAN BRUCHÊSI.Marwest Trading & Holdings Limited Règlement \"X\" La distribution de l'actif de la compagnie entre les actionnaires est, par les présentes, autorisée au pro rata du nombre d'actions détenues par chacun.Vrai sommaire certifié du règlement \"X\" de la compagnie \"Marwest Trading & Holdings Limited\".Montréal, P.Q., 30 juin 1950.(Sceau) Le Secrétaire, 28019 JOHN G.PORTEOUS.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de St-FIavien\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on July 27,1950.The principal place of business of the said professional syndicate is at Saint-Flavien, county of Lotbinière.JEAN BRUCHÊSI; 28011 Under Secretary of the Province.Montreal Polo & Country Club Limited Summary of By-Law No.A Be* it enacted and it is hereby enacted as Bylaw No.A of \"Montreal Polo & Country Club Limited\" that the assets of the Company be distributed among the shareholders.Montreal, August 1st, 1950.C.HOWARD GORDON, 28012-o Secretary.Superior Brush Mfg.Co.By-Law 24 That the number of the Directors of the Company is hereby increased from three to four.Montreal, July 18th, 1950.(Seal) ALEC LEWIS, 28013-o Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has enacted, on the 20th of July, 1950, the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Syndicat National Catholique des Travailleurs aux Carrière de Frontenac\", and such, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-sixth day of July, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 28014 Under Secretary of the Province.Marwest Tradding & Holdings Limited By-Law \"X\" The distribution of the assets of the Company amongst the Shareholders ratably to the number of shares held by each is hereby authorized.Certified true summary of By-Law \"X\" of \"Marwest Trading & Holdings Limited.\" Montreal, P.Q., June 30th, 1950.(Seal) JOHN G.PORTEOUS, 28019-o Secretary. 1990 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août 1950, Tome 82, N° 81 AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 28 juillet 1950, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"lie Syndicat National Catholique des Gantiers de St-Rayniond Inc.\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la Loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 31 juillet 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28018-o JEAN BRUCHÊSI.Avis est donné que, sur la recommandation de l'Assistant-procureur général, les règlements de \"Quebec Sightseeing Agents & Historical Guides Association\" \u2014 \"L'Association des Guides Historiques et des Agents de Visite de Lieux d'Intérêt de Québec\", comprenant les articles I à VH inclusivement et IX, ont été approuvés par l'Honorable Secrétaire de la Province le 20 juillet 1950, conformément aux dispositions de l'article 225a de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 276).Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 26 juillet 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 2S020 JEAN BRUCHÊSI.Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le texte d'une résolution du syndicat coopératif à responsabilité limitée \"Syndicat Coopératif de l'U.C.C.de St-Mathieu (Rimouski)\", société régie par la Loi des syndicats coopératifs de Québec, dont le siège social est situé à Saint-Mathieu, dans le comté de Rimouski, changeant le nom de ladite société en celui de \"La Coopérative Agricole St-Mathieu\", laquelle résolution a été adoptée à une assemblée générale spéciale des membres tenue le 31 janvier 1950, conformément aux dispositions de l'article 4 de ladite loi, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 27 juillet 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28035-o JEAN BRUCHÊSI.\"D\" Farm Inc.Règlement treize Diminuant le nombre des directeurs de six à trois.Le bureau de direction sera composé de trois directeurs, L'article un du règlement trois est modifié en cons équence Vraie copie cerfiée.Montréal, 28 avril 1950 (Sceau) Le Secrétaire, 28036 RUTH A.HAYDEN.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"L'Association des Employés de Samuel^ Hart NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has enacted, on the 28th of July, 1950, the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Le Syndicat National Catholique des Gantiers de St-Raymond Inc.\", and such, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, this thirty-first day of July, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 28018 Under Secretary of the Province.Notice^s hereby given that, upon the recommendation of the Deputy Attorney General, the By-Laws of \"Quebec Sightseeing Agents & Historical Guides Association\" \u2014 \"L'Association des Guides Historiques et des Agents de Visite de Lieux d'Intérêt de Québec\", comprising articles I to VII inclusive and IX, were approved by the Honourable the Provincial Secretary on July 20th 1950, pursuant to the provisions of section 225a of the Quebec Companies Act (R.S.Q.1911, chapter 276).Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of July, 1950.JEAN BRUCHESI, 28020-o Under Secretary of the Province.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the text of a resolution of the cooperative syndicate with limited liability \"Syndicat Coopératif de l'U.C.C.de St-Mathieu (Rimouski)\", an association governed by the Quebec Cooperative Syndicates Act, with head office at Saint-Mathieu, in the county of Rimouski, changing the name of the said association into that of \"La Coopérative Agricole St-Mathieu\", which said resolution was adopted at a special general meeting of the members, held on the 31st day of January, 1950, pursuant to the provisions of section 4 of the said Act, and that the said document has been filed in the archives of the Department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this twenty-seventh day of July, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 28035 Under Secretary of the Province.\"D\" Farm Inc.By-Law Thirteen Reducing the Number of Directors from six to three The Board of Directors shall consist of three Directors.Article one of By-law Three is amended accordingly.Certified a true Copy.Montreal, April 28th 1950.(Seal) RUTH A.HAYDEN, 28036-o Secretary.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"L'Association desjEmployés'de Samuel QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 5th, 1960, Vol.82, No.81 1991 & Co.\"\u2014\"The Samuel Hart & Co.Employees' Union\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 1er août 1950.Le siège social du syndicat professionnel précité est situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la Province, 28047-o JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) La formation d'une société, sous le nom de \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Fortierville\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 1er août 1950.I^e siège social du syndicat professionnel précité est situé à Fortierville, comté de Lotbinière.Le Sous-secrétaire de la Province, 28048-o JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 1er août 1950, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Le Syndicat Catholique et National des Comptables et des Commis de Sorel\", et ce, conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la Loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 2 août 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28049-o JEAN BRUCHÊSI.AVIS (Loi des syndicats professionnels) Avis est donné que l'honorable Secrétaire de la Province a décrété, le 31 juillet 1950, la fin de l'existence corporative du syndicat professionnel \"Le Syndicat National des Employés de Magasins de Sorel Inc.\", et ce conformément aux dispositions de l'article 20a de la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q.1941, chapitre 162, telles qu'ajoutées par la Loi 11 George VI, chapitre 52, article 5.Donné au bureau du Secrétaire de la Province, le 2 août 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28049-o JEAN BRUCHÊSI.Cercle Social Féminin de ville Mont-Royal, Inc.Extrait des règlements de la corporation ci-haut mentionnée, concernant l'augmentation du nombre des directeurs de trois à huit: \"6.Les affaires du cercle seront conduites par un bureau de direction composé de 8 membres.\" Copie conforme.La Secrétaire, 23052-O GABRIELLE DAIGNEAULT.Hart & Co.\"\u2014\"The Samuel Hart & Co.Employees] Union\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on August 1, 1950.The principal place of business of the said professional syndicate is at Montreal, judicial district of Montreal.JEAN BRUCHÊSI, 28047 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) The formation of an association under the name of \"Le Syndicat de l'U.C.C.de Fortierville\", for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of its members, has been authorized by the Provincial Secretary on August 1,1950.The principal place of business of the said professional syndicate is at Fortierville, county of Lotbinière.JEAN BRUCHÊSI, 28048 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has enacted, on the 1st of August, 1950; the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Le Syndicat Catholique et National des Comptables et des Commis de Sorel\", and such, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, this second day of August, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 28049 Under Secretary of the Province.NOTICE (Professional Syndicates' Act) Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has enacted, on the 31st of July, 1950, the termination of the corporate existence of the professional syndicate \"Le Syndicat National des Employés de Magasins de Sorel Inc.\", and such, pursuant to the provisions of section 20a of the Professional Syndicates' Act, R.S.Q., 1941, chapter 162, as added by the Act 11 George VI, chapter 52, section 5.Given at the office of the Provincial Secretary, this second day of August, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 28049 Under Secretary of the Province.Cercle Social Féminin de ville Mont-Royal, Inc.Excerpt from the by-laws of the above mentioned corporation, concerning the increase in the number of directors from three to eight: \"6.The affairs of the \"Cercle\" will be managed by a board of directors consisting of 8 members.\" True copy.GABRIELLE DAIGNEAULT, 28052 Secretary.? 1992 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 août 1950, Tome 82, N° 31 Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"Chantier Coopératif des Bergeronnes\", en date du 7 juillet 1950, dont le siège social est situé aux Grandes Bergeronnes, comté de Sagucnay, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 1er août 1950.Le Sous-secrétairc de la Province, 28053-o JEAN BRUCHf SI.L'Assistance a l'Enfant sans Soctien Extrait des minutes de l'assemblée générale spéciale des membres de \"L'Assistance à l'Enfant sans soutien\", tenue aux Trois-Rivières, le 30 juin 1950, concernant l'augmentation du nombre des directeurs de cette corporation de trois à cinq: \"que l'article N° 4 du règlement N 1 soit remplacé par le suivant: Directeurs 4.Les affaires de la Corporation seront administrées par un bureau de direction composé de cinq (5) membres.\" Certifié extrait conforme ce 3 juillet 1950.L'Assistance a l'Enfant sans Soutien, Le Président et directeur, 28054-o (signé) CHS-E.BOURGEOIS, ptre.Avis est par les présentes donné que l'honorable Secrétaire de la Province a dûment reçu le troisième original de la déclaration de fondation du syndicat coopératif \"The Morris Cooperative\", en date du 15 juillet 1950, dont le siège social est situé à St-Augustin, comté de Sague-nay, et que ce document a été déposé dans les archives du Secrétariat de la Province.Donné au bureau du Secrétaire de la Province le 1er août 1950.Le Sous-secrétaire de la Province, 28055-o JEAN BRUCHÊSI.Chartes \u2014 Abandon de AVIS PUBLIC Canada, Province de Québec, district des Trois-Rivières Avis est donné que \"La Ferme Laviolette Limitée\", Compagnie légalement constituée par Charte Provinciale, s'adressera au Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec pour obtenir l'abandon de sa Charte, en se conformant aux lois des Compagnies de la Province de Québec, quant aux procédures à suivre et au délai prévus par la Loi.Donné à Trois-Rivières, ce vingt-cinquième jour du mois de juillet, mil neuf cent cinquante.La Ferme Laviolette Limitée, Par le Notaire & Procureur, 28015-o J.C.SAWYER.Avis est donné que la compagnie \"Universal Sales Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes de la province de Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"Chan-tier Coopératif des Bergeronnes\", under date the seventh day of July, 1950, whereof the head office is at Grandes Bergeronnes, county of Sa-guenay, and that the said document has been filed in the archives of the department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this first day of August, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 28053 Under Secretary of thé Province.L'Assistance a l'Enfant sans Soutien Excerpt from the minutes of a special general meeting of the members of \"L'Assistance à l'Enfant sans Soutien\", held at Trois-Rivières, on the 30th day of June, 1950, concerning the increase in the number of directors of the said corporation from three to five: \"that article N° 4 of By-law No.1 be replaced by the following: Directors-4.The affairs of the Corporation will be managed by a board consisting of five (5) members.\" Certified true excerpt, this 3rd day of Julv 1950.L'Assistance a l'Enfant sans Soutien, (Signed) CHS.E.BOURGEOIS, Priest, 28054 President and director.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has duly received the third copy of the original of the declaration of foundation of the cooperative syndicate \"The Morris Cooperative\", under daté the fifteenth day of July, 1950, whereof the head office is at St-Augustin, county of Saguenay, and that the said document has been filed in the archives of he department of the Provincial Secretary.Given at the office of the Provincial Secretary, this first day of August, 1950.JEAN BRUCHÊSI, 28055 Under Secretary of the Province.Charters \u2014 Surrender of PUBLIC NOTICE Canada, Province of Quebec, District of Trois-Rivières Notice is given that the company \"La Ferme Laviolette Limitée\", lawfully incorporated by Provincial charter, will apply to the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter, in accordance with the Quebec Companies' Act, as regards the procedures to be followed and the delay set forth in the said Act.Given at Trois-Rivières, this twenty-fifth day of the month of July, one thousand nine hundred and fifty.La fermeJL a violette Limitée, Per: J.C.SAWYER, 28015 Notary & Attorney.Notice is hereby given that \"Universal Sales Company Limited\", incorporated by Letters Patent of the Province of Quebec, dated August QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 5th, 1950, Vol.82, No.31 1993 Quebec en date du 9 août 1946, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 30 juin 1950.Le Procureur de Universal Sales Company Limited, 2S021 NORMAN N.GENSER.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Allied Concrete Block Mfg.Co.Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 3 mai 1948.Avis est de plus dmné qu'à compter du premier août 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 2 août 1950.L'Assistant-procureur général, 2S050 L.DÉSILETS.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Fortierville Furniture Company\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 17 mars 1949.Avis est de plus donné qu'à compter du premier août 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le 2 août 1950.L'Assistant-procureur général, 2S050-O L.DÉSILETS.9th, 1946, will make application for leave to surrender its charter.Montreal, June 30th, 1950.NORMAN N.GENSER, Attorney for 2S021-O Universal Sales Company Limited.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Allied Concrete Block Mfg.Co.Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 3rd day of May, 1948.Notice is also given that from and after the first day of August, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 2nd day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28050-O Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Fortierville Furniture Company\", incorporated by letters patent bearing date the seventeenth day of March, 1949.Notice is also given that from and after the first day of August, 1950, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28050 Deputy Attorney General.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Héroux & Fils Ltée\" \u2014 \"Heroux & Sons Ltd.\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 3 mars 1949.Avis est de plus donné qu'à compter du premier août 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, le 2 août 1950.L'Assistant-procureur général, 28050-O L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Héroux & Fils Ltée\" \u2014 \"Héroux & Sons Ltd.\", incorporated by letters patent dated the third day of March, 1949.Notice is also given that from and after the first day of August, 1950, the said company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this second day of August, 1950.L.DÊSDLETS, 28050 Deputy Attorney General.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au Procureur général d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Ottawa Club Incorporated\", constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 juillet 1937.Avis est de plus donné qu'à compter du premier août 1950, ladite compagnie a été dissoute.Daté du bureau du Procureur général, ce 2 août 1950.L'Assistant-procureur général, 28050 L.DÉSILETS.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, Revised Statutes of Quebec, chapter 276, section 26, and subject to the liability enacted by section 27 of the said Act, the Attorney General has been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Ottawa Club Incorporated\", incorporated bv letters patent dated the 12th day of July, 1937.Notice is also given that from and after the first day of August, 1950, the said Company has been dissolved.Dated at the office of the Attorney General the 2nd day of August, 1950.L.DÉSILETS, 28050-O Deputy Attorney General. 1994 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août 1950, Tome 82, N6 81 Département des Terres et Forêts Department of Lands and Forests AVIS NOTICE Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame Officiai cadastre of the Parish of Notre-Dame du du Mont-Carmel division d'enregistrement Mont-Carmel Registration Division of Cham- de Champlain.plain.Avis est par la présente donné que les lots Notice is hereby given that lots 915-68 to 915-68 à 915-71, 915-77 à 915-80 sont annulés 915-71, 915-77 to 915-80 are cancelled in virtue en vertu de l'article 2174A du Code civil.of Article 2174A of the civil Code.Québec, le 10 juillet 1950.Quebec, July the 10,1950.Le Département des Terres et Forêts, Department of Lands and Forests, Service du Cadastre, Cadastral Branch, Le Sous-ministre, A VELA BÉDARD, 28022-o AVILA BÉDARD.28022-o Deputy Minister.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine-de-Longueuil (maintenant partie de la Ville de Greenfield Park) division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné que les lots 236-181 à 236-187, 236-254 à 236-257, 237-11, partie des lots 236-250, 236-253; les lots 238-3 à 238-6, 238-66 à 238-73, 238-76 à 238-101, 238-128 à 238-130, partie du lot 238-127 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 19 juillet 1950.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 28022-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Victoire (canton d'Arthabaska) ville de Victoriaville.Division d'enregistrement d'Arthabaska.Avis est par la présente donné que les lots 493-99 à 493-107, 493-140, à 493-142, 493-146 à 493-149, 493-152 .à 493-191, 493-190A, 493-220 à 493-244, 493-246 à 493-285, 493-290 à 493-312, 49-358, 493-366 à 493-404, 493-412, 493-413, partie des lots 493-119, 493-137, 493-143 à 493-145, 493-150, 493-151, 493-193 à 493-219, 493-245, 493-286 à 493-289, 493-313 à 493-341, 493-343 à 493-357, 493-359, 493-360, 493-365, 493-405 à 493-411, 493-414 à 493-434, sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 14 juin 1950; Le Département des Terres et Forêts, Service du cadastre, Le Sous-ministre, 28022-o AVILA BÉDARD.AVIS Cadastre officiel de la paroisse de St-Hippolyte division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné que dans le Rang I Wexford, les lots 15, 16A, 17A, 17B, 18 sont corrigés, le lot 16B est annulé et le Bloc A est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 25 juillet, 1950.Le Département des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 28022-o AVILA BÉDARD.NOTICE Officiai Cadastre of the Parish of St.Antoine de Longueuil (Now part of the town of Greenfield Park) registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots 236-181 to 236-187, 236-254 to 236-257, 237-11, part of lots 236-250, 236-253; lots 238-3 to 238-6, 238-66 to 238-73, 238-76 to 238-101, 238-128 to 238-130, part of lot 238-127 are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, July the 19th, 1950.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 28022-o Deputy Minister.NOTICE Official Cadaster of the Parish of Ste-Victoire (Township of Arthabaska) Town of Victoriaville Registration Division of Arthabaska.Notice is hereby given that lots 493-99 to 493-107, 493-140 to 493-142, 493-146 to 493-149, 493-152 to 493-191, 493-190A, 493-220 to 493-, 244, 493-246 to 493-285, 493-290 to 493-312, 493,358, 493-366 to 493-404, 493-412, 493-413-part of lots 493-119, 493-137, 493-143 to 493-145, 493-150, 493-151, 493-193 to 493-219, 493, 245, 493-386 to 493-289, 493-313 to 493-341-493-343 to 493-357, 493-359, 493-360, 493, 365, 493-405 to 493-411, 493-414, to 493-434-are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVDLA BÉDARD, 28022-o Deputy Minister.NOTICE Official Cadastre of the Parish of St.Hippolyte Registration Division of Terrebonne.Notice is hereby given that in Range I Wex ford, lots 15, 16A, 17A, 17B, 18 are corrected' lot 16B is cancelled and Block A is added in virtue of Article 2174A of the civil Code.Quebec, July the 25th, 1950.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 28022-o Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 6th, 1960, Vol.82, No.31 1995 Département du Travail AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et amendements), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par la section \"A\" du décret numéro 407 du 12 avril 1950 relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal, lui ont présenté une requête à l'effet de modifier ladite section \"A\" comme suit: Le paragraphe \"bb\" suivant est ajouté: \"bb) Boni de vie chère: Un boni de vie chère de trois ($0.03) cents l'heure doit être payé à compter de la date de publication du présent amendement aux catégories suivantes, lesquelles apparaissent au paragraphe \"b\" \"Taux minima de salaires\": Compagnon-plombier, poseur d'appareils de chauffage et mécanicien en tuyauterie Soudeur en tuyauterie Mécanicien junior Apprentis pourvu toutefois, que ledit boni de vie chère ne soit pas versé pour tout travail exécuté en plus de la semaine normale de quarante (40) heures ou aux compagnons-plombiers et soudeurs en tuyauterie dont le taux actuel de salaire est de un dollar et cinquante-huit cents ($1.58) ou plus et mécaniciens juniors dont le taux de salaire est de un dollar et quatorze cents ($1.14) ou plus.\" ' Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 5 août 1950.28051-o AVIS DE MODIFICATION L'honorable Antonio Barrette, Ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q.1941, chapitre 163 et aen-m dements), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers du bâtiment dans le district des Trois-Rivières, rendue obligatoire par le décret numéro 1658 du 19 avril 1940, lui ont présenté une requête à l'effet de modifier ledit décret et ses amendements comme suit: 1° L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article III: \"Si l'indice officiel du coût de la vie, tel qu'établi par le Bureau fédéral de la Statistique, atteint 168 points, le taux horaire de tous les salariés de la zone I assujettis à ce décret à l'exception des ajprentis, sera automatiquement augmenté de cinq ($0.05) cents; telle augmentation ne doit cc|>endant prendre effet que le premier lundi suivant la publication d'un avis à cet effet par l'une ou l'autre des parties contractantes à la convention collective servant de base au présent décret dans le journal Le Nouvelliste et le St-Muurïce Valley Chronicle.\" ¦ 2° L'article XDI est remplacé par le suivant: \"Xn.Durée du décret: Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 1er juin 1951.Il Department of Labour NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement rendered obligatory by part \"A\" of the decree number 407 of April 12, 1950, relating to the construction industry and trades in the district of Montreal, have submitted to him a request to amend the said part \"A\" as follows: The following subsection \"bb\" is added: \"bb) Cost of Living Bonus: A Cost of Living Bonus of three cents (80.03) per hour shall be paid as and from the date of publication of this amendment to the following categories listed in the preceding subsection \"6\" headed \"Minimum Rates of Wages\", namely: Journeyman in Plumbing, Heating and Pipe Work Pipe Welder Junior Mechanic Apprentices provided, however, that the said Cost of Living Bonus shall not be paid for any hours exceeding the normal working hours of forty (40) hours per weêk or to those employees whose actual hourly rate is already equal to or exceeds one dollar and fifty-eight cents ($1.58) for journeymen plumbers and pipe welders and one dollar and fourteen cents ($1.14) for junior mechanics.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 5, 1950.28051-o NOTICE OF AMENDMENT The Honourable Antonio Barrette, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), that the contracting parties to the collective labour agreement relating to the building trades in the district of Three Rivers, rendered obligatory by the decree number 1658 of April 19, 1940, have submitted to him a request to amend the said decree, and its amendments, as follows: 1.The following paragraph is added at the end of section III: \"Should the official cost of living index, as established by the Dominion Bureau of Statistics, attain 168 points the hourly rate of all employees of zone I governed by this decree, excepting apprentices, shall automatically be increased by five cents ($0.05); such increase, however, shall come into force only on the Monday following the publication of a notice to that effect by either one of the contrasing parties to the collective agreement rendered obligatory by the present decree in Le Nouvelliste and the St.Maurice Valley Chronicle.\" 2.Section XII is replaced by the following: \"XH.Duration of the decree: The present decree shall remain in force until June 1, 1951. 1996 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août 1950, Tome 82, N° 81 se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant le 1er juin de l'année 1951 ou de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au ministre du Travail.\" Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉRARD TREMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 5 août 1950.28051-o It then renews itself automatically from year to year unless one of the contracting parties notifies the other party in writing to the contrary within the period extending from the sixtieth to the thirtieth day prior to June 1st of the year 1951 or of any subsequent year.Such a notice must also be forwarded to the Minister of Labour.\" During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections which the interested parties may wish to set forth.GÉRARD TREMBLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, August 5, 1950.28051-u Département du trésor Treasurery Department Assurances Insurance Avis d'un projet de fusion d'une société Notice of a Project of Amalgamai ion de secours mutuels of a mutual benefit association Avis est par les présentes donné que la So- Notice is hereby given that the Société Mu- ciété Mutuelle de Bénéfice en Maladie Ville- tuelle de Bénéfice en Maladie Ville-Marie, a Marie, une société de secours mutuels constituée mutual benefit association incorporated in virtue en corporation conformément aux dispositions of section 66 of the Quebec Insurance Act (Chap- de l'article 66 de la Loi des assurances de Que- ter 299 R.S.1941) and registered in this Province, bec (chapitre 299 S.R.1941) et enregistrée dans will hold a special general meeting of its mem- cette Province, tiendra une assemblée générale bers on the 9th of August, 1950 at 8 o'clock spéciale de ses membres le 9 août 1950 à 8 hres p.m.at 6210 St.Vallier Street, City of Mont- p.m.à 6210 rue St-Vallier, Cité de Montréal, real, in view of considering a project of amalga- pour prendre en considération un projet de sa mation with the Fonds de Secours Mutuels des fusion avec le Fonds de Secours Mutuels des Forestiers Catholiques de la province de Québec, Forestiers Catholiques de la province de Québec, a mutual benefit society registered in this Prov- une société de secours mutuels enregistrée dans ince, having its head office in the City of Mont- cette Province, ayant son siège social dans la real, such amalgamation to be made in conform - Cité de Montréal, telle fusion devant se faire ity with the provisions of sections 265 and en conformité des dispositions des articles 265 following of the Quebec Insurance Act.et suivants de la Loi des assurances.Donné en la Cité de Montréal, ce 12ième jour Given in the City of Montreal, this 12th day de juillet 1950, conformément aux dispositions of July 1950, pursuant to the provisions of de l'article 265 de la Loi des assurances, de section 265 of the Quebec Insurance Act.Québec.Le Président, J.N.SEGUIN, J.N.SEGUIN., President.6210 rue St-Vallier, 6210, St.Vallier Street, 27987-30-2-O Montréal, P.Q.27987-30-2-O Montreal, P.Q.Examen du Barreau \u2014 Bar Examination BARREAU DU BAS SAINT-LAURENT \u2014 BAR OF THE LOWER SAINT LAWRENCE Candidat .pour l'admission a l'étude du droit Candidate fob the admission to the study of law Nom Name\tPrénom Surname\tAge\tRésidence Residence\tCollège College \t\t21\tTrois-Pistoles .\tJésus-Marie de Sillery.Rimouski, le 27 juillet 1950 \u2014 Rimouski, July 27, 1950.Le Secrétaire du Barreau du Bas Saint-Laurent, MAURICE TESSIER, 28057-31-2-o Secretary of the Bar of the Lower Saint Lawrence. QUEBEC OFFICIAL OAZETTE, Quebec, August 5th, 1950, Vol 82, No.31 1997 Greffes de Notaires Avis est par le présent donné, conformément aux dispositions du Code du Notariat, que le Conseil de la Chambre des Notaires, à sa réunion qui a été tenue à Montréal, le 14 juillet 1950, a accordé à Me Charles-Edouard Gagnon, notaire demeurant et exerçant à St-Stanislas, comté de Champlain, district judiciaire de Trois-Rivières, la transmission des minutes, répertoire et index de Me Robert Béliveau, notaire député-régistrateur à Québec.Montréal, 4 août 1950.Le Secrétaire-trésorier de la Chambre des Notaires, 28037-o ARTHUR COURTOIS.Notarial Records Notice is hereby given pursuant to the provisions of the Notarial Code, that the Council of the Board of Notaries, at its meeting held in Montreal on the 14th of July 1950, has granted to Me Charles-Edouard Gagnon, Notary residing and practising at St-Stanislas, County of Champlain, Judicial District of Three-Rivers, the transfer of the minutes, repertory and index of Me Robert Béliveau, Notary Deputy-Registrar at Quebec.Montreal, August 4th 1950.ARTHUR COURTOIS, Secretary-Treasurer of the 28037-o Board of Notaries.Liquidations, avis de Avis de dissolution de Société Dans l'affaire de David Fred Marcovitch, requérant, vs Malo Ralph Marcovitch, alias Malo R.Marken, marchand et Saul Le vine, marchand, tous deux des Cité et District de Montréal, défendeurs, et Albert Lamarre, comptable, des Cité et District de Montréal, en sa qualité de liquidateur de la Société connue sous le nom de Industrial Medical Supplies, 750 St.(îabriel, Montréal, Que., liquidateur.Avis est par les présentes donné que par jugement de la Cour Supérieure, district de Montréal, en date du 25ième jour de juillet 1950, rendu par l'Honorable Juge George S.Challies, la susdite Société a été dissoute et le soussigné, nommé liquidateur.Avis est de plus donné à tous les créanciers de produire leur réclamation dans les trente jours de la publication du présent avis.Daté à Montréal ce 1er jour d'août 1950.Le Liquidateur, ALBERT LAMARRE.Bureau de Lamarre & Inns, 10 est, rue St-Jacques, Montréal, Que.28038-o Canada, Province de Quél>ec.District de Québec, dans la Cour Supérieure, sous la Loi de Liquidation, N° 54-370.Dans l'affaire de Marcel Boivin & Compagnie Limitée, en liquidation.Avis par les Liquidateurs d'une vente d'Immeubles Avis est par les présentes donné qu'en vertu de l'article 35 de la 1/oi de Liquidation, (Ch.213, S.R.C.1927) et conformément à une résolution des inspecteurs de ladite compagnie en liquidation en date du 21 juin 1950 ratifiée par un jugementjde l'Honorable Juge Wilfrid Edge, J.C.S.en date du 23 juin 1950, MM.Georges-Henri Boulet et Edgar Ludger Boulet en leur qualité de liquidateurs de Marcel Boivin & Compagnie Limitée ont, par acte de vente reçu devant le notaire Charles Cantin, le 5 juillet 1950, sous le numéro 7081 des minutes dudit notaire, vendu à Sa Majesté le Roi du droit du Canada; représenté par la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement, certaines propriétés ci-après décrites Windings up Notices Notice of Dissolution of a Partnership In the matter of David Fred Marcovitch, plaintiff, vs Malo Ralph Marcovitch alias Malo R.Marken, merchant and Saul Levine, mer-chant, both of the City and District of Mon-real.defendants, and Albert Lamarre, accountant, of the City and District of Montreal, in his quality of Liquidator to the partnership known as Industrial Medical Supplies, 750 St-Gabriel St., Montreal, Quebec, liquidator.Notice is hereby given that, by a judgment of the Superior Court of the District of Montreal, under the date of July 25th, 1950, rendered by Honourable Justice George S.Challies, the above mentioned Partnership has been dissolved and the undersigned, appointed liquidator.Notice is moreover given to all creditors to produce their claim, within thirty days from the publication of the present notice.Dated at Montreal, this 1st day of August 1950.ALBERT LAMARRE, Loquidator.Office of Lamarre & Inns, lOSt.James St., East, Montreal, Que., 28038-o Canada, Province of Quebec, District of Quebec, in the Superior Court, under the Winding up Act No.54-370.In the matter of Marcel Boivin & Compagnie Limitée, in liquidation.Notice by the Liquidators of a Sale of Immoveables Notice is hereby given that under Section 35 of the Winding-up Act, (Ch.213, R.S.C.1927) and pursuant to a Resolution of the Inspectors of the said company in liquidation under date of June 21st 1950, ratified by a judgment of thé Honourable Wildrid Edge, J.S.C.under date of June 23rd 1950, Messrs.Georges-Henri Boulet and Edgar Ludger Boulet in their capacity of liquidators of Marcel Boivin & Compagnie Limitée have, by Deed of Sale received before notary Charles Cantin, on July 5th 1950, under number 7081 of the minutes of the said notary, sold to His Majesty the King in the rights of Canada, represented by Central Mortgage & Housing Corporation, certain properties hereinafter des- 1998 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 6 août I960, Tome 82, N° 31 comme étant situées sur la rue Languedoc pour cri bed as being situate on LanguedocIStreet for les montants indiqués en regard de chacune the amounts shown opposite the description of desdites propriétés et formant le total de.$144,- each of the said properties and making the 500.00 payable aux vendeurs es-qualité, lorsque total sum of $144,500.00 payable to the sellors ladite vente aura acquis l'effet du décret suivant in their capacity of Liquidators when the said les articles 9 et suivants du chapitre 342 des sale shall have had the effect of a Sheriff's Statuts Refondus de Québec 1941; par un autre sale in accordance with article 9 and following acte de vente reçu devant le même notaire à la of Chapter 342 of the Revised Statutes of Que-date susdite sous le numéro 7082 de ses minutes, bec 1941; by another Deed of Sale received before lesdits liquidateurs ont vendu à Sa Majesté le the same notary under date before mentioned Roi du droit du Canada, représenté par la Société under number 7082 of the minutes of the said Centrale d'Hypothèques et de Logement cer- notary, the said liquidators sold to His Majesty taines propriétés ci-après décrites comme étant the King in the rights of Canada represented by situées sur la rue Colombière pour les montants Central Mortgage & Housing Corporation cer-indiqués en regard de chacune desdites propriétés tain properties hereinafter described as situate et formant un total de $196,400.00 payé de la on Colombière Street for the amounts shown façon susdite: opposite the description of each of the said properties and making the total sum of $196,-400.00, paid in the following manner: Rue Languedoc: Lot 435 du cadastre officiel Languedoc Street: Lot 435 of the Official pour la paroisse St-Roch Nord, 410 \u2014 $8,500.00; Cadastre for the Parish of St-Roch North: 410 411 \u2014$8,500.00; 412 \u2014$8,500.00; 413 \u2014$8,-$8,500.00;411\u2014 $8,500.00; 412\u2014$8,500.00; 500.00; 414 \u2014$8,500.00; 420 \u2014$8,500.00; 434 413 \u2014 $8,500.00; 414 \u2014 $8,500.00; 420 \u2014 \u2014 $8,500.00; 435 \u2014$8,500.00; 437 \u2014$8,500.00 48,500.00; 434 \u2014 $8,500.00; 435 \u2014 $8,500.00; 440 \u2014 $8,500.00; 442 \u2014 $8,500.00; 443 \u2014 $8,- $37 \u2014 $8,500.00; 440 \u2014 $8,500.00; 442 \u2014 $8,-500.00; 444 \u2014 $8,500.00; 445 \u2014 $8,500.00; 446 500.00; 443 \u2014 $8,500.00; 444 \u2014 $8,500.00; \u2014 $8,500.00; 447 \u2014 $8,500.00; 448 \u2014 $8,500.00; 445 \u2014 $8,500.00; 446 \u2014 $8,500.00; 447 \u2014 $8,-Total: $144,500.00.500.00; 448 \u2014 $8,500.00; Toyal: $144,500.00.Rue Colombière: Lot 1064 du cadastre offi- Colombière Street : Lot 1064 of the Official ciel pour la paroisse de Charlesbourg, mainte- Cadastre for the Parish of Charlesbourg now nant quartier Limoilou, Cité de Québec: 1 \u2014 Limoilou ward, City of Quebec: 1 \u2014 $8,800.00; $8,800.00; 2 \u2014 $8,300.00; 3 \u2014 $8,300.00; 4 et 2 \u2014 $8,300.00; 3 \u2014 $8,300.00; 4 and part S.E.partie S.O.de 5 \u2014 $8,800.00; 6 et partie N.E.de of 5 \u2014 $8,800.00; 6 and part N.E.of 5 \u2014 5 \u2014$8,800.00; 7 \u2014 $8,300.00; 8 \u2014 $8,300.00; $8,800.00; 7 \u2014 $8,300.00; 8 \u2014 $8,300.00; 9 9 et partie S.O.de 10 \u2014 $8,800.00; 11 et partie and part S.E.of 10 \u2014 $8,800.00; 11 and part N.E.de 10 \u2014 $8,800.00; 12 \u2014 $8,300.00; 13 N.E.of 10 \u2014 $8,800.00; 12 \u2014 $8,300.00; 13 \u2014 \u2014 $8,300.00; 14 et partie S.O.de 15 \u2014$8,800.00.$8,300.00; 14 and part S.E.of 15 \u2014 $8,800.00; Lot 1065 du cadastre officiel pour la paroisse de Charlesbourg, maintenant quartier Limoilou, Cité de Québec: 2 \u2014 $8,300.00; 3\u2014 $8,300.00; 4 et partie S.O.de 5 \u2014 $8,800.00; 6 et partie N.E.de 5 \u2014 $8,800.00; 7 \u2014 $8,300.00; 8 \u2014 $8,300.00; 9 et partie S.O.de 10 \u2014 $8,800.00; 11 et partie N.E.de 10 \u2014 $8,800.00; 12 \u2014 $8,300.00; 13 \u2014 $8,300.00; 14 et partie S.O.de 15 \u2014 $8,800.00; Total: $196,400.00 Avis est par les présentes donné qu'afin de donner auxdites ventes l'effet du décret les liquidateurs susdits entendent suivre les formalités édictées par les articles 9 et suivants du Chapitre 342 des Statuts Refondus de Québec 1941; Avis est aussi par les présentes donné qu'en conformité des dispositions de ladite loi, une copie de chacun des deux actes de vente et le certificat des hypothèques du Registrateur de la division de Québec ont été déposés au Greffe de la Cour Supérieure du District de Québec le 19ième jour de juillet 1950, et qu'au cours des trois dernières années les immeubles plus haut décrits comme situés sur la rue Languedoc ont été la propriété respective de la Succession C.J.Lockwell, de MM.Paul et Camille Lockwell, de Marcel Boivin, de Marcel Boivin & Compagnie Limitée, de Marcel Boivin & Compagnie Limitée en liquidation et de MM.Georges-Henri et Edgar Ludger Boulet en leur qualité de liquidateurs, et qu'au cours de la même période les immeubles plus haut décrits comme situés sur la rue Colombière ont été la propriété respective de M.J.Albéric Giguère, de Marcel Boivin, de Marcel Boivin & Compagnie Limitée, de Marcel Boivin & Compagnie Limitée en liquidation et de MM.Georges-Henri et Edgar Ludger Boulet en leur qualité de liquidateurs, et toutes les personnes réclamant quelque privilège ou hypothèque sur les dits immeubles sont avisées qu'à moins Lot 1065 of the Officiai Cadastre for the Parish of Charlesbourg now Limoilou ward, City of Quebec: 2 \u2014 $8,300.00; 3 \u2014 $8,300.00; 4 and part S.E.of 5 \u2014 $8,800.00; 6 and part N.E.of 5 \u2014 $8,800.00; 7 \u2014 $8,300.00; 8 \u2014 $8,300.00; 9 and part S.E.of 10 \u2014 $8,800.00; 11 and part N.E.of 10 \u2014 $8,800.00; 12 \u2014 $8,-300.00; 13 \u2014 $8,300.00; 14 and part S.E.of 15 \u2014 $8,800.00; Total : $196,400.00.Notice is hereby given that in order to give to the said sales the effect of a Sheriff's sale the said liquidators intend to follow the formalities prescribed by article 9 and following of Chaper 342 of the Revised Statutes of Quebec 1941; .Notice is further hereby given that in conformity with the provisions of the said Act a copy of each one of the said Deeds of Sale and the certificate of hypothecs prepared by the Registrar of the District of Quebec have been lodged in the Office of the Prothonotary of the Superior Court of the District of Quebec on the 19th day of July 1950, and that during the last three years the immoveables hereinbefore described as situate on Languedoc Street have been the respective property of C.J.Lockwell estate, Messrs.Paul and Camille Lockwell, Marcel Boivin, Marcel Boivin & Compagnie Limitée, Marcel Boivin & Compagnie Limitée in liquidation and Messrs Georges Henri and Edgar Ludger Boulet in their capacity as liquidators, and during the said period the immoveables hereinbefore described as situate on Colombière Street have been the respective property of Mr.J.Alberic Giguère, Marcel Boivin, Marcel Boivin & Compagnie Limitée, Marcel Boivin & Compagnie Limitée in liquidation an Messrs.Georges Henri and Edgard Ludger Boulet in their capacity as liquidators, and all persons who claim any privilege or hypothec upon the said immoveables are hereby noti- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 6th, 1960, Vol.82, No.,31 1999 que leurs réclamations ne soient telles que le Uégistrateur est tenu, par les dispositions du Code er 15, 1948, and having its Head Office in Montreal, has established its office at 1247 Guy Street.From and after the date of this Notice, the said office shall be considered by the Company as being the Head Office of the Company.Montreal, July 26, 1950.MRS.NATHAN (JELBER, 28023-o Secretary-Treasurer.Sale \u2014 Bankruptcy Act Canada, Province of Quebec, District of Montreal.Superior Court (Sitting in Bankruptcy).In the matter of : Lucien Cardinal, Authorized Assignor.Public notice is hereby given that the immovable described as follows: An emplacement fronting on Boulevard Lafayette, at Montreal-South, known and designated as subdivision number eighty-three of original lot number one hundred and fifty-nine (159-83) on QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 6th, 1950, Vol.82, No.81 2003 (159-83) du cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine de Longueuil, avec maison portant le N° 141 du boulevard Lafayette, ainsi que le tout se trouve présentement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées au dit immeuble; Sera vendu à la porte de l'Église Paroissiale Catholique St-Géorges, à Montréal-Sud, MARDI le CINQ SEPTEMBRE 1950, à ONZE heures de l'avant-midi (heure avancéede l'Est, suivant Jugement de la Cour Supérieure du District de Montréal en matière de faillite, rendu le 19 juillet 1950, portant le No.28 des Dossiers de la dite Cour, aux enchères publiques, de manière à donner à cette vente l'effet du décret, conformément aux prescriptions de l'Article 45 de la Loi de Faillite.Conditions de vente, dix pour cent (10%) comptant, la balance sous trois jours.Pour informations et Cahier des Charges s'adresser au soussigné.Montréal, 5 août 1950.Le Svndic, ALBERT LAMARRE.Du Bureau de Lamarre & Inns, 10 est, rue St-Jacques, Montréal, 28044-31-2-O the official cadastre for the parish of St-Antoine de Longueuil \u2014 with the house bearing No.171 Boulevard Lafayette, as the whole presently subsists, with the active and passive, apparent or unapparent servitudes attached to the said immovable; Will be sold at the Catholic parochial church door of St-Georges, at Montreal-South, on TUESDAY, the FIFTH day of SEPTEMBER, 1950, at ELEVEN o'clock in the forenoon (Eastern Daylight Saving Time), according to a judgment of the Superior Court for the District of Montreal, sitting in Bankruptcy, rendered on the 19th of July, 1950, bearing No.28 of the records of the said Court, by public auction, so as to give the said sale the effect of a'Shcriff's sale, pursuant to the provisions of Section 45 of the Bankruptcy Act.Conditions of sale: ten per cent (10%) cash, the balance within three days.For information and list of charges, apply to the undersigned.Montréal, August 5, 1950.ALBERT LAMARRE, Trustee.Of the Office of Lamarre & Inns, 10 St.James street East, Montreal 28044-31-2 Vente pour taxes Sale for Taxes Province de Québec, Comté de Chambly Province of Quebec, County of Chambly Cité de Longueuil City of Longueuil Avis Public est, par les présentes donné que Public notice is hereby given that the Quebec la Commission Municipale de Québec, par un Municipal Commission by an Order date the arrêté en date du 19 juillet 1950, a ordonné au 19th of July 1950, has ordered the undersigned soussigné, conformément aux dispositions de la in conformity with the provisions of Section VII section VII de la Loi de la Commission Muni- of the Quebec Municipal Commission Act cipale de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 207) de (R.S.Q.1941, chapter 207) to sell the immovables vendre les immeubles ci-dessous désignés pour hereinafter described in payment of arrears of satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues taxes due to the City of Longueuil, with interest à la Cité de Longueuil, avec intérêts et frais, et and costs, and that consequently the said im- qu'en conséquence les dits immeubles seront movables will be sold by public auction in the vendu par encan public dans la salle du conseil à Council Hall of the City Hall of the City of l'Hôtel de ville de la Cité de Longueuil, 100 Longueuil, 100 St.Charles Street West, Lon- ouest rue St-Charlcs, Longueuil, le MERCREDI, gueuil, WEDNESDAY, the THIRTIETH day TRENTIEME jour d'AOUT 1950, à DIX of AUGUST, 1950 at TEN o'clock of the fore- hcures du matin, heure avancée de l'Est.noon (Eastern Daylight Saving time).Toutefois, seront exclus de la vente les im- However, there shall be excluded from the meubles sur lesquels les taxes devenues exigibles sale the immovables upon which taxes falling le ou avant le 1er décembre 1949 auront été due on or before the 1st of December 1949 shall payées avant le moment de la vente.have been paid before the sale.La vente des immeubles décrits dans la lière The sale of the immovables described in the section du présent avis sera faite sujette au droit first section of the present notice will be made de retrait, mais, suivant les dispositions de l'ar- subject to right of redemption, but according to tide 74 de la loi de la Commission Municipale de the provisions of section 74 of the Quebec Muni-Québec, la vente des immeubles décrits dans la cipal Commission Act, the sale of the immovables 2e section sera finale et le droit de retrait ne described in the second section will be final and pourra être exercé, tous les dits immeubles étant right of redemption can not be exercised; all des terrains vacants et des lots à bâtir d'une the said immovables being vacant lots of land évaluation municipale ne dépassant pas $1,000.00.and building lots of a municipal valuation not exceeding one thousand dollars.Première section \u2014 Immeubles sujets au droit de retrait First Section \u2014 Immovables subject to right of redemption Rôle N°\tNom des Propriétaires\tCadastre\t _\t\u2014\t\u2014\tSubdivision Roll No.\tName of Proprietors\tCadastral\t 1635 .\t\t343\t22 1636 .\t\t343\t23 8-2372.\tSuccession-Estate Suzan McVey veuve de-\t\t \twidow of Edward Quinn.\t199\t124 S-2372-A.\tSuccession-Estate Suzan McVey veuve de-\t\t \t\t198\t45 2004 f GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août 1950, Tome 82, N° 31 Deuxième Section \u2014 Immeubles non sujet aux droits de retrait Second Section \u2014 Immovables not subject to right of redemption Rôle N° Roll No.161 .162 .634 .S-190.Nom des Propriétaires Name of Proprietors Mine-Mrs.R.H.MacDonald.Agnès^Rutherford.Léo Sïmard.Napoléon Lamarre.Cadastre Cadastral 1 1 348 Subdivision 36 37 85 Description: Un emplacement connu et désigné comme étant une partie de la subdivision numéro cent quatre-vingt-treize du lot originaire numéro un (1-Pt.193) au cadastre officiel du Village do Longueuil maintenant la Cité de Longueil, mesurant quatre (4) pieds do largeur par la profondeur du dit lot, borné en front par la rue St-Charles, d'un côté par le lot no.1-194 et de l'autre côté par le résidu du lot no.1-193.Description: An emplacement known and designated as being part of subdivision number one hundred and ninety three of the original lot number one (l-l'l.193) of the official cadastre of the Village of Longueuil, measuring four (4) feet in width by the depth of said lot; bounded in front by St.Charles Street, on one side by lot number 1-194 and on the other side by the residue of lot number 1-193.S-1720.S-2530.Suburban Land Co.Succession-Estate Bernard Maguire-Edward Francis Maguire, Catherine Ellen Maguire, Mary-Ann Maguire, héritiers-heirs.345 29 à 33 inch Description: Un emplacement connu et désigné comme étant une partie de la subdivision numéro trente-neuf du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-sept (197 Pt.39) au cadastre officiel du village de Longueuil maintenant la Cité de Longueuil, mesurant cinquante (50) pieds de largeur dans les lignes Nord-Est et Sud-Ouest par une profondeur de cent vingt (120) pieds dans les lignes Nord-Ouest et Sud-Est et borné au Nord-Est par le lot N° 197-26, au Sud-Est par le lot 197-38, au Sud-Ouest par la rue Victoria et au Nord-Ouest par la moitié Nord-Ouest du dit lot.Description: An emplacement known and designated as being part of subdivision number thirty-nine of the original lot number one hundred and ninety-seven (197-Pt.39) of the official cadastre of the Village of Longueuil now tho City of Longueuil; measuring fifty (50) feet in width in tho north-east and south-west linos by one hundred and twenty (120) feet in depth in the north-west and south-east lines and bounded to the north-east by lot number 197-26, to the southeast by lot number 197-38, to tho south-west by Victoria Street and to tho north-west by the north-west half of said lot.Je certifi.ee que la liste sus-dite contient une description complète et entière des lots qui doiyent être vendus le TRENTIEME jour d'AOUT 1950, pour défaut de paiement des répartitions de taxes générales et spéciales imposées sur les dits immeubles et dues à la Cité de Longueuil.Les immeubles ci-dessus mentionés sont tous des plan et livre de renvoi officiels du village de Longueuil aujourd'hui la Cité de Longueuil, et sigués dans ladite Cité de Longueuil.Termes: argent comptant ou chèque visé.Donné en la Cité de Longueuil ce 1er jour d'août mil neuf cent cinquante.Le Secrétaire-trésorier, (Sceau) 28045-3l-2-o PAUL GAGNON.I certify that the foregoing list contains a complete and full description of the lots to be sold on the THIRTIETH-day of August, 1950.for nonpayment of apportionments on immovables of general and special taxes imposed on the said immovables and due to the City of Long-gueuil.The above mentionned immovables are all of the plan and book of reference of the Village of Longueuil, now the City of Longueuil and are situate in the City of Longueuil.Termes: cash or certified cheque.Given in the City of Longueuil, this First day of August, one thousand nine hundred and fifty.(Seal) PAUL GAGNON, 28045-31 -2-o Secretary-Treasurer.VENTES PAR SHÉRIFS SHERIFFS' SALES AVIS PUBLIC est par le présent donné que PUBLIC NOTICE, is hereby given that the les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés undermentioned LAND and TENEMENTS ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux have been seized, and will be sold at the respect-respectifs, tels que mentionnés plus bas.ive times and places mentioned below.ABITIBI Cour Supérieure Canada, /HPHE NORTHERN LI-Province de Québec, J 1 FE ASSURANCE District d'Abitibi, ) COMPANY OF CANA-N° V-1585 ' DA corps politique et incorporé ayant son siège social à London, province d'Ontario, et place d'affaires à Val d'Or district d'Abitibi, demandeur; contre WILLIAM LU-KASHUK, mineur de Bourlamaquc, district d'Abitibi, défendeur.Comme appartenant au défendeur Wiliam Lukashuk, le lot numéro sept cent soixante-trois (763) du plan et cadastre officiel pour la ville de Bourlamaque avec bâtisses y érigées circonstances et dépendances.ABITIBI Superior Court Canada, / HTHE NORTHERN LI-Province of Quebec, j -I FE ASSURANCE District of Abitibi, ) COMPANY OF CANA-No.V-1585 { DA, a body politic and corporate having its head office at London, province of Ontario, and 'a place of business at Val d'Or, district of Abitibi, plaintiff; against WILLIAM LUKASHUK, miner, of Bourlamaque, district of Abitibi, defendant.As belonging to the defendant William Lukashuk: lot number seven hundred and sixty-three (763) on the official cadastral plan for the Town of Bourlamaque, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, August 5th, 1950, Vol.82, No.31 2005 Pour être vendu à la porte de l'église St-Sauveur de Val d'Or, le NEUVIEME jour de SEPTEMBRE 1950 à DIX heures de l'avant-midi (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos, Que., le 31 juillet 1950.28024-31-2-o [Première insertion: 5 août 1950) Cour Supérieure Canada./ À DÊLARD THÊRI- Province de Québec, ) ¦**AULT, plombier, au-District d'Abitibi, j trefois de Val d'Or, dis-N° V-1421-A (trict d'Abitibi, et maintenant domicilié à Hull, district de Hull, demandeur; contre GÉRARD RICHARD, journalier de Val d'Or, district d'Abitibi, défendeur.Comme appartenant au défendeur Gérard Richard le lot numéro 34-705 du canton Bourla-maquc et du cadastre officiel de la Ville de Val d'Or, avec bâtisses dessus construites, circonstance et dépendances.Pour être vendu à la porte de l'église St-Sau-vcur de Val d'Or, le NEUVIEME (9) jour de SEPTEMBRE 1950, à ONZE (11) heures de l'avant-midi (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos, Que., le 31 juillet 1950 28025-3l-2-o [Première insertion: 5 août 1950] Canada, Province de Québec Cour de Magistrat District électoral ( FLORENT VANASSA, D'Abitibi à Val D'Or ) *- garagiste de Val d'Or, N°f>258.\"jdistrit d'Abitibi, et y 'faisant affaires sous les noms et raison sociale de Northern Tire Vulcanizing Eiirg, demandeur, Contre LIGUORI GAGNON, journalier de Val d'Or, district d'Abitibi.Une maison dans le village de Senneville construite sur le lot numéro trente cinq (35) du rang trois (3) du Canton Senneville sans titres de terrain.Pour être vendue à la porte de l'église paroissiale de Senneville le NEUVIEME jour de SEPTEMBRE 1950 à TROIS (3) heures de l'après-midi (heure avancée).Le Shérif, Bureau du Shérif, FERDINAND GERVAIS.Amos, Que., le 31 juillet 1950.28026-31-2-o [Première insertion: 5 août 1950] To be sold, at the church door of St-Sauveur de Val d'Or, on the NINTH day of SEPTEMBER, 1950, at TEN o'clock in the foreneon (Daylight Saving Time).FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, Que., July 31, 1950.28024-31-2 [First insertion: August 5, 1950] Superior Court Canada, ( A DÉLARD THÉRI- Province of Quebec, ) AULT, plumber, here-District of Abitibi, j tofore of Val d'Or, dis-No.V-1421-A [ trict of Abitibi, and now domiciled at Hull, district of Hull, plaintiff; against GÉRARD RICHARD, laborer, of Val d'Or, district of Abitibi, defendant.As belonging to the defendant Gérard Richard : The lot number 34-705 of the township Bourla-maque and on the official cadastre for the Town of Val d'Or\u2014with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.To be sold, at the church door of St-Sauveur de Val d'Or, on the NINTH (9th) day of SEPTEMBER, 1950, at ELEVEN (11) o'clock in the forenoon (Daylight Saving Time).FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, Que., July 31, 1950.28025-31-2 [First insertion: August 5, 1950] Canada, Province of Quebec Magistrate's Court Electoral District ( \"RLORENT VANAS-of Abitibi at Val D'Or ) *\u2022 SA, garage keeper of No.6258.) Val d'Or, district of ' Abitibi, and carrying on business there under the firm name and style of Northern Tire Vulcanizing Enrg., plaintiff; against LIGUORI GAGNON, laborer, of Val d'Or, district of Abitibi.A house in the village of Senneville, built on lot number thirty-five (35) of range three (3) of the township of Senneville \u2014 without title deeds to the land.To be sold at the parochial church door of Senneville on the NINTH day of SEPTEMBER, 1950, at THREE (3) o'clock in the afternoon (Daylight Saving Time).FERDINAND GERVAIS, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, Que., July 31, 1950.28026-31-2 [First insertion: August 5, 1950] - JOLIETTE Fieri Facias de Terris Cour supérieure Province de Québec, (\\TIATEUR DESRO-District de Joliette, ) v CHES, journalier, N° 9044.) de la cité et du district de \\ Montréal, demandeur, contre LOUIS DESROCHES, rentier de St-Jean de Matha, district de Joliette, partie aux présentes tant personnellement que comme chef de la communauté de biens existant entre lui et son épouse, défendeur, et ledit LOUIS DESROCHES, demandeur reconventionnel contre ledit VIA-TEUR DESROCHES, défendeur reconventionnel.\"La moitié indivise de l'immeuble ci-après décrit: une partie de terre située dans la paroisse de St-Damien de Brandon, dans le Dixième Rang du canton Brandon, désignée comme étant JOLIETTE Fieri Facias de Terris Superior Court Province of Quebec, /A/IATEUR DESRO-District of Joliette, 1 V CHES, laborer, of No.9044.\\ the city and district of ' Montreal, plaintiff; against LOUIS DESROCHES, annuitant, of St-Jean de Matha, district of Joliette, a party hereto both personnally and< as head of the community of property existing between him and his wife, defendant, and the said LOUIS DESROCHES, cross plaintiff; against the said VIATEUR DES-ROCHES, cross defendant.\"The undivided half of the immovable hereinafter described : a part of the farm situate in the parish of St-Damien de Brandon, in the Tenth range of the township Brandon, described as 2006 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août 1950, Tome 82, N° SI une partie des lots de terre numéros cent cinquante-quatre, cent cinquante-cinq et cent cinquante-six (Ptie Nos.154, 155 et 156) au cadastre de ladite paroisse de St-Damien de Brandon, mesurant sept arpents et demi de largeur sur la profondeur qu'il peut y avoir du cordon du onzième rang à aller à un gros cap de roche, jusqu'à la partie qui déverse du côté du dixième rang appartenant à Wilfrid Baril, tenant d'un côté au N° 157 appartenant à Rosario Baril et à l'autre côté au résidu du N° 154 appartenant à Maurice Desroches ci-après nommé, sans bâtisse.\" Pour être vendue à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Damien, district de Joliette, le SEIZIEME jour d'AOUT prochain, à ONZE heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du shérif, ROLAND PERRAULT.Joliette, le dix juillet 1950.27913-28-2-o [Première insertion: 15 juillet 1950] being a part of the lots of land numbers one hundred and fifty-four, one hundred and fifty-five and one hundred and fifty-six (Pt.Nos.154, 155 and 156) of the official cadastre for the said parish of St-Damien de Brandon, measuring seven arpents and one half in width by whatever depth there may be from the \"cordon\" of the eleventh range up to a big rock-head, as far as the part which inclines from the side of the tenth range, belonging to Wilfrid Baril, bounded on one side by No.157 belonging to Rosario Baril and on the other side by the residue of No.154 belonging to Maurice Desroches, hereinafter named, without buildings.\" To be sold, at the church door of the parish of Saint-Damien, district of Joliette, on the SIXTEENTH day of AUGUST, next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.ROLAND PERRAULT, Sheriff's Office, Sheriff.July tenth, 1950.27913-28-2 [First insertion: July 15, 1950] RICHELIEU Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure Province de Québec, fQLAUDE PER RICHELIEU Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court Province of Quebec, CLAUDE PERRAS, Province ecialties Company Limited .1982 Liquidation, avis de: Industrial Medical Supplies .1997 Marcel Boivin & Compagnie Limitée.1997 Nominations: Diverses.1999 Proclamation: Concernant l'établissement de la Cour de bien-être social dans les districts judiciaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Saint-François.2001 Sièoes sociaux: Barimad Holdings Limited.2002 Gelber Realty Corporation.2002 Ste Marguerite Salmon Club.2002 Vente, Loi de faillite: Cardinal, Lucien.2002 Vente pour taxes: Longueuil, cité de.2003 VENTES PAR SHÉRIFS: Abitibi : The Northern Life Assurance Company of Canada vs Lukashuk.2004 Thériault vs Richard.2005 Vanassa vs Gagnon.2005 Joliette: Desroches vs Desroches.2005 Richelieu: Perras vs Lemoine.2000 Rimouski: Ross vs Lamarre.2007 Stein et al vs Fournier.200(5 Stcin et al vs Fournier.2007 Universal Equipment Ltd.vs Halle- 2007 Saguenay: Stylecraft Leather Products Inc.1978 The Airport Garage Co.Ltd.1979 Togmaster Inc.1979 Victoria Corporation.1979 William Wright Laboratories Inc.1980 Wrapping Advertising Limited.1980 Supplementary Letters Patent: Jarry & Frère Co.Ltée.1981 Joseph Lorenzo Guay Incorporée.1981 I-.es Scies Mercier Limitée.1981 Northern Furs Limited.1981 Pinkerton Flowers Limited.1981 Victoriaville Specialties Company Limited .1982 Winding up Notices: Industrial Medical Supplies.1997 Marcel Boivin & Compagnie Limitée.1997 Appointments: Miscellaneous.1999 Proclamation : Concerning the establishing of the Social Welfare Court in the judicial districts of Montreal, Quebec, Trois-Rivières and Saint Francis.2001 Head Offices: Barimad Holdings Limited.2002 Gelber Realty Corporation.2002 Ste Marguerite Salmon Club.2002 Sale, Bankruptcy Act: Cardinal, Lucien.2002 Sale for Taxes: Longueuil, city of.2003 SHERIFFS' SALES: Abitibi : The Northern Life Assurance Company of Canada vs Lukashuk.2004 Thériault vs Richard.2005 Vanassa vs Gagnon.1 2005 Joliette: Desroches vs Desroches.2005 Richelieu: Perras vs Lemoine.2006 Rimouski: Ross vs Lamarre.2007 Stein et al vs Fournier.2006 Stein et al vs Fournier.2007 Universal Equipment Ltd.vs Halle .2007 Saguenay: Bouchard vs Pilote, Fortin vs Bradet.2009 Bouchard vs Pilote 2008 Fortin vs Bradet.2009 2008 , 2114 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 5 août I960, Tome 82, N° 81 Terrebonne: Terrebonne: Gagné vs Gagné.2010 Gagné vs Gagné.2010 Gauley vs Dupuis.2010 Gauley vs Dupuis.2010 Le Promoteur d'Industrie Limitée vs Le Promoteur d'Industrie Limitée vs Pineault.2009 Pineault.2009 * 28058-O 28058-O Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur du Roi.King's Printer."]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.