Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 mai 1944, samedi 13 (no 19)
[" No.10 f 1105 Vol.76 Gazette officielle de Quebec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, le samedi, 13 mai 1944 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice aux droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en surplus.5° L'alîonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi, à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, May 13th, 1944 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to : The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this la»st insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three lajst days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.v 1106 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 mai 1944, No 19, Vol 76 Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion: 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, jxmr les deux versions).Insertions subséquentes : 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents chacun.Feuilles volantes: SI la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième fait connaître la livraison de la Gazette pour la première insertion; le troisième indique le nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÊDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.5200\u20141-52 Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for l>oth versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: |1, per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second designates the issue of the Gazette for the first insertion ; the third indicates the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.REDEMPTI PARADIS, King's Printer.Government House.Quebec, June 27th, 1940.5200\u20141-52 Lettres patentes \"Beaver Investments Corp.\" Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du quatrième jour d'avril 1944, constituant en corporation: Ariste Brossard, avocat, Conseil en loi du Roi, Lucien Roux, avocat, Paul Lafon-taine, huissier, Roland Therien, courtier, et Francine Gravel, sténographe, fille majeure, tous des cité et district de Montréal, province de Québec, dans les buts suivants: Exercer les fonctions d'administrateurs de capitaux, conseillers en matières financières et agents de placement de capitaux, sous le nom de \"Beaver Investments Corp.\", avec un capital total de cinq mille dollars ($5,000.00), divisé en cinquante (50) actions de cent dollars ($100.-00) chacune.Le bureau principal de la compagnie sera en la cité de Montréal, dans le district de Montréal.\" Daté du bureau du procureur général, ce quatrième jour d'avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 6238-0 P.FRENETTE.Letters Patent \u2022 \"Beaver Investments Corp.\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, l>earing date the fourth day of April, 1944, incorporating: Ariste Brossard, advocate, King's Counsel, Lucien Roux, advocate, Paul Lafontaine, bailiff, Roland Therien, broker, and Francine Gravel, stenographer, spinster, all of the city and district of Montreal, Province of Quebec, for the following purposes: To carry on business as administrators of capital, advisors in financial matters and capital investment agents, under the name of \"Beaver Investments Corp.\", with a total capital stock of five thousand dollars ($5,000), divided into fifty (50) shares of one hundred dollars ($100) each.The head office of the company will be in the city of Montreal, district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1944.P.FRENETTE, 6238 Assistant Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 18th, 1944, No.19, Vol.76 1107 \"E.Sauvé Ltée\" Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du onzième jour d'avril 1944, constituant en corporation: Emery Sauvé, marchand, P.-Paul Sauvé et Jean-M.Sauvé, gérants, Roch-1).Sauvé et Demoiselle Pauline Sauvé, caissiers, tous cinq demeurant en la cité et le district de Montréal, province de Québec, dans les buts suivants: Exercer le commerce de quincaillier, soit comme grossiste, soit comme détaillant, et de toutes marchandises qui peuvent s'y rattacher, notamment de meubles de toute nature, articles de ferronnerie, quincaillerie, matériaux de constructions, peinture, vernis, huiles, vitres, outils, appareils électriques, articles de sport ou de fantaisie, ainsi que de toutes pièces ou articles qui peuvent faire l'objet d'un bazar, sous le nom de \"E.Sauvé Ltée\", avec un capital total de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents dollars ($99,900.00), divisé en mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998) actions de cinquante dollars ($50.00) chacune.Le bureau principal de la compagnie sera :\\ Montréal, dans le district de Montréal.Daté du bureau* du procureur général, ce onzième jour d'avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 0239-o P.FRENETTE.E.Sauvé Ltée\" Notice is hereby given that under Part I of the Quelx;c Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April, 1944, incorporating: Emery Sauvé, merchant, P.-Paul Sauvé and Jean-M.Sauvé, managers, Roch-D.Sauvé and Miss Pauline Sauvé, cashiers, all five residing in the city and district of Montreal, Province of Quebec, for the following purposes: To carry on business as hardware merchant, either as wholesaler or retailer, and deal in any mercliandise incidental thereto, notably in all kinds of furniture, ironware, articles, hardware, building materials, paint, varnish, oil, glass, tools, electrical apparatus, sporting goods or fancy wares, and also any pieces or articles capable of being of use in a bazar, under the name of \"E.Sauvé Ltée\", with a total capital stock of ninety-nine thousand nine hundred dollars ($09,900), divided into nineteen hundred and ninety-eight (1998) shares of fifty dollars (§50) each.The head office of the company will be at Montreal, district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April, 1944.P.FRENETTE, 6239 Assistant Deputy Attorney General.\"Hôpital Bellevue, Inc.\" Notice is given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the eleventh day of April, 1944, incorporating: Dr.Antoine Couture, physician, Madame Violette DeLisle, wife separate as to property of the said Dr.Antoine Couture, both of the.city of Quebec, Dr.Norbert Hourgault, physician, and Madame Marie Tan-guay, wife separate as to property of the said Dr.Norbert Hourgault, these two latter of Sillery, all of the district of Quebec, Province of Quebec, for the following purposes: To hospitalize the sick and see that the necessary care is given to them by competent people, and, for this purpose, to acquire or lease movables and immovables, pledge, mortgage, hypothecate, exchange or dispose of the same; To acquire in particular all assets of the hospital now in operation on Ste-Foy Road, Quebec, under the name of \"Hôpital Bellevue\".The corporate name of the company is: \"Hôpital Bellevue, Inc.\" The amount of capital stock of the company is $99,900., divided into 999 shares of one hundred dollars each, and the part of the capital stock to be issued as preferred shares is $24,900., divided into 249 shares of one hundred dollars each.The number of shareholders is limited to twenty (20).The head office of the company will be at Quebec, in the district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this eleventh day of April, 1944.P.FRENETTE, 6240 Assistant Deputy Attorney General.\"Les Pionniers et Patriotes\" \"Les Pionniers et Patriotes\" Avis est donné qu'en vertu des dispositions de Notice is given that under Part III of the la troisième partie de la Loi des compagnies de Quebec Companies' Act, letters patent have \"Hôpital Bellevue, Inc.\" Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quélwc, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quélx-c des lettres patentes, en date du onzième jour d'avril 1944, constituant en corporation: Dr Antoine Couture, médecin, Madame Violette DeLisle, épouse séparée de biens dudit Dr Antoine Couture, tous deux de la cité de Québec, Dr Norbert Bourgault, médecin, et Madame Marie Tanguay, épouse séparée de biens dudit Dr Norbert Bourgault, ces deux derniers de Sillery, tous du district de Québec, province de Québec, dans les buts suivants: Hospitaliser les malades et leur faire donner par des personnes compétentes les soins requis, et, à cette fin, acquérir ou louer tous meubles et immeubles, les nantir, hypothéquer, gager, échanger, aliéner; Acquérir notamment tout l'actif de l'Hôpital actuellement exploité sur le Chemin Ste-Foy, à Québec, sous le nom de \"Hôpital Bellevue\".Le nom corporatif de la compagnie est: \"Hôpital Bellevue, Inc.\" Le montant du capital-actions social de la compagnie est de $99,900.00, divisé en 999 actions de cent dollars chacune, et la partie du capital-actions qui sera émise comme actions privilégiées est de $24,900.00, divisée en 249 actions de cent dollars chacune.Le nombre des actionnaires est limité à vingt (20).Le bureau principal de la compagnie sera à Québec, dans le district de Québec.Daté du bureau du procureur général, ce onzième jour d'avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 6240-o P.FRENETTE. 1108 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 mai 1944, No 19, Vol.76 Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sixième jour d'avril 1944, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard Trottier, comptable, Joseph-Marie Qft-gnon, concierge, et I/mis-Philippe Pigeon, commis, tous trois de Québec, district de Quelle, province de Quélœc, dans les buts suivants: Dans le but d'aider à l'unité entre les diverses populations habitant le Canada, lour bien-être et leur avancement matériel, intellectuel et moral: Promouvoir chez ses membres et dans le public l'étude et la recherche de toutes les questions les intéressant individuellement et socialement; Promouvoir l'action qui protégera les Canadiens dans tous les domaines de l'activité, sous le nom de \"Les Pionniers et Patriotes\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de cent mille dollars ($100,000.).lje bureau principal de la corporation sera à Quelle, dans le district de Québec.Daté du bureau du procureur général, ce sixième jour d'avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 0241-o P.FRENETTE.\"Maple Leaf Peat Limited\" Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quél>ec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Quelle des lettres patentes, en date du quatrième jour d'avril 1944, constituant en corporation: Rodrigue-I;éonard DesLandes, marchand, Marthe Deschênes, sténographe, fille majeure, tous deux de Rivière-du-Loup, et John Irvine, industriel, de l'Isle Verte, tous trois de la province de Québec, dans les buts suivants: Manufacturer, produire, exporter, inqwrter, faire le commerce, mélanger, raffiner, acheter et vendre des isolants, fertilisants, engrais, produits chimiques, teintures, laine minérale, ciment, bois, laine de fer, minéraux suj>erphosphates, savon, peintures, vernis, mordants, polis teintures, huiles, acides, charbons, coke, goudron, produits et dérivés du goudron, tourbe, produits de la tourbe, mousse de mer produit d'icelle, caoutchouc, préparation chimique, articles et composés, séparément ou en combinaison et sous toutes conditions et à tous degrés de préparation et de fabrication et en faire le commerce, sous le nom de \"Maple Leaf Peat Limited\", avec un capital total de $49,900.00, divisé en 499 actions de cent dollars ($100.00) chacune.Le bureau principal de la compagnie sera à Rivière-du-Loup, dans le district de Kamouraska.Daté du bureau du procureur général, ce quatrième jour d'avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 6242-o P.FRENETTE.\"Médéric Charbonneau Limitée\" Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du douzième jour d'avril 1944, constituant en corporation : Bernard Bourdon, Conseil en loi du Roi, Henri Beaulieu et Jean Beaulieu, tous trois avocats, de la cité d'Outremont, district de Montréal, province de Québec, dans les buts suivants: Acquérir l'actif du commerce actuellement exercé par Monsieur Médéric Charbonneau, bijoutier, dans les cité et district de Montréal; l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, l>earing date the sixth day of April, 1944, to incorporate as a corporation without share capital: Gérard Trottier, accountant, Joseph-Marie Gagnon, janitor, and Louis-Philippe Pigeon, clerk, all three of Quebec, district of Quebec, Province of Quel>ec, for the following purposes: With a view to promoting unity between the various races in Canada, contributing towards their welfare and their material, intellectual and moral advancement: To promote amongst its members and the public the study of and research into all questions of interest to them individually and socially; To further work which would protect Canadians in all spheres of action, under the name of \"Les Pionniers et Patriotes\".The amount to which the immovable property which the corporation may possess is to 1*» limited, is one hundred thousand dollars ($100,000).The head office of the corporation is at Quebec, in the district of Quebec.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of April, 1944.P.FRENETTE, 0241 Assistant Deputy Attorney General.\"Maple Leaf Peat Limited\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the fourth day of April, 1944, incorporating: Rodrigue-Léonard DesLandes, merchant, Marthe Deschênes, stenographer, spinster, both of Rivière-du-Loup, and John Irvine, manufacturer, of l'Isle Verte, all three of the Province of Quebec, for the following pur|x»ses: To manufacture, produce, export, import, deal in, mix, refine, purchase and sell, insulators, fertilizers, manure, chemicals, dyes, mineral wool, cement, wood, steel wool, mineral superphosphates, soap, paint, varnish, pigments, stains, oil, acids, coal, coke, tar, tar products and derivatives, peat, peat products, sea-moss, products thereof, rubber, chemical preparations, articles and compounds, separately or combined and under any condition and in any state of preparation or manufacture and to deal therein, under the name of \"Maple Leaf Peat Limited\", with a total capital stock of $49,900., divided into 499 shares of one hundred dollars ($100) each.The head office of the company will be at Rivière-du-Loup, district of Kamouraska.Dated at the office of the Attorney General, this fourth day of April, 1944.\\J P.FRENETTE, 0242 Assistant Deputy Attorney General.\"Médéric Charbonneau Limitée\" Notice is given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twelfth day of April, 1944, incorporating: Bernard Bourdon, King's Counsel, Henri Beaulieu and Jean Beaulieu, all three advocates, of the city of Outremont, district of Montreal, Province of Quebec, for the following purposes: To acquire the assets of the business actually carried on by Mr.Médéric Charbonneau, jeweller, in the city and district of Montreal; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 1944, No.19, Vol.70 1109 Faire affaires comme marchand en gros ou en détail en toutes espèces de marchandises ou effets faisant ordinairement l'objet du commerce de bijoutier, joaillier, argentier et horloger, sous le nom de \"Médéric Charbonneau Limitée\", avec un capital total de vingt mille dollars (§20,000.-00), divisé en deux cents (200) actions de cent dollars ($100.00) chacune.Le bureau principal de la compagnie sera à Montréal, dans le district de Montréal.Daté du bureau du procureur général, ce douzième jour d'avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 6243-0 P.FRENETTE.\"Renaissance Films Inc.\" Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du sixième jour d'avril 1944, constituant en corporation: Paul Leblanc, avocat, Jeanne-Françoise Raymond, sténographe, fille majeure, tous deux de la cité d'Outremont, et Jean Filion, avocat, de la cité de Montréal, tous trois du district de Montréal, province de Québec, dans les buts suivants: Fabriquer, produire, réaliser, louer, vendre, exploiter, acheter et échanger, distribuer, projeter et répandre des films cinématographiques de tous genres et de tous systèmes, des opéras, pièces de théâtre, vaudevilles, pantomimes et spectacles, et d'une façon générale, faire tous actes relatifs à la réalisation des buts ci-dessus; Fabriquer, produire et opérer des machines, appareils de photographie et de einématogra-pliie, appareils de reproduction du son, de radio et de télévision, disques, ainsi que toutes machines et appareils de nature semblable, scènes, décors, costumes et accessoires pour la production ou la reproduction de vues animées, pièces de théâtre et opéras; Acquérir, construire, posséder, louer, céder à bail et exploiter des théâtres, des salles de vues animées et des édifices pour toutes autres formes d'amusements, et généralement exploiter des édifices et des terrains ayant pour objet l'amusement et la récréation du public, (Les pouvoirs ci-dessus n'autorisant pas les jeux rie hasard prohibés par le code criminel), sous le nom de \"Renaissance Films Inc.\", avec un capital total de cinq cent mille dollars ($500,-000.00), divisé en quatre mille (4000) actions privilégiées d'une valeur au pair de cent dollars ($100.00) chacune, non cumulatives et non participantes, et dix mille (10,000) actions communes d'une valeur au pair de dix dollars ($10.00) chacune.Le bureau principal de la compagnie sera dans les cité et district de Montréal.Daté du bureau du procureur général, ce sixième jour d'avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 0244-o P.FRENETTE.To carry on business as wholesale and retail merchant of all kinds of merchandise or wares usual to the jewellery business, jewellers, silversmiths and watch-makers, under the name of \"Médéric Charbonneau Limitée\", with a total capital stock of twenty thousand dollars ($20,-000), divided into two* hundred (200) shares of one hundred dollars ($100) each.The head office of the company will be at Montreal, in the district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twelfth day of April, 1944.P.FRENETTE, 6243 Assistant Deputy Attorney General.\"Renaissance Films Inc.\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the sixth day of April, 1944, incorporating: Paul Leblanc, advocate, Jeanne-Françoise Raymond, stenographer, spinster, both of the city of Outre-mont, and Jean Filion, advocate, of the city of Montreal, all three of the district of Montreal, Province of Quebec, for the following purposes: To manufacture, produce, realize, lease, sell, operate, purchase and exchange, distribute, show and propagate cinematographical films of every kind and every system, operas, plays, vaudeville pantomime and performances, and in a general manner, to do anything connected with carrying out of the above purposes; To manufacture, produce and operate machines, photographic and cinematographic apparatus, sound reproducing machines, radio and television apparatus, records, and also any machines and apparatus of similar nature, scenes, scenery, costumes and accessories for the production or reproduction of moving pictures, plays anil operas; To acquire, build, own, lease, give on lease and operate theatres, moving picture halls and buildings of every kind for any other form of amusement, and, generally, to operate buildings and lots of land for the purpose of public amusement and recreation; (the above powers do not authorize games of chance prohibited by the Criminal Code), under the name of \"Renaissance Films Inc.\", with a total capital stock of five hundred thousand dollars ($500,000), divided into four thousand (4000) preferred shares of a par value of one hundred dollars ($100) each, non-cumulative and non-participating, and ten thousand (10,000) common shares of a par value of ten dollars ($10) each.The head office of the company will be in the city and district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this sixth day of April, 1944.P.FRENETTE, 6244 Assistant Deputy Attorney General.Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent \"Anglo-Canadian Bond & Share Corporation\" Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres \"Anglo-Canadian Bond & Share Corporation\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the first day of May, 1944, were issued by the Lieutenant-Governor 1110 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 mai l$U, No 19, Vol.76 patentes supplémentaires en date du premier mai 1944, à la compagnie \"Anglo-Canadian Rond & Share Corporation\", ratifiant son règlement spécial \"A\" diminuant le capital-actions acquitté de la compagnie de la somme d'un million de dollars ($1,000,000) à la somme de cinq cent mille dollars ($500,000).Daté du bureau du procureur général, ce premier mai 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 6245 P.FRENETTE.\"Crashing, Ross Limited\" Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires en date du vingt-quatre avril 1944, changeant le nom de la compagnie \"A.G.Cushing, Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du douze juin 1926, sous le nom de \"A.G.Cushing, Limited\", en celui de \"Cushing, Ross Limited\".Daté du bureau du procureur général, ce vingt-quatre avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 6246 P.FRENETTE.\"Industries du Lac du Cerf Ltée\" Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Qiiétac des lettres patentes supplémentaires, en date du vingt-deuxième jour d'avril 1944, changeant le nom de la compagnie \"Martel Limitée\", constituée en corporation par lettres patentes en date du vingt-huitième jour de juillet 1942, sous le nom de \"Martel Limitée\", en celui de: \"Industries du Lac du Cerf Ltée\", et changeant l'endroit du bureau principal de la compagnie de Saint-Jérôme à Lic-du-Cerf.Daté du bureau du procureur général, ce vingt-deuxième jour d'avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 6247-o P.FRENETTE.Action en séparation de biens Canada, Province de Québec, District de Montréal, Cour Supérieure, N° 226633.Lucienne Durocher, épouse commune en biens de J.Hervé Marleau, employé de la compagnie des Tramways de Montréal, tous deux ties cité et district «le Montréal, demanderesse; vs ledit J.Hervé Marleau, des mêmes lieux, défendeur.La demanderesse a poursuivi le défendeur en séparation de biens.Montréal, 9 mai, 1944.Le Procureur de lu demanderesse, 6263-o F.EUGÈNE THERRIEN.Avis divers Avis est donné que, par arrêté ministériel en date «lu 2 mai 1944, lé changement de nom du \"Syndicat des Ouvriers du Caoutchouc de Granby\" en celui de \"Syndicat National du Caoutchouc «le Granby Inc.\" a été autorisé, et of the Province of Quebec, to the company \"Anglo-Canadian Rond & Share Corporation\", ratifying its Special By-Law \"A\" reducing the paid-up share capital of the company from the sum of one million dollars ($1,000,000.00) to the sum of five hundred thousand dollars ($500,-000.00).Dated at the office of the Attorney General, this first day of May, 1944.P.FRENETTE, 0245-o Assistant Deputy Attorney General.fKJ \"Cushing, Ross Limited\" Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent, bearing date the twenty-fourth day of April, 1944, were issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, changing the name of the company \"A.G.Cushing, Limited\", incorporated by letters patent bearing date the twelfth day of June, 1926, under the name of \"A.G.Cushing, Limited\", to that of: \"Cushing, Ross Limited\".Dated at the office of the Attorney General) this twenty-fourth day of April, 1944.P.FRENETTE, 6246-o Assistant Deputy Attorney General.\"Industries du Lac du Cerf Ltée\" Notice is given that un«ler Part I of the Quebec Companies' Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-second day of April, 1944, changing the name of the company \"Martel Limitée\", incorporated by letters patent bearing date the twenty-eighth day of July, 1942, under the name of \"Martel Limitée\", to that of: \"Industries du Lac du Cerf Ltée\", an«l changing the location of its head office from St-Jérôme to Lac-du-Cerf.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-second day of April, 1944.P.FRENETTE, 6247 Assistant Deputy Attorney General.Action for separation as to property Canada, Province of Quebec, District of Montreal, Superior Court, No.226633.Lucienne Durocher, wife common as to property of J.Hervé Marleau, employee of the Montreal Tramways Company, both of the City and District of Montreal, plaintiff; vs the said J.Hervé Marleau, of the same place, defendant.The plaintiff has taken an action for separation as to property against the defendant.Montreal, May 9th, 1944.F.EUGÈNE THERRIEN, 6283 Attorney for Plaintiff.Miscellaneous Notices Notice is given that, by Order in Council dated May 2nd, 1944, the change of name of \"Syndicat des Ouvriers du Caoutchouc de Granby\" to that of \"Syndicat National du Caoutchouc de Granby Inc.\" has been authorized, and such, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 1944, No.19, Vol.76 1111 ce, conformément uux diipofitioni «le l'article 7 «le la Loi «les syndicats professionnels.Donné au bureau «lu Secrétaire «le la Province, le 4 mai 1944.Le Sous-secrétaire «le la Province, 8300-4 JEAN BRUCHESI.Copie d'une résolution adoptée par la Commission des Liqueurs de Quelle, le 4 mai, 1944.Vil le rapport des analystes de la Commission des Loueurs de Québec à l'effet que la formule de Elixih Becrinol, Vitamine B.I Casgrain & Charbonneau, 445, rue St-Laurent, Montréal, P.Q.a été modifiée et corrigée, et que cette formule telle que corrigée n'est plus une liqueur alcoo-lique a laquelle la loi des liqueurs alcooliques s'applique; Il est résolu que la résolution «le la Commission des Liqueurs de Quélœc, en date du 14 mars 1944, soit et est rescindée, et «ni'avis en soit publié dans la Gazette Officielle de Québec.Ije Secrétaire, 8263-0 J.-E.COULIN.La formation «l'une société, sous le nom de \"L'Union des Institutrices du Diocèse de Rimouski\", pour l'étude, la «léfense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de la profession, a été autorisée par le Secrétaire «le la Province le 3 mai 1944.\\jc stège social «le la société précitée est situé à Himouski, dans le district de Rimouski.I.e Sous-secrétaire de la Province, 6368-0 JEAN BRUCHESI.La formation «l'une société, sous le nom «le \"Syndicat National «les Chauffeurs «le Taxis d'Arvnla\", pour l'étude, la défense et le développement «les intérêts économiques, sociaux t moraux de la profession, a été autorisée par le Secrétaire «le la Province le 21 avril 1944.Le siège social «lu syndicat précité est situé à Arvida, clans le «listrict de Chicoutimi.Le Sous-secrétaire «le la Province, 6354-0 JEAN BRUCHESI.I^a formation «l'une société, BOUS le nom «le \"Association «les Employés de Roessel «le Drummondville\", pour l'étude, la «léfense et le développement «les intérêts économiques, sociaux et moraux «le la profession, a été autorisée par le Secrétaire «le la province le 4 mai 1944.Le siège social de l'association précitée est situé au Centre Ouvrier, Ville St-Joseph, Drummondville, dans le district d'Arthabaska.Le Sous-secrétaire «le la Province, 6888-0 JEAN BRUCHESI.Sherbrooke Street Realty Corporation \"Règlement Spécial \"D\" Un règlement pour augmenter le nombre des directeurs.Attendu qu'il est jugé nécessaire «l'augmenter le nombre des directeurs de neuf à dix et «l'amender en conséquence les règlements de la compagnie: in conformity with the provisions of section 7 of the Professional Syndicates' Act.Given at the office of the Provincial Secretary, May 4th, 1944.JEAN BRUCHESI, 0250 Under Secretary of the Province.Copy of a resolution adopted by the Quebec Liquor Commission on May 4th, 1944.Seeing that the report of the analysts of the Quetec Liquor Commission, establishing that the formula of Elixir Becrinol, Vitamine B.I Casgrain & Charbonneau, 445 St-Laurent Street, Montreal, P.Que.has been amended and corrected, and that such formula, as corrected, is no longer an alcoholic liquor to which the Alcoholic Liquor Act may apply; It is resolved that the resolution of the Quebec Liquor Commission, bearing e and is repealed and that notice thereof lie published in the Quebec Official Gazette.J.E.COULIN, 0252 Secretary.The formation of an association, under the name of \"L'Union des Institutrices du Diocèse de Rimouski\" for the study, defence and promotion «>f the economic, social and moral interests of the profession, has been authorized by the Provincial Secretary on May 3rd, 1944.The principal place of business of the said association is at Rimouski, in the district of Rimouski.JEAN BRUCHESI, 0253 Under Secretary of the Province.The formation of an association, under the name «>f \"Syndicat National des Chauffeurs de Taxis d'Arvida\" for the study, defence ami promotion of the economic, social and moral interests of the profession, has been authorised by the Provincial Secretary, on April 21st, 1944.The principal place of business of the said association is at Arvi«la, in the «listrict of Chicoutimi.JEAN BRUCHESI, 6254 Under Secretary of the Province.The formation of an association, under the name of \"Association des Employés de Roessel «le Drummondville\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of the profession, has been authorized by the Provincial Secretary on May 4th, 1944.The principal place of business of the said association is at \"Centre Ouvrier\", Town of St.Joseph, Drummondville, in the district of Arthabaska.JEAN BRUCHESI, 6258 Under Secretary of the Province.Sherbrooke Street Realty Corporation \"Special By-Law \"D\" A By-Law to increase the number of Directors.Whereas it is expetlient to increase the number of Directors from nine to ten an«l to amend the By-laws of the Company accordingly: 1112 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 mai 1944, No 19, Vol.76 En conséquence qu'il soit et il est, par les présentes, décrété ce qui suit: 1.lie nombre des directeurs de la compagnie est, par les présentes, augmenté de neuf à dix.2.Les directeurs peuvent, (mais ne sont pas obligés) en aucun temps avant l'assemblée annuelle des actionnaires de la compagnie qui suit la date de la confirmation de ce règlement par les actionnaires, élire parmi les actionnaires qualifiés de la compagnie un directeur additionnel pour compléter le conseil d'administration de dix directeurs.3.Le règlement II de la compagnie intitulé Directeurs tel qu'amendé par le règlement XXIII, est, par les présentes, amendé de nouveau en retranchant le mot \"neuf\" 00 il apparaît dans le premier paragraphe dudit règlement et en y substituant en conséquence le mot \"dix\".\" Certifié vraie copie du règlement spécial \"D\" de la compagnie Sherbrooke Street Realty Corporation dûment décrété par les directeurs de ladite compagnie ;\\ une assemblée tenue le 24 mars 1944 et approuvé par le vote d'au moins les deux tiers en valeur des actions représentée par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale des actionnaires de ladite compagnie dûment convoquée et tenue le 21 avril 1944 dans le but de considérer ledit règlement.(Sceau] ]jg secrétaire, (5202 C.E.GREARSON.La formation d'une société, sous le nom de \"Association Catholique des Institutrices Rurales du District N° 24\", pour l'étude, la défense et le développement (les intérêts économiques, sociaux et moraux de la profession, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 20 avril 1944.Le siège social de l'association précitée est situé à Saint-Tite, dans le district des Trois-Rivières.Le Sous-secrétaire de la Province, 6266-0 JEAN BRUCHESI.\"Imperial Theatre Limited\" Extrait des minutes de la troisième assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie \"Imperial Theatre Limited\" tenue au bureau de la compagnie United Amusement Corporation Limited, 5887 avenue Monkland, Montréal, jeudi, le 20 avril 1944, à 10 heures du matin.Il a été proposé, secondé et unanimement résolu: Que l'amendement au règlement 19 des règlements généraux de la compagnie soit ratifié comme suit: \"A moins qu'il en soit déterminé autrement, le nombre des directeurs sera de huit, dont cinq formeront quorum.\" (Sceau] Certifié extrait conforme.Le secrétaire, 6267 W.H.MANNARD.La formation d'une société, sous le nom de \"La Fédération Nationale des Travailleurs de l'Aluminium Inc.\", jwur l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de la profession, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 3 mai 1944.Le siège social de la fédération précitée est situé à Shawinigan Falls, dans le district des Trois-Rivières.Le Sous-secrétaire de la Province, 6268-o JEAN BRUCHfiSI.Wherefore be it and it is hereby enacted as follows: 1.The number of the Directors of the Company is hereby increased from nine to ten.2.The Directors may (but need not) at any time prior to the Annual Meeting of the Shareholders of the Company next following the date of the confirmation of this By-law by the Shareholders, elect from amongst the qualified Shareholders of the Company an additional Director to complete the full board of ten directors.3.By-law II of the Company entitled Directors as amended by By-law XXIII is hereby further amended by deleting the word \"nine\" where it appears in the first paragraph of said By-law and substituting therefore the word \"ten\".\" Certified to be a true copy of Special By-law \"D\" of Sherbrooke Street Realty Corporation duly enacted by the Directors of said Company at a meeting held on March 24th, 1944, and approved by the vote of at least two-thirds in value of the shares represented by the Shareholders present at a Special General Meeting of the Shareholders of said Company duly called and held on April 21st, 1944, for the purpose of considering said By-law.(SeulI C.E.GREARSON, 6202-o Secretary.The formation of an association, under the name of \"Association Catholique des Institutrices Rurales du District N° 24\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of the profession, has been authorised by the Provincial Secretary, on April 20th, 1944.The principal place of business of the said association is at Sainte-Tite, in the district of Trois-Rivières.JEAN BRUCHESI, 6266 Under Secretary of the Province.\"Imperial Theatre Limited\" Extract from the minutes of the third annual general meeting of shareholders of \"Im|>erial Theatre Limited\" held in the office of United Amusement Corporation Limited, 5887 Monk-land Avenue, Montreal, on Thursday 20th April, 1944, at 10.00 o'clock a.m.It was moved, seconded and unanimously resolved: That the amendment to By-Law 19 of the general by-laws of the Company be ratified as follows: \"Unless otherwise determined, the number of Directors shall be eight of whom five shall form a quorum.\" (Seal] Certified a true extract.W.H.MANNARD, 0207-o Secretary.The formation of an association, under the name of \"La Fédération Nationale des Travailleurs de l'Aluminium Inc.\" for the study, defence and promotion of the economic, social and moral interests of the profession, has been authorized by the Provincial Secretary on May 3rd, 1944.The principal place of business of the said association is at Shawinigan Falls, in the district of Trois-Rivières.JEAN BRUCHESI, 6268 Under Secretary of the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 1944, No.19, Vol.70 1113 La formation «l'une société, sous le nom de \"L'Association Catholique des Institutrices Rurales du District N° 40\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de la profession, a été autorisée DAT le Secrétaire de la Province le 28 avril 1944.* Le siège social de l'association précitée est situé a Nicolet (Ville), dans le district de Ni-colet.Le Sous-secrétaire de la Province, 0269-o JEAN BRUCHESI.La formation d'une société, sous le nom de \"Le Conseil Régional Saguenay Lac St-Jean des Syndicats Nationaux des Métiers de la Construction\", pour l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de la profession, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 4 mai 1944.Le siège social de la société précitée est situé à Jonquière, dans le «listrict de Chicoutimi.Le Sous-secrétaire «le la Province, 0270-o , JEAN BRUCHESI.\\jx formation «l'une s«>ciété, lOUf le nom de \"L'Association Professionnelle «les Policiers «le la Province «le Québec\"\u2014\"Quebec Professional Policemen Association\", pour l'étude, la défense et le développement des Intérêts économiques, sociaux et moraux de la profession, a été autorisée par le Secrétaire de la Province le 10 mai 1944.Le siège social de l'association précitée est situé a Montréal, dans le district «le Montréal.IjC Sous-secrétaire de la Province, 6876-0 JEAN BRUCHESI.Avis est donné que, par arrêté ministériel en date du 9 mai 1944, les règlements 1, 2 et 3 «le \"Le Domaine Lauren tien, Inc.\", tels qu'adoptés à l'assemblée tenue le 11 avril 1944, ont été approuvés, et ce, conformément aux dispositions de l'article 225 «le la Loi des compagnies de Québec.Daté «lu bureau du Secrétaire «le la Province le onzième jour de mai 1944.Le Sous-secrétaire «le la Province, 0277-o JEAN BRUCHESI.\"Lue Immeubles Vauquelin Inc.\" \"Vauquelin Real Estate Inc.\" Extrait du procès-verbal d'une assemblée générale «lu Bureau de Direction «le Les Immeubles Vauquelin Inc., tenue à Québec, le 5 mai 1944: \"Sur motion dûment proposée et secondée, il est unanimement résolu que le nombre de directeurs de la Compagnie soit augmenté de cinq à six et que le règlement N° 8 «le la Compagnie soit annulé et remplacé par le suivant : \"Le Bureau de Direction se composera de six directeurs.\" Québec, ce 8 mai 1944.Le secrétaire, 0278-o (Signé) A.-ÈMILE BEAU VAIS, C.A.Avis est/ «lonné que, par arrêté ministériel, en date du'9 mai 1944, le changement de nom du \"Syndicat des Employés de la Canada Paper Co.\" en celui de \"Syndicat National des Travailleurs de la Pulpe et du Papier de Windsor Mills, Inc.\" a -été autorisé, et ce, conformément The formation of an association, under the name of \"L'Association Catholique des Institutrices Rurales du District Nû 40\" for* tli«> stuecting the Hospital Tax on Meals.24 An Act to amend the Workmen's Compensa- tion Act.25 An Act respecting a change of the Chief Place of the Judicial District of Gaspé and of the office of the Registration Division of Gaspé.26 An Act respecting the municipalities of the west part of the township of Romieu, Ste.Anne-«les-Monts, and St.Maxime-du-Mont-Louis.27 An Act to change the territorial division of Gaspé Peninsula.28 An Act respecting the loans «>f the School Boards of Montreal.107 An Act respecting the title to a certain property situated in the district of Montreal.113 An Act to amend the charter of the city of Shawinigan Falls.114 An Act to incorporate \"Associate*! Gospel Churches in the Province of Quebec\" as an ecclesiastical corporation in the Province of Quebec.117 An Act to confer certain powers on the corporation of the parish of St.Colomb de Sillery.123 An Act to confer certain powers on the Compagnie d'assurance mutuelle contre le feu du comté de Nicolet.125 An Act to incorporate the Town of Forestville.130 An Act respecting the Estate of the late Sir Robert Gillespie Reid.132 An Act resecting the Société d'Entreprise du Canada.134 An Act to amend the charter of the city of Verdun.130 An Act to amend the charter of the city of Hull.139 An Act to confirm the extinguishment of certain restrictions, servitudes and charges, and to amend the charter of the town of Mount Royal.140 An Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit Peter Marshall Laing to the practice of the legal profession.142 An Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit George Robert Beet-.horn Whitehead to the practice of the profession of advocate. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 18th, 1944, No.19, Vol.76 111Ô 143 Loi ratifiant une résolution de la Corporation du village de Tadoussac, et une résolution des Commissaires d'écoles de la municipalité de Sainte-Croix de Tadoussac, fixant les sommes payables comme taxes, pour toutes fins municipales et scolaires, par la Canada Steamship Lines Limited.La sanction royale est prononcée sur ces bills par le greffier du Conseil législatif, comme suit: \"Au nom de Sa Majesté, l'honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.\" 6249-0 Bureau-Chef Province de Québec, District de Terrebonne.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie Habitant Industries Limited (Industries de l'Habitant Limitée), constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec en date du 21ième jour de mars 1944, et ayant son bureau principal dans le village de Val David, a établi son siège social à Val David, Québec.A compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Val David, Québec, ce 28ième jour d'avril dix-neuf cent quarante-quatre.[Sceau] I^e secrétaire, 6261 LÉO DUFRESNE.Chartes\u2014Abandon de Avis est par les présentes donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au procureur général et au ministre des affaires municipales, de l'industrie et du commerce, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Anglo-Canadian Securities Corporation\", constituée en corporation par lettres patentes en date du dix juin 1931.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un mars 1944, ladite compagnie sera dissoute.Daté du bureau du procureur général, le trente et un mars 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au procureur général et au ministre des affaires municipales, de l'industrie et du commerce, d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Fundy, Limited\", constituée en corjwration par lettres patentes en date du vingt-sept mars 1928.Avis est de plus donné, qu'à compter du vingt-neuf avril 1944, ladite compagnie sera dissoute.Daté du bureau du procureur général, le dix-neuf avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE.143 Ac Act to ratify a resolution of the corporation of the village of Tadoussac and a resolution of The school commissioners for the municipality of Ste.Croix de Tadoussac, fixing the sums payable as taxes, for all municipal and school purposes, by the Canada Steamship Lines Limited.To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Legislative Council, in the following words: \"In His Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor assents to these bills.\" 6249-0 Chief-Office Province of Quebec, District of Terrebonne.Notice is hereby given that Habitant Industries Limited (Industries de l'Habitant Limitée), a body corporate, incorporated by Letters Patent of the Province of Quebec, dated the 21st day of March, 1944, and having its head office in the Village of Val David, has established its head office at Val David, Quebec.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Val David, Quebec, this 28th day of April, Nineteen hundred and forty four.(Seal) LEO DUFRESNE, (5261-o Secretary.Charters\u2014Surrender of Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, article 26, Chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by article 27 of the said Act, the Attorney General and the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce have been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Anglo-Canadian Securities Corporation\", incorporated by letters patent dated the tenth day of June, 1931.Notice is also given that from and after the thirty-first day of March, 1944, the said Company shall be dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of March, 1944.P.FRENETTE, Assistant Deputy Attorney General.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, article 26, Chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by article 27 of the said Act, the Attorney General and the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce have l^een pleased to accept the surrender oi the cliarter of the company \"Fundy, Limited\", incorporated by letters patent dated the twenty-seventh day of March, 1928.Notice is also given that from and after the twenty-ninth day of April, 1944, the said Company shall be dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of April, 1944.P.FRENETTE, Assistant Deputy Attorney General. 1116 GAZETTE OFFICIELLE DE QIÊBEC, Québec, 18 mai 1944, No 19, Vol 76 Avis est par les présente! donné qu'en vertu de la première partie de la I/>i des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.K.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée pur l'article 27 de ladite loi, il a plu au procureur général et au ministre des affaires municipales, de l'industrie et du commerce d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Kilgour, Hamilton & Company Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du vingt-sept juin 1928.Avis est de plus donné qu'à compter du trente et un mars 1944, ladite compagnie sera dissoute.Daté du bureau du procureur général, le trente et un mars 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, P.FRENETTE.Avis est, par les présentes, donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, article 26, chapitre 276, S.R.Q., 1941, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Loi, il a plu au procureur général et au ministre des affaires municipales, de l'industrie et du commerce d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie \"Taxis Limited\", constituée en corporation par lettres patentes en date du dix-neuf décembre 1933.Avis est de plus donné, qu'à compter du vingt-neuf avril 1944, ladite compagnie sera dissoute.Daté du bureau du procureur général, le dix-neuf avril 1944.L'Assistant-procureur général suppléant, 6251 P.FRENETTE.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, article 26, Chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by article 27 of the said Act, the Attorney General and the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce have been pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Kilgour, Hamilton & Company Limited\", incorporated by letters patent dated the twenty-seventh day of June, 1928.Notice is also given that from and after the thirty-first day of March, 1944, the said Company shall be dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this thirty-first day of March, 1944.P.FRENETTE, Assistant Deputy Attorney General, I v \u2014 , Notice is hereby given that under Part I ol the Quebec Companies' Act, article 26, Chapter 276, R.S.Q., 1941, and subject to the liability enacted by article 27 of the said Act, the Attorney General and the Minister of Municipal Affairs, Trade and Commerce have l)een pleased to accept the surrender of the charter of the company \"Taxis Limited\", incorporated by letters patent dated the nineteenth day of December, 1933.Notice is also given that from and after the twenty-ninth day of April, 1944, the said Company shall be dissolved.Dated at the office of the Attorney General, this nineteenth day of April, 1944.P.FRENETTE, 6251-0 Assistant Deputy Attorney General.Département de l'Agriculture Avis est par le présent donné qu'une société coopérative agricole a été constituée dans le comté de Rouville, en vertu de la loi des sociétés coopératives agricoles (S.R.1941* c- 120), sous le nom de \".Société Coopérative Agricole de Conserves de Rougemont\" et que son principal siège d'affaires est à Rougemont, comté de Rouville.Le ministre autorise la formation de cette société.Québec, ce huitième jour de mai 1944.Le sous-ministre de l'Agriculture, 0204-o ADRIEN MORIN.Department of Agriculture Notice is hereby given that a cooperative agricultural association has been formed in the County of Rouville, under the Coo|>erative Agricultural Associations Act (R.S.1941, chap.120), under the name of \"Société Coopérative Agricole de Conserves de Rougemont\" and that its principal place of business is at Rougemont, county of Rouville.The Minister authorizes the formation of the said association.Quebec, this eighth day of May, 1944.ADRIEN MORIN, 0204 Deputy Minister of Agriculture.Département de l'Instruction publique N° 188-44 Québec, le 2 mai 1944.Demande est faite d'annexer la municipalité scolaire de la ville de Racine, comté de Chicou-timi, à la municipalité scolaire d'Arvida, dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction Publique, 6232-18-2-0 VICTOR DORÉ.N° 311-44 Québec, le 2 mai 1944.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Georges, dans le comté de Beauce, les lots suivants du cadastre officiel de Aubert-Gallion : Department of Education No.188-44 Quebec, May 2nd, 1944.Application is made to annex the school municipality of the town of Racine, county of Chicou-timi, to the school municipality of Arvida, in the same county.VICTOR DORÉ, 6232-18-2 Superintendent of Education.No.311-44 Quebec, May 2nd, 1944.Application is made to detach from the school municipality of St-Georges, in the County of Beauce, the following lots of the official cadastre for Aubert-Gallion : s QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 1944, No.19, Vol.76 1117 579, 582, 584, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 600, 605, 607, 611 et 612 et de les annexer à la municipalité scolaire d'Aubert-Gallion, même comté.Le Surintendant de l'Instruction Publique, 6233-18-2-0 VICTOR DORÉ.N° 1015-38 Québec, le 2 mai 1944.Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de St-Paul-L'Ermite dans le comté de l'Assomption, les lots suivants du cadastre officiel de Notre-Dame-de-L'Assomp-tion-de-Repentigny, Nos 76, 80, 81, 82 143 a 149 inclusivement et le lot 152, et de les annexer à la municipalité scolaire de Repentigny dans le même comté.Le Surintendant de l'Instruction Publique, 0234-18-2-o VICTOR DORÉ.N° 378-44 Québec, le 2 mai 1944.Demande est faite d'ériger une municipalité scolaire distincte, sous le nom de St-Simon-les-Mines, comté de Beauce, qui comprendra le territoire suivant: 1.\u2014Les lots portant les numéros de 400 inclusivement à 413 inclusivement; les numéros 415, 417, 419, 424; de 431 inclusivement à 434 inclusivement; enfin, de 430 inslusivement à 439 inclusivement, qui seront détachés de la municipalité scolaire de Notre-Dame-de-la-Pro-vidence, comté de Beauce; 2.\u2014Les lots portant les numéros de 396 inclusivement à 405 inclusivement; les numéros 414, 416, 418; les numéros de 420 inclusivement à 423 inclusivement; les numéros de 425 inclusivement à 430 inclusivement; les numéros de 563 inclusivement à 819 inclusivement, qui seront détachés de la municipalité scolaire de St-François, comté de Beauce.3.\u2014Les lots portant les numéros 859 inclusivement à 864-G inclusivement, de 871-A à 871-H qui seront détachés de la municipalité scolaire de Aubert-Gallion, comté de Beauce; 4.\u2014Les lots portant les numéros 869, 869-A, 870, qui seront détachés de la municipalité scolaire de Saint-Benjamin, comté de Dorchester; Le Surintendant de L'Instruction Publique, 6235-18-2-0 VICTOR DORÉ.Département des Terres & Forêts AVIS Cadastre Officiel du Canton de Laval (Division d'Enregistrement de Saguenay) Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 116, 126 et 136, les lots 14a, 146, 15a, 156, 16a, 166, 17a, 176, 18a, 186, 18c, 19 à 34, tous du rang IV; les lots 11 à 34 du rang V; les lots 32 et 33 du rang VI et le Bloc \"C\", sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Les lots 10a, 106, lia, 116, 12a, 126, 13a et 136 du rang IV, sont corrigés en vertu de l'article 2174 du Code civil.Les lots 1 à 19, 20a, et 206 du rang VIII; 1 à 7, 8a, 86, 9 à 15 du rang IX; les lots la, 16, le, ld, 2a, 26, 3a, 36, 4a, 46, 4c, 5a, 56, 5c, 5d, 579, 582, 584, 587, 588, 589, 591, 595, 590, 600, 605, 607, OU and 612 and to annex the same to the school municipality of Aubert Gallion, in the same county.VICTOR DORÉ, 6233-18-2 Superintendent of Education.No.1015-38 Quebec, May 2nd, 1944.Application is made to detach from the school municipality of St-Paul-L'Ermite, in the county of l'Assomption, the following lots of the official cadastre of Notre-Dame-de-L'Assom-tion-de-Repentigny, Nos.76, 80, 81, 82, 143 to 149 inclusively and lot 152, and to annex them to the school municipality of Repentigny in the same county.VICTOR DORÉ, 0234-18-2 Superintendent of Education.No.378-44 Quebec, May 2nd, 1944.Application is made to erect a separate school municipality, under the name of St-Simon-les-Mines, county of Beauce, which shall comprise the following territory: 1.\u2014The lots bearing the numbers from 406 inclusively to 413 inclusively; numbers 415, 417, 419, 424; from 431 inclusively to 434 inclusively; finally, from 436 inclusively to 439 inclusively, which shall be detached from the school municipality of Notre-Dame-de-la-Providence, county of Beauce; 2.\u2014The lots bearing the numbers from 396 inclusively to 405 inclusively; numbers 414, 416, 418; the numbers from 420 inclusively to 423 inclusively; the numbers from 425 inclusively to 423 inclusively; the numbers from 425 inclusively to 430 inclusively; the numbers from 563 inclusively to 819 inclusively, to be detached from the school municipality of St-François, county of Beauce; 3.\u2014The lots bearing the numbers 859 inclusively to 864-G inclusively, from 871-A to 871-H to be detached from the school municipality of Aubert-Gallion, county of Beauce; 4.\u2014The lots bearing numbers 869, 869-A, 870, to be detached from the school municipality of Saint-Benjamin, county of Dorchester.VICTOR DORÉ, 6235-18-2 Superintendent of Education.Department of Lands & Forests NOTICE Official Cadastre of the Township of Laval (Registration Division of Saguenay) Notice is hereby given that part of lots 116, 126 and 136, lots 14a, 146, 15a, 156, 16a, 166, 17a, 176, 18a, 186, 18c, 19 to 34, all in range IV; lots 11 to 34 in range V; lots 32 and 33 in range VI and Block \"C\" are cancelled in virtue of Article 2174A of the civil Code.Lots 10a, 106, 11a, 116, 12a, 126, 13a and 136 in range IV are corrected in virtue of Article 2174 of the civil Code.Lots 1 to 19, 20a, 206 in range VIII; 1 to 7, 8a, 86, 9 to 15 in range IX; lots la, 16, lc, ld, 2a, 26, 3a, 36, 4a, 46, 4c, 5a, 56, 5c, 5d, 6a, 66, 1118 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 mai 19U, No 19, Vol.76 iia, lib, 7 à 12, 13a et 136 du rung X; les lots 1 à 21,22a, 226,23a, 236, 24a, 246, 25 à 28 du rang XI ; les lots 1 a H), 17a, 176, 18 à 37, 38a, 386, 38c, 39a, 396, 39c, 40a, 406, 40c, 41a, 416, 41c, 42a, 426, 43a, 436, 44a, 446, 45a, 456, les lots A, B, C, 1), E| F de la Réserve, tous du rang XII;, les lots la, 16, 2a 15 du rang XIII, les lots 1 à 13 du rang XIV; les lots 1 a 4, 5a, 56, 0 à 9, 10a, 106, 11 il 25 du rang XV sont ajoutés en vertu de l'article 2174 du ('ode civil.Québec, le 8 mai 1944.Ministère des Terres et Forêts, Service du Cadastre, Le Sous-ministre, 0274-o A VILA BEDARD.7 to 12, 13a and 136 in range X; lots 1 to 21, 22a, 226, 23a, 236, 24a, 246, 25 to 28 in range XI; lots 1 to 10, 17a, 176, 18 to 37, 38a, 386, 38c, 39a, 396, 39c, 40a, 406, 40c, 41a, 416, 41c, 42a, 426, 43a, 436, 44a, 446, 45a, 456, lots A, B, C, D, E, F of the Reserve, all in range XII; lots la, 16, 2 to 15 in range XIII; lots 1 to 13 in range XIV; lots 1 to 4, 5a, 56, 0 to 9, 10a, 106, 11 to 25 in range XV are added in virtue of Article 2174 of the civil Code.Quebec, May the 8th, 1944.Department of Lands and Forests, Cadastral Branch, AVILA BÉDARD, 0274-o Deputy Minister.Liquidation\u2014avis de ,er seven hundred fifty-three (753-257 and 258) on the official plan and book of reference of the town of Lachine, without buildings, as the whole now is presently with all the rights and servitudes thereto belonging, without any exception or reserve with the right to use the adjacent lanes to the said emplacement.\" The immoveables described in paragraph \"B\" shall be sold \"En Bloc\" following a judgment rendered on May 2 1944.A deposit of $1200.00 concerning the immoveable designated in paragraph \"A\" and a deposit of $25.00 concerning the immoveable designated in paragraph \"B\" shall be made by any bidder in order that his bid and offer be received as to the said immoveables.The above described immoveables shall be offered at public auction and adjudged to the highest and last bidder on the TWENTIETH day of JUNE 1944 at TEX THIRTY o'clock in the forenoon, sitting the Court, in the Court room No.31 of the Court House in Montreal, or in any other room the Honourable Judge may designate, subject to the charges, clauses and conditions contained in the list of charges deposited in the office of the prothonotary of the said Court; and any opposition to annul, to secure charges, or to withdraw, to be made to the said licitation must be filed in the office of the prothonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and any opposition for payment must be filed within six days after the adjudication ; and failing the parties to file such oppositions within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.Montreal, April 27th, 1944.SYLVESTRE and PELLETIER, 0256-19-2-o Attorneys for Plaintiff.Ventes pour taxes municipales Sales for Municipal Taxes Province de Québec\u2014District de Chicoutimi Province of Quebec.\u2014District of Chicoutimi VILLE DE BAGOTVILLE TOWN OF BAGOTVILLE Avis public est, par les présentes donné, que la Public notice is hereby given that the Quebec Commission municipale de Québec, par un arrêté Municipal Commission by an Order dated the en date du deux mai 1944, a ordonné au soussigné, second of May, 1944, hasordered the undersigned, conformément aux dispositions de l'article 54 de la pursuant to the provisions of section 54 of the Loi de la Commission municipale de Quél>ec Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q.1941, (S.R.Q.1941, chapitre 207) de vendre les immeu- chapter 207) to sell the immovables herein- bles ci-dessous désignés, pour satisfaire au paie- under designated for payment of taxes due the ment des arrérages de taxes dues â la corporation Corporation of the town of Bagotville, with de la ville de Bagotville, avec intérêt et frais, et interest and costs, and that, consequently, the qu'en conséquence les dits immeubles seront said immovables will be sold by public auction, in vendus par encan public, dans la salle du conseil, the Council Room at the Town Hall at Bagot- à l'Hôtel de ville, à Bagotville, le TRENTE ville, on the THIRTIETH of MAY, 1944, at MAI 1944, à DIX heures de l'avant-midi.TEN o'clock in the forenoon.Toutefois, seront exclus de la vente les immeu- However, there shall be excluded from the bles sur lesquels tous les versements échus des sale those immovables upon which all payments taxes municipales consolidées et toutes les taxes due for consolidated municipal taxes and ail non-municipales non consolidées, moins celles des consolidated municipal taxes, less those of the 2 1122 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 18 mai 1944, No 19, Vol.76 années 1943 et 1944, auront été payées avant le moment de la vente.La vente des immeubles décrits dans la première section du présent avis sera faite sujette au droit de retrait.Celle de l'immeuble décrit dans la deuxième section sera définitive et sans droit de retrait, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi de la Commission municipale de Québec, ledit immeuble étant un lot à bâtir d'une évaluation municipale ne dépassant pas mille dollars.PREMIÈRE SECTION IMMEUBLES SUJETS AU DItOIT DE HETHAIT 1.Eudore Boivin.\u2014Un terrain formant partie ren-trale du lot numéro 73, mesurant 02 pieds de front sur environ 98 pieds de profondeur, plus ou moins, borné en front, vers le sud, par la rue Gravel ; en profondeur, vers le nord, pur le petit bras de la rivière à Mars; d'un «¦ôté, vers l'ouest, par le terrain de Joseph Bélanger ou représentants ou par une ligne parallèle au côté est de la rue St-Jean et distante de 60 pieds de ce côté de ladite rue St-Jean; de l'autre côté, vers l'est, au résidu dudit lot 73 appartenant à Herménégilde Bélanger ou représentants.2.Patrick Boivin.\u2014Un terrain mesurant environ 115 pieds de front sur une profondeur, pour une partie, de 80 pieds et, pour une autre partie, de KO pieds, formé: a) d'un terrain mesurant 50 pieds de front sur une profondeur d'environ 80 pieds, formant partie du lot numéro 318, borné en front, au sud, au chemin public actuel ou rue St-Picrre; en arrière, au nord, au terrain appartenant actuellement à Gustave Martel ou représentants; d'un côté, à l'ouest, au terrain appartenant audit (îustave Martel ou représentants et de l'autre côté, à l'est, au terrain ci-après décrit.b) d'un terrain mesurant f>0 pieds de front sur le chemin public actuel, sur une profondeur de SU pieds, formant partie du lot numéro 318 et partie du lot numéro 145.borné en front, au sud, au chemin public actuel ou rue St-Piorre; en arrière, au nord, au terrain appartenant aux représentants de Benjamin Maltais; d'un autre côté, à l'ouest, au terrain ci-dessus décrit et do l'autre côté, au sud, au terrain appartenant aux représentants de Bcnjumin Maltais.3.Surcession Etienne (,'oulombe.\u2014Los lots numéros 150, 162, 163, 184 et 165.4.Lu Fabrique de Bagot ville.\u2014Un terrain mesurant 60 pieds de front sur une profondeur, de l'ouest à l'est, de 75 pieds, formant partie des lots numéros 201 et 205, borné en front, à l'ouest, à la rue Albert; on arrière, à l'est, ainsi que des côtés nord et sud, au résidu desdits lots appartenant il l'Oeuvre et Fabrique de la paroisse de Suint-Alphonse.5.Edgar Pilote.\u2014Un terrain comprenant : a) Ixî lot numéro 200-J et cette partie du lot numéro 201-E bornée vers le nord-est au lot numéro 201-C, vers le sud-ouest, à la rue Albert, vers le nord-ouest au lot numéro 200-J et vers le sud-est au résidu dudit lot numéro 201-E appartenant aux représentants de Godfrey Ellef8en.b) La partie du lot numéro 2S4 bornée vers le nord-est à la rue Albert, vers le sud-ouest au lot numéro 285 et vers le sud-est et le nord-ouest au prolongement des lignes sud-est et nord-ouest du terrain ci-dessus décrit, tel terrain, en face, de même largeur, mais du côté opposé de ladite rue Albert ayant approximativement une largeur de 60 pieds, plus ou moins par le tout.c) Le lot numéro 201-C.d) Le lot numéro 200-K.(i.Succession Alfred Perron.\u2014a) Le lot numéro 190.b) Le lot numéro 203.c) Un terrain mesurant environ 60 pieds de largeur, du nord au sud, sur 100 pieds de profondeur environ, de l'est à l'ouest, le tout plus ou moins, formant partie des lots numéros 113 et 114, compris dans les bornes suivantes: vers l'est par la rue de la Station, vers le sud, partie par le terrain de M M.Médéric et Charles Tremblay, et partie par celui de Thomas Villeneuve, fils de Louis, vers l'ouest partie par le terrain d'Arthur Perron et partie par celui de Joseph Normand ou représentants.DEUXIÈME SECTION years 1943 and 1944, shall have been paid before the time of the sale.The sale of the immovables described in the first section of the present notice shall be made subject to right of redemption.Tluit of the immovable described in the second section shaU be final and without right of redemption, pursuant to the provisions of section 74 of the Quebec Municipal Commission Act, the said immovable being a building lot of a municipal valuation not exceeding one thousand dollars.FIRST SECTION IMMOVABLES SUBJECT TO KIGHT OF REDEMPTION 1.Eudore Boivin.\u2014A lot of land forming the central part of lot number 73, measuring 62 feet in front by about !>5 feet in depth, more or less, bounded in front, on the South by (jravel street: on the depth, on the North, by the small arm of \"rivière à Mars\"; on one side, on the West, by the land of Joseph Bélanuer or representatives, or by a line parallel to the East side of St-Jean street, and 50 feet distant on said side of said St-Jean street; on the other side, on the East, by the residue of said lot 73 l>elonging to Herménégilde Bélanger or representatives.2.Patrick Boiyin.\u2014A lot of land measuring a hunt.115 feet in front by a depth, for one part, of HO feet, and, for another part, of NO feet, composed of: a) A lot of land measuring* 50 feet in front by a depth of about SO feet, forming part of lot number 318, bounded in front, on the South by the present public road or St-Pierre street: in rear, on the North, by the land presently belonging to (îustave Martel or representatives; on one side, on the West, by the land belonging tO said (îustave Gravel or representatives and on the other side, on the East, by the land hereinafter described.b) A lot of land measuring 00 feet in front on the present public road, by a depth of NO feet, forming part of lot number 318 and part of lot numlier 145, bounded in front, on the South, by the present public road or St-Pierre street, in rear, on the North, by the land belonging to the representatives of Benjamin Maltais; on one side, on the West, by the land hereinabove described and on the other side, on the South, by the land .belonging to the representatives of Benjamin Maltais.3.Estate of Etienne Coulombe.\u2014Lots numlxrs 150, 162, 163.164 and 165.4.\"La Fabrique de Bagotville\".-A lot of land measuring 60 feet in front by a depth, from West to East, of 75 feet, forming part of lots numbers 20-1 and 205, bounded in front, on the West by Albert street; in rear on the East and also on the North and South sides, by the residue of said lots belonging to \"L'Oeuvre et Fabrique de la paroisse do Saint-Alphonse\".5.Edgar Pilote.\u2014A lot of land, comprising: a) Lot number 200-J and that part of lot number 201-E bounded on the Northeast by lot number 201-C, on the Southwest by Albert street, on the Northwest by lot number 200-J and on the Southeast by the residue of said lot number 201-E, belonging to the representatives of Godfrey Ellefsen.b) That part of lot number 284 bounded on the Northeast by Albert street, on the Southwest by lot numlier 285, and on the Southeast and the Northwest, by the prolongation of the Southeast and Northwest lines of the lot of land hereinal>ove described, such lot of land facing, on same width but on the opposite side of the said Albert street, measuring approximately a width of 66 feet, more or less, by the whole.c) Lot number 201-C.d) Lot number 200-K.6.Estate of Alfred Perron.\u2014a) Lot number 190.b) Lot number 203.c) A lot of land measuring about 66 feet in width, from North to South, by about 160 feet in depth from East to West, the whole more or less, forming part of lots numbers 113 and 114, and comprised between the following boundaries: on the East by \"de la Station\" street, on the South, partly by the land of Messrs.Médéric and Charles Tremblay, and partly by that of Thomas Villeneuve, son of Louis, on the West, partly by the land of Arthur Perron and partly by that of Joseph Normand or representatives.SECOND SECTION IMMEUBLE NON SUJET AU DROIT DE RETRAIT IMMOVABLE NOT SUBJECT TO RIGHT OF REDEMPTION 7.Pierre Itiverin.\u2014Un terrain mesurant environ 28 7.Pierre Itiverin.\u2014A lot of land measuring about pieds de front sur environ 198 pieds de profondeur, 28 feet in front by about 198 feet in depth, forming the formant la partie sud du lot numéro 218, borné en.South part of lot number 218, bounded in front, on the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 1944, No.19, Vol.76 1123 front, vers l'ouest, par la rue Albert; en arrière, vers l'est, par le terrain de Joseph C.Lévcsque ou représentants; d'un cOt*, vers le nord, par le résidu du même lot numéro 218 appartenant aux représentants d'Elzéar Minier, et de l'autre côté, vers le sud, par le terrain d'Alphonse Fortin.Avec réserve que les 4 pieds de largeur du côté nord du terrain susdécrit sur 80 pieds de longueur depuis la rue Albert seront utilisés â perpétuité avec une lisière de terrain de même largeur fournie et à prendre sur le côté sud du terrain appartenant' aux représentants dudit Elzéar Minier, pour un chemin mitoyen de S pieds de largeur qui existera à perpétuité entre la propriété de ce dernier et celle ci-dessus décrite; ce chemin pour être entretenu en commun par les intéressés lorsqu'ils en feront usage, et chacun d'eux ou leurs représentants auront le droit de construire toutes bâtisses sur leur propriété respective en bordure de ce chemin,d'y mettre portes et fenêtres et de laisser dépasser de pas plus do 2 pieds le toit de ces bâtisses au dessus dudit chemin.Tous les lots ou parties de lots ci-dessus désignés sont du cadastre officiel du village de Bagotville et seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, s'il y en a, et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes pouvant les affecter.Les versements non échus des taxes municipales consolidées sont à la charge de l'acquéreur.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.Donné à Bagotville, ce 3iéme jour de mai 1944.(5212-18 -2-0 1a: secrétaire-trésorier, JOS.EUG.TREMBLAY West by Albert street ; in rear, on the East, by the land of Joseph t'y.Ixtvosque or representatives; on one side, on the North by the residue of said lot number 218 belonging to the representatives of Elzéar Minier, and on the other side, on the South, l>y the land of Alphonse Fortin.Subject to the reserve that, the 4 feet in width on the North side of the land hereinabove described, by 80 feet in length from Albert street, will l>e used, in tierpetuity with a strip of land of same width supplied »y and to l>e taken on the South side of the land belonging to the representatives of said Elzéar Minier, for a party (mitoyen) roud of 8 feet in width which shall subsist in perpetuity between the property of the latter and the one hereinabove described: said road to lx> maintained in common by the interested parties when they use the same, and each of them or their representatives shall have the right to erect any buildings on their respective properties, bordering the said road, to equip same with doors and windows, and to allow the roof of such buildings to project, not more than 2 feet, over the said road.All the lots or parts of lots hereinabove designated are from the official cadastre for the Village of Bagotville and will be sold with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, if any, and with all active and passive, apparent and unapparent servitudes capable of affecting the same.The unmatured payments of the consolidated municipal taxes will be charged to the purchaser.The adjudication price of each of said immovables will be payable immediately.Given at Bagotville, this 3rd dav of May.1944.JOS.EUG.TREMBLAY, 6212 -18 2 Secretary-Treasurer.Province de Québec, District de Chicoutimi.Province of Quebec, District of Chicoutimi.Municipalité du Ca.vto.v Begin Municipality of the Township Begin Avis public est, par les présentes, donné (pue la Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du cinq mai 1944, a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 207), de vendre les immeubles ci-dessous désignés, pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues :\\ la corporation municipale du canton Begin, avec intérêt et frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public, dans la salle «lu conseil du canton Bégin, à canton Begin, le SEPT JUIN 1944, à ONZE heures de Pavant-midi.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels tous les versements échus des taxes municipales consolidées et toutes les taxes municipales non consolidées de l'année 1943 et des années antérieures, auront été payés avant le moment de la vente.1.Henri Dufour.\u2014I>e lot 2, rang 2.2.Joseph Néron.\u2014Le lot 8, rang 2.3.Ludger Desbiens.\u2014Le lot 27, rang 1.4.Alphonse Perron.\u2014La demie nord du lot 28, rang 1.5.Ulysse Tremblay\u2014Partie du lot 33-B, rang 2, mesurant environ 100 pieds de largeur sur 100 pieds de profondeur, borné au nord et à l'ouest, par le lot 33, rang 2, au sud, par le lot 33-A, rang 2, et â l'est par le chemin public.f».Edmond Truchon.\u2014Le lot 33, rang 4.7.Gérard Boily.\u2014I.e lot 47, rang 3.* 8.Gérard Boily.\u2014Le lot 48, rang 3.0.Charles Blackburn.\u2014Le lot 34, rang 5.10.Adjutor Duchesne.\u2014I*e lot 4.'», rang 5.11.Adjutor Duchesne.\u2014Le lot 4(i, rang 5.12.Joseph Gagnon.\u2014Partie du lot 41-A, rang 4, mesurant 4 arpents carrés, environ, borné au nord par le lot 41, rang 5, à l'ouest par le lot 42, rang 4, au sud par le lot 41, rang 3, et à l'est par le lot .39, rang 4.Tous ces lots et parties de lots sont connus et désignés aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton Bégin et seront vendus avec bâtisses dessus construites Public notice is hereby given, that the Quebec Municipal Commission, by an order dated the fifth of May, 1944, has ordered the undersigned, pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q.1941, chapter 207), to sell the immovables hereinafter designated, in payment of arrears of taxes due the municipal corporation of the Township Begin, with interest and costs, and that consequently, the said immovables will be sold by public auction, in the council hall of the Township Begin, on the SEVENTH day of JUNE 1944, at ELEVEN o'clock in the forenoon.However, there shall be excluded from the sale the immovables whereon all payments due for consolidated municipal taxes and all non-consolidated municipal taxes for the year 1943 and previous years, shall have been paid before the sale.1.Henri Dufour.\u2014Lot 2, Range 2.2.Joseph Néron.\u2014Lot 8, Range 2.3.Ludger Desbicns.\u2014Lot 27, Range 1.4.Alphonse Perron.\u2014The North half of lot 28, Range 1.5.Ulysse Tremblay.\u2014Part of lot 33-B, Range 2, measuring about 100 feet in width by 100 feet in depth, bounded on the North and West by lot 33, Range 2, on the South by lot 33-A, Range 2, and on the East by the public road.0.Edmond Truchon.\u2014Lot 33, Range 4.7.Gérard Boily.\u2014I*ot 47, Range 3.8.Gérard Boily.\u2014I^jt 48, Range 3.9.Charles Blackburn.\u2014Lot 34, Range ô.10.Adjutor Duchesne.\u2014Lot 45, Range 5.11.Adjutor Duchesne.\u2014Lot 40, Range 5.12.Joseph Gagnon.\u2014Part of lot 41-A, Range 4, measuring about 4 square arpents, bounded on the North by let 41, Range 5, on the West by lot 42, Range 4, on the South by lot 41, Range 3, and on the East by lot 39, Range 4.All the said lots and parts of lots are known and designated on the official cadastral plan and in the book of reference for the Township Begin and will be sold 1124 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 mai 19M, No 19, Vol.70 circonstances et déixmdances, s'il y en a, et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes attachées auxdits immeubles.Les versements non échus oes taxes municipales consolidées sont à la charge de l'acquéreur.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.La vente sera en outre sujette au droit de retrait et aux autres dispositions de la Loi de la Commission municipale de Québec.Donné à Canton Bégin, ce huitième jour de mai 1944.lie secrétaire-trésorier, «259-19-2-0 ROMÉO LËVESQUE.VILLE DE QUÉBEC-OUEST Avis public est, par les présentes, donné que La Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du 10 mai 1944, a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de La Commission municipale de Québec (S.R.Q.1941, chap.207), de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la ville de Québec-Ouest et à la municipalité scolaire de la ville de Québec-Ouest, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public au deuxième étage de l'hôtel de ville, en la ville de Québec-Ouest, MERCREDI, le SEPTIÈME jour de JUIN 1944, â DIX heures de l'avant-midi.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes devenues exigibles le ou avant le 1er juillet 1943 auront été payées avant le moment de la vente.La vente de l'immeuble décrit dans la première section du présent avis sera faite sujette au droit de retrait.Celle des immeubles décrits dans la deuxième section sera définitive et sans droit de retrait conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi de La Commission municipale de Québec, lesdits immeubles étant tous des terrains vagues et lots à bâtir d'une évaluation municipale ne dépassant pas §1,000.00 (mille dollars).PREMIÈRE SECTION immeuble sujet au droit de retrait Nom et subdivision: 1.Napoléon Roy\u2014299.La sulxiivision ci-dessus est du lot originaire numéro 2431.La subdivision ci-dessus décrite au numéro 1 est avec bâtisses, circonstances et dépendances.DEUXIÈME SECTION immeubles non sujets au droit de retrait Suivant les dispositions de l'article 74 de la Loi de La Commission municipale de Québec, l'adjudication des immeubles ci-dessous désignés est définitive et le retrait ne peut être exercé, lesdits immeubles étant tous des terrains vagues et lots à bâtir d'une évaluation municipale ne dépassant pas mille dollars.2.Frontenac Realty Company, Limited\u201482 3.Frontenac Realty Company, Limited\u2014158 4.Frontenac Realty Company, Limited\u2014234 5.Frontenac Realty Company, Limited\u2014310 G.Frontenac Realty Company, Limited\u2014354 7.Frontenac Realty Company, Limit-d\u2014300 S.Frontenac Realty Company, Limite!\u2014392 1).Frontenac Realty Company, Limited-»-442 10.Frontenac Realty Company, Limited\u2014443 11.Frontenac Realty Company, Limited\u2014468 12.Frontenac Realty Company, Limited\u2014493 13.Mme J.P.Boutet\u2014494 14.Frontenac Realty Company, Limited \u2014 518 with buildings thereon erected, circumstances and dependencies, if any, and with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes attached to the said immovables.The payments not yet due for municipal consolidated taxes will be charged to the purchaser.The purchase price of each of the said immovables will be payable immediately.The sale shall, moreover, be subject to right of redemption and to the other provisions of the Quebec Municipal Commission Act.Given at the Township Begin, this eighth day of May, 1944.ROMÉO LÉVESQUE, 6259-19-2 Secretary-Treasurer.TOWN OF QUEBEC-WEST Public notice is hereby given, that the Quebec Municipal Commission, by an Order dated May 10th, 1944, has ordered the undersigned, pursuant to the provisions of section 54 of the Quebec Municipal Commission Act (R.S.Q.1941, chapter 207) to sell the immovables hereinunder designated for payment of taxes due to the Town of Quebec-West and to the school municipality of the Town of Quebec-West, with interest and costs, and that consequently, the said immovables will be sold by public auction, in the second story of the Town-Hall, in the Town of Quebec-West, on WEDNESDAY, the SEVENTH day of JUNE, 1944, at TEN o'clock in the forenoon.However, there shall be excluded from the sale those immovables upon which the taxes due on or before July 1st, 1943, shall have l>een paid before the time of the sale.The sale of the immovable descrilx>d in the first section of the present notice will be made subject to right of redemption.That of the immovables descrilwvl in the second section will be final and without right of redemption, pursuant to the provisions of section 74 of the Quebec Municipal Commission Act, the said immovables being vacant lands and building lots of a municipal valuation not exceeding $1000.(one thousand dollars).FIRST SECTION oi mov able subject to right of redemption Name and subdivision: I.Napoléon Roy\u2014299.The above subdivision is of original lot number 2431.The sulxiivision hereinalxjve described in nuinlx>r 1 is with buildings, circumstances and dependencies.SECOND SECTION immovables not subject to right of redemption Pursuant to the provisions of section 74 of the Quebec Municipal Commission Act, the adjudication of the immovables hereinbelow designated is final and cannot be subject to right of redemption, the said immovables being vacant lands and building lots of a municipal valuation not exceeding one thousand dollars.2.* Frontenac Realty Company, Limited\u201482 3.Frontenac Realty Company, Limited\u2014158 4.Frontenac Realty Company, Limited\u2014234 5.Frontenac Realty Company, Limited\u2014310 6.Frontenac Realty Company, Limited\u2014354 7.Frontenac Realty Company, Limited\u2014360 8.Frontenac Realty Company, Limited\u2014392 9.Frontenac Realty Company, Limited\u2014442 10.Frontenac Realty Company, Limited\u2014443 II.Frontenac Realty Company, Limited\u2014468 12.Frontenac Realty Company, Limited\u2014493 13.Mrs.J.P.Boutet\u2014494 14.Frontenac Realty Company, Limited\u2014518 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 1944, No.19, Vol.76 1125 15.Frontenac Realty Company, Limited\u2014519 1(1.Frontenac Realty ('ompany, Limited\u2014544 17.Frontenac Realty Company, Limited\u2014509 IK.Frontenac Realty Company.Limited\u2014594 19.Frontenac Realty Company, Limited\u2014595 A distraire une largeur de 15 pieds par une longueur de 850 pieds appartenant a The .Shawinigau Water & Power Company.20.Frontenac Realty Company, Limited\u2014020 A distraire une largeur de 50 pieds sur une longueur de 800 pieds appartenant a The Shawinigau Water & Power Ohnpany.21.Frontenac Realty Company, Limited\u2014645 A distraire une largeur de 15 pieds sur une longueur «le 880 pieds appartenant a The Shawinigau Water & Power ( 'ompany.22.Frontenac Realty Company, Limited\u2014 670 28.Frontenac Realty Company, Limited\u2014671 24.Frontenac Realty Company, Limited\u2014696 25.Frontenac Realty Company, Limited\u2014721 26.Frontenac Realty Company, Limited\u2014746 27.Frontenac Realty Company, Limited\u2014747 28.Frontenac Realty Company, Limited\u2014774 29.Frontenac Realty Company, Limited\u2014775 30.Frontenac Realty Company, Limited\u2014801 31.Frontenac Realty Company, Limited\u2014825 Les trente subdivisions ci-dessus sont toutes du lot originaire numéro 2439.32.Frontenac Realty Company, Limited\u201463 38.Frontenac Realty Company, Limited\u2014114 34.Frontenac Realty Company, Limited\u2014165 35.Frontenac Realty Company, Limited\u2014216 36.Frontenac Realty ( 'ompany, Limited\u2014246 37.Frontenac Realty Company, Limited\u2014254 38.Frontenac Realty Company, Limited\u2014280 39.Frontenac Realty ( 'ompany.Limited\u2014305 40.Frontenac Realty Company.Limited\u2014306 41.Frontenac Realty Company, Limited\u2014331 42.Mme J.P.Houtet\u2014332 43.Frontenac Realty Company, Limited\u2014356 44.Frontenac Realty Company, Limited\u2014357 45.Frontenac Realty ( 'ompany, Limited\u2014382 40.Frontenac Realty Company, Limited\u2014407 47.Frontenac Realty Company.Limited\u2014432 A distraire une largeur de 50 pieds sur une longueur de 350 pieds appartenant à The Shawinigau Water A Power ( 'ompany.48.Frontenac Realty Company.Limited\u2014457 A distraire une largeur de 15 pieds sur une longueur de 350 pieds appartenant à The Shawinigau Water & Power Company.49.Frontenac Realty ( 'ompany, Limited\u2014475 A distraire une largeur de 50 piods sur une longueur de 193 pieds appartenant à The Shawinigau Water & Power Company.50.Frontenac Realty Company, Limited\u2014492 A distraire une largeur de 7Vj pieds sur une longueur de 217 pieds appartenant a The Shawinigan Water & Power Company.51.Frontenac Realty Company, Limited\u201449.H 52.Frontenac Realty Company, Limited\u2014518 53.Frontenac Realty Company, Limited\u2014543 54.Frontenac Realty Company, Limited\u2014508 55.Frontenac Realty Company, Limited\u2014593 56.Frontenac Realty Company, Limited\u2014594 57.Frontenac Realty Company, Limited\u2014618 58.Frontenac Realty Company, Limited\u2014619 59.Frontenac Realty Company, Limited\u2014642 60.Frontenac Realty Company, Limited\u2014664 61.Frontenac Realty Company, Limited\u2014665 62.Frontenac Realty Company, Limited\u2014686 63.Frontenac Realty Company, Limited\u2014687 Les trente-deux subdivisions ci-dessus sont toutes du lot originaire numéro 2436.64.Van Dyke Land Co.Reg'd\u2014894 La subdivision ci-dessus est du lot originaire numéro 2431.65.Nor-Mount Realty Company, Limited- 19 66.Nor-Mount Realty Company, Limited - 46 67.Nor-Mount Realty Company, Limited- 73 68.Nor-Mount Realty Company, Limited-100 69.Nor-Mount Realty Company, Limited-127 70.Nor-Mount Realty Company, Limited-154 71.Nor-Mount Realty Company, Limited-181 72.Nor-Mount Realty Company, Limited-193 73.Nor-Mount Realty Company, Limited-199 74.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014200 75.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014218 76.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014245 77.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014272 78.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014299 79.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014326 80.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014353 81.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014380 15.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014519 16.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014544 17.Frontenac Realty Company, Limited 56!) 18.Frontenac RealtyCompany, Limited \u2014594 19.Krontenac Realty Company.Limited -595 To Ik> deducted a width of 15 feet by a length of 350 feet, !>clonging to the Shawinigan Water & Power ( 'ompany.20.Frontenac Realty Company, Limited\u2014620 To Im> deducted a width of 50 feet by a length of 350 feet belonu'inii to the Shawinigan Water & Power Company.21.Frontenac Realty Company, Limited\u2014645 To Ih* deducted, a width of 15 feet by a length of 350 feet iH'longing to the Shawinigan Water & Power Company, 22.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014670 23.Frontenac Realty Company, Limited\u2014671 24.Frontenac Realty Company, Limited\u2014696 25.Frontenac Realty Company, Limited\u2014721 26.Frontenac Realty Company, Limited\u2014746 27.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014747 28.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014774 29.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014775 30.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014801 31.Frontenac Realty Company.Limited\u2014825 The aliove thirty sulnlivisions are all of original lot number 2439.32.Frontenac Realty Company, Limited\u201463 33.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014114 34.Frontenac Realty Company, Limited\u2014165 35.Frontenac Realty Company, Limited\u2014216 36.Frontenac Realty ( 'ompany.Limited\u2014246 37.Frontenac Realty Company, Limited\u2014254 38.Frontenac Realty Company, Limited\u2014280 39.Frontenac Realty ( 'ompany, Limited\u2014305 40.Frontenac Realty Company, Limited\u2014306 41.Frontenac Realty Company, Limited\u2014331 42.Mrs.J.P.Houtet\u2014332 43.Frontenac Realty Company, Limited\u2014356 44.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014357 45.Frontenac Realty Company, Limited\u2014382 46.Frontenac Realty ( 'ompany.Limited\u2014407 47.Frontenac Realty ( 'ompany, Limited\u2014432 To Ik1 deducted, a width of 50 feet by a length of 350 feet, iM'longing to Shawinigan Water & Power Company.48.Frontenac Realty ( 'ompany.Limited\u2014457 To 1m> deducted a width of 15 feet by a length of 350 feet, lx*longing to the Shawinigan Water & Power Company.49.Frontenac Realty Company, Limited\u2014475 To Ik> deducted a width of 50 feet by a length of 193 feet, l>elonging to the Shawinigan Water & Power ( 'ompany.50.Frontenac Realty Company, Limited\u2014492 To Ih- deducted a width of 7'*j feet by a length of 217 feet, In-longing to the Shawinigan Water & Power Company.51.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014493 52.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014518 53.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014543 54.Frontenac Realty Company.Limited\u2014568 55.Frontenac Realty Company, Limited\u2014593 56.Frontenac Realty Company, Limited\u2014594 57.Frontenac RealtyCompany, Limited\u2014618 58.Frontenac Realty Company, Limited\u2014619 59.Frontenac Realty Company, Limited\u2014642 60.Frontenac Realty Company, Limited\u2014664 61.Frontenac Realty Company, Limited\u2014665 62.Frontenac Realty Company, Limited\u2014686 63.Frontenac Realty ('ompany.Limited\u2014687 The al>ove thirty-two sulxiivisions are all of original lot number 2436.64.Van Dyke Land Co.Reg'd\u2014894 The alx>ve subdivision is of original lot number 2431.65.Nor-Mount Realty Company, Limited- 19 66.Nor-Mount Realty Company, Limited- 46 67.Nor-Mount Realty Company, Limited- 73 68.Nor-Mount Realty Company, Limited-100 69.Nor-Mount Realty Company, Limited-127 70.Nor-Mount Realty Company, Limited-154 71.Nor-Mount Realty Company, Limited-181 72.Nor-Mount Realty Company, Limited-193 73.Nor-Mount Realty Company, Limited-199 74.Nor-Mount Realty Company.Limited\u2014206 75.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014218 76.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014245 77.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014272 78.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014299 79.Nor-Mount Realty ('ompany, Limited\u2014326 80.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014353 81.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014380 1126 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 1S mai 19M, No 19, Vol.76 82.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014405 83.Nor-Mount Realty ( 'ompany, Limited\u2014423 84.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014424 A distraire une largeur de 33 pieds sur une longueur de 1005 pieds appartenant à la Cité de Québec, étant le lot N° 424-1.85.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014444 80.Nor-Mount Realty ('ompany, Limited\u2014445 87.Nor-Mount Realty ( 'ompany, I.united\u2014405 88.Nor-Mount Realty ('ompany, Limited -485 80.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014511 00.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014538 91.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014505 02.Nor-Mount Realty ( 'ompany, Limited\u2014592 93.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014073 94.Nor-Mount Realty ( 'ompany, Limited\u2014700 95.Nor-Mount Realty ( 'ompany, Limited\u2014727 90.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014754 97.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014781 98.Nor-Mount Realty < 'ompany, Limited \u2014808 99.Nor-Mount Realty ( 'ompany, Limited\u2014835 100.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014802 101.Nor-Mount RealtyCompany, Limited -889 102.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014910 108.Nor-Mount RealtyCompany, Limited 943 104.Nor-Mount Realty ('ompany, Limited\u2014970 105.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014997 100.Nor-Mount Realty Company, Limited- 1024 107.Nor-Mount Realty ('ompany, Limited \u20141051 A distraire une largeur de 30 pieds sur une longueur de 350 pieds appartenant ii The Shawinigan Water & Power Company.Iaih quarante-trois subdivisions ci-dessus sont toutes du lot originaire numéro 2424.108.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014 1 109.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014 12 110.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014 28 111.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014 49 112.Nor-Mount RealtyCompany, Limited- 70 113.Nor-Mount Realty Company, Limited- 105 114.Léon Bergeron- ill 115.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014113 lit).Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014130 117.Nor-Mount RealtyCompany, Limited 105 118.Nor-Mount RealtyCompany, Limited 200 119.Nor-Mount RealtyCompany.Limited\u2014235 120.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014270 121.Nor-Mount RealtyCompany, Limited -305 122.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014 340 123.Nor-Mount RealtyCompany, Limited- 375 124.Nor-Mount Realty Company.Limited\u2014410 125.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014445 120.Nor-Mount RealtyCompany.Limited\u2014480 127.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014515 128.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014550 129.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014583 130.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014010 131.Nor-Mount RealtyCompany.Limited\u2014037 132.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014039 A distraire une largeur de 07 pieds sur une longueur de 371 pieds et 9 pouces appartenant à The Shawinigan Water & Power Company.A distraire également une largeur de 33 pieds sur une longueur de 1433 pieds appartenant â la Cité de Québec, étant le lot N° 2421-039-1.133.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014038 134.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014607 135.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014668 136.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014754 137.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014787 138.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014822 139.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014857 140.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014892 141.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014927 142.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014962 143.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014997 144.Nor-Mount Realty Company, Limited\u20141032 145.Nor-Mount Realty Company, limited\u20141007 146.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u20141102 147.Nor-Mount Realty (\"ompany, Limited\u20141137 148.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u20141172 149.Nor-Mount Realty Company, Limited\u20141207 150.Nor-Mount Realty Company, Limited\u20141230 A distraire une largeur de 06 pieds sur une longueur de 350 pieds appartenant à The Shawinigan Water & Power Company.A distraire également une largeur de 33 pieds sur une longueur de 203 pieds appartenant à la Cité de Québec, étant le lot N° 2421-1230-A.151.Nor-Mount Realty Company.Limited\u20141231 A distraire une largeur de 30 pieds sur une longueur de 350 pieds appartenant à The Shawinigan Water & Power Company.Les quarante-quatre subdivision» ri-dessus sont toutes du lot originaire numéro 2421.82.Nor-Mount Realty ( Company, Limited\u2014405 83.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014423 84.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014424 To be deducted, a width of 33 feet by a length of 1065 feet, l>clongiug to the City of Quebec, being lot No.424-1.85.Nor-Mount Realty ('ompany, Limited\u2014444 86.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014445 87.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014465 88.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014485 89.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014511 90.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014538 91.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014505 92.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014592 93.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014673 94.Nor-Mount Realty ('ompany, Limited\u2014700 95.Nor-Mount Realty Conqniuy, Limited\u2014727 90.Nor-Mount Realty ( 'ompany, limited\u2014754 97.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014781 98.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014808 99.Nor-Mount Realty ( 'ompany, Limited\u2014835 100.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014862 101.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014889 102.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014916 103.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014943 104.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014970 105.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014997 100.Nor-Mount Realty Company, limited\u20141024 107.Nor-Mount Realty Company, Limited\u20141051 To be deducted, a width of 30 feet by a length of 350 feet, la-longing to the Shawinigan Water & Power Company.The above forty-three subdivisions are all of original lot number 2424.108.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014 I 109.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014 12 110.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014 28 111.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014 49 112.Nor-Mount RealtyCompany, Limited\u2014 76 113.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014105 114.Léon Bergeron\u2014-ill 115.Nor-Mount Realty Company.Limited\u2014113 110.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014130 117.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014105 118.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014200 119.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014235 120.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014270 121.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014305 122.Nor-Mount Realty Company, Limited \u2014340 123.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014375 124.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014410 125.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014445 120.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014ISO 127.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014515 128.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014550 129.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014583 130.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014610 131.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014637 132.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014639 To be deducted, a width of 67 feet by a length of 371 feet and 9 inches belonging to the Shawinigan Water & Power Company.To l>e deducted also, a width of 33 feet by a length of 1433 feet.l>elonging to the City of Quebec, being lot No.2421-039-1.133.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014'638 134.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014667 135.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014668 136.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014754 137.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014787 138.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014822 139.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014857 140.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014892 141.Nor-Mount Realty Company, limited\u2014927 142.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014902 143.Nor-Mount Realty Company, Limited\u2014997 144.Nor-Mount Realty Company, Limited\u20141032 145.Nor-Mount Realty Company, limited\u20141067 146.Nor-Mount Realty Company, Limited\u20141102 147.Nor-Mount Realty Company, limited\u20141137 148.Nor-Mount Realty (\"ompany, Limited\u20141172 149.Nor-Mount Realty Company, Limited\u20141207 150.Nor-Mount Realty Company, Limited\u20141230 To 1* deducted, a width of 66 feet by a length of 350 feet, belonging to the Shawinigan Water & Power Company.To he deducted also, a width of 33 feet by a length of 203 feet belonging to the City of Quebec, being lot No.2421-1230-A.151.Nor-Mount Realty Company, Limited\u20141231 To be deducted a width of 30 feet by a length of 350 feet belonging to the Shawinigan Water & Power Company.The above forty-four sulxiivisions are all of original lot number 2421. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 19U, No.19, Vol.70 1127 Les immeubles ci-dessus décrits sont tous du cadastre officiel de la paroisse St-Sauveur de Québec, et sont situés en la ville de Québec-Ouest.Donné à Québec-Ouest, ce 10 mai 1914.(Sceau) I^e greffier, 0271-19-2-o G.ROULEAU.VENTES PAR LES SHÉRIFS AVIS PUBLIC est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tel que mentionné plus bas.MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure.\u2014District de Montréal Montréal, à savoir: ) C1 RANCIS JOHN 223207 [ r STARR ct al, De- mandeurs; vs DAME EDNA ROBINSON MURRAY, épouse séparée de biens de Douglas M.Hains, Défendeur, et HENRI BOURDON, curateur au délaissement.Comme appartenant an défendeur, mais aux mains dudit curateur au délaissement.Un morceau de terrain, en la cité de Montréal, comprenant cinquante-six pieds en front par cent quinze pieds en -profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, formant partie «lu lot de subdivision numéro soixante-douze du lot officiel numéro seize cent cinquante-quatre (1054-72) aux plan et livre de renvoi officiels du «piartier St-Antoine; borné en front par la rue St-Marc, d'un côté par la rue St-Luc, de l'autre côté et en arrière par d'autres parties dudit lot de subdivision numéro soixante-douze; avec les maisons portant les numéros civiques cent et cent deux rue St-Marc, avec l'usage à perpétuité de la ruelle de douze pieds de largeur en arrière connue comme étant la subdivision numéro quatre de ladite subdivision numéro soixante-douze (1054-72-4) en arrière dudit lot pris partiellement sur ledit lot et sur une autre partie du lot adjacent avant la resubdivision ci-après mentionnée.lirait morceau de terrain étant maintenant connu comme étant le lot numéro un de la resubdivision officielle dudit lot numéro soixante-douze dudit lot originaire numéro seize cent cinquante-quatre (1054-72-1) pour ledit quartier St-Antoine.\u2022 Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le QUINZIÈME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Un dépôt de $2,820 sera exigé de tout offrant et enchérisseur, suivant jugement de l'Honorable Juge Cousineau, en date du 10 mai 1944.Le shérif, Bureau du shérif, L.-P.CAISSE.Montréal, le 10 mai 1944.0273-19-2 [Première publication, le 13 mai 1944] PONTIAC Cour Supérieure.\u2014District de Pontiac Canada, ) TOUSSAINT MAIN- Province de Québec, i * VILLE, cultivateur, District de Pontiac, ( dans le canton de l'Ile N° 5021 ; aux Allumettes, demandeur; vs FRANCIL LAIRD, cultivateur, en sa qualité de curateur dûment nommé à Onésime Mainville, interdit et détenu à l'Hôpital StrJean The immovables hereinabove described are all of the official cadastre for the parish of St-Sauveur de Quél>ec, and are situate in the Town of Quebec-West.Given, at Quebec-West, this 10th of May, 1944.(Seal) G.ROULEAU, 6271-19-2 Clerk.SHERIFFS' SALES PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court.\u2014District of Montreal Montreal, to wit: [ CRAN CI S JO H N 223207 f F STARR el al, plaintiffs; vs DAME EDNA ROBINSON MURRAY, wife separate as to property of Douglas M.Hains, defendant, and HENRI BOURDON, curator to the abandonment.As belonging to the defendant, but in the hands of the said curator to the abandonment.\"A piece of land in the City of Montreal containing fifty-six feet in front by one hundred and fifteen feet in depth, English measure and more or less, forming part of the subdivision lot number seventy-two of the official lot number sixteen hundred and fifty-four (1054-72) of the Official Plan and Book of Reference of the St-Antoine Ward; bounded in front by St-Mark Street, on one side by St-Luke Street, on the other side and in rear by other parts of the said subdivision lot number seventy-two; with the houses bearing Civic Numbers One hundred, and One hundred and two St-Mark Street, with the use forever of the lane twelve feet in width in rear known as subdivision number four of said subdivision number seventy-two (1654-72-4) in rear of said lot taken partially on the said lot and other part of the adjoining lot before the after mentioned resubdivision.Said piece of land being now known as lot number one of the official resuhdivision of said lot number seventy-two of said original lot number sixteen hundred and fifty-four (1654-72-1) for the said St-Antoine Ward\".' To be sold, at my office, in the City of Montreal, on the FIFTEENTH day of JUNE next, at TEN o'clock in the forenoon.A deposit of $2820.00 shall be exacted from each and every bidder, pursuant to a Judgment of the Honourable Justice Cousineau, dated May 10th 1944.L.P.CAISSE, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, May 10th 1944.6273-19-2-o [First publication, May 13th, 1944] PONTIAC Superior Court.\u2014District of Pontiac Canada, ) TOUSSAINT MAIN-Province of Quebec, i A VILLE, Farmer in District of Pontiac, ( the Township of Allu- No.5021 / mette Island, plaintiff; vs FRANCIL LAIRD, farmer, in his quality of Curator duly appointed to Onésime Mainville, interdicted and detained in l'Hôpital St-Jean de 1128 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 mai IBM, No 19, Vol.76 de Dieu, à Montréal, du susdit canton de l'Ile aux Allumettes, district de Pontiac, défendeur.(o) Le quatorzième indivis du lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de l'Ile aux Allumettes, comté de Pontiac, province de 'Québec, comme étant le lot numéro un, dans le neuvième rang dudit canton (1, rang IX).(b) Le quatorzième indivis du lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de l'Ile aux Allumettes, comté de Pontiac, province de Québec, comme étant le lot numéro trente-quatre, dans le quatrième rang dudit canton, avec ensemble toutes les bâtisses dessus érigées (34, rang IV).(c) Le quatorzième indivis du lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de l'Ile aux Allumettes, comté de Pontiac, province de Québec, comme étant la demi-nord du lot numéro trente-neuf, dans le troisième rang, dans ledit canton, avec ensemble toutes les bâtisses dessus érigées, N, 39, rang III), ladite demi-nord dudit lot étant bornée conformément â la désignation décrite dans l'acte de vente de John Kcenan â Toussaint Mainville, enregistré au bureau d'enregistrement dudit comté de Pontiac dans Lib.IL Vol.21, folio 30, sous le N° 25234.(d) Le quatorzième indivis du lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de l'Ile aux Allumettes, comté de Pontiac, province de Québec, comme étant le lot numéro trente-huit A, dans le sixième rang dudit canton, avec ensemble les bâtisses dessus érigées, ledit lot comprenant trente-deux acres, plus ou moins (38a, rang VI).(e) Le quatorzième indivis du lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de l'Ile aux Allumettes, comté de Pontiac, province de Québec, comme étant la demi-est (VéE) du lot numéro quarante et un, dans le cinquième rang dudit canton, avec ensemble les bâtisses dessus érigées, ladite partie du lot comprenant cinquante acres, plus ou moins, (V£E lot 41, rang V).Pour-être vendus au bureau du régistraire du comté de Pontiac, à Campbell's Hay, Québec, MARDI, le VINGT-TROISIÈME jour de MAI mil neuf cent quarante-quatre, à DIX heures du matin.Le shérif, Bureau du shérif, DOMINIC SLOAN.Campbell's Bay, Québec, le 17 avril 1944.6084-16T2 [Première publication, le 22 avril 1944) Arrêtés en Conseil ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF N° 1453 Québec, le 2 mai 1944.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant le mesurage des bois de sciage coupés dans les forêts de la Couronne.Dieu, at Montreal, of the aforesaid Township of Allumette Island, defendant.(a) The One undivided Fourteenth of the lot known and designated according to the Official Plan and Book of Reference for the Township of Allumette Island, County of Pontiac, province of Quebec, as lot number One, in the Ninth Range of the said Township (No.1, Range IX).(b) The One undivided Fourteenth of the lot known and designated according to the Official Plan and Book of Reference for the Township of Allumette Island, County of Pontiac, province of Quebec, as lot number Thirty Four, in the Fourth Range of the said township, together with all the buildings thereupon erected (No.34, Range IV).(c) The One undivided Fourteenth of the lot known and designated according to the Official Plan and Book of Reference for the Township of Allumette Island, County of Pontiac, province of Quebec, as the North Half of the Lot number Thirty Nine, in the Third Range, in the said Township, together with all the buildings thereupon erected, (N^ No.39, Range III) said North Half of the said lot being bounded according to the designation outlined in a Deed of Sale from John Keenan to Toussaint Mainville, registered in the registry office for the said County of Pontiac in I ib.B.Vol.21, folio 30, under No.25234.(d) The One undivided Fourteenth of the lot known and designated according to the Official Plan and Book of Reference for the Township of Allumette Island, County of Pontine, province pf Quebec, as lot number Thirty Eight A, in the Sixth Range of the said Township, together with the buildings thereu|xm erected, said lot containing Thirty Two acres more or less: (No.38a, Range VI).(e) The One undivided Fourteenth of the lot known and designated according to the Official Plan and Book of Reference for the Township of Allumette Island, Countv of Pontiac, province of Quebec, as the East Half (E>£) of the lot number Forty One, in the Fifth Range of the said Township, together with the buildings thereupon erectedj said part of lot containing fifty acres more or less (E}4 lot No.41, Range V).To be sold at the Registrar's Office for the County of Pontiac, in Campbell's Bay, Quebec, on TUESDAY the TWENTY-THIRD day of MAY, one thousand nine hundred and forty-four, at TEN of the clock in the forenoon.DOMINIC SL.OAN, Sheriff's Office, Sheriff.Campbell's Bay, Quebec, April 17, 1944.0084-16-2-O [First publication, April 22, < 1944) Orders in Council ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER No.1453 Quebec, 2nd.May 1944.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the scalirfg of sawlogs cut in Crown .Forests. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 1944, No.19, Vol.76 1129 Attendu que, en attendant le résultat d'expériences en cours, il y aurait lieu de maintenir en vigueur, pour l'année 1944-4.5, les dispositions de l'arrêté ministériel numéro 11582, du 25 novembre 1943, en vertu desquelles le mesurage des billes destinées au sciage et provenant des terres de J» Couronne, peut être fait en fonction de leur diamètre au fin bout seulement, en majorant le volume ainsi obtenu de 15% pour les bois feuillus et de 20% jxmr les Ihms résineux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre des Terres et Forêts: Que le mode de mesurage prévu par l'arrêté ministériel numéro 3582, soit maintenu en vigueur |K)ur l'année 1944-45, pourvu toutefois que les gages payés aux bûcherons employés à forfait soient calculés d'après le mesurage aux deux boute, tel que prescrit par les règlements des Bois et Forêts.A.MORISSET, 0248-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1544 Qué!x»c, le 9 mai 1944.Présent: Ijc Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant une convention collective de travail relative aux employés municipaux de la cité de Joliette.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective, (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163), l'Association des Employés municipaux de Joliette, local 141, Congrès des Métiers et du Travail du Canada, a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: D'une past: \"La Cité de Joliette\", Et, dSmjtre part: ' \"L'Association des Employés municipaux de Joliette, local 141, Congrès des Métiers et du Travail du Canada\"; \"L'Association des Policiers et Pompiers de Joliette\"; |K)ur l'employeur et les salariés des occupations visées suivant les conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, livraison du 25 mars 1944; Attendu que les dispositions de ladite convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement des conditions de travail dans les métiers et les occupations visés et dans la juridiction territoriale indiquée dans ladite requête; Attendu que les prescriptions de ladite Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre intérimaire du Travail: Que ladite requête soit acceptée, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective, (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163), avec, toutefois/ les nouvelles dispositions Whereas, ponding the result of exj>eriments now being made, it will lx» proper to maintain in force for the year 1944-45, the provisions of Order in Council No.3582 of 25th.November 1913, in virtue of which the scaling of sawlogs cut on Crown lands may l>e carried out at the small end only and the volume thus obtained increased by 15% for hardwoods and 20% for softwoods; It is ordered, in consequence, on the proposal of the Honourable Minister of Lands & Forests: That the method of measurement proscribed by Order in Council No.3582 be maintained in force for the year 1944-45, provided however that the wages of woods workers engaged on piecework shall l>e calculated according to two-end measurement, as proscribed by the Woods and Forests Regulations.A.MORISSET, 0248-o Clerk to the Executive Council.ORDER IN COUNCIL CHAMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL Number 1544 Quebec, May 9, 1944.Present: The Lieutenant-Governor in Council Concerning a collective labour agreement relating to the municipal employees of the City of Joliette.Whereas, pursuant to the provisions of the Colledtive Agreement Act (Revised Statutes of Quelle 1941, chapter 103), \"L'Association des Employés municipaux de Joliette\", local 141, of the Trades and labour Congress of Canada, has presented to the Minister of Labour a request to render obligatory the collective labour agreement entered into between : On the one part: The City of Joliette, And, on the other part: \"L'Association des Employés municipaux de Joliette\", Local 141, of the Trades and Labour Congress of Canada ; \"L'Assocaition des Policiers et Pompiers de Joliette\", for the employer and the employees of the offices and occupations concerned, according to the conditions described in the Quebec Official Gazette of March 25, 1944; Whereas the provisions of the said agreement have acquired a preponderant significance and importance for the establishing of working conditions in the trades and occupations concerned and within the territorial jurisdiction indicated in the said request; Whereas the provisions of the said Act, concerning the publication of notices, have been duly observed ; Whereas no objection against its approval has l>een set forth; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Acting Minister of Labour: That the said request be accepted pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163), with, however, the following new provisions to be 1130 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 mai 19U, No 19, Vol.76 nui vantes, tenant lieu des conditions décrites dans la Gazette officielle de Québec, livraison du 25 mars 1944.I.\u2014Définitions:\u2014Dans le présent décret, les termes suivants ont la signification qui leur est ci-après donnée: a.\u2014Le mot \"employeur\" désigne la Cité de Joliette.b.\u2014Le mot \"employé\" désigne les employés «les départements de la Police et des Incemlies, «lu Système hy«lrauli«pie et tics Servies municipaux de la Cite de Joliette, dont la fonction ou le salaire sont prévus «lans le présent «lécret.IL\u2014Juridiction:\u2014I>e présent «lécret s'applujue et s'étend à la Cité de Joliette et à ses employés «les départements «le la Police et «les Incemlies, «lu Système hy«lrauli«pie et des Services municipaux mentionnée ci-apr«>s.III.\u2014Cédule des salaires:\u2014l^>s taux «le salaire suivants «loivent t'tre payés pour chacune «les occupations ci-après mentionnées: Salaires Occu pa tiotl s : hebdomad a ires Incendie et Police: Souf-chef.S 30.19 Capitaine.27.77 Lieutenant.28.98 Pompier-mécanicien.30.43 Pompier-inspecteur.20.02 Pompier-constable.26.62 Services mu n icipa ux: Electricité: Chef électricien.32.84 Premier électricien.30.19 Deuxième électricien.22.34 Garage: Chef mécanicien.30.19 Mécanicien.25.36 Chaufeur.0.50 l'heure Magasin : Forgeron-gardien.27.90 Plombier.26.56 Journalier.0.40 l'heure Pointeur.20.79 Marché: Gardien.21.73 Aqueduc, égoût, parc, voirie spécialisée: Contremaître général adjoint\u2014Inspecteur.27.90 Contremaître\u2014bornes-fontaines.26.62 Contremaître\u2014mécanicien.26.62 Contremaître\u2014Fleuriste.24.25 Préposé au malaxeur de ciment\u2014 égoût.0.45 l'heure Préposé à l'aqueduc\u2014égoût____0.45 l'heure Préposé à la tondeuse\u2014parc.0.45 l'heure Service généraux\u2014voirie et incinération sanitaire: Contremaître.26.62 Journalier.0.45 l'heure Journalier.0.40 l'heure Système hy«lraulique: Surintendant.32.97 Mécanicien.35.50 Pressé au fonctionement (Operator) 27.90 IV.\u2014Heures de travail:\u2014a.\u2014Département des incendies et de la police:\u2014Tout les employés de ce département travaillent sur deux équipes : substituted to the conditions «lescribed in the Quebec Official Gazette on March 25, 1944.I.\u2014Definitions:\u2014In the present decree, the following terms shall have the significance hereinafter given to them: a.\u2014The word \"employer\" means the City of Joliette.b.\u2014The word \"employee\" means and includes the employees of the Police ami Fire Department, of the Hydraulic System and Municipal Services Departments of the City of Joliette, whose functions and wages are determined and established in the present decree.II.\u2014Jurisdiction:\u2014The present «lecree applies ami extends to the City of Joliette and to its employees of the Police and Fire Department, of the Hydraulic System Department and of the Department of the Municipal Services hereinafter mentioned.III.\u2014Rates of wages:\u2014The following rates of Wages shall be paid f«>r each one of the occupa- tions hereinafter mentioned\u2022 Weekly Occupations: 'wages Fire and Police Department: Ass't.-chief.| 30.19 Captain.27.77 Lieutenant.28.98 Firemen-Engineman.30.43 Fireman-Inspector.26.62 Fireman-Constable.96.62 Municipal services: Electrical department : Chief-electrician.32.84 Electrician (first).30.19 Electrician (second).22.34 Garage: Chief-mechanic.30.19 Mechanic.25.36 Fireman.0.50 per hour Stores : Blacksmith-watchman.27.90 Plumber.26.56 Labourer.0.40 per hour Time-keeper.20.79 Market: Watchman.21.73 Aqueduct, sewers, park, roads (specialized occupations) : Ass't.-general foreman\u2014Inspector.27.90 Foreman\u2014street fountains.26.62 Foreman\u2014Engineman.26.62 Foreman\u2014Florist.24.25 Cement mixer operator\u2014sew ers.0.45 per hour Aqueduct employee\u2014sewers .0.45 per hour Lawn-mower operator\u2014park .0.45 per hour General services\u2014roads and sanitary incineration : Foreman.26.62 Labourer.0.45 per hour Labourer.0.40 per hour Hydraulic system : Superintendent.32.97 Mechanic.35.50 .Operator.27.90 IV.\u2014Hours of work:\u2014a.\u2014Fire and Police Department:\u2014All the employees of this department work on two shifts: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 19U, A'o.19, Vol.76 1131 i.L'équipe de jour: nix jours à onze (11) heures pur jour; it.L'équipe de nuit: six nuits à treize (13) heures par nuit.b.\u2014Département du système hydraulique:\u2014La semaine régulière de travail pour ces employés est de cinquante-six (50) heures.Lorsqu'un des employés de ce département prend ses vacances l'autre employé a droit au paiement de salaire et demi pour chaque heure supplémentaire durant laquelle il travaille en plus des huit (8) heures constituant une journée régulière de travail.c.\u2014Tous les autres départements:\u2014La semaine régulière de travail pour ces employés est de quarante-huit (48) heures.V.\u2014Liberté d'action:\u2014Tous les employés, sauf les pompiers, les constables, les électriciens et les contremaîtres et employés de l'aqueduc, jouissent d'une entière liberté d'action après les heures régulières de travail.VI.\u2014Travail supplémentaire:\u2014Tous les employés régis par le présent décret sauf les pompiers, les constables et les employés du système hydraulique, ont droit ail paiement de salaire et demi après quarante-huit (48) heures de travail dans une semaine, et pour tout travail exécuté entre 5.00 p.m.et 8.00 a.m.Tout travail exécuté les dimanches, les jours de fête religieuse d'obligation, le jour de la Saint-Jean-Baptiste et le jour de la Fête du Travail sera également rémunéré au taux de salaire et demi.VIL\u2014CûMgi:\u2014Tous les employés du département des incendies et de la police ont droit il une journée complète (vingt-quatre (24) heures) de congé par semaine, sans diminution de salaire.VIII.\u2014 Vacances:\u2014Tous les employés permanents de plus d'un an de service ont droit, chaque année, il deux semaines de vacances payées.IX.\u2014Durée du décret:\u2014Le présent «lécret est valable a compter de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1944.Il se renouvellera automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne un avis écrit à l'autre partie, à ce contraire, trente (30) jours avant le 31 décembre 1944 ou avant le 31 décembre de toute année subséquente.A.MORISSET, 0275-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1543 Québec, le 9 mai 1944.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant l'addition de deux parties co-contrac-tantes à la convention collective de travail relative aux tanneries et corroieries dans la province de Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective, (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163), des requêtes ont été présentées, au Ministre du Travail, par \"The Bonner Leather Company\", 2060 ouest, rue Notre-Dame, Montréal, et \"Coyle Tanning Company, Limited\", 55, avenue Dubé, Montréal-Est, à l'effet d'être acceptées comme parties .i.The day shift: six days of eleven (11) hours each ; it.The night shift: six nights of thirteen (13) hours each.b.\u2014Hydraulic system department:\u2014 The regular work week for these employees shall consist of fifty-six (56) hours.When one of the employees of this department takes his vacations, the other employee is entitled to the payment of time and one half for each overtime hour worked in excess of the eight (8) hours which constitute the regular working day.c.\u2014All other departments:\u2014The regular work week for these employées shall consist of forty-eight (48) hours.V.\u2014Liberty of action:\u2014All the employees, with the exception of firemen, constables, electricians and aqueduct foremen and employees, shall have complete liberty of action after the regular hours of work.VI.\u2014Overtime ivork:\u2014All the employees governed by the present decree, with the exception of firemen, constables and employees of the hydraulic system, shall be entitled to the payment of time and one half after forty-eight (48) hours of work in one week, and for any work performed between 5.00 p.m.and 8.00 a.m.Work performed on Sunday, religious holidays, St-Jean Baptiste Day and Labour Day shall also be paid at the rate of time and one half.VII.\u2014Day off:\u2014All the employees of the Fire and Police Department shall be entitled to a complete (layoff (twenty-four (24) hours), every week, without salary deduction.VIII.\u2014Vacations:\u2014All the permanent employees with more than one year of service shall be entitled, each year, to a vacation of two weeks, with pay.IX.\u2014Duration of the decree.\u2014The present decree shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette and shall remain effective until December 31, 1944.It shall then renew itself automatically, from year to year, unless one of the contracting parties give to the other written notice to the contrary thirty days before December 31, 1944, or before December 31, of any subsequent year.A.MORISSET, 6275-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL CHAMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL Number 1543 Quebec, May 9, 1944.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the adding of two contracting parties to the collective labour agreement relating to the tanners and curriers of the Province of Quebec.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163), two requests have been presented to the Minister of Labour by The Bonner Leather Company, 2060 Notre-Dame street West, Montreal, and Coyle Tanning Company, Limited, 55 Dubé avenue, Montreal-East, to be treated as co-contracting parties to the 1132 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 mai 19U, No 19, Vol.70 eo-eontractantes à la convention collective de travail relative aux tanneries et eorroicries dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 523, du 5 février 1940, et amendements; Attendu qu'un avis a ce sujet, a été publié dans la Gazette officielle de Québec du 25 mars 1944; Attendu «pie le comité paritaire chargé de surveiller l'application «lu «lécret a été dûment consulté à ce sujet; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre ladite requête; Il est ordonné, en consé«pience, sur la proposition «le l'honorable Ministre intérimaire du Travail: Que \"The Bonner Leather Company,'' 2000 ouest, rue Notre-Dame, Montréal, et \"Coyle Tanning Company, Limited\", 55 avenue Dubé, Montréal-Est, soient traitées comme parties co-con-tractantes à la convention collective «le travail rendue obligatoire par ledit «lécret numéro 523 et que leur nom soit ajouté aux parties de «leuxiè-me part.A.MORISSET, 0283-o Greffier «lu Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1541 Quél>ec, le 9 mai 1944.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil.Concernant des mollifications au «lécret numéro 409, du 20 février 1942, et amendements, relatif aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans la région «les Trois-Rivières.Attendu «jue, conformément aux disposition! de la Loi de la convention collective, (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 103), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse, dans la région des Trois-Rivières, rendue obligatoire par le décret numéro 4(59, du 20 février 1942, et amendements, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet d'apporter des modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, «lu 18 mars 1944; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Attemlu que le Conseil régional du Travail en temps de guerre de Québec a approuvé les dispositions de ladite requête, par décision rendue à sa séance du 25 avril 1944; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre intérimaire du Travail: Que ledit «lécret numéro 469 soit modifié de la façon suivante: 1.\u2014Le paragraphe \"/\" de l'article I est remplacé par le suivant: \"/.\u2014Les mots \"ondulation permanente\" désignent l'opération qui consiste à donner aux cheveux une \"ondulation qui dure\", qu'elle soit accompagnée ou non d'une ondulation à l'eau ou qu'elle soit donnée au moyen de manipulations, d'appareils électriques ou autres, ou par l'usage de crèmes, cosmétiques, poudres, lotions, toniques, antiseptiques, etc.\" 2.\u2014Le paragraphe \"/\" suivant est ajouté a l'article III: collective labour agreement relating to the tanners an«l curriers in the Province of Quebec, rendere«l obligatory by the «lecree number 523, of February 5, 1940, ami amendments; Whereas a notice to that effect has l>een published in the Quebec Official Gazette of March 25, 1944; Whereas the Parity Committee entrusted with the ndministrati«m of the decree has l>een e treated as co-contracting parties to the collective labour agreement reiulered obligatory by the «lecree number 523, and that their name be added to the parties of the second part.A.MORISSET, 0283-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL CHAMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL Number 1541 Quebec, May 9, 1944.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning modifications of the decree number 409, of February 26, 1942, and amendments, relating to the barber and hairdresser trades in the district of Trois-Rivières.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the barber and hairdresser trades in the district of Trois-Rivières, rendered obligatory by the decree number 469, of February 26, 1942, an«l amendments, have presented to the Minister of Labour a request to modify the said decree; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette on March 18,1944; Whereas no objection against its approval has lx»en set forth ; Whereas the Regional War Labour Board of Quebec has approved the provisions of the said re«iuest by a decision taken at its meeting of April 25, 1944; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Acting Minister of Labour: That the said «lecree nun il >er 469 be modified in the following manner: 1.\u2014Subsection \"/\" of section I is replaced by the following: \"/.\u2014The words \"permanent wave\" designate the operation performe«l for the purpose of giving the hair a \"lasting wave\", accompanied or not by a water wave, and whether it be given by means of manipulations, electrical devices or others, or through the use of creams, cosmetics, powders, lotions, tonics, antiseptics, etc.\" 2.\u2014The following subsection \"/\" is added to section III: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 19U, No.19, Vol.7(i 1133 \"/.\u2014W un ou des employés logent chez l'employeur, ce dernier ne peut exiger de chacun d'eux plus de $2.00 par semaine pour une chambre.Si un employeur nourrit un ou plusieurs de ses employés, il ne peut exiger plus de $5.00 par semaine de chacun d'eux, ou si tous les repas ne sont pas pris chez l'employeur, pas plus de $0.25 par repas.\" A.MORISSET, 0281-o Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 1542 Québec, le 9 mai 1944.Présent: Ix; Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant des modifications au décret numéro 3585, du 4 octobre 1940, et amendements, relatif aux établissements commerciaux de Magog.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective,'(Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 1G3), le comité paritaire des Marchands de Magog, a présenté au Ministre du Travail une requête a l'effet d'apporter des modifications au décret numéro 3585, du 4 octobre 1940, et amendements, relatif aux établissements commerciaux de Magog; Attendu (pie ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, livraison du 11 mars 1944; Attendu (pie des objections ont été formulées contre son approbation; Attendu que le Conseil régional du Travail en tempe de guerre de Québec a autorisé la diminution des heures de travail proposée dans ladite requête, par décision rendue à sa séance du 25 avril 1944; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre intérimaire du Travail: Que ledit décret numéro 3585 soit modifié de la façon suivante: 1.\u2014L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe \"a\" de l'article IV: \"Nonobstant les dispositions précédentes, la durée des heures de travail dans les boucheries, épiceries, boucheries-épiceries, ateliers de cordonniers et de selliers est de 7.30 a.m.I 6.00 p.m.le samedi.Il est cependant loisible aux employeurs visés, de remplacer l'arrêt de travail du samedi soir par un arrêt analogue le mercredi après-midi, après entente avec leurs salariés.\" 2.\u2014Le paragraphe \"6\" de l'article VI est remplacé par le suivant: \"6.\u2014Dans les établissements commerciaux: cinquante-neuf heures et demie (59H).Cependant, dans les boucheries, les épiceries et les boucheries-épiceries, la semaine de travail sera de soixante-deux (62) heures.Pour fins de nettoyage, il est permis de prolonger d'une heure la durée des heures de travail, le vendredi, et d'une demi-heure, le samedi, dans les boucheries et les épiceries-boucheries.\" A.MORISSET, 6282 o Greffier du Conseil Exécutif.\"/.\u2014When the employee or employees room at the employer's, the latter shall not charge more than $2.(K) per week for one room.When the employer lxiards one or more of his employees, he shall not charge more than $5.00 per week, per employee; a maximum of $0.25 l>er meal shall lx; charged when all meals arc not taken at the employer's.\" A.MORISSET, 0281-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL CHAMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL Number 1542 Quebec, May 9, 1944.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning modifications of the decree number 3585, of Octolxjr 4, 1940, and amendments, relating to the commercial establishments of Magog.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163), the Parity Committee of the Merchants of Magog has presented to the Minister of Labour a request to modify the decree number 3585, of October 4, 1940, and amendments, relating to the commercial establishments of Magog; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette on March 11, 1944; Whereas objections against its approval have been set forth ; Whereas the Regional War Labour Board for Quebec has authorized the reduction of working hours requested by a decision taken at its meeting of April 25, 1944; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Acting Minister of I-dibour:.That the said decree number 3585 be modified in the following manner: 1.\u2014The following paragraph is added to sub section \"a\" of section IV: \"Notwithstanding the foregoing provisions, the duration of the working hours, on Saturday, in butcher shops, groceries, grocer-butcher shops, shoemaker and harnassmaker shops shall be from 7.30 a.m.and 0.00 p.m.After an agreement with their employees, the employers concerned may, however, have them take an equal amount of hours off on Wednesday afternoon instead of Saturday night.\" 2.\u2014Subsection \"6\" of section VI is replaced by the following: \"6.\u2014In the commercial establishments: fifty-nine hours and one half (59^).However, in butcher shops, groceries, butcher-grocer shops, the week work shall consist of sixty-two (02) hours.In butcher shops and grocer-butcher shops, the duration of working hours may be increased by one hour on Friday, and by one half-hour on Saturday to permit the cleaning of the said shops.\" A.MORISSET, 628.2-0 Clerk of the Executive Council. 1134 GAZETTE 'OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 13 mai 1944, No 19, Vol 76 Index de la Gazette officielle de Québec, No 19 Action kn séparation de riens: Durocher vs Marleau.1110 Arrêtés en Conseil: 1453\u2014Concernant le mesurage des bois de sciage coupés dans les forêts de la Couronne.1128 1541\u2014Métiers de barbier, coiffeur et coiffeuse dans la région des Trois-Rivières 1132 1542\u2014Établissements commerciaux de Magog.1133 1543\u2014Tanneries et corroieries dans la province de Québec.1131 1544\u2014Employés municipaux de la cité de Joliette.1129 Avis aux Intéressés: Avis divers: Association Catholique des Institutrices Rurales du District N° 24 (Formation) 1112 Association des Employés de Roessel de Drummondville (Formation).1111 Hills sanctionnés.1114 Commission des Liqueurs de Québec (Rapport d'analyses).1111 Imperial Theatre Limited (Directeurs).1112 La Fédération Nationale des Travailleurs de l'Aluminium Inc.(Formation).1112 L'Association Catholique des Institutrices Rurales du District N° 40 (Formation).1113 L'Association Professionnelle des Policiers de la province de Québec\u2014Quebec Professional Policemen Association (Formation).1113 Ije Conseil Régional Saguenay Lac St-Jean des Syndicats Nationaux des Métiers de la Construction (Formation).1113 Le Domaine Laurentien, Inc.(Règle- ments).1113 lies Immeubles Vauquelin Inc.\u2014Vauquelin Real Estate Inc.(Directeurs).1113 L'Union des Institutrices du Diocèse de Rimouski (Formation).1111 Sherbrooke Street Realty Corporation (Directeurs).1111 Syndicat National des Chauffeurs de Taxis d'Arvida (Formation).1111 Syndicat National des Travailleurs de la Pulpe et du Papier de Windsor Mills, Inc.(Nom changé).1113 Syndicat National du Caoutchouc de Granby Inc.(Nom changé).1110 Hureau-chef: Index of the Quebec Official Gazette, No.19 Action for Separation as to Property: Durocher vs Marleau.1110 Orders in Council: 1453\u2014Concerning the scaling of sawlogs cut in Crown forests.1128 1541\u2014Barber and hairdresser trades in the district of Trois-Rivières.1132 1542\u2014Commercial establishments of Magog.1133 1543\u2014Tanners and curriers in the Province of Quebec.1131 1544\u2014Municipal employees of the city of Joliette.1129 1105 Miscellaneous Notices: Association Catholique des Institutrices Rurales du District N° 24 (Formation) 1112 Association des Employés de Roessel de Drummondville (Formation).1111 Bills sanctioned.1114 Quebec Liquor Commission (Report of analysis).1111 Ini|x?rial Theatre Limited (Directors).1112 La Fédération Nationale des Travailleurs de l'Aluminium Inc.(Formation).1112 L'Association Catholique des Institutrices Rurales du District N° 40 (Formation).1113 Quebec Professional Policemen Association\u2014L'Association Professionnelle des Policiers de la province de Québec (Formation).1113 Le Conseil Régional Saguenay Lac St-Jean des Syndicats Nationaux des Mé- t tiers de la Construction (Formation).1113 Le Domaine Laurentien, Inc.(Bylaws).1113 Vauquelin Real Estate Inc.\u2014Les Immeubles Vauquelin Inc.(Directors).1113 L'Union des Institutrices du Diocèse de ' Rimouski (Formation).1111 Sherbrooke Street Realty Corporation (Directors).1111 Syndicat National des Chauffeurs de Taxis d'Arvida (Formation).llll Syndicat National des Travailleurs de la Pulpe et du Papier de Windsor Mills, Inc.(Name changed).1113 Syndicat National du Caoutchouc de Granby Inc.(Name changed).1110 Chief-Office: 1105 Notice to Interested Parties: Industries de l'Habitant Limitée\u2014Hab- Habitant Industries Limited\u2014Industries itant Industries Limited.1115 de l'Habitant Limitée.1115 Chartes\u2014Abandon de: Charters\u2014Surrender of: Anglo-Canadian Securities Corporation.1115 Anglo-Canadian Securities Corporation.1115 Fundy, Limited.1115 Fundy, Limited.1115 Kilgour, Hamilton & Company Limited.1116 Kilgour, Hamilton & Company Limited.1110 Taxis Limited.1116 \u2014 Taxis Limited.1116 Départements\u2014Avis des: Departmental Notices : Agriculture: Agriculture: Société Coopérative Agricole de Conser- Société Coopérative Agricole de Conserves de Rougemont.1116 vos de Rougemont.1116 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, May 13th, 1944, No.19, Vol.76 113f> Instruction publique: Education: Racine, munie, scolaire de la ville.1116 Racine, school munie, of the town.1116 St-Georges, munie, scolaire.1116 St-Georges, school munie.1116 St-Paul-L'Ermite, munie, scolaire.1117 St-Paul-L'Ermite, school munie.1117 St-Simon-les-Mines, munie, scolaire.1117 St-Simon-les-Mines, school munie.1117 Terres et Forets: Lands and Forests: Laval, canton.1117 Laval, township.1117 Lettres patentes: ^ Letters Patent: Heaver Investments Corp.1106 ^-Reaver Investments Corp.1106 E.Sauvé Ltée.1107-4 E.Sauvé Ltée.1107 Hôpital Bellevue, Inc.1107 Hôpital Bellevue, Inc.1107 I/îs Pionniers et Patriotes.1107 Lés Pionniers et Patriotes.vfT,.1107 Maple Leaf Peat Limited.1108 Marie Leal Peat Limited.«?.1108 Médéric Charbonneau Limitée.1108 \"\"Médéric Charbonneau Limitée.1108 Renaissance Films Inc.1109 Renaissance Films Inc.1109 Lettres patentes supplémentaires: ^ Supplementary Letters Patent: Anglo-Canadian Bond & Share Corpora- Anglo-Canadian Bond & Share Corporation.1109 tion.1109 Cushing, Ross Limited.1110 \u2014 Cushing, Ross Limited.1110 Industries du ïaïc du Cerf Ltée.1110 Industries du Lac du Cerf Ltée.1110 Liquidation, avis de: * Winding Up Notice: McKay (Quebec) Exploration Limited .1118\u2014¦ McKay (Quebec) Exploration Limited .1118 Minutes de notaires: Notarial Minutes: Désy, Robert, en faveur de.1118 Désy, Robert, In favour of.1118 Nominations: Appointments: Diverses.1118 Miscellaneous.1118 Vente, Loi de faillite: Sale, Bankruptcy Act: Rousseau, Eléodore.1119 Rousseau, Eléodore.1119 Ventes par licitation: Sales dy Licitation: Deiorme vs Deiorme et al.1120 Deiorme v$ Deiorme et al.1120 Wilson vs Wilson et al.1119 Wilson vs Wilson et al.1119 Ventes pour taxes: Sales for Taxes: Bagotville, ville de.1121 Bagotville, town of.1121 Bégin, canton.1123 Bégin, township.1123 Québec-Ouest, ville de.1124 Quebec-West, town of.1124 Ventes par les Shérifs: Sheriffs' Sales: Montréal: Montreal: Starr et al vs Murray.1127 Starr et al vs Murray.1127 Pontiac: Pontiac: Mainville vs Laird.1127 Mainville vs Laird.1127 6284-o 6284-0 Québec: \u2014 Imprimé par Rédempti Paradis, Quebec: \u2014 Printed by Rédempti Paradis, imprimeur du Roi.' King's Printer. "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.